logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

95137

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1983

23 octobre 2006

S O M M A I R E

Agence Pundel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

95163

GoldenTree Asset Management Lux, S.à r.l., Lu- 

AKH Luxco S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

95142

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95159

AKH Luxco S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

95144

GoldenTree Asset Management Lux, S.à r.l., Lu- 

Alexander J. Davies, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

95165

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95161

ASL Automobile, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95169

GPS Shop, S.à r.l., Bastendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95166

Badlux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95159

HC Investissements, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

95162

BC International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

95146

Imdeco S.A., Pommerloch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95138

CEDAL S.A.,  Centre d’Expertise et de Diagnostic 

Immodun, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95164

Automobiles Luxembourgeois, Diekirch. . . . . . . .

95171

International Tobacco Advisory Services Ltd S.A.H., 

Chamarel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95148

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95173

Christian, Société à responsabilité limitée, Weis- 

Joben S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95178

wampach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95169

Kauri Capital 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

95149

CIS Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

95138

Keersma S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95175

CM Capital Markets Europe S.A., Luxembourg . . .

95173

Keersma S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

95165

Colfin Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

95155

Kovrolux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . 

95164

Coliseo Investissement S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95175

LM & Partners (LM-IS) SCA, Luxembourg  . . . . . . 

95164

Déchetsgestion, S.à r.l., Luxemburg  . . . . . . . . . . . .

95177

Loca-Nord S.A., Heinerscheid. . . . . . . . . . . . . . . . . 

95169

Dolpa, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95159

Meubles Carlo Scheer & Cie, S.à r.l., Wiltz . . . . . . 

95162

Eldalux, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95138

Mon Jardin - Espace Vert, S.à r.l., Schifflange  . . . . 

95163

Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Luxembourg 

Mon  Jardin  -  Nouvelles  Créations,  S.à r.l.,  Schiff- 

AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95172

lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95163

Elettra Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

95161

Multi-Projects S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . 

95175

Epic Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

95165

New Tech Venture Capital II Investments, S.à r.l., 

Etimine S.A., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95162

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95157

Etimine S.A., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95162

New Tech Venture Capital II Investments, S.à r.l., 

Europa Freight Corporation S.A., Luxembourg . . .

95165

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95158

European Fund Services S.A., Luxemburg  . . . . . . .

95174

Newell Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg 

95144

Fidugest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

95156

P.S.A. Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

95176

Field  Point  BL  I  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

P.S.A. Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

95176

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95155

P.S.A. Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

95176

Field  Point  PE  V  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

P.S.A. Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

95176

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95148

P.T. Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

95165

Field  Point  PE  V  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

Pan Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95179

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95180

Pharmeg Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

95176

Field  Point  PE  V  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

Pin Logistics AG, Leudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95146

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95182

Procable S.A., Niederanven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95182

Fjord, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95163

Resolution  Senia  Nord  Luxembourg,  S.à r.l.,  Lu- 

Florenne S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95157

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95147

General Investment Projects S.A., Luxembourg  . .

95161

Resolution  Senia  Nord  Luxembourg,  S.à r.l.,  Lu- 

General Investment Projects S.A., Luxembourg  . .

95161

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95148

95138

IMDECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 7, Berlerstrooss.

R. C. Luxembourg B 94.592. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 10 août 2006, réf. DSO-BT00110, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(993936.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 septembre 2006.

ELDALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9556 Wiltz, 80, rue du Rocher.

R. C. Luxembourg B 102.845. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 5 septembre 2006, réf. DSO-BU00010, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(993989.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 septembre 2006.

CIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 104.282. 

Avec effet au 20 décembre 2005, le conseil d’administration:
- a décidé à l’unanimité d’accepter la démission de Monsieur Mark Vincent Jarvis de ses fonctions d’administrateur,

avec effet au 19 décembre 2005;

- a décidé à l’unanimité de nommer, par voie de cooptation, Monsieur Emmanuel Quidet, né le 10 décembre 1959 à

Neuilly-sur-Seine, France et demeurant à Varsonofievsky Per., 4, app. 20, Moscou, 103031 Russie, aux fonctions
d’administrateur, avec effet au 20 décembre 2005. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du
25 octobre 2008.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Cathal Anthony Lyons, Administrateur;
- Monsieur Emmanuel Quidet, Administrateur;
- Monsieur Douglas Ware Gardner, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01820. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090663.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

RGB, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95180

Tishman  Speyer  Esof  Holdings  (Luxembourg), 

RSL S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95156

S.à r.l., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95141

Santropa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95144

Vermietungsgesellschaft  Objekt  11,  S.à r.l.,  Lu- 

(The) Server Group Europe S.A., Luxembourg. . . 

95163

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95156

Silift, S.à r.l., Bascharage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95164

Vermietungsgesellschaft  Objekt  12,  S.à r.l.,  Lu- 

Snake International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

95155

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95141

STI,  Systèmes  Technologiques  Industriels  S.A., 

Vermilion, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

95162

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95166

Web Brands GP, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

95170

The Cars Européen, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95179

Web Brands GP, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

95171

(The) Three Witches, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

95179

Web Brands Partners, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

95145

Tishman  Speyer  Esof  Holdings  (Luxembourg), 

Web Brands Partners, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

95146

S.à r.l., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95139

Yellow Perfection, S.à r.l., Bereldange  . . . . . . . . . .

95164

<i>Pour la société IMDECO S.A.
Signature

Diekirch, le 5 septembre 2006.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
FORTIS INTERTRUST (LXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire 
Signatures

95139

TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (DEUTSCHLAND), S.à r.l.).

Share capital: EUR 1,037,500.-.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 113.349. 

In the year two thousand and six, on the thirty-first of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

TISHMAN SPEYER EUROPEAN STRATEGIC OFFICE MASTER FUND L.P., a Limited Partnership organized under

the laws of England and Wales, having its registered office at Millbank Tower, 21-24 Millbank, London SW1P 4QP, Unit-
ed Kingdom, registered with the registrar of companies for England and Wales under number LP8497, represented by
its General Partner, TISHMAN SPEYER STRATEGIC INVESTMENTS (EUROPE) I L.L.C., a Limited Liability Company
incorporated under the laws of Delaware, with its principal place of business at 45 Rockefeller Center, NY 10111, New
York, United States of America,

here represented by Mr Gaël Toutain, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of a proxy established on July 27, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») existing in Luxembourg under the name of TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (DEUTSCHLAND), S.à r.l., hav-
ing its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Company
Register section B, under number 113.349, incorporated by a deed of the undersigned notary on December 14th, 2005,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n. 672 dated April 4, 2006, and whose bylaws
have been last amended by an extraordinary general meeting held on April 13, 2006 in front of the undersigned notary,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations.

II. The Company’s share capital is fixed at one million thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 1,037,500.-) di-

vided into forty-one thousand five hundred (41,500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to change the Company’s name from TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS

(DEUTSCHLAND), S.à r.l. into TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

IV. Pursuant to the above change of name, article 4 of the Company’s articles of association is amended and shall

henceforth read as follows:

«Art. 4. The Company will have the name TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.»
V. The sole shareholder resolves to amend article 6 and to add a second paragraph with the following wording:

«Art. 6. (second paragraph). The managers of the Company shall ensure at all times that (i) there will be no more

than thirty (30) shareholders in the Company, (ii) none of the shareholders in the Company will be a natural person,
and (iii) following any transfer of shares, clauses of the points (i) and (ii) of this paragraph will remain satisfied. For the
avoidance of doubt this paragraph operates only to give the Company the opportunity to qualify as a special foreign fund
for German tax purposes and each shareholder understands and agrees that it has no action whatsoever for damages
whether in contract or delict (and will not seek to pursue any such action) against either the assets of the Company,
the managers or the Company in the event that this paragraph is breached or amended.»

VI. The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Burton Lehman as Category A Manager of the Com-

pany with immediate effect and to grant him discharge for the exercise of his mandate until the date of his resignation.

VII. The sole shareholder acknowledges that further to this resignation, the board of managers of the Company will

be composed as follows:

<i>Category A Managers:

- Mr Paul Anthony Galiano, Vice President and Treasurer, born on the 9th of March 1965 in New York (United States

of America), residing at 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, United States of America;

- Miss Geraldine Copeland-Wright, Senior Director European Counsel, born on March 25, 1971, in Leeds (United

Kingdom), with professional address at St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, United Kingdom;

- Mr Timothy Edward Bannon, Managing Director, born on January 7, 1972, in Evanston, Illinois (United States of

America), with professional address at St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, United Kingdom;

- Mr Jerry I Speyer, President and Chief Executive Officer, born on the 23rd of June 1940 in Wisconsin (United States

of America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;

- Mrs Katherine Farley, Senior Managing Director, born on the 12th of October 1949 in New York (United States of

America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;

- Mr Robert J Speyer, Senior Managing Director and Assistant Secretary, born on the 11th of October 1969 in New

York (United States of America), residing at 265, East 66th Street, New York, NY 10021, United States of America;

- Mr Michael Philip Maurice Spies, Senior Managing Director, born on the 4th of September 1957 in Massachusetts

(United States of America), residing at 66, Redcliffe Road, London SW10 9MQ, United Kingdom.

<i>Category B Manager:

- Mr Marcel Stephany, Company Director, born on the 4th of September 1951 in Luxembourg (Grand Duchy of Lux-

embourg), residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg.

95140

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the present shareholders’ meeting are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-

name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TISHMAN SPEYER EUROPEAN STRATEGIC OFFICE MASTER FUND L.P., un limited partnership organisé selon les

lois Anglaises et du Pays de Galles, avec son siège social à Millbank Tower, 21-24 Millbank, Londres SW1P 4QP, Royau-
me-Uni, enregistré auprès du registre des sociétés pour l’Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro LP8497, re-
présenté par son general partner TISHMAN SPEYER STRATEGIC INVESTMENTS (EUROPE) I L.L.C., une société à
responsabilité limitée établie au Delaware (Etats-Unis d’Amérique), exerçant son activité principale au 45 Rockefeller
Center, NY 10111, New York, Etats-Unis d’Amérique,

ici représentée par M. Gaël Toutain, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-

berg, en vertu d’une procuration donnée le 27 juillet 2006.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (DEUTSCHLAND), S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heien-
haff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B,
sous le numéro 113.349, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 14 décembre 2005, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n. 672 en date du 4 avril 2006, et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois lors d’une assemblée générale extraordinaire en date du 13 avril 2006 tenue devant le notaire sous-
signé, non encore publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à un million trente-sept mille cinq cents euros (EUR 1.037.500,-) divisé en

quarante et un mille cinq cents (41.500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L’associé unique décide de changer la dénomination sociale de la Société de TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS

(DEUTSCHLAND), S.à r.l. en TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

IV. Suite au changement de nom ci-dessus, l’article 4 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«Art. 4. La Société a comme dénomination TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.»
V. L’associé unique décide d’insérer un second paragraphe à l’article 6 ayant la teneur suivante:

«Art. 6. (deuxième paragraphe). Les gérants de la Société s’assureront qu’à tout moment (i) il n’y aura pas plus

de trente (30) associés présent dans le capital de la Société, (ii) qu’aucun des associés de la Sociétés ne sera une per-
sonne physique, et (iii) que suite à tout transfert de parts sociales les dispositions (i) et (ii) seront respectées. L’objet
du présent est de permettre à la Société d’être qualifiée de «fond spécial étranger» au regard des autorités fiscales al-
lemandes. En cas de non respect ou de modifications des dispositions du paragraphe précédent, aucune action en res-
ponsabilité civile ou délictuelle contre la Société ou les gérants de la Société ne pourra être engagée par les associés de
la Société.»

VI. L’associé unique décide d’accepter la démission de M. Burton Lehman en tant que gérant de Catégorie A de la

Société avec effet immédiat et de lui accorder décharge pour l’exécution de son mandate jusqu’à la date de sa demission.

VII. L’associé unique reconnaît que suite à cette démission, le conseil de gérance est composé comme suit: 

<i>Gérants de Catégorie A:

- M. Paul Anthony Galiano, Vice Président et trésorier, né le 9 mars 1965 à New York (Etats-Unis d’Amérique), de-

meurant au 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, Etats-Unis d’Amérique;

- Mlle Geraldine Copeland-Wright, Administrateur Conseil Européen, née le 25 mars 1971 à Leeds (Royaume-Uni),

ayant son adresse professionnelle à St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, Royaume-Uni;

- M. Timothy Edward Bannon, Administrateur-délégué, né le 7 Janvier 1972 à Evanston, Illinois (Etats-Unis d’Améri-

que), ayant son adresse professionnelle à St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, Royaume-Uni;

- M. Jerry I. Speyer, Président Directeur Général, né le 23 juin 1940 à Wisconsin (Etats-Unis d’Amérique), demeurant

au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d’Amérique;

- Mme Katherine Farley, Administrateur-délégué, née le 12 octobre 1949 à New York (Etats-Unis d’Amérique), de-

meurant au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d’Amérique;

95141

- M. Robert J. Speyer, Administrateur-délégué, né le 11 octobre 1969 à New York (Etats-Unis d’Amérique), demeu-

rant au 56 Crosby Street Apt 4B, New York, NY 1012 -4435, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Michael Philip Maurice Spies, Administrateur-délégué, né le 4 septembre 1957 à Massachusetts (Etats-Unis

d’Amérique), demeurant au 66, Redcliffe Road, Londres SW10 9MQ, Royaume-Uni.

<i>Gérant de Catégorie B:

- M. Marcel Stephany, Administrateur de Sociétés, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), demeurant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Toutain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, vol. 29CS, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095615.3/211/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (DEUTSCHLAND), S.à r.l.).

Capital social: EUR 1.037.500,-.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 113.349. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 43640, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 8 septembre 2006.

(095616.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT 12, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 17.573. 

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 mai 2006 que:
1. le siège social de la société a été transféré du 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg;

2. ont été élu gérants en remplacement de Monsieur Klaus Feinen et Monsieur Hans-Joachim Hahn démissionnaires:
- Monsieur Hans-Bernd vor dem Esche, né à Minden (Allemagne), le 10 novembre 1947 et résidant à Auf dem Hahn

27, 40670 Meerbusch, Allemagne;

- Monsieur Eberhard Graf, né à Stuttgart (Allemagne), le 14 mai 1949 et résidant à Landhausstraße 84, 70190 Stut-

tgart, Allemagne.

Les mandats des nouveaux gérants viendront à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra dans

l’année 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06027. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092892.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

Luxembourg, le 21 août 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature

95142

AKH LUXCO, Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 98.981. 

In the year two thousand and six, on the twentieth day of July.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of shareholders of AKH LUXCO (the «Company»), a société en comman-

dite par actions, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Lux-
embourg trade and companies’ register under section B number 98.981, incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary, on 13 January 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 24 March
2004, number 330. The articles of incorporation have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary,
on 13 July 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 24 December 2005, number 1455.

The meeting is opened at 10:00 a.m., with Mr Vincent Fesquet, director, with professional address in Paris, France,

in the chair,

who appoints as secretary Mr Daniel Adam, director, with professional address in Luxembourg. The general meeting

elects as scrutineer Mrs Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Reduction of the share capital by an amount of fourteen thousand two hundred eighty-six Euro twenty-five cents

(EUR 14,286.25) in order to reduce it from its current amount of four hundred forty thousand three hundred six Euro
twenty-five cents (EUR 440,306.25) down to four hundred twenty-six thousand twenty Euro (EUR 426,020.-) by can-
cellation of eleven thousand four hundred twenty-nine (11,429) Class B Ordinary Shares with a par value of one Euro
twenty-five cents (EUR 1.25) each, held by the Company itself;

2. Subsequent amendment of article 6.1 of the articles of incorporation of the Company;
3. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no con-
vening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to reduce the share capital by an amount of fourteen thousand two hundred eighty-six Euro

twenty-five cents (EUR 14,286.25) in order to reduce it from its current amount of four hundred forty thousand three
hundred six Euro twenty-five cents (EUR 440,306.25) down to four hundred twenty-six thousand twenty Euro (EUR
426,020.-) by cancellation of eleven thousand four hundred twenty-nine (11,429) Class B Ordinary Shares with a par
value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, held by the Company itself following the redemption by the Com-
pany at nominal value of eleven thousand four hundred twenty-nine (11,429) Class B Ordinary Shares on 12 July 2005.

The share capital reduction shall result in the cancellation at nominal value of the Class B Ordinary Shares held by

the Company itself.

The meeting decides to confer an individual power to any director of the Company’s sole manager to execute, for

and on behalf of the Company, all documents, agreements, certificates, instruments and do everything necessary in con-
nection with the cancellation of the shares, including effectuating reimbursement to the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the above mentioned resolution, article 6.1 of the articles of incorporation of the Company is

amended and shall now read as follows:

«6.1. Subscribed Capital. The Company has a subscribed capital of four hundred twenty-six thousand twenty Euro

(EUR 426,020.-) represented by fully paid up shares, consisting of:

(a) one thousand (1,000) Class Y Ordinary Shares with a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each;
(b) two hundred sixty-one thousand nine hundred fifty (261,950) Class A Ordinary Shares with a nominal value of

one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each;

(c) forty-five thousand (45,000) Class B Ordinary Shares with a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR

1.25) each;

(d) one (1) Management Share with a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25);
(e) thirty-two thousand eight hundred sixty-five (32,865) Preferred Shares with a nominal value of one Euro twenty-

five cents (EUR 1.25).

95143

All shares shall vote together and, except as may be required by law or set forth in these articles, the holders of any

separate class of shares shall not be entitled to vote separately on any matter. No shares of any class shall be entitled
to any pre-emptive rights with respect to any shares of the Company, except as may be required by law.»

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions AKH

LUXCO (la «Société»), ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 98.981, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 13 janvier 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 24 mars 2004, nu-
méro 330. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 13 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 24 décembre 2005, numéro 1455.

L’Assemblée est ouverte à 10:00 heures sous la présidence de M. Vincent Fesquet, administrateur, demeurant pro-

fessionnellement à Paris, France,

qui désigne comme secrétaire M. Daniel Adam, administrateur, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Florene Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social d’un montant de quatorze mille deux cent quatre-vingt-six euros et vingt-cinq cents

(EUR 14.286,25) afin de le porter de sa valeur actuelle de quatre cent quarante mille trois cent six euros et vingt-cinq
cents (EUR 440.306,25) à quatre cent vingt-six mille vingt euros (EUR 426.020,-) par l’annulation de onze mille quatre
cent vingt-neuf (11.429) Actions Ordinaires de Classe B, ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR
1,25) chacune, détenues par la Société elle-même;

2. Modification subséquente de l’article 6.1 des statuts de la Société;
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social d’un montant de quatorze mille deux cent quatre-vingt-six euros et

vingt-cinq cents (EUR 14.286,25) afin de le porter de sa valeur actuelle de quatre cent quarante mille trois cent six euros
et vingt-cinq cents (EUR 440.306,25) à quatre cent vingt-six mille vingt euros (EUR 426.020,-) par l’annulation de onze
mille quatre cent vingt-neuf (11.429) Actions Ordinaires de Classe B, ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq
cents (EUR 1,25) chacune, détenues par la Société elle-même suite au rachat par la Société, à leur valeur nominale, de
onze mille quatre cent vingt-neuf (11.429) Actions Ordinaires de Classe B le 12 juillet 2005.

La réduction du capital social a pour conséquence l’annulation à leur valeur nominale des Actions Ordinaires de Clas-

se B détenues par la Société elle-même.

L’assemblée donne pouvoir individuel à tout administrateur du gérant unique de la Société aux fins de signer, au nom

et pour le compte de la Société, tout document, acte, contrat, certificat et instrument et de prendre toute mesure en
rapport avec l’annulation des actions, incluant le remboursement à la Société.

<i>Seconde résolution

A la suite des actions ainsi réalisées, l’article 6.1 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur sui-

vante:

«6.1. Capital souscrit. La Société a un capital souscrit de quatre cent vingt-six mille vingt euros (EUR 426.020,-)

représenté par des actions entièrement libérées, consistant en:

95144

(a) mille (1.000) Actions Ordinaires de Classe Y ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par

action;

(b) deux cent soixante et un mille neuf cent cinquante (261.950) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur

nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action;

(c) quarante-cinq mille (45.000) Actions Ordinaires de Classe B ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq

cents (EUR 1,25) par action;

(d) une (1) Action de Commandité ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25); et
(e) trente-deux mille huit cent soixante-cinq (32.865) Actions Préférentielles ayant une valeur nominale d’un euro et

vingt-cinq cents (EUR 1,25).

Toutes les actions votent ensemble et, sauf si la loi ou les présents statuts en disposent autrement, les porteurs d’ac-

tions de classes différentes ne seront pas en droit de voter séparément quelque question que ce soit. Aucune classe
d’action ne comporte un droit de préemption sur quelque action de la Société, sauf si la loi en dispose autrement.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: F. Bal, V. Fesquet, D. Adam, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, vol. 154S, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095655.3/211/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

AKH LUXCO, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 98.981. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 43516, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 8 septembre 2006.

(095657.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

SANTROPA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 19.276. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07233, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094423.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.

NEWELL LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 112.715. 

EXTRAIT

Suivant résolution circulaire prise par le conseil de gérance en date du 5 avril 2006, il a été décidé de transférer le

siège social de la Société de L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy à L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume Kroll.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08640. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093043.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

Luxembourg, le 21 août 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 31 août 2006.

Signature.

Pour extrait
F. Debroise
<i>Le mandataire

95145

WEB BRANDS PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. INTERNET BRANDS INVESTMENTS, S.à r.l.).

Share capital: EUR 310,875.-.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 113.558. 

In the year two thousand and six, on the twenty-first day of July.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

INTERNET BRANDS S.C.A, a société en commandite par actions, with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt,

L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

duly represented by Ms Ute Bräuer, Maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned no-

tary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith,

being the sole shareholder of INTERNET BRANDS INVESTMENTS, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsa-

bilité limitée, with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in-
corporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on December 22, 2005, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C number 712 of April 7, 2006, registered with the trade and companies’ register of Lux-
embourg under section B number 113.558.

The appearing party, representing the whole corporate capital, then deliberate upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Modification of the denomination of the Company;
2. Subsequent amendment of article 4 of the articles of association of the Company, that now reads as follows:

«Art. 4. The company will have the denomination of WEB BRANDS PARTNERS, S.à r.l.»,
and has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to modify the denomination of the company into WEB BRANDS PARTNERS, S.à r.l.

<i>Second resolution

As a consequence of the above-mentioned change of the denomination of the Company, article four (4) of the articles

of association is modified and now reads as follows:

«Art. 4. The company will have the denomination of WEB BRANDS PARTNERS, S.à r.l.»

<i>Estimation of cost

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the Com-

pany incurs is approximately at EUR 900.-.

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who has personal knowledge of English language, herewith states that on request of the ap-

pearing person, this deed is worded in English, followed by French text, the English version will prevail.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said appearing person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

INTERNET BRANDS S.C.A, une société en commandite par actions, établie et ayant son siège social au 8-10, rue

Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

ici représentée par Madame Ute Bräuer, Maître en droit, résidant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration, laquelle, signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire

soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement,

étant l’associé unique de INTERNET BRANDS INVESTMENTS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, consti-
tuée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C numéro 712 du 7 avril 2006, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 113.557. 

La partie comparante, représentant l’intégralité du capital social, a délibéré sur l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination de la Société;
2. Modification subséquente de l’Article 4 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société prend la dénomination de WEB BRANDS PARTNERS, S.à r.l.»

95146

<i>Première résolution

L’associé unique a décidé de modifier la dénomination de la Société en WEB BRANDS PARTNERS, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la modification ci-dessus de la dénomination de la Société qui précède, l’Article quatre (4) des

statuts de la Société aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 4. La société prend la dénomination de WEB BRANDS PARTNERS, S.à r.l.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

est évalué à la somme de EUR 900,-. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande de la personne comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, sur demande de la mêmes personne comparante
et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: U. Bräuer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 juillet 2006, vol. 437, fol. 81, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095743.3/242/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

WEB BRANDS PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. INTERNET BRANDS INVESTMENTS, S.à r.l.).

Capital social: EUR 310.875,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 113.558. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095744.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

PIN LOGISTICS AG, Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R. C. Luxembourg B 111.090. 

Suite aux changements intervenus dans la commune de Leudelange en relation avec les dénominations des rues de la

commune et de la nouvelle répartition des numéros 

auparavant rue du Bann, 28, changement en rue Léon Laval, 15
la société PIN LOGISTICS AG est établie à L-3372 Leudelange, rue Léon Laval, 15, à partir du 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01922. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087703.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

BC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 90.201. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07226, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094422.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Mersch, le 16 août 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 4 septembre 2006.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 20 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 31 août 2006.

Signature.

95147

RESOLUTION SENIA NORD LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. RESOLUTION SENIA NORD, S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 113.264. 

In the year two thousand six, on the third of August.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

RESOLUTION (LUXEMBOURG) S.C.A., having its registered office at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, reg-

istered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number 105.482, duly represented
by its general partner, RESOLUTION LUXEMBOURG GP S.A., in its turn represented by Mr Michel Van Krimpen and
Mr Stewart Kam-Cheong, directors, in their turn represented by Mrs Valérie Ingelbrecht or Mr Hille-Paul Schut, or any
other employee of CITCO (LUXEMBOURG) S.A., with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given
in Luxembourg on July 28th, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present

deed for the purpose of registration.

The appearing party is the sole shareholder of RESOLUTION SENIA NORD, S.à r.l., a «société à responsabilité lim-

itée» governed by the laws of Luxembourg, with registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, R.C.S.
Luxembourg B 113.264, which has been incorporated by deed of the notary Henri Hellinckx, residing in Mersch (Grand
Duchy of Luxembourg) on December 12th, 2005, published in the Mémorial C, number 676 of April 3rd, 2006 (the
«Company»).

The appearing party, represented as above mentioned, then requested the undersigned notary to act that the agenda

of the meeting is the following one: 

1) Change of the name of the company from RESOLUTION SENIA NORD, S.à r.l. into RESOLUTION SENIA NORD

LUXEMBOURG, S.à r.l. and amendment of Article 4 of the Articles of Incorporation;

2) Miscellaneous.

<i>First and sole resolution

The meeting decides to change the name of the company from RESOLUTION SENIA NORD, S.à r.l. into RESOLU-

TION SENIA NORD LUXEMBOURG, S.à r.l., so that Article 4 of the Articles of Incorporation will be read as follows:

«Art. 4. The Company will have the name RESOLUTION SENIA NORD LUXEMBOURG, S.à r.l.»
Nothing else being on the agenda the meeting was closed.

Wherehof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same party and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing party, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said party signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trois août.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire, de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

RESOLUTION (LUXEMBOURG) S.C.A., avec siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, inscrite auprès

du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.482, dûment représentée par son com-
mandité, RESOLUTION LUXEMBOURG GP S.A., elle-même représenté par Monsieur Michel Van Krimpen et Monsieur
Stewart Kam-Cheong, directeur, eux-mêmes représenté par Madame Valérie Ingelbrecht ou Monsieur Hille-Paul Schut
ou tout autre employé de la société CITCO (LUXEMBOURG) S.A., avec adresse professionnelle à Luxembourg, en ver-
tu d’une procuration délivrée à Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante est la seule et unique associée de la société RESOLUTION SENIA NORD, S.à r.l. , une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx de résiden-
ce à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg) le 12 décembre 2005, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 113.264, ayant son siège social à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (la «Socié-
té»), publié au Mémorial C, numéro 676 du 3 avril 2006.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a ensuite requis le notaire instrumentant d’acter que l’or-

dre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Changement de la dénomination de la société de RESOLUTION SENIA NORD, S.à r.l. en RESOLUTON SENIA

NORD LUXEMBOURG, S.à r.l. et modification de l’article 4 des statuts;

2. Divers.

95148

<i>Première et unique résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de RESOLUTION SENIA NORD, S.à r.l., en RESOLU-

TON SENIA NORD LUXEMBOURG, S.à r.l. et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts dont la teneur sera
désormais la suivante.

«Art. 4. La société aura la dénomination RESOLUTON SENIA NORD LUXEMBOURG, S.à r.l.
Plus rien de figurant à l’ordre du jour la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la partie compa-

rante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même
partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la partie comparante connue du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. Ingelbrecht et M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 7 août 2006, vol. 470, fol. 78, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Schlinck.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100968.3/5770/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

RESOLUTION SENIA NORD LUXEMBOURG,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 113.264. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100972.3/5770/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

FIELD POINT PE V (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 116.685. 

<i>Extrait des résolutions prises par les gérants/le gérant de la Société, datées du 30 juillet 2006

Les gérants/le gérant de la Société ont/a décidé en date du 30 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9,

rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.

Les gérants/le gérant de la Société font/fait remarquer en outre que l’adresse professionnelle des gérants/du gérant

suivant de la Société est désormais, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:

- Michel van Krimpen.

Luxembourg, le 30 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT06972. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093125.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

CHAMAREL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 46.708. 

<i>Extrait du proceés-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 2 mai 2006

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, au 10A, rue

Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07355. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093120.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

Remich, le 14 septembre 2006.

M. Schaeffer.

Remich, le 14 septembre 2006

M. Schaeffer.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

P. Rochas
<i>Administrateur

95149

KAURI CAPITAL 3, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 119.753. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fifth of September.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

KAURI CAPITAL PROPERTIES, «société à reponsabilité limitée», having its registered office 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg, constituted today by the undersigned notary,

duly represented by Mr Laurent Heiliger, Expert-Comptable, with professional address in Luxembourg, one of its

managers.

The appearing person, acting in the above capacity, has requested the notary to draw up the articles of incorporation

of a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which is established as follows:

Art. 1. Form. A société à responsabilité limitée (private limited liability company) (the «Company») governed by

the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and by these articles of incorporation (the «Articles
of Incorporation»), is hereby established by the founding shareholder.

The Company may at any time have one or several shareholders, as a result of the transfer of shares or the issue of

new shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.

Art. 2. Corporate name. The Company will exist under the corporate name of KAURI CAPITAL 3.

Art. 3. Corporate objects. The purposes for which the Company is formed are all operations or transactions per-

taining directly or indirectly to the taking of participating interests in any companies or enterprises in whatever form,
as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities, financial instruments, bonds, treasury bills, equity participation, stocks and pat-
ents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way
of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities
and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents,
grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The Company may also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter

into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity
of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by

any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security.

In general, the Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions, including real estate

investments, whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote
their development or extension.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the

shareholders, as the case may be.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the

managers.

The managers may establish subsidiaries and branches in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 6. Capital. The capital is set at fifteen thousand euro (EUR 15,000.-) represented by six hundred (600) shares

of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. Changes to the capital. The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199

of the law regarding commercial companies.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and

assets of the Company and to one vote at the general meetings of the shareholders. If the Company has only one share-
holder, the latter exercises all powers which are granted by law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the sole

shareholder or of the shareholders, as the case may be.

The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever

reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered
by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions of the
sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

95150

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares. Shares are freely transferable among shareholders. The share transfer inter vivos to

non shareholders is subject to the consent of at least seventy-five per cent (75%) of the Company’s capital. In case of
death of a shareholder, the share transfer to non shareholders is subject to the consent of no less than seventy-five per
cent (75%) of the votes of the surviving shareholders. In any event the remaining shareholders have a preemption right
which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non shareholder.

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.

Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Managers. The Company is managed by one or more manager(s), who need not to be shareholders, ap-

pointed by decision of the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, for a maximum period of six (6)
years.

Managers are eligible for reelection. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the

sole shareholder or of the shareholders at a single majority. Each manager may as well resign.

While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their

tenure and the powers and competence of the manager(s).

The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.
If more than one manager is appointed, the managers shall form a board of managers and articles 14, 15 and 16 shall

apply.

Art. 14. Bureau. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable

to attend, his functions will be taken by one of the managers present at the meeting.

The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need

not be members of the board of managers.

Art. 15. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by any manager. The

meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice.

The board of managers may only proceed to business if a majority of its members is present or represented. Managers

unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to vote in their
name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or email.

Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting. A manager

having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board, shall be obliged
to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may not take part
in the relevant proceedings of the board.

In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority

of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.

At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall

be informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.

In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference

calls.

Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.

Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

Art. 16. Minutes - Resolutions. All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed

by all the managers present or represented at the meeting or in circular resolutions as provided in the preceding para-
graph. Any power of attorneys will remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman.

The above minutes and resolutions shall be kept in the Company’s books at its registered office.

Art. 17. Powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is/are vested with

the broadest powers to perform all acts of management and disposal in the Company’s interest. All powers not express-
ly reserved by law or the present articles to shareholders fall within the competence of the board of managers.

Art. 18. Delegation of powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may

appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.

Art. 19. Representation of the Company. The Company shall be bound towards third parties by (i) the sole

signature of any of the managers and (ii) the sole signature or the joint signatures of any persons to whom such signatory
powers have been delegated by the managers, within the limits of such powers.

Art. 20. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event

affecting a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.

Art. 21. Liability of the managers. No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal ob-

ligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. A manager is only liable for the performance
of his duties.

Art. 22. Decisions of the shareholders
1. If the Company has only one shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting

of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915 are not applicable in such a situation.

95151

2. If the Company has more than one shareholder, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting

or, if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted
which has been sent by the manager(s) to the shareholders.

In the latter case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company,

within fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.

If the Company has more than one shareholder, no decision may validly be taken, unless it is approved by sharehold-

ers representing together at least one half of the corporate capital. All amendments to the Articles of Incorporation
have to be approved by a majority of shareholders representing together at least three quarters of the corporate capital.

Art. 23. Minutes. The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are documented

in writing, recorded in a register and kept by the manager(s) at the registered office of the Company. The powers-of-
attorney are attached to the minutes.

Art. 24. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty first day of De-

cember of each year.

Art. 25. Financial statements - Statutory auditor. Each year, on the last day of the financial year, the accounts

are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss
account, in accordance with the law. The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole share-
holder or to the shareholders, as the case may be, for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company

pursuant to article 198 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Should the Company have more than twenty-five shareholders, or otherwise as required by law, the general meeting

of shareholders shall appoint a statutory auditor as provided in article 200 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended. In all other cases, the general meeting of shareholders is free to appoint a statutory auditor or
an external auditor at its discretion.

Art. 26. Allocation of profits. Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund;

this allocation is no longer mandatory when and as long as the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders,

as the case may be. The manager(s) may decide on the declaration and payment of interim dividends.

Art. 27. Dissolution - liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the

liquidation will be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders or not, appointed by the sole
shareholder or by the shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 28. Matters not provided. All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in

accordance with applicable laws.

<i>Subscription and payment

All the six hundred (600) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash by KAURI CAPITAL

PROPERTIES, previously named.

The amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000.-) is thus as from now being made available to the Company, evi-

dence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of 10 August 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Transitory provision

The first financial year starts on this date and ends on 31 December 2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges, of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately two thousand euro.

<i>Extraordinary general meeting

The founding shareholder, representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to adopt the fol-

lowing resolutions as sole shareholder of the Company pursuant to article 200-2 of the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies, as amended:

I. Resolved to set at two (2) the number of managers and further resolved to appoint the following as managers for

a period ending on the date of the approval of the annual accounts 2006:

- Mr Laurent Heiliger, Expert-Comptable, with professional address in 3-5, place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg,

- Mr Manuel Hack, Expert-Comptable, with professional address in 3-5, place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg.

The managers will be entrusted with the powers set forth in article 17 of the Articles of Incorporation and the Com-

pany is bound towards third parties by the sole signature of one of the managers.

II. The registered office of the Company shall be set at 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.

95152

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, this deed

is worded in English followed by a French version; and that in case of any differences between the English text and the
French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, that person signed this original deed together with the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

KAURI CAPITAL PROPERTIES, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg, constituée aujourd’hui par le notaire soussigné,

dûment représentée par Monsieur Laurent Heiliger, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, un de ses gérants.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’il est constituée comme suit:

Art. 1

er

. Forme. Il est formé par le comparant ci-avant une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).

La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmis-

sion de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts.

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de KAURI CAPITAL 3.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise

de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions et bre-
vets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie
d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réa-
liser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux
sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n’entrera dans aucune

opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre et d’autres instruments de dettes ou de titres de capital
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l’in-
térêt de la Société.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y

inclus des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution des associés, selon

le cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d’une décision des gérants.
Les gérants pourront établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-), représenté par six cents (600)

parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions

prévues par l’article 199 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un

droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés. Si
la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la
collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l’associé unique ou

de la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers et successeurs de l’associé unique ou de l’assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons

que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur
les actifs et documents de la Société ou qu’un inventaire de l’actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l’exercice de
leurs droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l’associé unique ou de l’assemblée des associés,
suivant le cas.

95153

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun désigné parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-
associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits apparte-
nant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans
trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire affectant l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nom-

més par une décision de l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée ne dé-
passant pas six (6) ans.

Le ou les gérants sont rééligibles. L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés

pourra décider la révocation d’un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement
démissionner de ses fonctions.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).

L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Si plus d’un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance et les articles 14, 15 et 16 trouveront à

s’appliquer.

Art. 14. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger,

ses fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d’autres mandataires sociaux, associés ou non associés.

Art. 15. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance peuvent être convoquées par

chaque gérant. Les réunions sont tenues à l’endroit, au jour et à l’heure mentionnés dans la convocation.

Le conseil peut valablement délibérer lorsque la majorité des gérants est présente ou représentée. Les gérants em-

pêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et voter en leur nom.
Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion. Un gérant ayant

un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l’approbation du conseil doit en informer le conseil et doit
faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations du conseil.

En cas d’abstention d’un des membres du conseil suite à un conflit d’intérêt, les résolutions prises à la majorité des

autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.

A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans

lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.

Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l’ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors

d’une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs
écrits séparés ayant le même contenu.

Art. 16. Procès-verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans

des procès verbaux signés tous les gérants présents ou représentés à la réunion, ou dans des résolutions circulaires
comme prévu à l’alinéa qui précède. Les procurations resteront annexées aux procès verbaux. Les copies et extraits de
ces procès verbaux seront signés par le président.

Ces procès-verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.

Art. 17. Pouvoirs. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs

les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs
qui ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.

Art. 18. Délégation de pouvoirs. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut, peut/

peuvent nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.

Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par (i) la seule signature d’un

des gérants et, (ii) par la signature individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui les pouvoirs de signature ont été
délégués par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 20. Evénements affectant la gérance. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement

similaire affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.

Art. 21. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que
de l’exécution de son mandat.

95154

Art. 22. Décisions de l’associé ou des associés
1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés. Dans ce cas, les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

2. En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises lors d’une assemblée générale ou, s’il y a moins

de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) gérant(s) aux
associés.

Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

En cas de pluralité d’associés, aucune décision n’est valablement prise si elle n’est pas approuvée par des associés

représentant ensemble au moins la moitié du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée
par une majorité des associés représentant ensemble au moins les trois quarts du capital social.

Art. 23. Procès-verbaux. Les décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas, seront

documentées par écrit et consignées dans un registre tenu par le(s) gérant(s) au siège social de la Société. Les procura-
tions y seront annexées.

Art. 24. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 25. Bilan - Conseil de surveillance. Chaque année, le dernier jour de l’année sociale, les comptes sont ar-

rêtés et le gérant dresse un inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes con-
formément à la loi. Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’associé unique ou, suivant le cas, à la
collectivité des associés.

Tout associé, ou son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents compta-

bles, conformément à l’article 198 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Lorsque la société a plus de vingt-cinq associés, ou dans les autres cas prévus par la loi, l’assemblée générale des as-

sociés doit nommer un commissaire aux comptes comme prévu à l’article 200 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée. Dans tous les autres cas, l’assemblée générale des associés est libre, à sa discrétion
de nommer un commissaire aux comptes ou un réviseur d’entreprises.

Art. 26. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la constitution d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale représente dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés. Les

gérant(s) pourra (pourront) procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 27. Dissolution - liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment

que ce soit, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 28. Dispositions générales. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence aux

dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et paiement

Toutes les six cents (600) parts ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire par KAURI CAPITAL

PROPERTIES, prénommée.

La somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-) se trouve partant dès maintenant à la disposition de la Société, la

preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé fondateur, représentant l’intégralité du capital souscrit, a immédiatement pris les résolutions suivantes

comme associé unique de la Société conformément à l’article 200-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée:

I. Décide de fixer à deux (2), le nombre de gérants et décide par ailleurs de nommer comme gérants pour une période

expirant à la date de l’approbation des comptes annuels de l’année 2006:

- Monsieur Laurent Heiliger, expert-comptable, demeurant professionnellement 3-5, place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg,

- Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant professionnellement 3-5, place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg.

Les gérants se voient confier les pouvoirs prévus à l’article 17 des statuts de la Société et la société est valablement

engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle d’un des gérants.

95155

II. Le siège social de la société est fixé au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la partie comparante

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: L. Heiliger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2006, vol. 907, fol. 34, case 6. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105979.3/239/379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.

FIELD POINT BL I (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 115.663. 

<i>Extrait des résolutions prises par les gérants/le gérant de la Société, datées du 30 juillet 2006

Les gérants/le gérant de la Société ont/a décidé en date du 30 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9,

rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.

Les gérants/le gérant de la Société font/fait remarquer en outre que l’adresse professionnelle des gérants/du gérant

suivant de la Société est désormais au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:

- M. Michel van Krimpen.

Luxembourg, le 30 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT06973. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093127.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

SNAKE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 116.454. 

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 21 juillet 2006 a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social du 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, au 54, avenue de la Liberté,

L-1930 Luxembourg.

2. L’assemblée prend acte de la démission d’un administrateur, M. Marc Koeune, né à Luxembourg, le 4 octobre 1969

et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg et nomme en son remplacement Mme Laetitia
Vandegaer, née à B-Saint-Mard, le 20 juillet 1976, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03697. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092983.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

COLFIN EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 77.742. 

Afin de bénéficier de l’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévu par l’article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2005 de sa maison
mère, COLFIN, S.p.A., enregistrés à Luxembourg, le 31 août 2006, réf. LSO-BT09073, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094855.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Belvaux, le 2 octobre 2006.

J.-J. Wagner.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 24 août 2006.

Signature.

95156

VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT 11, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 17.572. 

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 13 juillet 2006 que:
1. le siège social de la société a été transféré du 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, au 560A, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg;

2. a été élu gérant en remplacement de Monsieur Klaus Feinen démissionnaire:
- Monsieur Hans-Bernd vor dem Esche, né à Minden (Allemagne), le 10 novembre 1947 et résidant à Auf dem Hahn

27, 40670 Meerbusch, Allemagne.

Le mandat du nouveau gérant viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra dans l’année

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06024. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092896.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

FIDUGEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 10.744. 

Société constituée par Maître Marc Elter le 27 février 1973, acte publié au Mémorial C n

°

 72 du 26 avril 1973. Les statuts

furent modifiés par Maître Reginald Neuman le 2 mai 1985 (Mémorial C n

°

 188 du 1

er

 juillet 1985), le 17 décembre

1986 (Mémorial C n

°

 106 du 22 avril 1987), le 27 mars 1990 (Mémorial C 351 du 27 septembre 1990) et le 3

décembre 1999 (Mémorial C n

°

 85 du 26 janvier 2000).

EXTRAIT

Il résulte d’une réunion du conseil d’administration tenue le 28 juillet 2006 que:
le siège social de la société est transféré au 10A, boulevard de la Foire a L-1528 Luxembourg, avec effet au 1

er

 août

2006.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08638. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093040.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

RSL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 13, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 68.350. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 8 septembre 2006

1. Les Administrateurs et Commissaire sortant sont réélus avec effet rétroactif à la date du 18 juin 2004 jusqu’à l’as-

semblée générale ordinaire qui aura lieu en 2009.

<i>Administrateurs:

- M. Herbert Grossmann, demeurant au 75, rue des Romains, L-2443 Senningerberg;
- M. Dominique Fontaine, demeurant au 17, rue du Château, B-6747 Saint-Léger;
- M. René Ludovicy, demeurant au 9, rue de Bourglinster, L-6180 Gonderange.

<i>Commissaire aux comptes:

- STRATEGO INTERNATIONAL, S.à r.l., 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU02202. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096375.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2006.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait
J. Wagener
<i>Le mandataire

Pour extrait conforme
D. Fontaine

95157

FLORENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 95.895. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 juillet 2006 

Au Conseil d’Administration de FLORENNE S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au Carré Bonn, 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02850. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093113.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

NEW TECH VENTURE CAPITAL II INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 113.483. 

In the year two thousand and six, on the ninth of February.
Before Us, Maître Hellinckx, notary residing in Mersch.

Appears:

Mr Pierre Delandmeter, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
acting as representative of the board of managers of NEW TECH VENTURE CAPITAL II INVESTMENTS, S.à r.l. with

registered office at L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, duly registered with the Luxembourg Trade Register under
section B number 113.483 (the «Company»), by virtue of a proxy hereto attached.

The Company was incorporated by a deed of the undersigned notary on December 13, 2005, not yet published in

the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The Appearer then declared and requested the notary to state the following:
1. The issued capital of the NEW TECH VENTURE CAPITAL II INVESTMENTS, S.à r.l., prenamed, amounts now to

five hundred and fifty thousand euro (EUR 550,000.-) represented by twenty-two thousand (22,000) fully paid Shares,
with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

2. According to Article 5 of the Articles of Incorporation, the authorized capital of the Company has been set up at

one million euro (EUR 1,000,000.-) represented by forty thousand (40,000) fully paid Shares, with a par value of twenty-
five euro (EUR 25.-) each. The Managers have been authorized to proceed to the increase in capital and Article 5 of the
Articles of Incorporation will then be amended in order to correspond to the increase in capital rendered effective.

3. In accordance with Article 5 of the Articles of Incorporation, the Managers have decided through the resolution

dated February 6, 2006 to increase the issued capital of the Company by four hundred and fifty thousand euro (EUR
450,000.-) to raise it from the present amount of five hundred and fifty thousand euro (EUR 550,000.-) to one million
euro (EUR 1,000,000.-) through the issuance of eighteen thousand (18,000) new Shares with a par value of twenty-five
euro (EUR 25.-) each, each entitled to the same rights as the former ones.

The eighteen thousand (18,000) new Shares have been subscribed and fully paid in cash through payment on a bank

account in the name of NEW TECH VENTURE CAPITAL II INVESTMENTS, S.à r.l. prenamed, so that the amount of
four hundred and fifty thousand euro (EUR 450,000.-) has been put at the free disposal of the latter, evidence of which
has been given to the undersigned notary through the presentation of the supporting documents relating to such pay-
ment and subscription.

Such increase of capital having been effected within the limits of the authorized capital, Article five of the Articles of

Incorporation shall be amended accordingly and shall read as follows:

«Art. 5. The issued capital of the Corporation is set at one million euro (EUR 1,000,000.-) represented by forty thou-

sand (40,000) Shares of twenty-five euro (25.-) each, all of which are fully paid up.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»
4. The sole shareholder has given its approval on February 6, 2006; a copy of its approval will remain attached to the

present deed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 7,000.-.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

H. van de Sanden
<i>Administrateur délégué 

95158

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le neuf février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Pierre Delandmeter, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du Conseil de gérance de la société NEW TECH VENTURE CAPITAL II

INVESTMENTS, S.à r.l., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, inscrite au Registre du Commerce et
des Sociétés à Luxembourg, Numéro B 113.483 (la «Société»), en vertu d’une procuration ci-annexée.

La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 13 décembre 2005, non encore

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le comparant expose et prie alors le notaire instrumentant d’acter comme suit:
I. Le capital social de la Société NEW TECH VENTURE CAPITAL II INVESTMENTS, S.à r.l. prédésignée, s’élève ac-

tuellement à cinq cent cinquante mille euros (EUR 550.000,-) représenté par vingt-deux mille (22.000) parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

II. Aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la Société a été fixé à un million d’euros (EUR

1.000.000,-) représenté par quarante mille (40.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25)
chacune. Les Gérants ont été autorisés à procéder à la réalisation de cette augmentation de capital, l’article cinq des
statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue.

III. Les Gérants, en conformité avec les pouvoirs qui leurs ont été conférés aux termes de l’article cinq des statuts,

ont décidé par résolution du 6 février 2006, d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre cent
cinquante mille euros (EUR 450.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent cinquante mille euros (EUR
550.000,-) à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) par la création de dix huit mille (18.000) parts sociales nouvelles d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune donnant les mêmes droits que les actions anciennes.

Les dix-huit mille (18.000) parts sociales nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement en numéraire par ver-

sement à un compte bancaire au nom de la société NEW TECH VENTURE CAPITAL II INVESTMENTS, S.à r.l., prédé-
signée, de sorte que la somme de quatre cent cinquante mille euros (EUR 450.000,-) a été mise à la libre disposition de
cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de la libéra-
tion et de souscription.

Suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, l’article cinq des statuts est modifié en

conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital émis de la Société est fixé à la somme d’un million d’euros (EUR 1.000.000,-) représenté par

quarante mille (40.000) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à un vote aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires.»
IV. L’actionnaire unique a donné son accord le 6 février 2006.
Une copie de cet accord restera annexé aux présentes.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 7.000,-.

A la demande du comparant, le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d’une

version française. Sur demande du comparant, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Delandmeter, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 13 février 2006, vol. 435, fol. 45, case 6. – Reçu 4.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106248.4/242/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.

NEW TECH VENTURE CAPITAL II INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 113.483. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106250.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.

Mersch, le 17 février 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 6 mars 2006.

H. Hellinckx.

95159

DOLPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 302.125.000,-.

R. C. Luxembourg B 79.973. 

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu entre la Société et LINKLATERS LOESCH (anciennement DE BANDT, VAN HEC-

KE, LAGAE &amp; LOESCH (anciennement LOESCH &amp; WOLTER)) en date du 29 août 2001 a été résilié avec effet à la date
du dépôt du présent extrait.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06850. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093170.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

BADLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 101.789. 

Avec effet au 1

er

 avril 2006, la démission de Monsieur Gérard Matheis en tant que gérant de la société a été acceptée.

Le siège de la société est transféré avec effet immédiat au L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri (5

e

étage).

Luxembourg, le 28 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2006, réf. LSO-BT08231. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093197.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

GoldenTree ASSET MANAGEMENT LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 595,250.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 112.971. 

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of February.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

GoldenTree ASSET MANAGEMENT LUX LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws

of the United States of America, with registered office at c/o NATIONAL CORPORATE RESEARCH, Ltd., 615 South
DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, United States of America (the «Sole Shareholder»),

duly represented by Virginie Lepage, Maître en Droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York,

on 21 February 2006.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of GoldenTree ASSET MANAGEMENT LUX, S.à r.l., a société à respon-

sabilité limitée having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register under number B 112.971, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
on 3 November 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Company»).

The Sole Shareholder, representing the entire share capital, takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder decides to increase the share capital of the Company from its current amount of five hundred

ninety-five thousand two hundred fifty euro (EUR 595,250.-) up to an amount of seven hundred eighty-one thousand
eight hundred twenty-five euro (EUR 781,825.-), through the issuance of seven thousand four hundred sixty-three
(7,463) new shares of the Company having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

All of the seven thousand four hundred sixty-three (7,463) new shares of the Company have been subscribed by the

Sole Shareholder at a total price of one hundred eighty-six thousand five hundred seventy-five euro (EUR 186,575.-),
entirely allocated to the share capital.

The subscribed shares have been fully paid up through a contribution in cash by the Sole Shareholder of hundred

twenty-six thousand nine hundred forty two British pounds and sixty-three pence (GBP 126,942.63) (the «Contribu-
tion»).

<i>Pour DOLPA, S.à r.l.
Signature

Pour avis sincère et conforme
Signature
<i>Gérant

95160

For the purposes of this resolution, the Sole Shareholder has decided to express the total value of the Contribution,

being currently denominated in British pound (GBP), in the euro currency (EUR), on the basis of the exchange rate
displayed on the official website of the European Central Bank (www.ecb.int) on February 21, 2006 at 2.00 p.m. CET,
according to which one British Pound (GBP 1.-) is the equivalent of EUR 1.4697.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolutions, article six first paragraph of the Articles of Incorporation of the Company

is amended and now reads as follows:

«Art. 6. The Company’s share capital is set at seven hundred eighty-one thousand eight hundred twenty-five euro

(EUR 781,825.-), represented by thirty-one thousand two hundred seventy-three (31,273) shares having a par value of
twenty-five euro (EUR 25.-) each.»

<i>Estimation of costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall

be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about three thousand five hundred euro
(EUR 3,500.-).

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by its name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GoldenTree ASSET MANAGEMENT LUX LLC, une limited liability company soumise au droit des Etats-Unis, avec

siège social c/o NATIONAL CORPORATE RESEARCH, Ltd., 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901,
Etats-Unis (l’«Associé Unique»),

ici représentée par Virginie Lepage, Maître en Droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à New York, le 21 février 2006.

La procuration signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La comparante est l’associé unique de GoldenTree ASSET MANAGEMENT LUX, S.à r.l., une société à responsabilité

limitée ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.971, constituée par un acte du notaire soussigné du 3 novembre 2005,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).

La comparante, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société afin de le porter de sa valeur actuelle de cinq cent

quatre-vingt-quinze mille deux cent cinquante euros (EUR 595.250,-) à un montant de sept cent quatre-vingt-un mille
huit cent vingt-cinq euros (EUR 781.825,-) par l’émission de sept mille quatre cent soixante-trois (7.463) parts sociales
nouvelles ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

L’intégralité des sept mille quatre cent soixante-trois (7.463) parts sociales nouvelles a été souscrite par l’Associé

Unique pour un montant total de cent quatre-vingt-six mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 186.575,-), entière-
ment affectés au capital social.

Les parts sociales souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces par l’Associé Unique de cent

vingt-six mille neuf cent quarante-cinq livres sterling et soixante-trois pence (GBP 126.945,63) (l’«Apport»).

Pour les besoins de cette résolution, l’Associé Unique a décidé d’exprimer la valeur totale de l’Apport, actuellement

exprimée en livre sterling (GBP), en euros (EUR) sur base du taux de conversion figurant sur le site Internet officiel de
la Banque Centrale Européenne (www.ecb.int), le 21 février 2006 à 14.00 heures CET, selon lequel une livre sterling
(GBP 1,-) équivaut à EUR 1,4697.

<i>Deuxième résolution

A la suite des résolutions précédentes, le premier paragraphe de l’article six des statuts de la Société est modifié et

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de sept cent quatre-vingt-un mille huit cent vingt-cinq euros (EUR

781.825,-), représentée par trente et un mille deux cent soixante-treize (31.273) parts sociales d’une valeur de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ trois mille cinq cents euros
(EUR 3.500,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

95161

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Lepage, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, vol. 27CS, fol. 77, case 8. – Reçu 1.865,75 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101125.3/211/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

GoldenTree ASSET MANAGEMENT LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 112.971. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 41681 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, en date du 21 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101127.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

ELETTRA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 101.908. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Adminidtration qui s’est tenu le 26 juillet 2006

Le Conseil d’Administration de ELETTRA HOLDINGS, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au Carré Bonn, 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg et ce avec effet au 3 juillet 2006.

Luxembourg, le 26 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01196. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093253.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

GENERAL INVESTMENT PROJECTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 61.683. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2006, réf. LSO-BU00526, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(095457.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

GENERAL INVESTMENT PROJECTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 61.683. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2006, réf. LSO-BU00527, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(095456.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger
<i>Notaire

D. van der Molen 
<i>Gérant

95162

HC INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 115.465. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 26 juillet 2006

Au Conseil d’Administration de HC INVESTISSEMENTS, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au Carré Bonn, 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg et ce avec effet au 3 juillet 2006.

Luxembourg, le 26 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01193. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093254.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

VERMILION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.531. 

Le bilan au 30 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2006, réf. LSO-BT09066, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094856.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

MEUBLES CARLO SCHEER &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9540 Wiltz, 14, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 102.439. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08840, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094864.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

ETIMINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck II, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 21.179. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01505, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 7 septembre 2006.

(094929.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

ETIMINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck II, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 21.179. 

Le bilan consolidé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01506, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 7 septembre 2006.

(094931.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

D. van der Molen 
<i>Gérant

Luxembourg, le 21 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Signature.

C. Zago
<i>Financial Manager

C. Zago
<i>Financial Manager

95163

AGENCE PUNDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 6, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 23.722. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08841, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094866.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

MON JARDIN - NOUVELLES CREATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3853 Schifflange, 20, rue Denis Netgen.

R. C. Luxembourg B 64.438. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08842, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094868.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

MON JARDIN - ESPACE VERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3853 Schifflange, 20, rue Denis Netgen.

R. C. Luxembourg B 64.437. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08843, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094871.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

THE SERVER GROUP EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 68.574. 

Le bilan au 15 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT03046, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2006.

(094875.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

FJORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 115.556. 

1. Suite à la cession de parts intervenue en date du 31 mai 2006 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS

(LUXEMBOURG) S.A. et M. Henrik Troeng les 500 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

M. Henrik Troeng, domicilié au 2 Josef Falknerstrasse, 6410 Telfs, Autriche, détient 500 parts sociales d’une valeur

nominale de EUR 25 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006, réf. LSO-BU00005. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094890.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

<i>FJORD, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

95164

LM &amp; PARTNERS (LM-IS) SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.025. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08018, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094879.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

IMMODUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.129. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT07920, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095221.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

YELLOW PERFECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 62, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 87.167. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT07922, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095222.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

KOVROLUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4112 Esch-sur-Alzette, 12, place d’Europe.

R. C. Luxembourg B 69.437. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT07924, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095225.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

SILIFT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.686. 

Constituée par-devant M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence alors à Echternach et maintenant à Luxembourg, en

date du 7 mars 1988, acte publié au Mémorial C N

°

 151 du 4 juin 1988, modifiée par-devant le même notaire en

date du 20 août 1992, acte publié au Mémorial C N

°

 571, modifiée par-devant le même notaire en date du 4

décembre 1992, acte publié au Mémorial C N

°

 571 du 4 décembre 1992, modifiée par-devant le même notaire en

date du 19 décembre 2000, acte publié au Mémorial C N

°

 777 du 19 septembre 2001, modifiée par acte sous seing

privé du 27 juillet 2001, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C N

°

 244 du 13 février 2002.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT07853, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095949.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2006.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Signature.

<i>Pour SILIFT
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

95165

EPIC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 85.535. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT07877, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095227.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

EUROPA FREIGHT CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 12.807. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00645, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095301.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

ALEXANDER J. DAVIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 38.696. 

Les comptes annuels (version abrégée) au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf.

LSO-BU00765, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095311.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

P.T. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.338. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01307, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095318.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

KEERSMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 34.936. 

En date du 20 juin 2006, l’assemblée générale a pris acte des démissions de Maître Denis Lenfant de son mandat d’ad-

ministrateur et de Monsieur Sébastien Kopp de son mandat de commissaire.

A cette même date, l’assemblée a décidé de nommer comme administrateur Monsieur Jean Thyssen, comptable, de-

meurant à L-6111 Junglinster, 15, rue Tun Deutsch et comme commissaire la société CHAPMAN CONSULTING INC,
avec siège social à Belize-City (Belize), Jasmine Court, 35A Regent Street.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale de 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08564. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096057.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2006.

Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Signature.

Signature.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

KEERSMA S.A.
Signature

95166

STI, SYSTEMES TECHNOLOGIQUES INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 39.640. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 3 août 2006 que:
- le conseil d’administration décide de transférer le siège social de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361

Luxembourg au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03614. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(087559.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

GPS SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-9350 Bastendorf, 9, Am Haff.

R. C. Luxembourg B 118.816. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fourteenth of August,
Before Us, Maître Jean Seckler, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Mr Marco Sperber, merchant, born in Hermeskeil (Germany), on the 9th of August 1966, residing in D-54451 Irsch,

Am Schafenberg 38A (Germany),

here represented by Miss Helene Müller, Doktor der Rechte, professionally residing in L-1341 Luxembourg, 9, Place

Clairefontaine,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 14th of June 2006;
said proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing person, voting under their given authority, announced the formation by them of a limited company,

governed by the relevant law and present articles.

Art. 1. There is formed a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity

as well as by present articles.

Art. 2. The object of the Company is the retail (internet) trading of goods related to aviation within the broadest

meaning of the word.

The company may contract loans, with or without guarantee and stand security for other persons or companies.
The company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which are

in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its
purposes.

Art. 3. The company will assume the denomination of GPS SHOP, S.à r.l.

Art. 4. The registered office is established in Bastendorf.

Art. 5. The company is established for an unlimited period of time.

Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented

by one hundred and twenty-five (125) shares of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Art. 7. The shares may be transferred to other parties by a notarial deed or a written agreement.

Art. 8. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the

company to an end.

Art. 9. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

Art. 10. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the

partners.

In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company in

all circumstances if the general meeting does not provide other disposition.

The Company may also appoint one or more persons, shareholders or not, as signing clerks or managers and fix their

powers.

Art. 11. Every shareholder has the right to vote at the general meeting. Each share gives the right to one vote. Every

shareholder has the right to appoint a special proxy who represents him at the general meetings of the shareholders.

The rights of the general meeting are exercised by the sole shareholder as long as the company only has one

shareholder.

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

95167

The decisions of the sole shareholder are laid down in writing in a register to be kept at the registered office of the

company.

Art. 12. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 13. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 14. Each year, on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the company’s assets and liabilities.

Art. 15. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.

Art. 16. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation, represent

the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners.

Art. 17. At the time of the winding-up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.

Art. 18. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the arti-

cles. The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of
18.9.33) are satisfied.

<i>Transitory Disposition

The first year will start from today and will end on December 31, 2006.

<i>Subscription and Payment

All the one hundred and twenty-five (125) shares have been fully paid up in cash by Mr Marco Sperber, prenamed, so

that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimation of the costs

The parties estimate the value of formation expenses at approximately nine hundred and fifty Euro.

<i>Decisions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation, the sole shareholder of the Company has herewith adopted the following

resolutions:

1) Mr Marco Sperber, merchant, born in Hermeskeil (Germany), on the 9th of August 1966, residing in D-54451

Irsch, Am Schafenberg 38A (Germany), is appointed manager of the company for undetermined period.

2) The manager has the widest powers to carry out all acts in the name of the company.
3) The registered office is established in L-9350 Bastendorf, 9 Am Haff.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that, on request of the appearing person, the present

incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the German text, the German version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, the said person signed together with the notary the present

deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundsechs, den vierzehnten August,
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

Herr Marco Sperber, Kaufmann, geboren in Hermeskeil (Deutschland), am 9. August 1966, wohnhaft in D-54451

Irsch, Am Schafenberg 38A (Deutschland),

hier vertreten durch Frau Helene Müller, Doktor der Rechte, beruflich wohnhaft in L-1341 Luxemburg, 9, Place

Clairefontaine,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, am 14. Juni 2006.
Welche Vollmacht ne varietur von der Bevollmächtigten und dem Notar unterzeichnet worden ist und gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben hinterlegt zu werden.

Dieser Komparent, namens wie er handelt, ersuchte den Notar die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschafter wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, welcher die diesbezüg-

liche Gesetzgebung zu Grunde liegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der (Internet) Handel mit Waren die einen Bezug zur Fliegerei im weitesten Sinne

haben.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

95168

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, aus-
führen.

Art. 3. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung GPS SHOP, S.à r.l.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft in Bastendorf.

Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) eingeteilt in einhun-

dertfünfundzwanzig (125) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100,- EUR).

Art. 7. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen wird durch ein privatschriftliches oder notarielles Schreiben festge-

stellt.

Art. 8. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Insolvenz oder den Konkurs eines Gesellschafters aufgelöst.

Art. 9. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum

oder an den Firmenschriftstücken stellen.

Art. 10. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und

welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten

die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten welche im Rahmen ihres Gesell-
schaftszweckes liegen. Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, ob Gesellschafter oder nicht, zu Pro-
kuristen oder Direktoren bestellen und deren Befugnisse festlegen.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben

wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.

Solange die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, hat er die in der außergewöhnlichen Generalversamm-

lung festgelegten Rechte.

Die Entscheidungen des Gesellschafters sind in einem Register am Gesellschaftssitz aufzubewahren.

Art. 12. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am ein und dreißigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 14. Am ein und dreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst der Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. 

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 18. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile wurden vollständig durch Herrn Marco Sperber, vorgenannt, vollständig

und in bar eingezahlt, so daß die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfü-
gung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

<i>Schätzung der Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf neun

hundert fünfzig Euro abgeschätzt.

<i>Beschlüsse des einzigen Gesellschafters

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der Anteilinhaber folgende Beschlüsse gefaßt:
1) Herr Marco Sperber, Kaufmann, geboren in Hermeskeil (Deutschland), am 9. August 1966, wohnhaft in D-54451

Irsch, Am Schafenberg 38A (Deutschland), wird zum Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit ernannt. 

2) Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Vollmachten im Namen der Gesellschaft alle Urkunde zu tätigen.
3) Sitz der Gesellschaft ist in L-9350 Bastendorf, 9, Am Haff.

95169

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Auftrag der Komparentin, dass

diese Gründungsurkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Antrag der Kompa-
rentin und im Fall von Abweichungen des englischen und des deutschen Textes ist die deutsche Fassung massgebend.

Woraufhin diese notarielle Urkunde in Junglinster an dem zu Beginn erwähnten Tag erstellt wurde.
Nachdem die Urkunde der Komparentin vorgelesen worden war, wurde sie von der Komparentin und dem Notar

unterzeichnet.

Gezeichnet: H. Müller, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 août 2006, vol. 537, fol. 72, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093401.3/231/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2006.

CHRISTIAN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 99.409. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 janvier 2006

La séance, tenue au siège social, rue de Stavelot 117, 9991 Weiswampach, débute à 20 heures.
L’assemblée est tenue sous la présidence de Monsieur Serge Christian, lequel nomme Madame Nadia Justen-Christian

à la fonction de secrétaire.

Toutes les parts étant réunies par la présence des deux seuls associés (total 750 parts appartenant à M. Serge Chris-

tian (568 parts) et Mme Nadia Justen-Christian (182 parts)), l’assemblée est valablement constituée et prête à délibérer
sur l’ordre du jour suivant:

- Démission d’un gérant.
L’assemblée approuve à l’unanimité, la démission de Monsieur Carl Schumacher avec effet au 31 décembre 2005.
Le sujet étant clos, la séance s’est achevée à 21 heures près lecture et approbation du présent procès-verbal.

Enregistré à Diekirch, le 30 août 2006, réf. DSO-BT00206. – Reçu 89 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(992302.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 août 2006.

LOCA-NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 2A, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 93.140. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2006 

Il a été décidé, entre autres:
1. de nommer Monsieur Yves Weerts en qualité d’administrateur-délégué;
2. que l’administrateur-délégué, Monsieur Yves Weerts, disposera de la signature sociale pour toutes les opérations

journalières, sans limitation de sommes. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 11 août 2006.

Enregistré à Diekirch, le 14 août 2006, réf. DSO-BT00128. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(993462.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 septembre 2006.

ASL AUTOMOBILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 96.823. 

Le siège social de la société est dénoncé avec effet au 30 juin 2006 à L-6686 Mertert, 16, route de Wasserbillig.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08361. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078416.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Junglinster, den 30. August 2006.

J. Seckler.

S. Christian / N. Justen-Christian.

<i>Pour LOCA-NORD S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

<i>Pour le domiciliataire
Signature

95170

WEB BRANDS GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. INTERNET BRANDS GP, S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 110.044. 

In the year two thousand and six, on the twenty first day of July.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

WARBURG PINCUS PRIVATE EQUITY IX L.P, a company existing under the laws of the State of Delaware, USA.,

with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware19801,

duly represented by Ms Ute Bräuer, Maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned no-

tary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith,

being the sole shareholder of INTERNET BRANDS GP, S.à r.l. (the «Company»), a Société à responsabilité limitée,

with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pur-
suant to a deed of the undersigned notary, on July 26, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C number 1343 of December 7, 2005; the articles of incorporation have been modified by a deed of the
undersigned notary, on December 22, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number
1042 of May 29, 2006 and registered with the trade and companies’ register of Luxembourg under section B number
110.044.

The appearing party representing the whole corporate capital then deliberate upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Modification of the denomination of the Company;
2. Subsequent amendment of article 4 of the articles of association of the Company, that now reads as follows:

«Art. 4. The company will assume the name of WEB BRANDS GP, S.à r.l., a company with limited liability.»;
and has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to modify the denomination of the company into WEB BRANDS GP, S.à r.l.

<i>Second resolution

As a consequence of the above-mentioned change of the name of the Company, article four (4) of the articles of

association is modified and now reads as follows:

«Art. 4. The company will assume the name of WEB BRANDS GP, S.à r.l., a company with limited liability.»

<i>Estimation of cost

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the Com-

pany incurs is approximately at EUR 900.-.

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who has personal knowledge of English language, herewith states that on request of the ap-

pearing person, this deed is worded in English, followed by French text, the English version will prevail.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said appearing person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

WARBURG PINCUS PRIVATE EQUITY IX L.P, une société de l’Etat du Delaware, USA, établie et ayant son siège

social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware19801, 

ici représentée par Madame Ute Bräuer, Maître en droit, résidant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration, laquelle, signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire

soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement,

étant l’associé unique de INTERNET BRANDS GP, S.à r.l. (la «Société»), Société à responsabilité limitée, ayant son

siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant, en date du 26 juillet 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C nu-
méro 1343 du 7 décembre 2005, les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du
22 décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1042 du 29 mai 2006, inscrite
au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 110.044.

La partie comparante, représentant l’intégralité du capital social, a délibéré sur l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination de la Société;

95171

2. Modification subséquente de l’Article 4 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société prend la dénomination de WEB BRANDS GP, S.à r.l, une société à responsabilité limitée.»

<i>Première résolution

L’associé unique a décidé de modifier la dénomination de la Société en WEB BRANDS GP, S.à r.l 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’Article quatre (4) des statuts de la Société, aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 4. La société prend la dénomination de WEB BRANDS GP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

est évalué à la somme de EUR 900,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande de la personne comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, sur demande de la mêmes personne comparante
et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: U. Bräuer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 25 juillet 2006, vol. 437, fol. 75, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095737.3/242/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

WEB BRANDS GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. INTERNET BRANDS GP, S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 110.044. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095740.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

CEDAL S.A., CENTRE D’EXPERTISE ET DE DIAGNOSTIC AUTOMOBILES LUXEMBOURGEOIS, 

Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 98.575. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 15 avril 2002 que:
1.- Monsieur Paul-Heinz Müller, conseil comptable, demeurant à L-9513 Wiltz, 60, rue de la Chapelle,
a été réélu aux fonctions d’administrateur de la société. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale des

actionnaires qui se tiendra en 2008.

2.- Monsieur Guy Müller, maître en sciences économiques, demeurant à L-8020 Strassen, 12, rue de la Paix, a été

réélu aux fonctions de commissaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale
des actionnaires qui se tiendra en 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 15 avril 2002.

Enregistré à Diekirch, le 8 septembre 2006, réf. DSO-BU00053. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(998013.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2006.

Mersch, le 16 août 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 4 septembre 2006.

H. Hellinckx.

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
Signature

95172

ELEKTRIZITÄTS-GESELLSCHAFT LAUFENBURG LUXEMBOURG AG, Aktiengesellschaft. 

Gesellschaftssitz: L-1331 Luxemburg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

H. R. Luxemburg B 103.420. 

Im Jahre zweitausendsechs, den achtzehnten Juli,
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg),

versammelt sich die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft ELEKTRIZITÄTS-

GESELLSCHAFT LAUFENBURG LUXEMBOURG AG, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 67, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 103.420,
welche gemäss Urkunde, aufgenommen am 21. September 2004 durch den unterzeichneten Notar und veröffentlicht
im Mémorial C Nummer 1302 vom 20. Dezember 2004, gegründet wurde.

Die Sitzung wird unter dem Vorsitz von Herrn Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt Frau Audrey Coppede, Privatangestelle, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, zur Sekretärin.

Die Generalversammlung erwählt Herrn David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, zum Stimmzähler.

Die in dieser Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre, sowie die Zahl der in ihrem Besitz

befindlichen Aktien wurden in eine Anwesenheitsliste eingetragen, welche von den anwesenden Aktionären und den
Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre unterzeichnet wurde; die Mitglieder der Generalversammlung erklären,
dass sie sich auf diese Liste, welche die Mitglieder des Büros aufgestellt haben, beziehen.

Die erwähnte Anwesenheitsliste wird nach ne varietur Unterzeichnung durch die Mitglieder des Büros und den

unterzeichneten Notar, von diesem aufbewahrt werden.

Die Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten, die Mitglieder des Büros und

den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Vorsitzende erklärt und die Generalversammlung stellt fest:
A) Dass diese ausserordentliche Generalversammlung folgende Tagesornung hat:

<i>Tagesordnung:

1) Aufstockung des Kapitals um EUR 120.000,-, um es von seinem jetzigen Betrag von EUR 100.000,- auf EUR

220.000,- zu erhöhen durch die Ausgabe von 1.200 neuen Aktien mit einem Nennwert von je EUR 100,-, welche die-
selben Rechte und Pflichten wie de bestehenden Aktien besitzen.

2) Verzicht des Minderheitsaktionärs, des Herrn Jean Fell, expert-comptable, geboren am 9. April 1956 in Echternach,

Grossherzogtum Luxemburg, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, auf
sein Vorzugszeichnungsrecht.

3) Zeichnung der 1.200 neuen Aktien mit einem Nennwert von je EUR 100,- durch den Mehrheitsaktionär, die

Gesellschaft mit beschränkter Haftung EGL AUSTRIA, GmbH, eingetragen in Wien, Oesterreich, unter der Nummer
FN 211073 b, mit Sitz in A-1010 Wien, Oesterreich, Palais Eschenbach, Eschenbachstrasse 11/8, und vollständige Ein-
zahlung dieser Aktien mittels Bareinlage in Höhe von EUR 120.000,-.

4) Entsprechende Abänderung des ersten Absatzes des fünften Artikels der Satzung, welcher künftig folgenden Wort-

laut haben wird: «Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertzwanzigtausend Euro (EUR 220.000,-), aufgeteilt in zwei-
tausendzweihundert (2.200) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).»

5) Verschiedenes.
B) Dass in dieser Generalversammlung das gesamte Kapital anwesend oder vertreten ist, so dass sie ordnungsgemäss

zusammengesetzt ist und rechtsgültig über die Tagesordnungspunkte befinden darf.

C) Dass das gesamte Kapital vertreten ist und dass von dem üblichen Einberufungsverfahren abgesehen werden

konnte, da die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sich als ordnungsgemäss einberufen ansehen und des Weiteren
erklären, dass sie über die Tagesordnung, welche ihnen im Voraus unterbreitet wurde, in Kenntnis gesetzt worden sind.

Daraufhin schneidet die Generalversammlung die Tagesordnung an und fasst nach Beratung folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Kapital um hundertzwanzigtausend Euro (EUR 120.000,-) aufzustocken, um

es von seinem jetzigen Betrag von einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) auf zweihundertzwanzigtausend Euro (EUR
220.000,-) zu erhöhen durch die Ausgabe von eintausendzweihundert (1.200) neuen Aktien mit einem Nennwert von
je einhundert Euro (EUR 100,-), welche dieselben Rechte und Pflichten wie de bestehenden Aktien besitzen.

<i>Zweiter Beschluss

Nachdem der Minderheitsaktionär, Herr Jean Fell, expert-comptable, geboren am 9. April 1956 in Echternach, Gros-

sherzogtum Luxemburg, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, vertreten
durch Herrn Paul Marx, vorbenannt, auf sein Vorzugszeichnungsrecht verzichtet hat, wurden die eintausendzweihundert
(1.200) neuen Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) durch den Mehrheitsaktionär, die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung EGL AUSTRIA, GmbH, eingetragen in Wien, Österreich, unter der Nummer FN
211073 b, mit Sitz in A-1010 Wien, Österreich, Palais Eschenbach, Eschenbachstrasse 11/8, gezeichnet und vollständig
eingezahlt mittels Bareinlage in Höhe von einhundertzwanzigtausend Euro (EUR 120.000,-), so dass die Summe von ein-
hundertzwanzigtausend Euro (EUR 120.000,-) der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung steht, so wie dies dem
unterzeichneten Notar durch ein Bankzertifikat nachgewiesen wurde.

95173

<i>Dritter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschliesst die Generalversammlung den

ersten Absatz von Artikel fünf der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. (erster Absatz). Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertzwanzigtausend Euro (EUR 220.000,-), aufge-

teilt in zweitausendzweihundert (2.200) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt zweitausendvierhundert Euro veranschlagt sind,

sind zu Lasten der Gesellschaft.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Sitzung aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienenen Parteien, dem unterzeichneten Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde
zusammen, mit dem Notar, unterschrieben.

Signé: P. Marx, A. Coppede, D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 juillet 2006, vol. 537, fol. 39, case 10. – Reçu 1.200 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091351.3/231/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.

INTERNATIONAL TOBACCO ADVISORY SERVICES LTD S.A., Société Anonyme Holding. 

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 7.586. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 mars 2006

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 mars 2006:

- Monsieur Kurt Nauer, administrateur de sociétés, demeurant 7, rue R-D Roosevelt, L-8344 Olm;
- M. Alan Grieve, Directeur, demeurant 75, Säntisstrasse, CH-8820 Wädenswil;
- M. Ian Ross, Chartered Accountant, demeurant 21A, Hünenbergweg, CH-6415 Arth.
Est nommé réviseur d’entreprises, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 mars 2006:

PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée, 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03860. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077692.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

CM CAPITAL MARKETS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.697. 

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises lors d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 12 sep-

tembre 2005 que:

- La décision de co-optation de l’administrateur Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg, en rem-

placement de Maître Philippe Morales, par le Conseil d’Administration en date du 4 janvier 2005, a été ratifiée;

- Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2006, réf. LSO-BT08487. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095008.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Junglinster, den 22. August 2006.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

95174

EUROPEAN FUND SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1820 Luxemburg, 17, rue Antoine Jans.

H. R. Luxemburg B 77.327. 

Im Jahre zweitausendsechs, den zweiten August,
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg),

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft EUROPEAN FUND SERVICES S.A., mit Sitz in L-1820 Luxemburg, 17, rue Antoine Jans, H.G.R.
Luxemburg Sektion B Nummer 77.327.

Die Gesellschaft wurde gegründet unter der Bezeichnung INTERTRANSACT S.A. gemäss Urkunde aufgenommen

durch Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim, am 8. August 2000, veröffentlicht im Mémorial C
Nummer 44 vom 23. Januar 2001,

und deren Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunden aufgenommen durch den instrumentierenden Notar:
- am 21. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 712 vom 1. September 2001;
- am 27. Dezember 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 230 vom 4. März 2003, enthaltend Abänderung der

Bezeichnung der Gesellschaft in EUROPEAN FUND SERVICES S.A.;

- am 13. Februar 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 371 vom 4. April 2003;.
- am 28. März 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 496 vom 8. Mai 2003;
- am 24. November 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1353 vom 19. Dezember 2003;
- am 20. Dezember 2005, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 780 vom 19. April 2006.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach (Luxemburg).
Der Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Frau Françoise Hübsch, Privatbeamtin, wohnhaft in Echternacherbrück

(Deutschland). 

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herr Stephan Jeandey, Kaufmann, wohnhaft in Konz (Deutschland).
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den

Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden
Notar unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1. Weiterführung der Gesellschaft EUROPEAN FUND SERVICES S.A., selbst wenn das Gesellschaftskapital bereits

mehr als die Hälfte aufgebraucht worden ist.

2. Emission von neuen Aktien. Die Gesellschaft emittiert neue Aktien. Die neuen Aktien werden im Verhältnis 15:4

zu einem Preis von EUR 100,- je Stück zum Bezug angeboten.

3. Änderung von Artikel 6 der Satzung.
Die außerordentliche Hauptversammlung bestätigt die Tagesordnung und nimmt folgende Beschlüsse einstimmig vor:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, die Gesellschaft EUROPEAN FUND SERVICES S.A. weiterzuführen, selbst

wenn das Gesellschaftskapital bereits mehr als die Hälfte aufgebraucht worden ist.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt neue Aktien zu emittieren. Die neuen Aktien werden im Verhältnis 15:4 zu

einem Preis von EUR 100,- je Stück zum Bezug angeboten. Somit wird das Gesellschaftskapital um vierhunderttausend
Euro (EUR 400.000,-) erhöht, um es von seinem jetzigen Betrag von eine Million fünfhunderttausend Euro (EUR
1.500.000,-) auf eine Million neunhunderttausend Euro (EUR 1.900.000,-) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe
von achtzigtausend (80.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von je fünf Euro (EUR 5,-), welche dieselben Rechte und
Vorteile genießen wie die bereits bestehenden Aktien.

<i>Dritter Beschluss

Die achtzigtausend (80.000) neuen Aktien werden durch die Gesellschaft SOCIETE GENERALE SECURITIES

HOLDING S.A. («SGSS») mit Sitz in 17, Cours Valmy, F-92800 Puteaux, nach Verzicht der eventuellen Zeichnungsrech-
te sämtlicher anderer Gesellschafter gezeichnet und voll einbezahlt. Darüber hinaus zahlt die SOCIETE GENERALE
SECURITIES HOLDING S.A. («SGSS») den Emissionsaufpreis in Höhe von sieben Millionen sechshunderttausend Euro
(EUR 7.600.000,-) an die Gesellschaft. Der Gesellschaft steht somit ab sofort insgesamt die Summe von acht Millionen
Euro (EUR 8.000.000,-) zur Verfügung, so wie dies dem amtierenden Notar mittels Bankbescheinigung nachgewiesen
wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt Artikel sechs (6) der Satzung abzuändern, und ihm folgenden Wortlaut zu geben;

95175

«Art. 6. Das gezeichnete Grundkapital der Gesellschaft beträgt eine Million neunhunderttausend Euro (EUR

1.900.000,-), welches eingeteilt ist in dreihundertundachtzigtausend (380.000) ordentliche Aktien von je fünf Euro (EUR
5,-).

Die Aktien sind Namensaktien. Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das jeder

Aktionär jederzeit Einsicht nehmen kann. Das Eigentum an einer Namensaktie wird durch die Eintragung in das Aktien-
register begründet. Auf Wunsch wird dem Aktionär ein Zertifikat über die Eintragung ausgestellt. Bei einer Abtretung
der Aktien sowie im Falle des Konkurses, der Zwangsliquidation oder im Sterbefall eines Aktionärs sowie im Falle der
Übertragung aus anderen Gründen haben die Aktionäre grundsätzlich ein Vorkaufsrecht. Die Modalitäten dieses Vor-
kaufsrechts sind in einer zwischen den Gesellschaftern zu vereinbarenden Aktionärsvereinbarung zu regeln. Die Gesell-
schaft behält sich das Recht vor, eine Abtretung der Aktien durch eine Übertragungserklärung abzulehnen, insofern
diese nicht in Übereinstimmung mit den Modalitäten des Vorkaufsrechts, wie es zwischen den Aktionären vereinbart
und der Gesellschaft zur Kenntnis gebracht wurde, steht.»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt vierundachtzigtausendfünfhundert Euro veran-

schlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Da damit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Thill, F.F. Hübsch, S. Jeandey, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 août 2006, vol. 537, fol. 60, case 9. – Reçu 80.000 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091627.3/231/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.

COLISEO INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 72.199. 

Nous vous informons par la présente que notre Société a mis fin à la relation commerciale nous liant à la société sous

rubrique, ceci avec effet au 14 juillet 2006.

Le 22 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, réf. LSO-BT07550. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093030.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

KEERSMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 34.936. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-

bourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08555, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 7 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094858.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

MULTI-PROJECTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 80.816. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01088, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095619.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Junglinster, den 22. August 2006.

J. Seckler.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
P. Mestdagh / J.-P. Reiland 
<i>Responsable de Département / Directeur 

Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Signature.

95176

P.S.A. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 87.661. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01256, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2006.

(095489.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

P.S.A. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 87.661. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01258, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2006.

(095480.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

P.S.A. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 87.661. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01262, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2006.

(095483.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

P.S.A. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 87.661. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01259, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2006.

(095484.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

PHARMEG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.225. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07230, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094421.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.

HALSEY, S.à r.l.
K. Segers

HALSEY, S.à r.l.
K. Segers

HALSEY, S.à r.l.
K. Segers

HALSEY, S.à r.l.
K. Segers

Luxembourg, le 31 août 2006.

Signature.

95177

DECHETSGESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 241, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 118.670. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, neunzehnten Juni,
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg),

Ist erschienen:

1.- Die Gesellschaft CORAX INC., mit Sitz in Lot 24, Taman Hilltop Phase II, F.T. Labuan (Malaysia), eingetragen im

Gesellschaftsregister von Malaysia unter der Nummer LL05094.

2.- Die Gesellschaft GALLO INC., mit Sitz in Lot 24, Taman Hilltop Phase II, F.T. Labuan (Malaysia), eingetragen im

Gesellschaftsregister von Malaysia unter der Nummer LL05093.

Beide sind hier vertreten durch Herrn Gernot Kos, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des

Foyers, auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Welche Vollmachten vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben der

gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparentinnen, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen die Satzung einer Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird zwischen dem Komparenten und allen, welche spätere Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnungf DECHETSGESTION, S.à r.l. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgendeine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,

welche geeignet wären, die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr
zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgül-
tigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxem-
burgischen Staatszugehörigkeit.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Umwelt-

management.

Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und
Rechten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Ab-
tretung, Tausch oder sonstwie veräußern; darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und
verwerten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewäh-
ren sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt

oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vor-

genannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spezifi-
schen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).

Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtge-

sellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesellschaf-
ter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen vom Datum des Angebotes eines
Gesellschafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnach-
folger des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der
Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 7. Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsfüh-

rer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche
sie ernennt, abberufen werden können.

Art. 8. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 9. Ein Teil des frei verfügbaren jährlichen Gewinns kann durch Gesellschafterbeschluss an den oder die

Geschäftsführer als Prämie ausgezahlt werden.

Art. 10. Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern

weiterbesteht. Diese haben das Recht von dem in Artikel 6. vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder
mit Einverständnis aller Anteilinhaber, mit den Erben die Gesellschaft weiterzuführen.

95178

Beim Tod des alleinigen Gesellschafters kann die Gesellschaft unter den Erben des Gesellschafters weiterbestehen,

soweit diese hierzu ihr Einverständnis geben.

Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder

an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 11. Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, übt dieser alle Befugnisse aus, welche

durch das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in

ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten

in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Bestimmung ist nicht anwendbar für laufende Operationen, welche zu normalen Bedingungen abgeschlossen

worden sind.

Art. 12. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Komparenten, han-

delnd wie erwähnt, auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend
die Handelsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die vorgenannten Gesellschafterinnen, dass die einhundert (100)

Anteile wie folgt gezeichnet werden: 

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

<i>Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft

sich auf ungefähr acht hundert Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschließend haben sich die Gesellschafterinnen zu einer außerordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu

der sie sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1150 Luxemburg, 241, route d’Arlon.
2.- Herr Lutz Alpers, Direktor, geboren in Bremerhaven (Bundesrepublik Deutschland), am 11. März 1949, wohnhaft

in 42, Lilitan Sungai Emas, 11100 Batu Feringgi, Penang (Malaysia), wird zum Geschäftsführer ernannt. 

3.- Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu

verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem
Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. Kos, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 juillet 2006, vol. 537, fol. 10, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091183.3/231/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.

JOBEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 108.237. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01131, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095622.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

1.- Die Gesellschaft CORAX INC., mit Sitz in Lot 24, Taman Hilltop Phase II, F.T. Labuan (Malaysia), fünfzig

Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Die Gesellschaft GALLO INC., mit Sitz in Lot 24, Taman Hilltop Phase II, F.T. Labuan (Malaysia), fünfzig

Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: einhundert Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Junglinster, den 14. August 2006.

J. Seckler.

Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Signature.

95179

THE THREE WITCHES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2118 Luxembourg, 5, allée Mansfeld.

R. C. Luxembourg B 57.973. 

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement rendu en date du 12 octobre 2006, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

THE THREE WITCHES, S.à r.l., avec siège social à L-2118 Luxembourg, 5, allée Mansfeld.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge, et liquidateur Maître Marguerite

Ries, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 31 octobre 2006 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04616. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113135.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

THE CARS EUROPEEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement rendu en date du 12 octobre 2006, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

THE CARS EUROPEEN, S.à r.l., dont le siège social à L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer, a été dénoncé en

date du 3 décembre 2001.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge, et liquidateur Maître Marguerite

Ries, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 31 octobre 2006 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04618. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113139.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

PAN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 39.509. 

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement rendu en date du 12 octobre 2006, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

PAN IMMOBILIERE S.A., dont le siège social à L-1012 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth, a été dénoncé en date

du 18 mars 2004.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge, et liquidateur Maître Marguerite

Ries, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 31 octobre 2006 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04620. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113141.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Pour extrait conforme
M

e

 M. Ries

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
M

e

 M. Ries

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
M

e

 M. Ries

<i>Le liquidateur

95180

RGB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 55.109. 

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement rendu en date du 12 octobre 2006, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

RGB, S.à r.l., dont le siège social à L-1014 Luxembourg, 58, rue Glesener, a été dénoncé en date du 7 août 1997. 
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge, et liquidateur Maître Marguerite

Ries, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 31 octobre 2006 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04622. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113143.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

FIELD POINT PE V (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 116.685. 

In the year two thousand and six, on the twelfth day of July,
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

FIELD POINT (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, existing under the laws of Luxembourg,

having its registered office in 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 114.791,

duly represented by Saskia Konsbruck, lawyer, residing in Luxembourg,
in its quality as sole shareholder of:
FIELD POINT PE V (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
a société à responsabilité limitée, having its registered office in 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg (the «Company»),

incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 18 May 2006, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
116.685.

The sole shareholder asks the notary to state:
I. That the sole shareholder present or represented, the proxy of the represented shareholder and the number of

his shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the sole shareholder, the proxy of the repre-
sented shareholder and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxy of the represented shareholder, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to

the present deed.

II. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the sole shareholder

present or represented declaring that it has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notice was necessary.

III. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly delib-

erate on all the items of the agenda.

Then the sole shareholder after deliberation, took the following resolutions:

<i>First and second resolution

The sole shareholder resolves to change the corporate purpose of the Company and to accordingly amend article 2

of the articles of incorporation to read as follows:

«The purpose of the Company is the acquisition and disposition of shares of stock, equity interests and other equity

securities, loans, bonds, debentures, obligations, notes, advances, and other debt instruments and securities, whether
unsecured or secured by equipment, personal property, receivables and other collateral other than real estate, issued
or assumed by companies domiciled either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as the management
of all operations relating to such shares, loans and other equity and debt instruments and securities, including the direct
or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies acting as debtors, borrowers or obligors.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale, as well the holding, leasing, improving, managing

and mortgaging of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as the management
of all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxem-
bourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management
and/or lease of real estate properties.

Pour extrait conforme
M

e

 M. Ries

<i>Le liquidateur

95181

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-

plishment of its purpose.»

There being no further business, the meeting is adjourned.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a German version; upon request of the appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person known to the notary by its name, first name, civil status and

residence, said person signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den zwölften Juli,
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

FIELD POINT (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht von

Luxemburg, mit Sitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg unter der Nummer B 114.791, 

hier vertreten durch Saskia Konsbruck, Rechtsanwältin, wohnhaft zu Luxemburg,
in ihrer Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter von:
FIELD POINT PE V (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
einer société à responsabilité limitée mit Sitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg (die «Gesellschaft»), gegründet

gemäß einer Urkunde des unterzeichneten Notars vom 18. Mai 2006, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B
116.685.

Der Gesellschafter ersucht den unterzeichneten Notar zu beurkunden:
I. Dass der alleinige Gesellschafter anwesend oder vertreten ist und dass der Vertreter des vertretenen Gesellschaf-

ters und die Anzahl seiner Gesellschaftsanteile in einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste wird
von dem alleinigen Gesellschafter, dem Vertreter des vertretenen Gesellschafters und von dem Büro der Versammlung
unterzeichnet und gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Vollmacht des vertretenen Gesellschafters wird nach Zeichnung ne varietur durch die erschienenen Parteien

ebenfalls gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

II. Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und der alleinige Gesellschafter, der anwesend

oder vertreten ist, sich als ordnungsgemäß einberufen bekennt und erklärt, dass er vor der Versammlung über die
Tagesordnung in Kenntnis gesetzt wurde, so dass keine Einberufungsschreiben notwendig waren.

III. Dass diese gegenwärtige Versammlung, bei der das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, ordnungsgemäß

zusammengesetzt ist und rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung beraten kann.

Nach Beratung trifft der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse: 

<i>Erster und zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, den Zweck der Gesellschaft zu ändern und somit auch den Artikel 2 der

Gesellschaftssatzung, der nun wie folgt lautet:

«Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Veräußerung von Aktienanteilen, Kapitalbeteiligungen und anderen

Beteiligungstiteln, Darlehen, Obligationen, Schuldscheinen, Krediten und anderen Schuldtiteln und Wertpapieren, ob
ungesichert oder gesichert durch Einrichtungen, persönliches Eigentum, Forderungen und andere Sicherheiten, bei
denen es sich nicht um Grundstücke handelt, die von Gesellschaften mit Sitz in Luxemburg oder im Ausland ausgegeben
oder übernommen werden, sowie die Verwaltung aller Geschäfte in Zusammenhang mit solchen Anteilen, Darlehen und
anderen Eigenkapitalinstrumenten, Schuldtiteln und Wertpapieren, einschließlich der direkten oder indirekten Beteili-
gungen in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, die als Schuldner oder Kreditnehmer handeln.

Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf sowie der Besitz, die Vermietung, die Sanierung,

die Verwaltung von und die Gewährung von Hypotheken auf Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland sowie
die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Erwerbs von Beteiligungen in
luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Zweck der Erwerb, die Verwertung, die Förderung, der Ver-
kauf, die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus Garantien übernehmen für Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indi-

rekte Beteiligung hält oder die derselben Gruppe angehören wie die Gesellschaft, und kann diesen Gesellschaften Dar-
lehen gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.»

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, wird die Versammlung für beendet erklärt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Erschienenen diese

Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichun-
gen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

95182

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.

Gezeichnet: S. Konsbruck, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, vol. 154S, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094633.3/211/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.

FIELD POINT PE V (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 116.685. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 43422 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 6 septembre 2006.

(094634.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.

PROCABLE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6947 Niederanven, 7, Z.I. Bombicht.

H. R. Luxemburg B 118.695. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsechs, den elften August,
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitz in Luxemburg, 

Sind erschienen:

1. Die Aktiengesellschaft ATMOSFAEHR S.A., eingetragen im Handelsregister Luxembourg, Nummer B 69.790, mit

Sitz in L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch, 

hier vertreten durch Herrn Robert Weirig, Privatbeamter, wohnhaft in Sandweiler,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt in Luxemburg, am 9. August 2006.
2. Die Aktiengesellschaft KINGFISHER SERVICES S.A., eingetragen im «The General Public Registry Directorate,

Card No 368576, Doc. 33774, Panama City», mit Sitz in Panama 5, Republic of Panama, 34-20 Calle 34,

hier vertreten durch Herrn Robert Weirig, vorbenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt in Luxemburg, am 9. August 2006.
Diese Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen.
Diese Erschienenen ersuchten den instrumentierenden Notar, wie folgt die Satzung einer von ihnen zu gründenden

Aktiengesellschaft (société anonyme) zu beurkunden:

Kapitel I.- Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet unter der Bezeichnung PROCABLE S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Niederanven.
Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am

Gesellschaftssitz, oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird
oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluß vorüberge-
hend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Die vorübergehende Verlegung des Gesellschaftssitzes beeinträchtigt nicht die Nationalität der Gesellschaft; die

diesbezügliche Entscheidung wird getroffen und Drittpersonen zur Kenntnis gebracht durch dasjenige Gesell-
schaftsgremium, welches unter den gegebenen Umständen am besten hierzu befähigt ist.

Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Handel, der Im- und Export von Waren, insbesonders von Kabeln, sowie alle

damit direkt oder indirekt verbundenen Nebenleistungen.

Zweck der Gesellschaft ist weiterhin die Erbringung von allgemeinen Dienstleistungen und Verwaltungstätigkeiten.
Die Gesellschaft kann Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-

schaften aufnehmen sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen vornehmen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung,

festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Grün-
dung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe
angedeihen lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von Ge-
sellschaften teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erscheinen.

Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte

erwerben, verwalten und verwerten.

Luxemburg, den 11. August 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

95183

Kapitel II.- Gesellschaftskapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in tausendzweihun-

dertvierzig (1.240) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt

werden.

Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre. 
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen

Bedingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder vermindert werden.

Kapitel III.- Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet. Die Mitglieder

des Verwaltungsrates müssen nicht Aktionär der Gesellschaft sein. Sie werden ernannt von der Generalversammlung
der Aktionäre; die Dauer ihrer Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Die Generalversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit die Mitglieder des Verwaltungsrates abberufen.
Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, ihre Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Gene-

ralversammlung festgesetzt.

Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Präsidenten.
Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden einberufen durch den Präsidenten, so oft das Interesse der Gesellschaft

es verlangt. Der Verwaltungsrat muß einberufen werden, falls zwei Verwaltungsratsmitglieder es verlangen.

Zum ersten Mal kann die der Gesellschaftsgründung folgende ausserordentliche Generalversammlung einen Vorsit-

zenden, einen Präsidenten oder einen Delegierten des Verwaltungsrats ernennen.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um die Verwaltung und die Geschäf-

te der Gesellschaft durchzuführen. Grundsätzlich ist er zuständig für alle Handlungen, welche nicht durch die Satzung
oder durch das Gesetz der Generalversammlung vorbehalten sind. Der Verwaltungsrat kann, unter den gesetzlichen
Bestimmungen, Vorschüsse auf Dividenden zahlen.

Art. 9. Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Delegierten des

Verwaltungsrates vertreten, ungeachtet der in Artikel 10 der Satzung vorgesehenen Vollmachten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben im

Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen, welche die
Bezeichnung von geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern tragen.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung oder bestimmte Punkte und Bereiche davon an

einen oder mehreren Direktoren übertragen, oder für bestimmte Funktionen Sondervollmachten an von ihm gewählte
Prokuristen abgeben, die weder Mitglied des Verwaltungsrates, noch Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen.

Art. 11. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-

tungsrat, oder ein vom Verwaltungsrat dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten.

Kapitel IV.- Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft untersteht einem oder mehreren Kommissaren. Die Kommissare werden

durch die Generalversammlung ernannt. Die Generalversammlung bestimmt desweiteren über ihre Anzahl, ihre Bezüge
und über die Dauer ihres Mandates.

Die Dauer des Mandates der Kommissare darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Kapitel V.- Generalversammlung

Art. 13. Eine jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an dem in der Einberufung angegebenen

Ort, am letzten Freitag des Monats mai eines jeden Jahres um 10.00 Uhr statt.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag

verschoben.

Kapitel VI.- Geschäftsjahr, Jahresergebnis

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Der Reingewinn besteht aus dem Überschuß, welcher in der Bilanz nach Abzug der Verbindlichkeiten,

Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibt.

Jährlich sind fünf Prozent (5,00%) des Reingewinnes den gesetzlichen Rücklagen zuzuführen, und zwar solange bis die

Rücklagen zehn Prozent (10,0%) des Gesellschaftskapitals erreicht haben. Falls die Rücklagen, aus welchem Grunde es
auch sei, vermindert werden sollten, so sind die jährlichen Zuführungen von fünf Prozent (5,0%) des Reingewinnes
wieder aufzunehmen.

Über den hinausgehenden Betrag des Reingewinnes verfügt die Generalversammlung nach freiem Ermessen.

Kapitel VII.- Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.
Gelangt die Gesellschaft zur Auflösung, so erfolgt ihre Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren. Liquida-

toren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften sein. Die Ernennung der Liquidatoren, die Festsetzung
ihrer Befugnisse und ihre Bezüge werden durch die Generalversammlung vorgenommen.

95184

Kapitel VIII.- Allgemeines

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des luxemburgischen

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich allen Ergänzungen und Änderungen hinge-
wiesen. 

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2007 statt.

<i>Zeichnung der Aktien

Nachdem die Satzung der Gesellschaft wie hiervor angegeben verabschiedet wurde, haben die Gründer die Aktien

wie folgt gezeichnet: 

Die hiervor gezeichneten Aktien wurden voll in bar eingezahlt, sodass der Gesellschaft ab heute die Summe von

einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, worüber dem unterzeichneten Notar der Nachweis
gebracht wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, daß alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften gegeben sind und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen
Bedingungen.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag aller Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit

ihrer Gründung erwachsen oder berechnet werden, wird abgeschätzt auf 3.000,- Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben sich die Erschienenen, welche die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals vertreten, zu

einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden, zu welcher sie sich als ordentlich einberufen
betrachten. Sie stellen fest, daß die Generalversammlung rechtskräftig bestellt ist und fassen einstimmig folgende
Beschlüsse:

1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgesetzt auf drei Personen, diejenige der Kommissare auf eine

Person.

2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012 berufen:
a) Herrn Udo Roman Guldner, Diplom-Kaufmann, geboren am 18.Januar 1960 in Aachen/Deutschland, wohnhaft in

F-57350 Spicheren, 1, rue Docteur Schweitzer. 

b) Frau Isabelle Guldner geborene Bubel, Diplom-Betriebswirt, geboren am 6. August 1966 in Bitche/Frankreich,

wohnhaft in F-57350 Spicheren, 1, rue Docteur Schweitzer.

c) Die Aktiengesellschaft KINGFISHER SERVICES S.A., eingetragen im «The General Public Registry Directorate,

Card N

°

 368576, Doc. 33774, Panama City», mit Sitz in Panama 5, Republic of Panama, 34-20 Calle 34.

Herr Udo Roman Guldner und Frau Isabelle Guldner-Bubel werden als Delegierte des Verwaltungsrates ernannt.
3. Zum Kommissar wird bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012 berufen:
Die Gesellschaft LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l., eingetragen im Handelsregister Luxembourg, Nummer B 69.995,

mit Sitz in L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

4. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6947 Niederanven, 7, Z.I. Bombicht.

Worüber Urkunde, aufgenommen in der Amtsstube in Luxemburg.
Nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt; haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Weirig, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, vol. 29CS, fol. 43, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial erteilt, Recueil des Sociétés et

Associations. 

(091428.3/216/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.

1) Die Gesellschaft ATMOSFAEHR S.A.H., vorgenannt, eintausendzweihundertneununddreissig Aktien . . . . .  1.239
2) Die Gesellschaft KINGFISHER SERVICES S.A., vorgenannt, eine Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: tausendzweihundertvierzig Aktien 

1.240

Luxemburg, den 11. August 2006.

J.-P. Hencks.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Imdeco S.A.

Eldalux, S.à r.l.

CIS Luxembourg S.A.

Tishman Speyer Esof Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

Tishman Speyer Esof Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

Vermietungsgesellschaft Objekt 12

AKH Luxco

AKH Luxco

Santropa

Newell Luxembourg Finance, S.à r.l.

Web Brands Partners, S.à r.l.

Web Brands Partners, S.à r.l.

Pin Logistics AG

BC International S.A.

Resolution Senia Nord Luxembourg, S.à r.l.

Resolution Senia Nord Luxembourg, S.à r.l.

Field Point PE V (Luxembourg), S.à r.l.

Chamarel S.A.

Kauri Capital 3

Field Point BL I (Luxembourg), S.à r.l.

Snake International S.A.

Colfin Europe, S.à r.l.

Vermietungsgesellschaft Objekt 11

Fidugest S.A.

RSL S.A.

Florenne S.A.

New Tech Venture Capital II Investments, S.à r.l.

New Tech Venture Capital II Investments, S.à r.l.

Dolpa, S.à r.l.

Badlux, S.à r.l.

GoldenTree Asset Management Lux, S.à r.l.

GoldenTree Asset Management Lux, S.à r.l.

Elettra Holdings, S.à r.l.

General Investment Projects S.A.

General Investment Projects S.A.

HC Investissements, S.à r.l.

Vermilion, S.à r.l.

Meubles Carlo Scheer &amp; Cie, S.à r.l.

Etimine S.A.

Etimine S.A.

Agence Pundel, S.à r.l.

Mon Jardin - Nouvelles Créations, S.à r.l.

Mon Jardin - Espace Vert, S.à r.l.

The Server Group Europe S.A.

Fjord, S.à r.l.

LM &amp; Partners (LM-IS) SCA

Immodun, S.à r.l.

Yellow Perfection, S.à r.l.

Kovrolux

Silift

Epic Luxembourg S.A.

Europa Freight Corporation

Alexander J. Davies, S.à r.l.

P.T. Investments S.A.

Keersma S.A.

STI, Systèmes Technologiques Industriels S.A.

GPS Shop, S.à r.l.

Christian, Société à responsabilité limitée

Loca-Nord S.A.

ASL Automobile, S.à r.l.

Web Brands GP, S.à r.l.

Web Brands GP, S.à r.l.

CEDAL S.A., Centre d’Expertise et de Diagnostic Automobiles Luxembourgeois

Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Luxembourg AG

International Tobacco Advisory Services Ltd S.A.

CM Capital Markets Europe S.A.

European Fund Services S.A.

Coliseo Investissement S.A.

Keersma S.A.

Multi-Projects S.A.

P.S.A. Luxembourg, S.à r.l.

P.S.A. Luxembourg, S.à r.l.

P.S.A. Luxembourg, S.à r.l.

P.S.A. Luxembourg, S.à r.l.

Pharmeg Holding S.A.

Déchetsgestion, S.à r.l.

Joben S.A.

The Three Witches, S.à r.l.

The Cars Europeen, S.à r.l.

Pan Immobilière S.A.

RGB, S.à r.l.

Field Point PE V (Luxembourg), S.à r.l.

Field Point PE V (Luxembourg), S.à r.l.

Procable S.A.