logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

92305

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1924

12 octobre 2006

S O M M A I R E

CASTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 45.716. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06667, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090051.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

CASTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 45.716. 

Les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06670,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090047.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

Aero Ré, S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92333

Lux  Euro-Asian  Investments  III,  S.à r.l.,  Luxem- 

Aerospace Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

92333

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

92331

Antlia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92339

North Star Participations S.A., Luxembourg  . . . . 

92339

Berkshire S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92333

Novares International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

92342

Boissonot Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

92339

Pamplona PE Holdco 4 S.A., Luxembourg  . . . . . . 

92308

Bonus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92342

Perseus I, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

92333

Castel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92305

Reimerwé, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

92337

Castel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92305

Reimerwé, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

92338

Fratelli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92335

SES Global Latin America S.A., Betzdorf  . . . . . . . 

92344

Glarksdale Marine Investment Corporation, S.à r.l., 

Sonae Re S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

92335

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92335

Thalweg Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

92342

Globavia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92333

Theisen & Schmitz, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

92335

H2O Land, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

92339

Theisen & Schmitz, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

92335

Intervalor S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

92328

TS Koenigsallee Fixtures, S.à r.l., Senningerberg . 

92306

Intervalor S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

92330

TS Koenigsallee Fixtures, S.à r.l., Senningerberg . 

92307

Lerins Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

92342

Luxembourg, le 21 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 21 août 2006.

Signature.

92306

TS KOENIGSALLEE FIXTURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 110.498.

In the year two thousand and six, on the twenty-fifth of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TS KOENIGSALLEE HOLDINGS I, S.à r.l., a private limited liability company incorporated and organized under the

Luxembourg law, having its registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Trade and Com-
pany Register of Luxembourg, section B, under number 110.499,

here represented by Mr Gael Toutain, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Luxembourg,
by virtue of a proxy established on February 28th, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») established in the Grand Duchy of Luxembourg under the name of TS KOENIGSALLEE FIXTURES, S.à r.l. (here-
after the «Company»), having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Luxembourg, and duly registered with the
Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 110.498, incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary of August 24th, 2005, published in the Mémorial, Recueil Spécial n. 1467 dated December 28th,
2005.

II. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five

hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company’s share capital by five hundred sixteen thousand two hun-

dred Euro (EUR 516,200.-) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) up to five hundred twenty-eight thousand seven hundred Euro (EUR 528,700.-) by the creation and issue of
twenty thousand six hundred and forty-eight (20,648) new shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-)
each.

<i>Subscription - Payment

The sole shareholder, TS KOENIGSALLEE HOLDINGS I, S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, declared to

subscribe the twenty thousand six hundred and forty-eight (20,648) new shares and pay them fully up in the amount of
five hundred sixteen thousand two hundred Euro (EUR 516,200.-) consisting in the conversion of a receivable as of Sep-
tember 15th, 2005, whereby the Company promised to pay to the order of its sole shareholder, TS KOENIGSALLEE
HOLDINGS I, S.à r.l., prenamed, the amount of five hundred sixteen thousand two hundred Euro (EUR 516,200.-) cor-
responding to the amount due and payable under the terms and conditions of an interest free loan note signed between
the Company and its sole shareholder (the «Note»). Proof of the existence and value of such receivable has been given
to the undersigned notary by the original of the Note between the Company and its sole shareholder.

The sole shareholder declares that the total value of the contribution in kind is five hundred sixteen thousand two

hundred Euro (EUR 516,200.-).

IV. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth

read as follows:

Art. 6. «The share capital is fixed at five hundred twenty-eight thousand seven hundred Euro (EUR 528,700.-), divid-

ed into twenty-one thousand one hundred and forty-eight (21,148) shares, with a nominal value of twenty-five Euro
(EUR 25.-) each, fully paid up.»

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which will be borne by the Company as a

result of the presently stated increase of capital, are estimated at nine thousand Euro (EUR 9,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation.

On request of the same appearing person and, in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,

civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

92307

A comparu:

TS KOENIGSALLEE HOLDINGS I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous lé numéro 110.499,

ici représentée par M. Gael Toutain, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-

berg,

en vertu d’une procuration donnée le 28 février 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de TS KOENIGSALLEE FIXTURES, S.à r.l. (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 110.498, et,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 août 2005, publié au Mémorial, Recueil Spécial
n. 1467 en date du 28 décembre 2005.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent seize mille deux cents euros (EUR

516.200,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à cinq cent vingt-huit
mille sept cents euros (EUR 528.700,-) par la création et l’émission de vingt mille six cent quarante-huit (20.648) parts
sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Souscription - Libération

L’associé unique, TS KOENIGSALLEE HOLDINGS I, S.à r.l., précitée, par son mandataire, déclare souscrire aux vingt

mille six cent quarante-huit (20.648) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement au montant de cinq cent seize
mille deux cents euros (EUR 516.200,-) consistant en la conversion d’une dette en vertu de laquelle la Société s’est en-
gagée à payer à son associé unique, TS KOENIGSALLEE HOLDINGS I, S.à r.l., prénommée, un montant de cinq cent
seize mille deux cents euros (EUR 516.200,-) correspondant au montant dû et exigible en vertu des conditions d’un prêt
sans intérêt entre la Société et son associé unique (le «Prêt») en date du 15 septembre 2005. Preuve de l’existence et
de la valeur du Prêt a été donnée au notaire instrumentant par l’original du contrat de prêt sans intérêt entre la Société
et son associé unique.

Le seul associé déclare que la valeur totale de cet apport en nature est de cinq cent seize mille deux cents euros (EUR

516.200,-).

IV. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur sui-

vante:

Art. 6. «Le capital est fixé à cinq cent vingt-huit mille sept cents euros (EUR 528.700,-), représenté par vingt et un

mille cent quarante-huit (21.148) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf mille euros (EUR 9.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il

a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Toutain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, vol. 153S, fol. 39, case 9. – Reçu 5.162 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087017.3/211/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2006.

TS KOENIGSALLEE FIXTURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 110.498. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 42494 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 18 août 2006.

(087018.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2006.

Luxembourg, le 6 juin 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

92308

PAMPLONA PE HOLDCO 4 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 118.106. 

In the year two thousand and six, on the fourteenth day of August.
Before us, Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of PAMPLONA PE HOLDCO 4 S.A. a

Luxembourg société anonyme having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 118.106 (the Company).

The Company was incorporated on 28 July 2006 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing at

Remich (Grand Duchy of Luxembourg), which deed has not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.

The Meeting is chaired by Gwen Vanweddingen, lawyer, professionally residing in Luxembourg (the Chairman). The

Chairman appoints Aldric Grosjean, lawyer, professionally residing in Luxembourg, as secretary of the Meeting (the Sec-
retary). The Meeting elects Claire-Marie Darnand, lawyer, professionally residing in Luxembourg as scrutineer of the
Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the
Bureau.

The shareholders of the Company represented at the Meeting and the number of ordinary shares (the Ordinary

Shares) they hold are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been
signed by the representatives of the shareholders and the members of the Bureau.

The proxies from the shareholders represented at the Meeting, after having been signed ne varietur by the proxy-

holder and the undersigned notary, shall also remain attached to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:
I. It appears from the attendance list that 40,000 ordinary shares of the Company having a nominal value of EUR 1.25

each representing the entire subscribed share capital of the Company amounting to EUR 50,000 are present or duly
represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda.

II. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of the convening notices.
2. Creation of a new class of voting shares of the Company to be designated as preferred shares (the Preferred

Shares), and subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company and insertion of a new
article dealing with the right pertaining with the Preferred Shares (the Articles).

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 149,385 (one hundred and forty-nine thousand

three hundred and eighty-five Euro) in order to bring the share capital of the Company from its current amount of EUR
50,000 (fifty thousand Euro) to EUR 199,385 (one hundred and ninety-nine thousand one hundred and eighty-five Euro)
by way of creation of 119,508 (one hundred and nineteen thousand five hundred and eight) Preference Shares having a
nominal value of EUR 1.25 each (one Euro twenty-five cents).

4. Waiver by Pavel Nazarian of its preferential subscription right and acceptance that the newly issued Preferred

Shares be all subscribed by PAMPLONA CAPITAL PARTNERS I, LP.

5. Subscription and payment of the share capital increase referred to under item 3. above.
6. Subsequent amendment of article 5 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital referred to

under item 3.

7. Amendment of each articles of the Articles to the extent necessary so as to insert the relevant provisions of a

shareholders’ agreement relating to all securities in the Company, insertion of a definition section and new articles in
the Articles in view of inserting the relevant provisions of a shareholders’ agreement relating to all securities in the Com-
pany therein; subsequent renumbering and restatement of the Articles in their entirety, with insertion or changes, to
the extent necessary, of headings in the Articles.

8. Amendment of the share register of the Company and authorisation to any director of the Company to proceed

on behalf of the Board of Directors of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register
of the Company.

9. Miscellaneous.
III. After deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the subscribed share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives

the convening notices, the shareholders of the Company represented considering themselves as duly convened and de-
claring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to create a new class of voting shares of the Company to be designated as preferred shares

(the Preferred Shares), and subsequently to amend article 5 of the Articles and to insert of a new article dealing with
the right pertaining with the Preferred Shares.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 149,385 (one hundred and

forty-nine thousand three hundred and eighty-five Euro) in order to bring the share capital of the Company from its
current amount of EUR 50,000 (fifty thousand Euro) to EUR 199,385 (one hundred and ninety-nine thousand three hun-

92309

dred and eighty-five Euro) by way of creation of 119,508 (one hundred and nineteen thousand five hundred and eight)
Preference Shares having a nominal value of EUR 1.25 each (one Euro twenty-five cents).

<i>Fourth resolution

The Meeting acknowledges that Pavel Nazarian waives, in its capacity as an existing shareholder of the Company, its

preferential subscription right in respect of the newly issued Preferred Shares and accepts that all these newly issued
Preferred Shares be subscribed only by PAMPLONA CAPITAL PARTNERS I, LP, the other shareholder of the Com-
pany.

<i>Fifth resolution

The Meeting approves and accept the following subscription and payment of the 119,508 (one hundred and nineteen

thousand five hundred and eight) newly issued Preferred Shares of the Company as follows:

<i>Subscription - Payment

One of the two current shareholders of the Company, being PAMPLONA CAPITAL PARTNERS I, LP, PAMPLONA

CAPITAL PARTNERS I, LP, an exempted limited partnership formed under the laws of the Cayman Islands having its
registered office at PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-
lands, hereby represented by Aldric Grosjean, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
in George Town, Grand Cayman, on 10 August 2006, declares to subscribe to 119,508 (one hundred and nineteen thou-
sand five hundred and eight) newly issued Preferred Shares and to fully pay them up by a contribution in cash.

The contribution in cash in an aggregate amount of EUR 149,385 (one hundred and forty-nine thousand three hun-

dred and eighty-five Euro) is to be allocated to the nominal share capital of the Company.

Evidence of such payment in an aggregate amount of EUR 149,385 (one hundred and forty-nine thousand three hun-

dred and eighty-five Euro) has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate issued by ING
LUXEMBOURG on 10 August 2006 confirming the availability of the subscription amounts on the Company’s bank
account.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Articles in order to reflect the changes adopted

under the third resolution above, so that it shall henceforth read as follows:

«Art. 5. Share Capital 
5.1 The subscribed share capital of the Company is set at EUR 199,385 (one hundred and ninety-nine thousand one

hundred and eighty-five Euro), represented by 40,000 (forty thousand) ordinary shares with a par value of EUR 1.25
(one Euro and twenty-five cents) each and by 119,508 (one hundred and nineteen thousand five hundred and eight) Pre-
ferred Shares with a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each (the Ordinary Shares and the Preferred
Shares are collectively referred to as the Shares).»

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to amend each of the articles of the Articles to the extent necessary so as to insert the relevant

provisions of a restated and amended shareholders’ agreement relating to all securities in the company. As a conse-
quence, the Meeting resolves to insert a definition section in the Articles and new articles in the Articles in view of
inserting the relevant provisions of restated and amended shareholders’ agreement relating to all securities in the com-
pany therein. The Meeting resolve to restate and renumber the Articles in their entirety, and to the extent necessary,
to insert or change any headings in the Articles, so that they read in their entirely amended, renumbered and restated
version as follows:

Chapter I. Definitions

ACIRA means ACIRA SCHMUCKVERTRIEBS, GmbH, a limited liability company under German law (Gesellschaft

mit beschränkter Haftung, GmbH), having its registered office in Obertshausen, Germany, and being registered with the
Commercial Register (Handelsregister) of the Local Court (Amtsgericht) of Offenbach under the registration number
HRB 6936.

Additional Shares has the meaning ascribed to this term in the SHA and is of an amount as set out in the exhibit 2.1

of the SHA.

Advisory Agreement has the meaning acribed to this term in Section 9.1 of the SHA.
AMOR, GmbH &amp; Co. KG means a limited partnership (Kommanditgesellschaft KG) having its registered office in

Obertshausen, Germany, and being registered with the Commercial Register (Handelsregister) of the Local Court
(Amtsgericht) of Offenbach under the registration number HRA 9003 or any of its legal successors.

AMOR Group Companies has the meaning ascribed to in recital (A) of the SHA. 
AMOR Transaction has the meaning ascribed to in recital (E) of the SHA.
Articles means the articles of association of the Company.
Bad Leaver I means the Leaver I who (i) is asked to leave AMOR, GmbH &amp; Co. KG for Cause I and the employment

agreements being in place between him and any of the AMOR Group Companies are terminated by the relevant Group
Company for good cause (wichtiger Grund) within the meaning of Section 626 of the German Civil Code (Bürgerliches
Gesetzbuch) or (ii) if he is in breach of his non-compete obligations under his employment agreement.

Bad Leaver II means the Leaver II whose (i) Advisory Agreement between him and AMOR, GmbH &amp; Co. KG is ter-

minated for Cause II or (ii) who is in breach of his non-compete obligations under the SPA and/or the SHA.

Board means the board of directors of the Company.

92310

Cause I means events based on which (i) the Leaver I is sentenced by a final court order for criminal offences to the

disadvantage of any Group Company (including but not limited to for a bankruptcy offence, fraud or breach of trust
pursuant to the provisions of the German Criminal Code (Strafgesetzbuch)) or a similar Luxembourg or foreign provi-
sion or (ii) any of the Group Companies suffers a damage and/or any other loss due to intentional actions of the Leaver I.

Cause II means (i) events based on which Leaver II is sentenced by a final court order for criminal offences to the

disadvantage of any Group Company (including but not limited to for a bankruptcy offence, fraud or breach of trust
pursuant to the provisions of the German Criminal Code (Strafgesetzbuch)) or a similar foreign provision or (ii) Leaver
II intentionally inflicting damages on any of the Group Companies after 31 May 2006 other than consistent with past
practice.

Co-lnvestor(s) has the meaning ascribed to this term in recital (A) of the SHA.
Company means PAMPLONA PE HOLDCO 4 S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme)

having its registered office at 43, boulevard de la Petrusse, L-2320 Luxembourg and in the process of registration with
the Luxembourg Trade and Company Register.

CPEC means all the convertible preferred equity certificates issued by the Company from time to time.
Exit means:
(a) a Listing;
(b) the sale of all or substantially all of the Shares;
(c) the disposal by one or more transactions of all or substantially all of the shares of GmbH 1, GmbH 2, AMOR,

GmbH &amp; Co. KG or the business of the AMOR Group excluding any intragroup reorganization within the existing
group; or

(d) recapitalisation of any of the Company, GmbH 1, GmbH 2 or AMOR, GmbH &amp; Co. KG.
Fair Market Value means the fair market value determined in accordance with the procedure set out in clause 13.5

of the SHA.

General Shareholders Meeting means the general meeting of the Shareholders of the Company.
Good Leaver I means (i) a Leaver I whose cessation of employment or service occurs as a result of death, disability

or retirement at the normal retirement age (of 60 years) or (ii) an Intermediate Leaver I who serves notice on AMOR,
GmbH &amp; Co. KG (a) for good cause or (b) after more than four years following the completion date of the transaction
as contemplated by the SHA. 

Good Leaver II means a Leaver II whose termination of the Advisory Agreement occurs for reasons not qualifying as

a Bad Leaver II.

GmbH 1 means RM 2646 VERMÖGENSVERWALTUNGS, GmbH, a German company, having its registered office in

Munich and registered in the Commercial Register of the local court of Munich under number 163126.

GmbH 2 means AMOR, GmbH i. G., a German limited liability company, having its registered office in Obertshausen

and being in the process of registration with the Commercial Register of the local court of Offenbach.

Group Companies means the Company, GmbH 1, GmbH 2, AMOR, GmbH &amp; Co. KG or any subsidiary of any of

these companies (each a Group Company).

Individual Investment Amount means the individual investment amount as defined in the SHA and as set out in exhibit

2.1 of the SHA.

Intermediate Leaver I means a Leaver I who leaves AMOR, GmbH &amp; Co. KG and serves notice on AMOR, GmbH &amp;

Co. KG and who is not a Good Leaver I or Bad Leaver I.

Issuance means any issuance of shares, CPECs, PECs or any other securities or rights resulting in claims against the

Company (whether convertible into equity or not, but excluding straight bank loans at arms length) and all other
measures that might lead to a economical dilution of any shareholder other than PAMPLONA.

Leaver I means a Shareholder who is a Co-Investor and ceases to be an employee of AMOR, GmbH &amp; Co. KG in

accordance with Section 13.1 of the SHA. 

Leaver II means a Shareholder who is a Co-Investor and ceases to be an advisor of AMOR, GmbH &amp; Co. KG in

accordance with Section 14.1 of the SHA. 

Law means the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Leaver means either a Leaver I or a Leaver II.
Listing means the admission to listing of any of the Shares on any regulated investment exchange.
PAMPLONA means PAMPLONA CAPITAL PARTNERS I, LP, an exempted limited partnership formed under the

laws of the Cayman Islands having its registered office at PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT LLP means PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT LLP, a limited liability

partnership under the laws of England having its business address at 25 Park Lane, London W1K 1RA, United Kingdom. 

PEC means all the preferred equity certificates issued by the Company from time to time.
Preferred Shares means the voting preferred shares of the Company outstanding from time to time.
Ordinary Shares means the ordinary shares of the Company outstanding from time to time.
Securities means collectively the Ordinary Shares, the Preferred Shares, the PEC and the CPEC.
SHA means the shareholders’ agreement relating to all securities in the Company dated 2 August 2006 by and

between Dr. Ulrich Byszio and Mr Torsten Hörnis, PAMPLONA PE HOLDCO 4 S.A. and PAMPLONA CAPITAL
PARTNERS I, LP.

Shares means the Preferred Shares and the Ordinary Shares.
Shareholders means the persons holding Shares in the Company from time to time.
SPA means the sale and purchase agreement dated on or around 2 August 2006 (deed role no. 202 of the notary

Johann Andreas Rossbach, Frankfurt am Main, Germany), by and between inter alia GmbH 1 acting on the account and

92311

on behalf of GmbH 2, Dr. Ulrich Byszio, Ms Susann Byszio, AMOR, GmbH &amp; Co. KG, ACIRA and PAMPLONA
CAPITAL MANAGEMENT LLP, whereby GmbH 2 will acquire all limited partnership interests in AMOR, GmbH &amp; Co.
KG and all shares in ACIRA and certain other entities as described in section 1.4 of this agreement.

Total Investment means the amount to be invested in the Company by PAMPLONA and the Co-Investors in accord-

ance with exhibit 2.1 of the SHA.

Transaction Documentation means the SPA and the Facilities Agreement between GmbH 1 and IKB DEUTSCHE

INDUSTRIEBANK AG.

Chapter II. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There exists among the present Shareholders and all those who may become holders of Shares a public limited liability

company (société anonyme) under the name of PAMPLONA PE HOLDCO 4 S.A.

Art. 2. Registered Office
2.1 The registered office is established in the City of Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary General Meeting of Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by a resolution of the Board.
2.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the Board.

2.5 In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would

interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with
such office, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal
circumstances; such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding
the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be
taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of
the Company.

2.6 The Company’s books and records (including all correspondence) will be kept at the registered office.

Art. 3. Purpose
3.1 The Company’s purpose is to acquire shareholdings and interests, in any form whatsoever, in the AMOR Group

Companies, to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way in the AMOR Group Companies, and generally to hold, manage, develop, sell or
dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit. The Company may further
grant to, or for the benefit of, any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated
in any way with the AMOR Group Companies, any assistance as e.g. pledges, loans, advances or guarantees. The Com-
pany may borrow and raise money in any manner for the purpose of its investment in the AMOR Group Companies
and secure the repayment of any money borrowed. The Company may further borrow funds and issue bonds and other
securities to a limited number of subscribers. The Company will not take advantage of the act of 31 July 1929, on Holding
Companies.

3.2 The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to

those matters set out above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. Duration
4.1 The Company is established for an unlimited duration.
4.2 It may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting of Shareholders adopted in the manner

provided by these Articles and by the Law.

Chapter III. Share capital - Ordinary shares - Preferred shares

Art. 5. Share Capital
5.1 The subscribed capital of the Company is set at EUR 199,385 (one hundred and ninety-nine thousand three hun-

dred and eighty-five Euro), represented by 40,000 (forty thousand) Ordinary Shares with a par value of EUR 1.25 (one
Euro and twenty-five cents) each and by 119,508 (one hundred nineteen thousand five hundred and eight) Preferred
Shares with a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each.

5.2 All the Shares are fully paid up.
5.3 Subject to the limitations contained in these Articles, the Board is authorised to issue 340,492 (three hundred

and forty thousand four hundred and ninety-two) ordinary shares which are reserved for the conversion of CPECs out-
standing in Ordinary Shares of the Company and is therefore authorised to bring the subscribed share capital of the
Company from its current amount to an amount of EUR 625,000 (six hundred twenty thousand Euro), it being the limit
of the authorised share capital.

5.4 Subject to the limitations contained in these Articles, the Board is authorised and empowered to:
(a) increase the share capital of the Company within the limits of the authorised share capital by issuing from time to

time new Ordinary Shares only upon conversion of CPECs in Ordinary Shares to be paid up by way of contribution of
assets in kind being the CPECs;

(b) fix the place and the date of the issue or the successive issues of new Ordinary Shares and the terms and condi-

tions of subscription and payment of the new Ordinary Shares; and

(c) abolish or limit the preferential subscription right of the Shareholders when proceeding to the issue of new Or-

dinary Shares upon conversion of the CPECs in Ordinary Shares within the limits of the authorised share capital to be
paid up in kind and in compliance with the provisions of the Articles.

92312

5.5 The above mentioned authorisation will be valid for a period of five years from 14 August 2006 and it may be

renewed by a resolution of the extraordinary General Meeting of Shareholders as to the shares of the authorised capital
which will not have been issued by the Board before then. The above mentioned authorisation shall not be used, directly
or indirectly, to the extent prior consent by the Shareholders is required under these Articles and/or the SHA.

5.6 Each time the Board acts to render effective the increase of capital as authorised above, the present article of the

Articles shall be amended so as to reflect the increase of the subscribed share capital, and the Board or any person
authorised by the Board shall state such amendment in the form prescribed by law.

Art. 6. Ordinary Shares - Preferred Shares
Subject to the distribution of a surplus as provided in article 39 below, each Share entitles to equal profits and liqui-

dation profits of the Company in direct proportion to the number of Shares in existence.

Art. 7. Increase and Reduction of the Capital  
7.1 The capital of the Company may be increased or reduced in one or several times, by a resolution of the Share-

holders adopted in the manner required for the amendment of the Articles and prescribed by the Law.

7.2 The new Shares to be subscribed in cash will be offered by preference to the Shareholders in proportion to the

part of the capital which is represented by their Shares. The General Meeting of Shareholders will fix the period for
exercising the preferential subscription right. It will grant to the Board any powers in order to carry out the decisions
adopted and to fix the conditions of exercise of the preferential subscription right.

7.3 However, by way of derogation from the above, the General Meeting of Shareholders may, in addition to the

authorization set out in article 5.4(c) above and in accordance with the conditions provided in the Law and these Arti-
cles, abolish or limit the preferential subscription right or authorize the Board to do so.

Art. 8. Acquisition and Redemption of Proper Shares
8.1 The Company may acquire its own Shares in accordance with the conditions provided in the Law. The acquisition

and holding of its own Shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Law.

8.2 Notwithstanding any other provisions of the SHA or these Articles, the redemption price for Preferred Shares

shall be at any time equal to the Fair Market Value of the Preferred Shares (the Redemption Price). The Company may
pay the Redemption Price in cash, Ordinary Shares with an aggregate amount equal to the Redemption Price or, with
the prior consent of the concerned Shareholder(s) property with an aggregate amount equal to the Redemption Price.

Art. 9. Form of Shares - Shareholders’ Register
9.1 The Shares will be and remain in registered form.
9.2 A Shareholders’ register will be kept at the registered office and it may be examined by each shareholder who so

requires. The register will contain:

- the precise designation of each Shareholder and the indication of the number of his Shares;
- the indication of the payments made on his Shares;
- the transfers of Shares and the dates thereof.
9.3 Each Shareholder will notify to the Company by registered letter his address and any change thereof. The Com-

pany will be entitled to rely on the last address thus communicated.

9.4 The ownership of the registered Share will be documented by way of the registration of the Shareholder in the

Shareholders’ register.

9.5 Certificates reflecting these inscriptions will be delivered to the Shareholders.
9.6 The transfer of Shares will be made by declaration of transfer registered in the same register, dated and signed

by the transferor and the transferee or by their representatives, as well as on the basis of the provisions on the transfer
of claims laid down in article 1690 of the code civil. The Company may accept and register in the register any transfer
recorded in any correspondence or other documents establishing the consent of the transferor and the transferee.

9.7 Any registration in the Shareholders’ register will be made by the Board or by any person duly authorized to that

effect by the Board.

9.8 The Board shall only register any transfer of Shares made in accordance with the provisions of the SHA and the

registration of the transfer of Shares shall be subject to the conditions set out in article 10.1 hereof.

Chapter IV. Transfer of securities

Art. 10. General Provisions
10.1 If less than all Securities of the Company are transferred to a third party, the transferor shall execute the transfer

only after, and under the conditions that, the transferee, before such transfer, (i) has assumed any and all obligations of
the transferor related to the Securities as provided for in the Articles and the SHA as amended and/or modified from
time to time and (ii) has executed an agreement to such effect prior to the effectiveness of the intended transfer and
assignment.

10.2 Any Securities held by a Co-Investor shall be transferable only in the event of the execution of a Drag Along

Right, Tag Along Right, if the Co-Investor is a Leaver and where the transfer of Securities is performed in accordance
with the terms of these Articles and the SHA or if the Board has agreed to such transfer. Such consent shall be granted
if the relevant Co-Investor intends to transfer his Securities thereof to a company in which he holds all the shares, pro-
vided that such transfer is executed under the condition subsequent (auflösende Bedingung) that the relevant Co-Inves-
tor does no longer hold all shares in such company. For the purposes of these Articles «Transfer» or «Transferable»
shall mean the transfer of Securities or the disposal of Securities by way of sale, assignment or otherwise such as, without
limitation, pledge lien or other virtual disposal.

10.3 Any transfer not made in accordance with the terms of these Articles and of the SHA shall not be valid and

enforceable. Subject to the terms of these Articles, prior to notification of transfer and approval of the Board of the

92313

Company having been given, the Company shall treat the holder of record registered on the share register as the person
exclusively entitled to receive dividends and other distributions, to vote, to receive notice and otherwise to exercise all
the rights and powers of the owner of a relevant Share, and the Company shall not recognize and accept to register any
transfer of shares in its records other than transfers made in accordance with these Articles and the SHA.

10.4 Every holder of Securities shall ensure that he is at all times able and legally empowered to transfer with full title

guarantee the Securities held by him if so required by the SHA.

Art. 11. Tag-along Rights
If PAMPLONA intends to transfer and assign all its Securities by means of sale, transfer and assignment, exchange,

contribution, conversion within the meaning of the German Transformation Act (Umwandlungsgesetz, UmwG), or in
any comparable manner, the remaining Shareholders shall have the right to demand from PAMPLONA that all Securities
held by the remaining Shareholders shall also be transferred to the potential purchaser on the same terms and condi-
tions. Such intention of PAMPLONA shall be notified in advance in writing to the remaining Shareholders. If PAMPLONA
intends to transfer and assign only part of its Securities, the remaining Shareholders shall only be entitled to demand
from PAMPLONA that the same percentage of their Securities shall be transferred and assigned to the Purchaser, pro-
vided however that the remaining Shareholders shall be entitled to demand from PAMPLONA that all their Securities
shall be transferred and assigned if as a result of the transfer and assignment of PAMPLONA’s Securities and the pro-
rata transfer and assignment of the Co-Investors’ Securities, an unrelated third party would obtain the majority of the
voting rights in the Company.

Art. 12. Drag-along Rights
12.1 If PAMPLONA intends to sell Shares representing at least 50% of the ordinary issued share capital in the Com-

pany, PAMPLONA may demand from each remaining Shareholder that the latter sell and transfer the respective pro
rata amount of its Securities relative to the amount of Shares to be sold by PAMPLONA by means of sale and assign-
ment, exchange, contribution, conversion within the meaning of Section 1 of the German Transformation Act
(Umwandlungsgesetz, UmwG) or in a comparable manner at the same price per Ordinary Share, Preferred Share, PEC
or CPEC as will be payable to PAMPLONA (hereinafter referred to as the Drag-Along). The request for the Drag-Along
shall be asserted in advance in writing to the remaining Shareholders. The rights of the remaining Shareholders under
article 11 hereof shall remain unaffected.

12.2 If the purchase price to be paid by the third party for the acquisition of any Securities is lower than the amount

of the Total Investment of those Securities and such purchase price has not been determined by an auction carried out
by a reputable investment bank or in connection with a Listing, the Shareholders obliged under the Drag-Along shall be
entitled, collectively to present an alternative offer for the acquisition of all Shares (the Alternative Offer). The right to
present an Alternative Offer shall expire if the Shareholders obliged under the Drag-Along have not submitted an indic-
ative Alternative Offer within two weeks after service (Zugang) of the Drag-Along notice, or if the Shareholders obliged
under the Drag-Along have not submitted a final Alternative Offer within four weeks after submission of their indicative
Alternative Offer. If a final binding and with fully committed financing Alternative Offer has been provided in accordance
with the foregoing sentence and the purchase price under the Alternative Offer is higher than the purchase price offered
by the third party, PAMPLONA shall be obliged to sell its Securities in accordance with the terms and conditions of the
final Alternative Offer.

Art. 13. Good Leaver - Bad Leaver - Intermediate Leaver
A. The Leaver I
13.1 In case the Leaver I ceases to be an employee of AMOR, GmbH &amp; Co. KG, the Leaver I will be obliged and

entitled to sell and transfer, without undue delay, his Securities held in the Company to the Company subject to a sale
and purchase agreement to be concluded between him and the Company in accordance with article 13 of the SHA and
subject to the terms of Sections 13.2, 13.3 and 13.4 of the SHA.

13.2 If Leaver I qualifies as a Bad Leaver I, Leaver I will be obliged to transfer, without undue delay, all Securities held

by him in the Company to the Company and he will not receive any proceeds from these transfers. The terms of Section
13.2 of the SHA shall be applicable.

13.3 If Leaver I qualifies as a Good Leaver I, Leaver I will transfer all Securities held by him to the Company and will

receive the Fair Market Value of the Securities.

13.4 If Leaver I qualifies as an Intermediate Leaver I, Leaver I will transfer all Securities held by him to the Company

and will receive the lower of (a) his Individual Investment Amount as set out in exhibit 2.1 of the SHA or (b) the Fair
Market Value of the Securities.

B. The Leaver II
13.5 In case the Advisory Agreement of Leaver II has been terminated, the Leaver II will be obliged and entitled to

sell and transfer, without undue delay, his Additional Shares held in the Company to the Company subject to a sale and
purchase agreement to be concluded between him and the Company in accordance with Section 14 of the SHA and
subject to the terms of Sections 14.2 and 14.3 of the SHA.

13.6 If Leaver II qualifies as a Bad Leaver II, Leaver II will be obliged to transfer, without undue delay, all Additional

Shares held by him in the Company to the Company and will not receive any proceeds from these transfers. The terms
of Section 14.3 of the SHA will be applicable.

13.7 If Leaver II qualifies as a Good Leaver II, Leaver II will transfer all Additional Shares held by him to the Company

and will receive the Fair Market Value of the Securities.

13.8 For the avoidance of doubt, only the Additonal Shares of Leaver II shall be subjet to the Leaver Provisions and

in no event any other Securities of held by Leaver II in the Company.

C. General Restriction
13.9 The rights and obligations set forth in articles 13.1 to 13.8 hereof shall only apply to the extent legally permissible.

92314

Chapter V. Management - Corporate governance - Representation - Auditor 

Art. 14. Board
14.1 The Company will be administered by the Board composed of at least three directors; a majority of which shall

have their place of residence in Luxembourg and who need not be Shareholders and who will be appointed at a General
Shareholders Meeting for a period not exceeding six years.

14.2 Directors are always re-eligible and they may be removed at any time by a General Shareholders Meeting with

or without cause.

14.3 The mandate of the directors who have not been re-elected will terminate immediately after the ordinary Gen-

eral Meeting of Shareholders of the year in the course of which their mandate will expire.

14.4 PAMPLONA may at any time and for any reason designate for appointment by the General Shareholders Meeting

any one person to be a director of the Company and may similarly suggest to the General Shareholders Meeting the
removal from office of any director appointed in accordance with article 14.1. 

14.5 Each director of the Company and GmbH 1 and of any other non-operative company controlled by the Company

shall not receive an annual remuneration exceeding EUR 5,000 per year and per company and shall not be appointed
for a period longer than three years (the reappointment after such period being permissible).

Art. 15. Vacancy
15.1 In the event of a vacancy on the Board, such vacancy may be filled by the remaining directors in the manner

provided by the Law. In such an event the next shareholders’ meeting will proceed to the final election.

15.2 A director elected in replacement of another director whose mandate has not expired will terminate the man-

date of his predecessor.

Art. 16. Chairman
16.1 The Board will choose from among its Luxembourg resident members a chairman.
16.2 In the absence of the chairman, the directors present at the meeting will appoint another director as chairman

pro tempore.

Art. 17. Meetings
17.1 Meetings of the Board will be convened and presided by the chairman or, in his absence, by the director replacing

him.

17.2 The Board will meet as often as the Company’s interests so require, or each time two directors at least so re-

quire. The meetings will normally be held in Luxembourg at the place stated in the convening notice.

Art. 18. Procedure
18.1 The Board may deliberate or act validly only if a majority of its members are present or represented, provided

that non-Luxembourg resident directors may not constitute a majority of the directors present at the meeting.

18.2 Any director may appoint in writing, by cable or by fax another director as his proxy in order to represent him

at a determined meeting of the Board and to vote on his behalf. The director acting by proxy will be deemed to be
present for the purpose of his vote.

18.3 Any director may participate in any meeting of the Board by conference call or by other similar means of com-

munication allowing all the persons attending the meeting to hear one another, provided that no director may partici-
pate telephonically from outside Luxembourg at such meeting. Any participation to a conference call initiated and
chaired by a director located in Luxembourg shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the
meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

18.4 Circular resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting of the Board. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an
identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board held by way of circular
resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

18.5 Any resolutions of the Board are adopted by a majority of the directors holding office.
18.6 The exclusive and effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall be carried

out in or from Luxembourg.

18.7 In case the Board intends to schedule a physical meeting, the Board shall inform all Shareholders about such

physical meeting and the topics of such meetings in due course, but not later than two days prior to such meeting. The
Shareholders may designate a representative who is authorised to assist as an observer (without any voting rights) in all
such meetings of the Board.

Art. 19. Minutes
19.1 The resolutions adopted by the Board will be minuted. The minutes will be signed by the chairman of the meeting

and by one other director. The minutes relating to resolutions adopted by circular vote will be signed by the chairman
of the Board and by one other director. The proxies, the votes and opinions expressed in writing, by cable or by fax
will remain attached thereto.

19.2 Copies or extracts of such minutes which need to be produced in judicial proceedings or otherwise will be

signed by the chairman of the Board, by any director or by the person(s) to whom the daily management of the Company
has been delegated.

19.3 The minutes will be kept at the Company’s registered office.
19.4 The Board shall inform the Shareholders about important decisions not in the ordinary course of business and

provide them with copies of the minutes of the resolutions of the Board in due course.

92315

Art. 20. Powers of the Board
The Board is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Com-

pany’s purpose, except the powers which are expressly reserved by the Law or by the Articles to the General Meeting
of Shareholders.

Art. 21. Daily Management
21.1 The Board may delegate the daily management and the representation of the Company within such daily man-

agement to one or more persons. It appoints and removes the persons to whom such management has been delegated,
who may, but need not be directors, and fixes their remuneration and determines their powers.

21.2 The delegation of the daily management to a member of the Board is subject to the prior authorization of the

General Meeting of Shareholders and imposes on the Board the duty to annually report to the ordinary General Meeting
of Shareholders on the salaries, compensation and benefits whatsoever allocated to the delegate.

21.3 The Board and the persons to whom the daily management has been delegated, within the limits of such man-

agement, may also delegate special and determined powers to one or several persons chosen by them.

21.4 The Board may establish one or several committees, whose members need not be directors, and determine

their composition and powers.

Art. 22. Representation
22.1 The Company will be bound in any acts, including those requiring the intervention of a public officer or notary

public, and in judicial proceedings, by the sole signature of any director.

22.2 It will also be validly bound by any persons to whom special powers have been granted, but only within the limits

of such powers.

Art. 23. Statutory Auditor
23.1 The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or several auditors, who need not be

Shareholders, and who will be elected by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding six years.

23.2 The auditors are always re-eligible and they may be removed at any time by the General Meeting of Shareholders.
23.3 The General Meeting of Shareholders determines the number of the auditors.
23.4 The mandate of the auditors who have not been re-elected will terminate immediately after the ordinary General

Meeting of Shareholders of the year in the course of which their mandate will expire.

23.5 The duties and the powers of the auditors will be those provided for in the law.

Chapter V. General meetings of shareholders - Shareholders

Art. 24. Powers
24.1 Any regularly constituted General Meeting of Shareholders represents the entire body of Shareholders.
24.2 Its decisions adopted in conformance with these Articles and the Law are binding on all the Shareholders, in-

cluding the absent or dissenting Shareholders.

24.3 None of the following actions or measures shall be undertaken by (i) the Board if the Board shall have the power

as a matter of law to carry out or to implement such actions or measures unless such actions or measures shall have
received the prior written consent of all the Shareholders or by (ii) by the General Meeting of Shareholders unless the
relevant action or measure shall have been unanimously resolved by all the Shareholders:

(a) Any amendment to the Articles or any constitutional documents of the Company and any of the Group Compa-

nies, except for the change of the fiscal year;

(b) The solvent liquidation, the Winding-up or dissolution of AMOR, GmbH &amp; Co. KG and the Company;
(c) Any material change of the business of any of the Group Companies as conducted as of the date of the closing of

the SPA;

(d) Any transaction (i) not at arms’ length, or (ii) between any Group Company on the one side, and a related party

of PAMPLONA or PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT LLP on the other side, other than:

(i) a transfer of PAMPLONA’s shareholding in the Company; or
(ii) any transactions and/or agreements foreseen under the SHA and/or the Transaction Documentation;
(e) Any other purpose of the Company other than those indicated at article 3.1 of the Articles;
(f) Any Issuance without subscription right of the Shareholders on the same terms and conditions and in the same

proportion of their existing holdings of Securities to the Securities outstanding;

(g) Any Issuance of Securities where the subscription is not in the same proportion as the capital structure of the

Company;

(h) Any transaction that would adversely affect the shareholder rights of a Co-Investor relative to the shareholder

rights of PAMPLONA.

Notwithstanding the foregoing, any acquisitions of businesses or shareholdings in accordance with section 2.9 of the

SHA and the requisite amendments of the Company’s Articles reflecting such acquisitions and, as the case may be, the
increase of the Company’s stated share capital, shall not require the prior written consent of all the Shareholders.

Art. 25. Meetings
25.1 The annual General Meeting of Shareholders will be held each year on the sixteenth day of the month of No-

vember, at 11.00 a.m., local time.

25.2 If such day is a public holiday, the General Meeting of Shareholders will be held on the next following business

day, at the same hour.

25.3 General Meetings of Shareholders, whether ordinary or extraordinary, will be held at the registered office of

the Company or such other place in Luxembourg as may be specified in the notice convening the meeting.

92316

25.4 General Meetings of Shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment

of the Board, which is final, circumstances of force majeure so require.

25.5 A quorum of at least 50% of all the Shares shall be present or represented in order for a General Meetings of

Shareholders, whether ordinary or extraordinary, to be valid and to validly deliberate.

Art. 26. Convening Right
26.1 The Board will convene the General Meeting of Shareholders.
26.2 A General Meeting of Shareholders must be convened so as to be held within one month if one or more Share-

holders representing at least 20% of the Company’s capital so require. Such request must be in writing and specify the
items to be put on the agenda.

Art. 27. Convening Notices
27.1 The notices convening the General Meetings of Shareholders will be made by registered letter sent to each

Shareholder at the address listed in the Shareholders’ register and no later than one (1) month prior to such General
Meeting of Shareholders.

27.2 If all the Shareholders are present or represented at a General Meeting of Shareholders or if all the Shareholders

have waived the convening notice and if they state that they have knowledge of the agenda thereof, the General Meeting
of Shareholders may be held without prior notice.

Art. 28. Representation
Each Shareholder may act at any General Meeting of Shareholders by appointing in writing as his proxy another per-

son who need not be a Shareholder.

Art. 29. Bureau
29.1 Each General Meeting of Shareholders will be chaired by the chairman of the Board or, in his absence, by the

person appointed by the Shareholders.

29.2 The chairman of the General Meeting of Shareholders appoints a secretary and the meeting elects one or more

scrutineers. They together form the bureau.

Art. 30. Voting Right
Each Share has one vote.

Art. 31. Decisions of General Shareholders’ Meetings
31.1 The General Meeting of Shareholders may only deliberate on the items on the agenda.
31.2 Except as otherwise required by the Law or provided for in the SHA and/or the Articles, the resolutions will be

adopted by a majority of the votes.

31.3 The General Meeting of Shareholders convened for the purpose of amending the Articles can only be validly

held if the agenda specifies the proposed amendments and, if applicable, contains the text of those relating to the
Company’s purpose or form. In the General Meeting of Shareholders, in order to be valid, the resolutions amending the
Articles need to be adopted by a two-thirds majority of the votes of all the Shares present or represented.

Art. 32. Minutes
32.1 The minutes of the General Meeting of Shareholders will be signed by the members of the bureau and by the

Shareholders who so request.

32.2 Copies or extracts of such minutes which need to be produced in judicial proceedings or otherwise will be

signed by the chairman of the Board, by any director or by the person(s) to whom the daily management of the Company
has been delegated.

32.3 The minutes will be kept at the Company’s registered office.
32.4 The Board shall provide all the Shareholders with copies of all the minutes of the General Meeting of Sharehold-

ers in due course, but not later than two weeks after such meeting took place.

Chapter VI. Annual accounts - Appropriation of profits

Art. 33. Accounting Year
33.1 The accounting year of the Company will begin on the 1st June and will terminate on the 31st May of each year.
33.2 Each year the Board will draw up an inventory and prepare, in conformance with the law, the annual accounts,

which include the balance-sheet, the profit and loss account and the notes.

Art. 34. Approval of the Annual Accounts - Discharge
34.1 The General Meeting of Shareholders hears the management report, examines the report of the auditor and, if

thought fit, approves the accounts. 

34.2 After approval of the accounts, the General Meeting of Shareholders, by separate vote, decides on the discharge

of the directors and of the auditors. 

Art. 35. Publicity
The annual accounts, the management report and the documents provided for in the law will be made public in the

manner provided for in the law.

Art. 36. Distribution of Profits
36.1 An amount equal to at least one twentieth of the net profits shown in the balance-sheet, less the general ex-

penses and the provisions deemed necessary, and any other expenses, must be set aside annually from such profits for
the purpose of forming the reserve prescribed by law. That allocation ceases to be necessary as soon and as long as the
said reserve will be equal to one tenth of the Company’s capital.

92317

36.2 The General Meeting of Shareholders will have discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular

allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserves or carry it forward.

Art. 37. Dividends
37.1 The Board will decide upon the time and place of payment of any dividend declared by the General Meeting of

Shareholders.

37.2 The Board may declare and pay interim dividends in accordance with the Law.

Chapter VII. Dissolution - Liquidation

Art. 38. Dissolution - Liquidation
38.1 In the event of the voluntary dissolution of the Company for any reason and at any moment whatsoever, the

liquidation will be carried out by one or several liquidators appointed by the General Meeting of Shareholders deciding
such liquidation, which, as the case may be, will determine their powers and their compensation. The power to amend
the articles of incorporation, if so justified by the needs of the liquidation, remains with the General Meeting of Share-
holders.

38.2 The powers of the directors will come to an end by the appointment of the liquidators.

Art. 39. Allocation of the Surplus
In the event of any voluntary or involuntary liquidation, bankruptcy, dissolution or Winding-up of the affairs of the

Company and after payment of all debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the surplus
will be paid in priority to the holders of Preferred Shares in proportion to the Preferred Shares which they hold. To the
extent possible, each Preferred Share entitles to a distribution of a surplus equal to the higher of (i) market value of a
Preferred Share or (ii) the pro rata liquidation proceeds taking into account the portion of a Preferred Share in relation
to the entire share capital of the Company.

Chapter VII. General provision

Art. 40. Application of the law
All matters not governed by the Articles and the SHA will be determined in accordance with the Law. In case of any

contradiction between provisions of these Articles and the SHA, the SHA shall prevail to the extent legally permissible.

<i>Eighth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the changes adopted under the

third resolution above and to empower and authorise any director of the Company to individually proceed under his
sole signature on behalf of the Company to the registration of the changes adopted under the third resolution above in
the share register of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as

a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 4,600.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the same ap-
pearing parties, in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den vierzehnten August.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette (Grossherzogtum Luxemburg).

Treten zu einer außerordentlichen Generalversammlung (die Generalversammlung) zusammen, die Aktionäre der

Aktiengesellschaft PAMPLONA PE HOLDCO 4 S.A., eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme), mit
Gesellschaftssitz 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, eingetragen beim Handels- und Gesellschafts-
register in Luxemburg unter der Nummer B 118.106.

Die Gesellschaft wurde am 28. Juli 2006 gegründet, gemäß Urkunde erstellt durch Notar Martine Schaeffer, Notar

mit Amtssitz in Remich (Grossherzogtum Luxemburg), noch nicht veröffentlicht.

Die ausserordentliche Generalversammlung tritt an unter dem Vorsitz von Herrn Gwen Vanweddingen, Rechtsan-

walt, mit beruflichem Wohnsitz in Luxemburg (der Vorsitzender). Der Vorsitzende ernennt Herrn Aldric Grosjean,
Rechtsanwalt, mit beruflichem Wohnsitz in Luxemburg, zum Schriftführer (der Schriftführer). Die Versammlung wählt
Frau Claire-Marie Darnand, Rechtsanwalt, mit beruflichem Wohnsitz in Luxemburg, zum Stimmenzähler (der Stimmen-
zähler).

Die Aktieninhaber der Gesellschaft, die in der gegenwärtigen Versammlung vertreten sind sowie die Anzahl der

Stammaktien (die Stammaktien) werden in einer Anwesenheitsliste aufgeführt. Diese bleibt gegenwärtiger Urkunde
beigebogen nachdem sie von den Vertretern sowie von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes unterzeichnet
wurde.

Auch bleiben die Vollmachten der Aktieninhaber, die in der gegenwärtigen Versammlung vertreten sind, nach ne

varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigten und den Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit
derselben einregistriert zu werden.

Alsdann ersuchte der Vorsitzender den instrumentierenden Notar folgendes zu beurkunden:

92318

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche 40.000 Stammaktien der Gesellschaft, mit einem

Nennwert von je EUR 1,25 (ein Euro und fünfundzwanzig Cent) pro Aktie, die Gesamtheit des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals über einen Wert von EUR 50.000 vertretend, in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich ver-
treten sind, so dass die Generalversammlung rechtsgültig zusammengetreten ist und alle Punkte der Tagesordnung
beschließen kann.

II. Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:
1. Verzicht auf die Einberufungsformalitäten.
2. Schaffung durch die Gesellschaft einer neuen Kategorie von stimmberechtigten Aktien, die als Vorzugsaktien be-

zeichnet werden, anschliessende Abänderung von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung und Einfügung in die Satzung eines
neuen Artikels bezugnehmend auf die mit den Vorzugsaktien verbundenen Rechte.

3. Erhöhung des bisherigen Gesellschaftskapitals von EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro) um EUR 149.385 (einhundert-

neunundvierzigtausenddreihundertfünfundachzig Euro) auf EUR 199.385 (einhundertneunundneunzigtausenddreihun-
dertfünfundachzig Euro), durch die Schaffung von 119.508 (einhundertneunundneunzehntausendfünfhundertacht Euro)
neuen Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je EUR 1,25 pro Aktie.

4. Verzicht durch Herrn Pavel Nazarian auf sein Vorzugsrecht und Genehmigung der Zeichnung durch PAMPLONA

CAPITAL PARTNERS I, LP aller neu ausgegebenen Vorzugsaktien.

5. Zeichnung und Einzahlung der unter Punkt 3. erwähnten Kapitalerhöhung.
6. Abänderung von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung, um die unter Punkt 3. erwähnte Erhöhung des Gesellschafts-

kapitals wiederzuspiegeln.

7. Nötige Abänderung der einzelnen Artikel der Gesellschaftssatzung, um die entsprechenden Bestimmungen der Ge-

sellschaftervereinbarung betreffend sämtliche Sicherheiten und Garantien zu integrieren, Einführung einer Begriffsbe-
stimmungsrubrik und neuer Artikel in die Gesellschaftssatzung, um die entsprechenden Bestimmungen der
Gesellschaftervereinbarung betreffend sämtliche Sicherheiten und Garantien zu integrieren; anschliessende Neunume-
rierung und Neuformulierung der gesamten Gesellschaftssatzung mit der Einfügung oder Abänderung, falls notwendig,
der Überschriften der Gesellschaftssatzung.

8. Abänderung des Aktienregisters der Gesellschaft und Erteilung einer Bevollmächtigung an jeden Geschäftsführer

der Gesellschaft, um im Auftrag des Verwaltungsrates die Eintragung ins Aktienregister der neu ausgegebenen Aktien
vorzunehmen.

9. Verschiedenes.
III. Sodann traf die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Da die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals bei der gegenwärtigen Versammlung vertreten ist, verzich-

tet die Versammlung auf die Einberufungsformalitäten; die Aktieninhaber betrachten sich als rechtsmässig einberufen
und bestätigen, Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, die ihnen im Voraus übermittelt wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung fasst den Beschluss eine neue Kategorie von stimmberechtigten Aktien, die als Vorzugsaktien (die

Vorzugaktien) bezeichnet werden zu schaffen und beschliesst deshalb die Abänderung von Artikel 5 der Gesellschafts-
satzung und die Einfügung in die Satzung eines neuen Artikels bezugnehmend auf die mit den Vorzugsaktien verbundenen
Rechte.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung fasst den Beschluss, das bisherige Gesellschaftskapitals von EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro) um

EUR 149.385 (einhundertneunundvierzigtausenddreihundertfünfundachzig Euro) auf EUR 199.385 (einhundert neunund-
neunzigtausenddreihundertfünfundachzig Euro) zu erhöhen, durch die Schaffung von 119.508 (einhundertneunzehntau-
sendfünfhundertacht) neuen Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je EUR 1,25 (einem Euro und fünfund-zwanzig
Cent).

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass Herr Pavel Nazarian auf sein Vorzugsrecht in Bezug auf die neu ausge-

gebenen Vorzugsaktien verzichtet und ist demnach mit der Zeichnung der gesamten Kapitalerhöhung durch die
PAMPLONA CAPITAL PARTNERS I, LP einverstanden.

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschliesst und genehmigt die Zeichnung und Einzahlung der 119.508 (einhundertneunzehntau-

sendfünfhundertacht) neuen Vorzugsaktien der Gesellschaft, wie folgt:

<i>Zeichnung - Zahlung

Die Gesellschaft zählt gegenwärtig zwei Aktieninhaber. Der eine Inhaber, PAMPLONA CAPITAL PARTNERS I, LP,

eine steuerbefreite Kommanditgesellschaft, gegründet nach dem Recht der Cayman Islands, mit Gesellschaftssitz PO
Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, hier vertreten durch
Herrn Aldric Grosjean, Rechtsanwalt, mit beruflichem Wohnsitz in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht ausgestellt in
George Town, Grand Cayman am 10. August 2006, bestätigt die Zeichnung von 119.508 (einhundertneunzehntausend-
fünfhundertacht) neu ausgegebenen Vorzugsaktien und deren vollen Einzahlung in bar.

Die Einzahlung in bar der Gesamtsumme in Höhe von EUR 149.385 (einhundertneunundvierzigtausenddreihundert-

fünfundachzig Euro) wird dem Grundkapital der Gesellschaft zugewiesen.

92319

Beweis der vollen Einzahlung der Gesamtsumme in Höhe von EUR 149.385 (einhundertneunundvierzigtausenddrei-

hundertfünfundachzig Euro) wurde dem unterzeichneten Notar mittels einer Sperrungsbestätigung der ING BANK
LUXEMBURG, mit Datum 10. August 2006, welche die Verfügbarkeit der Einzahlung bestätigt, erbracht.

<i>Sechster Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Abänderung des ersten Paragraphen von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung, um den

unter Punkt 3. erfassten Beschluss wiederzuspiegeln, sodass Artikel 5 jetzt folgenden Wortlaut hat:

«Art. 5. Aktienkapital 
5.1 Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf EUR 199.385 (einhundertneunundneunzigtausenddrei-

hundertfünfundachtzig Euro), aufgeteilt in 40.000 (vierzigtausend) Stammaktien im Nennwert von jeweils EUR 1,25 (ein
Euro und fünfundzwanzig Cent) und in 119.508 (einhundertneunzehntausendfünfhundertacht) Vorzugsaktien im Nenn-
wert von jeweils EUR 1,25 (ein Euro und fünfundzwanzig Cent) (Stamm- und Vorzugsaktien werden hier kollektiv unter
der Bezeichnung Aktien bezeichnet).» 

<i>Siebter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die nötige Abänderung der einzelnen Artikel der Gesellschaftssatzung, um die entspre-

chenden Bestimmungen der Gesellschaftervereinbarung betreffend sämtliche Sicherheiten und Garantien zu integrieren,
die Einführung einer Begriffsbestimmungsrubrik und neuer Artikel in die Gesellschaftssatzung, um die entsprechenden
Bestimmungen der Gesellschaftervereinbarung betreffend sämtliche Sicherheiten und Garantien zu integrieren sowie
die anschliessende Neunumerierung und Neuformulierung der gesamten Gesellschaftssatzung mit der Einfügung oder
Abänderung, falls notwendig, der Überschriften der Gesellschaftssatzung.

Kapitel I. Definitionen

ACIRA ist die ACIRA SCHMUCKVERTRIEBS, GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) nach

deutschem Recht mit eingetragenem Geschäftssitz in Obertshausen, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Offenbach unter der Nummer HRB 6936.

Zusätzliche Aktien hat die diesem Begriff in der Aktionärsvereinbarung zugewiesene Bedeutung, und die zusätzlichen

Aktien belaufen sich auf den im Anhang 2.1 zur Aktionärsvereinbarung genannten Betrag.

Beratervertrag hat die diesem Begriff im Artikel 9.1 der Aktionärsvereinbarung zugewiesene Bedeutung.
AMOR, GmbH &amp; Co. KG ist eine Kommanditgesellschaft (KG) mit eingetragenem Geschäftssitz in Obertshausen,

Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Offenbach unter der Nummer HRA 9003, oder eine
ihrer Rechtsnachfolgerinnen.

AMOR Konzernmitglied hat die diesem Begriff in der Präambel der Aktionärsvereinbarung unter (A) zugewiesene

Bedeutung.

AMOR Transaktion hat die diesem Begriff in der Präambel der Aktionärsvereinbarung unter (E) zugewiesene Bedeu-

tung.

Satzung ist die Satzung der Gesellschaft.
Schlechter Ausscheidender I bezeichnet den Ausscheidenden I, der (i) zum Ausscheiden aus der AMOR, GmbH &amp;

Co. KG wegen Grund I aufgefordert wird, und dessen Anstellungsverträge, die zwischen ihm und eines der Mitglieder
der AMOR Gruppe abgeschlossen wurden, von der zuständigen Gesellschaft der Gruppe aus wichtigem Grund im Sinne
des Artikels 626 des Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs gekündigt werden, oder (ii) die Wettbewerbsverbotsklausel
in seinem Anstellungsvertrag verletzt hat.

Schlechter Ausscheidender II bezeichnet den Ausscheidenden II, (i) dessen Beratervertrag zwischen ihm und der

AMOR, GmbH &amp; Co. KG wegen Grund II gekündigt wird oder (ii) der die Wettbewerbsverbotsklauseln im Kaufvertrag
oder in der Aktionärsvereinbarung verletzt hat.

Vorstand ist der Vorstand (Board of Directors) der Gesellschaft.
Grund I bezeichnet Vorfälle, aufgrund derer (i) der Ausscheidende I durch ein endgültiges Gerichtsurteil wegen straf-

rechtlicher Vergehen zum Nachteil einer Gesellschaft der Gruppe (einschließlich aber nicht beschränkt auf Konkursver-
gehen, Betrug oder Verletzung seiner Verpflichtungen als eine Person in Vertrauensstellung gemäß den Bestimmungen
des Deutschen Strafgesetzbuchs) oder gemäß dementsprechenden Bestimmungen in Luxemburg oder anderen Ländern
verurteilt wird, oder (ii) eine Gesellschaft der Gruppe einen Schaden und/oder sonstigen Verlust wegen vorsätzlicher
Handlungen des Ausscheidenden I davonträgt.

Grund II bezeichnet (i) Vorfälle, aufgrund derer der Ausscheidende II durch ein endgültiges Gerichtsurteil wegen

strafrechtlicher Vergehen zum Nachteil einer Gesellschaft der Gruppe (einschließlich aber nicht beschränkt auf Kon-
kursvergehen, Betrug oder Verletzung seiner Verpflichtungen als eine Person in Vertrauensstellung gemäß den Bestim-
mungen des Deutschen Strafgesetzbuchs) oder gemäß dementsprechenden Bestimmungen anderer Länder verurteilt
wird, oder (ii) einen Vorfall, bei dem der Ausscheidende II einer Gesellschaft der Gruppe vorsätzlich und entgegen ver-
gangenen Praktiken nach dem 31. Mai 2006 Schaden zufügt.

Mitanleger hat die diesem Begriff in der Präambel der Aktionärsvereinbarung unter (A) zugewiesene Bedeutung.
Gesellschaft ist die PAMPLONA PE HOLDCO 4 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht von

Luxemburg mit eingetragenem Geschäftssitz in 43, boulevard de la Petrusse, L-2320 Luxembourg, die sich im Prozess
der Eintragung im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg befindet.

CPECs sind sämtliche von Gesellschaft von Zeit zu Zeit ausgegebenen wandelbaren Vorzugsaktienscheine.
Abgang bezeichnet:
(a) eine Börsenzulassung;
(b) den Verkauf aller oder im wesentlichen aller Aktien;

92320

(c) im Wege einer oder mehrerer Transaktionen die Veräußerung aller oder im wesentlichen aller Geschäftsanteile

der GmbH 1, GmbH 2, AMOR, GmbH &amp; Co. KG oder des Betriebs der AMOR Gruppe, mit Ausnahme einer konzern-
internen Umstrukturierung innerhalb der bestehenden Gruppe; oder

(d) eine Kapitalumschichtung der Gesellschaft oder der GmbH 1, GmbH 2 oder der AMOR, GmbH &amp; Co. KG.
Angemessener Marktpreis ist der angemessene Marktpreis gemäß dem im Artikel 13.5 der Aktionärsvereinbarung

festgelegten Verfahren.

Hauptversammlung ist die Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft.
Guter Ausscheidender I ist (i) ein Ausscheidender I, dessen Beendigung seiner Anstellung oder seines Dienstleistungs-

verhältnisses auf Tod, Arbeitsunfähigkeit oder Austritt aus dem Arbeitsleben bei Erreichen des normalen Rentenalters
(von 60 Jahren) zurückzuführen ist, oder (ii) ein Zwischenausscheidender I, der der AMOR, GmbH &amp; Co. KG eine Kün-
digung zustellt (a) aus gutem Grund oder (b) nach mehr als vier Jahren nach dem Datum des Abschlusses der in der
Aktionärsvereinbarung niedergelegten Transaktion.

Guter Ausscheidender II ist ein Ausscheidender II, dessen Beratervertrag aus anderen Gründen gekündigt wird als

aus Gründen, die ihm die Position eines schlechten Ausscheidenden II verschaffen würden.

GmbH 1 ist die RM 2646 VERMÖGENSVERWALTUNGS, GmbH, eine deutsche Gesellschaft mit eingetragenem Ge-

schäftssitz in München, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer 163126.

GmbH 2 ist die AMOR, GmbH i. G., eine deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem

Geschäftssitz in Obertshausen, die sich im Prozess der Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Offenbach
befindet.

Gesellschaften der Gruppe sind die Gesellschaft, GmbH 1, GmbH 2, AMOR, GmbH &amp; Co. KG oder eine Tochter/

Zweiggesellschaft einer der vorgenannten Gesellschaften (jeweils Gesellschaft der Gruppe).

Einzelanlagebetrag ist der in der Aktionärsvereinbarung definierte und im Anhang 2.1 der Aktionärsvereinbarung

bezifferte Einzelanlagebetrag.

Zwischenausscheidender I ist ein Ausscheidender I, der aus der AMOR, GmbH &amp; Co. KG ausscheidet und der

AMOR, GmbH &amp; Co. KG eine Kündigung zustellt und nicht in die Kategorien guter Ausscheidender I oder schlechter
Ausscheidender I fällt.

Ausgabe sind die Ausgabe von Aktien bzw. Anteilen, CPECs, PECs oder sonstigen Wertpapieren oder Rechten, die

zu Forderungen gegenüber Gesellschaft berechtigen (in Eigenkapital umwandelbar oder nicht, aber ausschließlich unge-
sicherten Bankdarlehen auf geschäftlicher Basis) und sämtliche anderen Maßnahmen, die zu einer wirtschaftlichen Ver-
wässerung eines Aktionärs, außer der PAMPLONA, führen könnten.

Ausscheidender I ist ein Gesellschafter, der Mitanleger ist und gemäß Artikel 13.1 der Aktionärsvereinbarung als Mit-

arbeiter der AMOR, GmbH &amp; Co. KG ausscheidet.

Ausscheidender II ist ein Gesellschafter, der Mitanleger ist und gemäß Artikel 14.1 der Aktionärsvereinbarung als Mit-

arbeiter der AMOR, GmbH &amp; Co. KG ausscheidet.

Gesetz ist das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner letzten Fassung.
Ausscheidender ist ein Ausscheidender I oder ein Ausscheidender II.
Börsenzulassung ist die Zulassung einer der Aktien bei einer öffentlich regulierten Anlegerbörse.
PAMPLONA ist die PAMPLONA CAPITAL PARTNERS I, LP, eine freigestellte Kommanditgesellschaft nach dem

Recht der Cayman Islands mit eingetragenem Geschäftssitz in PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT LLP ist die PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT LLP, eine Kommandit-

gesellschaft nach dem Recht von England mit eingetragener Geschäftsanschrift in 25 Park Lane, London W1K 1RA,
United Kingdom.

PEC sind sämtliche Vorzugsaktienscheine, die Gesellschaft von Zeit zu Zeit ausgibt.
Vorzugsaktien sind die von Zeit zu Zeit ausstehenden stimmberechtigten Vorzugsaktien der Gesellschaft.
Stammaktien sind die von Zeit zu Zeit ausstehenden Stammaktien der Gesellschaft.
Wertpapiere ist der Oberbegriff für die Stammaktien, die Vorzugsaktien, die PECs und die CPECs.
Aktionärsvereinbarung ist die Aktionärsvereinbarung vom 2. August 2006 über sämtliche Wertpapiere an Gesell-

schaft, abgeschlossen zwischen Dr. Ulrich Byszio und Mr Torsten Hörnis, PAMPLONA PE HOLDCO 4 S.A. und
PAMPLONA CAPITAL PARTNERS I, LP. 

Aktien sind die Vorzugsaktien und die Stammaktien.
Gesellschafter/Aktionäre sind die Personen, die von Zeit zu Zeit Aktien an Gesellschaft halten.
Kaufvertrag ist der am oder um den 2. August 2006 (Urkundenrolle Nr. 202 des Notars Johann Andreas Rossbach,

Frankfurt am Main, Deutschland) abgeschlossene Kaufvertrag zwischen unter anderem GmbH 1 im Namen der GmbH
2, Dr. Ulrich Byszio, Ms Susann Byszio, AMOR, GmbH &amp; Co. KG, ACIRA und PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT
LLP, auf dessen Grundlage GmbH 2 sämtliche Kommanditanteile an der AMOR, GmbH &amp; Co. KG sowie sämtliche An-
teile an ACIRA und gewissen anderen Körperschaften gemäß den Darlegungen im Artikel 1.4 des Vertrags erwerben
wird.

Gesamtanlage ist der Betrag, der von PAMPLONA und den Mitanlegern gemäß Anhang 2.1 der Aktionärsvereinba-

rung in Gesellschaft investiert wird.

Dokumentation der Transaktion ist/sind die Aktionärsvereinbarung und die Fazilitätenverträge zwischen GmbH 1

und IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG.

Kapitel II. Name - Eingetragener Geschäftssitz - Zweck - Laufzeit

Art. 1. Name
Die derzeitigen Gesellschafter und sämtliche Personen, die Inhaber von Aktien werden mögen, bilden eine Aktienge-

sellschaft (société anonyme) in Firma PAMPLONA PE HOLDCO 4 S.A.

92321

Art. 2. Eingetragener Geschäftssitz
2.1 Der eingetragene Geschäftssitz befindet sich in der Stadt Luxemburg.
2.2 Er kann durch Beschluss einer außergewöhnlichen Aktionärsversammlung, die in der für Satzungsänderungen vor-

gesehenen Art und Weise tagt, innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.3 Die Anschrift des eingetragenen Geschäftssitzes kann durch Beschluss des Vorstands innerhalb der Stadtgemeinde

verlegt werden.

2.4 Zweigniederlassungen oder sonstige Geschäftsstellen können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im

Ausland durch Beschluss des Vorstands eingerichtet werden.

2.5 Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen eintreten oder unmittelbar be-

vorstehen, die die üblichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Geschäftssitz oder die Möglichkeiten
der Kommunikation mit diesem Geschäftssitz stören bzw. behindern, kann der eingetragene Geschäftssitz vorüberge-
hend in das Ausland verlegt werden, bis die anomalen Umstände vollständig beendet sind, wobei diese vorübergehende
Maßnahme keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft hat, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung
des eingetragenen Geschäftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Diese vorübergehenden Maßnahmen wer-
den von einer der Körperschaften bzw. Personen durchgeführt, der das tägliche Management der Gesellschaft anver-
traut wurde, und sämtliche betroffenen bzw. interessierten Parteien werden entsprechend benachrichtigt.

2.6 Die Geschäftsbücher und -unterlagen der Gesellschaft (einschließlich ihrer Korrespondenz) sind am eingetrage-

nen Geschäftssitz aufzubewahren.

Art. 3. Zweck
3.1 Gesellschaft verfolgt den Zweck des Erwerbs von Beteiligungen und Anteilen jeglicher Form an den Gesellschaften

der AMOR Gruppe, den Erwerb von Wertpapieren und Rechten im Wege von Beteiligungen, der Vornahme von Ein-
lagen, Zeichnungen, Firmenkäufen oder Optionen, Verhandlungen oder auf anderem Wege an den Gesellschaften der
AMOR Gruppe, und im allgemeinen die Inhaberschaft, das Management, die Entwicklung, den Verkauf oder die Veräu-
ßerung derselben entweder vollständig oder teilweise und gegen Erhalt der von Gesellschaft als angemessen betrachte-
ten Gegenleistung. Im weiteren ist Gesellschaft berechtigt, jeder Holdinggesellschaft, Tochter-oder Zweiggesellschaft
oder jeder sonstigen Gesellschaft, die in irgendeiner Weise mit der Gruppe der AMOR Gesellschaften verbunden ist,
oder zugunsten der vorerwähnten Gesellschaften Beistand erbringen, wie beispielsweise Zusagen erteilen, Darlehen,
Vorauszahlungen oder Garantien gewähren. Gesellschaft kann zum Zwecke ihrer Investitionen bzw. Anlagen in die
Gruppe der AMOR Gesellschaften auf jede beliebige Art und Weise Gelder aufnehmen oder leihen und die Rückzahlung
aufgenommener Gelder sichern. Gesellschaft kann darüber hinaus Gelder aufnehmen und Obligationen oder sonstige
Wertpapiere an eine begrenzte Anzahl an Zeichnern ausstellen. Gesellschaft wird die Vorteile des Gesetzes vom 31. Juli
1929 über Holdinggesellschaften nicht für sich in Anspruch nehmen.

3.2 Gesellschaft kann sämtliche geschäftlichen, technischen und finanziellen Tätigkeiten durchführen, die mittelbar

oder unmittelbar mit den oben aufgeführten Zwecken verbunden sind, um die Vornahme ihrer Zwecke zu erleichtern.

Art. 4. Laufzeit
4.1 Gesellschaft wird für einen unbegrenzten Zeitraum gegründet. 
4.2 Sie kann durch Beschluss der Hauptversammlung, der gemäß den in dieser Satzung und im Gesetz niedergelegten

Vorschriften zu verabschieden ist, jederzeit aufgelöst werden.

Kapitel III. Aktienkapital - Stammaktien - Vorzugsaktien

Art. 5. Aktienkapital
5.1 Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf EUR 199.385 (einhundertneunundneunzigtausenddrei-

hundertfünfundachtzig Euro), aufgeteilt in 40.000 (vierzigtausend) Stammaktien im Nennwert von jeweils EUR 1,25 (ein
Euro und fünfundzwanzig Cent) und in 119.508 (einhundertneunzehntausendfünfhundertacht) Vorzugsaktien im Nenn-
wert von jeweils EUR 1,25 (ein Euro und fünfundzwanzig Cent).

5.2 Sämtliche Aktien sind vollständig eingezahlt.
5.3 Vorbehaltlich der in dieser Satzung niedergelegten Auflagen, kann der Vorstand 340.492 (dreihundertvierzigtau-

sendvierhundertzweiundneunzig) Stammaktien ausgeben, die für die Umwandlung der als Stammaktien der Gesellschaft
ausstehenden CPECs reserviert sind, und somit das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen
Betrag auf einen Betrag von EUR 625.000 (sechshundertfünfundzwanzigtausend Euro) bringen, wobei es sich beim letzt-
genannten Betrag um die Obergrenze des genehmigten Aktienkapitals handelt.

5.4 Vorbehaltlich der in dieser Satzung niedergelegten Auflagen, ist der Vorstand bevollmächtigt und befugt:
(a) das Aktienkapital der Gesellschaft innerhalb der Grenzen des genehmigten Aktienkapitals durch zeitweilige Aus-

gabe neuer Stammaktien ausschließlich im Wege der Wandlung von CPECs in Stammaktien, die durch Einlage von Sach-
werten in Form der CPECs eingezahlt werden, zu erhöhen;

(b) den Ort und das Datum der Ausgabe oder sukzessiven Ausgabe neuer Stammaktien und die Bedingungen und

Konditionen der Zeichnung von und Einzahlung auf die neuen Stammaktien festlegen; und

(c) die bevorrechtigten Zeichnungsrechte von Gesellschaftern abschaffen oder einschränken, wenn neue Stammakti-

en im Wege der Umwandlung der CPECs in Stammaktien innerhalb der Grenzen des genehmigten Aktienkapitals aus-
gegeben werden, die in Sachwerten und gemäß den Bestimmungen dieser Satzung einzuzahlen sind.

5.5 Die oben genannte Befugnis gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 14. August 2006 und kann durch Be-

schluss einer außergewöhnlichen Aktionärsversammlung über die Aktien des genehmigten Kapitals, die vor diesem Zeit-
punkt vom Vorstand noch nicht ausgegeben sein werden, verlängert werden. Die vorstehende Befugnis darf weder
mittelbar noch unmittelbar in einem Ausmaß verwendet werden, wie es gemäß dieser Satzung und/oder der Aktionärs-
vereinbarung der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter bedarf.

92322

5.6 Immer wenn der Vorstand im Sinne des Inkrafttretens einer wie oben genehmigten Kapitalerhöhung handelt, ist

dieser Artikel der Satzung derart zu ändern, dass die Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals widergespiegelt wird,
und der Vorstand oder eine von ihm bevollmächtigte Person wird diese Änderung in der gesetzlich vorgeschriebenen
Art und Weise erklären.

Art. 6. Stammaktien - Vorzugsaktien
Vorbehaltlich der Ausschüttung eines Gewinns gemäß Artikel 39 unten wird mit jeder Aktie das Recht auf gleiche

Beteiligung an Gewinnen und Abwicklungsgewinnen der Gesellschaft in direkter Proportion zur Anzahl der existieren-
den Aktien verliehen.

Art. 7. Erhöhung und Senkung des Kapitals 
7.1 Das Kapital der Gesellschaft kann einmal oder mehrmals durch Beschluss der Gesellschafter, der in der für die

Änderung der Satzung vorgeschriebenen Art und Weise und gemäß dem Gesetz zu verabschieden ist, erhöht oder ge-
senkt werden.

7.2 Die neuen, in bar zu zeichnenden Aktien werden vorzugsweise den bestehenden Gesellschaftern im Verhältnis zu

dem von ihnen durch ihre Aktien bereits gehaltenen Kapital angeboten. Die Hauptversammlung legt eine Frist für die
Ausübung der bevorrechtigten Zeichnungsrechte fest. Sie gewährt dem Vorstand jegliche Vollmachten, damit er die ver-
abschiedeten Entscheidungen umsetzen und die Bedingungen für die Wahrnehmung der bevorrechtigten Zeichnungs-
rechte festlegen kann.

7.3 In Abweichung von den vorstehenden Regelungen kann die Hauptversammlung allerdings zusätzlich zu der im Ar-

tikel 5.4 (c) oben genannten Bevollmächtigung sowie gemäß den im Gesetz und in dieser Satzung vorgesehenen Bedin-
gungen die bevorrechtigten Zeichnungsrechte abschaffen oder einschränken oder den Vorstand bevollmächtigen,
dementsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Art. 8. Erwerb und Rücknahme eigener Aktien
8.1 Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien gemäß den im Gesetz vorgesehenen Bedingungen erwerben. Erwerb und

Inhaberschaft ihrer eigenen Aktien richten sich nach den kraft Gesetz geltenden Bedingungen und Einschränkungen.

8.2 Unbeschadet sonstiger Bestimmungen in der Aktionärsvereinbarung oder in dieser Satzung entspricht der Rück-

kaufpreis für Vorzugsaktien jederzeit dem angemessenen Marktwert der Vorzugsaktien (der Rückkaufpreis). Gesell-
schaft kann den Rückkaufpreis in bar, in Form von Stammaktien in einem dem Rückkaufpreis entsprechenden
Gesamtbetrag oder in Form von Vermögen in einem dem Rückkaufpreis entsprechenden Gesamtbetrag entrichten.

Art. 9. Form der Aktien - Aktionärsregister
9.1 Die Aktien sind und bleiben Namensaktien.
9.2 Am Geschäftssitz wird ein Aktionärsregister unterhalten, das von jedem Gesellschafter auf Wunsch eingesehen

bzw. geprüft werden kann. Das Register enthält die folgenden Angaben:

- die genaue Bezeichnung eines jeden Gesellschafters sowie die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien;
- die auf seine Aktien vorgenommenen Einzahlungen;
- die Abtretung der Aktien und die Abtretungsdaten.
9.3 Jeder Gesellschafter wird Gesellschaft per Einschreiben seine Anschrift sowie jegliche Anschriftenänderungen mit-

teilen. Gesellschaft ist befugt, sich auf die zuletzt mitgeteilte Anschrift zu berufen.

9.4 Die Inhaberschaft der eingetragenen Aktie wird anhand der Eintragung des Gesellschafters im Aktionärsregister

dokumentiert.

9.5 Die Gesellschafter erhalten Aktienscheine, in denen diese Eintragung wiedergegeben wird.
9.6 Die Abtretung von Aktien erfolgt durch eine Abtretungserklärung, die im selben Register eingetragen wird, datiert

und unterzeichnet vom Abtretenden sowie vom Abtretungsempfänger oder deren Vertreter, sowie auf der Grundlage
der Bestimmungen über Forderungsabtretungen gemäß Artikel 1690 des Code Civil. Gesellschaft kann jegliche Abtre-
tungen akzeptieren und im Register eintragen, die in Korrespondenz oder sonstigen die Zustimmung des Abtretenden
und des Abtretungsempfängers enthaltenden Unterlagen mitgeteilt werden.

9.7 Jegliche Eintragung im Aktionärsregister werden vom Vorstand oder von einer vom Vorstand für diese Zwecke

bevollmächtigten Person vorgenommen.

9.8 Der Vorstand trägt jegliche Abtretungen von Aktien gemäß den Bestimmungen der Aktionärsvereinbarung ein

und die Eintragung von Aktienabtretungen unterliegt den im Artikel 10.1 dieser Satzung aufgeführten Bedingungen.

Kapitel IV. Abtretung von Wertpapieren

Art. 10. Allgemeine Bestimmungen
10.1 Werden weniger als sämtliche Wertpapiere der Gesellschaft an eine dritte Partei abgetreten, darf der Abtre-

tende die Abtretung nur rechtskräftig durchführen, nachdem und soweit der Abtretungsempfänger vor der Abtretung
(i) jegliche Verpflichtungen des Abtretenden in Bezug auf die Wertpapiere, die gemäß dieser Satzung und der Aktionärs-
vereinbarung in ihren jeweils letzten Fassungen und/oder mit ihren von Zeit zu Zeit vorgenommenen Änderungen bzw.
Nachträgen existieren, übernommen hat und (ii) vor dem Inkrafttreten der beabsichtigten Abtretung und Übertragung
eine Vereinbarung in diesem Sinne unterzeichnet hat.

10.2 Jegliche von einem Mitanleger gehaltenen Wertpapiere sind nur bei Unterzeichnung eines Drag-Along-Rechts

(Recht, eine Veräußerung verlangen zu können), Tag-Along-Rechts (Recht auf Mitverkauf) abtretbar, wenn der Mitanle-
ger ein Ausscheidender ist und wenn die Abtretung der Wertpapiere gemäß den Bedingungen dieser Satzung und der
Aktionärsvereinbarung erfolgt oder der Vorstand der Abtretung zugestimmt hat. Diese Zustimmung wird erteilt, wenn
der betreffende Mitanleger die Absicht hat, die jeweiligen Wertpapiere an eine Gesellschaft abzutreten, an der er sämt-
liche Anteile hält, vorausgesetzt, diese Abtretung erfolgt unter der auflösenden Bedingung, dass der betreffende Mitan-
leger nicht mehr sämtliche Anteile an einer solchen Gesellschaft hält. Für die Zwecke dieser Satzung bezeichnen die

92323

Begriffe «Abtretung» oder «abtretbar» die Abtretung von Wertpapieren oder die Veräußerung von Wertpapieren im
Wege des Verkaufs, der Übertragung/Abtretung oder auf anderem Wege wie, ohne einschränkend zu gelten, im Weg
der Beleihung oder eines Pfandrechts oder einer anderen Veräußerung, die im Grunde genommen diese Wirkung hat.

10.3 Abtretungen, die nicht nach Maßgabe der Bedingungen dieser Satzung oder der Aktionärsvereinbarung vorge-

nommen werden, sind ungültig und nicht durchsetzbar. Vorbehaltlich der Bedingungen dieser Satzung wird Gesellschaft
den im Aktienregister offiziell eingetragenen Aktieninhaber bis zur Mitteilung über eine Abtretung und Genehmigung
des Vorstands der Gesellschaft als die Person behandeln, die das ausschließliche Recht auf Entgegennahme von Dividen-
den und sonstigen Ausschüttungen, auf Stimmabgabe, Entgegennahme von Mitteilungen und die sonstige Ausübung jeg-
licher Rechte und Vollmachten des Inhabers der betreffenden Aktie hat; Gesellschaft wird darüber hinaus nur die
Abtretungen anerkennen und in die offiziellen Unterlagen eintragen, die gemäß dieser Satzung und der Aktionärsverein-
barung vorgenommen wurden.

10.4 Jeder Inhaber von Wertpapieren wird Sorge dafür tragen, dass er jederzeit in der Lage und rechtmäßig befugt

ist, die von ihm gehaltenen Wertpapiere im Sinne der in der Aktionärsvereinbarung niedergelegten Anforderungen mit
vollständiger Eigentumsrechtsgarantie abzutreten.

Art. 11. Tag-Along Rechte
Hat PAMPLONA die Absicht, alle ihrer Wertpapiere im Wege eines Verkaufs, einer Abtretung und Übertragung, ei-

nes Tauschgeschäfts, einer Einlage oder Wandlung im Sinne des Deutschen Umwandlungsgesetzes, UmwG oder in ver-
gleichbarer Art und Weise abzutreten und zu übertragen, steht den anderen Gesellschaftern das Recht zu, PAMPLONA
aufzufordern, dass jegliche von den anderen Gesellschaftern gehaltenen Wertpapiere ebenfalls unter den gleichen Be-
dingungen und Konditionen an den potentiellen Käufer abgetreten werden. Eine derartige Absicht seitens PAMPLONA
ist den anderen Gesellschaftern im Voraus schriftlich mitzuteilen. Hat PAMPLONA die Absicht, nur einen Teil ihrer
Wertpapiere abzutreten bzw. zu übertragen, haben die anderen Gesellschafter auch nur das Recht, von PAMPLONA
zu fordern, dass der gleiche Prozentsatz der von ihnen gehaltenen Wertpapiere an den Käufer abgetreten bzw. über-
tragen wird; dabei gilt allerdings die Voraussetzung, dass die anderen Gesellschafter von PAMPLONA fordern können,
dass ihre gesamten Wertpapiere abgetreten bzw. übertragen werden können, wenn infolge der Abtretung und Über-
tragung der Wertpapiere der PAMPLONA und der anteilmäßigen Abtretung und Übertragung der Wertpapiere der
Mitanleger eine externe dritte Partei die Mehrheit der Stimmrechte an der Gesellschaft erhalten würde.

Art. 12. Drag-Along Rechte
12.1 Hat PAMPLONA die Absicht, Aktien zu verkaufen, die mindestens 50% des als Stammaktien ausgegebenen Ak-

tienkapitals der Gesellschaft repräsentieren, kann PAMPLONA von jedem anderen Gesellschafter fordern, dass er den
jeweiligen anteilmäßigen Betrag der von ihm gehaltenen Wertpapiere in Proportion zu dem von PAMPLONA im Wege
des Verkaufs und der Abtretung, eines Tauschgeschäfts, einer Einlage, Umwandlung im Sinne von Artikel 1 des Deut-
schen Umwandlungsgesetzes, UmwG, oder auf vergleichbare Art und Weise zu verkaufenden Aktienmenge zu dem
Preis pro Stammaktie, Vorzugsaktie, PEC oder CPEC verkauft und abtritt, der auch an PAMPLONA zu zahlen ist (nach-
stehend «Drag-Along» genannt). Die Drag-Along-Aufforderung wird den anderen Gesellschaftern im Voraus schriftlich
mitgeteilt. Die Rechte der anderen Gesellschafter gemäß Artikel 11 dieser Satzung bleiben unberührt.

12.2 Liegt der von der dritten Partei für den Erwerb von Wertpapieren zu entrichtende Kaufpreis unter dem Betrag

der Gesamtinvestition für diese Wertpapiere und wurde dieser Kaufpreis nicht durch eine von einer namhaften Investi-
tionsbank oder in Zusammenhang mit einer Börsennotierung durchgeführten Auktion festgelegt, haben die im Rahmen
des Drag-Along verpflichteten Gesellschaft das Recht, gemeinsam ein alternatives Angebot für den Erwerb sämtlicher
Aktien zu unterbreiten (das «alternative Angebot»). Das Recht zur Unterbreitung eines alternativen Angebots läuft ab,
wenn die im Rahmen des Drag-Along verpflichteten Gesellschafter nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der
Drag-Along-Mitteilung ein indikatives alternatives Angebot vorgelegt haben oder wenn die im Rahmen des Drag-Along
verpflichteten Gesellschafter nicht innerhalb von vier Wochen nach Vorlage ihres indikativen alternativen Angebots ein
endgültiges alternatives Angebot unterbreitet haben. Wird gemäß vorstehendem Satz ein endgültig verbindliches alter-
natives Angebot mit vollständig zugesagter Finanzierung vorgelegt und liegt der im Rahmen des alternativen Angebots
bestehende Kaufpreis über dem von der dritten Partei angebotenen Kaufpreis, ist PAMPLONA verpflichtet, ihre Wert-
papiere nach Maßgabe der Bedingungen und Konditionen des endgültigen alternativen Angebots zu verkaufen.

Art. 13. Guter Ausscheidender - Schlechter Ausscheidender - Zwischenausscheidender
A. Der Ausscheidende I
13.1 Endet das Mitarbeiterverhältnis des Ausscheidenden I bei AMOR, GmbH &amp; Co. KG, ist der Ausscheidende I

verpflichtet und berechtigt, die von ihm an Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere nach Maßgabe eines zwischen ihm und
Gesellschaft gemäß Artikel 13 der Aktionärsvereinbarung und vorbehaltlich der Artikel 13.2, 13.3 und 13.4 der Aktio-
närsvereinbarung abzuschließenden Kaufvertrags ohne unzumutbare Verzögerungen an Gesellschaft zu verkaufen und
zu übertragen.

13.2 Fällt der Ausscheidende I in die Kategorie des schlechten Ausscheidender I, ist der Ausscheidende I verpflichtet,

sämtliche von ihm an Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere ohne unzumutbare Verzögerungen an Gesellschaft abzutre-
ten, ohne einen Erlös daraus zu erhalten. Es gelten dann die Bedingungen des Artikels 13.2 der Aktionärsvereinbarung.

13.3 Fällt der Ausscheidende I in die Kategorie des guten Ausscheidenden I, überträgt er sämtliche von ihm an

Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere gegen Erhalt des angemessenen Marktwertes derselben an Gesellschaft.

13.4 Fällt der Ausscheidende I in die Kategorie des Zwischenausscheidenden I, überträgt er sämtliche von ihm an

Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere und erhält dafür (a) den im Anhang 2.1 der Aktionärsvereinbarung genannten
Einzelanlagebetrag oder, soweit niedriger, (b) den angemessenen Marktwert der Wertpapiere.

92324

B. Der Ausscheidende II
13.5 Wird der Beratervertrag mit dem Ausscheidenden II gekündigt, ist der Ausscheidende II verpflichtet und berech-

tigt, die von ihm an Gesellschaft gehaltenen zusätzlichen Aktien nach Maßgabe eines zwischen ihm und Gesellschaft ge-
mäß Artikel 14 der Aktionärsvereinbarung und vorbehaltlich der Artikel 14.2 und 14.3 der Aktionärsvereinbarung
abzuschließenden Kaufvertrags ohne unzumutbare Verzögerungen an Gesellschaft zu verkaufen und zu übertragen.

13.6 Fällt der Ausscheidende II in die Kategorie des schlechten Ausscheidenden II, ist der Ausscheidende II verpflich-

tet, sämtliche von ihm an Gesellschaft gehaltenen zusätzlichen Aktien ohne unzumutbare Verzögerungen an Gesellschaft
abzutreten, ohne einen Erlös daraus zu erhalten. Es gelten dann die Bedingungen des Artikels 14.2 der Aktionärsverein-
barung.

13.7 Fällt der Ausscheidende II in die Kategorie des guten Ausscheidenden II, überträgt er sämtliche von ihm an Ge-

sellschaft gehaltenen zusätzlichen Aktien gegen Erhalt des angemessenen Marktwertes derselben an Gesellschaft.

13.8 Um jegliche Zweifel auszuschalten, gilt als vereinbart, dass nur die zusätzlichen Aktien des Ausscheidenden II den

Bestimmungen über Ausscheidende unterliegen, in keinem Fall aber andere Wertpapiere, die der Ausscheidende II an
Gesellschaft hält.

C. Allgemeine Auflage
13.9 Die in den Artikels 13.1 bis 13.8 niedergelegten Rechte und Verpflichtungen gelten nur in dem rechtlich zuläs-

sigen Ausmaß.

Kapitel V. Management - Verwaltungsstruktur des Unternehmens - Vertretung - Wirtschaftsprüfer

Art. 14. Vorstand
14.1 Gesellschaft wird vom Vorstand verwaltet, der sich aus mindestens drei Directors zusammensetzt, deren Mehr-

heit ihren Wohnsitz in Luxemburg haben muss; die Directors müssen nicht notwendigerweise Gesellschafter sein und
werden für eine Amtszeit von maximal sechs Jahren von der Hauptversammlung bestellt.

14.2 Die Directors können grundsätzlich wieder gewählt werden und können mit oder ohne Vorliegen von Gründen

jederzeit von der Hauptversammlung abberufen werden.

14.3 Das Mandat der nicht wieder gewählten Directors endet umgehend nach der Hauptversammlung des Jahres, in

dessen Verlauf ihr Mandat abläuft.

14.4 PAMPLONA kann jederzeit und aus jedweden Gründen eine beliebige Person zur Bestellung derselben als

Director der Gesellschaft durch die Hauptversammlung designieren; desgleichen kann sie der Hauptversammlung vor-
schlagen, einen gemäß Artikel 14.1 bestellten Director seines Amtes zu entheben.

14.5 Jeder Director der Gesellschaft und der GmbH 1 sowie anderer Firmen, die von Gesellschaft kontrolliert wer-

den, aber nur Firmenmantelfunktion haben, erhält eine Vergütung von maximal EUR 5.000 pro Jahr und pro Gesellschaft
und wird für einen Zeitraum von maximal drei Jahren bestellt (wobei eine Wiederbestellung nach Ablauf des Dreijah-
reszeitraums zulässig ist).

Art. 15. Freie Ämter
15.1 Freie Ämter im Vorstand werden durch die verbleibenden Directors in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise

belegt. In einem solchen Fall führt die nächste Aktionärsversammlung die endgültige Wahl aus.

15.2 Wird als Ersatz für einen Director, dessen Mandat noch nicht abgelaufen ist, ein anderer Director gewählt, hebt

dieser das Mandat seines Vorgängers auf.

Art. 16. Vorsitzender
16.1 Der Vorstand wählt aus dem Kreise der in Luxemburg ansässigen Personen einen Vorsitzenden.
16.2 Bei Abwesenheit des Vorsitzenden bestellen wie bei einer Sitzung anwesenden Directors einen anderen Direc-

tor zum vorübergehenden Vorsitzenden.

Art. 17. Versammlungen
17.1 Die Sitzungen des Vorstands werden vom Vorsitzenden oder, bei seiner Abwesenheit von dem Director, der

ihn vertritt, einberufen und geleitet.

17.2 Der Vorstand trifft so häufig zusammen, die Belange der Gesellschaft es erforderlich machen oder sobald min-

destens zwei Directors eine Sitzung fordern. Die Sitzungen finden normalerweise in Luxemburg an dem in der Einladung
genannten Ort statt.

Art. 18. Verfahren
18.1 Der Vorstand kann nur dann gültig beraten bzw. handeln, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder

vertreten ist; dabei gilt die Voraussetzung, dass nicht in Luxemburg ansässige Mitglieder keine Mehrheit der bei einer
Versammlung anwesenden Directors darstellen können.

18.2 Jeder Director kann schriftlich, per Telex oder Fax einen anderen Director zu seinem Stellvertreter bestellen,

damit dieser ihn bei einer anberaumten Sitzung des Vorstands vertreten und in seinem Namen abstimmen kann. Der
stellvertretend handelnde Director gilt für die Zwecke seiner eigenen Stimmabgabe ebenfalls als anwesend.

18.3 Jeder Director kann per Konferenztelefon oder anhand dementsprechender Kommunikationsmittel, die allen

Personen ermöglichen, sich gegenseitig zu hören, an den Sitzungen des Vorstands teilnehmen; dabei gilt als Vorausset-
zung, dass kein Director einer solchen Sitzung von einem Ort aus telefonisch beiwohnen darf, der sich außerhalb von
Luxemburg befindet. Jede Teilnahme an einer Telefonkonferenz, die von einem in Luxemburg ansässigen Director initi-
iert und geleitet wird, gilt als Sitzung, bei der er persönlich anwesend ist, und die in dieser Form abgehaltene Sitzung gilt
als eine in Luxemburg abgehaltene Sitzung.

18.4 Beschlüsse durch Rundschreiben, die von sämtlichen Directors unterzeichnet werden, sind genauso gültig und

verbindlich wie die bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung verabschiedeten Be-
schlüsse. Diese Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Ausfertigungen mit demselben

92325

Beschluss erscheinen und können durch Brief, Telefax oder Telex nachgewiesen werden. Eine in der Form eines Be-
schlussrundschreibens abgehaltene Sitzung gilt als in Luxemburg abgehalten.

18.5 Die Beschlüsse des Vorstands bedürften der Mehrheit der bestellten Directors.
18.6 Ausschließlicher und rechtswirksamer Ort des Managements ist Luxemburg Sämtliche Managementtätigkeiten

werden in oder von Luxemburg aus vorgenommen.

18.7 Falls der Verwaltungsrat eine Versammlung beschliesst, der die Aktieninhaber in Person beizuwohnen haben,

werden die Inhaber von dem Verwaltungsrat über vorgenannte Versammlung und deren Tagesordnung nicht später als
2 (zwei) Tage vor dem Termin informiert. Die Aktieninhaber können dann einen Vertreter ernennen, der allen derar-
tigen Versammlungen als Beobachter (ohne jegliche Stimmrechte) beiwohnt.

Art. 19. Protokoll
19.1 Die vom Vorstand verabschiedeten Beschlüsse werden in ein Protokoll aufgenommen. Dieses Protokoll wird

vom Vorsitzenden der Sitzung sowie einem weiteren Director unterzeichnet. Protokolle, in denen per Rundschreiben
angenommene Beschlüsse niedergelegt werden, sind vom Vorstandsvorsitzenden und einem weiteren Director zu un-
terzeichnen. Die schriftlich, per Telex oder Fax erteilten bzw. vorgenommenen Stimmrechtsvollmachen, Stimmabgaben
und Meinungen werden dem Protokoll hinzugefügt.

19.2 Kopien oder Auszüge aus solchen Protokollen, die bei Gerichtsverfahren oder anderweitig vorzulegen sind, müs-

sen vom Vorstandsvorsitzenden, einem Director oder der/den Person/en unterzeichnet werden, der/denen das tägliche
Management der Gesellschaft obliegt.

19.3 Die Protokolle werden am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft aufbewahrt.
19.4 Der Vorstand informiert die Aktieninhalter über alle wichtigen Entscheidungen, die nicht zu den alltäglichen Ent-

scheidungen, und versorgt sie zeitgerecht mit Kopien der Beschlüsse des Vorstands.

Art. 20. Befugnisse des Vorstands
Dem Vorstand obliegen die weitestgehenden Vollmachten zur Vornahme sämtlicher Handlungen, die für das Errei-

chen der Zwecke der Gesellschaft erforderlich oder sachdienlich sind; ausgenommen davon sind die Befugnisse, die kraft
Gesetz oder der Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Art. 21. Tägliches Management
21.1 Der Vorstand kann das tägliche Management und die Vertretung der Gesellschaft im Rahmen des täglichen Ma-

nagements an eine oder mehrere Personen delegieren. Er nimmt die Bestellungen und die Absetzungen der Personen
vor, denen diese Aufgaben anvertraut werden, die aber nicht Directors sein müssen, und legt deren Vergütungen und
Befugnisse fest.

21.2 Die Delegierung des täglichen Managements an ein Vorstandsmitglied versteht sich vorbehaltlich der vorherigen

Zustimmung der Hauptversammlung und legt dem Vorstand die Pflicht auf, der Hauptversammlung alljährlich Bericht
über die von diesem Vorstandsmitglied bezogenen Gehälter, Vergütungen und weiteren Leistungen aller Arten zu er-
statten.

21.3 Der Vorstand und die Personen, denen das tägliche Management anvertraut wurde, können im Rahmen dieses

Managements besondere und festgelegte Befugnisse an eine oder mehrere von ihnen auserwählte Personen delegieren.

21.4 Der Vorstand kann einen oder mehrere Ausschüsse einrichten, deren Mitglieder nicht unbedingt Directors sein

müssen, und deren Zusammensetzung und Befugnisse festlegen.

Art. 22. Vertretung
22.1 Gesellschaft kann durch die alleinige Unterschrift eines jeden Directors an Handlungen gebunden werden,

einschließlich solchen, die die Einmischung einer Person im öffentlichen Dienst oder eines Notars erfordern oder mit
Gerichtsverfahren zusammenhängen.

22.2 Sie kann darüber hinaus durch sämtliche Personen gebunden werden, denen Sondervollmachten erteilt wurden,

allerdings nur soweit, wie diese Personen im Rahmen dieser Vollmachten handeln.

Art. 23. Gesetzlich vorgeschriebener Wirtschaftsprüfer
23.1 Die Aufsicht der Tätigkeiten der Gesellschaft wird einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern anvertraut, die

nicht Gesellschafter sein müssen und von der Hauptversammlung für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren gewählt
werden.

23.2 Die Wirtschaftsprüfer können wieder gewählt werden und von der Hauptversammlung jederzeit ihres Amts ent-

hoben werden.

23.3 Die Hauptversammlung legt die Anzahl der Wirtschaftsprüfer fest. 
23.4 Werden Wirtschaftsprüfer nicht wieder gewählt, endet ihr Mandat umgehend nach der gewöhnlichen Hauptver-

sammlung des Jahres, in dessen Verlauf ihr Mandat abläuft.

23.5 Die Pflichten und Vollmachten der Wirtschaftsprüfer richten sich nach dem Gesetz.

Kapitel V. Hauptversammlungen - Gesellschafter

Art. 24. Vollmachten/Befugnisse
24.1 Jede regulär konstituierte Hauptversammlung handelt in Vertretung sämtlicher Gesellschafter.
24.2 Nach Maßgabe dieser Satzung und des Gesetzes von der Hauptversammlung angenommene Entscheidungen sind

für sämtliche Gesellschafter verbindlich, einschließlich denen, die bei der betreffenden Sitzung nicht anwesend waren
oder gegen die Entscheidung gestimmt haben.

24.3 Die folgenden Handlungen oder Maßnahmen dürfen (i) nicht eigenständig vom Vorstand vorgenommen bzw. er-

griffen werden, wenn der Vorstand im Rahmen des Gesetzes nur mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung aller Ge-
sellschafter zur Vornahme bzw. Ergreifung solcher Handlungen oder Maßnahmen befugt ist; (ii) von der

92326

Hauptversammlung nur dann vorgenommen bzw. ergriffen werden, wenn sie von allen Gesellschaftern einstimmig be-
schlossen worden sind:

(a) Änderung der Satzung oder von Gründungsdokumenten der Gesellschaft oder einer Gesellschaft der Gruppe, au-

ßer einer Änderung des Geschäftsjahres;

(b) Die solvente Liquidation, Abwicklung oder Auflösung der AMOR, GmbH &amp; Co. KG und der Gesellschaft;
(c) Wesentliche Änderungen am Geschäftsbetrieb einer Gesellschaft der Gruppe, wie er zur Zeit des Übergabestich-

tags des Kaufvertrags vorgenommen wurde;

(d) Jede Transaktion, (i) die nicht auf rein geschäftlicher Grundlage erfolgt oder (ii) zwischen einer Gesellschaft der

Gruppe einerseits und einer mit PAMPLONA oder PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT LLP verbundenen Partei
andererseits vorgenommen werden soll, außer:

(i) eine Abtretung der Beteiligung Pamplonas an der Gesellschaft; oder
(ii) in der Aktionärsvereinbarung und/oder den Transaktionsdokumenten vorgesehene Transaktionen und/oder Ver-

einbarungen.

(e) jegliche weiteren Zwecke der Gesellschaft, außer die in Artikel 3.1 erwähnten Zwecke;
(f) jegliche Ausgaben ohne Zeichnungsrechten der Gesellschafter unter den Bedingungen und Konditionen und der

Proportion, in der sich ihre bereits gehaltenen Wertpapiere zu den ausstehenden Wertpapieren verhalten;

(g) jegliche Ausgaben von Wertpapieren, in deren Zusammenhang die Zeichnung nicht die gleiche Proportion auf-

weist wie die Kapitalstruktur der Gesellschaft;

(h) jegliche Transaktionen, die die Gesellschafterrechte eines Mitanlegers in Bezug auf Gesellschafterrechte der

PAMPLONA nachteilig beeinträchtigen würden.

Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen bedürfen Erwerbungen von Geschäftsbetrieben oder Beteiligungen

gemäß Artikel 2.9 der Aktionärsvereinbarung und den einschlägigen Nachträgen zur Satzung der Gesellschaft, die diese
Erwerbungen widerspiegeln, und - soweit der Fall - eine Erhöhung des erklärten Aktienkapitals der Gesellschaft nicht
der vorherigen schriftlichen Zustimmung aller Gesellschafter.

Art. 25. Versammlungen
25.1 Die Jahreshauptversammlung der Gesellschafter wird in jedem Jahr am sechzehnten November um 11.00 Uhr

lokaler Zeit abgehalten.

25.2 Fällt dieser Tag auf einen öffentlichen Feiertag, wird die Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag zur

gleichen Uhrzeit abgehalten. 

25.3 Gewöhnliche und außergewöhnliche Hauptversammlungen werden am eingetragenen Geschäftssitz der Gesell-

schaft oder an dem anderen Ort in Luxemburg abgehalten, der in der Einladung zur Versammlung genannt ist. 

25.4 Hauptversammlungen, einschließlich der Jahreshauptversammlung dürfen im Ausland abgehalten werden, wenn

der Vorstand die endgültig verbindliche Meinung vertritt, dass dies infolge von Umständen höherer Gewalt erforderlich
ist.

25.5 Gewöhnliche und außergewöhnliche Hauptversammlungen bedürfen zwecks Gültigkeit und gültiger Tagung der

persönlichen Anwesenheit bzw. der Anwesenheit durch Vertretung von mindestens 50% aller Aktien.

Art. 26. Recht zur Einberufung
26.1 Hauptversammlungen werden vom Vorstand einberufen.
26.2 Hauptversammlungen sind so einzuberufen, dass sie innerhalb von einem Monat abgehalten werden können,

wenn einer oder mehrere Gesellschafter, der/die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals repräsentieren, entspre-
chendes fordert/fordern. Diese Aufforderung bedarf der Schriftform und Angabe der auf die Tagesordnung zu setzenden
Punkte.

Art. 27. Einladungen
27.1 Die Einladungen zur Ordentlichen Generalversammlung erfolgt per Einschreibebrief an jeden Aktieninhaber, an

die im Aktienregister angegebene Anschrift und werden nicht später als 1 (einen) Monat vor der vorgenannten Ordent-
lichen Generalversammlung entsendet.

27.2 Sind bei einer Hauptversammlung alle Gesellschafter anwesend bzw. vertreten oder haben sämtliche Gesell-

schafter auf eine Einladung verzichtet und erklären, die Tagesordnung zu kennen, kann die Hauptversammlung ohne vor-
herige Mitteilung abgehalten werden.

Art. 28. Vertretung
Jeder Gesellschafter kann bei Hauptversammlungen tätig werden, indem er einer anderen Person, die nicht Gesell-

schafter sein muss, eine entsprechende schriftliche Vollmacht erteilt.

Art. 29. Bureau
29.1 Jede Hauptversammlung findet unter dem Vorsitz des Vorstandsvorsitzenden oder, im Falle seiner Abwesenheit,

unter dem Vorsitz der von den Gesellschaftern bestellten Person statt.

29.2 Der Vorsitzende der Hauptversammlung bestellt einen Schriftführer und die Versammlung wählt einen oder

mehrere Stimmenzähler/Wahlprüfer. Sie zusammen bilden das Bureau.

Art. 30. Stimmrechte
Jede Aktie verleiht eine Stimme.

Art. 31. Entscheidungen der Hauptversammlung  
31.1 Die Hauptversammlung tagt nur zu den in der Tagesordnung aufgeführten Punkten.
31.2 Soweit kraft Gesetz oder gemäß Aktionärsvereinbarung und/oder Satzung nicht anderweitig erforderlich, wer-

den Beschlüsse mit der Mehrheit der Stimmen verabschiedet.

92327

31.3 Hauptversammlungen, die zum Zwecke der Änderung/Ergänzung der Satzung einberufen werden, können nur

gültig abgehalten werden, wenn die vorgesehene Änderung/Ergänzung in der Tagesordnung aufgeführt ist und, soweit
anwendbar, den Text der Änderungen/Ergänzungen enthält, wenn sie sich auf den Zweck oder die Form der Gesellschaft
beziehen. Die bei einer Hauptversammlung verabschiedeten Beschlüsse über eine Änderung/Ergänzung der Satzung be-
dürfen zwecks Gültigkeit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden bzw. vertretenden Aktien.

Art. 32. Protokoll
32.1 Das Protokoll der Hauptversammlungen wird von den Mitgliedern des Bureaus und den Gesellschaftern unter-

zeichnet, die dieses wünschen.

32.2 Kopien oder Auszüge von Protokollen, die bei Gerichtsverfahren oder anderweitig vorzulegen sind, müssen vom

Vorstandsvorsitzenden, von einem Director oder von der/den Person/en unterzeichnet werden, der/denen das alltäg-
liche Management der Gesellschaft anvertraut wurde.

32.3 Die Protokolle werden am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft aufbewahrt.
32.4 Der Verwaltungsrat übermittelt den Aktieninhaber rechtzeitig und nicht später als zwei Wochen nach Abhaltung

der Versammlung, sämtliche Sitzungsprotokolle der Ordentlichen Generalversammlung.

Kapitel VI. Jahresabschlüsse - Gewinnzuweisungen

Art. 33. Geschäftsjahr
33.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juni und endet am 31. Mai eines jeden Jahres.
33.2 Der Vorstand erstellt in jedem Jahr eine Bestandsliste sowie nach Maßgabe des Gesetzes die Jahresabschlüsse,

die aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und den Anmerkungen bestehen.

Art. 34. Genehmigung der Jahresabschlüsse - Entlastung
34.1 Die Hauptversammlung hört den Bericht des Managements an, prüft den Bericht der Wirtschaftsprüfer und ge-

nehmigt, soweit sie einverstanden ist, die Jahresabschlüsse.

34.2 Nach Genehmigung der Abschlüsse entscheidet die Hauptversammlung im Rahmen einer separaten Abstimmung

über die Entlastung der Directors und Wirtschaftsprüfer.

Art. 35. Bekanntgabe
Die Jahresabschlüsse, der Bericht des Managements sowie die kraft Gesetz vorgelegten Unterlagen sind in der

gesetzlich vorgeschriebenen Art und Weise öffentlich bekannt zu machen.

Art. 36. Gewinnausschüttungen
36.1 Ein Betrag in Höhe von mindestens einem Zwanzigstel des in der Bilanz ausgewiesenen Nettojahresergebnisses,

abzüglich Gemeinkosten und als erforderlich betrachteten Rückstellungen, ist pro Jahr aus einem solchen Ergebnis der
gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zuzuweisen. Diese Zuweisung ist nicht mehr erforderlich, sobald und solange die-
se Rücklage sich auf ein Zehntel des Kapitals der Gesellschaft beläuft. 

36.2 Die Hauptversammlung kann nach ihrem Ermessen über den Umgang mit dem Jahresüberschuss entscheiden.
Insbesondere kann sie den Gewinn anhand von Dividenden ausschütten, ihn der Rücklage zuweisen oder vortragen.

Art. 37. Dividenden
37.1 Der Vorstand entscheidet über Zeitpunkt und Ort der Ausschüttung der von der Hauptversammlung erklärten

Dividenden.

37.2 Der Vorstand kann nach Maßgabe des Gesetzes Zwischendividenden erklären und ausschütten.

Kapitel VII. Auflösung - Abwicklung

Art. 38. Auflösung - Abwicklung
38.1 Im Falle einer freiwilligen Auflösung der Gesellschaft aus jedweden Gründen, zu einem beliebigen Zeitpunkt und

in jedweder Art und Weise wird die Abwicklung von einem oder mehreren Abwicklern vorgenommen, der/die von der
Hauptversammlung bestellt wird/werden, die die Auflösung beschlossen hat; die Hauptversammlung legt darüber hinaus
auch deren Vollmachten und Vergütungen fest. Die Befugnis zur Änderung der Gründungsurkunde, soweit eine solche
Änderung durch die Auflösung gerechtfertigt ist, obliegt der Hauptversammlung.

38.2 Mit der Bestellung der Abwickler enden die Befugnisse der Directors. 

Art. 39. Überschusszuweisung
Im Falle einer/eines freiwilligen oder zwangsläufigen Abwicklung, Konkurses, Auflösung oder Liquidation der Angele-

genheiten der Gesellschaft sowie nach Zahlung sämtlicher Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder für die-
se Zwecke erfolgenden Geldhinterlegungen wird der verbleibende Überschuss zunächst an die Inhaber der
Vorzugsaktien in Proportion zu den von ihnen gehaltenen Vorzugsaktien gezahlt. Soweit möglich, berechtigt jede Vor-
zugsaktie zur Ausschüttung eines Überschussbetrags in Höhe (i) des Marktwerts einer Vorzugsaktie oder, soweit höher,
(ii) der anteilmäßigen Abwicklungserlöse unter Berücksichtigung des Anteils einer Vorzugsaktie am gesamten Aktienka-
pital der Gesellschaft.

Kapitel VII. Allgemeine Bestimmungen

Art. 40. Maßgebliches Recht
Alle Angelegenheiten, die nicht in der Gesellschaftssatzung und in der Gesellschaftervereinbarung geregelt sind, rich-

ten sich nach den Bestimmungen des Gesetzes. Falls sich die Bestimmungen der Gesellschaftsatzung und der Gesellschaf-
tervereinbarung widersprechen, sind die Bestimmungen der Gesellschaftervereinbarung, soweit gesetzlich möglich,
massgebend.

92328

<i>Achter Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Aktienregisters der Gesellschaft abzuändern, um die unter Punkt 3. erfasste Ände-

rung wiederzuspiegeln und beschliesst jedem Geschäftsführer der Gesellschaft, Einzelbevollmächtigung zu erteilen, um
im Auftrag der Gesellschaft die Eintragung ins Aktienregister der unter Punkt 3. erfassten Abänderung vorzunehmen.

<i>Kosten

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstige Verbindlichkeiten welcher Art auch immer, die dieser Urkunde

zufolge auftreten, gehen zu Lasten der Gesellschaft und betragen schätzungsweise EUR 4.600.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt, dass auf Antrag der Komparenten, diese

Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Auf Antrag der vorgenannten
Komparenten ist, bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung mass-
gebend.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten und die Komparenten, haben die

Bevollmächtigten und vorgenannten Komparenten mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Vanweddingen, A. Grosjean, C.-M. Darnand, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 août 2006, vol. 920, fol. 34, case 3. – Reçu 1.493,85 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087406.3/272/1284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

INTERVALOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 14.387. 

L’an deux mille six, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INTERVALOR S.A.,

avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neu-
man, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 novembre 1976, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, numéro 390 du 24 décembre 1976, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la
dernière fois suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre
2002, publié au Mémorial C, numéro 165 du 17 février 2003,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 14.387.

<i>Bureau

La séance est ouverte à 15.15 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques,

demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Fanny Marx, employée privée, demeurant professionnellement

à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fabrice Meeuwis, licencié en sciences économiques et sociales, de-

meurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Composition de l’assemblée

Il existe actuellement 4.000 (quatre mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, en-

tièrement souscrites et libérées et représentant l’intégralité du capital social de EUR 100.000,- (cent mille euros).

Les noms des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant.

<i>Exposé du Président

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Fixation d’une durée illimitée de la société.
2. Modification de l’article 3 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«La société est constituée pour une durée illimitée.»

Esch-sur-Alzette, le 18 août 2006.

B. Moutrier.

92329

3. Renouvellement pour une nouvelle durée de cinq ans de l’autorisation qui avait été conférée au conseil d’adminis-

tration en date du 27 novembre 2002 en vue de porter le capital à EUR 1.500.000 dans les mêmes termes et conditions
que ceux fixés antérieurement.

4. Modification des alinéas 4 à 12 de l’article 5 des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:
«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille

euros) qui sera représenté par 60.000 (soixante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) cha-
cune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 13 juillet 2011, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
5. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du troisième vendredi du mois de juillet au troisième ven-

dredi du mois de juin et pour la première fois en 2007.

6. Modification du premier alinéa de l’article 15 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 15. Alinéa 1

er

. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans

la convocation le troisième vendredi du mois de juin à seize (16.00) heures.

II.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale, il a pu être fait abs-

traction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se considère

comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

Le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

<i>Résolutions

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide que la durée de la société sera désormais illimitée, et par conséquent décide de modifier

l’article 3 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«La société est constituée pour une durée illimitée.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale prend acte du rapport du conseil d’administration proposant le renouvellement du capital auto-

risé de EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille euros) représenté par 60.000 (soixante mille) actions d’une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, et proposant de conférer au conseil d’administration, dans le cadre
de ce capital autorisé, le pouvoir de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens ac-
tionnaires.

Ce rapport après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé

au présent acte pour être enregistré avec lui.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale approuve le rapport du conseil d’administration proposant le renouvellement du capital auto-

risé de EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille euros) et décide de renouveler l’autorisation qui avait été conférée
au conseil d’administration en date du 27 novembre 2002 en vue de porter le capital à EUR 1.500.000 (un million cinq
cent mille euros) représenté par 60.000 (soixante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros)
chacune, dans les mêmes termes et conditions que ceux fixés antérieurement.

92330

<i>Quatrième résolution

Suite aux deux résolutions qui précèdent l’assemblée générale décide de modifier les alinéas 4 à 12 de l’article 5 des

statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille

euros) qui sera représenté par 60.000 (soixante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) cha-
cune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 13 juillet 2011, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle du troisième vendredi du mois de

juillet au troisième vendredi du mois de juin et pour la première fois en 2007, et par conséquent de modifier le premier
alinéa de l’article 15 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 15. Alinéa 1

er

. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans

la convocation le troisième vendredi du mois de juin à seize (16.00) heures.»

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul

préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède et interprétation donnée à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus

du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec Nous, no-
taire, aucun actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: P. Lentz, F. Marx, F. Meeuwis, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, vol. 154S, fol. 66, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(094674.3/222/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.

INTERVALOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 14.387. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094676.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Luxembourg-Bonnevoie, le 1

er

 septembre 2006.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 1

er

 septembre 2006.

T. Metzler.

92331

LUX EURO-ASIAN INVESTMENTS III, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 83.310. 

In the year two thousand and six, on the seventh of July.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) LSF3 REOC III, L.P., established in Delaware, USA, represented by Michael D. Thomson, acting in his capacity as

Vice President of LSF3 GenPar III, LLC, as general partner of LSF3 REOC III, L.P.,

here represented by Ms Aline Giersch, private employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Dallas, Texas on 3 July 2006;
2) LONE STAR FUND III (BERMUDA) L.P., established in the Islands of Bermuda, represented by Sandra Collins,

acting in her capacity as Vice President of LONE STAR MANAGEMENT CO. Ill, LTD., general partner of LONE STAR
PARTNERS III, L.P., as general partner of LONE STAR FUND III (BERMUDA), L.P.,

here represented by Ms Aline Giersch, private employee, with professional address in Luxembourg, 
by virtue of a power of attorney, given in Dallas, Texas on 3 July 2006.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The appearing parties are the sole shareholders of the Luxembourg private limited liability company (société à re-

sponsabilité limitée) LUX EURO-ASIAN INVESTMENTS III (the Company) having its registered office at 10B, rue Henri
Schnadt, L-2530 Luxembourg, incorporated on 10 August 2001 pursuant to a notarial deed recorded by the undersigned
notary, published in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et As-
sociations, Mémorial C), N

°

 of 105, p. 5035, on 19 January 2002, and registered with the Luxembourg trade and com-

panies’ register under number B 83.310.

The shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that the appearing parties own 100% of the Company’s share capital and the entire share capital is thus present or

represented;

II. the agenda of the Meeting is as follows:
1. the decision to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. the decision to appoint Mr Philippe Detournay and Mr Benjamin Drew Velvin III as liquidators (liquidateurs) in re-

lation to the liquidation of the Company (the Liquidators);

3. the determination of the powers of the Liquidators and the liquidation procedure of the Company; and
4. the decision to instruct the Liquidators to execute at the best of their abilities and with regard to the circumstances

all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

After deliberation, the shareholders passed, by a unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation vo-

lontaire).

<i>Second resolution

The Meeting resolves to appoint Mr Philippe Detournay and Mr Benjamin Drew Velvin III as liquidators (liquidateurs)

in relation to the liquidation of the Company (the Liquidators).

The Liquidators have the widest powers to do everything, which is required for the liquidation of the Company and

the disposal of the assets of the Company under their sole individual signature.

<i>Third resolution

The meeting resolves to confer to the Liquidators the powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxembourg act

dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies’ Act 1915).

The Liquidators shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article

145 of the Companies’ Act 1915, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The Liquida-
tors may, under their sole responsibility, delegate their powers for specific operations or tasks to one or several persons
or entities.

The Liquidators shall be authorised to make, in their sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds

(boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Companies’ Act 1915.

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to instruct the Liquidator to execute at the best of their abilities and with regard to the cir-

cumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that at the request of the above appear-

ing parties, this notarial deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same appearing
parties, and in the case of discrepancy between the English and French versions, the English version shall prevail.

The document having been read to the mandatory of the appearing persons, said mandatory signed together with Us,

the notary the present original deed. 

92332

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le sept juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) LSF3 REOC III, L.P., établie dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis), représentée par M. Michael D. Thomson, agissant

en tant que Vice Président de LSF3 GenPar III, LLC, en tant que general partner de LSF3 REOC III, L.P.,

ici représenté par Mlle Aline Giersch, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Dallas, Texas, le 3 juillet 2006;
2) LONE STAR FUND III (BERMUDA), établie aux Bermudes, représentée par Mme Sandra Collins, agissant en tant

que Vice Présidente de LONE STAR MANAGEMENT CO. III, LTD., agissant en tant que general partner de LONE
STAR PARTNERS III, L.P., agissant en tant que general partner de LONE STAR FUND III (BERMUDA), L.P.,

ici représentée par Mlle Aline Giersch, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Dallas, Texas, le 3 juillet 2006.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-

parantes et le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les parties comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée LUX EURO-ASIAN INVEST-

MENTS III (la Société), ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, constituée le 10 août 2001
suivant un acte du notaire soussigné, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés
et Associations, Mémorial C, n

°

 105 du 19 janvier 2002 à la page 5032, enregistrée au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.310.

Les associés, représentés comme indiqué ci-dessous, ont demandé au notaire d’acter que:
I. les comparants détiennent 100% du capital social de la Société et l’intégralité du capital social est dès lors présente

ou représentée;

II. l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. dissolution et liquidation volontaire de la Société;
2. nomination de M. Philippe Detournay et M. Benjamin Drew Velvin III comme liquidateurs de la Société (les Liqui-

dateurs), en relation avec la liquidation volontaire de la Société;

3. détermination des pouvoirs à conférer aux Liquidateurs et de la procédure de liquidation; et
4. décision de charger les Liquidateurs de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la Société,

et de payer toutes les dettes de la Société.

Après délibération, les associés ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de dissoudre et liquider volontairement la Société.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateurs M. Philippe Detournay et M. Benjamin Drew Velvin III (les Li-

quidateurs), en relation avec la liquidation volontaire de la Société.

Les Liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir sous leur seule signature tout acte nécessaire pour

la liquidation de la Société et la réalisation de son actif.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’attribuer aux Liquidateurs tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Les Liquidateurs sont autorisés à passer tous actes et d’exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus

aux articles 145 de la Loi de 1915, sans autorisation préalable d’une assemblée générale des actionnaires. Les Liquida-
teurs pourront déléguer, sous leur propre responsabilité, leurs pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement
déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Les Liquidateurs sont autorisés à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société con-

formement à l’article 148 de la Loi de 1915.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de charger les Liquidateurs de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de

la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des parties compa-

rantes, le présent acte notarié est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. Sur la demande des mêmes
parties comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, celle-ci a signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: A. Giersch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, vol. 154S, fol. 55, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088149.3/230/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

Luxembourg, le 25 juillet 2006.

A. Schwachtgen.

92333

AEROSPACE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 73.268. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05445, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089074.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

GLOBAVIA S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 74.635. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05448, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089075.7//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

AERO RÉ, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 51.757. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06716, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089250.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

BERKSHIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 109.446. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04664, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

L’affectation du résultat au 31 décembre 2005, enregistrée à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06310, a été

déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089793.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

PERSEUS I, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue Jean-Baptiste Gillardin.

R. C. Luxembourg B 118.438. 

STATUTS

L’an deux mille six, le trente juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant professionnellement à Pétange, agissant au nom et pour compte de

la société à responsabilité limitée PERSEUS I, avec siège à F-75008 Paris, 30, avenue Georges V (R.C.S. Paris n

°

 449 491

497), en vertu d’une décision datée du 23 mai 2006, annexée au présent acte,

lequel comparant a requis le notaire d’acter une assemblée générale extraordinaire avec le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Ratification du transfert du siège social dans la Commune de Pétange (Luxembourg), avec continuation de la société

avec la nationalité luxembourgeoise sous la dénomination PERSEUS I, S.à r.l.

P. Gallasin.

P. Gallasin.

Luxembourg, le 24 août 2006.

Signature.

<i>Pour BERKSHIRE S.A.
Signature

92334

2. Augmentation de capital de 11.500,- EUR pour le porter de son montant actuel de 1.000,- EUR (mille euros) au

montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) divisé en 100 parts de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) cha-
cune.

3. Refonte des statuts pour les adapter à la législation luxembourgeoise.
4. Nomination d’un gérant.
5. Divers.
L’assemblée générale décide la refonte des prédits statuts pour leur donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il existe depuis le 30 juin 2006 une société sous à responsabilité limitée sous la dénomination de PERSEUS I.

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la Commune de Pétange. Il pourra être transféré en toute autre

localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

Art. 3. La société a pour objet: 
- l’acquisition de tous immeubles ou fractions d’immeubles ou droits sociaux donnant vocation à des immeubles ou

fractions d’immeubles, la mise en valeur de ces immeubles par toutes édification, améliorations et touts travaux de via-
bilité et autres;

- la propriété, l’administration, la gestion et l’exploitation des immeubles et biens sociaux par tous moyens et notam-

ment par bail ou location;

- la participation et notamment par voie de création de société ou de groupements d’intérêts économiques, de sous-

cription ou d’acquisition d’actions ou de tous autres droits sociaux, d’apport,de fusion, d’association ou de toute autre
manière dans toutes entreprises exerçant toutes activités économiques, financières, commerciales, industrielles, mobi-
lières ou immobilières;

- et en plus généralement toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou

indirectement à cet objet.

Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou caution-

nements à des personnes privées, aux associés, ainsi que à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou
indirect.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile, sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en 100 parts

sociales de 125,- EUR chacune, souscrit par l’unique associée, la société anonyme CONTINENTAL DEVELOPMENTS,
S.à r.l. (R.C. B n

°

 108.287), avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
Sont nommés gérants:
- Monsieur Thierry Chambon, né le 18 juin à Tunis, demeurant 42, rue Mary Basseyre à F-92170 Vanves,
- Monsieur Pascal Wagner, né le 8 février 1966 à Pétange, avec adresse professionnelle 81, rue Jean-Baptiste Gillardin

à L-4735 Pétange.

La société est valablement engagée par la signature individuelle d’un des co-gérant.
Le siège social est établi à L-4735 Pétange, 81, rue Jean-Baptiste Gillardin.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, sont estimés à 1.200,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu de Nous, Notaire, par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Wagner, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 juillet 2006, vol. 918, fol. 80, case 8. – Reçu 115 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087936.3/207/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

Pétange, le 27 juillet 2006.

G. d’Huart.

92335

SONAE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 73.263. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06712, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089253.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

GLARKSDALE MARINE INVESTMENT CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 114.084. 

Les comptes de clôture au 14 juillet 2006, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10890, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2006.

(089268.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

THEISEN &amp; SCHMITZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 31, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.233. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07334, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089325.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

THEISEN &amp; SCHMITZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 31, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.233. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07337, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089329.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

FRATELLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 107.596. 

L’an deux mille six, le trente et un mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FRATELLI S.A., ayant son

siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

 (R.C.S. Luxembourg section B numéro 107.596), consti-

tuée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg),
en date du 20 avril 2005, publié au Mémorial C, numéro 900 du 15 septembre 2005.

L’assemblée est présidée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, avec domicile professionnel à

L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Luxembourg, le 24 août 2006.

Signature.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

Signature.

Signature.

92336

<i>Ordre du jour:

1. Suppression du deuxième alinéa de l’article dix des statuts.
2. Modification de l’article treize des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Les Administrateurs ne pourront agir que dans le cadre des réunions du Conseil d’Administration régulièrement

convoquées, ou par consentement écrit conformément à l’article 11 ci-dessus. Le Conseil d’Administration aura le pou-
voir de déterminer la politique de la Société ainsi que le cours et la conduite de l’administration et des activités de la
Société.

Tous pouvoirs que la loi ou les présents Statuts ne réservent pas expressément à l’assemblée générale des actionnai-

res seront de la compétence du Conseil d’Administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que sa représentation dans ce cadre pourront, conformément à l’article 60

de la Loi de 1915, être confiées à un ou plusieurs Administrateurs, fondés de pouvoir ou gérants, actionnaires ou non,
agissant individuellement ou conjointement et qui seront désignés et révoqués par le Conseil d’Administration, lequel
déterminera leurs pouvoirs. Si cette délégation est octroyée à un membre du Conseil d’Administration, celle-ci sera
subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.»

3. Modification de l’article quatorze des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la signature individuelle d’un Administrateur, ou par la/les

signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’admi-
nistration.

La société pourra également accorder tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.» 
4. Démission de la société à responsabilité limitée BAC MANGEMENT, S.à r.l. de son mandat d’administrateur et

décharge.

5. Nomination de Monsieur Ely Ruimy, administrateur de sociétés, né le 31 décembre 1964 à Casablanca (Maroc),

demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 77 ter, rue Charles Laffitte, comme administrateur jusqu’à l’assemblée statutaire
appelée à délibérer sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.

6. Suite à la suppression des deux catégories d’administrateur, qualification des membres du conseil d’administration

comme suit:

a) Monsieur Alain Driancourt, directeur de banque, né le 5 décembre 1949 à Paris (France), demeurant profession-

nellement à CH-1211 Genève, Suisse, 3, cour de Rives, P.O. Box 3177;

b) Madame Nidia I.P. de Sousa Ruivo, assistante administrative, née le 22 janvier 1945 à Sines (Portugal), demeurant

à CH-1224 Genève, Suisse, Chêne-Bougeries, 8, chemin de la Fontaine;

c)  Monsieur  Ely  Ruimy,  administrateur  de  sociétés,  né  le  31  décembre  1964  à  Casablanca  (Maroc),  demeurant  à

F-92200 Neuilly-sur-Seine, France, 77 ter, rue Charles Laffitte.

7. Démission de la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l. de son mandat de commissaire aux comptes

et décharge.

8. Nomination de la société à responsabilité limitée KOHNEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 114.190,

avec siège social à L-2128 Luxembourg, 66, rue Marie-Adélaïde, comme commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée
statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.

9. Transfert du siège social de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte.

10. Divers.
II.- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

III.- Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer le deuxième alinéa de l’article dix des statuts.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article treize des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 13. Les Administrateurs ne pourront agir que dans le cadre des réunions du Conseil d’Administration réguliè-

rement convoquées, ou par consentement écrit conformément à l’article 11 ci-dessus. Le Conseil d’Administration aura
le pouvoir de déterminer la politique de la Société ainsi que le cours et la conduite de l’administration et des activités
de la Société.

Tous pouvoirs que la loi ou les présents Statuts ne réservent pas expressément à l’assemblée générale des actionnai-

res seront de la compétence du Conseil d’Administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que sa représentation dans ce cadre pourront, conformément à l’article 60

de la Loi de 1915, être confiées à un ou plusieurs Administrateurs, fondés de pouvoir ou gérants, actionnaires ou non,
agissant individuellement ou conjointement et qui seront désignés et révoqués par le Conseil d’Administration, lequel
déterminera leurs pouvoirs. Si cette délégation est octroyée à un membre du Conseil d’Administration, celle-ci sera
subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quatorze des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

92337

«Art. 14. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la signature individuelle d’un Administrateur, ou

par la/les signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil
d’administration.

La société pourra également accorder tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.» 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de donner décharge à l’administrateur démissionnaire, la société à responsabilité limitée BAC

MANGEMENT, S.à r.l., pour l’exercice de son mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Ely Ruimy, administrateur de sociétés, né le 31 décembre 1964 à Casablan-

ca (Maroc), demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 77 ter, rue Charles Laffitte, comme administrateur jusqu’à l’assem-
blée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.

<i>Sixième résolution

Suite à la suppression des deux catégories d’administrateur, l’assemblée décide de qualifier les membres du conseil

d’administration comme suit:

a) Monsieur Alain Driancourt, directeur de banque, né le 5 décembre 1949 à Paris (France), demeurant profession-

nellement à CH-1211 Genève, Suisse, 3, cour de Rives, P.O. Box 3177;

b) Madame Nidia I.P. de Sousa Ruivo, assistante administrative, née le 22 janvier 1945 à Sines (Portugal), demeurant

à CH-1224 Genève, Suisse, Chêne-Bougeries, 8, chemin de la Fontaine;

c) Monsieur Ely Ruimy, administrateur de sociétés, né le 31 décembre 1964 à Casablanca (Maroc), demeurant à

F-92200 Neuilly-sur-Seine, France, 77 ter, rue Charles Laffitte.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire, la société à responsabilité limi-

tée INTERAUDIT, S.à r.l., pour l’exercice de son mandat.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée KOHNEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg

B 114.190, avec siège social à L-2128 Luxembourg, 66, rue Marie-Adélaïde, comme commissaire aux comptes jusqu’à
l’assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

 à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Marx, Ch. Dostert, D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 juin 2006, vol. 536, fol. 90, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Hirtt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(086982.3/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2006.

REIMERWE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 48.412. 

L’an deux mille six, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée REIMERWE

(ci-après «la Société»), ayant son siège social à L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg, inscrite au registre de com-
merce de Luxembourg sous le numéro B 48.412, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 28 juillet 1994,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 3 décembre 1994.

L’assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Jean-Louis Rairoud, directeur financier et ad-

ministratif, demeurant au 29, rue de Grandvoir, B-6800 Libramont,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita Maggipinto, employée privée, demeurant à Mondercange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Delphine Hensgen, juriste, demeurant à Marange/Silvange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

Junglinster, le 24 juillet 2006.

J. Seckler.

92338

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

Réduction du capital
L’Assemblée décide de réduire le capital de 500.000,- EUR à 100.000,- EUR par un remboursement de 100.000,- EUR

à chaque actionnaire.

Seul l’article 6 des statuts de la Société a été modifié et prendra la teneur suivante:

«Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à 100.000,- EUR représenté par quatre mille (4.000) parts sociales

d’une valeur nominale de 25,- EUR.

Toutes ces parts sont entièrement libérées.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale statuant comme en matière de

modification des statuts.

Les Associés existants bénéficient d’un droit de souscription préférentiel pour la souscription des actions nouvelle-

ment émises et ce en proportion de leur participation dans la Société.

La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les conditions légalement requises.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour, qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de quatre cent mille euros (EUR 400.000,-)

pour le ramener de son montant actuel de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) à cent mille euros (EUR 100.000,-) par
remboursement à chacun des actionnaires d’un montant de cent mille euros (EUR 100.000,-) en procédant à la réduc-
tion de la valeur nominale des parts sociales, de sorte que le capital sera désormais représenté par quatre mille (4.000)
parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

En conséquence, l’article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par quatre mille (4.000) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Toutes ces parts sont entièrement libérées.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de

modification des statuts.

Les associés existants bénéficient d’un droit de souscription préférentiel pour la souscription des parts sociales nou-

vellement émises et ce en proportion de leur participation dans la Société.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions légalement requises.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J.-L. Rairoud, A. Maggipinto, D. Hensgen, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, vol. 154S, fol. 88, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(088230.3/200/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

REIMERWE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 48.412. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088233.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

Luxembourg, le 18 août 2006.

F. Baden.

F. Baden.

92339

NORTH STAR PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 82.807. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06177, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089397.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

ANTLIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 96.949. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06152, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089400.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

BOISSONOT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 85.871. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06151, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089401.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

H2O LAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PAEFERBUSCH S.A.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.766. 

L’an deux mille six, le onze juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

AERIUM H2O, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon le droit luxembourgeois, ayant

son siège social situé 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 115.265 (la «Société»),

dûment représentée par Monsieur Brieuc Alexandre de Crombrugghe de Looringhe, gérant, ayant son adresse pro-

fessionnelle au 25, Khighsbridge, Londres SW1X 7RZ, Royaume-Uni.

La comparante est l’actionnaire unique de la société PAEFERBUSCH S.A., ayant son siège social à L-2210 Luxem-

bourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous

le numéro 64.766, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 mai 1998, publié au Mémorial
C numéro 610 du 24 août 1998.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, détenant l’intégralité du capital social de la Société, a pris les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

L’actionnaire unique décide de changer la forme sociale de la Société et d’adopter la forme d’une société à respon-

sabilité limitée.

<i>Deuxième résolution

L’actionnaire unique décide de changer la dénomination sociale de la Société de PAEFERBUSCH S.A. à H2O LAND,

S.à r.l.

<i>Troisième résolution

L’actionnaire unique décide de changer l’objet social de la Société, qui prend désormais la teneur suivante:
«La Société a pour objet le placement de ses avoirs en valeurs mobilières et immobilières variées dans le but de faire

bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion et des plus-values éventuelles.

Elle pourra notamment investir en immeubles, vendre ces immeubles, les hypothéquer, les mettre en valeur et les

louer.

Luxembourg, le 17 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 27 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 17 juillet 2006.

Signature.

92340

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires ou autres. La So-

ciété peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une
participation directe ou indirecte ou des sociétés, qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

En général, la Société pourra faire toutes transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire on susceptible d’en
favoriser l’exploitation et le développement.»

<i>Quatrième résolution

L’actionnaire unique décide de transférer le siège social de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon à L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Cinquième résolution

L’actionnaire unique constate, avec effet à la date du présent acte, la démission de l’ensemble des gérants, à savoir: 
- Monsieur André Wilwert, résidant 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
- Monsieur Paul Marx, résidant 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
- Monsieur Eric Magrini, résidant 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
L’actionnaire unique leur accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de leur fonction.

<i>Sixième résolution

L’actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes comme gérants de la Société pour une durée indé-

terminée à compter de la date de la présente assemblée:

a. Monsieur Ely-Michel Ruimy, Président Directeur Général, né le 31 décembre 1964 à Casablanca, demeurant au 77,

rue Charles Laffitte, F-92200 Neuilly-sur-Seine,

b. Monsieur Franck Ruimy, Directeur, né le 2 février 1971 à Casablanca, demeurant professionnellement au 25, Kni-

ghstbridge, Londres, SW1X 7RZ, Royaume-Uni,

c. Monsieur Brieuc Alexandre de Crombrugghe de Looringhe, Directeur, né le 17 janvier 1974 à Bruxelles, demeurant

professionnellement au 25, Knighstbridge, Londres, SW1X 7RZ, Royaume-Uni.

<i>Septième résolution

L’actionnaire unique décide de modifier les statuts de la Société afin de refléter le changement de forme, de la déno-

mination et de l’objet social.

L’actionnaire unique décide en conséquence d’arrêter comme suit les statuts de la société à responsabilité limitée:

Art. 1

er

. II existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de H2O LAND, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet le placement de ses avoirs en valeurs mobilières et immobilières variées dans le but

de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion et des plus-values éventuelles.

Elle pourra notamment investir en immeubles, vendre ces immeubles, les hypothéquer, les mettre en valeur et les

louer.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires ou autres. La So-

ciété peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une
participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

En général, la Société pourra faire toutes transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire on susceptible d’en
favoriser l’exploitation et le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents)

représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 24,79 (vingt-quatre euros
soixante-dix-neuf cents) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l’article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée générale

des associés.

92341

A l’égard des tiers, la société sera engagée par la signature individuelle du gérant en cas de gérant unique ou en cas

de pluralité de gérants par la signature individuelle d’un des gérants.

En cas d’empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par deux associés, agissant

conjointement.

Art. 12. Le on les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. II a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se référent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Répartition des parts sociales

Les parts sociales étant échangées contre les actions anciennes à raison d’une part sociale pour une action ancienne,

mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales représentatives du capital sont détenues par AERIUM H2O, S.à r.l., une
société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire et enregistrée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.265.

Toutes les parts sont entièrement libérées.

<i>Exercice social

L’exercice social ayant commencé le premier janvier deux mille six se terminera le trente et un décembre deux mille

six.

<i>Mandat des gérants

Monsieur Ely-Michel Ruimy, Président Directeur Général, né le 31 décembre 1964 à Casablanca, demeurant au 77,

rue Charles Laffitte, F-92200 Neuilly-sur-Seine, est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée. 

Monsieur Franck Ruimy, Directeur, né le 2 février 1971 à Casablanca, demeurant professionnellement au 25, Knighst-

bridge, Londres, SW1X 7RZ, Royaume-Uni, est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.

Monsieur Brieuc Alexandre de Crombrugghe de Looringhe, Directeur, né le 17 janvier 1974 à Bruxelles, demeurant

professionnellement au 25, Knighstbridge, Londres, SW1X 7RZ, Royaume-Uni, est nommé gérant de la Société pour
une durée indéterminée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à deux mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B.A. de Crombrugghe de Looringhe, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 juillet 2006, vol. 537, fol. 27, case 7. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088025.3/231/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

Junglinster, le 14 août 2006.

J. Seckler.

92342

THALWEG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 97.644. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT05830, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089410.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

LERINS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 84.030. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT05834, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089412.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

NOVARES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 82.485. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03481, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2006.

(089413.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

BONUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 118.453. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société ZYBURN LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man),
ici représentée par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219

Luxembourg, 17, rue Beaumont, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17,

rue Beaumont.

La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société de participations

financières, sous forme de société anonyme, qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:

Art. 1

er

. Il existe une société de participations financières sous forme de société anonyme et sous la dénomination

de BONUS S.A.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se présentent ou paraissent

THALWEG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Th. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

LERINS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Th. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

NOVARES INTERNATIONAL S.A.
V. Arno’ / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / <i>Administrateur

92343

imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anor-
males. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce trans-
fert provisoire restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres, marques et brevets
de toute origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en
valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à neuf cent mille euros (900.000,- EUR), représenté par neuf mille (9.000) actions

de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2006.

92344

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de neuf cent mille euros (900.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ onze mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Régis Donati, expert-comptable, né à Briey (France), le 19 décembre 1965, demeurant professionnelle-

ment à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

- Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 13 février 1975, demeurant

professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

- Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, né à Luxembourg, le 20 mai 1963, demeurant professionnellement à

L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée INDEPENDANT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beau-

mont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 81.323.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2009.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elles ont toutes signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, R. Scheifer-Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 juillet 2006, vol. 537, fol. 20, case 5. – Reçu 9.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087983.3/231/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

SES GLOBAL LATIN AMERICA, Société Anonyme.

Registered office: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 118.454. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-eighth of July.
Before Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) SES GLOBAL, a société anonyme, having its registered office at Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf (R.C.S. Lux-

embourg B 81.267), 

1.- La société ZYBURN LIMITED, prédésignée, huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions   . . . . . . . .

8.999

2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: neuf mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.000

Junglinster, le 14 août 2006.

J. Seckler.

92345

2) SES GLOBAL PARTICIPATIONS, a société anonyme, having its registered office at Château de Betzdorf, L-6815

Betzdorf (R.C.S. Luxembourg B 101.799),

both represented by Pierre Margue, Vice President Legal and Corporate Affairs SES GLOBAL, residing in Betzdorf,

pursuant to proxies dated 27 July 2006.

The proxies given, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached

to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a société

anonyme which they declare to organise between themselves.

Art. 1. Name. There is hereby established a company in the form of a société anonyme under the name of SES

GLOBAL LATIN AMERICA (hereinafter the «Company»).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Betzdorf, Grand Duchy of Lux-

embourg. 

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

decision of the board of directors. If the board of directors determines that extraordinary political, economic, social or
military events have occurred or are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at
its registered office or the communication between such registered office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain
a Luxembourg company.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required

for amendment of these articles of incorporation.

Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is the operation of satellites or satellite systems covering the West-

ern hemisphere and, in particular, the Latin American continent. Within the scope of this purpose, the Company may
purchase and commercialise satellites and satellite capacity including launch services, engines, equipment and services of
whatever kind which are necessary or useful for its operations; it may establish, use or run fixed or mobile ground sta-
tions which ensure the tracking, telemetry and remote control of satellites as well as the communication links with such
satellites.

The Company may further carry out, implement and promote, directly by itself or indirectly through enterprises in

which it holds participations, or by any other means, all activities of intermediary, commissioner, broker or agent in
matters of satellite operations. It may operate, physically or electronically, handling or other agencies and render all
kinds of services in relation with, or complementary to, the abovementioned activities or contributing to the accom-
plishment or extension thereof.

The Company may participate in any form whatsoever, in Luxembourg or foreign companies, by purchase, sale, ex-

change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and may as well effect the ad-
ministration, develop and manage its portfolio.

The Company may lend or borrow with or without collateral, provided that any monies so borrowed may only be

used for the purpose of the Company or companies which are shareholders or subsidiaries of, or which are associated
with or affiliated to, the Company.

In general, the Company may undertake any financial, commercial, industrial or real estate transactions which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purpose and, in such context, it may give or receive guaran-
tees, issue all types of securities and financial instruments and enter into any type of hedging, trading or derivative trans-
actions.

Art. 5. Share Capital. The Company has a share capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into

three thousand one hundred (3,100) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) per share. 

The share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. Form of shares. All shares of the Company shall be issued in registered form only.
The issued shares shall be entered in the register of shares which shall be kept by the Company or by one or more

persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each owner of shares, his
address and the number of shares held by him.

The inscription of the shareholder’s name in the register of shares evidences his right of ownership of such shares.

A certificate shall be delivered upon request to the shareholder. Such certificate shall be signed by two members of the
board ofdirectors. The signatures shall be either manual, printed or in facsimile.

Any transfer of shares shall be recorded in the register of shares by delivery to the Company of an instrument of

transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shares,
dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly
and, each time, together with the delivery of the relevant certificate, if issued. Such inscription shall be signed by two
members of the board of directors or by one or several persons duly authorised therefore by the board of directors.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent.

Such address will also be entered into the register of shares.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to be

entered into the register of shares and the shareholder’s address will be deemed to be at the registered office of the

92346

Company or at such other address as may be so entered into the register by the Company from time to time until
another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his
address as entered into the register of shares by means of a written notification to the Company at its registered office
or at such other address as may be determined by the Company from time to time.

The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of

ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one
single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspen-
sion of all rights attached to such share(s).

Art. 7. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three

members, their number being determined by the general meeting of shareholders. Directors need not to be sharehold-
ers of the Company.

The directors shall be elected by the general meeting of shareholders for a period of not exceeding six (6) years and

until their successors are elected, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution
taken by the general meeting of shareholders. The directors shall be eligible for reappointment.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors

elected by the general meeting of shareholders may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors shall choose from among its members a

chairman, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The board of directors may also choose a
secretary, who need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the board of
directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the board of
directors.

The chairman shall preside over all meetings of the board of directors, but in his absence the members of the board

of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of a majority of the directors present or
represented at any such meeting.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or any two directors, at the place indicated in the notice

of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-
mail of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the
hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice
which shall duly set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively,
by the consent in writing or by telegram or telefax or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for
meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telefax, or e-

mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

The board of directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented

at a meeting of the board of directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting
the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be
given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event that

in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall not
have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference call or similar means of communi-

cations equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting. 

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors may also be passed by unanimous consent in

writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors

shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings. or otherwise shall be signed by

the chairman, or by the secretary, or by two directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The directors may only act at duly convened meetings of the board

of directors or by written consent in accordance with article 8 hereof.

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

Art. 11. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any

two directors of the Company, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by
the board of directors.

Art. 12. Delegation of Powers. The board of directors may generally or from time to time delegate the power

to conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such
management as provided for by article 60 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended,
to an executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to one
or more directors, managers or other agents who may act individually or jointly. The delegation to a member of the

92347

board of directors is subject to the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The board of directors
shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these dele-
gations of authority including the authority to sub-delegate.

The board of directors may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.

Art. 13. Conflict of Interest. In case of a conflict of interest of a director, it being understood that the mere fact

that the director serves as a director of a shareholder or of an affiliated company of a shareholder shall not constitute
a conflict of interest, he must inform the board of directors of any conflict and may not take part in the vote but will be

counted in the quorum. A director having a conflict on any item on the agenda must declare this conflict to the chair-

man before the meeting starts. 

Any director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the board of di-

rectors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his
statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting, but will
be counted in the quorum. At the following general meeting, before any other resolution to be voted on, a special report
shall be made on any transactions in which any of the directors may have a personal interest conflicting with that of the
Company.

Art. 14. General Meeting of Shareholders. The general meeting of shareholders shall represent the entire body

of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the Company.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the board of directors. Shareholders representing one

fifth of the subscribed share capital may, in compliance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies,
as amended, request the board of directors to call a general meeting of shareholders.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company

or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the last Wednesday in the month of March at 3.00 p.m.

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the following bank

business day in Luxembourg.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices

of meeting.

General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered

letter at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the register of share-
holder, or as otherwise instructed by such shareholder.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the

agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

The board of directors may determine all other conditions which must be fulfilled by shareholders in order to attend

a meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders shall designate its own chairman who shall preside over the meeting. The chair-

man shall designate a secretary who shall keep minutes of the meeting.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda

(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each share is entitled to one vote at all general meetings of shareholders. A shareholder may act at any meeting of

shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder.

Unless otherwise provided by law, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote of the

shareholders present or represented. 

Art. 15. Supervision of the Company. The operations of the Company shall be supervised by one or several

statutory auditors. The statutory auditor(s) shall be appointed and dismissed by the general meeting of shareholders.
Their term of office may not exceed six (6) years.

Art. 16. Accounting Year. The accounting year of the Company shall commence on the first of January and shall

terminate on the thirty-first of December of each year.

Art. 17. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to

the reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have
reached one tenth of the subscribed share capital.

The annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of shareholders.
Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of law. 

Art. 18. Dissolution of the Company. In case of a dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out

by one or several liquidators, who need not be shareholders, appointed by the general meeting of shareholders which
shall determine their powers and compensation. The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s)
to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

Art. 19. Amendments to the Articles of Incorporation. The present articles of incorporation may be amended

from time to time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 20. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in ac-

cordance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 21. Language. The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In

case of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

92348

<i>Transitory provisions

1) The first accounting year shall begin at the date of incorporation and shall terminate on the 31 December 2007.
2) The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2008.

<i>Subscription

 The shares in the Company are subscribed as follows: 

All these shares have been entirely paid-up by a contribution in cash so that the amount of thirty-one thousand Euro

(EUR 31,000.-) is as of now fully available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately EUR 3,000.-.

<i>Statements

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article twenty-six of the law of 10 August 1915

regarding commercial companies, as amended, have been fully observed.

<i>General Meeting of Shareholders

The above-named persons representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly con-

vened have immediately proceeded to a general meeting of shareholders.

Having first verified that it was regularly constituted, the general meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to set the number of directors at 3 and to elect the following persons as members of

the board of directors for a term to expire at the annual general meeting called to approve the accounts of the account-
ing year ended 2007:

- Mr Romain Bausch, Chairman, born on 3 July 1953 in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), residing profes-

sionally at Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf (Grand Duchy of Luxembourg);

- Mr Robert Bednarek, Director, born on 6 October 1957 in New York (United States of America), residing profes-

sionally at Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf (Grand Duchy of Luxembourg);

- Mr Mark Rigolle, Director, born on 11 April 1965 in Maidstone (United Kingdom), residing professionally at Château

de Betzdorf, L-6815 Betzdorf (Grand Duchy of Luxembourg).

<i>Second resolution

The general meeting resolves to elect ERNST &amp; YOUNG, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered in the

Trade Register of Luxembourg under number B 47.771 as statutory auditor of the Company for a term to expire at the
annual general meeting called to approve the accounts of the accounting year ended 2007.

<i>Third resolution

In compliance with Article 60 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, the general

meeting of shareholders authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company as well as
the representation of the Company with respect to such management to one of its members.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to fix the address of the Company at L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation or the request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof this notarial deed was drawn up in the office of the undersigned notary, on the date set at the beginning of

this deed.

This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Ont comparu:

1) SES GLOBAL, une société anonyme, ayant son siège social à Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf (R.C.S. Luxem-

bourg B 81.267),

2) SES GLOBAL PARTICIPATIONS, une société anonyme, ayant son siège social à Château de Betzdorf, L-6815

Betzdorf (R.C.S. Luxembourg B 101.799),

toutes les deux représentées par Monsieur Pierre Margue, Vice President Legal and Corporate Affairs SES GLOBAL,

demeurant à Betzdorf, en vertu de procurations données le 27 juillet 2006.

Les procurations, signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné, resteront annexées au pré-

sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

1) SES GLOBAL, pre-qualified, three thousand ninety-nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,099
2) SES GLOBAL PARTICIPATIONS, pre-qualified, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

92349

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent

constituer entre eux.

Art. 1

er

. Dénomination. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SES GLOBAL LATIN AMERI-

CA (la «Société»).

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi à Betzdorf, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique,

social ou militaire, de nature à rendre impossible l’activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou
de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant comme

en matière de modification des statuts.

Art. 4. Objet. La Société a pour objet l’exploitation de satellites ou de systèmes de satellites couvrant l’hémisphère

Ouest et, en particulier, le continent d’Amérique Latine.

Dans le cadre de cet objet, la Société peut acheter et commercialiser des satellites y compris des services de lance-

ment, des engins, des équipements et des services de quelque sorte que ce soit qui sont nécessaires ou utiles pour ses
opérations; elle peut établir, utiliser ou exploiter des stations terrestres mobiles ou fixes qui assurent la poursuite, la
télémesure et la télécommande de ces satellites ainsi que les liaisons de communication avec ceux-ci.

La Société pourra en outre exercer, exécuter et promouvoir, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’en-

treprises dans lesquelles elle détient des participations, ou par tous autres moyens, toutes activités d’intermédiaire, de
commissionnaire, de courtier ou d’agent en matière de satellites. Elle peut opérer, physiquement ou électroniquement,
des agences de manipulation ou autres et rendre toutes sortes de services en relation ou en complément aux activités
mentionnées ci-avant.

La Société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises

ou étrangères, par l’achat, la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, certificats d’obligations, reconnais-
sances de dettes, bons et toutes autres valeurs mobilières ainsi que l’administration, le développement et la gestion de
son portefeuille.

La Société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, à condition que les sommes empruntées soient affectées

à la réalisation de l’objet de la Société ou de ses actionnaires, filiales, sociétés associées ou affiliées.

De manière générale, la Société peut assurer toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou immobi-

lières pouvant être utiles à l’accomplissement et le développement de son objet, et dans ce contexte donner ou recevoir
des garanties, émettre tout type d’actions et d’instruments financiers et entrer dans toute sorte de transactions com-
merciales, de «hedging» et de dérivées.

Art. 5. Capital Social. La Société a un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois

mille cent (3.100) actions ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.

Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des

actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Forme des actions. Toutes les actions de la Société seront uniquement émises sous forme nominative.

Toutes les actions émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou plu-
sieurs personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d’actions,
son domicile, ainsi que le nombre d’actions qu’il détient.

Le droit de propriété de l’actionnaire sur les actions s’établit par l’inscription de son nom dans le registre des action-

naires. Un certificat constatant cette inscription sera délivré sur demande à l’actionnaire. Ce certificat devra être signé
par deux membres du conseil d’administration. Les signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit sous
forme télécopiée.

Tout transfert d’actions sera inscrit au registre des actionnaires au moyen de la remise à la Société d’un instrument

de transfert convenant à la Société, ou par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des actionnaires, datée
et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet, et, à chaque fois, avec
la remise à la Société du certificat d’actions qui s’y rapporte, s’il en a été émis. Une pareille inscription devra être signée
par deux membres du conseil d’administration, ou par une ou plusieurs autres personnes dûment autorisées à cet effet
par le conseil d’administration.

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront

être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.

Au cas où un actionnaire ne fournit pas d’adresse à la Société, la Société sera autorisée à en faire mention au registre

des actionnaires, et l’adresse de l’actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse ins-
crite au registre des actionnaires jusqu’à ce qu’une autre adresse soit communiquée à la Société par l’actionnaire. Un
actionnaire pourra, à tout moment, faire changer l’adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite,
envoyée au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci.

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues

ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, les personnes invoquant un droit sur la/

92350

les action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l’égard de la Société. L’omission
d’une telle désignation impliquera la suspension de l’exercice de tous les droits attachés aux action(s).

Art. 7. Conseil d’Administration. La Société est gérée par un conseil d’administration composé d’un minimum

de trois membres, le nombre exact étant déterminé par l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs n’ont
pas besoin d’être actionnaires. 

Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans

et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par
décision de l’assemblée générale. Les administrateurs sortants peuvent être réélus. Au cas où le poste d’un administra-
teur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants élus par l’assemblée
générale des actionnaires pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions attachées au poste
devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Art. 8. Réunions du Conseil d’Administration. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un pré-

sident et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n’a pas
besoin d’être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’admi-
nistration ou d’exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le conseil d’ad-
ministration. Le président préside les réunions du conseil d’administration. En l’absence du président, les membres du
conseil d’administration peuvent désigner un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore, par un vote
à la majorité des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans

l’avis de convocation. La ou les personnes convoquant l’assemblée déterminent l’ordre du jour. Un avis par écrit, télé-
gramme, télécopie ou e-mail contenant l’ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant
l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas l’avis de convocation, envoyé vingt-quatre heures avant
la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation
en cas d’assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque admi-
nistrateur. Une convocation spéciale n’est pas requise pour des réunions du conseil d’administration se tenant à des
heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre

administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents

ou représentés à une réunion du conseil d’administration. Si le quorum n’est pas obtenu une demi-heure après l’heure
prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ul-
térieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du conseil d’administration par le secrétaire, s’il y
en a, ou à défaut par tout administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au

cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution,
le président de la réunion n’aura pas de voix prépondérante. En cas d’égalité, la résolution sera considérée comme re-
jetée.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d’administration au moyen d’une conférence télé-

phonique ou d’un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peu-
vent s’entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par

voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les mem-
bres du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision est celle de la dernière signature.

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux des réunions du con-

seil d’administration sont signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la
présidence de cette réunion.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou ailleurs seront signés par

le président ou par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration.  Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réu-

nions du conseil d’administration régulièrement convoquées, ou par confirmation écrite conformément à l’article 8 ci-
dessus. 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer les actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressé-
ment à l’assemblée générale sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11. Signature sociale. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de

deux administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil
pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 12. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer de manière générale ou ponctuelle-

ment la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, con-
formément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, à un
directeur ou à un ou plusieurs comités, qu’ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs
administrateurs, gérants ou autres mandataires susceptibles d’agir seuls ou conjointement. La délégation à un membre
du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Le conseil d’administra-

92351

tion détermine l’étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pou-
voir, y compris le pouvoir de subdéléguer.

Le conseil pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représentants de son

choix. 

Art. 13. Conflits d’Intérêt. Dans le cas d’un conflit d’intérêt d’un administrateur, étant entendu que le simple fait

que l’administrateur soit l’administrateur d’un actionnaire ou d’une société affiliée d’un actionnaire ne sera pas constitutif
d’un conflit d’intérêt, il doit informer le conseil d’administration de tout conflit d’intérêt et ne pourra pas prendre part
au vote mais sera compté dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d’intérêt sur tout objet de l’ordre du jour
doit déclarer ce conflit d’intérêt au président avant que la réunion ne débute.

Tout administrateur ayant dans une transaction soumise pour approbation au conseil d’administration un intérêt per-

sonnel opposé à l’intérêt de la Société, sera obligé d’informer le conseil et de faire enregistrer cette situation dans le
procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion, mais il sera compté dans le quorum. A l’assem-
blée générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être fait sur toutes transactions
dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société. 

Art. 14. Assemblée Générale des Actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires représente l’universalité

des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes
relatifs aux opérations de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d’administration. Les actionnaires représentant

un cinquième du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée, requérir le conseil d’administration de convoquer l’assemblée générale
des actionnaires.

L’assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, le dernier mercredi du mois de mars à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable bancaire

suivant.

D’autres assemblées générales d’actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation

respectifs.

Les assemblées générales seront convoquées par un avis de convocation énonçant l’ordre du jour et envoyé par lettre

recommandée au moins huit jours avant l’assemblée à tout détenteur d’actions à son adresse portée au registre des
actionnaires, ou suivant toutes autres instructions données par cet actionnaire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l’ordre du

jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir

prendre part aux assemblées générales.

L’assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera l’assemblée. Le président pourra désigner

un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l’assemblée.

Les affaires traitées lors d’une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l’ordre du jour

(qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.

Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à

toute assemblée générale des actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n’a pas besoin d’être actionnaire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires

sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Art. 15. Surveillance de la société. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commis-

saires aux comptes. Le(s) commissaire(s) aux comptes est (sont) désignés et révoqués par l’assemblée générale des ac-
tionnaires. La durée de leur fonction ne peut excéder six (6) ans.

Art. 16. Exercice Social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se ter-

mine le trente et un décembre de la même année.

Art. 17. Affectation des Bénéfices Annuels. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront

affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d’être exigée lorsque le montant de la réserve légale
aura atteint un dixième du capital social souscrit.

L’assemblée générale des actionnaires dispose librement du bénéfice net annuel.
Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 18. Dissolution de la Société. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’opérera par un ou plusieurs

liquidateurs, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires, nommé(s) par l’assemblée générale des actionnaires qui détermi-
nera les pouvoirs et rémunérations de chaque liquidateur. Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liqui-
dateur(s) aux actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social. Article 19. Modifications des
Statuts. 

Les présents statuts pourront être modifiés périodiquement par une assemblée générale des actionnaires statuant

aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée.

Art. 20. Loi Applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

92352

Art. 21. Langue. Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivis d’une version française. En cas de divergence

entre les deux textes, la version anglaise prévaudra.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2008.

<i>Souscription

Les actions sont souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ EUR 3.000,-.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, l’assem-
blée générale a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nombre d’administrateurs à 3 personnes et d’élire les personnes suivantes au

conseil d’administration pour une période expirant à l’assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de
l’exercice social de l’année 2007:

- M. Romain Bausch, Président, né le 3 juillet 1953 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant pro-

fessionnellement au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf (Grand-Duché de Luxembourg); 

- M. Robert Bednarek, Administrateur, né le 6 octobre 1957 à New York (Etats-Unis), demeurant professionnelle-

ment au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf (Grand-Duché de Luxembourg);

- M. Mark Rigolle, Administrateur, né le 11 avril 1965 à Maidstone (Grande-Bretagne), demeurant professionnelle-

ment au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf (Grand-Duché de Luxembourg).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer ERNST &amp; YOUNG, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771 comme commissaire de la Société
pour une période devant expirer à l’assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l’exercice social
de l’année 2007.

<i>Troisième résolution

Conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’as-

semblée générale des actionnaires autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi
que la représentation de la Société en relation avec cette gestion à l’un de ses membres.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de fixer l’adresse du siège social de la Société à L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Margue, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, vol. 154S, fol. 88, case 2. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(088062.3/200/505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

1) SES GLOBAL, préqualifiée, trois mille quatre-vingt dix-neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2) SES GLOBAL PARTICIPATIONS, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

Luxembourg, le 16 août 2006.

F. Baden.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Castel S.A.

Castel S.A.

TS Koenigsallee Fixtures, S.à r.l.

TS Koenigsallee Fixtures, S.à r.l.

Pamplona PE Holdco 4 S.A.

Intervalor S.A.

Intervalor S.A.

Lux Euro-Asian Investments III

Aerospace Services S.A.

Globavia S.A.

Aero Ré

Berkshire S.A.

Perseus I

Sonae Re S.A.

Glarksdale Marine Investment Corporation, S.à r.l.

Theisen &amp; Schmitz, S.à r.l.

Theisen &amp; Schmitz, S.à r.l.

Fratelli S.A.

Reimerwé, S.à r.l.

Reimerwé, S.à r.l.

North Star Participations S.A.

Antlia S.A.

Boissonot Finance S.A.

H20 Land, S.à r.l.

Thalweg Holding S.A.

Lerins Holding S.A.

Novares International S.A.

Bonus S.A.

SES Global Latin America