logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

49057

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1023

26 mai 2006

S O M M A I R E

24 Sport Village -  Società  Immobiliare  S.A.,  Lu- 

GSS III Partners SNFH, S.à r.l., Senningerberg. . . 

49077

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49104

GSS III Partners  Wuppertal,  S.à r.l.,  Senninger- 

AGN - Horsburgh & Co, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

49086

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49079

AGN - Horsburgh & Co, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

49086

Hansen, S.à r.l., Koerich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49084

Alsterkrugchaussee   Immobilien   A.G.,   Luxem- 

Harmonie Eischen, A.s.b.l., Eischen . . . . . . . . . . . . 

49096

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49089

Heim S.A., Lellig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49092

Arde, S.à r.l., Beckerich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49064

Iaba S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49079

Avenches, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

49065

Immo-Sûre, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . 

49086

Balance d’Or, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

49083

Impulse S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49058

Beethovenstrasse Immobilien A.G., Luxembourg .

49092

Impulse S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49058

Belano Holding S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49099

Impulse S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49058

Blittersdorf Immobilien A.G., Luxembourg  . . . . . .

49092

Infopatient S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49083

Boissons Heintz S.A., Hosingen  . . . . . . . . . . . . . . . .

49058

Infopatient S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49083

Boissons Heintz S.A., Hosingen  . . . . . . . . . . . . . . . .

49058

James Browning Participations S.A., Luxemburg . 

49093

BRE/Sweden 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

49066

JER Bishopsgate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

49062

CommCapital, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

49064

JER Bishopsgate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

49062

Data One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49095

JER Europe Fund III Bishopsgate,  S.à r.l.,  Luxem- 

Dexia World Alternative, Sicav, Luxembourg  . . . .

49103

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49089

E.I.I.G. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49086

JER Europe Fund III Bishopsgate,  S.à r.l.,  Luxem- 

Electricité Thewes, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . .

49083

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49092

Entversalux, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . .

49084

Lybra Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

49064

Eurohaus Immobilien A.G., Luxembourg  . . . . . . . .

49095

Management  Technologie  Development Holding 

Europa South, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

49077

S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49079

Exit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49089

Matrox Holding A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

49085

Fasanenhof Immobilien A.G., Luxembourg. . . . . . .

49095

Matrox Holding A.G., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . 

49084

Fidji Luxco (BC) S.C.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . .

49087

Mediagenf, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

49065

Fidji Luxco (BC) S.C.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . .

49088

Meis John, S.à r.l., Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49089

Foncilux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49080

Mercante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49086

Fondation Aide Populaire d’Urgence, A.s.b.l.,  Lu- 

Mercante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49086

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49059

Metal Cad Concept S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . 

49065

Galatea Lux Two, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

49080

Motor Center Angelsberg S.A., Dudelange . . . . . . 

49061

Gallaher  Luxembourg  Overseas Finance, S.à r.l., 

Mulix, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49079

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49099

OCM/Nordenia  Luxembourg  GP   S.A.,   Luxem- 

Gallaher  Luxembourg  Overseas  Finance, S.à r.l., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49066

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49103

Parc du Rhône, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

49064

Gilux S.A., Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49059

Projectswiss, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

49065

Gilux S.A., Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49059

Raffalux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49104

Grosvenor  Crescent  Developments  Finance, S.à 

Raffalux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49104

r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49062

Somlux A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49064

Grosvenor Crescent Developments JV, S.à r.l., Lu- 

Vantico International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

49062

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49065

Vincera S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49080

Grosvenor  Crescent  Developments,  S.à r.l.,  Lu- 

Votre Jardin, S.à r.l., Dommeldange. . . . . . . . . . . . 

49104

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49062

Wallerich-Lux S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . 

49083

GSS III Partners Duisberg, S.à r.l., Senningerberg .

49077

49058

BOISSONS HEINTZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, Zone Industrielle Op der Hei.

R. C. Luxembourg B 92.581. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 1

<i>er

<i> juillet 2005

Il a été décidé, entre autres,
1. de renouveler pour le terme d’un an le mandat du Réviseur d’Entreprises, Monsieur Alain Kohnen, 144, route de

Stavelot à L-9991 Weiswampach. Son nouveau mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 20 décembre 2005.

Enregistré à Diekirch, le 21 décembre 2005, réf. DSO-BL00316. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900081.3/667/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2006.

BOISSONS HEINTZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, Zone Industrielle Op der Hei.

R. C. Luxembourg B 92.581. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 21 décembre 2005, réf. DSO-BL00367, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hosingen, le 9 janvier 2006.

(900080.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2006.

IMPULSE, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.083. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01018, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023789/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

IMPULSE, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.083. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01020, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023791/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

IMPULSE, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.083. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01022, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023793/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

<i>Pour BOISSONS HEINTZ S.A., Société Anonyme
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 10 mars 2006.

Signature.

Luxembourg, le 10 mars 2006.

Signature.

Luxembourg, le 10 mars 2006.

Signature.

49059

GILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 46, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 91.771. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2005

Il a été décidé, entre autres, de confirmer le mandat du Commissaire actuellement en fonction, soit la société à res-

ponsabilité limitée FIDUNORD, S.à r.l., anciennement FN-SERVICES, S.à r.l., et dont la dénomination a été changée en
date du 29 janvier 2004, avec siège social au 144, route de Stavelot à L-9991 Weiswampach. 

Le mandat du Commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 20 décembre 2005.

Enregistré à Diekirch, le 21 décembre 2005, réf. DSO-BL00318. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900083.3/667/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2006.

GILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 46, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 91.771. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 21 décembre 2005, réf. DSO-BL00368, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Heinerscheid, le 9 janvier 2006.

(900082.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2006.

FONDATION AIDE POPULAIRE D’URGENCE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

<i>ACTIF

<i>PASSIF

<i>Pour GILUX S.A., Société Anonyme
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

31/12/2005

31/12/2004

EUR

EUR

B.

Frais d’Etablissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

Frais d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

586,02

586,02

Amort. des frais d’établissements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-586,02

-586,02

D.

Actif circulant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617.446,25

657.063,15

I.

Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.616,44

12.616,44

II. Valeurs mobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555.710,69

597.715,45

III. Avoirs en banque, avoirs en compte chèques postaux, chèques et encaisse . . . . 54.119,12

46.731,26

Avoir en banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.100,74

42.079,26

CCP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.018,38

4.652,00

IV. Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

F. 

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.069,30

120.465,00

Total de l’actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665.515,55

777.528,15

31/12/2005

31/12/2004

EUR

EUR

A.

Capitaux propres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-432.140,52

-311.675,52

I.

Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148.736,11

-148.736,11

V. Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-580.876,63

-460.411,63

C.

Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.081.252,0

7

1.081.252,07

D.

Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.404,00

7.951,60

II. Autres dettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.404,00

7.951,60

E.

Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.404,00

7.951,60

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665.515,55

777.528,15

49060

<i>CHARGES

<i>PRODUITS

<i> PROJET DE BUDGET 2006 

31/12/2005

31/12/2004

EUR

EUR

1.

Corrections de valeurs sur élément d’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

0

Corrections de valeur sur frais d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

0

.

Dotations aux cor. de val. sur actifs circulants   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

0

2.

Intérêts et charges assimilées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.914, 42.

14.102,41

Droits de garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

498,92

590,48

Différence de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.609, 50

12.644, 90

Frais de banque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

806,00

867,03

Autres charges financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 0

 0

3. 

Autres charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127. 775,32

157.236 68

Frais d’imprimerie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

187,43

495,62

Commissions de domiciliation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.783, 00

7.071, 86

Commissions de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.410,33

2.861,67

Frais de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

2.441,00

Mission d’expertise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.890, 00

1.800, 00

Frais de secrétariat social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

565,60

526,40

Frais de publication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

0

Autres frais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.086,48

998,51

Remboursement de frais   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

446,00

 3.508, 22

Moins-values sur réalisation d’actifs circulants   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.153,57

24.302,39

Reprise sur intérêts sur obligations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.616,44

7.595,63

Rémunération du personnel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17.483, 68

17.187, 53

Impôts sur salaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

177,10

Charges de sécurité sociale et de prévoyance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.501, 87

13.378, 88

Vério France S.A.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

1.615,60

Assurances Mutualiste   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

149,00

0

Dons effectués   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62.546,92

73.276,39

Profit de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

0

Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133.689,74

171.339,21

31/12/2005

31/12/2004

EUR

EUR

2.

Produits provenant de l’actif circulant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50.574,21

50.574,21

Plus-values sur réalisation de val. mobilières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64.030,64

27.095,13

Différence de change   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.410,52

3243,07

Autres produits financiers   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

323,92

689,57

Intérêts sur obligations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17.860,36

17.546,44

Commission Mission d’expertise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.995, 00

1.900, 00

3.

Produits exceptionnels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

300,00

Perte de la période  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -48.069,30

-120.465 000

Total des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133.689,74

77171.339,21

Soutien à l’association «EDUCE» (Mexique) pour:
- le projet «programme de formation»
- le projet «miel médicinal»
- le projet «plantes ornementales»

à hauteur de EUR 13.108,10

Soutien à l’association CASDE «Centro de Apoyo Solidario Documentation y Estudio
AC» (Mexique) pour:
l’aide aux enfants victimes de violences familiales»
- une «mission d’expertise» et d’évaluation des projets conduits depuis 1996 et projetés
pour les années à venir
- la mise en place de «mesures immédiates»

à hauteur de EUR 22.555,06

Soutien à l’association Iraqi Al Amal,

à hauteur de EUR

4.208, 60

Soutien à l’association «Secours Populaire Libanais»,

à hauteur de EUR

4.208,60

Soutien à la Cisjordanie a l’institut «HDIP» et à l’«UPMRC» pour:

à hauteur de EUR

8.417,20

- l’aide d’urgence
Soutien à l’association «ISESEC «(Philippines) dans le but de:
- construire les sanitaires d’une école,

49061

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2006, réf. LSO-BN02025. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014355//102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

MOTOR CENTER ANGELSBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3542 Dudelange, 201-203, rue du Parc.

R. C. Luxembourg B 16.724. 

L’an deux mille six, le premier mars.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme MOTOR CENTER ANGELS-

BERG S.A., avec siège social à L-7410 Angelsberg, 1, route de Mersch, constituée suivant acte du notaire instrumentaire
en date du 22 février 1999, publié au Mémorial C numéro 381 du 27 mai 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Albert Engel, directeur de sociétés, demeurant à L-9286

Diekirch, 4, rue Joseph Theis.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Alex Riwers, employé privé, demeurant à L-7650 Heffin-

gen, 14, op der Strooss.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Tom Engel, économiste, demeurant à L-9286 Diekirch, 4, rue Joseph

Theis.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils représentent ont été portés sur une liste

de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les
membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Transfert du siège social de L-7410 Angelsberg, 1, route de Mersch à L-3542 Dudelange, 201-203, rue du Parc.
II. Que l’intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations

d’usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-3542 Dudelange, 201-203, rue du Parc, et

par conséquence de modifier la première phrase du deuxième alinéa de l’article pemier des statuts pour lui donner la
teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Dudelange.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Engel, A. Riwers, T. Engel, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 2 mars 2006, vol. 618, fol. 20, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(023105/234/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

- cimenter le sol d’une école

à hauteur de EUR

1.000,00

Soutien à l’association d’ «Amitié Franco-Vietnamienne» en faveur des victimes de
l’agent orange,

à hauteur de EUR

5.500,00

Aide au projet Cameroun pour:
- le soutien universitaire au «Collectif des Etudiants de Yaoundé»

à hauteur de EUR

5.787,52

- le soutien aux «Femmes en Action Contre la Pauvreté» 

à hauteur de EUR

2.000,00

Diekirch, le 7 mars 2006.

F. Unsen.

49062

VANTICO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 72.960. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 3 mars 2006.

(023429/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

JER BISHOPSGATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. JER EUROPE FUND III BISHOPSGATE, S.à r.l.).

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 114.093. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 41479 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 13 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023455/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

GROSVENOR CRESCENT DEVELOPMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 110.792. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 7 mars 2006.

(023462/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

GROSVENOR CRESCENT DEVELOPMENTS FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 110.791. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 7 mars 2006.

(023463/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

JER BISHOPSGATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. JER EUROPE FUND III BISHOPSGATE, S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 114.093. 

In the year two thousand and six, on the eighth day of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appear:

J.E. ROBERT COMPANY, INC., a company incorporated under the laws of the State of Virginia, United States of

America, having its registered office at c/o C T Corporation System, 7401 Cox Road, Suite 301, Glen Allen, VA, 23060-
6802, United States of America, registered under number 0232682-5 with the Virginia Registrar of Companies,

duly represented by Laetitia Ambrosi, lawyer, with professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, by

virtue of a proxy given under private seal on February 8, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

H. Hellinckx
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

H. Hellinckx
<i>Notaire

H. Hellinckx
<i>Notaire

49063

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person, represented as stated here above, is the sole shareholder of the private limited liability com-

pany («société à responsabilité limitée») established under the laws of Luxembourg under the name of TARIEL HOLD-
ING, S.à r.l., newly JER EUROPE FUND III BISHOPSGATE, S.à r.l. (the «Company»), with registered office at 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Company Register, incorporated by
virtue of a deed of M

e

 Henri Hellinckx dated January 30, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations and whose articles of association have been amended by virtue of a deed of M

e

 Henri Hellinckx dated

February 7, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The sole shareholder resolves to change the Company’s name into JER BISHOPSGATE, S.à r.l. and to subsequently

amend article 4 of the Company’s bylaws with immediate effect, which will be read as follows: 

«Art. 4. The Company will have the name of JER BISHOPSGATE, S.à r.l.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a

result of the present shareholder meeting are estimated at approximately eight hundred Euro (EUR 800.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le huit février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

J.E. ROBERT COMPANY, INC., une société constituée et régie sous les lois de l’Etat de Virginie, Etats-Unis d’Amé-

rique, ayant son siège social au c/o C T Corporation System, 7401 Cox Road, Suite 301, Glen Allen, VA, 23060-6802,
Etats-Unis d’Amérique, immatriculée sous le numéro 0232682-5 au Registre de Commerce et des Sociétés de Virginie,

dûment représentée par Laetitia Ambrosi, juriste, demeurant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 8 février 2006.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

tant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg et régie par les lois

du Luxembourg sous la dénomination de TARIEL HOLDING, S.à r.l. nouvellement JER EUROPE FUND III BISHOPS-
GATE, S.à r.l., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en cours d’inscription au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte de M

e

 Henri Hellinckx reçu en date du 30 janvier 2006,

non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
de M

e

 Henri Hellinckx reçu en date du 7 février 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations.

II. L’associé unique décide de changer la dénomination de la Société en JER BISHOPSGATE, S.à r.l. et de modifier en

conséquence l’article 4 des statuts de la Société comme suit, avec effet immédiat

«Art. 4. La Société aura la dénomination JER BISHOPSGATE, S.à r.l.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de ladite comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Ambrosi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2006, vol. 27CS, fol. 51, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023438/211/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

Luxembourg, le 2 mars 2006.

J. Elvinger.

49064

CommCapital, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 106.053. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 7 mars 2006.

(023464/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

LYBRA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 104.059. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 7 mars 2006.

(023466/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

ARDE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8523 Beckerich, 9, Reidenerwee.

R. C. Luxembourg B 42.866. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 7 mars 2006.

(023470/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

PARC DU RHONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.928. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 7 mars 2006.

(023472/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

SOMLUX A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 81.056. 

Le bilan au 31 décembre 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02254, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

(023883/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

H. Hellinckx
<i>Notaire

H. Hellinckx
<i>Notaire

H. Hellinckx
<i>Notaire

H. Hellinckx
<i>Notaire

SOMLUX A.G.
<i>Le conseil d’administration
Signatures

49065

MEDIAGENF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.934. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 7 mars 2006.

(023473/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

AVENCHES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.927. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 7 mars 2006.

(023474/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

PROJECTSWISS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.932. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 7 mars 2006.

(023477/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

GROSVENOR CRESCENT DEVELOPMENTS JV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 110.793. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 7 mars 2006.

(023480/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

METAL CAD CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3429 Dudelange, 147, route de Burange.

R. C. Luxembourg B 87.078. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02386, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2006.

(023928//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

H. Hellinckx
<i>Notaire

H. Hellinckx
<i>Notaire

H. Hellinckx
<i>Notaire

H. Hellinckx
<i>Notaire

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE ACCURA S.A. 
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

49066

BRE/SWEDEN 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 102.008. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 7 mars 2006.

(023484/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

OCM / NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 114.639. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-first day of February.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND III, LP, a Delaware limited partnership having its registered office at

Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, United States,
registered with the Delaware Secretary of State under number 3725285,

duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Los Angeles on 20 February 2006;
2) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND IIIA, LP, a Delaware limited partnership having its registered office at

Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, United States,
registered with the Delaware Secretary of State under number 3794755,

duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Los Angeles on 20 February 2006;
3) OCM EUROPEAN PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND, L.P., an exempted limited partnership organized under

the laws of the Cayman Islands, having its registered address at Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908 GT,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

duly represented by Mr Carsten Opitz, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Los Angeles on 20 February 2006; and
4) OCM OPPORTUNITIES FUND VI, LP, a Delaware limited partnership having its registered office at Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, United States, registered with
the Delaware Secretary of State under number 3982314,

duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given Los Angeles on 20 February 2006.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain

attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of association

of a société anonyme, which they declare organised among themselves as follows:

Chapter I. - Name, Duration, Purpose, Registered office

Art. 1. Name 
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of OCM / NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A.
(the «Company»).

Art. 2. Duration
The company is established for an unlimited period of time.

Art. 3. Purpose
(a) The purpose of the Company is to acquire and hold a participation in OCM / NORDENIA POF LUXEMBOURG

S.C.A. and in OCM / NORDENIA OPPS LUXEMBOURG S.C.A., each a société en commandite par actions duly incor-
porated and existing under the laws of Luxembourg, and to act as the manager, general partner and shareholder of each
of OCM / NORDENIA POF LUXEMBOURG S.C.A. and OCM / NORDENIA OPPS LUXEMBOURG with unlimited li-
ability.

(b) The Company may further hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg and foreign compa-

nies and may participate in any other form of investment, including the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration,
voting and control of any such participations.

(c) The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

H. Hellinckx
<i>Notaire

49067

(d) The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-

plishment of its purpose.

Art. 4. Registered office
(a) The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered

office may be transferred within the same municipality by decision of the board of directors.

(b) Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of

directors.

(c) In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.

Chapter II. - Share capital, Shares

Art. 5. Subscribed Capital
(a) The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) consisting of twenty-four thousand eight

hundred (24,800) shares having a par value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each.

(b) The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted

in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

(c) The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. Authorized Capital
(a) In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which is fixed at two hundred thou-

sand Euro (EUR 200,000.-) represented by additional one hundred sixty thousand (160,000) shares having a par value
of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each.

(b) During the period of five years, from the date of the publication of these articles of association, the directors are

hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as
they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential
right to subscribe to the issued shares.

(c) The authorised capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted

in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

(d) The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 7. Shares and Shareholder Register
(a) The shares of the company are in registered form.
(b) A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by registration in the said register.
Certificates of such registration shall be issued and signed by three directors.

(c) The Company will recognize only one holder per share. In the event that a share is held by more than one person,

the persons claiming ownership of such share shall be required to appoint one sole proxy to represent such share in
relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such share until
one person has been designated as the sole owner in relation to the Company.

(d) The transfer of shares will be carried by a declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated

and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfer of shares may also be carried
out in accordance with the rules on the transfer of claims set out in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Fur-
thermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

Chapter III. - General meetings of shareholders

Art. 8. Powers of the meeting of Shareholders  
Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of shareholders of

the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the com-
pany.

Art. 9. Convening and Adjourning General Meetings
(a) The general meeting is convened by the board of directors. It shall also be convened upon request in writing of

shareholders representing at least one fifth of the Company’s share capital. If all of the shareholders are present or rep-
resented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been duly informed of the agenda of the meeting,
the meeting may be held without prior notice or publication.

(b) The quorum and time-limits required by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings

of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

(c) The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

Art. 10. General Annual Meeting
The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or

at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on 4 April each year at 10:00 a.m. If

49068

such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings
of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Art. 11. Vote
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile. Except as otherwise required by law, resolutions at a
meeting of shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the shareholders present or represented.

Chapter IV. - Board of directors

Art. 12. Powers of the board of directors
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors.

Art. 13. Management of the Company
(a) According to article 60 of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the daily management of the

Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or
more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their nomination, rev-
ocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the
board of directors is subject to prior authorisation of the general meeting of shareholders.

(b) The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 14. Composition of the Board
(a) The Company shall be managed by a board of directors composed of at least five (5) members who need not be

shareholders of the Company.

(b) The board of directors should choose from among its members a chairman, and may choose from among its mem-

bers a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keep-
ing the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. 

Art. 15. Meetings of the Board of Directors
(a) The board of directors shall meet upon call by the chairman, or three directors, at the place indicated in the notice

of meeting.

(b) A quorum of the board of directors shall be the presence or the representation of a majority of the directors

holding office.

(c) The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the

shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

(d) Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors at least three days in advance

of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. Notice shall be made by mail, fax or e-mail to the address last given to the
secretary of the board of directors and shall contain, inter alia, the place, date and time of the meeting and an agenda
identifying in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting. This notice may be omitted in case of assent
of each director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special
convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior res-
olution adopted by the board of directors.

(e) Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing another director as his

proxy, a copy of such writing being sufficient. A director may represent one or more of his colleagues.

(f) Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication initiated in the Grand Duchy of Luxembourg and allowing all persons participating at such meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meet-
ing.

(g) Meetings of the board of directors may also be held by conference-call, video conference or by any other tele-

communication means initiated in the Grand Duchy of Luxembourg and allowing all persons participating at such meet-
ing to hear one another.

Art. 16. Minutes
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by (i) the chairman or, in his absence, by the

vice-chairman, or (ii) by three directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by three directors.

Art. 17. Vote and Resolutions
(a) Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at a meeting at which a quorum

is present or represented.

(b) The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writ-

ing, a copy of such writing being sufficient. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the res-
olution. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same
content and each of them signed by one or several directors.

49069

Art. 18. Election of Board Members
The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, which shall determine their

number, remuneration and term of office. The directors are elected by a simple majority vote of the shares present of
represented.

Art. 19. Term of Board Members
The term of the office of a director may not exceed two years and the directors shall hold office until their successors

are elected. Former and current directors are eligible for re-election.

Art. 20. Removal of Board Members
Any director may be removed without cause by the general meeting of shareholders.

Art. 21. Vacancy
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders, in compliance
with applicable legal provisions.

Art. 22. Dealings with Third Parties
The Company will be bound to third parties by (i) the joint signatures of any three of the directors or (ii) the sole

signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 23. Director or Officer Interests
(a) No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be effected or in-

validated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal interest in, or is
a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter,
any director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm
with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such con-
tract or other business.

(b) Notwithstanding the above paragraph, in the event that any director or officer of the Company may have any

personal interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the board of directors such
personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director’s or
officer’s interest therein shall be reported to the shareholders in the next general meeting.

Art. 24. Indemnity
(a) The directors do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regu-

larly made by them in the name of the Company. Directors are authorised agents only and are therefore merely re-
sponsible for the execution of their mandate.

(b) The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the
Company is a shareholder or a creditor and from which he shall not be entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or miscon-
duct; in the event of settlement, indemnification shall only be provided in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit a breach
of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

(c) The Company shall pay the expenses incurred by any person indemnifiable hereunder in connection with any pro-

ceeding in advance of the final disposition, so long as the Company receives a written undertaking by such person to
repay the full amount advanced if there is a final determination that such person is not entitled to indemnification for
other reasons. The termination of any action, suit or proceeding by judgment, order, settlement, conviction, or a plea
of nolo contendere or its equivalent, shall not of itself, create a presumption that the indemnifiable person did not satisfy
the standard of conduct entitling him or her to indemnification hereunder. The Company shall make a cash payment to
such indemnifiable person equal to the full amount to be indemnified promptly upon notification of an obligation to in-
demnify from the indemnifiable person.

Art. 25. Expenses
Upon presentation of the relevant receipts, the Company shall reimburse any reasonable expenses incurred by the

members of the board of directors to attend the meeting of the board of directors.

Chapter V. - Supervision of the company

Art. 26. Statutory Auditor(s)
(a) The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors, which may be shareholders

or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s), and shall determine their number,
remuneration and term of office, which may not exceed six years. Former and current statutory auditors are eligible
for re-election.

(b) Any statutory auditor may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
(c) If the Company exceeds the criteria set by article 215 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as

amended, the institution of statutory auditor will be suppressed and one or more independent auditors, chosen among
the members of the institut des réviseurs d’entreprises will be designated by the general meeting, which fixes the dura-
tion of their office. 

49070

Chapter VI. - Financial year, Profits

Art. 27. Financial Year
The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on December thirty-

first.

Art. 28. Profits
(a) From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allo-

cation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company, as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in Article
5 hereof.

(b) The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the

remainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed in compliance with the
terms and conditions provided for by law.

Chapter VII. - Liquidation

Art. 29. Liquidation
In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who

may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

Chapter VIII. - Amendment of the articles of association

Art. 30. Amendment to the Articles
These Articles may be amended by a majority of at least two-thirds of the votes of the shareholders of the Company

at a general meeting of the shareholders at which at least 50% of the capital of the Company is represented in person
or by proxy. In the event that the foregoing quorum requirement is not satisfied, these Articles may be amended by a
majority of at least two-thirds of the votes of the shareholders of the Company at a second general meeting of the share-
holders with respect to which no quorum requirement shall apply.

Chapter IX. - Final clause, Applicable law

Art. 31. Governing Law
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg

law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31 De-

cember 2006.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2006. 

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows: 

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) is as of now

available to the company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been
fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately five thousand (5,000.-) Euro.

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at five (5) and the number of statutory auditor at one (1).

1) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND III, LP, pre-named,
paid eleven thousand four hundred seven Euro and fifty cents (EUR 11,407.50) in subscription for nine thou-

sand one hundred twenty-six shares; and  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,126

2) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND IIIA, LP, pre-named,
paid two hundred seventeen Euro and fifty cents (EUR 217.50) in subscription for one hundred seventy-

four shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174

3) OCM EUROPEAN PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND, LP, pre-named,
paid seven thousand seven hundred fifty Euro (EUR 7,750.-) in subscription for six thousand two hundred

shares; and. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,200

4) OCM OPPORTUNITIES FUND VI, LP, pre-named,
paid eleven thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 11,625.-) in subscription for nine thousand three

hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,300

Total: thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) paid for twenty-four thousand eight hundred shares . . . . .

24,800

49071

2. The following persons are appointed as directors of the Company:
- Mr Justin Bickle, with professional address at 31st Floor, Citypoint, 4, Ropemaker Street, London EC2Y 9AW, Unit-

ed Kingdom, born on 11 January 1971, in Plymouth, United Kingdom;

- Mr Caleb Kramer, with professional address at 31st Floor, Citypoint, 4, Ropemaker Street, London EC2Y 9AW,

United Kingdom, born on 17 June 1969, in Washington DC, United States of America; and

- Jean Fell, expert-comptable, born on 9 April 1956 in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, with professional

address at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Cornelius Martin Bechtel, conseil, born on 11 March 1968 in Emmerich, Germany, with professional address at 67,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Szymon Dec, conseil, born on 3 July 1978 in Lodz, Poland, with professional address at 67, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. The following entity is appointed as statutory auditor of the Company: 
ERNST &amp; YOUNG Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4. The address of the company is set at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the annual general meeting called to

approve the accounts as of 31 December 2007.

6. The general meeting, according to article 60 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,

authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the
Company in relation with this management to any of its members.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholders

of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request
of the same proxyholder and in case of divergences between the English and the German text, the English version will
be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the said persons appearing signed

together with the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahr zweitausendundsechs, den einundzwanzigsten Februar.
Sind vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

 Erschienen:

1) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND III, LP, eine Gesellschaft Delaware Rechts mit Geschäftsadresse in

Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, USA, eingetragen
Delaware Secretary of State unter der Nummer 3725285,

vertreten durch Herrn Carsten Opitz, «maître en droit», wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Los Angeles am 20. Februar 2006;
2) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND IIIA, LP, eine Gesellschaft Delaware Rechts mit Geschäftsadresse in

Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, USA, eingetragen
Delaware Secretary of State unter der Nummer 3794755,

vertreten durch Herrn Carsten Opitz, «maître en droit», wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Los Angeles am 20. Februar 2006;
3) OCM EUROPEAN PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND, L.P., eine Gesellschaft Cayman Islands Rechts mit Ge-

schäftsadresse in Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

vertreten durch Herrn Carsten Opitz, «maître en droit», wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Los Angeles am 20. Februar 2006; und
4) OCM OPPORTUNITIES FUND VI, LP, eine Gesellschaft Delaware Rechts mit Geschäftsadresse in Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, USA, eingetragen Delaware
Secretary of State unter der Nummer 3982314,

vertreten durch Herrn Carsten Opitz, «maître en droit», wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Los Angeles am 20. Februar 2006.
Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten

Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den Notar die folgende Gründungsurkunde einer Aktiengesellschaft, deren Gründung sie

hiermit erklären, auszustellen:

Kapitel I. - Name, Dauer, Zweck, Eingetragener Sitz

Art. 1. Name
Hiermit wird zwischen den Unterzeichnern und allen, die Eigentümer der später ausgegebenen Aktien werden kön-

nen, eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) unter dem Namen OCM / NORDENIA
LUXEMBOURG GP S.A. (die «Gesellschaft») gegründet.

Art. 2. Dauer
Die Gesellschaft wird auf unbefristete Zeit gegründet.

49072

Art. 3. Zweck
(a) Der Zweck der Gesellschaft ist es, Beteiligungen an der OCM / NORDENIA POF LUXEMBOURG S.C.A. und der

OCM / NORDENIA OPPS LUXEMBOURG S.C.A., beides Kommanditgesellschaften auf Aktien (société en commandite
par actions), wirksam gegründet und existierend nach luxemburgischem Recht, zu erwerben und zu halten, und als Ver-
walter, Komplementär und Gesellschafter mit unbeschränkter Haftung der OCM / NORDENIA POF LUXEMBOURG
S.C.A. und der OCM / NORDENIA OPPS LUXEMBOURG zu handeln.

(b) Die Gesellschaft kann weitere Beteiligungen jeder Form an anderen luxemburgischen und ausländischen Gesell-

schaften halten und sich an jeder weiteren Investitionsart beteiligen, einschließlich des Erwerbs durch Kauf, Zeichnung
oder in irgendeiner anderen Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch von Wertpapieren jeder Art, und der
Verwaltung, Wahl und Kontrolle solcher Beteiligungen.

(c) Im Übrigen kann die Gesellschaft Garantien und Darlehen gewähren oder die Gesellschaften, an denen sie eine

direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die Teil der gleichen Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft selbst ist,
in anderer Form unterstützen.

(d) Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, betrieblichen oder finanziellen Tätigkeiten betreiben, die sie zur Durch-

führung ihres Unternehmensgegenstandes für nützlich erachtet.

Art. 4. Eingetragener Sitz
(a) Der eingetragene Sitz der Gesellschaft wird in Luxemburg, Großherzogtum von Luxemburg, errichtet. Der

eingetragene Sitz kann durch Beschluss des Verwaltungsrates innerhalb desselben Verwaltungsbezirks verlegt werden.

(b) Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen oder andere Geschäftssitze entweder in Luxem-

burg oder im Ausland errichtet werden.

(c) Im Falle, dass der Verwaltungsrat feststellt, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwick-

lungen eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft in ihrem eingetra-
genen Sitz oder die unbeschwerte Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland stören würden, kann
der eingetragene Sitz bis zur vollständigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland
verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen wirken sich jedoch nicht auf die Nationalität der Gesellschaft aus,
die trotz der vorübergehenden Verlegung ihres eingetragenen Sitzes weiterhin eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Kapitel II. - Aktienkapital, Aktien

Art. 5. Gezeichnetes Kapital
(a) Das gezeichnete Kapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), bestehend aus vierundzwanzigtausen-

dachthundert (24.800) Aktien mit einem Nennwert von jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25). 

(b) Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden,

der so zu fassen ist, wie es auch für eine Änderung dieser Gründungsurkunde erforderlich ist.

(c) Die Gesellschaft kann in dem Ausmaß und nach Bestimmungen, die das Gesetzt erlaubt, ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.

Art. 6. Genehmigtes Kapital
(a) Zusätzlich zum gezeichneten Kapital besitzt die Gesellschaft ein genehmigtes Kapital, das mit zweihunderttausend

Euro (EUR 200.000,-) festgesetzt ist und durch zusätzliche einhundertsechzigtausend (160.000) Aktien mit einem Nenn-
wert von jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) vertreten wird.

(b) Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden hiermit ermächtigt, während eines Zeitraums von fünf Jahren nach

Veröffentlichung dieser Satzung Aktien zu emittieren und Optionen zur Zeichnung von Aktien an solche Personen und
zu solchen Bedingungen zu gewähren, die sie für geeignet halten und insbesondere dies durchzuführen, ohne den beste-
henden Aktionären ein Vorzugsrecht auf Zeichnung der ausgegebenen Aktien vorzubehalten.

(c) Das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden,

der so zu fassen ist, wie es auch für eine Änderung dieser Gründungsurkunde erforderlich ist.

(d) Die Gesellschaft kann in dem Ausmaß und nach Bestimmungen, die das Gesetz erlaubt, ihre eigenen Aktien zu-

rückkaufen.

Art. 7. Aktien und Aktionärsverzeichnis  
(a) Die Aktien der Gesellschaft werden eingetragen.
(b) Ein Verzeichnis der eingetragenen Aktien wird am eingetragenen Sitz geführt, wo es für jeden Aktionär zur Kon-

trolle ausliegt. Dieses Verzeichnis enthält alle Informationen, die gemäß Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung erforderlich sind. Das Eigentum der eingetragenen Aktien
wird durch Eintragung in dem genannten Verzeichnis begründet. Bescheinigungen über diese Eintragung werden von drei
Mitgliedern des Verwaltungsrates ausgestellt und unterzeichnet.

(c) Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Im Falle, dass eine Aktie von mehr als einer Person ge-

halten wird, sind die Personen, die den Besitz einer solchen Aktie beanspruchen, dazu verpflichtet, einen einzigen Be-
vollmächtigten zu ernennen, der diese Aktie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft hat das Recht, die
Ausübung aller mit einer solchen Aktie verbundenen Rechte auszusetzen, bis eine Person als im Verhältnis zur Gesell-
schaft einziger Eigentümer bestellt wird.

(d) Die Übertragung von Aktien wird durch eine Übertragungserklärung durchgeführt, die in das Verzeichnis der Ak-

tionäre eingetragen und durch den Übertragenden und den Übernehmer oder durch ihre(n) Vertreter datiert und un-
terzeichnet wird. Die Übertragung von Aktien kann auch gemäß den Vorschriften zur Übertragung von Ansprüchen
nach Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzes durchgeführt werden. Außerdem kann die Gesellschaft jede Über-
tragung, auf die in irgendeiner Korrespondenz oder in einem anderen Dokument Bezug genommen wird, das die Zu-

49073

stimmung des Übertragenden und des Übernehmers erkennen lässt, akzeptieren und in das Verzeichnis der Aktionäre
eintragen.

Kapitel III. - Hauptversammlungen der Aktionäre

Art. 8. Befugnisse der Aktionärsversammlung
Jede ordnungsgemäß abgehaltene Aktionärsversammlung der Gesellschaft stellt die Gesamtheit der Aktionäre der

Gesellschaft dar. Sie besitzt die umfassendsten Befugnisse, um Handlungen in Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft
zu verfügen, durchzuführen oder umzusetzen.

Art. 9. Einberufung und Vertagung von Generalversammlungen
(a) Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie wird auch auf schriftlichen Antrag der

Aktionäre einberufen, die mindestens ein Fünftel des Aktienkapitals der Gesellschaft ausmachen. Wenn alle Aktionäre
in einer Aktionärsversammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie angeben, dass sie ordnungsgemäß über die
Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, kann die Versammlung ohne vorherige Mitteilung oder Veröffent-
lichung stattfinden.

(b) Wenn hier nichts anderes bestimmt wird, gelten für die Mitteilungen über die Einberufung und die Durchführung

der Aktionärsversammlungen der Gesellschaft das Quorum und die Fristen, die gesetzlich vorgeschrieben sind.

(c) Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festsetzen, die die Aktionäre erfüllen müssen, damit sie an

einer Aktionärsversammlung teilnehmen.

Art. 10. Jährliche Generalversammlung
Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre findet jedes Jahr am 4. April um 10.00 Uhr morgens in Luxemburg

am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Luxemburg statt, wie es in der Mitteilung über
die Versammlung angegeben sein kann. Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die jährliche Generalver-
sammlung am darauf folgenden Werktag statt. Andere Aktionärsversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit
stattfinden, wie es in den jeweiligen Mitteilungen über die Versammlung angegeben sein kann.

Art. 11. Stimme
Jede Aktie hat das Recht auf eine Stimme. Ein Aktionär kann bei jeder Aktionärsversammlung handeln, indem er eine

andere Person schriftlich, per Telegramm, Telex oder Telefax als seinen Bevollmächtigten ernennt. Wenn durch Gesetz
nicht anders verlangt, werden Beschlüsse in einer ordnungsgemäß zusammengetretenen Aktionärsversammlung mit ein-
facher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Kapitel IV. - Verwaltungsrat

Art. 12. Befugnisse des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat erhält umfassendste Befugnisse, um alle Verwaltungs- und Verfügungsakte im Interesse der

Gesellschaft durchzuführen oder umzusetzen. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch diese
Artikel der Generalversammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Art. 13. Geschäftsführung der Gesellschaft
(a) Gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden

Fassung kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung der Gesellschaft in Bezug auf die
Geschäftsführung an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, Verwalter, Geschäftsführer oder andere
Vertreter übertragen werden, ob sie nun Aktionäre sind oder nicht, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Ihre Ernen-
nung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt. Für die Übertragung
von Befugnissen an ein Mitglied des Verwaltungsrates ist die vorherige Zustimmung der Generalversammlung erforder-
lich.

(b) Die Gesellschaft kann besondere Befugnisse auch durch eine notariell beglaubigte Vollmacht oder ein privatschrift-

liches Dokument einräumen.

Art. 14. Zusammensetzung des Verwaltungsrates  
(a) Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der aus mindestens fünf (5) Mitgliedern besteht, die nicht

Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

(b) Der Verwaltungsrat sollte aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen und kann aus seinen Mitgliedern

einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Er kann auch einen Schriftführer auswählen, der nicht Mitglied des
Verwaltungsrates sein muss, der für die Führung der Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der General-
versammlungen verantwortlich ist.

Art. 15. Sitzungen des Verwaltungsrates
(a) Der Verwaltungsrat tritt nach Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch drei Mitglieder des Verwaltungs-

rates an dem Ort zusammen, der in der Mitteilung über die Sitzung angegeben ist.

(b) Als Quorum des Verwaltungsrates gilt die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und amtierenden Mitglie-

der des Verwaltungsrates.

(c) Der Vorsitzende führt bei allen Generalversammlungen und Sitzungen des Verwaltungsrates den Vorsitz, die

Aktionäre oder der Verwaltungsrat können jedoch in seiner Abwesenheit mit der Mehrheit der in einer solchen Sitzung
anwesenden Stimmen ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates als Vorsitzenden auf Zeit bestellen.

(d) Über die Sitzung des Verwaltungsrates muss mindestens drei Tage vor dem Datum der anberaumten Sitzung eine

schriftliche Benachrichtigung an die Mitglieder des Verwaltungsrates übermittelt werden, außer im Notfall, wobei die
Art und die Gründe der Dringlichkeit in der Benachrichtigung erwähnt sein müssen. Die Benachrichtigung erfolgt durch
Post, Telefax oder e-mail an die zuletzt an den Schriftführer des Verwaltungsrates bekannt gegebene Adresse und hat

49074

unter anderem Ort, Datum und Zeit der Sitzung und die Tagesordnung zu enthalten, die in angemessener Weise aus-
führlich die in der Sitzung zu besprechenden Angelegenheiten enthält. Auf diese Benachrichtigung kann im Falle der
schriftlichen Zustimmung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Telegramm, Telex oder Abschrift oder alle
anderen derartigen oder ähnlichen Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine besondere Mitteilung über die
Einberufung einer Sitzung des Verwaltungsrates ist nicht erforderlich, die zu einer Zeit und an einem Ort abzuhalten ist,
die in einem vorherigen vom Verwaltungsrat gefassten Beschluss festgesetzt wird.

(e) Alle Mitglieder des Verwaltungsrates können in einer Sitzung des Verwaltungsrates auch dadurch handeln, indem

sie ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates als ihre Bevollmächtigten ernennen, wobei eine Kopie eines solchen
Schreibens ausreichend ist. Ein Mitglied des Verwaltungsrates kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.

(f) Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an Sitzungen des Verwaltungsrates über eine Konferenzschaltung oder

andere ähnliche, im Großherzogtum von Luxemburg initiierte Kommunikationsmethoden teilnehmen, bei denen alle
Teilnehmer der Sitzung einander hören können. Die Teilnahme an einer Sitzung über diese Kommunikationswege ist
einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung gleichwertig. 

(g) Sitzungen des Verwaltungsrates können ebenfalls über Konferenzschaltung, Videokonferenz oder durch ähnliche,

im Großherzogtum von Luxemburg initiierte Kommunikationsmethoden teilnehmen, bei denen alle Teilnehmer der
Sitzung einander hören können.

Art. 16. Sitzungsprotokolle
Die Sitzungsprotokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden (i) vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder (ii) von drei Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet. Kopien und Aus-
züge aus diesen Protokollen, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden, müssen vom Vorsitzenden
oder von drei Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet werden.

Art. 17. Abstimmung und Beschlüsse
(a) Beschlüsse werden durch Mehrheitsentscheid der Mitglieder des Verwaltungsrates gefasst, die bei der Sitzung, auf

der eine beschlussfähige Mitgliederanzahl anwesend oder vertreten ist, anwesend oder vertreten sind.

(b) Der Verwaltungsrat kann Beschlüsse einstimmig per Rundschreiben verabschieden, indem die Zustimmung

schriftlich zum Ausdruck gebracht wird. In diesem Falle ist eine Kopie dieses Schreibens ausreichend. Die Gesamtheit
der Schreiben bildet das Protokoll, das die Beschlussfassung dokumentiert. Eine derartige Entscheidung kann in einem
einzelnen Dokument oder in mehreren separaten Dokumenten mit gleichem Inhalt und der Unterschrift eines oder
mehrerer Mitglieder des Verwaltungsrates nachgewiesen werden.

Art. 18. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von den Aktionären auf ihrer jährlichen Generalversammlung gewählt,

die auch ihre Anzahl, ihre Vergütung und ihre Amtszeit festlegt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch ein-
fache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktienanteile gewählt.

Art. 19. Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates
Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates darf zwei Jahre nicht überschreiten. Die Mitglieder des

Verwaltungsrates üben ihr Amt so lange aus, bis ihre Nachfolger gewählt wurden. Ehemalige und gegenwärtige Mitglie-
der des Verwaltungsrates dürfen wiedergewählt werden.

Art. 20. Abwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann ohne Angabe von Gründen von der Generalversammlung der Aktionäre

abgewählt werden.

Art. 21. Unbesetzte Stellen
Wenn die Position eines Mitglieds des Verwaltungsrates durch Tod, Ruhestand oder andere Gründe unbesetzt ist,

können die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates durch Mehrheitsentscheid in Übereinstimmung mit den entspre-
chenden Rechtsvorschriften ein Mitglied des Verwaltungsrates wählen, das diese Position bis zur nächsten Aktionärs-
versammlung einnimmt.

Art. 22. Bindung gegenüber Dritten
Die Gesellschaft wird (i) durch die gemeinsame Unterzeichnung von drei beliebigen Mitgliedern des Verwaltungsrates

oder (ii) durch die alleinige Unterschrift einer beliebigen Person, der vom Verwaltungsrat diese Unterschriftenbefugnis
erteilt wurde, gegenüber Dritten gebunden.

Art. 23. Beteiligungen der Mitglieder des Verwaltungsrates oder Geschäftsführer
(a) Verträge oder andere Geschäfte zwischen dem Unternehmen und einem anderen Unternehmen oder einer an-

deren Firma werden nicht von dem Umstand beeinflusst oder dadurch ungültig gemacht, dass eines oder mehrere der
Mitglieder des Verwaltungsrates oder Geschäftsführer des Unternehmens an diesem anderen Unternehmen oder dieser
anderen Firma beteiligt oder darin Mitglied des Verwaltungsrates, Teilhaber, Geschäftsführer oder Angestellter ist. So-
fern dies nicht im Folgenden anders festgelegt ist, darf kein Mitglied des Verwaltungsrates oder Geschäftsführer des Un-
ternehmens, das/der als Mitglied des Verwaltungsrates, Teilhaber, Geschäftsführer oder Angestellter eines anderen
Unternehmens oder einer anderen Firma tätig ist, mit dem/der das Unternehmen einen Vertrag abschließen oder an-
derweitig Geschäfte tätigen möchte, aufgrund dieser Zugehörigkeit zu diesem anderen Unternehmen von der Planung,
Abstimmung oder Handlung zugunsten eines solchen Vertrages oder Geschäftes abgehalten werden.

(b) Ungeachtet des obigen Abschnitts muss ein Geschäftsführer oder Mitglied des Verwaltungsrates, der/das ein per-

sönliches Interesse an einem Geschäft des Unternehmens hat, dem Verwaltungsrat dieses persönliche Interesse mittei-
len; er darf ein solches Geschäft nicht planen oder darüber abstimmen und dieses Geschäft oder dieses Interesse des

49075

Mitglieds des Verwaltungsrates oder Geschäftsführers daran wird den Aktionären auf ihrer nächsten Generalversamm-
lung mitgeteilt.

Art. 24. Haftungsausschluss
(a) Die Mitglieder des Verwaltungsrates übernehmen aufgrund ihrer Position keine persönliche Haftung bezüglich

Verpflichtungen, die von ihnen ordnungsgemäß im Namen des Unternehmens eingegangen wurden. Die Mitglieder des
Verwaltungsrates sind lediglich bevollmächtigte Vertreter und daher nur für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

(b) Das Unternehmen hält die Mitglieder des Verwaltungsrates oder Geschäftsführer und deren Erben, Testaments-

vollstrecker oder Verwalter gegen Ausgaben schadlos, die durch ihn im Zusammenhang mit Klagen, Verfahren oder Pro-
zessen verursacht werden, an denen er aufgrund seiner (derzeitigen oder ehemaligen) Tätigkeit als Mitglied des
Verwaltungsrates oder Geschäftsführer des Unternehmens oder - auf Antrag des Mitglieds des Verwaltungsrates - eines
anderen Unternehmens beteiligt ist, bei dem das Unternehmen ein Aktionär oder Gläubiger ist und bei dem der Ge-
schäftsführer oder das Mitglied des Verwaltungsrates keinen Anspruch auf Schadloshaltung hat. Eine Ausnahme hiervon
bilden Klagen, Verfahren oder Prozesse, in denen er schließlich aufgrund von Fahrlässigkeit oder grobem Fehlverhalten
für haftbar gefunden wurde. Im Falle eines Vergleichs erfolgt die Ersatzleistung im Zusammenhang mit der vom Vergleich
abgedeckten Angelegenheit nur, wenn Rechtsberater dem Unternehmen bestätigen, dass die zu entschädigende Person
keine Pflichtverletzung begangen hat. Das genannte Recht auf Entschädigung schließt andere Rechte, auf welche die be-
treffende Person gegebenenfalls Anspruch hat, nicht aus.

(c) Das Unternehmen geht für die Verfahrenskosten der Person, die hiernach schadlos gehalten werden kann, in Vor-

leistung, solange das Unternehmen keine schriftliche Mitteilung von dieser Person erhält, dass die gesamte vorgeleistete
Summe zurückgezahlt werden muss, falls abschließend festgestellt wird, dass die Person aus anderen Gründen nicht ent-
schädigungsberechtigt ist. Der Abschluss eines Verfahrens, Prozesses oder einer Klage durch ein Urteil, eine Verfügung,
einen Vergleich, eine Verurteilung oder eine Erklärung über die Urteilsanerkennung (nolo contendere) o.ä. allein gibt
noch keinen Grund zu der Annahme, dass die zu entschädigende Person den Verhaltensstandard nicht erfüllt hat, die
ihn oder sie zu einer Entschädigung nach diesem Absatz berechtigt. Das Unternehmen hält die zu entschädigende Person
mit einer Barzahlung des vollständigen zu ersetzenden Betrages unverzüglich nach Mitteilung einer Ersatzleistungsver-
pflichtung durch die zu entschädigende Person schadlos.

Art. 27. Ausgaben
Nach Vorlage der entsprechenden Quittungen erstattet das Unternehmen angemessene Ausgaben, die den Mitglie-

dern des Verwaltungsrates aufgrund der Teilname an den Sitzungen des Verwaltungsrates entstehen.

Kapitel V. - Aufsicht über das Unternehmen

Art. 26. Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsführung
(a) Die Geschäfte des Unternehmens werden von mindestens einem Prüfungsbeauftragten der Geschäftsführung ge-

prüft. Dieser Prüfungsbeauftragte der Geschäftsführung kann ein Aktionär sein. Die Hauptversammlung der Aktionäre
ernennt den oder die gesetzlichen Buchprüfer und bestimmt ihre Anzahl, Vergütung und Amtszeit, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Ehemalige und gegenwärtige Prüfungsbeauftragte der Geschäftsführung dürfen wiedergewählt
werden.

(b) Jeder Prüfungsbeauftragte der Geschäftsführung kann mit oder ohne Angabe von Gründen von der Hauptver-

sammlung der Aktionäre abgewählt werden.

(c) Wenn das Unternehmen die von Artikel 215 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in

seiner jeweils geltenden Fassung festgelegten Kriterien überschreitet, wird die Institution des Prüfungsbeauftragten der
Geschäftsführung unterdrückt, und es wird von der Hauptversammlung unter Festlegung der Amtszeit mindestens ein
Wirtschaftsprüfer bestimmt, der Mitglied im Institut des réviseurs d’entreprises ist.

Kapitel VI. - Geschäftsjahr, Erlöse

Art. 27. Geschäftsjahr
Das Rechnungsjahr des Unternehmens beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember.

Art. 28. Erlöse
(a) Fünf Prozent (5%) der jährlichen Reinerlöse des Unternehmens werden den gesetzlichen Rücklagen zugewiesen.

Diese Zuweisung ist nicht mehr verpflichtend, wenn und solange diese Rücklagen zehn Prozent (10%) des gezeichneten
Kapitals des Unternehmens gemäß Artikel 5 dieser Gründungsurkunde oder ggf. gemäß Erhöhung/Herabsetzung nach
Artikel 5 dieser Gründungsurkunde betragen.

(b) Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Empfehlung des Verwaltungsrates über die Verwendung der

übrigen jährlichen Reinerlöse. Zwischendividenden können im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüt-
tet werden.

Kapitel VII. - Liquidation

Art. 29. Liquidation
Im Falle der Auflösung des Unternehmens wird die Liquidation von mindestens einem Liquidator ausgeführt. Dabei

kann es sich um natürliche oder juristische Personen handeln, die von der Aktionärsversammlung bestimmt werden, die
die Auflösung beschlossen hat und die auch ihre Befugnisse und ihre Vergütung bestimmt.

Kapitel VIII. - Zusätze zum Gesellschaftsvertrag

Art. 30. Zusätze zur Satzung
Diese Satzung kann durch Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Aktionäre des Unternehmens auf der Haupt-

versammlung der Aktionäre, auf der mindestens 50% des Unternehmenskapitals persönlich oder durch Bevollmächtigte

49076

vertreten sind, mit Zusätzen versehen werden. Wenn die genannte Beschlussfähigkeitsbedingung nicht erfüllt wird, kann
diese Gründungsurkunde mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Aktionäre des Unternehmens auf einer
zweiten Hauptversammlung der Aktionäre, für die keine Beschlussfähigkeitsbedingung mehr gilt, geändert werden.

Kapitel IX. - Abschlussbestimmung, Geltendes Recht

Art. 31. Geltendes Recht
Alle Angelegenheiten, die nicht in dieser Gründungsurkunde geregelt werden, werden in Übereinstimmung mit dem

luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung geregelt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2006 stattfinden.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Zeichner haben wie nachstehend angegeben gezeichnet: 

Alle Aktien wurden voll in bar zum Viertel ihres Zeichnungspreises eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab sofort der

Betrag von EUR 31.000,- zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde. 

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt hiermit, dass er überprüft hat, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10.

August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung aufgeführten Bedingungen vorherrschen
und erklärt ausdrücklich, dass diese erfüllt wurden.

<i>Kosten

Die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft infolge ihrer

Gründung getragen werden, werden auf ungefähr fünftausend (5.000,-) Euro geschätzt.

<i>Aktionärsversammlung

Sodann haben die Erschienen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer Aktionärsversammlung zusammenge-

funden, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären. Nachdem die Gültigkeit der Zusammensetzung übergeprüft
wurde, hat die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1. Die Anzahl der Mitglieder des wird auf fünf (5) und die Anzahl der Rechnungsprüfer wird auf einen (1) festgelegt.
2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder des Verwaltungsrates ernannt:
- Justin Bickle, geboren am 11. Januar 1971 in Plymouth, Großbritannien, mit der Geschäftsanschrift unter 31st Floor,

Citypoint, 1, Ropemaker Street, London EC2Y 9AW; und

- Caleb Kramer, geboren am 17. Juni 1969 in Washington, D.C., Vereinigte Staaten von Amerika, mit der Geschäfts-

anschrift unter 31st Floor, Citypoint, 1, Ropemaker Street, London EC2Y 9AW;

- Jean Fell, Buchsachverständiger, geboren am 9. April 1956 in Echternach, Großherzogtum Luxemburg, mit der

Geschäftsanschrift unter 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

- Cornelius Martin Bechtel, Berater, geboren am 11. März 1968 in Emmerich, Deutschland, mit der Geschäftsanschrift

unter 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und

- Szymon Dec, Berater, geboren am 3. Juli 1978 in Lodz, Polen, mit der Geschäftsanschrift unter 67, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Zum Rechnungsprüfer wird die folgende Person ernannt:
ERNST &amp; YOUNG Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft wird festgelegt auf 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-

burg, Großherzogtum Luxemburg.

4. Die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Rechnungsprüfers enden mit der jährlichen Hauptver-

sammlung, die einberufen wird, um die Bücher zum 31. Dezember 2007 zu genehmigen.

5. Gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaft in seiner jeweils geltenden Fassung

ermächtigt die Hauptversammlung den Verwaltungsrat, einem oder mehreren seiner Mitglieder die laufende Geschäfts-
führung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber zu übertragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

1) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND III, LP, vorgenannt,
hat elftausendvierhundertsieben Euro und fünzig Cent (EUR 11.407,50) eingezahlt und neuntausendendein-

hundertsechsundzwanzig Aktien gezeichnet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.126

2) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND IIIA, LP, vorgenannt, 
hat zweihundertsiebzehn Euro und fünzig Cent (EUR 217,50) eingezahlt und ein hundertvierundsiebzig Ak-

tien gezeichnet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174

3) OCM EUROPEAN PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND, LP, vorgenannt,
hat siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 7.750,-) eingezahlt und sechstausendzweihundert Aktien

gezeichnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.200

4) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND VI, LP, vorgenannt,
hat elftausendsechshundertfünfundzwanzig Euro (11.625,-) eingezahlt und neuntausenddreihundert Aktien

gezeichnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.300

Insgesamt: einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingezahlt für vierundzwanzigtausendachthundert Ak-

tien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.800

49077

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen des Bevollmächtigten der

vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher
Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung
maßgebend. 

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit

Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. Opitz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, vol. 152S, fol. 45, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022758/230/674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

GSS III PARTNERS DUISBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CURZON CAPITAL PARTNERS DUISBERG, S.à r.l.).

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 100.961. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 41243 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 13 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023529/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

GSS III PARTNERS SNFH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CURZON CAPITAL PARTNERS SNFH, S.à r.l.).

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 100.881. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 41245 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 13 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023532/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

EUROPA SOUTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 110.506. 

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of February.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Appeared:

- The company TRIPLE FIVE WORLDWIDE LIMITED, having its registered office at 57/63 Linewall Road, Gibraltar,
here represented by Mr Laurent Kind, private employee, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faïencerie, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its mandatory, declared and requested the notary to act:
- That the limited liability company EUROPA SOUTH, S.à r.l., having its registered office in L-2320 Luxembourg, 43,

boulevard de la Pétrusse, (R.C.S. Luxembourg section B number 110.506), has been incorporated by deed of Maître
Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on the 9th of September 2005, published in the Mémorial C, Number 3
of the 2nd of January 2006.

- That the corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), divided into five hundred

(500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

- That the appearing party, represented as said before, is the sole actual partner of the said company and that she has

taken the following resolutions according to the agenda.

<i>First resolution

The sole partner, represented as said before, decides to change the name of the company into TRIPLE FIVE SOUTH,

S.à r.l., and subsequently to amend article 2 of the articles of association as follows:

«Art. 2. The Company will assume the name of TRIPLE FIVE SOUTH, S.à r.l.»

Luxembourg, le 7 mars 2006.

A. Schwachtgen.

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

49078

<i>Second resolution

The sole partner, represented as said before, decides to transfer the registered office of the company from L-2320

Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse to L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at seven hundred and fifty Euro.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the mandatory, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same mandatory and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the mandatory, known to the notary by its surname, Christian name, civil status

and residence, the mandatory signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

- La société TRIPLE FIVE WORLDWIDE LIMITED, ayant son siège social au 57/63 Linewall Road, Gibraltar,
ici représentée par Monsieur Laurent Kind, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée EUROPA SOUTH, S.à r.l., ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43,

boulevard de la Pétrusse, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 110.506), a été constituée suivant acte reçu par Maître
Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem,

en date du 9 septembre 2005, publié au Mémorial C numéro 3 du 2 janvier 2006.
- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société et

qu’elle a pris sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’associée unique, représentée comme dit ci-avant, décide de changer la dénomination de la société en TRIPLE FIVE

SOUTH, S.à r.l., et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts comme suit:

«Art. 2. La Société prend la dénomination de TRIPLE FIVE SOUTH, S.à r.l.»

<i>Deuxième résolution

L’associée unique, représentée comme dit ci-avant, décide de transférer le siège social de L-2320 Luxembourg, 43,

boulevard de la Pétrusse, à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

<i>Constatation

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire com-

parant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire comparant, connu du notaire par son nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Kind, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 mars 2006, vol. 535, fol. 92, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023494/231/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

Junglinster, le 10 mars 2006.

J. Seckler.

49079

GSS III PARTNERS WUPPERTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CURZON CAPITAL PARTNERS WUPPERTAL, S.à r.l.).

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 100.967. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 41244 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 13 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023534/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 105.524. 

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom Dienstag, 8. November 2005,14:00 Uhr 

<i>abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Das Mitglied des Verwaltungsrates Herr Matthias Lehnen, wird von seinem Amt abberufen.
2) Zum neuen Verwaltungsratmitglied wird Frau Hiltrud Lehnen, Privatbeamtin, wohnhaft in Raiffeisenstr. 12, 54634

Bitburg, Deutschland, berufen.

Der Verwaltungsrat setzt sich somit zusammen aus folgenden Personen:
- Frau Larissa Abramovich, Kauffrau,
- Herr Eduard Grybach, Kaufmann,
- Frau Hiltrud Lehnen, Privatbeamtin.
Die Mandante entfallen sofort nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2010.

Luxemburg, den 8. November 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01482. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023551//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

IABA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 66.563. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01860, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023564/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

MULIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 7.558. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01845, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2006.

(024492/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

J. Elvinger
<i>Notaire

Unterschrift
<i>Die Versammlung

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour MULIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

49080

VINCERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 86.747. 

Le bilan et l’annexe au 31 octobre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01872, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023589/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

FONCILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 8.060. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00749, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

(023739/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

GALATEA LUX TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 111.542. 

In the year two thousand and five, on the twenty-ninth of November.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of GALATEA LUX TWO, S.à r.l., a private limited

liability company, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 111.542 and incorpo-
rated under the Luxembourg law pursuant to a deed dated on 19 October 2005 and whose articles have not yet been
published in Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg, who appoints as secretary Mr Hubert

Janssen, lawyer, residing in Torgny, Belgium.

The meetings elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, lawyer, residing in Torgny, Belgium.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and request the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list, that the five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro

(EUR 25) each, representing the entirety of the subscribed capital of the Company, are represented in this extraordinary
general assembly.

III. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all

convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide
on the agenda of the meeting.

IV. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. To increase the issued share capital of the Company with an amount of EUR 2,337,650.- (two millions three hun-

dred thirty-seven thousand six hundred fifty Euro) in order to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve
thousand five hundred Euro) to EUR 2,350,150.- (two millions three hundred fifty thousand one hundred fifty Euro) by
creating and issuing 93,506 (ninety-three thousand five hundred six) new shares with a nominal value of EUR 25.-
(twenty-five Euro) each (the «New Shares»), with a total share premium of EUR 8 (eight Euro);

2. To record the subscription and full liberation of the New Shares to be paid up by contribution in cash of EUR

2,337,658.- (two millions three hundred thirty-seven thousand six hundred fifty-eight Euro), whereof EUR 8.- (eight
Euro) as payment of the total share premium, by GALATEA LUX TWO, S.à r.l., a private limited liability company
organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 111.542 (the «Subscriber»);

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

49081

3. To amend article 5.1 of the Articles regarding the share capital, so as to reflect the taken decisions and to adapt

the subsequent definitions, which shall now read as follows: «5.1 The corporate capital is fixed at EUR 2,350,150.- (two
millions three hundred fifty thousand one hundred fifty Euro) represented by 94,006 (ninety-four thousand six) shares
with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.»;

4. Miscellaneous.

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company with an amount of EUR 2,337,650.-

(two millions three hundred thirty-seven thousand six hundred fifty Euro) in order to raise it from its current amount
of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 2,350,150.- (two millions three hundred fifty thousand one
hundred fifty Euro) by creating and issuing 93,506 (ninety-three thousand five hundred six) new shares with a nominal
value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each (the «New Shares»), with a total share premium of EUR 8.- (eight Euro).

<i>Subscription and payment

Intervenes GALATEA LUX ONE, S.à r.l., a Luxembourg private limited company with registered office at 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 111.532,

here represented by M

e

 Alain Farana, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal

on November 28th, 2005.

Who, after having stated that the Subscriber has full knowledge of the articles of incorporation of the Company,

declares to subscribe in the name of the Subscriber to the ownership of the 93,506 New Shares with a nominal value
of EUR 25.- each, which have been fully paid up by a contribution in cash.

These New Shares have been fully paid up in cash so that the amount of EUR 2,337,658.- (two millions three hundred

thirty-seven thousand six hundred fifty-eight Euro), whereof EUR 8 (eight Euro) as payment of the total share premium,
is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges
it.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to amend subsequently the article 5.1 of the Articles regarding the share capital, which

shall now read as follows:

«5.1 The corporate capital is fixed at EUR 2,350,150.- (two millions three hundred fifty thousand one hundred fifty

Euro) represented by 94,006 (ninety-four thousand six) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro)
each.»

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately twenty-eight thousand Euro.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed. 
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worked in English, followed by a French version, at the request of the same appearing
persons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société GALATEA LUX TWO, S.à r.l., société

privée à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand-Duché du
Luxembourg), inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.542 (la «Socié-
té») et constituée conformément au droit luxembourgeois par acte du 19 octobre 2005 dont les statuts n’ont pas
encore été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secré-

taire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique. L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur
Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées ne varietur par les associés ou leurs représentants, le
bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant, resteront ci-annexés pour être enregistrées avec l’acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les cinq cent (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros

(EUR 25,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social souscrit de la Société, sont représentés à cette assemblée
générale extraordinaire.

III. Tous les associés déclarent avoir été informés à l’avance Tous les associés déclarent avoir été préalablement

informés de l’ordre du jour de l’assemblée et renoncent aux formalités de convocation. L’assemblée est donc réguliè-
rement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

49082

<i>Ordre du jour:

1. Augmenter le capital social émis de la Société d’un montant de EUR 2.337.650,- (deux millions trois cent trente-

sept mille six cent cinquante euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cent
euros) à EUR 2.350.150,- (deux millions trois cent cinquante mille cent cinquante euros) par la création et l’émission de
93.506 (quatre-vingt-treize mille cinq cent six) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), avec une prime totale d’émission de EUR 8,- (huit euros);

2. Acter la souscription et la libération complète des Nouvelles Parts Sociales par apport en espèce d’un montant de

EUR 2.337.658,- (deux million trois cent trente-sept mille six cent cinquante-huit euros), dont EUR 8,- (huit euros) com-
me paiement de la prime totale d’émission, par la société GALATEA LUX ONE ONE, S.à r.l., une société à responsa-
bilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand-
Duché du Luxembourg), et inscrite au registre du Commerce et des Sociétés sou le numéro B 111.532 (le
«Souscripteur»);

3. Modifier en conséquence l’article 5.1 des Statuts concernant le capital social qui aura désormais la teneur suivante:
«5.1. Le capital social souscrit est fixé à 2.350.150 (deux millions trois cent cinquante mille cent cinquante euros)

représenté par 94.006 (quatre-vingt-quatorze mille et six) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-
cinq euros), chacune.»;

4. Divers.

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social émis de la Société d’un montant de EUR 2.337.650,- (deux mil-

lions trois cent trente se: mille six cent cinquante euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 12.500,-
(douze mille cinq cent euros) à EUR 2.350.150,- (deux millions trois cent cinquante mille cent cinquante euros) par la
création et l’émission de 93.506 (quatre-vingt-treize mille cinq cent six) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale
de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), avec une prime totale d’émission de EUR 8,-
(huit euros).

<i>Souscription et paiement

Comparaît GALATEA LUX ONE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 111.532,

Représenté par M

e

 Alain Farana, juriste, demeurant au Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé du

28 novembre 2005.

Qui, après avoir exposé que le Souscripteur a une connaissance complète des Statuts de la Société, déclare souscrire

au nom du Souscripteur à la propriété de 93.506 Nouvelles Parts Sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune
qui ont été entièrement payée par apport en espèce. 

Ces Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement libérées par un apport en espère de sorte que la somme de EUR

2.337.658,- (deux million trois cent trente-sept mille six cent cinquante-huit euros), dont EUR 8,- (huit euros) comme
paiement de la prime totale d’émission, est dès à présent à la disposition de la Société, dont la preuve en a été dûment
donné au notaire qui le reconnaît expressément.

<i>Seconde résolution

L’associé unique décide de modifier en conséquence l’article 5.1 des Statuts concernant le capital social qui aura

désormais la teneur suivante:

«5.1. Le capital social souscrit est fixé à 2.350.150 (deux millions trois cent cinquante mille cent cinquante euros)

représenté par 94.006 (quatre-vingt-quatorze mille six) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros), chacune.»

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

en conséquence du présent acte s’élèvent approximativement à vingt-huit mille euros.

Aucun autre sujet ne figurant à l’ordre du jour, et personne n’ayant pris la parole, l’assemblée générale a été clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande des comparants, le présent

acte est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Sur quoi le présent acte a été fait à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent acte. Après que lecture

de l’acte a été faite à la personne comparante et dont le notaire connaît le nom, prénom, état civil et résidence, la
personne pré mentionnée a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, vol. 150S, fol. 97, case 5. – Reçu 23.376,58 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023519/211/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

J. Elvinger.

49083

INFOPATIENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 76.170. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02058, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

(023743/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

INFOPATIENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 76.170. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02055, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

(023839/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

BALANCE D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 6-8, rue Origer.

R. C. Luxembourg B 24.235. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00889, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023751/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

ELECTRICITE THEWES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6437 Echternach, 17, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 99.666. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00892, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023756/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

WALLERICH-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3429 Dudelange, 147, route de Burange.

R. C. Luxembourg B 65.546. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02389, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2006.

(023930//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Echternach, le 13 mars 2006.

Signature.

Echternach, le 13 mars 2006.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE ACCURA S.A. 
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

49084

ENTVERSALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6617 Wasserbillig, 15, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 46.943. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00895, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023757/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

HANSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8384 Koerich, 34A, rue de Windhof.

R. C. Luxembourg B 70.772. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00897, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023759/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

MATROX HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1635 Luxemburg, 87, allée Léopold Goebel.

H. R. Luxemburg B 50.650. 

Im Jahre zweitausendsechs, den zehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Anteilseigner, der Aktiengesellschaft

MATROX HOLDING AG, mit Sitz in L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel, eingetragen beim Handels- und
Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 50.650,

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar André Schwachtgen, mit dem Amtssitze in Luxemburg, am

13. März 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 315 vom 10. Juli 1995, und
deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amts-
wohnsitze in Sanem, am 11. Juli 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 567
vom 16. Oktober 1997.

Das Kapital wurde in Euro umgewandelt gemäss Generalversammlung der Aktionäre unter Privatschrift vom 10. Mai

2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 159 vom 30. Januar 2002.

Die Statuten wurden zuletzt abgeändert wie folgt:
- zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 18. Oktober 2004, veröffentlicht im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1320 vom 27. Dezember 2004;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 16. September 2005, veröffentlicht im Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 193 vom 27. Januar 2006.

Das Gesellschaftskapital beträgt sechshundertachtzigtausend Euro (EUR 680.000,-) und ist eingeteilt in siebenund-

zwanzigtausendzweihundert (27.200) Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-). 

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Raymond Henschen, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg.
Er beruft zum Schriftführer Frau Monique Henschen-Haas, Wirtschaftsprüferin, wohnhaft in Luxemburg,
und zum Stimmzähler Frau Bénédicte Robaye, Privatbeamtin, wohnhaft in Léglise.
Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung und bittet den amtierenden Notar zu beurkunden, dass:
I) Die Tagesordnung der Generalversammlung folgende Punkte begreift:
1.- Aufstockung des Gesellschaftskapitals von einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) um es von dem bestehenden

Betrag von sechshundertachtzigtausend Euro (EUR 680.000,-) auf den Betrag von siebenhundertachtzigtausend Euro
(EUR 780.000,-) zu erhöhen, durch die Schaffung von viertausend (4.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von je fünf-
undzwanzig Euro (EUR 25,-), welche mit den gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet sind wie die bestehenden Ak-
tien.

2.- Zeichnung der neu geschaffenen Aktien durch den Aktionär Herr Kestutis Stragys, Gesellschaftsmanager,

wohnhaft in Kaunas (Litauen), mit Verzicht der jetzigen Aktionäre auf ihr Vorzugsrecht.

Einzahlung der neu geschaffenen Aktien.
3.- Abänderung von Artikel 3 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt siebenhundertachtzigtausend Euro (EUR 780.000,-), eingeteilt in einunddreis-

sigtausendzweihundert (31.200) Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

4.- Mandat an den Verwaltungsrat vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
II) Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren

Einberufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

Echternach, le 13 mars 2006.

Signature.

Echternach, le 13 mars 2006.

Signature.

49085

III) Gegenwärtigem Protokoll liegt eine Präsenzliste, mit Verzeichnis der Anteile und der Gesellschafter bei; welche

Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem
amtierenden Notar unterzeichnet ist.

IV) Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben einregistriert zu werden.

V) Aus der vorerwähnten Präsenzliste geht hervor, dass alle ausgegebenen Aktien bei gegenwärtiger Versammlung

anwesend oder vertreten sind und dass somit die Versammlung rechtsgültig beschliessen kann.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um den Betrag von einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-)

aufzustocken um es von dem bestehenden Betrag von sechshundertachtzigtausend Euro (EUR 680.000,-) auf den Betrag
von siebenhundertachtzigtausend Euro (EUR 780.000,-) zu erhöhen, durch die Schaffung von viertausend (4.000) neuen
Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche mit den gleichen Rechten und Pflichten
ausgestattet sind wie die bestehenden Aktien.

<i>Zweiter Beschluss

Der Aktionär Herr Vytenis Junevicius, Gesellschaftsmanager, wohnhaft in Kaunas (Litauen),
hier vertreten durch Herrn Raymond Henschen, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer

Vollmacht unter Privatschrift vom 6. Februar 2006,

welche Vollmacht nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch die Komparenten und den amtierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden,

verzichtet andurch auf sein Vorzugsrecht zur Zeichnung der neu geschaffenen Aktien. Somit wurden die neu geschaf-

fenen Aktien im Einverständnis aller Aktionäre wie folgt gezeichnet:

<i>Zeichnung der Aktien

Die neu geschaffenen Aktien werden gezeichnet wie folgt:
- Herr Kestutis Stragys, Gesellschaftsmanager, wohnhaft in Kaunas (Litauen), zeichnet die viertausend (4.000) Aktien,
hier vertreten durch Herrn Raymond Henschen, vorgenannt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 6.

Februar 2006,

welche Vollmacht nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch die Komparenten und den amtierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

<i>Einzahlung der Aktien

Die neu geschaffenen Aktien wurden voll in bar eingezahlt, somit steht der Gesellschaft der Betrag von einhundert-

tausend Euro (EUR 100.000,-) zur freien Verfügung, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher
dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Dritter Beschluss

Auf Grund der vorhergehenden Beschlüsse beschliesst die Generalversammlung Artikel 3 der Statuten abzuändern

um ihm folgenden Wortlaut zu geben.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt siebenhundertachtzigtausend Euro (EUR 780.000,-), eingeteilt in einunddreis-

sigtausendzweihundert (31.200) Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

<i>Vierter Beschluss

Dem Verwaltungsrat wird Mandat erteilt vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten

Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die ge-
genwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Henschen, M. Henschen-Haas, B. Robaye, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 13 février 2006, vol. 360, fol. 85, case 6. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(023042/201/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

MATROX HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 50.650. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023043/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

Echternach, den 8. März 2006.

H. Beck.

Echternach, le 8 mars 2006.

H. Beck.

49086

IMMO-SURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 27, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 91.849. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00898, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023760/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

E.I.I.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 80.437. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01480, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023762/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

MERCANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 81.776. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01008, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023764/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

MERCANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 81.776. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01007, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023763/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

AGN - HORSBURGH &amp; CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 75.354. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01476, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024349/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

AGN - HORSBURGH &amp; CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 75.354. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01473, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024348/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Echternach, le 13 mars 2006.

Signature.

Luxembourg, le 10 mars 2006.

Signature.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

Signature.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

Signature.

Signature.

Signature.

49087

FIDJI LUXCO (BC) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 111.801. 

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth day of October.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr Sébastien Binard, licencié en droit, residing in Luxembourg, acting as the representative of FIDJI LUXCO (BC)

S.CA. (the «Company»), a société en commandite par actions, having its registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Munsbach, registration with the Luxembourg trade and companies’ register pending, pursuant to a resolution of
the sole manager of the Company dated 26 October 2005.

A copy of the said resolution, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state her declarations as

follows:

1) The Company has been incorporated in the form of a société en commandite par actions under the name of FIDJI

LUXCO (BC) S.C.A. pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 5 October 2005,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2) The issued share capital of the Company is currently set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented

by twenty-four thousand eight hundred (24,800) fully paid up shares having a par value of one Euro twenty-five cents
(EUR 1.25).

3) Pursuant to article 6 of the articles of incorporation of the Company, the authorised share capital of the Company

is currently set at five hundred million euro (EUR 500,000,000.-), consisting of four hundred million (400,000,000) shares
having a par value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25).

The sole manager of the Company is authorised to issue shares without reserving for the existing shareholders a

preferential right to subscribe to the shares issued.

4) By a resolution adopted on 26 October 2005, the sole manager of the Company has decided to increase the Com-

pany’s share capital by an amount of three hundred nine thousand four hundred fifty-two Euro and fifty cents (EUR
309,452.50), from its current amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) up to an amount of three hundred
forty thousand four hundred fifty-two Euro and fifty cents (EUR 340,452.50), through the issue of two hundred forty-
seven thousand five hundred sixty-two (247,562) shares having a par value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25)
each (the «Newly Issued Shares»), such Newly Issued Shares being fully paid up in cash.

In accordance with article 6 of the articles of incorporation of the Company, the manager of the Company has

decided to suppress the preferential subscription right of the existing shareholders to subscribe the Newly Issued
Shares.

The two hundred forty-seven thousand five hundred sixty-two (247,562) Newly Issued Shares are entirely subscribed

by BAIN CAPITAL FCI CAYMAN L.P., a limited partnership organized under the laws of the Cayman Islands, having its
registered office c/o Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, for a total price of two million seven hundred forty-one thousand six hundred thirty-six Euro and twenty-five
cents (EUR 2,741,636.25), the whole fully paid up in cash and allocated as follows:

- three hundred nine thousand four hundred fifty-two Euro and fifty cents (EUR 309,452.50) will be allocated to the

share capital;

- two million four hundred thirty-two thousand one hundred eighty-three Euro and seventy-five cents (EUR

2,432,183.75) will be allocated to the share premium.

As a consequence of such increase of share capital, article 6, first paragraph of the articles of incorporation of the

Company is amended and now reads as follows:

Art. 6. The Company has a share capital of three hundred forty thousand four hundred fifty-two Euro and fifty cents

(EUR 340,452.50) consisting of two hundred seventy-two thousand three hundred sixty-two (272,362) shares having a
par value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25).

<i>Expenses

The expenses, fees, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company

as a result of the present deed, are estimated at approximately thirty thousand Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing

person the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this deed.
After reading and interpretation to the appearing person, known to the notary by her first name and surname, civil

status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-six octobre.
Par-devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Sébastien Binard, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de représentant de FIDJI

LUXCO (BC) S.C.A. (la «Société»), une société en commandite par actions ayant son siège social au 5, Parc d’Activité

49088

Syrdall, L-5365 Munsbach, dont l’inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg est pendante,
suivant une résolution du gérant unique de la Société en date du 26 octobre 2005.

Une copie de ladite résolution paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La personne comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter

les déclarations suivantes:

1) La Société a été constituée sous la forme d’une société en commandite par actions sous le nom de FIDJI LUXCO

(BC) S.C.A. suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 octobre
2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2) La Société a un capital émis de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par vingt-quatre mille huit cents

(24.800) actions entièrement libérées, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

3) Suivant l’article 6 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société est fixé à cinq cents millions d’euros

(EUR 500.000.000,-), représenté par quatre cents millions (400.000.000) d’actions ayant une valeur nominale d’un euro
vingt-cinq cents (EUR 1,25).

Le gérant unique de la Société est autorisé à émettre des actions sans réserver aux actionnaires existants un droit

préférentiel de souscription.

4) Par une résolution adoptée en date du 26 octobre 2005, le gérant unique de la Société a décidé d’augmenter le

capital social à hauteur d’un montant de trois cent neuf mille quatre cent cinquante-deux euros et cinquante cents (EUR
309.452,50) afin de le porter de sa valeur actuelle de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un montant de trois cent
quarante mille quatre cent cinquante-deux euros et cinquante cents (EUR 340.452,50), par l’émission de deux cent qua-
rante-sept mille cinq cent soixante-deux (247,562) actions ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR
1,25) chacune (les «Actions Nouvellement Emises»), ces Actions Nouvellement Emises ayant été libérées intégralement
en espèces.

Conformément à l’article 6 des statuts de la Société, le gérant de la Société a décidé de supprimer le droit préférentiel

de souscription des actionnaires existants pour les Actions Nouvellement Emises.

Les deux cent quarante-sept mille cinq cent soixante-deux (247,562) Actions Nouvellement Emises sont intégrale-

ment souscrites par BAIN CAPITAL FCI CAYMAN L.P., un limited partnership régi par le droit des Iles Caïmans, ayant
son siège social c/o Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, pour un prix total de deux millions sept cent quarante et un mille six cent trente-six Euro et vingt-cinq cents
(EUR 2.741.636,25), intégralement libéré en numéraire et affecté comme suit:

- trois cent neuf mille quatre cent cinquante-deux euros et cinquante cents (EUR 309.452,50) seront affectés au

capital social;

- deux millions quatre cent trente-deux mille cent quatre-vingt-trois euros et soixante-quinze cents (EUR

2.432.183,75) seront affectés à la prime d’émission.

En conséquence de cette augmentation de capital, l’article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

Art. 6. La Société a un capital souscrit de trois cent quarante mille quatre cent cinquante-deux euros et cinquante

cents (EUR 340.452,50) représenté par deux cent soixante-douze mille trois cent soixante-deux (272.362) actions d’une
valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

<i>Frais

Les frais, droits, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à

sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente mille euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la même partie comparante et en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu à la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état civil et demeure, la

partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Binard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 8, case 9. – Reçu 27.416,36 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023612/211/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

FIDJI LUXCO (BC) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 111.801. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 40028 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 13 mars 2006.

(023616/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

Luxembourg, le 9 novembre 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

49089

ALSTERKRUGCHAUSSEE IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 20.262. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01055, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023765/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

EXIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 69.549. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01995, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

(023767/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

MEIS JOHN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8521 Beckerich, 62, rue de Hovelange.

R. C. Luxembourg B 98.008. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01999, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

(023770/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

JER EUROPE FUND III BISHOPSGATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TARIEL HOLDING, S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 114.093. 

In the year two thousand and six, on the seventh day of February.
Before US Maître Henri Hellinckx, notary, residing at Mersch.

There appear:

J.E. ROBERT COMPANY, INC., a company incorporated under the laws of the State of Virginia, United States of

America, having its registered office at c/o C T Corporation System, 7401 Cox Road, Suite 301, Glen Allen, VA, 23060-
6802, United States of America, registered under number 0232682-5 with the Virginia Registrar of Companies,

duly represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a company incorporated under the laws of

Luxembourg, duly represented by Michel van Krimpen and Marc Torbick, respectively Director and Attomey-in-Fact-B
by virtue of a proxy given under private seal on February 7, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present Deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») established under the laws of Luxembourg under the name of TARIEL HOLDING, S.à r.l. (the «Company»), with
registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Company
Register, incorporated by virtue of a deed of M

e

 Henri Hellinckx dated January 30, 2006, not yet published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and whose articles of association do not have been amended up to
now.

II. The sole shareholder resolves to change the Company’s name into JER EUROPE FUND III BISHOPSGATE, S.à r.l.,

and to subsequently amend article 4 of the Company’s bylaws with immediate effect, which will be read as follows:

«Art. 4. The Company will have the name of JER EUROPE FUND III BISHOPSGATE, S.à r.l.»

Luxembourg, le 10 mars 2006.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

49090

III. The sole shareholder resolves to accept the resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a

société anonyme existing and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under number B 37.974, as sole
manager of the Company with immediate effect.

IV. The sole shareholder resolves to give full discharge to the former manager for its mandate as manager of the

Company until today’s date. Such discharge will be confirmed during the meeting of the members having to approve the
annual accounts of the Company as at 31 December 2006.

V. The sole shareholder resolves to amend article 12 of the Company’s bylaws with immediate effect, which will be

read as follows:

«Art. 12. The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B.

The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its

single manager.

In case of plurality of managers, the company will be validly committed towards third parties by the joint signature of

a category A manager acting together with a category B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.»

VI. The sole shareholder resolves to appoint the following persons as managers of the Company with immediate

effect and for an unlimited period of time:

Category A Managers:
- Daniel T. Ward, bom on May 17, 1957 in Camden, New Jersey, United States of America, with professional address

at 8309 River Falls Drive Potomac, MD 20854, United States of America;

- Malcolm Le May, born on January 24, 1958 in Farbborough, United Kingdom, with personal address at Upham

House, Upham, Hampshire SO32 1JH, United Kingdom.

Category B managers:
- Michel van Krimpen, born on February 19, 1968 in Rotterdam, The Netherlands, with professional address at 9, rue

Schiller, L-2519 Luxembourg; 

- Alan Botfield, born on December 22, 1970 in Stirling, Scotland, with professional address at 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a

result of the present shareholder meeting are estimated at approximately one thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxyholders of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le sept février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

J.E. ROBERT COMPANY, INC., une société constituée et régie sous les lois de l’Etat de Virginie, Etats-Unis d’Amé-

rique, ayant son siège social au c/o C T Corporation System, 7401 Cox Road, Suite 301, Glen Allen, VA, 23060-6802,
Etats-Unis d’Amérique, immatriculée sous le numéro 0232682-5 au Registre de Commerce et des Sociétés de Virginie,

49091

dûment représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société anonyme constituée et

régie sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, dûment représentée
par Michel van Krimpen et Marc Torbick, respectivement Directeur et Attomey-in-Fact-B en vertu d’une procuration
donnée sous seing privé le 7 février 2006.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg et régie par les lois

du Luxembourg sous la dénomination de TARIEL HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, en cours d’inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte
de M

e

 Henri Hellinckx reçu en date du 30 janvier 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, et dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.

II. L’associé unique décide de changer la dénomination de la Société en JER EUROPE FUND III BISHOPSGATE, S.àr.l.

et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts de la Société comme suit, avec effet immédiat.

«Art. 4. La Société aura la dénomination JER EUROPE FUND III BISHOPSGATE, S.à r.l.»
III. L’associé unique décide d’accepter la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une

société anonyme constitué et régie suivant les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 37.974, de ses fonctions de gérant unique de la Société avec effet immédiat.

IV. L’associé unique décide de donner pleine décharge à l’ancien gérant de la Société pour son mandat de gérant de

la Société jusqu’à ce jour. Ladite décharge sera confirmée durant la réunion des associés ayant à approuver les comptes
annuels de la Société au 31 décembre 2006.

V. L’associé unique décide de modifier l’article 12 des statuts de la Société avec effet immédiat, qui aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.

Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d’un gérant de catégorie

A agissant avec un gérant de catégorie B.

Le gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en
personne à la réunion.»

VI. L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants de la Société avec effet

immédiat et ce pour une durée indéterminée:

Gérants de catégorie A:
- Daniel T. Ward, né le 17 mai 1957 à Camden, New Jersey, Etats-Unis d’Amérique, demeurant professionnellement

au 8309 River Falls Drive Potomac, MD 20854, Etats-Unis d’Amérique;

- Malcolm Le May, né le 24 janvier 1958 à Farbborough, Royaume Uni, demeurant personnellement à Upham House,

Upham, Hampshire SO32 1JH, Royaume Uni.

Gérants de catégorie B:
- Michel van Krimpen, né le 19 février 1968 à Rotterdam, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg;

- Alan Botfield, né le 22 décembre 1970 à Stirling, Ecosse, demeurant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg. 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

49092

A la requête de ladite comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, ils ont signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. van Krimpen, M. Torbick, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 février 2006, vol. 435, fol. 50, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(023353/242/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

JER EUROPE FUND III BISHOPSGATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TARIEL HOLDING, S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 114.093. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 10 mars 2006.

(023355/242/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

BEETHOVENSTRASSE IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 15.772. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01059, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023778/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

BLITTERSDORF IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 19.478. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01063, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023780/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

HEIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6839 Lellig, 4, rue Neie Wee.

R. C. Luxembourg B 85.628. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02024, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

(023828/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Mersch, le 9 mars 2006.

H. Hellinckx.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 10 mars 2006.

Signature.

Luxembourg, le 10 mars 2006.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

49093

JAMES BROWNING PARTICIPATIONS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 19, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 114.704. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsechs, den zweiundzwanzigsten Februar.
Vor Uns Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Dr Michael Hasenstab, «Consultant», geboren in München, Deutschland, am 4. Juli 1969, wohnhaft in 10, Arlington

Road, Richmond Surrey, TW10 7BY, Grossbritannien,

hier vertreten durch Herrn Joao Ferreira, Privatangestellter, mit Berufsanschrift in 19, rue Aldringen, L-1118

Luxembourg,

auf Grund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg, am 27. Januar 2006.
2) ARDAVON HOLDINGS LIMITED, eine Gesellschaft mit Sitz in Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin

Islands, einregistriert in Tortola unter der Nummer 445031,

hier vertreten durch Herrn Joao Ferreira, vorgenannt,
auf Grund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg, am 27. Januar 2006.
Besagte Vollmachten werden nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentieren-

den Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben den Formalitäten der Einregistrierung
unterworfen zu werden.

Welche Komparenten, durch ihre Bevollmächtigte, beschlossen haben unter sich eine Aktiengesellschaft zu gründen

gemäss folgender Satzung:

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung JAMES BROWNING PARTICIPATIONS

S.A.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in jede

beliebige Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,

welche geeignet wären die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss

der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Leisten von Forschungs- und Verwaltungsdiensten für ihre

Tochtergesellschaften. 

Zweck der Gesellschaft sind desweiteren, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle irgendwelche industriellen,

kommerziellen, finanziellen, beweglichen oder unbeweglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Grün-
dung, Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaf-
ten, unter welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung, sei es
permanent oder vorübergehend, des somit zweckmäßigen geschaffenen Wertpapierbestands, sofern die Gesellschaft
nach den Bestimmungen betreffend die «Société de Participations Financières» betrachtet wird.

Die Gesellschaft kann sich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften mit einem

identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder nütz-
lich sind.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend (31.000,-) Euro (EUR), eingeteilt in dreitausendeinhun-

dert (3.100) Aktien mit einem Nennwert von zehn (10,-) Euro (EUR) pro Aktie, voll eingezahlt.

Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.
Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien

ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen unter Berücksichtigung der

Bestimmungen von Artikel 49-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels

Beschlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsän-
derungen.

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre

oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich; sie können beliebig

abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen; die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige
Wahl vor.

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind.

49094

Er ist zuständig für alle Angelegenheiten welche nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der General-

versammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Ver-

sammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich
oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder durch

Telefax erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder

anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen; diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der Gene-

ralversammlung unterworfen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats oder durch

die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrats rechtskräftig verpflichtet.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; dieselben werden auf sechs Jahre ernannt; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreissigsten Dezember

desselben Jahres.

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Donnerstag des Monats Juni um 10.00 Uhr

in Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag

statt.

Art. 10. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen.
Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern

sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben. Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die
Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung
festgesetzten Datum hinterlegen müssen.

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzu-

heissen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Rein-
gewinns.

Art. 12. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handels-

gesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Interimsdividende auszuzahlen.

Art. 13. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden

ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2007.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet: 

Diese gezeichneten Aktien wurden alle vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von

einunddreissigtausend (31.000,-) Euro (EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewie-
sen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10.

August 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-).

1) Herr Michael Hasenstab, vorgenannt, dreitausendneunundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2) ARDAVON HOLDINGS LIMITED, vorgenannt, eine Aktie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dreitausendeinhundert Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

49095

<i>Gründungsversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassen, nachdem sie die ordnungs-
gemäße Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt haben, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
a) Herr Francis N. Hoogewerf, Verwaltungsratmitglied, geboren in Minehead, Grossbritannien, am 12. Februar 1941,

mit Berufsanschrift in 19, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg;

b) Herr Richard Turner, geprüfter Buchhalter, geboren in Bloemfontein (Republik Süd Afrika), am 10. Dezember

1939, wohnhaft in 28, rue du Couvent, L-1363 Howald; und

c) Herr Paul Worth, Verwaltungsratmitglied, geboren in Wokingham (Grossbritannien), am 13. Dezember 1952,

wohnhaft in 38, rue de Bourglinster, L-6112 Junglinster.

3) Es wird zum Kommissar ernannt:
Herr Henri Vanherberghen, «ingénieur commercial et comptable agréé», geboren am 15. Mai 1941 in Uccle, wohn-

haft in 78, rue A. Asselbergs, B-1180 Brüssel.

4) Das Mandat der Verwaltungsratmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung

des Jahres 2011.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1118 Luxemburg, 19, rue Aldringen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: J. Ferreira, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, vol. 152S, fol. 45, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023732/230/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

EUROHAUS IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 10.915. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01067, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023781/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

FASANENHOF IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 21.354. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01070, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023783/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

DATA ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 78.075. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02029, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

(023835/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Luxembourg, le 2 mars 2006.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 10 mars 2006.

Signature.

Luxembourg, le 10 mars 2006.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

49096

HARMONIE EISCHEN, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8460 Eischen, 1, rue de Clairefontaine.

R. C. Luxembourg F 1.446. 

STATUTS

Entre les soussigné(e)s:
Monsieur Ciavarella Pietro, employé de Banque,
demeurant à L-8480 Eischen, 1, Cité Aischdall, nat. luxembourgeoise;
Monsieur Frank François, instituteur en retraite,
demeurant à L-8469 Eischen, 21A, rue de la Gaichel, nat luxembourgeoise;
Monsieur Gonçalves Manuel, peintre,
demeurant à L-8478 Eischen, 29, rue de Waltzing, nat. portugaise;
Monsieur Jemming Pierre, retraité,
demeurant à L-8474 Eischen, 25, rue de la Montagne, nat. luxembourgeoise;
Monsieur Laurent Dominique, infirmier gradué hospitalier,
demeurant à L-8466 Eischen, 4, rue de l’Ecole, nat. luxembourgeoise; 
Monsieur Lucas Nico, retraité,
demeurant à L-8460 Eischen, 60, rue de Clairefontaine, nat. luxembourgeoise;
Monsieur Mannes Jean, instructeur d’auto-école,
demeurant à L-8480 Eischen, 51, Cité Aischdall, nat. luxembourgeoise;
Monsieur Muller Gauthier dit Val, retraité,
demeurant à L-8463 Eischen, 2, rue du Bois, nat. luxembourgeoise;
Monsieur Reinart John, ingénieur-technicien,
demeurant à L-8460 Eischen, 19, rue de Clairefontaine, nat. luxembourgeoise;
Madame Ritz Elisabeth, indépendante,
demeurant à L-8471 Eischen, 14, rue de la Gare, nat. allemande;
Monsieur Schleck Steve, employé de l’Etat,
demeurant à L-8472 Eischen, 31, Grand-rue, nat. luxembourgeoise;
Monsieur Wolff Jean, retraité,
demeurant à L-8467 Eischen, 7, rue de l’Eglise, nat. luxembourgeoise;
Monsieur Zimmer Willy, retraité,
demeurant à L-8476 Eischen, 6, rue de Steinfort, nat. luxembourgeoise;
et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du

21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée, et par les présents statuts.

I. Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. L’association prend la dénomination HARMONIE EISCHEN, Association sans but lucratif, en abrégé HAR-

MONIE EISCHEN, A.s.b.l.

Elle a son siège social à Eischen. Sa durée est illimitée.

Art. 2. L’association a pour objet de développer et de promouvoir la pratique et la formation musicale, ainsi que par

extension, toutes activités qui se rapportent à la vie musicale et socioculturelle.

L’association est politiquement et confessionnellement neutre.

II. Membres

Art. 3. Sont membres de l’association les musiciens, membres du conseil d’administration, porte-drapeau, archiviste

et toutes autres personnes participant activement à la vie de l’association.

Seules peuvent devenir membre de l’association les personnes ayant atteint l’âge de 16 ans. Les personnes de moins

de 16 ans ont un statut d’élève de l’association.

Art. 4. Le nombre des membres de l’association est illimité et ne pourra être inférieur à cinq. Le conseil d’adminis-

tration établit et complète la liste des membres pour le 30 avril de l’année.

Art. 5. Les personnes qui désirent devenir membre de l’association présentent une demande d’admission au conseil

d’administration qui statue sur le bien-fondé de cette demande et qui n’est pas obligé de donner à l’intéressé les motifs
d’un éventuel refus.

Art. 6. L’association peut décerner des titres honorifiques à des personnes qui se distinguent par leur engagement

particulier pour la cause de l’association.

Art. 7. Sera membre donateur, toute personne désireuse d’aider l’association à réaliser son but et réglant à l’asso-

ciation une contribution annuelle fixée par l’Assemblée Générale. Les membres donateurs n’ont pas de droits au sein
de l’association.

Art. 8. Les membres de l’association paient une cotisation annuelle. Le montant est fixé par l’assemblée générale et

ne peut être supérieur à vingt-cinq (25,00 EUR) euros.

Art. 9. La qualité de membre se perd: 
a) par la démission volontaire adressée au conseil d’administration,
b) par le décès,

49097

c) par le non-paiement de la cotisation annuelle, trois mois après une sommation de payer dûment notifiée par lettre

recommandée,

d) par l’exclusion prononcée par l’Assemblée générale, statuant à la majorité des deux tiers des voix des membres

présents ou représentés, pour motifs graves.

Le membre démissionnaire ou exclu ainsi que les héritiers ayant droit du membre associé décédé:
- n’ont aucun droit sur le fonds social de l’association et ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations,
- sont tenus de rendre endéans les quinze jours et dans un état impeccable tout le matériel (instrument, uniformes,

partitions et autres) de l’association.

III. Administration

Art. 10. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association. Il est

l’organe exécutif des décisions de l’assemblée générale.

Le conseil d’administration est notamment tenu:
- de veiller à l’exécution des directives et délibérations de l’assemblée générale,
- de gérer les finances et d’organiser les activités de l’association,
- de prendre les initiatives nécessaires pour réaliser le but de l’association,
- de représenter l’association dans toutes les démarches et manifestations,
- de représenter l’association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Il peut sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou même, si l’assemblée générale l’auto-

rise, à un tiers.

Art. 11. Le conseil d’administration se compose de cinq membres au moins et de quinze membres au plus, élus par

l’assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de trois ans consécutifs. Le mandat est renouvelable.
Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-

président(s), secrétaire et trésorier. Leur fonction prend fin avec leur mandat.

Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables

que de leur mandat.

Art. 12. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président chaque fois que l’intérêt de l’asso-

ciation le réclame ou que la moitié de ses membres le demande. Il ne peut prendre de résolutions que si la moitié de
ses membres est présente. Les résolutions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en
cas d’égalité de voix. Les décisions sont consignées dans un rapport et archivées au siège de l’association.

Art. 13. L’association est valablement engagée en toutes hypothèses par les signatures conjointes du président ou

d’un vice-président ainsi que celle du secrétaire ou du trésorier.

A l’égard des banques, l’association est valablement engagée par la signature de son président ou de son trésorier

isolément et sans restriction du montant dans la limite de l’avoir en compte.

IV. Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale constitue le pouvoir souverain de l’association. Elle détient les pouvoirs qui lui sont

expressément réservés par la loi ou reconnus par les présents statuts. 

Sont notamment de sa compétence:
a) les modifications aux statuts,
b) la désignation et révocation des membres du conseil d’administration,
c) l’approbation des budgets et des comptes,
d) la dissolution volontaire de l’association,
e) l’approbation du rapport d’activité de l’année écoulée et de l’année à venir,
f) l’approbation des règlements établis par le conseil d’administration,
g) la fixation des cotisations annuelles,
h) la désignation, chaque année, de deux réviseurs de caisse. Leur mandat est incompatible avec celui de membre du

conseil d’administration,

i) l’exclusion de membres,
j) la délibération en dernière instance sur toutes les questions intéressant l’association.

Art. 15. L’assemblée générale ordinaire a lieu pendant le premier trimestre suivant la clôture de l’exercice social.

L’exercice social correspond à l’année civile.

L’association peut être réunie en assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision du conseil d’admi-

nistration ou à la demande d’un cinquième des membres au moins.

Art. 16. L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration par lettre ordinaire adressée à chaque

membre, au moins huit jours avant l’assemblée.

La convocation mentionne le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de l’assemblée générale.
L’ordre du jour est établi par le conseil d’administration. Toute proposition, signée d’un nombre égal au vingtième

des membres de la dernière liste annuelle, doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 17. Tous les membres de l’association doivent être convoqués aux assemblées générales. Il est loisible aux mem-

bres de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre. Un membre ne peut être porteur que d’une
seule procuration écrite.

49098

L’assemblée générale est constituée quel que soit le nombre de membres présents et les décisions sont prises à la

majorité simple des voix, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi. En cas d’égalité de
voix, celle du président est prépondérante.

Tous les membres ont un droit de vote égal. Les votes interviennent à main levée, à l’exception de ceux portants sur

des personnes et à l’exception de ceux pour lesquels un cinquième des membres présents et représentés exigent un
vote par bulletin secret.

Aucune décision ne peut être prise sur un point qui n’a pas été inscrit à l’ordre du jour, à moins que l’assemblée

générale n’en décide autrement à la majorité de 2/3 des voix.

L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à défaut, par un vice-président ou

le plus âgé des membres du conseil d’administration présents.

Art. 18. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modification des statuts ou la dissolution de l’as-

sociation que conformément aux articles 8 et 20 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but
lucratif, telle qu’elle a été modifiée.

Art. 19. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le pré-

sident et le secrétaire. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres ou tiers peuvent en prendre con-
naissance mais sans déplacement du registre.

Toute modification aux statuts est publiée dans le mois de sa date au Mémorial.

V. Compte et budget

Art. 20. L’année sociale concorde avec l’année civile.

Art. 21. A la fin de chaque exercice, les comptes sont arrêtés. Le bilan et le détail des recettes et des dépenses sont

soumis aux réviseurs de caisse pour examen et visa.

Art. 22. Le conseil d’administration soumet tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale le compte de l’exer-

cice écoulé avec le rapport des réviseurs de caisse et le budget du prochain exercice.

VI. Modification des statuts, dissolution et liquidation

Art. 23. Toute modification des statuts sera réglée d’après la procédure prévue à l’article 8 de la loi du 21 avril 1928

sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée.

Art. 24. La dissolution volontaire de l’association est réglée par l’article 20 de la loi précitée.

Art. 25. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire les avoirs de l’association sont à confier à l’administration com-

munale de Hobscheid. Si dans un délai de dix ans aucune nouvelle association ne s’est reconstituée sous la dénomination
HARMONIE EISCHEN, l’autorité communale liquide le patrimoine au profit d’une association sociale politiquement et
confessionnellement neutre.

VII. Dispositions finales

Art. 26. Les soussigné(e)s déclarent que l’HARMONIE EISCHEN, association sans but lucratif, reprend l’actif et le

passif de la société de fait HARMONIE EISCHEN constituée en 1898.

L’HARMONIE EISCHEN, association sans but lucratif, est à considérer comme successeur légal de l’HARMONIE EIS-

CHEN.

Art. 27. Tous les points non visés par les présents statuts sont réglés par les dispositions de la loi du 21 avril 1928

sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée.

La nullité d’une ou de plusieurs dispositions statutaires n’entraîne pas la nullité des autres dispositions des statuts et

ne contrarie pas l’existence de l’association

Eischen, le 10 février 2006.

<i>Assemblée Générale du 10 février 2006

Immédiatement après la constitution de l’association, tous les associés, se considérant dûment convoqués se sont

réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le siège social de l’association est établi à L-8460 Eischen, 1, rue de Clairefontaine.
2. Par dérogation aux dispositions statutaires, l’exercice social commence le 11 février 2006 et se termine le 31 dé-

cembre 2006. 

3. La cotisation annuelle par membre est fixée à 3,00 (trois) euros.
4. Sont appelés aux fonctions de membre du conseil d’administration: 
Monsieur Ciavarella Pietro, employé de Banque,
demeurant à L-8480 Eischen, 1, Cité Aischdall, nat. luxembourgeoise;
Monsieur Frank François, instituteur en retraite,
demeurant à L-8469 Eischen, 21A, rue de la Gaichel, nat. luxembourgeoise;
Monsieur Gonçalves Manuel, peintre,
demeurant à L-8478 Eischen, 29, rue de Waltzing, nat portugaise;
Monsieur Jemming Pierre, retraité,
demeurant à L-8474 Eischen, 25, rue de la Montagne, nat. luxembourgeoise;
Monsieur Laurent Dominique, infirmier gradué hospitalier,
demeurant à L-8466 Eischen, 4, rue de l’Ecole, nat luxembourgeoise; 
Monsieur Lucas Nico, retraité,
demeurant à L-8460 Eischen, 60, rue de Clairefontaine, nat. luxembourgeoise;

49099

Monsieur Mannes Jean, instructeur d’auto-école,
demeurant à L-8480 Eischen, 51, Cité Aischdall, nat. luxembourgeoise;
Monsieur Muller Gauthier dit Val, retraité,
demeurant à L-8463 Eischen, 2, rue du Bois, nat luxembourgeoise;
Monsieur Reinart John, ingénieur-technicien,
demeurant à L-8460 Eischen, 19, rue de Clairefontaine, nat luxembourgeoise;
Madame Ritz Elisabeth, indépendante,
demeurant à L-8471 Eischen, 14, rue de la Gare, nat. allemande;
Monsieur Schleck Steve, employé de l’Etat,
demeurant à L-8472 Eischen, 31, Grand-rue, nat. luxembourgeoise;
Monsieur Wolff Jean, retraité,
demeurant à L-8467 Eischen, 7, rue de l’Eglise, nat. luxembourgeoise;
Monsieur Zimmer Willy, retraité,
demeurant à L-8476 Eischen, 6, rue de Steinfort, nat. luxembourgeoise.
5. Sont appelés aux fonctions de réviseurs de caisse:
Madame Feyder-Hermann Liliane, demeurant à L-8478 Eischen, 24A, rue de Waltzing;
Monsieur Pepin Ignace, demeurant à L-8357 Goeblange, 36, domaine du Beauregard.

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 10 février 2006

Ensuite le Conseil d’Administration s’est réuni et a désigné à l’unanimité comme:
Président: Monsieur Zimmer Willy, retraité,
demeurant à L-8476 Eischen, 6, rue de Steinfort, nat. luxembourgeoise;
Vice-président: Monsieur Jemming Pierre, retraité,
demeurant à L-8474 Eischen, 25, rue de la Montagne, nat. luxembourgeoise;
Secrétaire: Monsieur Schleck Steve, employé de l’Etat,
demeurant à L-8472 Eischen, 31, Grand-rue, nat luxembourgeoise;
Trésorier: Monsieur Frank François, instituteur en retraite, 
demeurant à L-8469 Eischen, 21A, rue de la Gaichel, nat. luxembourgeoise.

Eischen, le 10 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02927. – Reçu 474 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024426//217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

BELANO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 24.102. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 9 mars 2006.

(023862/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

GALLAHER LUXEMBOURG OVERSEAS FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 105.806. 

In the year two thousand and five, on the eleventh day of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholder of GALLAHER LUXEMBOURG OVERSEAS FINANCE,

S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
incorporated by deed enacted on December 30, 2004, registered at Luxembourg trade register section B, n

°

 105.806,

published in Mémorial C, number 491 dated May 25, 2005, page 23536, whose articles have been amended for the last
time on March 25, 2005, published in Mémorial C, number 981 dated October 4, 2005, page 47076.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing at Luxembourg. 
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, lawyer, residing at

Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance

list. That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.

P. Ciavarella / F. Frank / M. Gonçalves / P. Jemming / D. Laurent / N. Lucas / J. Mannes / G. Muller / J. Reinart / 
E. Ritz / S. Schleck / J. Wolff / W. Zimmer

H. Hellinckx
<i>Notaire

49100

II.- As appears from the attendance list, the 2,805,800 (two million eight hundred and five thousand eight hundred)

shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda of which the shareholder has been duly informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Modification of the rules regulating:
- the appointment of managers;
- the appointment of the chairman of the board of managers;
- the powers of the chairman of the board of managers;
- the quorum of managers meetings;
- the location of activities carried out by any ad hoc agent(s) appointed by the board of managers;
- the participation of managers to board meetings;
- the decisions taken by the board of managers through written resolution. 
2.- Subsequent modification of Articles twelve of the Articles of Association.
After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

The sole shareholder decided to modify the various rules ensuring that:
- a manager can not be appointed if it causes the majority of managers to be United Kingdom resident;
- the chairman of the board of managers shall always be a non United Kingdom resident;
- the chairman shall always have the casting vote in the event of split vote, save in the case where this casting vote

would be to render the decision or vote in question one that is reached or passed by the majority of the managers who
are resident in the United Kingdom;

- a quorum of managers meetings only exists if the majority of managers present are not United Kingdom resident;
- if the board of managers delegates power to ad hoc agent(s), the powers shall not be carried out by this agent(s) in

the United Kingdom;

- any proxy or representative appointed by a non-UK resident manager must be a non-UK resident;
- managers are no longer allowed to participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference,

or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at
the same time;

- where decisions are made by written resolution, such decision shall be invalid if the majority of managers sign the

resolution while in the United Kingdom.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is resolved to amend articles twelve of the Articles of Incorporation

to read as follows:

Art. 12. A board of managers consisting of at least (four) managers manages the Company. The managers need not

be shareholders of the Company.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of share-

holders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder.
A new manager cannot be appointed if it causes the majority, of managers to be United Kingdom resident. The remu-
neration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general meeting
of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any
manager. This ability to remove one manager should not be exercised if it would leave a majority of United-Kingdom
managers within the board. The power to replace a manager can not lead to a majority of United-Kingdom managers
within the board. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders
or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

The joint signature of any two managers shall bind the Company.
The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc

agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. Such delegated powers cannot be carried out
by the ad hoc agent (s) in the United Kingdom.

Any proxy or representative appointed by a non-UK resident manager must be a non-UK resident.
The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object and provided the
terms of this article shall have been complied with.

Managers’ decisions are taken by meeting of the board of managers. A meeting of the board of managers can only be

validly held if the majority of managers present or represented are not United Kingdom resident.

The board of managers shall choose from among its members a chairman, who shall be a non United Kingdom resi-

dent. In case of split vote, the chairman shall have the casting vote, save in the case where this casting vote would be to
render the decision or vote in question one that is reached or passed by the majority of the managers who are resident
in the United Kingdom.

It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the

meetings of the board of managers. 

The board of managers shall meet when convened by one manager.

49101

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
All meetings of managers shall be held in the municipality of Luxembourg. 
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means

or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any

other suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers. (Three) managers present in person, by proxy or by representative are a quorum
provided that the majority of present or represented managers be non United-Kingdom resident.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or elec-

tronic means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.
Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least (three) managers,

present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting. Such resolution in writing shall be invalid if the, majority of managers sign resolution while in the
United Kingdom.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by

ordinary mail, electronic mail or telecopier, or any other suitable telecommunication means. Such resolutions or deci-
sions shall be invalid if the majority of managers sign resolution and decision while in the United Kingdom.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same

content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with the present deed have been estimated at about two thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed, was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le onze novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée GALLAHER

LUXEMBOURG OVERSEAS FINANCE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll ins-
crite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B, numéro 105.806, constituée suivant acte reçu
le 30 décembre 2004, publié au Mémorial C, numéro 491 daté du 25 mai 2005, page 23536, dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois le 25 mars 2005, acte publié au Mémorial C, numéro 981 daté du 4 octobre 2005, page
47076.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hess, juriste,

demeurant à Messancy, Belgique.

Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.805.800 (deux millions huit cent cinq mille huit cents) parts sociales,

représentant 1 intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé a été préalablement
informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification des règles relatives:
- à la nomination des gérants;
- à la nomination du président du conseil de gérance; 
- aux pouvoirs du président du conseil de gérance;

49102

- aux quorums des réunions du conseil de gérance;
- au lieu d’exercice des activités exercées par tout agent ad hoc désigné par le conseil de gérance;
- à la participation des gérants aux réunions du conseil de gérance;
- aux décisions prises par le conseil de gérance par décision écrite.
2. Modification subséquente de l’article 12 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier les différentes règles assurant que:
- un gérant ne puisse être nommé si cela entraîne que la majorité des gérants soit résidents au Royaume-Uni;
- le président du conseil de gérance ne soit jamais résident au Royaume Uni;
- le président du conseil de gérance ait toujours voix prépondérante en cas d’égalité de vote au sein du conseil de

gérance, mais seulement si l’exercice de ce vote prépondérant n’a pas pour effet de prendre une décision proposée ou
décidée par une majorité de gérants résidents au Royaume-Uni;

- une réunion des gérants ne puisse être tenue que si la majorité des gérants présents soient non résidents au

Royaume-Uni;

- si le conseil de gérance délègue ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc, les pouvoirs exercés par cet (ces)

agent(s) ne soient jamais exercés au Royaume-Uni;

- toute procuration accordée par un gérant non résident au Royaume-Uni doit l’être à un non résident au Royaume-

Uni;

- les gérants ne sont plus autorisés à assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence,

ou tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de
s’entendre en même temps;

- dans le cadre de résolutions écrites, de telles résolutions ne soient valides que si la majorité des gérants les signent

en dehors du Royaume-Uni.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article douze

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 12. Un conseil de gérance constitué d’au moins (quatre) gérants gère la Société. Les gérants peuvent ne pas être

associés.

Les gérants sont désignés, et leur rémunération fixée, par décision de l’assemblée générale des associés délibérant à

la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l’associé unique. Un nouveau gérant ne pourra être nom-
mé si cela entraîne que la majorité des gérants soient résidents au Royaume Uni. La rémunération des gérants pourra
être modifiée par une résolution prise aux mêmes conditions de majorité. L’assemblée générale des associés ou le cas
échéant, l’associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant. Le pouvoir de révo-
quer ou de remplacer un gérant ne pourra s’exercer si cela entraîne une majorité de gérants résident au Royaume-Uni
au sein du conseil. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou le cas échéant
à l’associé unique, par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

La signature conjointe de deux gérants liera la société.
Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Ces pouvoirs délégués ne peuvent être exer-
cés par le ou les agents ad hoc au Royaume-Uni.

Toute procuration accordée par un gérant non résident au Royaume-Uni doit l’être à un non résident au Royaume-

Uni.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Vis-à-vis des tiers, les gérants auront tout pouvoir pour agir pour le compte de la Société en toute circonstance et

pour exécuter et approuver tout acte et opération conformes à l’objet social de la Société, sous réserve que les termes
du présent article auront été respectés.

Les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance pourront

se tenir uniquement dans le cas où la majorité des gérants présents seront résidents ailleurs qu’au Royaume-Uni.

Le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président, qui ne pourra être résident au Royaume-Uni. En cas

d’égalité de vote, le président aura voix prépondérante, mais seulement si l’exercice de ce vote prépondérant n’a pas
pour effet de prendre une décision proposée ou décidée par une majorité de gérants résidents au Royaume-Uni.

Il peut également choisir un secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du

procès-verbal de réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée

pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Toute réunion du conseil dé gérance se tient au sein de la commune de Luxembourg.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, ou par télécopie, câble, télégramme, télex,

moyens électroniques ou tout autre moyen approprié de communication.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens élec-

troniques ou tout autre moyen approprié de communication de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

49103

Aucune convocation séparée n’est requise pour les réunions tenues à des dates et lieux fixés lors d’une précédente

réunion du conseil de gérance.

(Trois) gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum pour autant que la

majorité des gérants présents ou représentés soit non-résidents au Royaume-Uni.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble,

télégramme, télex, ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plus d’un gérant.
Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par (trois) gérants au

moins, présents ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance. De telles résolutions par écrit ne pourront être prises que si la majorité des
gérants signe ce genre des résolution en dehors du Royaume-Uni.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, ou autre moyen de télécommunication approprié. Les résolutions ou
décisions ne seront valables dans ce cas que si la majorité des gérants signant les résolutions et les décisions ne le font
pas au Royaume-Uni.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux

gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à environ deux mille euros. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 27, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023450/211/247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

GALLAHER LUXEMBOURG OVERSEAS FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 105.806. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 40194, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 13 mars 2006.

(023451/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

DEXIA WORLD ALTERNATIVE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 82.737. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01504, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

(023860/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Luxembourg, le 16 décembre 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Pour DEXIA WORLD ALTERNATIVE, SICAV
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

49104

VOTRE JARDIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2414 Dommeldange, 31, rue Jean Raspert.

R. C. Luxembourg B 84.896. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01565, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2006.

(023872/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

24 SPORT VILLAGE - SOCIETA IMMOBILIARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 84.439. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02208, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2006.

(023868/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

RAFFALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 60.205. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02412, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024343/1133/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

RAFFALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 60.205. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02414, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024344/1133/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

<i>Pour VOTRE JARDIN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL, Société Anonyme
<i>Le Domiciliataire
Signatures

Signature.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Boissons Heintz S.A.

Boissons Heintz S.A.

Impulse

Impulse

Impulse

Gilux S.A.

Gilux S.A.

Fondation Aide Populaire d’Urgence

Motor Center Angelsberg S.A.

Vantico International, S.à r.l.

JER Bishopsgate, S.à r.l.

Grosvenor Crescent Developments, S.à r.l.

Grosvenor Crescent Developments Finance, S.à r.l.

JER Bishopsgate, S.à r.l.

CommCapital, S.à r.l.

Lybra Investments, S.à r.l.

Arde

Parc du Rhône, S.à r.l.

Somlux A.G.

Mediagenf, S.à r.l.

Avenches, S.à r.l.

Projectswiss, S.à r.l.

Grosvenor Crescent Developments JV, S.à r.l.

Metal Cad Concept S.A.

BRE/Sweden 2, S.à r.l.

OCM/Nordenia Luxembourg GP S.A.

GSS III Partners Duisberg, S.à r.l.

GSS III Partners SNFH, S.à r.l.

Europa South, S.à r.l.

GSS III Partners Wuppertal, S.à r.l.

Management Technologie Development Holding S.A.

Iaba S.A.

Mulix, S.à r.l.

Vincera S.A.

Foncilux S.A.

Galatea Lux Two, S.à r.l.

Infopatient S.A.

Infopatient S.A.

Balance d’Or, S.à r.l.

Electricité Thewes, S.à r.l.

Wallerich-Lux S.A.

Entversalux, S.à r.l.

Hansen, S.à r.l.

Matrox Holding A.G.

Matrox Holding A.G.

Immo-Sûre, S.à r.l.

E.I.I.G. S.A.

Mercante S.A.

Mercante S.A.

AGN - Horsburgh &amp; Co, S.à r.l.

AGN - Horsburgh &amp; Co, S.à r.l.

Fidji Luxco (BC) S.C.A.

Fidji Luxco (BC) S.C.A.

Alsterkrugchaussee Immobilien A.G.

Exit, S.à r.l.

Meis John, S.à r.l.

JER Europe Fund III Bishopsgate, S.à r.l.

JER Europe Fund III Bishopsgate, S.à r.l.

Beethovenstrasse Immobilien A.G.

Blittersdorf Immobilien A.G.

Heim S.A.

James Browning Participations S.A.

Eurohaus Immobilien A.G.

Fasanenhof Immobilien A.G.

Data One S.A.

Harmonie Eischen

Belano Holding S.A.

Gallaher Luxembourg Overseas Finance, S.à r.l.

Gallaher Luxembourg Overseas Finance, S.à r.l.

Dexia World Alternative, Sicav

Votre Jardin, S.à r.l.

24 Sport Village Società Immobiliare S.A.

Raffalux S.A.

Raffalux S.A.