logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

3073

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 65

11 janvier 2006

S O M M A I R E

A.I. Asesoria de Inversiones S.A., Luxembourg  . . .

3095

Greensleave S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

3108

ABM Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3095

Greensleave S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

3108

ABM Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3095

Greensleave S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

3108

ABM Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3095

Hypraholding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

3087

ABM Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3095

IBL Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

3075

ABM Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3095

Imelu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3090

Akeler Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

3094

Imex Europe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

3083

Allalin Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

3075

Immovacances S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

3088

Amelia Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

3084

Ingersoll-Rand Worldwide Capital, S.à r.l., Luxem-

Arguedas Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

3081

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3092

Balthasar, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

3088

Ingersoll-Rand Worldwide Capital, S.à r.l., Luxem-

Bari Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3089

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3092

Bayern LB International Fund Management S.A., 

Investitionsgesellschaft der Ardennen, S.à r.l., Lu-

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3089

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3088

Cameo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3088

K & K Dental Design, G.m.b.H., Echternach . . . . . 

3084

Camping Simmerschmelz II A.G., Septfontaines . .

3085

Kingberg Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

3074

Celan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

3087

Klöckner Pentaplast Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Cetiri Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

3090

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3110

DB Silver, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

3096

Klöckner Pentaplast Participations, S.à r.l., Luxem-

Du Fort Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .

3094

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3110

E.C.G. Domiciliation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

3093

(The) Learning Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . 

3078

E.C.G. S.A., Expertise Comptable et Gestion, Lu-

(The) Learning Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . 

3078

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3094

Leorado, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3084

E.I., Européenne d’Investissement S.A., Pétange . .

3107

Lexington Corporation, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

3077

E.I., Européenne d’Investissement S.A., Pétange . .

3107

Linie Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

3081

E.I., Européenne d’Investissement S.A., Pétange . .

3107

Logitrans Europ S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

3092

E.I., Européenne d’Investissement S.A., Pétange . .

3107

Luce Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

3078

Espace Promotion Holding, Luxembourg . . . . . . . .

3083

M.H. Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

3108

Ets Nell, S.à r.l., Rollingen-Mersch . . . . . . . . . . . . . .

3081

Macquarie  Industrie  Beteiligungen  S.A.,  Luxem-

Euro-Land S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

3077

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3108

Eurogest S.A., Clervaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3079

Maritime  Construction  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

Everwood Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3083

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3107

Fidemon, S.à r.l., Mondercange  . . . . . . . . . . . . . . . .

3092

Matisa, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3110

Finango S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3083

Media Travel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

3090

Finanmag S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

3082

Medina Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

3082

Finsalute S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3094

Meginvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3080

Flouh- an Sammlerclub Lëtzebuerg Stad - Musel-

Meginvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3080

frënn Réimech, A.s.b.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

3085

Mondi International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

3109

Gedrenksbuttek Kleyr, S.à r.l., Echternach . . . . . . .

3083

Mondi International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

3109

Geopartner, G.m.b.H., Berchem  . . . . . . . . . . . . . . .

3085

Mondi International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

3109

3074

KINGBERG IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 37.972. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2005 que, le mandat des organes sociaux étant

venu à échéance, ont été renommés:

a) administrateurs
- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de

la Porte-Neuve;

- Monsieur Jean Pirrotte, directeur d’assurances e.r. avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-

mont;

- Mademoiselle Danièle Martin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la

Porte-Neuve.

b) commissaire aux comptes
- Monsieur Nicolas Schaeffer jr., maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de

la Porte-Neuve.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élu expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en

l’an 2009.

Luxembourg, le 30 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05901. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076975.3/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

SUN VALLEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 110, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 97.654. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00165, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076908.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Mondilux International Investments S.A., Luxem-

Serin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

3120

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3106

Sirec, International Reinsurance Company S.A., 

Mucora Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

3082

Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3075

Naturparadies, S.à r.l., Ulflingen . . . . . . . . . . . . . . . 

3105

Société Hollando-Suisse de Participation S.A.H., 

Neptuno Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

3120

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3082

Newvalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3082

Sofréa,  Société  Française  de  Réassurance  S.A.,

Niam III Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

3094

Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3075

Ollioules Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

3088

Soluxol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3090

Onoclea Corporation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

3078

Soprosoulux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

3110

Optimal Security, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

3091

Stockwell Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3090

Optimal Security, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

3091

Stones Steak House Strassen, S.à r.l., Bertrange. .

3077

Osdi S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3076

Stones Steak House Strassen, S.à r.l., Bertrange. .

3077

Padostom S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . 

3084

Stones Steak House Strassen, S.à r.l., Bertrange. .

3077

Padostom S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . 

3084

Sun Valley, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3074

Paragon S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3092

Taureau Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

3120

Parc Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

3093

Taylor Woodrow Finance (Gibraltar) 2005 Limited,

Parc Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

3093

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3111

Parc Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

3093

Trotwood Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

3110

Peintures Biwersi, S.à r.l., Wellenstein . . . . . . . . . . 

3093

U.P. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3080

Pelican 10 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3081

United Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3076

Pink Ocean Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

3120

Versbau S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3088

Prifot S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3087

Wallenborn Transports S.A., Munsbach . . . . . . . . .

3109

Raval Europe S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3076

Westing Petroleum S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

3091

Rodasil S.A., Mertert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3084

Yago Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3081

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signature

Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature.

3075

SOFREA, SOCIETE FRANÇAISE DE REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 26.659. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2005 

<i>Quatrième résolution: Nominations statutaires

L’Assemblée décide à l’unanimité de ne pas renouveler le mandat de la société KPMG AUDIT en tant que Réviseur

d’Entreprises. Elle nomme à l’unanimité le Réviseur d’Entreprises MAZARS à Luxembourg jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire qui doit statuer sur les comptes de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00986. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072871.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

SIREC, INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 49.656. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 mai 2005 

<i>Quatrième résolution: Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises

Le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A. arrivant à échéance à l’issue de cette Assemblée, il est reconduit

à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée Génrale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00984. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072872.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

ALLALIN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 97.001. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05533, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076590.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

IBL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 16, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 27.007. 

Le bilan, l’annexe légale constatant I’affectation du résultat, le rapport du commissaire établis au 31 octobre 2004,

enregistrés à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05622, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076691.3/1039/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

ALLALIN INVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour IBL LUXEMBOURG S.A.
FUDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

3076

OSDI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 13.416. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 14 juin 2005

Le mandat des administrateurs venant à échéance avec la présente assemblée, C.M.S. SERVICES LTD ne souhaitant

pas voir son mandat renouvelé, l’assemblée nomme aux postes d’administrateurs:

- Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant au 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange;
- Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant au 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange;
- IMMOLYS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony
Neuman, L-2241 Luxembourg;
et celui du commissaire aux comptes;
- SAFILUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony
Neuman, L-2241 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02185. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072883.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

UNITED PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 12.779. 

EXTRAIT 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juillet 2005 que: 
Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-

bourg est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur Edmond Ries, administrateur dé-
missionnaire. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels au 30 juin 2007.

Luxembourg, le 3 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02098. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072896.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

RAVAL EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, Z.I. rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 89.008. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Foetz le 10 mai 2005 

<i>Ordre du jour:

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) La démission au poste d’administrateur de Monsieur Yoram Israeli. 

<i>Résolution

L’assemblée décide à l’unanimité de:
1) accepter la démission au poste d’administrateur de Monsieur Yoram Israeli.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance s’est levée à 11.00 heures.
Le secrétaire donne lecture du procès-verbal lequel est signé par les membres du bureau et les associés ou manda-

taires qui en expriment le désir. 

Dont procès-verbal.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02998. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072899.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

E. Grumberg / Ch. Gaioni / S. Igri
<i>Le Président / <i>Le Secrétaire / <i>Le scrutateur

3077

STONES STEAK HOUSE STRASSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 265, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.634. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04889, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074832.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2005.

STONES STEAK HOUSE STRASSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 265, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.634. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04904, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074833.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2005.

STONES STEAK HOUSE STRASSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 265, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.634. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04906, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074827.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2005.

LEXINGTON CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 100.940. 

<i>Extrait du contrat de cession de parts signé le 14 juin 2005

En vertu de l’acte de cession de parts du 14 juin 2005,
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., demeurant au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré

125 parts détenues dans la société à

CALICO LIMITED en tant que trustee du CALICO TRUST, ayant son siège social au 50-64 Customhouse Quay, Wel-

lington, Nouvelle Zélande.

Les associés de la société sont à présent:
CALICO LIMITED en tant que trustee du CALICO TRUST: 125 parts sociales.

Luxembourg, le 3 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02600. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072922.3/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

EURO-LAND, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 22.222. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06351, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076608.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. 
Signatures

Luxembourg, le 25 août 2005.

Signatures.

3078

THE LEARNING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 44.225. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05277, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076583.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

THE LEARNING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 44.225. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05279, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076585.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

LUCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 33.481. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 13 juillet 2005 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2005:

- Monsieur Joao Paulo Dupuich Pinto de Castello Branco, administrateur de sociétés, demeurant à Lisbonne, Tv. Do

Moinho de Vento N

°

 8, Administrateur-Délégué;

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg;

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2005:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02441. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072902.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

ONOCLEA CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 104.841. 

<i>Extrait du contrat de cession de parts signé le 14 juin 2005

En vertu de l’acte de cession de parts du 14 juin 2005,
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., demeurant au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré

125 parts détenues dans la société à

COCOA LIMITED en tant que trustee du COCOA TRUST, ayant son siège social au 50-64 Customhouse Quay,

Wellington, Nouvelle Zélande.

Les associés de la société sont à présent:
COCOA LIMITED en tant que trustee du COCOA TRUST: 125 parts sociales.

Luxembourg, le 4 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02598. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072925.3/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Luxembourg, le 25 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 25 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 4 août 2005.

Signature.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

3079

EUROGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.

R. C. Luxembourg B 98.444. 

<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 juillet 2005

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROGEST S.A., ayant son

siège social à L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach,

- constituée suivant l’acte du Maître Camille Mines, notaire à Clervaux le 25 novembre 1994, publiée au Mémorial C

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 113 du 10 mars 1995, page 5403,

- inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous le numéro

B 98.444,

- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 27 juin 1995,
- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 7 avril 2000,
- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 23 mai 2000,
- modifiée par l’Assemblée Générale du 26 juin 2001, publiée au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associa-

tions, numéro 1126 du 25 juillet 2002, page 54030,

- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 janvier 2004, publiée au Mémorial C Recueil Spécial des

Sociétés et Associations, numéro 227 du 25 février 2004, page 10861,

- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 janvier 2004, publiée au Mémorial C Recueil Spécial des

Sociétés et Associations, numéro 383 du 8 avril 2004, page 18344,

- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mars 2004, publiée au Mémorial C Recueil Spécial des So-

ciétés et Associations, numéro 767 du 27 juillet 2004, page 36722,

- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 août 2004,
- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 août 2004.
L’assemblée est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de Mademoiselle Véronique Fink, demeurant à B-4960 Mal-

medy, rue des Princes-Abbés 6, qui designe comme secrétaire, Madame Netty Turmes, demeurant à L-9710 Clervaux,
3, Grand-rue. L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Nancy Querinjean, démeurant à B-4960 Geromont,
23, Chemin du Lêfa.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose.
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de deux administrateurs.
2. Nomination d’un nouvel administrateur.
3. Acceptation de la démission de l’administrateur-délégué.
4. Nomination d’un nouvel administrateur-délégué.
5. Acceptation de la démission du Président du Conseil d’Administration.
6. Nomination d’un nouveau Président du Conseil d’Administration.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires et le nombre d’actions des actionnaires,

sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, est signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les
membres du bureau de l’assemblée.

III. Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

L’assemblée générale extraordinaire, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’accepter, à partir du 21 juillet 2005, la démission des deux administrateurs suivants:
- Mademoiselle Isabelle Bertrand, née le 10 juin 1979 à St-Vith (B), demeurant à B-4770 Amel, Deidenberg 167.
- Madame Anne Schmitz, née le 27 novembre 1920 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-9709 Clervaux, route de Mar-

nach 7.

Et leur donne quitus de leur gestion jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur, à partir de ce jour, Mademoiselle Nancy Querinjean,

née le 5 décembre 1983 à Malmedy (B), demeurant à B-4960 Malmedy, 23, Chemin du Lêfa.

Son mandat prendra fin, lors de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille onze.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Mademoiselle Isabelle Bertrand, née le 10 juin 1979 à St Vith (B), de-

meurant à B-4770 Amel, Deidenberg 167, en tant qu’administrateur-délégué à partir du 21 juillet 2005.

Et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur-délégué, à partir de ce jour, Mademoiselle Véronique

Fink, née le 29 décembre 1983 à Malmedy (B), demeurant à B-4960 Malmedy, 6, rue des Princes-Abbés.

Son mandat prendra fin, lors de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille onze.

3080

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission du Président du Conseil d’Administration Mademoiselle Isabelle Bertrand,

née le 10 juin 1979 à St Vith (B), demeurant à B-4770 Amel, Deidenberg 167.

Et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveau Président du Conseil d’Administration Mademoiselle Véronique

FINK, née le 29 décembre 1983 à Malmedy (B), demeurant à B-4960 Malmedy, 6, rue des Princes-Abbés, avec le pouvoir
de signature isolée. 

Son mandat prendra fin, lors de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille onze.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 10.15 heures.

Enregistré à Diekirch, le 26 juillet 2005, réf. DSO-BG00152. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902518.3/826/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 août 2005.

U.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.926. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 21 

<i>juin 2005

La société MAZARS, Réviseurs d’entreprises &amp; Experts-comptables, avec siège à L-2530 Luxembourg, 10, rue Henri

M. Schnadt, est nommée réviseur externe à la place de la PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., réviseur externe sortant,
pour lequel son mandat vient à échéance lors de la présente assemblée. Le mandat du nouveau réviseur viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02942. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072931.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

MEGINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.238. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04324, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076596.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

MEGINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.238. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04326, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076595.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

V. Fink / N. Turmes / N. Querinjean
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Pour extrait sincère et conforme
U.P. S.A.
A. Vergani / G. Casartelli
<i>Président / Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

3081

YAGO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.578. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05531, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076591.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

LINIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 50.909. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05250, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076592.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

ARGUEDAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 68.062. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06352, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076605.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

PELICAN 10, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 102.619. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06354, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076606.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

ETS NELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7540 Rollingen-Mersch, 179, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 99.204. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05929, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076619.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

YAGO IMMOBILIERE S.A.
C. Schlesser
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Echternach, le 25 août 2005.

Signature.

3082

FINANMAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 47.951. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06350, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076607.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

MUCORA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.329. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06348, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076609.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

MEDINA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 43.921. 

Le bilan et l’annexe au 31 mars 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg le 25 août 2005, réf. LSO-BH06349, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076611.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

SOCIETE HOLLANDO-SUISSE DE PARTICIPATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 3.557. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06358, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076612.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

NEWVALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 62.331. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06346, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076614.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 25 août 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 25 août 2005.

Signatures.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 25 août 2005.

Signatures.

3083

ESPACE PROMOTION HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.552. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06371, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076616.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

GEDRENKSBUTTEK KLEYR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 94.035. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05931, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076621.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

FINANGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 94.079. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06362, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076622.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

IMEX EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 63.638. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05933, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076624.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

EVERWOOD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 99.754. 

Le bilan et l’annexe pour la période allant du 22 mars 2004 au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et

informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06385, ont été déposés au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076640.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Echternach, le 25 août 2005.

Signature.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Echternach, le 25 août 2005.

Signature.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

3084

PADOSTOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 10, rue d’Audun.

R. C. Luxembourg B 93.867. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05938, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076629.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

PADOSTOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 10, rue d’Audun.

R. C. Luxembourg B 93.867. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05940, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076630.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

K &amp; K DENTAL DESIGN, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6490 Echternach, 37, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 99.634. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05954, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076626.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

LEORADO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, rue d’Esch.

R. C. Luxembourg B 104.198. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05936, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076628.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

RODASIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Mertert, 34, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 94.165. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05943, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076632.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

AMELIA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 54.081. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06375, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076637.3/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Echternach, le 25 août 2005.

Signature.

Echternach, le 25 août 2005.

Signature.

Echternach, le 25 août 2005.

Signature.

Echternach, le 25 août 2005.

Signature.

Echternach, le 25 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 25 août 2005.

Signature.

3085

GEOPARTNER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3321 Berchem, 5, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 94.973. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 17 août 2005, réf. LSO-BH00110, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076638.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

CAMPING SIMMERSCHMELZ II A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-8363 Septfontaines.

R. C. Luxembourg B 52.296. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 17 août 2005, réf. DSO-BH00108, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076641.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

FLOUH- AN SAMMLERCLUB LËTZEBUERG STAD - MUSELFRËNN REIMECH, 

Association sans but lucratif.

Siège social: L-2728 Luxembourg, 11, rue Jules Wilhelm.

R. C. Luxembourg F 1.207. 

STATUTS

Entre les soussignés (Nom, Prénom, Profession, Domicile, Nationalité)
1) Dax Roland, fonctionnaire d’Etat en retraite, 11, rue Jules Wilhelm, L-2728 Luxembourg, nationalité luxembour-

geoise;

2) Kirchen Albert, retraité, 29, rue Principale, L-6990 Rameldange, nationalité luxembourgeoise;
3) Reinert Martine, employée d’Etat, 10, rue Gaaschtbierg, L-8230 Mamer, nationalité luxembourgeoise;
4) Goedert Karin, 8, rue Schortgen, L-4318 Esch-sur-Alzette, nationalité luxembourgeoise;
5) Magnoni Jean-Claude, 8, rue Schortgen, L-4318 Esch-sur-Alzette, nationalité luxembourgeoise;
6) Frantzen Pascale, fonctionnaire d’Etat, 16, rue de Filsdorf, L-5717 Aspelt, nationalité luxembourgeoise;
7) Maringer Carlo, indépendant, 10, rue Gaaschtbierg, L-8230 Mamer, nationalité luxembourgeoise;
8) Zender Josette, femme au foyer, 11, rue Jules Wilhelm, L-2728 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise;
9) Back Suzette, retraitée, 29, rue Principale, L-6990 Rameldange, nationalité luxembourgeoise;
et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est constituée une association sans but lucratif, régie par la

loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22
février 1984 et 4 mars 1994 ainsi que par les présents statuts.

Chapitre I

er

.- Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination FLOUH- AN SAMMLERCLUB LËTZEBUERG STAD - MUSELFRËNN

REIMECH, Association sans but lucratif, marchés aux puces et collectionneurs.

Art. 2. Le siège de l’association est établi à Luxembourg.

Art. 3. La durée de l’association est illimitée.

Art. 4. L’association a pour objet de collectionner des articles de brocante et de collection.
Constitution du comité:  

Chapitre 2.- Membres

Art. 5. Le nombre des membres est illimité: il ne peut cependant être inférieur à trois.

Diekirch, le 25 août 2005.

Signature.

Diekirch, le 25 août 2005.

Signature.

1) Président 

Dax Roland 

2) Vice-président 

Kirchen Albert 

3) Secrétaire 

Reinert Martine 

4) Trésorier 

Goedert Karine 

5) Réviseur de Caisse 

Frantzen Pascale 

6) Réviseur de Caisse 

Magnoni Jean-Claude 

7) Membre (Responsable Presse et Publicité)  Maringer Carlo 
8) Membre 

Back Suzette 

9) Membre 

Zender Josette 

Fait à Luxembourg, le 25 août 2005.

Signatures.

3086

Art. 6. Peuvent devenir membres actifs toutes personnes manifestant leur volonté déterminée à observer les pré-

sents statuts et agréées par le comité.

Art. 7. Peuvent devenir membres donateurs toutes personnes qui, sans prendre part activement au fonctionnement

de l’association, lui prêtent une aide financière annuellement selon une cotisation fixée par l’article 9 des présents statuts
et modifiable annuellement sur décision de l’assemblée générale.

Art. 8. Le Comité peut conférer le titre de membre d’honneur à des personnes qui ont rendu des services ou fait

des dons à l’association.

Art. 9. La cotisation annuelle pour les membres est fixée à 7,50 EUR (sept euros, cinquante centimes).

Art. 10. La qualité de membre se perd: 
1. par démission écrite au comité;
2. par exclusion prononcée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents pour violation

des statuts ou pour tout autre motif grave;

3. par décès.

Art. 11. Le membre démissionnaire et exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement

des cotisations.

Chapitre 3.- Du comité

Art. 12. L’association est administrée par un comité qui se compose d’un nombre impair de membres compris entre

3 et 11 dont le président, le secrétaire et le trésorier. 

Les membres du comité sont élus pour 1 an par l’assemblée générale. Lorsqu’un administrateur cesse ses fonctions

avant l’expiration de son mandat, le comité peut provisoirement prévoir son remplacement jusqu’à la prochaine assem-
blée générale.

Le membre du comité alors élu achèvera le mandat de son prédécesseur.
Les membres sortants sont rééligibles.
Les membres du comité désignent entre eux pour la durée de 1 an un président, un secrétaire et un trésorier. Ils

sont rééligibles.

Les candidatures pour un mandat au sein du comité doivent être adressées (par écrit) au président (au plus tard 48

heures) avant l’assemblée générale.

Art. 13. Le comité se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent sur convocation du président.

Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix, émises par les membres présents.

Art. 14. Le comité a les pouvoirs les lus étendus pour l’administration et la gestion de la société. Tout ce qui n’est

pas expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.

Art. 15. L’association est engagée en toute circonstance par la signature conjointe du président et du secrétaire ou

du trésorier.

Chapitre 4.- De l’assemblée générale

Art. 16. L’assemblée générale se réunit annuellement dans le courant du mois de janvier au jour, heures et lieu dans

l’avis de convocation.

Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu’elle est convoquée par le comité ou lorsqu’un cinquième des

associés en fait la demande.

Les convocations sont faites huit jours au moins à l’avance par voie de presse et / ou par lettres individuelles indiquant

obligatoirement l’ordre du jour.

Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents (en cas de partage la

voix du président est déterminante) sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.

Chaque membre de l’assemblée a une voix.
Les membres peuvent se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre par procuration écrite. Aucun

membre ne peut représenter plus que deux membres.

Art. 17. L’assemblée générale délibère sur la nomination et la révocation des administrateurs. L’assemblée générale

entend les rapports du comité sur la situation financière de l’association.

Elle se prononce sur les comptes de l’exercice écoulé, sur le prochain budget et délibère sur les questions à l’ordre

du jour.

Deux réviseurs de caisse, non membres du comité, sont désignés annuellement par l’assemblée générale.

Chapitre 5.- Divers

Art. 18. Les statuts pourront être modifiées conformément aux dispositions prévues par les articles 4, 8 et 9 de la

loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994, sur les associations sans
but lucratif.

Art. 19. La dissolution de l’association est régie par l’article 20 de la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée

par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Art. 20. En cas de dissolution de l’association, les fonds de l’association reviendront, après apurement de toutes les

dettes, charges et frais de liquidation, à une bienfaisance.

3087

Art. 21. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se référeront à la loi du 21 avril 1928, telle

qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 sur les associations et les fondations sans but
lucratif.

Art. 22. L’assemblée constituante, qui s’est réunie à Luxembourg le 24 août 2005 a approuvé les présents statuts.
Suivant les signatures

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

De suite, les soussignés prénommés, fondateurs de l’association, se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité et sur ordre du jour conforme la résolution
suivante.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06696. – Reçu 397 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077146.3/000/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

PRIFOT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 46.008. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06379, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076642.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

CELAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 74.244. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06392, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076643.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

HYPRAHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 40.084. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue anticipativement le 28 juin 2005

- La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Mademoiselle Carole Caspari, démissionnaire est
ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05924. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076903.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Signatures.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
HYPRAHOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

3088

BALTHASAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 99.905. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06079, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076644.3/1369/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

CAMEO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.081. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06077, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076645.3/1369/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

INVESTITIONSGESELLSCHAFT DER ARDENNEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1

er

.

R. C. Luxembourg B 55.737. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05386, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076649.3/1268/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

VERSBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 64.249. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05390, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076651.3/1268/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

OLLIOULES PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 103.224. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05393, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076653.3/1268/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

IMMOVACANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 62.463. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05378, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076670.3/1268/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Luxembourg, le 26 août 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 26 août 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 25 août 2005.

M.-B. Wingerter De Santeul.

Luxembourg, le 25 août 2005.

M.-B. Wingerter De Santeul.

Luxembourg, le 25 août 2005.

M.-B. Wingerter De Santeul.

Luxembourg, le 25 août 2005.

M.-B. Wingerter De Santeul.

3089

BARI HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1325 Luxemburg, 1, rue de la Chapelle.

H.R. Luxemburg B 39.008. 

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendundfünf, am achten Juli.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz zu Mersch (Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Jean Wagener, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
handelnd in seiner Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter der Gesellschaft BONN FINANZ BVF, mit Sitz in Tortola,

BVI,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 7. Juli 2005, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage

beigefügt bleibt.

Der Erschienene, namens wie er handelt, hat den unterzeichneten Notar ersucht nachstehende Erklärungen zu

beurkunden:

Die Aktiengesellschaft BARI HOLDING S.A., mit Sitz in Luxemburg, wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde

vom 18. Dezember 1991, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 239 vom 4. Juni 1992 und die Satzung
wurde abgeändert gemäss Urkunde unter Privatschrift vom 4. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C,
Nummer 1261 vom 29. August 2002.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 100.000,- (einhunderttausend Euro) eingeteilt in 4.000 (viertausend) Aktien

mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).

Die Gesellschaft BONN FINANZ BVF, vorgenannt, ist Besitzerin sämtlicher Aktien der vorgenannten Gesellschaft

BARI HOLDING S.A. vorbenannt, geworden. 

Die alleinige Aktienbesitzerin erklärt die Gesellschaft BARI HOLDING S.A., vorbenannnt, mit sofortiger Wirkung

aufzulösen. Sie übernimmt die Funktion des Liquidators.

Sie hat Kenntnis von der Satzung der Gesellschaft und ist genauestens über die finanzielle Lage der Gesellschaft

informiert.

Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates erteilt.
In ihrer Eigenschaft als alleinige Aktienbesitzerin erklärt die Gesellschaft BONN FINANZ BVF alle Aktiva der Gesell-

schaft zu übernehmen und alle Passiva zu regeln; die Passiva müssen abgeschlossen oder gedeckt sein vor der Übertra-
gung der Aktiva an die alleinige Aktienbesitzerin.

Auf Grund dieser Fakten erklärt der Notar die Gesellschaft als aufgelöst.
Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute in 1325 Luxemburg, 1, rue de la

Chapelle, hinterlegt.

Worüber Urkunde, enthaltend zwei Blankostellen, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Wagener, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 juillet 2005, vol. 432, fol. 42, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt, Recueil des Sociétés et Associations. 

(080322.3/242/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 37.803. 

<i>Beschluss des Verwaltungsrates vom 3. Juni 2005

1. Mit Wirkung zum 3. Juni 2005 legen Herr Henri Stoffel und Herr Alain Weber ihre Geschäftsleitungsmandate

nieder.

2. Mit Wirkung zum 3. Juni 2005 wird die Geschäftsführung an Herrn Guy Schmit und an Herrn Dr. Oliver Schlick

übertragen.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06457. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076889.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Mersch, den 16. August 2005.

H. Hellinckx.

Luxemburg, den 1. August 2005.

A. Weber / G. Schmit.

3090

MEDIA TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 40.016. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06337, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076665.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

SOLUXOL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 6.077. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06343, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076666.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

IMELU S.A., Société Anonyme.

Siège social: 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 75.377. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06370, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2005.

(076667.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

CETIRI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 45.148. 

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, en-

registrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06339, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076668.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

STOCKWELL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 40.220. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06388, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076669.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Luxembourg, le 25 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 25 août 2005.

Signatures.

LUCAS COMPANY SERVICES S.A.
Signature

Luxembourg, le 25 août 2005.

Signatures.

Signatures
<i>Administrateurs

3091

WESTING PETROLEUM S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1325 Luxemburg, 1, rue de la Chapelle.

H.R. Luxemburg B 12.363. 

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendundfünf, am achten Juli.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz zu Mersch (Luxemburg).

Ist erschienen:

HALKETT S.A., Gesellschaft des panamesischen Rechtes, mit Sitz in Panama City, Edificio Eastern 12, Avenida

Federico Boyb, Republik Panama,

hier vertreten durch Herrn Jean Wagener, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht ausgestellt am 8. Juli 2005.
Der Erschienene, namens wie er handelt, hat den unterzeichneten Notar ersucht nachstehende Erklärungen zu

beurkunden:

Die Aktiengesellschaft WESTING PETROLEUM S.A., mit Sitz in Luxemburg, wurde gegründet gemäss notarieller

Urkunde vom 31. Juli 1974, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 206 vom 17. Oktober 1974 und die
Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss notarieller Urkunde vom 18. September 1997.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt USD 50.000,- (fünfzigtausend U.S. Dollar) eingeteilt in 500 (fünfhundert) Aktien

mit einem Nennwert von je USD 100,- (einhundert U.S. Dollar), welche voll eingezahlt sind.

Die Gesellschaft HALKETT S.A., vorgenannt, ist Besitzerin sämtlicher Aktien der vorgenannten Gesellschaft

WESTING PETROLEUM S.A. vorbenannt, geworden.

Die alleinige Aktienbesitzerin erklärt die Gesellschaft WESTING PETROLEUM S.A., vorbenannnt, mit sofortiger

Wirkung aufzulösen. Sie übernimmt die Funktion des Liquidators.

Sie hat Kenntnis von der Satzung der Gesellschaft und ist genauestens über die finanzielle Lage der Gesellschaft

informiert.

Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates erteilt.
In ihrer Eigenschaft als alleinige Aktienbesitzerin erklärt die Gesellschaft HALKETT S.A. alle Aktiva der Gesellschaft

zu übernehmen und alle Passiva zu regeln; die Passiva müssen abgeschlossen oder gedeckt sein vor der Übertragung der
Aktiva an die alleinige Aktienbesitzerin.

Auf Grund dieser Fakten erklärt der Notar die Gesellschaft als aufgelöst.
Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute in 1325 Luxemburg, 1, rue de la

Chapelle, hinterlegt.

Worüber Urkunde, Geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Wagener, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 juillet 2005, vol. 432, fol. 42, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Für gleichlautende kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt, Recueil des Sociétés et Associations. 

(080323.3/242/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

OPTIMAL SECURITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 69, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 77.670. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06251, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076787.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

OPTIMAL SECURITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 69, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 77.670. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06252, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076789.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Mersch, den 16. August 2005.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature.

3092

LOGITRANS EUROP S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.638. 

Le bilan et l’annexe au 30 juin 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06381, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076671.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

FIDEMON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3936 Mondercange, 4, op Feileschterkeppchen.

R. C. Luxembourg B 103.886. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06062, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076672.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

PARAGON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 18.228. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06368, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076673.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

INGERSOLL-RAND WORLDWIDE CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 89.900. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH06082, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076696.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

INGERSOLL-RAND WORLDWIDE CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 89.900. 

Les comptes consolidés au 31 décembre 2002, au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004 of INGERSOLL-RAND

COMPANY LIMITED, enregistrés à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06157, LSO-BH06163, LSO-BH06172,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076707.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature
<i>Le liquidateur

Strassen, le 25 août 2005.

Signature.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 23 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 23 août 2005.

Signature.

3093

E.C.G. DOMICILIATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 97.584. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BH00795, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076689.3/1039/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

PEINTURES BIWERSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 1, rue Gielebongert.

R. C. Luxembourg B 44.019. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BH00794, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076690.3/1039/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

PARC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 79.714. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05875, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076741.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

PARC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 79.714. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05878, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076740.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

PARC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 79.714. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05880, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076739.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature.

Signature.

<i>Pour PARC HOLDING S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG S.A.
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour PARC HOLDING S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG S.A.
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour PARC HOLDING S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG S.A.
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

3094

E.C.G. S.A., EXPERTISE COMPTABLE ET GESTION, Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 97.706. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BH00793, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076692.3/1039/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

DU FORT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.785. 

Le bilan consolidé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05125, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076709.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

AKELER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.047. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 25 août 2005.

(076738.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

FINSALUTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 43.430. 

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06340, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076742.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

NIAM III LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 101.197. 

RECTIFICATIF

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH00649, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2005.

(076807.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour AKELER HOLDINGS S.A.
J. Seckler
<i>Le notaire

Luxembourg, le 23 août 2005.

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

3095

ABM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.932. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06325, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076766.2/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

ABM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.932. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06328, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076821.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

ABM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.932. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06332, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076830.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

ABM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.932. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06333, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076837.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

ABM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.932. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06335, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076838.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

A.I. ASESORIA DE INVERSIONES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 57.469. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06321, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076759.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Luxembourg, le 22 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 24 août 2005.

Signature.

3096

DB SILVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 110.398. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fifth day of September.
Before Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), acting

in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain
depositary of the present deed.

There appeared the following:

DEUTSCHE BANK FINANCE INTERNATIONAL, GmbH, a company governed by the laws of Germany, having its

registered office at Mergenthalerallee 77, D-65760 Eschborn, Germany, registered with the register of commerce and
companies of Frankfurt am Main under number HRB 48541,

here represented by M

e

 Franck Cera, lawyer residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Eschborn (Germany), on 2 September 2005.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a

company:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established by the single shareholder a société à responsabilité limitée (the «Com-

pany») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the «Articles of
Incorporation»).

The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of DB SILVER, S.à r.l.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Board of Managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Managers.

In the event that in the view of the Board of Managers extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.

Art. 3. Object. The corporate object of the Company is:
- the investment in credit and FX-linked deposits with DEUTSCHE BANK AG;
- the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration,

development and management of such holdings.

The company may carry out any transactions, whether commercial or financial which are directly or indirectly con-

nected with its corporate object at the exclusion of any banking activity.

In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of the above purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quo-

rum and majority rules provided by law.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Capital. The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

divided into five hundred (500) shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully
paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

The authorised capital is fixed at one million Euro (EUR 1,000,000.-) to be divided into forty thousand (40,000) shares

with a par value of twenty five Euro (EUR 25.-) per share.

3097

The Board of Managers is authorized and empowered during a period ending five years after the publication date of

the articles of association in the Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Mémorial C, to realise any increase of the
capital within the limits of the authorised capital in one or several times.

The new issued shares further to the increase of the capital within the limits of the above authorised capital can only

be subscribed by existing shareholders at the time of the increase of the capital.

Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Board of

Managers may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the authorised shares to be
subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the authorised shares to be subscribed and
issued, to determine if the authorised shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to
what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either on cash or assets other than cash.

The Board of Managers may delegate to any duly authorised Manager or officer of the Company or to any other duly

authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of

this article will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in authentic form by
the Board of Managers or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced

in one or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the
quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment
of these Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.

Chapter III. Board of managers, Statutory auditors

Art. 9. Board of Managers. The Company will be managed and administered by a board of managers (the «Board

of Managers») composed of at least three members who need not be shareholders (the «Managers»).

The Managers will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their

number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re
eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a
resolution of the shareholders’ meeting.

Art. 10. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers will appoint from among its members a

chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet at least quarterly in Luxembourg upon call by the Chairman. A meeting of the Board

of Managers must be convened if any two Directors so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers and of the shareholders (if any), except that in

his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours’ written

notice of board meetings shall be given in writing, by fax, by telegram or by electronic mail. Any such notice shall specify
the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may
be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings
held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, by fax or by telegram another

Manager as his proxy.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with

3098

each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. For the avoidance of
doubt, in case such means are used, such participating Managers must be present on the Luxembourg territory at the
time of the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers.

Art. 11. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers

will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 12. Powers of the Board of Managers. The Board of Managers is vested with the broadest powers (except

for those powers which are expressly reserved by law to the general meeting of shareholders) to perform all acts nec-
essary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles
of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Board
of Managers.

Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust de-

termined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Art. 14. Liability of the Managers. No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-

tion in relation to the commitment taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a director, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except
as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a director, associate, officer
or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not,
by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s interest therein shall be reported to the
single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

Art. 16. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-

ture of any two Managers or by the sole signature of the person to whom the daily management of the Company has
been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such
signatory power has been delegated by the Board of Managers, but only within the limits of such power.

Art. 17. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be.

Chapter IV. Meeting of shareholders

Art. 18. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter

exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of
10 August 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by fax. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days
as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and fax it to the Company. 

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by
shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law
will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. 

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board

of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 19. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

3099

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles of Incorporation, it has the

broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 20. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice convening the meeting on 15 May of each year.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 21. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman or by any member of the Board of Managers.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 22. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day

of December in every year.

Art. 23. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board

of Managers draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accord-
ance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-

ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 24. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends. The

Board of Managers fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 25. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by

a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensa-
tion.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable law

Art. 26. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. 

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately thousand four hundred Euro.

Shareholder

subscribed

number

amount

capital (EUR)

 of shares

 paid-in (EUR)

DEUTSCHE BANK FINANCE INTERNATIONAL, GmbH, pre-

named . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12,500.-

500

12,500.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12,500.-

500

12,500.-

3100

<i>Transitory provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of 31 December

2005.

<i>Extraordinary general meeting

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the fol-

lowing as Managers for a period ending at the general meeting of shareholders approving the annual accounts for the
year ending on 31 December 2005:

1) Mr Werner Burg, Banker, with professional residence at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;
2) Mr Rolf Caspers, Banker, with professional residence at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;
3) Mr Tom Verheyden, Banker, with professional residence at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

<i>Second Resolution

The registered office shall be at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

The sole shareholder resolved to allocate the sum of one thousand two hundred and fifty euro (1,250.- EUR) to the

legal reserve.

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the German text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung vorherstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundfünf, am fünften Tag des Monats September. 
Vor dem unterzeichneten Notar André Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz zu Luxemburg (Großherzogtum

Luxemburg), in Vertretung von Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxem-
burg), in dessen Besitz und Verwahr gegenwärtige Urkunde verbleibt. 

Ist erschienen:

DEUTSCHE BANK FINANCE INTERNATIONAL,GmbH, eine Gesellschaft deutschen Rechts, mit eingetragenem

Sitz in Mergenthaleralle 77, D-65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen in dem Handelsregister von Frankfurt am Main,
unter der Nummer HRB 48541,

hier vertreten durch M

e

 Franck Cera, Rechtsanwalt wohnhaft in Luxemburg,

auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, erstellt am 2. September 2005 in Eschborn (Deutschland).
Die Vollmacht, von dem Komparenten und dem instrumentierenden Notar unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Ur-

kunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.

Dieser Komparent, handelnd wie erwähnt, hat den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag aufgestellt:

Kapitel I. Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form, Name. Durch den Alleingesellschafter ist hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die

«Gesellschaft»), die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, und hauptsächlich dem Gesetz vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften, in seiner zuletzt geltenden Fassung, dem Artikel 1832 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs Luxemburgs und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die «Satzung») unterliegt.

Die Gesellschaft besteht ursprünglich aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist. Die

Gesellschaft kann jedoch zu jeder Zeit insbesondere nach einer Übertragung oder einer Neuausgabe von Gesellschafts-
anteilen aus mehreren Gesellschaftern bestehen, deren Zahl vierzig (40) nicht übersteigen darf.

Die Gesellschaft existiert unter dem Namen DB SILVER, S.à r.l.

Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Stadt Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann aufgrund eines Beschlusses des Geschäftsführungsrates an jeden anderen Ort innerhalb

der Stadt Luxemburg verlegt werden.

Zweigniederlassungen oder andere Büros der Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland können

durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden.

Sollte der Geschäftsführungsrat der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher

oder sozialer Art eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft am
Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz beziehungsweise zwischen dem Gesellschaftssitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur völligen Beilegung
der außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei
Auswirkungen auf den Statut der Gesellschaft, welche unbeschadet der provisorischen Verlegung ihres Sitzes weiterhin
den luxemburgischen Gesetzen unterliegt. Diese vorübergehenden Maßnahmen sind von einem der Organe oder Per-
sonen, die mit der täglichen Geschäftsführung betraut sind, zu beschließen und den hiervon betroffenen Personen mit-
zuteilen.

Art. 3. Ziel. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst:
- die Investierung in Kredit- und FX-gebundene Depots mit der DEUTSCHEN BANK AG;

3101

- die Akquisition und das Halten von Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie

die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft vermag jede Tätigkeit, sei sie kommerzieller oder finanzieller Natur, welche in direktem oder indi-

rektem Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck steht, auszuüben, mit Ausnahme jeglicher Bankentätigkeit.

Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, die ihrem Er-

messen nach zur Ausführung und Entwicklung oben angeführter Zwecke dienen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Die Gesellschaft kann durch eine Entscheidung des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, welche

unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Quorum und Mehrheitsregeln abstimmt, aufgelöst werden.

Kapitel II. Kapital, Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünf-hundert Euro

(EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile, mit einem Nennwert von jeweilig fünfundzwanzig Euro (EUR
25,-), welches vollständig eingezahlt wurde. 

Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgel-

der, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses Auf-
geldkontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zum Ausgleich
von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter oder zur Bereitstellung der gesetzlichen Rückstel-
lung genutzt werden.

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt eine Million Euro (EUR 1.000.000,-), aufgeteilt in vierzigtausend

(40.000) Anteile mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Der Geschäftsführungsrat ist ermächtigt, binnen fünf Jahren nach dem Datum der Veröffentlichung der Satzung in dem

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Mémorial C, das Kapital einmalig oder mehrfach in den Grenzen des ge-
nehmigten Kapitals zu erhöhen.

Die im Rahmen der in den Grenzen des genehmigten Kapitals neu ausgegebenen Anteile können zum Zeitpunkt der

Kapitalerhöhung lediglich von den bestehenden Gesellschaftern gezeichnet werden.

Der Geschäftsführungsrat legt die Bedingungen für die Zeichnung und Ausgabe des somit erhöhten Betrages des Ka-

pitals fest, hauptsächlich in Bezug auf die Zeichnung und die Bezahlung der zu zeichnenden und auszugebenden geneh-
migten Anteile, die Festlegung des Zeitpunkts und des Betrages der zu zeichnenden und auszugebenden genehmigten
Anteile, die Entscheidung ob die genehmigten Anteile mit oder ohne Aufgeld gezeichnet werden, die Entscheidung in-
wiefern die Bezahlung der neu unterzeichneten Anteile durch Barbezahlung oder andere Einlagen als Barzahlung an-
nehmbar ist.

Der Geschäftsführungsrat kann einen Geschäftsführer oder Vertreter der Gesellschaft oder jede andere rechtmäßig

bevollmächtigte Person damit beauftragen Zeichnungen anzunehmen und Zahlungen für Anteile welche einem Teil oder
sämtlichen damit erhöhten Beträge des Kapitals entsprechen entgegenzunehmen.

Nach jeder Kapitalerhöhung, welche gemäß der von dem Gesetz vorgeschriebenen Form durchgeführt und festge-

halten worden ist, wird der erste Artikel dieser Satzung gemäß der gegebenen Kapitalerhöhung abgeändert; diese Ab-
änderung wird in authentischer Form von dem Geschäftsführungsrat oder von einer durch den Geschäftsführungsrat zu
diesem Zweck bevollmächtigten Person festgehalten.

Art. 6. Anteile. Jeder Anteil gibt im Verhältnis zu der Summe der bestehenden Anteile ein Recht auf einen Bruchteil

der Gewinne und des Gesellschaftsvermögens, sowie zur Abgabe einer Stimme bei der Gesellschafterversammlung. Das
Eigentum an einem Anteil beinhaltet implizit das Einverständnis zu den Bedingungen der Satzung und den Beschlüssen
des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung.

In Bezug auf die Gesellschaft ist jeder Anteil unteilbar.
Steht ein Gesellschaftsanteil mehreren Mitberechtigten gemeinschaftlich zu, so können sie die Rechte aus diesem nur

durch einen gemeinsamen Vertreter, welcher nicht unbedingt ein Mitberechtigter sein muß, ausüben.

Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen wenn er der einzige Gesellschafter der Gesellschaft ist.

Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. An Nichtgesell-
schafter dürfen die Anteile nur mit dem bei einer Gesellschafterversammlung erklärten Einverständnis der Gesellschaf-
ter, die mindestens drei Viertel des Kapitals darstellen, übertragen werden.

Die Übertragung von Anteilen muss durch eine notarielle Urkunde oder durch einen privatschriftlichen Vertrag be-

legt werden. Solange eine solche Übertragung der Gesellschaft nicht ordnungsgemäß angezeigt oder von ihr angenom-
men worden ist, gemäß den in Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuchs festgelegten Regeln, ist jene Übertragung der
Gesellschaft und Dritten gegenüber nicht bindend.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile gemäss dem Gesetz zurückkaufen.

Art. 7. Erhöhung oder Herabsetzung des Kapitals. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft kann einmalig

oder mehrfach durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, der in Überein-
stimmung mit den, nach dieser Satzung oder den zur Änderung dieser Satzung ergangenen Gesetzen, erforderlichen
Quoren und Mehrheiten, angenommen wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 8. Handlungsunfähigkeit oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die Handlungsunfähigkeit oder Insolvenz

oder ein vergleichbarer, den Alleingesellschafter oder einen anderen Gesellschafter betreffenden Umstand hat nicht die
Auflösung der Gesellschaft zur Folge. 

3102

Kapitel III. Geschäftsführer, Revisoren

Art. 9. Verwaltung. Die Gesellschaft wird durch ein Gremium von Geschäftsführern (der «Geschäftsführungsrat»)

geleitet, das aus nicht weniger als drei Mitgliedern besteht, die nicht Gesellschafter sein müssen (die «Geschäftsführer»).

Die Geschäftsführer werden von dem Alleingesellschafter oder von der Gesellschafterversammlung gewählt, die ihre

Anzahl und ihre Amtsdauer, welche nicht sechs Jahre überschreiten darf, festlegen. Sie verbleiben bis zur Wahl ihrer
Nachfolger im Amt. Sie sind erneut wählbar und können jedoch jederzeit, mit oder ohne Angabe von Gründen, durch
einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung abberufen werden. 

Art. 10. Sitzungen des Geschäftsführungsrats. Der Geschäftsführungsrat ernennt aus seinen Mitgliedern einen

Vorsitzenden (der «Vorsitzende»). Der Geschäftsführungsrat kann ebenso einen Schriftführer ernennen, der nicht Mit-
glied des Geschäftsführungsrates sein muss und der für die Protokollführung während der Sitzungen des Geschäftsfüh-
rungsrates und der Gesellschafterversammlung verantwortIich ist.

Der Geschäftsführungsrat tritt nach Einberufung durch den Vorsitzenden mindestens jedes Quartal zusammen. Eine

Sitzung des Geschäftsführungsrats muss ferner auf Wunsch zweier seiner Mitglieder einberufen werden.

Der Vorsitzende steht allen Sitzungen des Geschäftsführungsrats und der Gesellschafterversammlung (falls es eine

solche gibt) vor, es sei denn, dass der Geschäftsführungsrat einen anderen Geschäftsführer und die Gesellschafterver-
sammlung eine andere Person wegen der Abwesenheit des Vorsitzenden als Vorsitzenden auf Zeit durch Wahl der an-
wesenden oder vertretenen Mehrheit in dieser Sitzung ernannt hat.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei einer vorher erteilten Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die

Sitzungen des Geschäftsführungsrats mindestens vierundzwanzig Stunden vor ihrem Termin schriftlich durch ein die
Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium einberufen. Jedes dieser Einberufungsschreiben soll Ort und
Zeit der Sitzung sowie die Tagesordnung und die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Jedes Mit-
glied des Geschäftsführungsrats kann schriftlich durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium
auf die Benachrichtigung verzichten. Für Sitzungen, deren Veranstaltungsort und Zeit in einem zuvor angenommenen
Beschluss des Geschäftsführungsrats festgelegt worden sind, ist keine gesonderte Benachrichtigung erforderlich.

Jede Geschäftsführungsratssitzung findet in Luxemburgstatt.
Jedes Geschäftsführungsratsmitglied kann sich bei den Geschäftsführungsratssitzungen durch ein anderes Geschäfts-

führungsratsmitglied vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich bevollmächtigt.

Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrats erfordert die Anwesenheit oder die Vertretung einer Mehrheit der

Mitglieder. Entschlüsse werden per Mehrheitsentscheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäfts-
führungsratsmitglieder gefasst.

Ein oder mehrere Geschäftsführungsratsmitglieder können an einer Sitzung durch eine Telefonkonferenzschaltung,

durch eine Videokonferenzschaltung oder durch ähnliche, gleichzeitige und gegenseitige Kommunikation zwischen den
Teilnehmern sicherstellende Mittel teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit in einer Sit-
zung gleichgestellt. Zur Vermeidung eines etwaigen Missverständnisses, sollten solche Mittel eingesetzt werden, so müs-
sen alle teilnehmende Geschäftsführer sich zum Zeitpunkt der Sitzung in Luxemburg befinden.

In Dringlichkeitsfällen steht eine von allen Geschäftsführungsratsmitgliedern unterzeichnete Entscheidung einem Be-

schluss gleich, der in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsratssitzung gefasst worden
wäre. Ein solcher Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben
Inhalts und jeweils von einem oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet festgehalten sein.

Art. 11. Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung. Die Protokolle der Geschäftsführungsratssitzung

werden von dem Vorsitzenden und, soweit vorhanden, dem Schriftführer unterzeichnet. Jede erteilte Vollmacht bleibt
dem Protokoll beigefügt.

Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, unter-

zeichnen der Vorsitzende und, soweit vorhanden, der Schriftführer oder zwei andere Mitglieder des Geschäftsführungs-
rates.

Art. 12. Befugnisse des Geschäftsführungsrats. Der Geschäftsführungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse

(mit Ausnahme derer die dem Gesetz zufolge ausdrücklich der Gesellschafterversammlung zustehen), um alle zur Errei-
chung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Tätigkeiten vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die die
Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich dem Alleingesellschafter oder der Gesellschafterversammlung übertragen
haben, fallen in die Zuständigkeit des Geschäftsführungsrates.

Art. 13. Übertragung von Befugnissen. Der Geschäftsführungsrat kann einer oder mehreren Personen seiner

Wahl besondere Befugnisse oder Vollmachten übertragen oder letztere mit dauernden oder zeitweisen Funktionen aus-
statten.

Art. 14. Haftung der Geschäftsführer. Ein Mitglied des Geschäftsführungsrates trifft keine persönliche Haftung

hinsichtlich der aufgrund seiner Funktion für die Gesellschaft eingegangen Verpflichtungen. Jedes Mitglied des Geschäfts-
führungsrates ist nur für die Ausführung seiner Aufgaben verantwortlich.

Art. 15. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgend-

einer anderen Gesellschaft oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt ist
oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer solchen Gesellschaft oder Firma ist. Vor-
behaltlich nachfolgender gegenteiliger Bestimmungen wird kein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Gesellschaft,
der als Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma, mit der die
Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte tätigt, infolge einer solchen Verbindung mit

3103

solch einer anderen Gesellschaft oder Firma zwangsläufig daran gehindert, über solche Verträge oder andere Geschäfte
betreffende Angelegenheiten zu beraten und diesbezüglich zu entscheiden oder zu handeln.

Nichtsdestotrotz dem Vorangegangenem, falls ein Geschäftsführer oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein

persönliches Interesse an einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse unbeschadet
des Vorangehenden dem Geschäftsführungsrat zur Kenntnis bringen und darf nicht an Beratungen bezüglich solcher
Rechtsgeschäfte teilnehmen oder darüber abstimmen, und diese Rechtsgeschäfte und Interessen eines Geschäftsführers
oder Bevollmächtigten sind dem Alleingesellschafter oder bei der nächsten Gesellschafterversammlung offenzulegen.

Art. 16. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die gemeinsame Unter-

schrift von zwei Geschäftsführern oder, im Rahmen der täglichen Geschäftführung, durch die alleinige Unterschrift der-
jenigen Person welche mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wurde, oder durch die gemeinsame oder einzelne
Unterschrift derjenigen Personen welchen die besondere Zeichnungsbefugnis von dem Geschäftsführungsrat übertragen
wurde, aber immer nur im Rahmen dieser besonderen Zeichnungsvollmacht, vertreten.

Art. 17. Revisoren. Die Geschäfte der Gesellschaft und ihre finanzielle Situation, einschließlich der Bücher und

Konten, können, und müssen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, von einem oder mehreren Revisoren, die nicht
Gesellschafter zu sein brauchen, durchgesehen werden.

Die Revisoren (falls es solche gibt) werden von dem Alleingesellschafter oder, wo dies der Fall ist, von der Gesell-

schafterversammlung, die ihre Anzahl festlegt, für eine Dauer von nicht mehr als sechs Jahren gewählt. Sie werden bis
zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt bleiben. Sie sind erneut wählbar und können jederzeit, mit oder ohne Angabe von
Gründen, durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, wo dies der Fall ist, der Gesellschafterversammlung, ab-
berufen werden.

Kapitel IV. Gesellschafterversammlung

Art. 18. Gesellschafterversammlung. Besteht die Gesellschaft nur aus einem Alleingesellschafter, übt dieser die

Befugnisse aus, die das Gesetz der Gesellschafterversammlung übertragen hat. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Ge-
setzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 sind hierauf nicht anwendbar.

Besteht die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig Gesellschaftern, können die Gesellschafter über den Text

der anzunehmenden Beschlüsse, der ihnen vom Geschäftsführungsrat schriftlich durch ein die Schriftlichkeit des Textes
gewährleistendes Medium übermittelt wird, in schriftlicher Abstimmung entscheiden. Im letzteren Fall sind die Gesell-
schafter verpflichtet innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Be-
schlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Medium
zukommen zu lassen.

Außer in Fällen eines Alleingesellschafters, können die Gesellschafter auf Einberufungsschreiben, ausgegeben in Über-

einstimmung mit dem luxemburgischen Gesetz durch den Geschäftsführungsrat, in zweiter Linie durch die Revisoren
und nachrangig nach diesen, durch die Gesellschafter, die die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, zusammentre-
ten. Das gemäß dem Gesetz an die Gesellschafter versandte Einberufungsschreiben gibt den Ort und die Zeit sowie die
Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftspunkte der jeweiligen Gesellschafterversammlung an.

Sind alle Gesellschafter bei einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, über die Ta-

gesordnung der Versammlung unterrichtet zu sein, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten
werden.

Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch eine die Schriftlichkeit wahrende Über-

tragungsweise übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst Ge-
sellschafter sein muss, vertreten lassen.

Gesellschafterversammlungen sowie die Jahresgesellschafterversammlung können außer Landes abgehalten werden,

wenn dies nach dem endgültigen Ermessensurteil des Geschäftsführungsrates durch die Umstände höherer Gewalt an-
gebracht ist.

Art. 19. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterver-

sammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Unter Vorbehalt aller dem Geschäftsführungsrat dem Gesetz oder der Satzung zufolge zustehenden Befugnisse, be-

sitzt die Gesellschafterversammlung die weitgehendsten Befugnisse alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Hand-
lungen der Gesellschaft auszuüben oder zu ratifizieren.

Art. 20. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die lediglich abzuhalten ist,

wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter hat, wird am Sitz der Gesellschaft oder an jedem anderen,
in der Hinweisbekanntmachung spezifizierten Platz am 15. Mai jeden Jahres abgehalten.

Fällt dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag, wird die Versammlung am nächstfolgenden Geschäftstag abgehalten.

Art. 21. Verfahren. Abstimmung. Bei jeder Gesellschafterversammlung, die zum Zwecke der Abänderung der

Satzung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, deren Annahme dieser Satzung oder gegebenenfalls dem Gesetz zufolge
den Quorum- oder Mehrheitserfordernissen einer Abänderung der Satzung unterliegt, einberufen wurde, werden Be-
schlüsse gültig, falls diese durch eine Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten,
angenommen werden.

Alle anderen Beschlüsse sind gültig falls diese durch eine Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens die Hälfte des

Kapitals vertreten, angenommen werden, es sei denn andere Mehrheitsverhältnisse werden gegebenenfalls von dem Ge-
setz oder der Satzung vorgeschrieben.

Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.
Kopien oder Auszüge der Protokolle der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig

übermittelt werden, unterzeichnen der Vorsitzende oder ein Mitglied des Geschäftsführungsrates.

3104

Kapitel V. Geschäftsjahr, Ausschüttung und verteilung von gewinnen 

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar eines jeden

Jahres und endet am letzten Tag des Monats Dezember desselben Jahres.

Art. 23. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Finanzjahres werden die Konten geschlossen und

der Geschäftsführungsrat erstellt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermö-
gensanlagen und Verpflichtungen, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Dieser Jahresabschluss wird dem Alleingesellschafter oder, wo dies der Fall ist, der Gesellschafterversammlung zur

Abstimmung unterbreitet.

Vor dieser Annahme, kann jeder Gesellschafter oder sein Berater die finanztechnischen Unterlagen am Gesellschafts-

sitz durchlesen. Besteht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während
einer Zeitspanne von fünfzehn Tagen vor dem Datum der Jahresgesellschafterversammlung ausgeübt werden.

Art. 24. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent

(5%) der gesetzlich vorgesehenen Rückstellung zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt, sobald und solange die gesetz-
liche Rückstellung die Höhe von zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung werden festlegen, wie der verbleibende Überschuss an

Reingewinn verteilt werden soll; ob durch vollständige oder teilweise Bildung einer Rückstellung oder als Zuweisung zu
einer Provisionszahlung; durch Übernahme bis in das nächste Geschäftsjahr oder durch Ausschüttung an die Gesellschaf-
ter.

Vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen kann der Geschäftsführungsrat eine Abschlagsdividende

auszahlen. Der Geschäftsführungsrat legt die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.

Kapitel VI. Auflösung, Abwicklung

Art. 25. Auflösung, Abwicklung. Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der

Gesellschafterversammlung, der in Übereinstimmung mit den zur Änderung dieser Satzung erforderlichen Quoren und
Mehrheiten gefasst worden ist, aufgelöst werden, unter Vorbehalt gegensätzlicher gesetzlicher Bestimmungen.

Wird die Gesellschaft aufgelöst, soll ihre Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt werden, die

von dem Alleingesellschafter oder der Gesellschafterversammlung, welche ebenfalls deren Befugnisse und Vergütung
festlegen, ernannt werden.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche sowie der Kosten des

Abwicklungsverfahrens wird der Reinerlös aus der Abwicklung an die Gesellschafter pro rata gemäß der Anzahl ihrer
Anteile verteilt.

Kapitel VII. Anwendbares recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind,

bestimmen sich nach den Gesetzen, insbesondere nach dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-
ten, in seiner zuletzt geltenden Fassung. 

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Satzung ist somit von der erschienenen Partei erstellt worden, welche nachstehende Anzahl von Anteilen ge-

zeichnet sowie folgende Beträge in bar eingezahlt hat: 

Beweis über alle diese Zahlungen wurde dem unterzeichnenden Notar überbracht welcher bezeugt, dass sämtliche

Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner zuletzt geltenden
Fassung, respektiert wurden.

<i>Geschätzte Kosten

Die Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entste-

hen, werden auf ungefähr tausendvierhundert Euro geschätzt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2005.

<i>Außerordentliche Gesellschafterversammlung

<i>Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt, die Anzahl der Geschäftsführer auf drei (3) festzulegen und folgende Personen für

einen Zeitraum, der mit der Annahme des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2005 abzuschließende Geschäfts-
jahr endet, zu Geschäftsführern zu wählen:

1) Herrn Werner Burg, Bankier, beruflich wohnhaft in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg;
2) Herrn Rolf Caspers, Bankier, beruflich wohnhaft in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg;
3) Herrn Tom Verheyden, Bankier, beruflich wohnhaft in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg.

Gesellschafter

Gezeichnetes

Anzahl der

Eingezahltes

Kapital (EUR)

Anteile

Kapital (EUR)

DEUTSCHE BANK FINANCE INTERNATIONAL, GmbH, vorge-

nannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,-

500

12.500,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,-

500

12.500,-

3105

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt, dass sich der Gesellschaftssitz in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxem-

burg, Großherzogtum Luxemburg, befindet.

<i>Dritter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt den Betrag von eintausendzweihundertundfünfzig Euro (1.250,- EUR) in die ge-

setzliche Rückstellung einzuzahlen.

Der unterzeichnende Notar, der des Englischen mächtig ist, erklärt hiermit, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der

weiter oben erwähnten Partei in englischer Sprache verfasst ist und von einer Fassung in deutscher Sprache gefolgt wird;
auf Antrag derselben Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der
englische Text.

Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg auf-

genommen wurde.

Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort be-

kannten, erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe vorliegende Urkunde mit dem unterzeichnenden No-
tar unterzeichnet. 

Gezeichnet: F. Cera, A. Schwachtgen.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 7. September 2005, Band 897, Blatt 8, Feld 7. – Erhalten 125 Euro.

<i>Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Oehmen.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080481.3/239/577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

NATURPARADIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-9905 Ulflingen, 37, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 107.631. 

<i>Kauf- und Abtretungsvertrag von Gesellschaftsanteilen 

Zwischen:
1. der SAPPHO S.A.,
mit Gesellschaftssitz in L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, eingetragen in das Handels- und Gesellschaftsregister

Luxemburg unter Nr. B 28.868, vertreten durch ihre Verwaltungsräte Herrn Daniel Reding, Herrn Guy Esch und Herrn
Yves Wallers,

Bevollmächtigter zum Abschluss des vorliegenden Vertrages gemäß Vollmacht vom 14. Juli 2005, Herr Wilfried

Keller, und

der ECP EUROPEAN COMMERCE PORT, S.à r.l.,
mit Gesellschaftssitz in L-9991 Weiswampach, 107, Auf dem Kiemel, eingetragen in das Handels- und Gesellschafts-

register Luxemburg unter Nr. B 96.276,

vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Wilfried Keller,
Verkäuferin von Gesellschaftsanteilen; 
und
2. Frau Bernadette Keller, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Gerbertraße 11, in ihrer Funktion als Geschäftsführerin der

NATURPARADIES, S.à r.l.,

Käuferin von Gesellschaftsanteilen.
Ist am heutigen Tage folgender Vertrag, zwecks Abtretung von Gesellschaftsanteilen, abgeschlossen worden:
1. Erklärung
Die Vertragspartei zu 1. erklärt hiermit, daß sie Gesellschafter der NATURPARADIES S.à.r.l., Gesellschaft mit

beschränkter Haftung Luxemburger Rechts, mit Sitz in L-9905 Ulflingen, 37, Grand-rue, gegründet am 30. April 1999
und im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen unter der N

°

 B 107.631, ist.

Das Gesellschaftskapital beträgt 12.394,68 EUR
(zwölftausenddreihundervierundneunzig Euro achtundsechzig Cent).
Das Gesellschaftskapital besteht aus 50 (fünfzig) Anteilen.
Die Anteile der NATURPARADIES, S.à r.l. sind zwischen den Gesellschaftern folgendermaßen verteilt:
SAPPHO S.A.: 48 (achtundvierzig) Anteile
ECP EUROPEAN COMMERCE PORT, S.à r.l.: 2 (zwei) Anteile 
2. Abtretung
Die Partei zu 1., die SAPPHO S.A. und die ECP EUROPEAN COMMERCE PORT, S.à r.l., vorgenannt, erklären hier-

durch abzutreten und frei zu übertragen an:

die Partei zu 2., Frau Bernadette Keller, vorgenannt, dies annehmend,
50 (fünfzig) Anteile der obengenannten Gesellschaft NATURPARADIES, S.à r.l.
Da es sich um Anteile einer Luxemburgischen Gesellschaft handelt, wird ausdrücklich festgelegt, daß dieser Vertrag

zwecks Abtretung von Gesellschaftsanteilen exklusiv dem Luxemburger Recht und der Luxemburger Gerichtsbarkeit
unterhegt.

Sodann erklärt Frau Bernadette Keller, vorgenannt, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin, sowie

auch Geschäftsführerin/alleinige Verwalterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung NATURPARADIES, S.à r.l., vor-

Beles, den 8. September 2005.

J.-J. Wagner.

3106

bezeichnet, die hiervor getätigte Abtretung von Gesellschaftsanteilen im Namen der Gesellschaft anzunehmen und sie
derselben gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches als gültig zugestellt zu betrachten.

3. Verkaufspreis der Anteile
Die Abtretung gemäss vorhegenden Vertrages erfolgt zum Preis von 1,- EUR/Anteil, d. h., es erhalten die
SAPPHO S.A. (für 48 Anteile): 48,- EUR
und die
ECP EUROPEAN COMMERCE PORT S.à.r.l. (für 2 Anteile): 2,- EUR
Der Gesamtpreis der Abtretung beträgt somit 50,- Euro.
Die SAPPHO S.A. und die ECP EUROPEAN COMMERCE PORT S.à.r.l. (Partei zu 1.) bestätigen hiermit, die vorge-

nannten Summen von Frau Bernadette Keller (Partei zu 2.) erhalten zu haben.

4. Zusicherungen
Die Verkäuferin (Partei zu 1.) sichert zu, daß:
- der Gesellschaftsvertrag der NATURPARADIES, S.à r.l. in der Fassung vom 30. April 1999 unverändert fortbesteht,

eine Änderung nicht beschlossen und keine weiteren Vereinbarungen hinsichtlich der NATURPARADIES S.à.r.l. beste-
hen;

- die Anteile frei von Rechten Dritter sind;
- weitere Gesellschafter nicht vorhanden sind;
- die der Käuferin überreichten Jahresabschlüsse der NATURPARADIES, S.à r.l. den gesetzlichen Vorschriften und

den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung entsprechen und die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der NATURPARADIES S.à.r.l. zutreffend wiedergeben ist;

- keinerlei Verbindlichkeiten der NATURPARADIES, S.à r.l. bestehen, die nicht aus den Buchführungsunterlagen

ersichtlich sind;

- die NATURPARADIES, S.à r.l. an keine Verträge gebunden ist, die nicht als Anlage zu diesem Vertrag aufgeführt sind;
- die NATURPARADIES, S.à r.l. über alle zur Fortführung des Geschäftsbetriebs erforderlichen Erlaubnisse verfügt;
- die NATURPARADIES, S.à r.l. weder an einem Verfahren vor staatlichen Gerichten oder Behörden noch an einem

Verfahren vor Schiedsgerichten beteiligt ist;

- die NATURPARADIES, S.à r.l. Rechtsvorschriften nicht verletzt, insbesondere ihre steuerlichen und sozialversiche-

rungrechtlichen Pflichten erfüllt hat;

- die NATURPARADIES, S.à r.l. vertragliche Rechte Dritter nicht verletzt und sich keinen vertraglichen Beschränkun-

gen in ihrer Geschäftstätigkeit unterworfen hat;

- alle Angaben in diesem Vertrag richtig sind. 
5. Verschiedenes
Dieser Vertrag wurde nach Luxemburger Recht abgeschlossen und sollte eine oder mehrere der obigen Klausen,

durch Richterspruch, als nichtig erklärt werden; bleiben dennoch die restlichen Klauseln, sowie die Abtretung der
Gesellschaftsanteile rechtskräftig.

Durch diesen Vertrag haben die unterzeichnenden Parteien unwiderruflich festgelegt, daß die ECP EUROPEAN

COMMERCE PORT, S.à r.l. und die SAPPHO S.A. ihre gesamten Anteile (50) der vorbezeichneten Gesellschaft
NATURPARADIES, S.à r.l. an Frau Bernadette Keller abgetreten haben.

Ausgefertigt in Luxemburg, den 12. August 2005. 

(N.B.: jede Seite dieses Vertrages ist durch jede Partei abzuzeichnen, der Vermerk «gelesen und genehmigt» muß der

Unterschrift auf der letzten Seite vorhergehen.)

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01992. – Reçu 397 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080369.3/000/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

MONDILUX INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 25.168. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05859, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076801.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

<i>Für die <i>ECP EUROPEAN COMMERCE PORT S.à.r.l. / <i>SAPPHO S.A.
Unterschrift / Unterschrift
B. Keller

<i>Pour MONDILUX INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

3107

E.I., EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 64.314. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06476, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076771.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

E.I., EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 64.314. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06472, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076774.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

E.I., EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 64.314. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06469, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076775.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

E.I., EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 64.314. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06466, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076777.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

MARITIME CONSTRUCTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 68.653. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Général Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social le 10 décembre 2002

que:

1) Le mandat de l’Administrateur Monsieur Bozzini Sergio étant venu à échéance, son présent mandat n’est pas re-

nouvelé.

2) Le mandat de l’Administrateur Monsieur Bozzini Sergio étant venu à échéance, le présent mandat y relatif n’est pas

renouvelé.

A biffer:
Monsieur Polito et Monsieur Bozzini, ont les pouvoirs de signer individuellement pour toute transaction d’un montant

inférieur ou égal à 100.000,- USD (ou contre valeur devise) et conjointement pour tout autre montant dépassant cette
valeur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05773. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076907.3/2329/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pétange, août 2005.

Signature.

Pétange, août 2005.

Signature.

Pétange, août 2005.

Signature.

Pétange, août 2005.

Signature.

Signature.

3108

GREENSLEAVE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.707. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05862, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076806.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

GREENSLEAVE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 37.707. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05863, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076805.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

GREENSLEAVE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 37.707. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05872, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076804.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

M.H. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 84.943. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076770.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

MACQUARIE INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.255. 

Lors de l’Assemblée Générale tenue le 22 mars 2005, les actionnaires de la société ont décidé de nommer Gérard

Becquer en tant qu’administrateur de la société avec effet immédiat jusqu’à l’assemblée générale tenue en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06307. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076841.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

<i>Pour GREENSLEAVE S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour GREENSLEAVE S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour GREENSLEAVE S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Senningerberg, le 25 août 2005.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 23 août 2005.

Signature.

3109

MONDI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 58.464. 

Il résulte du transfert des parts sociales en date du 27 juillet 2005 que:
MONDI EUROPEAN HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, BVI,

a transféré le 27 juillet 2005 2.104.428 de parts sociales à MONDI INVESTMENTS (AUSTRIA), S.à r.l., 48, rue de
Bragance, L-1255 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05772. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076815.3/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

MONDI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 58.464. 

Il résulte du transfert des parts sociales en date du 27 juillet 2005 que:
ANGLO MERCURY S.A., ayant son siège social à 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a transféré le 27 juillet

2005 2.104.427 de parts sociales à MONDI INVESTMENTS (AUSTRIA), S.à r.l., 48, rue de Bragance, L-1255 Luxem-
bourg.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06092. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076814.3/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

MONDI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 58.464. 

Il résulte du transfert des parts sociales en date du 25 juillet 2005 que:
ANGLO AMERICAN FINANCE (UK) PLC, ayant son siège social à 20 Carlton House Terrace, London SW1Y 5AN,

a transféré le 25 juillet 2005 2.097.005 de parts sociales à ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED, 20 Carlton House
Terrace, London SW1Y 5AN.

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05775. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076812.3/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

WALLENBORN TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 67.255. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076781.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

A. Weber.

3110

KLÖCKNER PENTAPLAST PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 144.625,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 92.751. 

Suite au décès de Monsieur Brent Wheeler, survenu le 17 novembre 2004, son mandat en tant que gérant de la so-

ciété KLÖCKNER PENTAPLAST PARTICIPATIONS, S.à r.l. prend fin, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06313. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076828.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

KLÖCKNER PENTAPLAST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 124.768.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 84.252. 

En date du 27 juillet 2005, Monsieur Gunderlach Norbert a décidé de démissionner de son poste en tant que gérant

de la société KLÖCKNER PENTAPLAST LUXEMBOURG, S.à r.l. avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06312. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076831.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

TROTWOOD INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 9.000,-.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 105.209. 

Suite à la décision datée au 31 janvier 2005, l’associé unique de la société TROTWOOD INVESTMENTS, S.à r.l. a

décidé de nommer en tant que Réviseur d’Entreprises, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., avec siège social au 400, route
d’Esch, L-1471 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approu-
vera le bilan au 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06308. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076840.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

MATISA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 8, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 93.177. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00209, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076918.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

SOPROSOULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 76.493. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00284, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076906.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Luxembourg, le 19 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 18 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 24 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature.

3111

TAYLOR WOODROW FINANCE (GIBRALTAR) 2005 LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 15,000.-.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 110.384. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twelfth of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of TAYLOR WOODROW FINANCE (GIBRALTAR)

2005 LIMITED (the «Company»), a limited liability company organised under the laws of Gibraltar, having its registered
office in 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar, incorporated by deed enacted on the 23
February 2005 and validly registered at the Register of Companies of Gibraltar with registration number 94287.

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder of the Company, TAYLOR WOODROW HOLDINGS LIMITED, incorporated under the

laws of the United Kingdom, having its registered office at 2 Princes Way, Solihull, West Midlands, United Kingdom,
owner of the 300 (three hundred) shares, representing the whole capital of the Company, is duly here represented by
Patrick Van Hees, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on 8 April, 2005, so that the meeting may
validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder has been beforehand informed.

II.- The proxy form of the represented shareholder, after having been initialled ne varietur by the above person, will

remain annexed to the present deed to be registered with the minutes.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Appointment of new managers of the Company;
2. Ratification of the decisions of the management board taken on April 7, 2005 in the United Kingdom deciding (inter

alia) to transfer the management and control and the Company’s office address to Luxembourg;

3. Acknowledgement that the Company continues under Gibraltar law to be regarded as validly incorporated in Gi-

braltar;

4. Confirmation of the description and consistency of all the assets and liabilities of the Company and of the paid-up

issued share capital of the Company;

5. Amendment of the Company’s articles of association in order to make them comply with Luxembourg legislation

on the «sociétés à responsabilité limitée».

IV.- The meeting was provided with the copy of the following documents:
i. A copy of the Memorandum and Articles of Association of the Company;
ii. The resolutions of the management board of the Company dated April 7, 2005 taken in the United Kingdom; and
iii. A signed balance sheet of the Company as at April 11, 2005 together with a signed statement of value of the Com-

pany dated April 11,2005.

All the above mentioned documentation initialled ne varietur by the proxy holder of the represented shareholder,

and the undersigned notary, will remain attached to the present minutes to be filed with the registration authorities. 

After the foregoing was approved by the sole shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is hereby resolved to designate John Elkington, Aidan Foley and Eugene McMahon as new managers of the Compa-

ny, who having received previous notice of their possible designation, have accepted by written in a letter of acceptance,
their position and assumed the obligation to faithfully and properly carry out their duties.

Consequently the board of managers of the Company is composed as follows: 
- Mr. Steve Impey (class A manager);
- Mr. Ian Johnson (class A manager);
- Mr. John Elkington (class B manager);
- Mr. Aidan Foley (class C manager); and
- Mr. Eugene McMahon(class C manager).

<i>Second resolution

It is resolved to transfer the effective place of management and control, the main place of business and the office

address of the Company to the Grand-Duchy of Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, and
therefore to reiterate and ratify, in as much as necessary, the resolutions of the management board of the Company
held on April 7, 2005 deciding notably (i) to transfer the management and control of the Company to the Grand-Duchy
of Luxembourg, (ii) to transfer the business of the Company to the Grand-Duchy of Luxembourg and to close it down
in the United Kingdom,.

<i>Third resolution

It is resolved that the Company continues in the Grand-Duchy of Luxembourg in the form of a Luxembourg «société

à responsabilité limitée» but under the understanding that the Company continues to be regarded, under the law of
Gibraltar, as a validly incorporated Gibraltar company.

3112

<i>Fourth resolution

The shareholder records that the description and consistency of the assets and liabilities of the Company results from

a balance sheet dated April 11, 2005 annexed to a statement of value dated April 11,2005 which have been delivered to
the notary on the date hereof. A copy of the balance sheet and the statement of value, signed ne varietur by the proxy
holder of the represented shareholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed
at the same time. The shareholder states that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain the
ownership in their entirety of the Company, which continues to own all its assets, and continues to be obliged by all its
liabilities and commitments.

The meeting confirms that the issued and paid up share capital of the Company is set up at GBP 15,000.- (fifteen

thousand British Pounds), divided in 300 (three hundred) shares with a nominal value of GBP 50.- (fifty British Pounds)
each.

The shareholder, TAYLOR WOODROW HOLDINGS LIMITED, declares that it owns 300 (three hundred) shares

of the Company.

<i>Fifth resolution

It is resolved to amend the Company’s articles of association in order to make them comply in substance with both

the law of the Grand-Duchy of Luxembourg applicable to a Luxembourg «société à responsabilité limitée» and the laws
of Gibraltar applicable to a Gibraltar «limited company».

The articles of association will henceforth read as follows:

Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. The Company, while keeping its registered office at Gibraltar, hereby takes the form of a Luxembourg «so-

ciété à responsabilité limitée», limited liability company (the «Company»), governed by the present Articles and by cur-
rent applicable laws.

Art. 2. The Company’s name is TAYLOR WOODROW FINANCE (GIBRALTAR) 2005 LIMITED.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations,
contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, any rights, patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, man-
age, develop, sell, or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and
in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, or in
which the Company has a direct or indirect financial interest, or any company of the group the Company is belonging
to, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment
of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in 10/8 International Commercial Center, Casemates Square, Gibraltar,

and its effective place of management and control, main place of business and office address in Luxembourg in the Grand-
Duchy of Luxembourg,

Art. 5. The duration of the Company is unlimited.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings of shareholders or the sole shareholder (as the case may be).

Capital - Share

Art. 8. The Company’s capital is set at GBP 15,000 (fifteen thousand British Pounds), represented by 300 (three

hundred) shares with a nominal value of GBP 50 (fifty British Pounds) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholder(s) adopted in the

same manner required for amendment of the Articles.

Art. 9. One share confers one voting right and a shareholder has a voting right commensurate to his shareholding.

Art. 10. The shares are freely transferable. 
The shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless the shareholder(s) shall have agreed there-

to by a resolution.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

Management

Art. 11. The Company will be managed by a board of managers composed of «Class A», «Class B» and «Class C»

managers. The managers need not be shareholder(s) of the Company.

3113

The Class A managers may only be employees of any company of the TAYLOR WOODROW group and shall be

residing in the United Kingdom;

The Class B managers may only be employees of any company of the TAYLOR WOODROW group and shall not be

residing in the United Kingdom;

The Class C managers are any non-UK resident individuals who are not employees of the TAYLOR WOODROW

group.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of share-

holders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder.
The remuneration of the managers can be modified by a resolution of the shareholder(s) taken at the same majority
conditions. The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad
nutum, with or without cause, remove and replace any manager. All powers not expressly reserved by the Law or the
Articles to the shareholders or the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of
managers.

The Company shall be bound by:
- The joint signature of a Class B and a Class C manager; or
- The joint signature of three managers, provided that two of them are Class B and/or Class C managers, and at least

one of them is a Class A or Class B manager.

The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc

agent(s) who need not be shareholders or managers of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the ex-
ecution of his mandate.

Art. 13. The decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers. All meetings of the board of

managers shall be held in the Grand-Duchy of Luxembourg.

The board of managers shall choose among its members a chairman, who cannot be a Class A manager. It may also

choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the board of managers, or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 48 hours in advance of the time

set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meet-
ing.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means

or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any

other suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers.

If two managers are present, only a Class B and a Class C manager present in person, by proxy or by representative,

will constitute a quorum. If three managers are present in person, by proxy or by representative, a quorum can only be
constituted if two of the managers are Class B and/or Class C managers, and at least one of the managers is a Class A
or Class B manager.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or elec-

tronic means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.
Any and all managers, provided that they are not located in the United Kingdom, may participate in a meeting of the

board of managers by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons par-
ticipating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

General meetings of shareholders

Art. 14. Decisions of shareholders are taken as follows:
- In case of plurality of shareholders, the holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the share-

holders number is less than twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution
or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable
telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing.

- If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the

shareholders. In such a case, one general meeting shall be held annually in Luxembourg on the last business day of June.
Other general meetings of shareholders shall be held in the city of Luxembourg at time specified in the notice of the
meeting.

3114

Art. 15. General meetings of shareholders are convened by the board of managers, failing which by the sole share-

holder.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of

the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means or by any other suitable telecommunication means another person who need not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders repre-

senting more than half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letter to a

second meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting shareholders whatever portion of capital

may be represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary resolution of the sole sharehold-

er or an extraordinary general meeting of shareholders, at a majority in number of shareholders representing at least
three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of the

Law.

As a consequence thereof, the sole shareholder takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole

shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on 1st February and shall end on 31 January. Exceptionally, as the Com-

pany was incorporated on 23 February 2005, the current financial year has started on 23 February 2005 to end on 31
January 2006.

Art. 17. Each year, as of 31 January, the manager, or the board of manager(s) as the case may be, will draw up the

balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and
be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the manager, or the board of managers as the case may be, will prepare a profit and loss account,

which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account. 

If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days pre-

ceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the company

Art. 19. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one

or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be shareholder.

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders fol-

lowing appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of shareholder(s).

Where the legal thresholds are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified

auditor(s) («réviseurs d’entreprises») appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the
case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d’entreprises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor(s) may be appointed by

resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 20. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent of the net profit will be transferred to the Statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the Statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The general meeting of shareholders may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be

distributed to the shareholders proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.

3115

Art. 21. Notwithstanding the provisions of article twenty, the general meeting of shareholders of the Company,

upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers
or the sole manager (as the case may be) itself, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a
reserve to be established according to the applicable law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 22. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the law, or the sole shareholder

(as the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 23. The liquidation will be carried out by one or more liquidator(s), physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which will specify its/their powers and fix
its/their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholder(s)

proportionally to the shares he/they hold.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed, or which shall be charged to it in connection with the present deed are estimated at two thousand
five hundred Euro.

For the registration tax, the present transfer of the administrative and actual effective management seat of the Com-

pany to Luxembourg is not subject to the pro rata contribution duty in accordance with Article 3-2 of the law of De-
cember 1971. TAYLOR WOODROW FINANCE (GIBRALTAR) 2005 LIMITED is a Company subject to the pro rata
registration fee in accordance with the tax legislation of Gibraltar.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le douze avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, soussigné.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de TAYLOR WOODROW FINANCE (GIBRAL-

TAR) 2005 LIMITED (la «Société»), une société à responsabilité limitée régie par le droit de Gibraltar, ayant son siège
social au 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar, créée aux termes d’un acte notarié en
date du 23 février 2005, et valablement enregistrée au Registre des Sociétés de Gibraltar sous le numéro 94287.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. L’associé unique de la Société, TAYLOR WOODROW HOLDINGS LIMITED, société régie par le droit du Royau-

me-Uni et ayant son siège social au 2 Princes Way, Solihull, West Midlands, Royaume-Uni, propriétaire des 300 (trois
cents) parts sociales émises, représentant l’intégralité du capital social est ici dûment représentée par Patrick Van Hees,
prédésigné, en vertu d’une procuration sous seing privée en date du 8 avril 2005, de sorte que l’assemblée peut valable-
ment délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.

II. La procuration de l’associé représenté, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire restera

annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

III. L’ordre du jour de la Société est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Nomination de nouveaux gérants de la Société;
2. Ratification de la décision du conseil de gérance adoptée le 7 avril 2005 au Royaume-Uni relative au transfert du

siège de la direction effective ainsi que de l’adresse de la Société à Luxembourg;

3. Acquiescement au fait que la Société continue à être considérée comme une société valablement constituée et

régie par le droit de Gibraltar;

4. Confirmation de la description et de la consistance de tous les actifs et passifs de la Société ainsi que de la libération

du capital social de la Société;

5. Modification des statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec la législation luxembourgeoise sur les

sociétés à responsabilité limitée;

IV. Copie des documents suivants ont été soumis à l’assemblée:
i. une copie des statuts de la Société;

3116

ii. les résolutions adoptées par le conseil de gérance au Royaume-Uni en date du 7 avril 2005;
iii. un exemplaire signé du bilan de la Société au 11 avril 2005 ainsi qu’une déclaration de situation de la Société signée

au 11 avril 2005.

Les documents susmentionnés, après avoir été paraphés ne varietur par le mandataire de l’associé comparant et le

notaire instrumentant, resteront annexés au présent procès-verbal pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.
Après délibération, l’assemblée décide unanimement ce qui suit:

<i>Première résolution

Il a été décidé de nommer John Elkington, Aidan Foley et Eugene Mc Mahon en qualité de gérants de la Société; ayant

été informés de leur possible nomination, ils ont accepté par écrit leur nomination aux termes d’une lettre d’acceptation,
et ont déclaré accepter de mener à bien leur mission.

Par conséquent, le conseil de gérance est composé comme suit:
- M. Steve Impey (gérant de catégorie A);
- M. Ian Johnson (gérant de catégorie A);
- M. John Elkington (gérant de catégorie B);
- M. Aidan Foley (gérant de catégorie C); et
- M. Eugene McMahon (gérant de catégorie C).

<i>Seconde résolution

Il a été décidé de transférer le siège de la direction effective, le principal établissement de la Société et son adresse

au Grand-Duché du Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, et, en conséquence, de réitérer
et ratifier, autant que nécessaire, les résolutions du conseil de gérance de la Société en date du 7 avril 2005 décidant
notamment de(i) transférer le siège de direction effective de la Société au Grand-Duché au Luxembourg, (ii) de trans-
férer l’activité de la Société au Grand-Duché du Luxembourg et de la cesser au Royaume-Uni.

<i>Troisième résolution

Il est décidé que la Société poursuit son existence au Grand-Duché du Luxembourg sous la forme d’une société à

responsabilité limitée, étant entendu que la Société continue à être considérée au regard du droit de Gibraltar comme
une société valablement constituée sous l’empire du droit de Gibraltar.

<i>Quatrième résolution

L’associé précise que la description et la consistance de tous les actifs et passifs de la Société figurent au bilan en date

du 11 avril 2005 annexé à une déclaration de situation en date du 11 avril 2005 qui ont été fournis au notaire ce jour.
Une copie du bilan et de la déclaration de situation, signés par le mandataire de l’associé et le notaire comparant, res-
teront annexés aux présentes aux fins d’enregistrement.

L’associé déclare que tous les actifs et passifs de la Société, sans limite, demeurent entièrement la propriété de la

Société qui continue à avoir la propriété de tous ses actifs et à être obligée par tous ses engagements et obligations.

L’assemblée confirme que le capital émis et libéré de la Société s’élève à GBP 15.000.- (quinze mille Livres sterling)

divisé en 300 (trois cent) parts ayant une valeur nominale de GBP 50.- (cinquante Livres sterling) chacune. 

L’associé, TAYLOR WOODROW HOLDINGS LIMITED, déclare détenir la propriété des 300 (trois cent) parts de

la Société.

<i>Cinquième résolution

Il est décidé de modifier les statuts de la Société afin qu’ils soient en conformité à la fois avec les lois luxembourgeoises

applicables aux «sociétés à responsabilité limitée» et les lois de Gibraltar applicables à une société «limited» de Gibraltar.

Les statuts de la société doivent être lus comme suit: 

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. La Société, tout en conservant son siège social à Gibraltar, prend la forme d’une société à responsabilité

limitée luxembourgeoise (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois actuellement en vigueur.

Art. 2. La dénomination de la société est TAYLOR WOODROW FINANCE (GIBRALTAR) 2005 LIMITED.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, ac-
quérir tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de
négociation et de toute autre manière et notamment d’acquérir tous droits, droits intellectuels, marques, copyrights,
brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généra-
lement les détenir, gérer, développer, les vendre, les donner en licence ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions
que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de toute société les acquérant;
de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d’octroyer à toute
société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou aux
dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, ou à toute
société du groupe auquel la Société appartient, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des
fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à
bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois
sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs décrits précédemment et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

3117

Art. 4. La Société a son siège social au 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar et son

siège de direction effective, principal établissement et adresse à Luxembourg au Grand-Duché du Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est indéterminée.

Art. 6. Le décès, la suspension des droits civiques, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à

la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Pour l’exercice de leurs droits, ils doivent s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées ou de l’associé unique (le cas échéant).

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à GBP 15.000.- (quinze mille Livres Sterling), représenté par 300 (trois cent) parts

sociales de GBP 50.- (cinquante Livres Sterling).

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adop-

tée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 9. Une part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions, et un associé a un droit de

vote proportionnel à sa participation dans le capital social.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des tiers non-associés à moins que l’associé (ou les associés)

n’ait donné son accord.

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire par part sociale.

Gérance

Art. 11. La Société sera gérée par un conseil de gérance composé de gérants de Catégorie A, de Catégorie B, de

Catégorie C. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés de la Société.

Les gérants de Catégorie A sont obligatoirement des employés de toute société du groupe TAYLOR WOODROW

et sont obligatoirement résidents au Royaume-Uni.

Les gérants de Catégorie B sont obligatoirement des employés de toute société du groupe TAYLOR WOODROW

et résident obligatoirement dans tout autre Etat que le Royaume-Uni.

Les gérants de Catégorie C sont obligatoirement des personnes non-résidentes au Royaume-Uni et qui ne sont pas

des employés du groupe TAYLOR WOODROW.

Les gérants seront nommés et leur rémunération déterminée par décision de l’assemblée générale des associés dé-

libérant à la majorité simple des voix ou sur décision de l’associé unique, le cas échéant. La rémunération des gérants
peut être modifiée par une résolution du ou des associé(s) prise aux même conditions de majorité. L’assemblée générale
des associés ou l’associé unique (le cas échéant) pourront, à tout moment, avec ou sans justification, révoquer et rem-
placer tout gérant. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou à l’associé uni-
que (le cas échéant) par les Lois ou les présents Statuts sont de la compétence du conseil de gérance.

La société sera engagée par:
- La signature conjointe d’un gérant de Catégorie B et d’un gérant de Catégorie C;
- La signature conjointe de trois gérants, pourvu que deux au moins d’entre eux soient des gérants de Catégorie B

et/ou de Catégorie C, et que l’un au moins d’entre eux soit un gérant de Catégorie A ou de Catégorie B.

Le conseil de gérance, peut ponctuellement sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à

un ou plusieurs agents ad hoc, le(s)quel(s) ne sera/seront pas obligatoirement associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les pouvoirs, les responsabilités et la rémunération (s’il y en a) de son/ses agent(s),

la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.

Les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance. Toutes les réunions du conseil de

gérance doivent se tenir sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président, qui ne peut en aucun cas être un gérant de Catégorie

A. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction
du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance ou pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants au moins 48 heures

avant la date fixée pour cette réunion, sauf cas d’urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de
réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Cette convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex,

moyens électroniques ou tout autre moyen approprié de communication.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Aucune convocation n’est requise pour des réunions qui se tiennent aux heure et lieu fixés aux termes d’une réso-

lution antérieure du conseil de gérance.

3118

Si deux gérants sont présents, seulement un gérant de Catégorie B et un gérant de Catégorie C, présents en person-

ne, par procuration ou par représentant, constituent un quorum. Si trois gérants sont présents en personne, par pro-
curation ou par représentant, un quorum ne peut être constitué que si deux des gérants sont des gérants de Catégorie
B et/ou Catégorie C, et si au moins l’un des gérants est un gérant de Catégorie A ou de Catégorie B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant un autre gérant pour le représen-

ter par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, ou moyens électroniques.

Un gérant peut représenter plus d’un gérant.
Tout gérant, pour autant qu’il ne soit pas physiquement situé au Royaume-Uni, peut assister à une réunion du conseil

de gérance s’il intervient par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen de télécommunication approprié et per-
mettant à toutes les personnes participant à la réunion de communiquer à un même moment.

La participation à une réunion du conseil de gérance par de tels moyens est réputée équivalente à une participation

en personne.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites dans un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux

gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises comme suit:
- en présence d’une pluralité d’associés, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des

associés est inférieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision
à prendre, transmis par écrit ou télécopie, câble, télégramme, télex ou tout autre moyen de communication approprié.
Chaque associé vote par écrit.

- Si le nombre d’associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés.

Dans ce cas, une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg le dernier jour ouvré du mois de juin. Toute
autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l’heure et au jour fixé dans la con-
vocation à 1’assemblée.

Art. 15. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance, ou à défaut par l’associé

unique.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l’assemblée, sauf pour l’assemblée générale annuelle pour la-
quelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l’assemblée.

Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l’assemblée.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble, té-

légramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas
être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus

de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, les associés seront immédiatement convoqués à une

seconde assemblée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises que par une résolution

extraordinaire de l’associé unique ou de l’assemblée générale extraordinaire des associés à la majorité des associés re-
présentant les trois quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Il s’ensuit que l’associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.
Excepté les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l’associé unique et

la Société doivent faire l’objet d’un procès-verbal ou être rédigés par écrit.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le 1

er

 février se termine le 31 janvier. Exceptionnellement, en raison du fait que

la Société a été constituée le 23 février 2005, l’exercice social en cours a commencé le 23 février 2005 pour se terminer
le 31 janvier 2006. 

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 janvier, le gérant ou le conseil de gérance, le cas échéant, établira le bilan

qui contiendra l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant
en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes du ou des gérants, commissaire(s) aux comptes (le cas échéant)
et associé(s) envers la société. 

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée générale des

associés avec le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Si le nombre d’associés excède vingt-cinq, cette inspection ne pourra être effectuée que durant les quinze jours pré-

cédents l’assemblée générale annuelle des associés.

3119

Surveillance de la société

Art. 19. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs

commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant

sa nomination.

A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d’en-

treprises désigné(s) par résolution de l’assemblée générale des associés ou par l’associé unique (le cas échéant) parmi
les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs commissaires peuvent être nommés par

résolution de l’assemblée générale des associés ou de l’associé unique (le cas échéant) qui décide des termes et condi-
tions de son/leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 20. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au

titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales ou de l’affecter
au compte report à nouveau ou de le transférer à un compte de réserve extraordinaire.

Art. 21. Nonobstant les dispositions de l’article vingt, les associés réunis en assemblée générale, peut, sur proposi-

tion du conseil de gérance ou le gérant unique (le cas échéant), décider de payer des acomptes sur dividendes en cours
d’exercice social sur base d’un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le gérant unique (le cas échéant),
desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à
distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bé-
néfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 22. L’assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou l’associé uni-

que (le cas échéant), doivent donner leur accord à la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi qu’aux termes et
conditions de celle-ci.

Art. 23. La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,

nommés par l’assemblée générale ou l’associé unique (le cas échéant) qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués à l’associé unique ou aux associés au pro rata de leur

participation dans le capital de la Société. 

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ deux mille cinq cents euros. 

Pour les besoins de l’enregistrement, le Notaire déclare que le dit transfert du siège administratif et de direction ef-

fective vers le Luxembourg n’est pas sujet à la perception du droit d’apport conformément à l’article 3-2 de la loi du 29
décembre 1971. TAYLOR WOODROW FINANCE (GIBRALTAR) 2005 LIMITED, S.à r.l. est une Société soumise au
droit d’apport conformément à la législation fiscale de Gibraltar.

Attendu qu’il n’y a plus d’autres points à l’assemblée, cette dernière est close.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que les comparants l’ont requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, vol. 147S, fol. 89, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080225.3/211/557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

J. Elvinger.

3120

SERIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 57.492. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06327, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076674.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

TAUREAU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 58.996. 

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, en-

registrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06319, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076675.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

NEPTUNO COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 55.626. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06353, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076676.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

PINK OCEAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.047. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06396, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2005.

(076677.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 25 août 2005.

Signature.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Kingberg Immobilière S.A.

Sun Valley, S.à r.l.

Sofréa, Société Française de Réassurance S.A.

Sirec, International Reinsurance Company S.A.

Allalin Invest S.A.

IBL Luxembourg S.A.

Osdi S.A.

United Properties S.A.

Raval Europe S.A.

Stones Steak House Strassen, S.à r.l.

Stones Steak House Strassen, S.à r.l.

Stones Steak House Strassen, S.à r.l.

Lexington Corporation, S.à r.l.

Euro-Land

The Learning Corporation S.A.

The Learning Corporation S.A.

Luce Holding S.A.

Onoclea Corporation, S.à r.l.

Eurogest S.A.

U.P. S.A.

Meginvest S.A.

Meginvest S.A.

Yago Immobilière S.A.

Linie Holding S.A.

Arguedas Holding S.A.

Pelican 10

Ets Nell, S.à r.l.

Finanmag S.A.

Mucora Holding S.A.

Medina Investments S.A.

Société Hollando-Suisse de Participation

Newvalux S.A.

Espace Promotion Holding

Gedrenksbuttek Kleyr, S.à r.l.

Finango S.A.

Imex Europe, S.à r.l.

Everwood Holding S.A.

Padostom S.A.

Padostom S.A.

K &amp; K Dental Design, G.m.b.H.

Leorado, S.à r.l.

Rodasil S.A.

Amelia Invest S.A.

Geopartner, G.m.b.H.

Camping Simmerschmelz II

Flouh- an Sammlerclub Lëtzebuerg Stad - Muselfrënn Réimech

Prifot S.A.

Celan Holding S.A.

Hypraholding S.A.

Balthasar, S.à r.l.

Cameo, S.à r.l.

Investitionsgesellschaft der Ardennen, S.à r.l.

Versbau S.A.

Ollioules Participations, S.à r.l.

Immovacances S.A.

Bari Holding S.A.

Bayern LB International Fund Management S.A.

Media Travel S.A.

Soluxol

Imelu S.A.

Cetiri Holding S.A.

Stockwell Holding S.A.

Westing Petroleum S.A.

Optimal Security, S.à r.l.

Optimal Security, S.à r.l.

Logitrans Europ S.A.

Fidemon, S.à r.l.

Paragon S.A.

Ingersoll-Rand Worldwide Capital, S.à r.l.

Ingersoll-Rand Worldwide Capital, S.à r.l.

E.C.G. Domiciliation, S.à r.l.

Peintures Biwersi, S.à r.l.

Parc Holding S.A.

Parc Holding S.A.

Parc Holding S.A.

E.C.G. S.A., Expertise Comptable et Gestion

Du Fort Participations S.A.

Akeler Holdings S.A.

Finsalute S.A.

Niam III Luxembourg, S.à r.l.

ABM Immobilière S.A.

ABM Immobilière S.A.

ABM Immobilière S.A.

ABM Immobilière S.A.

ABM Immobilière S.A.

A.I. Asesoria de Inversiones S.A.

DB Silver, S.à r.l.

Naturparadies, S.à r.l.

Mondilux International Investments S.A.

E.I., Européenne d’Investissement S.A.

E.I., Européenne d’Investissement S.A.

E.I., Européenne d’Investissement S.A.

E.I., Européenne d’Investissement S.A.

Maritime Construction Luxembourg S.A.

Greensleave S.A.

Greensleave S.A.

Greensleave S.A.

M.H. Luxembourg S.A.

Macquarie Industrie Beteiligungen S.A.

Mondi International, S.à r.l.

Mondi International, S.à r.l.

Mondi International, S.à r.l.

Wallenborn Transports S.A.

Klöckner Pentaplast Participations, S.à r.l.

Klöckner Pentaplast Luxembourg, S.à r.l.

Trotwood Investments, S.à r.l.

Matisa, S.à r.l.

Soprosoulux S.A.

Taylor Woodrow Finance (Gibraltar) 2005 Limited

Serin Holding S.A.

Taureau Holding S.A.

Neptuno Company S.A.

Pink Ocean Finance S.A.