logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

33937

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 708

18 juillet 2005

S O M M A I R E

Agilitas S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33943

Ebony Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

33954

Alias Mustang International S.A., Luxembourg  . . .

33978

EFI S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33942

Apei, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33952

Fidelity Funds II Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

33974

Apei, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33953

Fidelity Funds, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33978

Arkinmob Investissements S.A., Luxembourg . . . .

33973

Freemind Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

33953

Arkinmob Investissements S.A., Luxembourg . . . .

33973

Gestaut S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33950

Atoz S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33940

Golden Tropi Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

33970

Atoz S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33941

Growth Invest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . 

33972

Au Royaume Fleuri, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

33956

Growth Invest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . 

33972

B.S.A.W-Exploitation S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

33969

Gulf Distribution Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

33943

B.S.A.W-Exploitation S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

33970

Hearthistic Prod., A.s.b.l., Differdange. . . . . . . . . . 

33946

Believe Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

33941

Hovra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33960

Beltxnea S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33964

HSH Nordbank International S.A., Luxemburg  . . 

33960

Brait S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33982

HSH Nordbank International S.A., Luxemburg  . . 

33964

Business Invest Gestion S.A., Esch-sur-Alzette. . . .

33954

Ikano Finance (Russia) S.A., Luxembourg . . . . . . . 

33940

Canillac Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

33967

Indevo A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33940

CF  Services,  Corporate  and  Fiduciary  Services 

Irepa Industrial Research & Patents S.A.,  Luxem- 

S.C., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33968

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33971

CF  Services,  Corporate  and  Fiduciary  Services 

Janek Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

33956

S.C., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33969

Jocar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

33972

Chinesco Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

33958

Jocar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

33972

Cifa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

33943

Jocar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

33972

Cifa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

33943

Jocar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

33972

Cifa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

33938

Kinase Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

33968

Compagnie Financière Ponte Carlo Holding S.A., 

Kombassan Holdings S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . 

33982

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33950

Las Gaviotas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

33971

Copanca S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33945

Luxembourg International Holding  S.A.,  Luxem- 

Cram S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33939

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33958

Cram S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33939

Makvalor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33964

Cram S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33950

Mazfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33968

Cram S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33950

Morton Fininvestment Holding S.A., Luxembourg

33955

D.C. Cars, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . .

33959

Morton Fininvestment Holding S.A., Luxembourg

33955

D.C. Cars, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . .

33960

Morton Fininvestment Holding S.A., Luxembourg

33955

Daimlerchrysler  Financial  Services  S.A., Luxem- 

Morton Fininvestment Holding S.A., Luxembourg

33955

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33946

Morton Fininvestment Holding S.A., Luxembourg

33955

Dankalux, S.à r.l. and Co. S.C.A., Luxembourg  . . .

33964

Morton Fininvestment Holding S.A., Luxembourg

33955

Dankalux, S.à r.l. and Co. S.C.A., Luxembourg  . . .

33966

Parbat Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

33943

De Darlion Industries S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

33950

Pearson Luxembourg No. 2, S.à r.l., Luxembourg  

33966

DS Smith (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . .

33971

R.C. Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33971

DS Smith (Holding) B.V., S.à r.l., Luxembourg. . . .

33971

Recherche  Médicale  Distribution  (R.M.D.)  S.A., 

33938

TOURTOUR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.126. 

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 27 décembre 2004 a appelé aux fonctions

d’administrateur Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur
Guy Fasbender. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs: 
Madame Monique Juncker, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 
Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Enfin cette Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., 123, avenue du X

Septembre, L-2551 Luxembourg, en remplacement de FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A. Son mandat prendra fin
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03067. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023083.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

CIFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.155. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 7 mars 2005

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2005:

<i>Signataires catégorie A: 

- Monsieur Stefano Raimondi, employé, demeurant au 32, Via P. Borsellino, I-25018 Montichiari (BS), Italie;
- Monsieur Fabiano Caglioni, employé, demeurant au 5, Via Fratini, I-24066 Pedrengo (BG), Italie.

<i>Signataires catégorie B: 

- Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président du Conseil

d’Administration;

- Monsieur Luc Hansen, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2005:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Le siège social est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 mars 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02538. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023122.3/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33978

Sunshine Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

33958

RSM Henri Grisius &amp; Associés, S.à r.l., Luxembourg

33942

T.H.F., Tréfileries Haute Forêt S.A., Mertert  . . . .

33951

RSM Henri Grisius &amp; Associés, S.à r.l., Luxembourg

33942

T.H.F., Tréfileries Haute Forêt S.A., Mertert  . . . .

33952

SAB, GmbH, Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33949

Tecservices S.A., Walferdange  . . . . . . . . . . . . . . . .

33939

Sireal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33941

Tourtour S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

33938

Speraconsult S.A., Mertert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33944

Traction S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33954

Staveley S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33973

Transpacific Fund, Sicaf, Luxembourg  . . . . . . . . . .

33973

Sunrays S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33949

Verrinvest Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .

33954

Sunshine Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

33957

Wic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

33968

<i>Pour TOURTOUR S.A.
M. Juncker
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

33939

TECSERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 38.719. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05997, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021820.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

CRAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.157. 

<i> Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 11 octobre 2004 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2004:

<i>Signataire catégorie A: 

- Monsieur Alberto Mutti, demeurant professionnellement au 11/13, via de Gasperi à Senago, Italie;

<i>Signataires catégorie B: 

- Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président du conseil

d’administration;

- Monsieur Pierre Lentz, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2004:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01575. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023219.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

CRAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.157. 

<i> Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 7 mars 2005 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2005:

<i>Signataire catégorie A: 

- Monsieur Alberto Mutti, demeurant à Solferino, Italie;

<i>Signataires catégorie B: 

- Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président du conseil

d’administration;

- Monsieur Pierre Lentz, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2005:

AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03056. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023217.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

FIDUCIAIRE MARCEL STEPHANY
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

33940

IKANO FINANCE (RUSSIA) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 106.009. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 28 février 2005

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 28 février 2005 que:
- Monsieur Silva Jose Fernando Dias, né le 6 juin 1965 à Sao Paulo (Brésil), Risk Director, demeurant à Rua Jose Ta-

vares de Siqueira, 426, apto 112, 03085-030, Sao Paulo SP, Brazil, a démissionné de son mandat d’administrateur de type
A avec effet au 28 février 2005;

- Monsieur Dennis Edward Fulling, né le 17 janvier 1965 à New York (USA), Chief Financial Officer, demeurant à 295

Grenwich street, #353, New York, NY 10007 USA, est nommé administrateur de type A avec effet au 28 février 2005
et jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir en 2006;

- KPMG AUDIT ayant son siège social à 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a démissionné de son mandat de

réviseur d’entreprise avec effet au 28 février 2005;

- PricewaterhouseCoopers ayant son siège social à 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, est nommé

réviseur d’entreprise avec effet au 28 février 2005 et jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires
devant se tenir en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01021. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023102.3/280/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

INDEVO A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-13383 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 42.890. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02195, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

(023110.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

ATOZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 101.128. 

L’an deux mille cinq, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ATOZ S.A., avec siège social

à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous
le numéro 101.128, constituée suivant acte reçu en date du 26 mai 2004, par Maître Jean Seckler, notaire de résidence
à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil n

°

 784 du 30 juillet 2004, et dont les statuts

furent modifiés par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil n

°

1053 du 20 octobre 2004.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Ferres, employé, avec adresse professionnelle à 1B,

Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Nicolas Cuisset, employé, avec adresse professionnelle à 1B, Heien-

haff, L-1736 Senningerberg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social

actuellement fixé à trois cent mille euro (EUR 300.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée gé-
nérale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée comprend l’unique point suivant:
Modification de l’article 4, alinéa premier des statuts, pour lui conférer la teneur suivante:

«Art. 4. Alinéa premier. La Société a pour objet l’exécution de tous travaux d’expertise comptable, fiscales, éco-

nomiques et financières, de tous mandats d’organisation technique, administrative et commerciale, toutes les activités

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Signature.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

33941

de domiciliation, ainsi que toutes activités se rattachant directement ou indirectement à la profession d’expert-compta-
ble, fiscal, économique et financier ou à celle de conseil en organisation.»

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4, alinéa premier des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

«Art. 4. Alinéa premier. La Société a pour objet l’exécution de tous travaux d’expertise comptable, fiscales, éco-

nomiques et financières, de tous mandats d’organisation technique, administrative et commerciale, toutes les activités
de domiciliation, ainsi que toutes activités se rattachant directement ou indirectement à la profession d’expert-compta-
ble, fiscal, économique et financier ou à celle de conseil en organisation.»

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: O. Ferres, N. Cuisset, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 68, case 7. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-

tions.

(023046.3/211/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

ATOZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 101.128. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

J. Elvinger.

(023068.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

SIREAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 70.005. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02204, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

(023111.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

BELIEVE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 14.020. 

Constituée par-devant M

e

 André Prost, notaire alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 1

er

 juillet 1976,

acte publié au Mémorial C n

o

 213 du 6 octobre 1976, modifiée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de

résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 20 janvier 1988, acte publié au Mémorial C n

o

 101 du

16 avril 1988. Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2001, acte publié
par extrait au Mémorial C n

o

 659 du 27 avril 2002, les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire en date

du 20 décembre 2002, acte publié au Mémorial C n

o

 169 du 18 février 2003, et en date du 5 mars 2003, acte publié

au Mémorial C n

o

 485 du 6 mai 2003.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02558, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023115.3/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Luxembourg, le 17 février 2005.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

<i>Pour BELIEVE FINANCE S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

33942

RSM HENRI GRISIUS &amp; ASSOCIES, Société à responsabilité limitée,

(anc. FHG &amp; ASSOCIES, FIDUCIAIRE HENRI GRISIUS &amp; ASSOCIES).

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 85.099. 

L’an deux mille cinq, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée FHG, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le

numéro B 97.245, ayant son siège social au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,

ici valablement représentée par la signature conjointe de deux de ses gérants, à savoir: Monsieur Henri Grisius,

expert-comptable, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg et Madame
Michelle Delfosse, ingénieur civil, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

2.- Madame Michelle Delfosse, prénommée, agissant en son personnel.
3.- Monsieur Henri Grisius, prénommé, agissant en son personnel.
4.- Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-

1340 Luxembourg.

5.- Monsieur Laurent Heiliger, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée FIDU-

CIAIRE HENRI GRISIUS &amp; ASSOCIES en abrégé FHG &amp; ASSOCIES, ayant son siège social au 3-5, place Winston
Churchill, L-1340 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
85.099, constitué suivant acte notarié en date du 3 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 545 du 9 avril 2002 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 1

er

 février 2002,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 829 du 31 mai 2002, prennent la résolution suivante:

<i>Résolution

Les associés décident de changer la dénomination sociale de la Société en RSM HENRI GRISIUS &amp; ASSOCIES.
En conséquence, l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. II existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de RSM HENRI GRI-

SIUS &amp; ASSOCIES.»

Plus n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: H. Grisius, M. Delfosse, M. Hack, L. Heiliger, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 février 2005, vol. 891, fol. 44, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023159.3/239/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

RSM HENRI GRISIUS &amp; ASSOCIES, Société à responsabilité limitée,

(anc. FHG &amp; ASSOCIES, FIDUCIAIRE HENRI GRISIUS &amp; ASSOCIES).

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 85.099. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 16 mars 2005.

(023162.3/239/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

EFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 83, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 99.060. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

(023502.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Belvaux, le 15 mars 2005.

J.-J. Wagner.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Signature.

33943

GULF DISTRIBUTION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 79.371. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02199, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

(023113.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

AGILITAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9255 Diekirch, 12, place de la Libération.

R. C. Luxembourg B 96.302. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 octobre 2003, acte publié au 

Mémorial C n

o

 1178 du 11 novembre 2003.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02531, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023116.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

PARBAT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 41.084. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 1992, acte publié au 

Mémorial C n

o

 560 du 1

er

 décembre 1992.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02998, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023117.3/1261/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

CIFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.155. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02540, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023125.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

CIFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.155. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02539, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023127.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

<i>Pour AGILITAS S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A. 
Signature

<i>Pour PARBAT FINANCE S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Luxembourg, le 14 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

Signature.

33944

SPERACONSULT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 67.569. 

Im Jahre zweitausendfünf, am achtundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft SPERACONSULT S.A., mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 51, route de Luxem-

bourg, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven, am 1. De-
zember 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 135 vom 3. März 1999 und
deren Statuten zuletzt abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar, am 17. Dezember
1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 289 vom 18. April 2000, zu einer
ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Muriel Trap, Privatbeamtin, wohnhaft beruflich in Remich, eröff-

net.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Henriette de Percin, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Remich.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Stefan Willems, Privatbeamter, wohnhaft in D-54290 Trier, Karl

Marx-Strasse 27.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6633 Wasserbillig, 51, route de Luxembourg, nach L-6686 Mertert, 51,

route de Wasserbillig, und entsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Statuten.

2. Abschaffung des Nennwertes der Aktien.
3. Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals in Euro, mit Rückwirkung zum 1. Januar 2002, zum festgesetz-

ten Kurs von vierzig Euro dreitausenddreihundertneunundneunzig Cent (40,3399 LUF) zu einem Euro (1,- EUR), von
einer Million vierhundertsechstausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.406.250,- LUF) auf vierunddreissig-
tausend achthundertsechzig Euro zwei Cent (34.860,02 EUR) eingeteilt in eintausendachthundertneunzig (1.890) Aktien.

4. Aufstockung des Gesellschaftskapitals um einhundertvier Euro achtundneunzig Cent (104,98 EUR) um es von sei-

nem Betrag von vierunddreissigtausendachthundertsechzig Euro zwei Cent (34.860,02 EUR) auf vierunddreissigtausend-
neunhundertfünfundsechzig Euro (34.965,- EUR) zu bringen.

5. Aufstockung des Gesellschaftskapitals um zehntausend Euro (10.000,- EUR) um es von dem Betrag von

vierunddreissigtausendneunhundertfünfundsechzig Euro (34.965,- EUR) auf vierundvierzigtausendneunhundert fünfund-
sechzig Euro (44.965,- EUR) zu bringen durch Ausgabe von zweihundertvierzig (240) neuen Aktien.

6. Zeichnung und Einzahlung sämtlicher zweihundert vierzig (240) neuen auszugebenden Aktien durch Bareinlage des

gleichen Betrages durch die Gesellschaft SOTRALENTZ LUXEMBOURG S.A.

7. Abänderung von Artikel 5, Absatz 1 der Statuten.
8. Verschiedenes.
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums

der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen. Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand ge-
zeichnet. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne
varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertre-

ten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt
ist, zu beschliessen.

IV. Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6633 Wasserbillig, 51, route de Lu-

xembourg, nach L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig, und entsprechende Abänderung von Artikel 2, Absatz 1 der
Statuten um ihm folgenden Wortlauf zu geben:

«Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst die Abschaffung des Nennwertes der Aktien.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst die Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals in Euro, rückwirkend zum 1. Ja-

nuar 2002, zum festgesetzten Kurs von vierzig Euro dreitausenddreihundertneunundneunzig Cent (40,3399 LUF) zu ei-
nem Euro (1,- EUR), von einer Million vierhundertsechstausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.406.250,-
LUF) auf vierunddreissigtausendachthundertsechzig Euro zwei Cent (34.860,02 EUR), eingeteilt in eintausendachthun-
dertneunzig (1.890) Aktien, ohne Nennwert.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst die Aufstockung des Aktienkapitals der Gesellschaft, ohne Ausgabe von neuen Aktien, in

Höhe um einhundertvier Euro achtundneunzig Cent (104,98 EUR) um es von seinem Betrag von vierunddreissigtausen-
dachthundertsechzig Euro zwei Cent (34.860,02 EUR) auf vierunddreissigtausendneunhundertfünfundsechzig Euro

33945

(34.965,- EUR) zu erhöhen, durch Bareinlage von einhundertvier Euro achtundneunzig Cent (104,98 EUR), wie dies dem
unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst die Aufstockung des Aktienkapitals der Gesellschaft in Höhe von zehntausend Euro

(10.000,- EUR) um es von dem Betrag von vierunddreissigtausendneunhundertfünfundsechzig Cent (34.965,- EUR) auf
vierundvierzigtausendneunhundertfünfundsechzig Euro (44.965,- EUR) zu erhöhen, durch Schaffung von zweihundert-
vierzig (240) neuen Aktien (A) mit Stimmrecht, ohne Nennwert, welche mit denselben Rechten ausgestattet sind wie
die bestehenden Aktien (A).

<i>Zeichnung und Einzahlung

Nachdem die anderen Aktionäre auf ihr zustehendes Zeichnungsrecht verzichtet haben, erklärt der Aktionär SO-

TRALENTZ LUXEMBOURG S.A., mit Gesellschaftssitz in L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig, hier vertreten
durch Herr Karl Burkardt, Kaufmann, wohnhaft in D-54451 Irsch, 13, Baumbüsch, in seiner Eigenschaft als Generalbe-
vollmächtigter die neuen ausgegebenen zweihundertvierzig (240) Aktien «A» ohne Nennwert, zu zeichnen und einzu-
zahlen, durch Bareinlage von zehntausend Euro (10.000,- EUR), so dass der Gesellschaft der Betrag von zehntausend
Euro (10.000,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Diese Zeichnung und Einzahlung wird durch die Versammlung genehmigt.

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst die Aktien in Inhaberaktien umzuwandeln.

<i>Siebter Beschluss

Infolge der vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 5, Absatz 1 der Statuten abgeändert und hat folgenden Wortlaut:

«Art. 5. Absatz 1. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt vierundvierzigtausendneunhundertfünfundsechzig Euro

(44.965,- EUR), eingeteilt in zweitausendeinhundertdreissig (2.130) Aktien ohne Nennwert, bestehend aus eintausend-
neunhundertzwanzig (1.920) Aktien «A», mit Stimmrecht und aus zweihundertzehn (210) Aktien «B», ohne Stimmrecht.
Die Aktien sind Inhaberaktien.»

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Trap, H. de Percin, S. Willems, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 2 mars 2005, vol. 468, fol. 83, case 3. – Reçu 101,04 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023165.3/221/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

COPANCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.156. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 7 mars 2005

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2005:

<i>Signataire catégorie A: 

- Monsieur Fabiano Caglioni, demeurant au 5, Via Frattini à Pedrengo, Italie.

<i>Signataires catégorie B: 

- Monsieur Thierry Fleming, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président du

Conseil d’Administration;

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxem-

bourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2005:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 mars 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02543. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023130.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Remich, den 10. März 2005.

A. Lentz.

Pour extrait conforme
Signature

33946

DAIMLERCHRYSLER FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme,

(anc. MERCEDES-BENZ FINANCE BELGIUM S.A.).

Siège social: B-1800 Vilvoorde, 27 Luchthavenlaan.

Succursale: L-1248 Luxembourg, 45, rue de Bouillon.

R. C. Luxembourg B 52.410. 

EXTRAIT

A la requête de la société anonyme de droit belge DAIMLERCHRYSLER FINANCIAL SERVICES S.A. (anciennement

MERCEDES-BENZ FINANCE BELGIUM S.A.), établie et ayant siège social à B-1800 Vilvoorde, 27 Luchthavenlaan, ins-
crite au Registre de Commerce de Bruxelles sous le numéro B 382998, représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonction.

Il est demandé l’inscription et la publication des mentions suivantes:
1. Le conseil d’administration de la société anonyme de droit belge DAIMLERCHRYSLER FINANCIAL SERVICES S.A.

se compose des personnes suivantes:

a. Monsieur Eberhard Laur, Président, demeurant à D-14109 Berlin, Am kleinen Wannsee 18;
b. Monsieur Peter Brock, Vice-président, demeurant à B-8200 Sint-Andries (Belgique), Witte Molenstraat 97;
c. Monsieur Horst Eidemüller, administrateur, demeurant à D-73230 Kirchheim/Teck (Allemagne), Birkhahnweg 49;
d. Monsieur Dr Manfred Schneider, administrateur, demeurant à B-1950 Kraainem (Belgique), Mooiloverlaan 3.
2. Les personnes physiques ayant le pouvoir d’engager la société DAIMLERCHRYSLER FINANCIAL SERVICES S.A.,

pour l’activité de la succursale de Luxembourg, à l’égard des tiers:

a. Monsieur Kurt Stoldt, demeurant à L-6951 Olingen, 10, rue de Betzdorf;
b. Dr Folke Rauscher, demeurant à B-1000 Bruxelles (Belgique), 9, avenue des Abeilles; et
c. Monsieur Reiner Heine, demeurant à B-1530 Hoeilaart (Belgique), Gladiolenlaan 7;
d. Monsieur Steven Somers, demeurant à B-2630 Aartselaar, Rozelaan 30.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01055. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023120.3/850/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

HEARTHISTIC PROD., A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-4560 Differdange, 6, rue Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg F 976. 

STATUTS

Constitution d’une association sans but lucratif du 14 mars 2005.
L’an deux mille cinq, le quatorze mars.

Ont comparu:

1) Monsieur Giovanni Patri, demeurant à L-4560 Differdange, rue Pierre Frieden n

o

 6;

2) Monsieur Mauro Patri, demeurant à L-2670, boulevard de Verdun n

o

 51;

3) Madame Anna De Michele, demeurant à L-5680 Dalheim, Neie Wee, n

o

 5.

La procuration ci-avant mentionnée restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants, annexée aux pré-

sentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants déclarent constituer par les présentes une association sans but lucratif conformément à la loi

du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, et ils en ont arrêté les
statuts comme suit:

Titre 1

er

. Dénomination, Siège social, Durée

Art. 1

er

. L’association est dénommée: HEARTHISTIC PROD., A.s.b.l.

Art. 2. Son siège social est établi à L-4560 Differdange, rue Pierre Frieden n

o

 6.

Toute modification du siège social doit être publiée dans le mois de sa date, au Mémorial.

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.

Titre 2. Objet

Art. 4. L’association a pour objet le développement artistique et sportif, et la planification, la réalisation de spectacles,

événements.

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prê-

ter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

33947

Titre 3. Associés

Section I

re

. Admission

Art. 5. Le nombre des membres de l’association n’est pas limité. Son minimum est fixé à trois. Les premiers membres

sont les fondateurs soussignés.

Art. 6. Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par le conseil d’administration.

Art. 7. Le conseil d’administration peut conférer le titre de sympathisants ou protecteurs aux personnes qu désirent

aider l’association à réaliser son but. Les sympathisants ou protecteurs ne sont pas titulaires de droits au sein de l’asso-
ciation.

Section II. Démission, Exclusion

Art. 8. La démission et l’exclusion des membres se font de la manière déterminée par l’article 12 de la loi du 21 avril

1928.

L’exclusion d’un membre peut être prononcée pour motifs graves, tels que refus de se conformer aux statuts, aux

règlements ou aux décisions des organes de l’association ou incompatibilité avec l’honnêteté et l’honneur. L’intéressé
doit, au préalable avoir été invité à fournir ses explications.

Art. 9. L’associé démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit de l’associé décédé, n’ont

aucun droit sur le fonds social.

Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de scelles, ni inventaire.

Section III. Cotisations

Art. 10. Les membres paient une cotisation annuelle. Le montant de cette cotisation est fixé annuellement par l’as-

semblée générale. Elle ne pourra être supérieure à 25,00 (vingt-cinq) euros.

Titre 4. Assemblée Générale

Art. 11. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expres-

sément reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence:
1) les modifications aux statuts sociaux;
2) la nomination et la révocation des administrateurs;
3) l’approbation des budgets et des comptes;
4) la dissolution volontaire de l’association;
5) les exclusions d’associés.

Art. 12. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, dans le courant du mois d’avril.
L’association peut être réunie en assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision du conseil d’admi-

nistration ou à la demande d’un cinquième des associés au moins. Chaque réunion se tiendra aux jours, heure et lieu
mentionnés dans la convocation.

Tous les associés doivent y être convoqués.

Art. 13. L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration par lettre ordinaire adressée à chaque

associé, au moins quinze jours avant l’assemblée, et signée par le secrétaire, au nom du conseil d’administration.

L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.

Art. 14. Chaque associé a le droit d’assister à l’assemblée générale. Il peut se faire représenter par un mandataire.
Chaque associé ne peut être titulaire que d’une personne.

Art. 15. Toute proposition signée d’un nombre d’associés égal au vingtième de la dernière liste annuelle doit être

portée à l’ordre du jour.

Art. 16. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration; en cas d’empêchement du

président l’assemblée générale sera présidée par le plus âgé des administrateurs présents.

Art. 17. Tous les membres ont un droit de vote égal à l’assemblée générale, chacun dispose d’une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et représentés, sauf dans le cas où il

en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts.

Art. 18. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modification des statuts de l’association que con-

formément à l’article 8 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, telle qu’elle est mo-
difiée.

Art. 19. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le pré-

sident et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connais-
sance mais sans déplacement du registre.

Tous les associés ou tiers justifiant un intérêt peuvent demander des extraits signés par le président du conseil d’ad-

ministration et par un administrateur.

Titre 5. Administration, Gestion journalière

Art. 20. L’association est administrée par un conseil d’administration composée de trois membres au moins, nom-

més parmi les associés par l’assemblée générale pour un terme ne pouvant dépasser trois ans, et en tous temps révo-
cables par elle.

33948

Art. 21. En cas de vacance au cours d’un mandat, un administrateur remplaçant peut être nommé par l’assemblée

générale. Il achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 22. Le conseil désigne parmi ses membres un président, un trésorier et un secrétaire.

Art. 23. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président. Il ne peut statuer que si la majorité de

ses membres est présente ou représentée, le mandat entre membres du conseil d’administration, qui peut être donné
par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, étant admis. Un membre du conseil d’administration ne peut représenter
qu’un seul de ses collègues.

Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés; quand il y a parité des

voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Elles sont consignées sous forme de procès-verbaux,
signés par le président et le secrétaire et inscrites dans un registre spécial. Les extraits qui doivent être produits et tous
les autres actes seront signés par le président et le secrétaire.

Art. 24. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association.
Sont seuls exclu de sa compétence les actes réservés par la loi ou les présents statuts à celle de l’assemblée générale.
Il peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, faire et passer tous actes et tous contrats, transiger,

compromettre, acquérir, échanger, vendre tous biens meubles et immeubles, hypothéquer, emprunter, conclure des
baux de toute durée, accepter tous legs, subsides, donations et transfert, renoncer à tous droits, conférer tous pouvoirs
à des mandataires de son choix, associés ou non, représenter l’association en justice, tant en défendant qu’en deman-
dant.

Il peut aussi toucher et recevoir toutes sommes et valeurs, retirer toute sommes et valeurs consignées, ouvrir des

comptes auprès des banques et de l’Office des chèques postaux, effectuer sur lesdits comptes toutes opérations et no-
tamment tout retrait de fonds par chèques, ordre de virement ou de transfert ou toute autre mandat de paiement, pren-
dre en location tout coffre en banque, payer toutes sommes dues par l’association, retirer de la poste, de la douane, de
la société des chemins de fer les lettres, télégrammes, colis, recommandés, assurés ou non; encaisser tout mandat poste
ainsi que toutes assignations ou quittances postales, renoncer à tous les droits contractuels ou réels ainsi qu’à toutes
garanties réelles ou personnelles; donner mainlevée, avant ou après paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hy-
pothécaires, transcriptions, saisies ou autres empêchements; exécuter tous jugements.

Le conseil nomme tous les agents, employés et membres du personnel de l’association et les destitue; il détermine

leurs occupations et traitements.

Art. 25. Le conseil peut déléguer la gestion journalière de l’association, avec l’usage de la signature afférente à cette

gestion, soit à un administrateur-délégué choisi parmi les membres, soit à un tiers. Il fixera les pouvoirs et éventuelle-
ment la rémunération de la personne chargée de la gestion journalière.

Le conseil peut, de même, déléguer des pouvoirs spéciaux soit à l’un de ses membres soit à un tiers.

Art. 26. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues, au nom de l’asso-

ciation, par le conseil d’administration, sur les poursuites et diligences du président.

Art. 27. L’association est engagée vis-à-vis des tiers:
- en toutes circonstances par la seule signature du président ou par les signatures conjointes de deux administrateurs,
- dans le cadre de la gestion journalière de l’association par la signature de la personne à laquelle la gestion journalière

a été déléguée,

- par les signatures conjointes ou la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature a été

donné par le conseil d’administration mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 28. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont

responsables que de l’exécution de leur mandat.

Titre 6. Règlement d’ordre intérieur

Art. 29. Un règlement d’ordre intérieur pourra être proposé par le conseil d’administration à l’assemblée générale.
L’adoption de ce règlement respectivement ses modifications ultérieures se feront par l’assemblée générale à la ma-

jorité simple des associés présents ou représentés.

Titre 7. Dispositions diverses

Art. 30. L’exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre. Par exception,

le premier exercice débutera à partir de la date de la publication des présentes au Mémorial pour se clôturer le trente
et un décembre 2005.

Art. 31. Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant seront annuellement soumis à l’approba-

tion de l’assemblée générale ordinaire.

Art. 32. Les fonds nécessaires à la réalisation de l’objet social seront constitués par:
- les contributions de l’Etat,
- les contributions des communes,
- les contributions de collectivités publiques,
- les contributions de personnes morales et privées,
- de dons et de legs,
- de recettes des manifestations et activités éventuellement organisées par elle,
- des cotisations des membres.

33949

Art. 33. L’assemblée générale désignera deux commissaires chargés de vérifier les comptes de l’association et de lui

présenter un rapport annuel. Ils sont nommés pour un terme ne pouvant dépasser trois années. Ils sont rééligibles.

Art. 34. La dissolution de l’association sera décidée conformément à la loi. L’assemblée générale désignera le ou les

liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Ces décisions ainsi que les noms, profession et adresse du ou des liquidateurs seront publiés aux Mémorial.

Art. 35. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi du vingt et un avril mil

neuf cent vingt-huit sur les associations et fondations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée.

<i>Assemblée Générale

Et immédiatement après la constitution de l’association tous les associés, se considérant dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé à trois (3), celui des commissaires à deux (2).
2. Sont appelés aux fonctions de membres du conseil d’administration:
- Monsieur Giovanni Patri, demeurant à L-Differdange, rue Pierre Frieden, n

o

 6;

- Monsieur Mauro Patri demeurant à L-2670, boulevard de Verdun, n

o

 51;

- Madame Anna de Michele, demeurant à L-5680 Dalheim, Neie Wee, n

o

 5.

3. Sont appelés aux fonctions de commissaires:
a) Olivier Laurent, demeurant à L-8706 Useldange, rue au Bierg n

o

 6;

b) Fernando Gagliardi, demeurant à L-1945 Luxembourg, route de Longwy n

o

 238.

4. Les mandats des administrateurs et des commissaires prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire an-

nuelle qui se tiendra en 2008.

5. La cotisation annuelle par associé est fixée à 25 euros.

Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, en langue d’eux connue, instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03596. – Reçu 243 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023078.3/000/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2005.

SUNRAYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 89.797. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03112, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

(023121.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

SAB, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, Z.A. Am Scheerleck.

R. C. Luxembourg B 67.201. 

<i>Sitzungsprotokoll vom Gesellschafterbeschluß vom 1. März 2005

<i>Erster und einziger Beschluß

Die Gesellschafter der SAB GmbH beschließen Herrn Robert Schweich, technischer Angestellter, wohnhaft in

L-6616 Wasserbillig, 24, rue Duchscher, zum technischen Geschäftsführer zu ernennen, welcher die Gesellschaft mit
seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig verpflichten kann.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03276. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023152.3/745/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Signatures.

SUNRAYS S.A.
V. Arno’ / F. Innocenti
<i>Administrateur / Administrateur

PROLUXRAIL HOLDING S.A. / PROLUXRAIL HOLDING S.A. / PROCONSULT GmbH / -
R. Ebsen / N. Ebsen / T. Frühauf / E. Wittmütz

33950

GESTAUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.655. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03115, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

(023124.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

DE DARLION INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 85.507. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03116, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

(023126.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE PONTE CARLO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.516. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03118, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

(023128.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

CRAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.157. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01576, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023264.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

CRAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.157. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02037, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023267.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

GESTAUT S.A.
V. Arno’ / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / Administrateur

DE DARLION INDUSTRIES S.A.
A. De Bernardi / V. Arno’
<i>Administrateur / Administrateur

COMPAGNIE FINANCIERE PONTE CARLO HOLDING S.A.
M.-F. Ries-Bonani / A. De Bernardi
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

Signature.

33951

T.H.F., TREFILERIES HAUTE FORET S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 39.500. 

Im Jahre zweitausendfünf, am achtundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze in Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft TREFILERIES HAUTE FORET, in Abkürzung T.H.F. S.A., mit Sitz in L-6776

Grevenmacher, 4, An de Laengten, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden im Amtssitze
in Luxemburg, am 28. Januar 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 299
vom 7. Juli 1992 und deren Statuten zuletzt abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar,
am 14. Mai 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 368 vom 13. August 1993,
zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Muriel Trap, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Remich, eröff-

net.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Henriette de Percin, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Remich.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Stefan Willems, Privatbeamter, wohnhaft zu D-54290 Trier, Karl

Marxstrasse 27.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6776 Grevenmacher, 4, An de Laengten nach L-6686 Mertert, 51, route

de Wasserbillig und entsprechende Abänderung des ersten Absatzes in Artikel 2 der Statuten. 

2. Abschaffung des Nennwertes der Aktien.
3. Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals in Euro, mit Rückwirkung zum 1. Januar 2002, zum festgesetz-

ten Kurs von vierzig Euro dreitausenddreihundertneunundneunzig Cent (40,3399,- LUF) zu einem Euro (1,- EUR), von
einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) auf dreissigtausendneunhundert sechs-
undachtzig Euro neunundsechzig Cent (30.986,69 EUR) eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien. 

4. Aufstockung des Gesellschaftskapitals um dreizehn Euro einunddreissig Cent (13,31 EUR) um es von seinem Betrag

von dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro neunundsechzig Cent (30.986,69 EUR) auf den Betrag von ein-
unddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zu bringen. 

5. Abänderung von Artikel 5, Absatz 1 der Statuten.
6. Bestätigung des Beschlusses vom 21. Dezember 2001.
7. Beschluss betreffend Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915.
8. Verschiedenes.
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums

der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-

net. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne va-
rietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertre-

ten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt
ist, zu beschliessen.

IV. Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6776 Grevenmacher, 4, An de Laengten nach

L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig, und entsprechende Abänderung von Artikel 2, Absatz 1 der Statuten um ihm
folgenden Wortlauf zu geben:

«Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst die Abschaffung des Nennwertes der Aktien. 

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst die Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals in Euro, rückwirkend zum 1. Ja-

nuar 2002, zum festgesetzten Kurs von vierzig Euro dreitausenddreihundertneunundneunzig Cent (40,3399 LUF) zu ei-
nem Euro (1,- EUR), von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000.- LUF) auf
dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro neunundsechzig Cent (30.986,69 EUR) eingeteilt in eintausendzwei-
hundertfünfzig (1.250) Aktien, ohne Nennwert.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst die Aufstockung des Aktienkapitals der Gesellschaft in Höhe von dreizehn Euro einund-

dreissig Cent (13,31,- EUR) um es von dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro neunundsechzig Cent
(30.986,69 EUR) auf einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zu erhöhen, durch Bareinlage von dreizehn Euro ein-
unddreissig Cent (13,31,- EUR), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

33952

<i>Fünfter Beschluss

Infolge der vorhergehenden Beschlüsse wird, rückwirkend zum 1. Januar 2002, Artikel 5, Absatz 1 der Statuten ab-

geändert um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 5. Absatz 1. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in eintau-

sendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien, ohne Nennwert.»

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung bestätigt den Beschluss vom 21. Dezember 2001, indem folgende Verwaltungsratsmitglie-

der ab 2. Januar 2002 ernannt wurden:

- Herr Wilfried Lattig, Kaufmann, geboren in D-Trier, am 30. April 1946, wohnhaft in D-54343 Föhren, In der Rotheck

37;

- Herr Hermann Jakob, Betriebswirt, geboren in D-Mertesdorf, am 27. März 1946, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf,

Bergstrasse 24;

- Herr Heinz Knauf, Kaufmann, geboren in D-Mehring, am 31. Mai 1948, wohnhaft in D-54346 Mehring, Medardus-

strasse 66;

- Herr Hans Dieter Schreiber, Betriebswirt, geboren in D-Perffingen, am 23. Oktober 1957, wohnhaft in D-54298

Orenhofen, Zemmererstrasse 75.

Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endet nach der ordentlichen Generalversammlung vom Jahre 2007.

<i>Siebenter Beschluss

Nach Einsicht der Bilanzen beschliesst die Gesellschaft, gemäss Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften, die Gesellschaft weiterzuführen und den Jahresverlust der Bilanz zum 31. Dezember 2002 auf
das folgende Geschäftsjahr zu übertragen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Trap, H. de Percin, S. Willems, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 2 mars 2005, vol. 468, fol. 83, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023167.3/221/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

T.H.F., TREFILERIES HAUTE FORET S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 39.500. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 10 mars 2005.

(023169.3/221/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

APEI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. APOTECA S.à r.l.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 26-30, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.065. 

L’an deux mille cinq le deux février.
Par-devant Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

1. Monsieur Guy Tabourin, indépendant, et 
2. Madame Doris Weber, indépendante, demeurant ensemble à L-2167 Luxembourg, 131, rue des Muguets.
Les prénommés sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée APOTECA S.à r.l., avec siège

social à Luxembourg, 12, rue de la Boucherie, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 mars
2000, acte publié au Mémorial C numéro 515 du 19 juillet 2000.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter les constatations et résolutions prises à l’unanimité

en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués:

Remich, den. 10 März 2005.

A. Lentz.

A. Lentz
<i>Notaire

33953

<i>Première résolution

Les associés constatent et acceptent les cessions de parts suivantes:
1) Monsieur Guy Tabourin, préqualifié, cède ses cinquante parts sociales (50) à Monsieur Wennan Zheng, indépen-

dant, demeurant à L-8395 Septfontaines, 12, rue de l’Eglise, intervenant au présent acte et cet acceptant. 

Cette cession de parts a été faite contre paiement d’une somme de six mille deux cent cinquante euros (EUR 6.250),

montant qui est payable en vingt-cinq (25) tranches de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) par virements bancaires
sur un compte à indiquer par le cédant chaque dernier du mois à partir du mois de janvier 2005 au mois de janvier 2007.

2) Madame Doris Weber, préqualifiée, cède ses cinquante parts sociales (50) à Monsieur Bin He, indépendant, de-

meurant à L-7540 Rollingen, 91, rue de Luxembourg, intervenant au présent acte et cet acceptant. 

Cette cession de parts a été faite contre paiement d’une somme de six mille deux cent cinquante euros (EUR 6.250),

montant qui est payable en vingt-cinq (25) tranches de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) par virements bancaires
sur un compte à indiquer par le cédant chaque dernier du mois à partir du mois de janvier 2005 au mois de janvier 2007.

Messieurs Wennan Zheng et Bin He déclarent consentir à ces cessions de parts et s’acceptent mutuellement comme

nouveaux associés de la société.

Suite à ces cessions de parts, la répartition de parts sociales est la suivante: 

<i>Deuxième résolution

Les nouveaux associés décident de changer la dénomination sociale en APEI S.à r.l.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social à L-1449 Luxembourg, 26-30, rue de l’Eau.

<i>Quatrième résolution

Suite à ces résolutions, les associés ont décidé d’adapter les statuts de la société et de modifier l’article 1

er

 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. La société prend la dénomination de APEI S.à r.l., société à responsabilité limitée.»

Les frais et honoraires en relation avec le présent acte sont tous à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signés le présent acte avec le notaire. 

Signé: G. Tabourin, D. Weber, W. Zheng, B. He, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 16 février 2005, vol. 406, fol. 18, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023216.3/240/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

APEI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. APOTECA, S.à r.l.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 26-30, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.065. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023218.3/240/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

FREEMIND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 77.182. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03119, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

(023131.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

- Monsieur Wennan Zheng, préqualifié, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- Monsieur Bin He, préqualifié, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Rambrouch, le 14 mars 2005.

L. Grethen.

L. Grethen
<i>Notaire

FREEMIND HOLDING S.A.
V. Arno’ / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / <i>Administrateur

33954

TRACTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 82.284. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03120, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

(023133.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

VERRINVEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.891. 

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02957, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

(023135.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

BUSINESS INVEST GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 30, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 26.759. 

EXTRAIT

II résulte des décisions prises lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour l’exercice 2003, tenue en

date du 22 décembre 2004, que le siège social de la société à été transféré à Esch-sur-Alzette, route de Belvaux, 30.

Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01892. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023136.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

EBONY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 102.155. 

Suite à la cession de parts intervenue en date du 1

er

 février 2005 entre CERBERUS ASSOCIATES LLC et CERBERUS

LuxCo LDC, les 125 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- CERBERUS LuxCo LDC, CALEDONIAN BANK &amp; TRUST LIMITED - Caledonian House - PO Box 1043 GT Geor-

ge Town - Grand Cayman - Cayman Islands, 125 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,00.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03502. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023161.3/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

TRACTION S.A.
F. Innocenti / J.-M Heitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

VERRINVEST LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>EBONY INVESTMENTS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

33955

MORTON FININVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.456. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02848, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023172.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

MORTON FININVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.456. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02850, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023174.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

MORTON FININVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.456. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02855, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023176.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

MORTON FININVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.456. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02856, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023178.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

MORTON FININVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.456. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02859, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023180.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

MORTON FININVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.456. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02861, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023183.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

33956

JANEK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 15.356. 

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02955, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023137.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

AU ROYAUME FLEURI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 89, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 106.585. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Madame Maria Helena Gomes, sans état, née à Vila Ca/Pombal (P), le 5 août 1958, demeurant à L-1140 Luxem-

bourg, 89, route d’Arlon.

2) Madame Patricia Blasi, employée privée, née à Villerupt (F), le 15 septembre 1969, demeurant à F-57390 Russange,

14, rue Arthur Rimbaud.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de AU ROYAUME FLEURI, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

Art. 3. La société a pour objet le commerce de fleuriste, avec vente des articles de la branche, ainsi que des acces-

soires, décorations, événements et services.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobi-

lières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile, sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en 100 parts

sociales de 125,- EUR chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

La somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), se trouve à la disposition de la société, ce que les associés

reconnaissent mutuellement.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

JANEK HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

1) Madame Maria Helena Gomes, préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

2) Madame Patricia Blasi, préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

33957

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille vingt euros.

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Est nommée gérante: Madame Maria Helena Gomes, préqualifiée.
2. La société est valablement engagée par la seule signature de la gérante.
3. Le siège social de la société est fixé à L-1140 Luxembourg, 89, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: H. Gomes, P. Blasi, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 janvier 2005, vol. 904, fol. 32, case 8. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023207.3/207/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

SUNSHINE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 87.146. 

L’an deux mille cinq, le deux mars. 
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SUNSHINE PROPERTIES

S.A., ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 87.146, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 avril
2002, publié au Mémorial C, numéro 1075 du 13 juillet 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Phlypo, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxem-

bourg. 

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Augmentation du capital social d’un montant de 89.000,- EUR pour le porter de son montant actuel de 31.000 EUR

à 120.000,- EUR par versement en espèces, sans émission d’actions nouvelles.

2) Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les man-
dataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social de

trente et un mille euros (31.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de quatre-vingt-neuf mille

euros (89.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cent vingt mille
euros (120.000,- EUR) sans émission d’actions nouvelles.

<i>Libération

Le montant de l’augmentation de capital à concurrence de quatre-vingt-neuf mille euros (89.000,- EUR) a été intégra-

lement libéré par les actionnaires existants, tels qu’ils figurent sur la liste de présence, au prorata de leur participation
dans le capital social, moyennant versements en espèces, de sorte que la somme de quatre-vingt-neuf mille euros
(89.000,- EUR) se trouve dès maintenant à libre et entière disposition de la société, la preuve en a été fournie au notaire
instrumentaire, qui le constate expressément.

Pétange, le 20 janvier 2005.

G. d’Huart.

33958

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance

avec ce qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à cent vingt mille euros (120.000,- EUR) représenté par mille (1.000)

actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’ augmentation de capital qui précède, s’élève à approximativement 2.000,- EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lutgen, I. Phlypo, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, vol. 147S, fol. 35, case 7. – Reçu 890 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(023191.3/212/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

SUNSHINE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 87.146. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

(023193.3/212/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

CHINESCO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.769. 

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02953, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

(023140.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 13.169. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 25 octobre 2004, AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme, 283, rou-

te d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Madame Isabelle Arend,
démissionnaire, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02179. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023234.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

P. Frieders.

P. Frieders
<i>Notaire

CHINESCO FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour LUXEMBOURG INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

33959

D.C. CARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4601 Differdange, 91-93, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 88.851. 

L’an deux mille cinq, le seize février.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Olivier Cuglietta, mécanicien, demeurant à L-3855 Schifflange, 166, cité Emile Mayrisch,
ici représenté par Monsieur Gaël Laffalize, employé privé, demeurant à B-Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 7 février 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, demeurera annexée aux

présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
a.- La société à responsabilité limitée D.C. CARS, S.à r.l., avec siège social à L-4601 Differdange, 91-93, avenue de la

Liberté, a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Esch-sur-AIzette, en date
du 28 août 2002, publié au Mémorial C page 72941 de 2002,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 88.851;
b.- Le capital social s’élève à douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq (EUR 125,-) euros chacune et il est actuellement réparti comme suit: 

Sur ce
Le comparant a déclaré qu’aux termes d’une cession de parts sociales sous seing privé datée du 25 janvier 2005,

Monsieur Pascal Domizio, préqualifié, lui a cédé ses trente-trois (33) parts sociales pour et moyennant un (1) euro sym-
bolique.

Le cessionnaire est devenu propriétaire des parts cédées le 25 janvier 2005 et il en a eu la jouissance et a été subrogé

dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir dudit jour.

<i>Acceptation

Le comparant, agissant en sa qualité de gérant technique et administratif, consent à la cession de parts ci-avant

mentionnée, conformément à l’article 1690 du Code civil, tant en nom personnel qu’au nom et pour compte de la
société et la tient pour valablement signifiée à la société et à lui-même.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après cette cession, l’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale extraordinai-

re, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En conséquence de ce qui précède l’article 7 des statuts est supprimé et aura désormais la teneur suivante:
«Les cent (100) parts sociales ont toutes été souscrites par l’associé unique, Monsieur Olivier Cuglietta, mécanicien,

demeurant à L-3855 Schifflange, 166, cité Emile Mayrisch.» 

<i>Deuxième résolution

II accepte la démission du gérant administratif, Monsieur Pascal Domizio, préqualifié, et lui donne décharge pour son

mandat.

<i>Troisième résolution

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique, Monsieur Olivier

Cuglietta, préqualifié.

<i>Frais

Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de

neuf cent cinquante (EUR 950,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé le présent acte avec Nous, notaire. 

Signé: G. Laffalize, U. Tholl. 
Enregistré à Mersch, le 21 février 2005, vol. 430, fol. 67, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023291.3/232/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Monsieur Olivier Cuglietta, préqualifié, soixante-sept parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 67

Monsieur Pascal Domizio, ouvrier, demeurant à Esch-sur-AIzette, 7, ruelle du Château, trente-trois parts  . . .

33

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Mersch, le 14 mars 2005.

U. Tholl.

33960

D.C. CARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4601 Differdange, 91-93, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 88.851. 

Statuts coordonnés suivant acte du 16 février 2005, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

(023300.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

HOVRA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.485. 

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02952, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023141.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

HSH NORDBANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 14.784. 

Im Jahre zweitausendundfünf, den vierundzwanzigsten Februar, um 9.30 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit Amtswohnsitz in Luxemburg. 

Treten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen, die Aktionäre der Aktiengesellschaft HSH

NORDBANK INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B Nummer 14.784 (hiernach «die Gesellschaft»), gegründet gemäß
Urkunde, aufgenommen durch Notar Hyacinthe Glaesener, mit damaligem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 23. März
1977, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 78 vom 7. April 1977.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und dies zuletzt gemäß Urkunde aufgenommen durch No-

tar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, am 2. Juni 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 739 vom 11.
Juli 2003.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr André Marc, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, welcher Herrn Chri-

stian Jungers, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer bestellt.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Steve Koenig, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg (der

Vorsitzende, der Sekretär und der Stimmenzähler bilden das «Büro» der Versammlung).

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-

klärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktionäre in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder

rechtlich vertreten sind; demzufolge ist die Generalversammlung regelmäßig zusammengesetzt und kann gültig über alle
Punkte der Tagesordnung beschließen; diese Anwesenheitsliste wurde von den Aktieninhabern beziehungsweise deren
Vertretern sowie von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem Notar unterzeichnet, und bleibt gegen-
wärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß

durch die Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Ak-
tionäre.

II. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Verzicht auf Frist- und Formalitätsregelungen der Einberufung.
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von 610.000.000 EUR (sechshundertzehn Millionen Euro), um

es von 43.000.000 EUR (dreiundvierzig Millionen Euro) auf 653.000.000 EUR (sechshundertdreiundfünfzig Millionen Eu-
ro) zu erhöhen, dies durch die Ausgabe von 119.020 (einhundertneunzehntausend und zwanzig) neuen Aktien ohne
Nennwert.

3. Zeichnung und Einzahlung der Gesellschaftskapitalerhöhung durch Einbringung eines Teilgeschäftsbereiches der

HSH NORDBANK AG, Luxembourg Branch.

4. Abänderung des ersten Absatzes des fünften Artikels der Gesell-schaftssatzung auf Grund der gefassten Beschlüsse.
5. Abänderung des Aktienregisters der Gesellschaft gemäß den oben erwähnten Änderungen, sowie Erteilung einer

Bevollmächtigung an einen Rechtsanwalt der Kanzlei ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG, diese Abänderung im Aktien-
register der Gesellschaft durchzuführen.

U. Tholl
<i>Notaire

HOVRA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

33961

Sodann trifft die Versammlung, nach Beratung und Billigung der Erklärungen des Vorsitzenden, einstimmig folgende

Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Gemäß Artikel 29 der Gesellschaftssatzung und in Anbetracht der Tatsache, dass alle Aktionäre vertreten sind, be-

schließt die Generalversammlung auf die Frist- und Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten; die Gesell-
schafter betrachten sich als rechtmäßig eingeladen und bestätigen volle Kenntnis der Tagesordnung zu haben, welche
ihnen vorher mitgeteilt wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital um den Betrag von 610.000.000 EUR (sechshundert-

zehn Millionen Euro), um es von 43.000.000 EUR (dreiundvierzig Millionen Euro) auf 653.000.000 EUR (sechshundert-
dreiundfünfzig Millionen Euro) zu erhöhen, dies durch die Ausgabe von 119.020 (einhundertneunzehntausend und
zwanzig) neuen Aktien ohne Nennwert.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass Herr Franz S. Waas Ph. D., Vorsitzender des Verwaltungsrats der

HSH NORDBANK INTERNATIONAL S.A., mit beruflichem Wohnsitz in D-24103 Kiel, Martensdamm 6 in seiner Ei-
genschaft als Eigentümer einer Aktie, vertreten, anhand einer Vollmacht, ausgestellt in Kiel am 11. Februar 2005, durch
Herrn André Marc, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, auf das Vorzugsrecht der Gesellschafter auf Zuteilung eines
seinem Anteil an dem bisherigen Aktienkapital entsprechenden Teils der neuen Aktien bei der vorliegenden Kapitaler-
höhung verzichtet und demnach mit der Zeichnung der gesamten Kapitalerhöhung durch HSH NORDBANK AG ein-
verstanden ist.

Die HSH NORDBANK AG, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Sitz in D-20095 Hamburg, Gerhart-Haupt-

mann-Platz 50 und D-24103 Kiel, Martensdamm 6, vertreten, anhand einer Vollmacht, ausgestellt in Kiel am 14. Februar
2005, durch Herrn André Marc, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, erklärt, die 119.020 (einhundertneunzehntau-
send und zwanzig) neu ausgegebenen Aktien zu zeichnen und diese mittels einer Sacheinlage in Form eines Teilgeschäfts
der HSH NORDBANK AG, LUXEMBOURG BRANCH, voll einzuzahlen.

Bei der Sacheinlage handelt es sich um die Einbringung der Gesamtaktiva und -passiva des Teilbetriebes «Wertpapier-

geschäft»; hierunter subsumiert die Niederlassung grundsätzlich Wertpapiere ohne Strukturen mit Derivaten sowie Re-
finanzierungsgeschäfte.

Diese Sacheinlage in einer Höhe von 610.000.000 EUR (sechshundertzehn Millionen Euro) ist integral dem Gesell-

schaftskapital zuzuführen.

Das Einzahlen wurde gemäß den Artikeln 261 und 32-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, durch einen

unabhängigen Wirtschaftsprüfer, die Gesellschaft PricewaterhouseCoopers, mit Sitz in L-1471 Luxembourg, 400, route
d’Esch, begutachtet, und dessen Schlussfolgerung wie folgt lautet:

«Als Schlussfolgerung unserer Prüfung bescheinigen wir hiermit, dass uns keine Umstände bekannt geworden sind,

die darauf hindeuten würden, dass der Wert der Sacheinlage nicht mindestens gleich der Anzahl und dem Wert der im
Gegenzug neu auszugebenden Aktien ist.»

Besagtes Gutachten vom 23. Februar 2005, ne varietur unterzeichnet durch die Mitglieder des Versammlungsvorstan-

des und den instrumentierenden Notar, wird gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu wer-
den.

Der entsprechende neue Wortlaut der Satzung wird unter dem vierten Beschluss wiedergegeben.

<i>Aktieneigentümer der Gesellschaft sind demnach:  

Das Datum, ab welchem buchhalterisch obige Sacheinlage vorgenommen wird, wird auf den 11. Februar 2005 festge-

legt.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Abänderung des ersten Absatzes des fünften Artikels der Satzung der Ge-

sellschaft auf Grund der gefassten Beschlüsse.

Der Wortlaut des ersten Absatzes des fünften Artikels ist demnach folgender:
«Das Aktienkapital beträgt 653.000.000 EUR (sechshundertdreiundfünfzig Millionen Euro), eingeteilt in 127.410 (ein-

hundertsiebenundzwanzigtausendvierhundertzehn) Aktien ohne Wertangabe, welche voll eingezahlt sind.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, das Aktienregister der Gesellschaft gemäß der oben erwähnten Änderungen ab-

zuändern und bevollmächtigt einen Rechtsanwalt der KANZLEI ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG, diese Abänderung
im Aktienregister der Gesellschaft durchzuführen.

<i>Einregistrierung

Obige Sacheinlage besteht aus einer Teilaktivität einer Gesellschaft die in der Europäischen Gemeinschaft eingetragen

ist, und demnach beruft die Gesellschaft sich auf Artikel 4-1 des abgeänderten Gesetzes vom 29. Dezember 1971, der
die Befreiung der Einlage von der anteiligen luxemburgischen Kapitalsteuer (droit d’apport) vorsieht.

Aktieninhaber

Anzahl der gehaltenen Aktien

HSH NORDBANK AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127.409

Herr Franz S. Waas Ph. D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127.410

33962

<i>Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten welcher Art auch immer, die der Gesellschaft

aufgrund der vorliegenden Versammlung entstehen und für die sie haftet, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte
mit 7.000 EUR (siebentausend Euro) bewertet.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldungen mehr vorliegen,

schließt der Vorsitzende die Sitzung um 10.00 Uhr.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-

kunde auf Verlangen der erschienenen Parteien in deutscher Sprache, gefolgt von einer Übersetzung in englischer Spra-
che, verfasst ist, und dass auf Verlangen derselben erschienenen Parteien bei Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, die deutsche Fassung maßgebend ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsvorstandes zusammen
mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Follows the Englisch version of the above text:

In the year two thousand and five, the twenty-fourth day of February at 9.30 a.m.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of HSH NORDBANK IN-

TERNATIONAL S.A. (the Company), a société anonyme incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet, and being registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 14.784. The Company has been incorporated pursuant to a deed
of Maître Hyacinthe Glaesener, notary residing in Luxembourg at that time, on 23 March 1977, published in the Mémo-
rial C, N° 78 of 7 April 1977, such articles having been amended on several occasions and for the last time by a deed of
notary Jean Seckler, residing in Junglinster, on 2 June 2003, published in the Mémorial C, N° 739 of 11 July 2003.

The Meeting is chaired by André Marc, attorney-at-law, residing in Luxembourg, who appoints Christian Jungers, at-

torney-at-law, residing in Luxembourg, as Secretary.

The Meeting appoints as Scrutineer Steve Koenig, attorney-at-law, residing in Luxembourg (the Chairman, the Sec-

retary and the Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting). 

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the shareholders

representing the entirety of the share capital of the Company are duly present or represented at this Meeting which is
consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without
prior notice, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda. The
attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the notary,
shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.

The proxies from the shareholders represented at the Meeting after having been signed ne varietur by the appearing

parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authori-
ties.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 610,000,000 (six hundred and ten million Euro)

in order to bring the share capital from its present amount of EUR 43,000,000 (forty-three million Euro) to EUR
653,000,000 (six hundred and fifty-three million Euro) by way of the creation and issuance of 119,020 (one hundred
nineteen thousand and twenty) new shares of the Company, without a par value. 

3. Subscription and full payment of the share capital increase by a contribution in kind of a part of the activity of HSH

NORDBANK AG, LUXEMBOURG BRANCH.

4. Amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company to reflect the above

mentioned change; 

5. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above mentioned changes with power

and authority to any lawyer of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG to make on behalf of the Company the required
amendments in the share register of the Company.

The facts exposed are recognised as accurate by the Meeting, and after deliberation, the Meeting unanimously takes

the following resolutions.

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the Meeting, the Meeting waives, in accordance with

article 29 of the articles of association, the convening notices, the shareholders being represented consider themselves
as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been made available to them in advance. 

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 610,000,000 (six hundred

and ten million Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 43,000,000 (forty-three million
Euro) to EUR 653,000,000 (six hundred and fifty-three million Euro) by way of the creation and issuance of 119,020 (one
hundred nineteen thousand and twenty) new shares of the Company, without a par value. 

33963

<i>Third resolution

The Meeting resolves to note that Mr Franz S. Waas Ph. D., chairman of the board of directors of HSH NORDBANK

INTERNATIONAL S.A., having his professional residence in D-24103 Kiel, Martensdamm 6, in his capacity of sharehold-
er of one share, hereby represented by André Marc, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney signed in Kiel on 11 February 2005, declares that he waives his preferential subscription right and that he ac-
knowledges that HSH NORDBANK AG subscribes to the entirety of the increase of the share capital. 

HSH NORDBANK AG, a company incorporated under the laws of Germany and having its registered office in D-

20095 Hamburg, Gerhart-Hauptmann-Platz 50 and D-24103 Kiel, Martensdamm 6, hereby represented by André Marc,
attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney signed in Kiel on 14 February 2005, has de-
clared to subscribe to the entirety of the share capital increase of 119,020 (one hundred nineteen thousand and twenty)
shares and to fully pay the share capital increase by a contribution in kind of a part of the activity of HSH NORDBANK
AG, LUXEMBOURG BRANCH. 

The contribution in kind comprises the contribution of all assets and liabilities of the part of the activity «securities

business»; this includes up to definition of the branch in principle all securities without derivative structures and the
respective refinancing transactions.

This contribution in kind having a value of EUR 610,000,000 (six hundred and ten million Euro) is to be allocated to

the share capital account of the Company. 

Pursuant to articles 26 - 1 and article 32 - 1 of the Luxembourg Company Act, the Shares so contributed in kind have

been the subject of a report prepared by PricewaterhouseCoopers, having its registered office in L-1471 Luxembourg,
400, route d’Esch, as independent auditor (réviseur d’entreprises), which concludes as follows:

«Based on the work performed, we have no knowledge of any event, that could indicate that the value of the contri-

bution in kind is not at least equal to the number and the value of the shares to be issued in return.»

The said auditor’s report dated 23 February 2005, after having been signed ne varietur by the members of the board

of the meeting and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

The change in the articles of association will be reflected under the fourth resolution.

<i>The shareholders of the company are: 

In the accounts the contribution in kind will be operated with effective date February 11, 2005.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the above Resolutions, the Meeting resolves to amend paragraph 1 of article 5 of the articles of

association of the Company and which will henceforth read as follows:

«The share capital of the company is fixed at EUR 653,000,000 EUR (six hundred and fifty-three million Euro), divided

into 127,410 (one hundred twenty-seven thousand four hundred and ten) shares without nominal value, which are fully
paid up.»

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and appoints

any lawyer of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG to make the required amendments in the share register of the Com-
pany.

<i>Tax exemption

As the contribution in kind consists of part of the activity of a company incorporated and having its registered office

in the European Union the Company refers to article 4-1 of the law dated 29 December 1971, as amended, which pro-
vides for capital duty exemption.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses, costs and expenditures in relation to the present deed are estimated to be approxi-

mately EUR 7.000 (seven thousand Euro).

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed at 10.00 a.m.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in German followed by an English version; at the request of the same appearing parties, it
is stated that, in case of discrepancies the German version shall prevail. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing parties, known to the undersigned notary by names, first names,

civil status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary, the present orig-
inal deed.

Signed: A. Marc, Ch. Jungers, St. Koenig, P. Frieders.

Shareholder

Amount of shares

HSH NORDBANK AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,409
Mr Franz S. Waas Ph. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

127,410

33964

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, vol. 147S, fol. 26, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

(023175.3/212/229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

HSH NORDBANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 14.784. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

(023177.3/212/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

MAKVALOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.635. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02951, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

(023143.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

BELTXNEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.297. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02950, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023144.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

DANKALUX, S.à r.l. AND Co. S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 57.014. 

In the year two thousand and five, on the third of March.
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of DANKALUX, S.à r.l. AND Co. S.C.A., a société

en commandite par actions, with registered office in L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich, RCS Luxem-
bourg B 57.014, incorporated by deed of M

e

 André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on November 29,

1996, published in the Mémorial C, number 70 of February 14, 1997. 

The meeting was presided by Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg,
who appointed as secretary Ms Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg. 
The meeting elected as scrutineer Mr Frédéric Lemoine, attorney-at-law, residing in Luxembourg. 
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:
1.- Amendment of the second sentence of the first paragraph of article 16 of the articles of association so that it reads

as follows:

Luxemburg, den 14. März 2005.

P. Frieders.

P. Frieders
<i>Notaire

MAKVALOR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

BELTXNEA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

33965

«The members of the Supervisory Board shall be elected by the general meeting of Shareholders for a period not

exceeding six years, provided however, that any of the members of the Supervisory Board may be removed with or
without cause and/or replaced at any time by a resolution adopted by the Shareholders.»

2.- Further amendment of article 16 of the articles of association, with effect on April 1, 1997, in order to delete the

last paragraph.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-
holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay af-
fixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III. It appears from the attendance list, that all the eight thousand seven hundred and fifty (8,750) Ordinary Shares and

all the three thousand seven hundred and fifty (3,750) B Shares, representing the whole share capital of one million two
hundred and fifty thousand Pounds Sterling (1,250,000.- GBP) are represented at the present extraordinary general
meeting.

IV. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders

have been informed before the meeting.

V. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the

meeting proceeded to the agenda. The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of
the members of the meeting the following resolutions which were taken unanimously: 

<i>First resolution

The general meeting decides to amend the second sentence of the first paragraph of article 16 of the articles of as-

sociation so that it reads as follows:

«The members of the Supervisory Board shall be elected by the general meeting of Shareholders for a period not

exceeding six years, provided however, that any of the members of the Supervisory Board may be removed with or
without cause and/or replaced at any time by a resolution adopted by the Shareholders.»

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend article 16 of the articles of association, with effect on April 1, 1997, in order

to delete the last paragraph.

There being no further items on this agenda, the meeting was closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed. 

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le trois mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions DANKA-

LUX, S.à r.l. AND Co. S.C.A., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 57.014, constituée suivant acte reçu par Maître André
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 novembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 70 du
14 février 1997. 

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Frédéric Lemoine, avocat, demeurant à Luxembourg. 

Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Modification de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Les membres du Conseil de Surveillance seront élus par l’assemblée générale des Actionnaires pour une période ne

pouvant excéder six ans, à condition cependant, que tout membre du Conseil de Surveillance puisse être révoqué avec
ou sans cause et/ou remplacé à tout moment par décision prise par les Actionnaires.»

2.- Modification de l’article 16 des statuts, avec effet au 1

er

 avril 1997, en supprimant le dernier alinéa.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Il résulte de cette liste de présence que toutes les huit mille sept cent cinquante (8.750) Actions Ordinaires et

toutes les trois mille sept cent cinquante (3.750) Actions B, représentatives de l’intégralité du capital social d’un million

33966

deux cent cinquante mille Livres Sterling (1.250.000,- GBP) sont représentées à la présente assemblée générale extra-
ordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour. Après délibération, le prési-

dent met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 16 des statuts pour lui don-

ner la teneur suivante:

«Les membres du Conseil de Surveillance seront élus par l’assemblée générale des Actionnaires pour une période ne

pouvant excéder six ans, à condition cependant, que tout membre du Conseil de Surveillance puisse être révoqué avec
ou sans cause et/ou remplacé à tout moment par décision prise par les Actionnaires.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 16 des statuts, avec effet au 1

er

 avril 1997, en supprimant le dernier

alinéa.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française. Sur demande des mêmes comparants
et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membre du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Ch. Keereman, C. Wiser, F. Lemoine, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, vol. 147S, fol. 35, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(023196.2/212/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

DANKALUX, S.à r.l. AND Co. S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 57.014. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

(023198.3/212/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

PEARSON LUXEMBOURG N

°

 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.148. 

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre décembre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée PEARSON

LUXEMBOURG N° 2, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg
section B numéro 100.137, constituée suivant acte reçu le 31 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 575 du 4 juin 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 10.000 (dix mille) parts, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

Luxembourg, le 16 mars 2005. 

P. Frieders.

P. Frieders
<i>Notaire

33967

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de l’année sociale de la société de 1

er

 janvier - 31 décembre de chaque année par 31 décembre - 30

décembre de chaque année et fixation de l’année sociale en cours qui a débuté le 31 mars 2004 pour se terminer le 30
décembre 2004.

2.- Modification afférente des articles 17 et 18 des statuts.
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de:
- changer l’année sociale de la société du 1

er

 janvier au 31 décembre de chaque année par une année sociale qui com-

mence le 31 décembre d’une année et se termine le 30 décembre de l’année suivante;

- clôturer l’année sociale en cours, qui a débuté le 31 mars 2004, au 30 décembre 2004.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier:
a) l’article 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

<i>Version anglaise:

«The Company’s financial year begins on 31 December of one year and closes on 30 December of the next year.»

<i>Version française:

«L’exercice social commence le 31 décembre d’une année pour se terminer le 30 décembre de l’année suivante.»
b) l’article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

<i>Version anglaise:

«Each year, as of 30 December, the board of managers will draw up the balance sheet which will contain a record of

the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a sum-
mary of all its commitments and the debts of the manager(s):, statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward
the Company.

At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general

meeting of shareholders together with the balance sheet.»

<i>Version française:

«Chaque année, avec effet au 30 décembre, le conseil de gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants, des commissaires (s’il en existe) et des associés envers la société.

Dans le même temps, le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée

générale des associés avec le bilan.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Speecke, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 19, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023453.3/211/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

CANILLAC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.388. 

Le bilan au 31 août 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02948, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023148.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

J. Elvinger.

CANILLAC HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

33968

KINASE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.588. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02947, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023151.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

MAZFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.303. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02946, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023155.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

WIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.337. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03030, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023158.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

CF SERVICES, CORPORATE AND FIDUCIARY SERVICES, Société Civile.

Siège social: Luxembourg.

L’an deux mille cinq, le quatre mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite

sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 71.178, ici représentée par Monsieur John Seil, ci-après nommé, agissant en sa
qualité d’administrateur de la société, ayant le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg.
3. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1) Que suite à une cession de part sous seing privé intervenue en date du 23 février 2005, laquelle cession restera,

après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être
formalisée avec elles, il a été cédé: 

par Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à L-6973 Rameldange, 12,

Am Beiebierg, à Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, une (1) part sociale de la société CORPORATE AND FIDUCIARY SERVICES, en abrégé CF SERVICES.

2) en conséquence de ce qui précède, la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Monsieur Pierre Lentz et Mon-

sieur John Seil sont les seuls associés actuels de la société civile CORPORATE AND FIDUCIARY SERVICES en abrégé
CF SERVICES avec siège social à Luxembourg, constituée par acte notarié, en date du 15 septembre 1988, publié au
Mémorial, Recueil Spécial Sociétés et Associations numéro 323 du 8 décembre 1988 dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 28 juillet 2003, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1002 du 30 septembre 2003.

Après avoir exposé ce qui précède, les associés, représentés comme dit ci-avant, se sont réunis en assemblée géné-

rale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

KINASE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

MAZFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

WIC HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

33969

<i>Première résolution

Conformément à l’article 7 des statuts, les associés décident à l’unanimité, d’accepter et de donner leur agrément à

la cession de part dont question ci-avant.

<i>Deuxième résolution

Les associés constatent la conversion automatique de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembour-

geois en euros en date du 1

er

 janvier 2002.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze cents

(2.478,94 EUR) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Ces parts sociales se répartissent comme suit: 

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de la présente est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: J. Seil, P. Lentz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, vol. 147S, fol. 39, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023259.3/220/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

CF SERVICES, CORPORATE AND FIDUCIARY SERVICES, Société Civile.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

(023262.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

B.S.A.W-EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1726 Luxembourg, 41, rue Pierre Hentges.

R. C. Luxembourg B 31.781. 

L’an deux mille quatre, le deux mars.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme B.S.A.W-EXPLOITATION S.A., avec

siège social à Lamadelaine, constituée par acte du notaire André Schwachtgen en date du 15 septembre 1990, publiée
au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 67 du 2 mars 1990, dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 5 novembre 2004, en cours de publication au
Mémorial.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (Belgique),
qui désigne comme secrétaire Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Korpys, vendeur magasinier, demeurant à Serémange-Erzange

(France). 

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de la société B.S.A.W-EXPLOITATION S.A. de Lamadelaine à L-1726 Luxembourg, 41,

rue Pierre Hentges.

2. Changement subséquent de l’article 1

er

 alinéa 2 des statuts suite au changement de siège de la société. 

1.- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98 parts sociales

2.- Monsieur John Seil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part

sociale

3.- Monsieur Pierre Lentz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part

sociale

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts sociales

Luxembourg, le 14 mars 2005.

G. Lecuit.

G. Lecuit
<i>Notaire

33970

3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société à L-1726 Luxembourg, 41, rue Pierre Hentges.

<i>Deuxième résolution

Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 1

er

 alinéa 2 des statuts, qui aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 1

er

. Deuxième alinéa. Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de la présente est évalué à environ sept cent cinquante euros (750,- EUR). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Tassigny, M. Nezar, E. Korpys, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, vol. 23CS, fol. 88, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023265.3/220/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

B.S.A.W-EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1726 Luxembourg, 41, rue Pierre Hentges.

R. C. Luxembourg B 31.781. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

(023268.3/220/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

GOLDEN TROPI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 86.341. 

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,

L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02183. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023240.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

G. Lecuit.

G. Lecuit
<i>Notaire

<i>Pour GOLDEN TROPI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

33971

DS SMITH (HOLDING) B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 181.292.375,-.

Siège statutaire: NL-2288 EH Rijkswijk, Pays-Bas, 17, Treubstraat.

Siège de direction effective: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 93.311. 

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02738, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023163.3/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

DS SMITH (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 93.199. 

Le bilan au 29 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02738, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023166.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

IREPA INDUSTRIAL RESEARCH &amp; PATENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.579. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02846, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023170.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

R.C. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 61.039. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03501, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2005.

(023197.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

LAS GAVIOTAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 86.360. 

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,

L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02181. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023237.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

<i>Pour LAS GAVIOTAS, Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

33972

JOCAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.123. 

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02863, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023184.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

JOCAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.123. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02866, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023186.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

JOCAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.123. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02868, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023187.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

JOCAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.123. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02878, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023189.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

GROWTH INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 6.624. 

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00375, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023359.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

GROWTH INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 6.624. 

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00376, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023360.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

Signature.

33973

ARKINMOB INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 54.302. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03494, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2005.

(023188.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

ARKINMOB INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 54.302. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03495, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2005.

(023190.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

STAVELEY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 18.362. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 2 mars 2005

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2004:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président;

- Monsieur Richard Laurence Todd, directeur, demeurant au 5, avenue Neville, New Malden, Grande-Bretagne;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2004:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg, en remplacement de

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., commissaire aux comptes démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03040. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023282.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.

TRANSPACIFIC FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Registered office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 8.576. 

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of TRANSPACIFIC FUND will be held at the registered office of the Company at 46, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg on <i>July 26, 2005 at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the follow-
ing matters:

<i>Agenda:

1. To hear the report of the Board of Directors for the year ended March 31, 2005.
2. To hear the report of the Independent Auditor.
3. Approbation of the annual accounts for the year ended March 31, 2005.
4. Allocation of the net profit and the amount and date of payment of the dividend.
5. To discharge the Directors with respect to the performance of their duties during the year ended March 31, 2005.
6. Statutory elections.
7. Nomination of a new Independent Auditor.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

33974

8. Approbation of the payment of the Directors’ fees for the period under review.
9. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the statutory general meeting and that decisions will be

taken by the majority of the shares present or represented at the meeting.

In order to take part at the statutory meeting, the owners of registered shares must be registered in the Company’s

register of shareholders five clear days before the meeting and the owners of bearer shares will have to deposit their
shares five clear days before the meeting at the registered office of the Fund or at the following banks:

- BANQUE DE NEUFLIZE, 3, avenue Hoche, Paris, France
- ABN AMRO BANK N.V., Kemelstede 2, 4817 ST Breda, The Netherlands.

Luxembourg, 8 July 2005.

II (03348/755/28) 

<i>The Board of Directors.

FIDELITY FUNDS II SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1021 Luxembourg, place de l’Etoile, Kansallis House.

R. C. Luxembourg B 76.939. 

At the Extraordinary General Meeting held at the registered office of FIDELITY FUNDS II SICAV («the Fund») on

Wednesday 29 June 2005 at 9.15 a.m. (CET), a quorum was not attained. Therefore:

Notice is hereby given that the adjourned

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of the Fund will be held at the registered office of the Fund in Luxembourg on Wednesday <i>3 August
2005 at 9.45 a.m. (CET) to consider the following agenda:

<i>Agenda:

1. To change the name of the Fund from FIDELITY FUNDS II SICAV to FIDELITY FUNDS II and to amend Article

1 of the Articles of Incorporation in accordance with this change.

2. Amend Article 3 of the Articles of Incorporation so as to read: «The exclusive object of the Corporation is to

invest the funds available to it in securities of all types, money market instruments, derivative instruments, cash
and cash equivalents as well as other assets permitted by law with the purpose of spreading investment risk and
affording its shareholders the results of the management of its assets.
 The Corporation may take any measures and carry out any transactions which it may deem useful for the fulfil-
ment and development of its purposes to the fullest extent permitted by the law of 20th December 2002 on
undertakings for collective investment (the «Law»).»

3. Amend the second sentence of Article 4 of the Articles of Incorporation so as to read: «Branches or other offices

may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad...»

4. Amend the second paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation so as to read: «The minimum capital

of the Corporation shall be the equivalent in United States dollars of 1,250,000.- euro.»

5. Delete paragraph 11 of Article 5 of the Articles of Incorporation.
6. Amend the current paragraph 16 of Article 5 of the Articles of Incorporation so as to read: «... and other instru-

ments of transfer satisfactory to the Corporation on the basis of which the Corporation may record the transfer
in the Register of Shareholders or by written declaration of transfer recorded in the Register of Shareholders...»

7. Addition of the following sentence at the beginning of the current paragraph 17 of Article 5 of the current Articles

of Incorporation: «The Corporation only recognises one single owner per share.»

8. Amend the first paragraph of Article 7 of the Articles of Incorporation so as to read: «... if in the opinion of the

Corporation such holding may be detrimental to the Corporation or the majority of the shareholders thereof or
of any class thereof, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as
a result thereof it may have adverse regulatory, tax or fiscal consequences, and in particular if the Corporation
may become subject to tax laws other than those of the Grand Duchy of Luxembourg...»

9. Amend paragraph 2 of Article 7 D (1) of the Articles of Incorporation so as to read: «... addressed to such share-

holder at their last address known to or appearing in the Register of Shareholders of the Corporation...»

10. Amend Article 8 of the Articles of Incorporation so as to read: «Whenever used in these Articles the term «US

person» means:
(a) a citizen or resident of the United States of America;
(b) a partnership, corporation, limited liability company or similar entity, organised or incorporated under the
laws of the United States of America, or an entity taxed as such or subject to filing a tax return as such under
the United States federal income tax laws;
(c) any estate or trust the executor, administrator or trustee of which is a US Person unless, in the case of trusts
of which any professional fiduciary acting as trustee is a US Person, a trustee who is not a US Person has sole or
shared investment discretion with respect of trust assets and no beneficiary of the trust (and no settler if the
trust is revocable) is a US Person;
(d) any estate or trust the income of which from sources without the United States of America is includible in
gross income for purposes of computing United States income tax payable by it;
(e) any agency or branch of a foreign entity located in the United States of America;

33975

(f) any discretionary account or non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held
by a dealer or other fiduciary located within or outside the United States of America for the benefit or account
of a US Person;
(g) any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary
organised, incorporated or (if an individual) resident in the United States of America, except that any discretion-
ary account or similar account (other than an estate or trust) held for the benefit or account of a non-US Person
by a dealer or other professional fiduciary organised, incorporated (or if an individual) resident in the United
States of America shall not be deemed a US Person;
(h) any firm, corporation or other entity, regardless of citizenship, domicile, situs or residence if, under the in-
come tax laws of the United States of America from time to time in effect, any proportion of the income thereof
would be taxable to a US Person even if not distributed, other than a passive foreign investment company;
(i) any partnership, corporation or other entity if (A) organised or incorporated under the laws of any foreign
jurisdiction; and (B) owned or formed by a US Person or Persons principally for the purpose of investing in se-
curities not registered under the US Securities Act of 1933 (including but not limited to Shares of the Fund);
(j) any employee benefit plan unless such employee benefit plan is established and administered in accordance
with the law of a country other than the United States of America and customary practices and documentation
of such country and is maintained primarily for the benefit of persons substantially all of whom are non-resident
aliens with respect to the United States of America; and
(k) any other person or entity whose ownership of Shares or solicitation for ownership of Shares in FIDELITY
INVESTMENTS INSTITUTIONAL SERVICES COMPANY Inc., FIDELITY DISTRIBUTORS INTERNATIONAL
LIMITED or the Fund, acting through their Officers or Directors, shall determine may violate any securities law
of the United States of America or any state or other jurisdiction thereof.
US Person shall not include an Eligible Investor or any person or entity, notwithstanding the fact that such person
or entity may come within any of the categories referred to above, as to whom Fidelity Distributors International
Limited or the Fund, acting through their Officers or Directors, shall determine that ownership of Shares or so-
licitation for ownership of Shares shall not violate any securities law of the United States of America or any state
or other jurisdiction thereof.
As used herein, United States of America includes its states, commonwealths, territories, possessions and the
District of Columbia.
Whenever used in these Articles, «three per cent owner» means any person, firm or corporate body which as
a legal or beneficial holder owns more than three per cent of the number of shares of the Corporation from time
to time outstanding.
Three per cent owner as used herein shall not include any subscriber to shares of the Corporation issued in con-
nection with organisation of the Corporation while such subscriber holds such shares or any securities dealer
who acquires shares with a view to their distribution in connection with an issue of shares by the Corporation.»

11. Amend paragraph 4 of Article 10 of the Articles of Incorporation so as to read: «If bearer shares are in issue,

notice of meeting of shareholders will be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Lux-
embourg and in a Luxembourg newspaper... sent to the holders of nominative shares eight days prior to the meet-
ing...»

12. Amend the first sentence of paragraph 4 of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to read: «The Board

of Directors from time to time shall appoint the officers and the Managing Directors of the Corporation...»

13. Amend paragraph 5 of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to read: «Notice of any meeting of the

Board of Directors shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, fax or by any other electronic means...
This notice may be waived by the consent in writing by telegram, telex, fax or by any other electronic means of
each director...»

14. Amend paragraph 6 of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to read: «... which appointment shall be

in writing or in the form of a telegram or telex or fax or by any other electronic means. Any Director may attend
a meeting of the Board of Directors using teleconference or video means and participating in a meeting by such
means shall constitute presence in person at such meeting.»

15. Amend Article 15 of the Articles of Incorporation so as to read: «The Board of Directors shall, based upon the

principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy for the investments
relating to each class of shares and the course of conduct of the management and business affairs of the Corpor-
ation. The Board of Directors shall also have power to determine any restrictions which shall from time to time
be applicable to the investments of the Corporation’s assets, in accordance with Part I of the Law including, with-
out limitation, restrictions in respect of:
a) the borrowings of the Corporation and the pledging of its assets; and
b) the maximum percentage of its assets which it may invest in any form or class of security and the maximum
percentage of any form or class of security which it may acquire.
The Board of Directors may decide that investment of the Corporation’s assets be made (i) in transferable se-
curities/money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Law; (ii) in
transferable securities/money market instruments dealt in on another market in a Member State of the European
Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public; (iii) in transferable securi-
ties/money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in any other country in Europe,
Asia, Australia, Oceania, the American continents and Africa, or dealt in on another market that is regulated, in
the countries referred to above, provided that such market operates regularly and is recognised and open to the
public; (iv) in recently issued transferable securities/money market instruments provided the terms of the issue

33976

include an undertaking that application will be made for admission to official listing on any of the stock exchanges
or other regulated markets referred to above and provided that such admission is secured within one year of the
issue; and (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by
the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and as disclosed in the sales documents
of the Corporation. 
The Board of Directors of the Corporation may decide to invest up to one hundred per cent of the total net
assets of the Corporation in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed
by any Member State of the European Union, its local authorities, a non-Member State of the European Union,
as acceptable by the supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Corporation, or public
international bodies of which one or more of such Member States of the European Union are members, provided
that in the case where the Corporation decides to make use of this provision it must hold securities from at least
six different issues and securities from any one issue may not account for more than thirty per cent of the Cor-
poration’s total net assets.
The Board of Directors may decide that investment of the Corporation’s assets be made in financial derivative
instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the
Law and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying
consists of instruments covered by Article 41 (1) of the Law, financial indices, interest rates, foreign exchange
rates or currencies, in which the Corporation may invest according to its investment objectives as disclosed in
the sales documents of the Corporation.
The Board of Directors may decide that investments of the Corporation’s assets being made with the aim to
replicate certain stock indices or bond indices, provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg
supervisory authority on the basis that it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the mar-
ket to which it refers and is published in any appropriate manner.
The Corporation will not invest more than 10% of its net assets in units of undertakings for collective investment
as defined in the Law.
When investments of the Corporation are made in the capital of subsidiary companies which, exclusively on its
behalf carry on only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is lo-
cated, with regard to the redemption of units at the request of unitholders, paragraphs (1) and (2) of Article 48
of the Law do not apply.»

16. Replacement of the words «law of thirtieth March one thousand nine hundred and eighty eight regarding collec-

tive investment undertakings» with «Law» in the first paragraph of Article 20 of the Articles of Incorporation.

17. Delete the words «with or without cause» from the end of the second paragraph of Article 20 of the Articles of

Incorporation.

18. Amend the third sentence of the second paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation so as to read:

«Shares of the capital of the Corporation redeemed by the Corporation shall be cancelled.»

19. Delete the words «(such fee and estimate not to exceed one per cent of such Net Asset Value)» from the end

of the second sentence of the third paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation.

20. Replace the final paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation in its entirety with the following: «Fur-

ther, redemption requests may be deferred under certain circumstances and within certain thresholds as detailed
in the sales documents.»

21. Insert the following paragraph after the current final paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation: «In

addition a dilution levy may be imposed on deals as specified in the sales documents. Such dilution levy should
not exceed 5% of the Net Asset Value and will be calculated taking into account the estimated costs, expenses
and potential impact on security prices that may be incurred to meet redemption and conversion requests.»

22. Insert the following paragraph at the end of Article 21 of the Articles of Incorporation: «There may be deducted

from the Net Asset Value a fee payable to the Corporation with a maximum of 2%.»

23. Delete the words «, unless all such shareholders and their addresses are known to the Corporate» from the end

of the second paragraph of Article 21.bis of the Articles of Incorporation.

24. Insert the following paragraph after paragraph nine of Article 22 of the Articles of Incorporation: «(g) in the event

of the convening of an extraordinary general meeting of the shareholders for the purpose of winding up the Cor-
poration as from the time of such convening.»

25. Amend the last sentence of Section B (ii) of Article 22, Valuation Regulations, of the Articles of Incorporation:

«... securities are to be valued at fair market value in the opinion of the Corporation.»

26. Insert the following sentence after Section B (vi) of Article 22, Valuation Regulations, of the Articles of Incorpo-

ration: «The Board of Directors is authorised to apply other appropriate valuation principles for the assets of the
Corporation if the aforesaid valuation methods may not be applied or are inappropriate due to extraordinary
circumstances or events.»

27. Amend the last paragraph of Article 22 Section C, Valuation Regulations, of the Articles of Incorporation so as

to read: «... any paying agent and permanent representatives in places of registration, directors, managing direc-
tors and officers, any other agent employed by the Corporation, fees for legal and auditing services, insurance,
promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and print-
ing of prospectuses, explanatory memoranda or registration statements, preparing and filing of Articles of Incor-
poration, ...»

28. Insert the following paragraph at the end of section G of Article 22, Valuation Regulations, of the Articles of In-

corporation: «The Net Asset Value may be adjusted as the Board of Directors may deem appropriate to reflect

33977

inter alia any dealing charges, including any dealing spreads, fiscal charges and potential market impact resulting
from shareholder transactions.»

29. Amend the first sentence of Article 22.bis of the Articles of Incorporation so as to read: «The Board of Directors

may decide that all or any part of the pool or pools of assets established for any class of shares referred to in
section F. of Article twenty-two (hereafter referred to as «Participating Fund») will be managed on a pooled basis
together with all or part of the pool or pools of assets established for another class of shares of the Corporation
or for another Luxembourg collective investment scheme where it is appropriate...»

30. Insert the following paragraph at the end of Article 23 of the Articles of Incorporation: «In addition, a dilution

levy may be imposed on deals as specified in the sales documents. Such dilution levy should not exceed 5% of the
Net Asset Value and will be calculated taking into account the estimated costs, expenses and potential impact on
security prices that may be incurred to meet purchase requests.»

31. Amend Article 27 of the Articles of Incorporation so as to read: «The Corporation shall enter into an investment

management agreement with an entity of the Fidelity group (the «Fidelity Entity»), under which agreement such
Fidelity Entity will advise upon and manage the portfolio investments of the Corporation.
In the event of the non-conclusion or the termination of the investment management agreement in any manner
whatsoever, the Corporation will at the request of the relevant Fidelity Entity change its name forthwith to a
name not resembling the one specified in Article one hereof, specifically not including the word «Fidelity» or any
similar word in any part thereof.
The investment management agreement shall contain provisions governing its amendment and termination.
This Article twenty-seven may not be amended or repealed, except by the affirmative vote of the holders of not
less than two thirds (2/3) of the shares of the Corporation present or represented at a shareholders’ meeting
called for such purpose at which the holders of not less than two thirds (2/3) of the outstanding shares of the
Corporation are present or represented and voting.
The management fee payable to the investment manager in respect of its services shall not, in respect of each
separate pool of assets, exceed the rate specified in the sales documents of the Corporation applicable to the
average of the Net Asset Value of the relevant pool of assets. Any increase of the management fee within the
limits specified herein shall become effective only upon three months’ notice given in writing to all registered
shareholders.
The Corporation shall enter into a custodian agreement with a bank or savings institution which shall satisfy the
requirements of the Law (the «Custodian») who shall assume towards the Corporation and its shareholders the
responsibilities provided by the Law. All securities and other assets of the Corporation are to be held by or to
the order of the Custodian. The fees payable to the Custodian will be determined in the custodian agreement.
In the event of the Custodian desiring to retire the Board of Directors shall within two months appoint another
financial institution to act as custodian and upon doing so the Directors shall appoint such institution to be cus-
todian in place of the retiring Custodian. The Directors shall have power to terminate the appointment of the
Custodian but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed
in accordance with this provision to act in place thereof.
If any cash forming part of the assets of the Corporation is deposited with any investment manager or any dis-
tributor of shares in the Corporation appointed by the Corporation or any Connected Person of any of them,
interest must be granted on such deposit at a rate not below the prevailing rate for a deposit of that term and
that currency.
Neither the Custodian nor the investment manager nor any Connected Person of any of them, shall vote their
own shares in the Corporation at, or count towards the quorum for, a general meeting of shareholders at which
they have a material interest. But this restriction shall not apply to shares held in a nominee capacity only when
voting instructions are received from the owner nor in respect of any adjourned meeting where the initial meet-
ing was inquorate...»

32. Amend Article 30 of the Articles of Incorporation so as to read: «All matters not governed by these Articles of

Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th August 1915 on Commercial Companies
and amendments thereto, as well as the Law.»

33. Consideration of such other business as may properly come before the meeting.

The resolutions require a majority in favour of at least two thirds of the votes cast. Holders present in person or by

proxy, whatever their number and the number of shares held by them, will constitute a quorum at the adjourned meet-
ing. To be valid proxies must reach the registered office of the Fund on 26 July 2005 at the latest. Proxies received at
the first meeting will be held and valid for the adjourned meeting.

Subject to the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Fund with regard to ownership of shares

by US persons or of shares which constitute in aggregate more than three per cent (3%) of the outstanding shares, each
share is entitled to one vote. Shareholders are invited to attend and vote at the meeting or may appoint another person
in writing to attend and vote at the meeting. Such proxy need not be a shareholder of the Fund.

Shareholders may vote by proxy by returning the form of proxy to the address given below:
FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
Kansallis House, place de l’Etoile, B.P. 2174, L-1021 Luxembourg

29 June 2005.

II (03324/584/245) 

<i>By Order of the Board of Directors.

33978

ALIAS MUSTANG INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 95.884. 

Le conseil d’administration prie les actionnaires de la société anonyme ALIAS MUSTANG INTERNATIONAL

d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra le jeudi <i>28 juillet 2005 à 10.00 heures à Luxembourg au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg,
afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport du commissaire aux comptes et du rapport de gestion.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2004.
3. Affectation à donner au résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Démission d’un administrateur.
6. Transfert du siège social.

Les actionnaires sont informés que cette Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les

résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés. Pour
pouvoir assister à ladite Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur devront présenter leurs certificats d’actions ou
un certificat de blocage bancaire.
II (03362/755/22) 

RECHERCHE MEDICALE DISTRIBUTION (R.M.D.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 66.242. 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra au siège social le mercredi <i>27 juillet 2005 à 9.00 heures et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation des résultats
4. Décharge à accorder aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Divers

II (03291/607/17) 

FIDELITY FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1021 Luxembourg, place de l’Etoile.

R. C. Luxembourg B 34.036. 

At the Extraordinary General Meeting held at the registered office of FIDELITY FUNDS («the Fund») on Wednesday

29 June 2005 at 9.00 a.m. (CET), a quorum was not attained. Therefore:

Notice of hereby given that the adjourned

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of the Fund will be held at the registered office of the Fund in Luxembourg on Wednesday <i>3 August

<i>2005 at 9.30 a.m. (CET) to consider the following agenda:

<i>Agenda:

1. Amend Article 3 of the Articles of Incorporation so as to read: «The exclusive object of the Corporation is to

invest the funds available to it in securities of all types, money market instruments, derivative instruments, cash
and cash equivalents as well as other assets permitted by law with the purpose of spreading investment risk and
affording its shareholders the results of the management of its assets.
The Corporation may take any measures and carry out any transactions which it may deem useful for the fulfil-
ment and development of its purposes to the fullest extent permitted by the law of 20th December 2002 on
undertakings for collective investment (the «Law»).»

2. Amend the second sentence of Article 4 of the Articles of Incorporation so as to read: «Branches or other offices

may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad ...»

3. Amend the second paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation so as to read: «The minimum capital

of the Corporation shall be the equivalent in United States dollars of 1,250,000.- euro.»

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

33979

4. Delete paragraph 11 of Article 5 of the Articles of Incorporation.
5. Amend the current paragraph 16 of Article 5 of the Articles of Incorporation so as to read: «... and other instru-

ments of transfer satisfactory to the Corporation on the basis of which the Corporation may record the transfer
in the Register of Shareholders or by written declaration of transfer recorded in the Register of Shareholders ...»

6. Addition of the following sentence at the beginning of the current paragraph 17 of Article 5 of the current Articles

of Incorporation: «The Corporation only recognises one single owner per share.»

7. Amend the first paragraph of Article 7 of the Articles of Incorporation so as to read: «... if in the opinion of the

Corporation such holding may be detrimental to the Corporation or the majority of the shareholders thereof or
of any class thereof, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as
a result thereof it may have adverse regulatory, tax or fiscal consequences, and in particular if the Corporation
may become subject to tax laws other than those of the Grand Duchy of Luxembourg ...»

8. Amend paragraph 2 of Article 7 D (1) of the Articles of Incorporation so as to read: «... addressed to such share-

holder at their last address known to or appearing in the Register of Shareholders of the Corporation ...»

9. Amend Article 8 of the Articles of Incorporation so as to read: «Whenever used in these Articles the term «US

person» means:
(a) a citizen or resident of the United States of America;
(b) a partnership, corporation, limited liability company or similar entity, organised or incorporated under the
laws of the United States of America, or an entity taxed as such or subject to filing a tax return as such under
the United States federal income tax laws;
(c) any estate or trust the executor, administrator or trustee of which is a US Person unless, in the case of trusts
of which any professional fiduciary acting as trustee is a US Person, a trustee who is not a US Person has sole or
shared investment discretion with respect of trust assets and no beneficiary of the trust (and no settler if the
trust is revocable) is a US Person;
(d) any estate or trust the income of which from sources without the United States of America is includible in
gross income for purposes of computing United States income tax payable by it;
(e) any agency or branch of a foreign entity located in the United States of America;
(f) any discretionary account or non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held
by a dealer or other fiduciary located within or outside the United States of America for the benefit or account
of a US Person;
(g) any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary
organised, incorporated or (if an individual) resident in the United States of America, except that any discretion-
ary account or similar account (other than an estate or trust) held for the benefit or account of a non-US Person
by a dealer or other professional fiduciary organised, incorporated (or if an individual) resident in the United
States of America shall not be deemed a US Person;
(h) any firm, corporation or other entity, regardless of citizenship, domicile, status or residence if, under the in-
come tax laws of the United States of America from time to time in effect, any proportion of the income thereof
would be taxable to a US Person even if not distributed, other than a passive foreign investment company;
(i) any partnership, corporation or other entity if (A) organised or incorporated under the laws of any foreign
jurisdiction; and (B) owned or formed by a US Person or Persons principally for the purpose of investing in se-
curities not registered under the US Securities Act of 1933 (including but not limited to Shares of the Fund);
(j) any employee benefit plan unless such employee benefit plan is established and administered in accordance
with the law of a country other than the United States of America and customary practices and documentation
of such country and is maintained primarily for the benefit of persons substantially all of whom are non-resident
aliens with respect to the United States of America; and
(k) any other person or entity whose ownership of Shares or solicitation for ownership of Shares in Fidelity In-
vestments Institutional Services Company Inc., Fidelity Distributors International Limited or the Fund, acting
through their Officers or Directors, shall determine may violate any securities law of the United States of Amer-
ica or any state or other jurisdiction thereof.
US Person shall not include an Eligible Investor or any person or entity, notwithstanding the fact that such person
or entity may come within any of the categories referred to above, as to whom Fidelity Distributors International
Limited or the Fund, acting through their Officers or Directors, shall determine that ownership of Shares or so-
licitation for ownership of Shares shall not violate any securities law of the United States of America or any state
or other jurisdiction thereof.
As used herein, United States of America includes its states, commonwealths, territories, possessions and the
District of Columbia.
Whenever used in these Articles, «three per cent owner» means any person, firm or corporate body which as
a legal or beneficial holder owns more than three per cent of the number of shares of the Corporation from time
to time outstanding.
Three per cent owner as used herein shall not include any subscriber to shares of the Corporation issued in con-
nection with organisation of the Corporation while such subscriber holds such shares or any securities dealer
who acquires shares with a view to their distribution in connection with an issue of shares by the Corporation.»

10. Amend paragraph 4 of Article 10 of the Articles of Incorporation so as to read: «If bearer shares are in issue,

notice of meeting of shareholders will be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Lux-
embourg and in a Luxembourg newspaper ... sent to the holders of nominative shares eight days prior to the
meeting ...»

33980

11. Amend the first sentence of paragraph 4 of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to read: «The Board

of Directors from time to time shall appoint the officers and the Managing Directors of the Corporation ...»

12. Amend paragraph 5 of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to read: «Notice of any meeting of the

Board of Directors shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, fax or by any other electronic means ...
This notice may be waived by the consent in writing by telegram, telex, fax or by any other electronic means of
each director ...»

13. Amend paragraph 6 of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to read: «... which appointment shall be

in writing or in the form of a telegram or telex or fax or by any other electronic means. Any Director may attend
a meeting of the Board of Directors using teleconference or video means and participating in a meeting by such
means shall constitute presence in person at such meeting.»

14. Amend Article 15 of the Articles of Incorporation so as to read: «The Board of Directors shall, based upon the

principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy for the investments
relating to each class of shares and the course of conduct of the management and business affairs of the Corpor-
ation. The Board of Directors shall also have power to determine any restrictions which shall from time to time
be applicable to the investments of the Corporation’s assets, in accordance with Part I of the Law including, with-
out limitation, restrictions in respect of:
a) the borrowings of the Corporation and the pledging of its assets; and
b) the maximum percentage of its assets which it may invest in any form or class of security and the maximum
percentage of any form or class of security which it may acquire.
The Board of Directors may decide that investment of the Corporation’s assets be made (i) in transferable se-
curities/money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Law; (ii) in
transferable securities/money market instruments dealt in on another market in a Member State of the European
Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public; (iii) in transferable securi-
ties/money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in any other country in Europe,
Asia, Australia, Oceania, the American continents and Africa, or dealt in on another market that is regulated, in
the countries referred to above, provided that such market operates regularly and is recognised and open to the
public; (iv) in recently issued transferable securities/money market instruments provided the terms of the issue
include an undertaking that application will be made for admission to official listing on any of the stock exchanges
or other regulated markets referred to above and provided that such admission is secured within one year of the
issue; and (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by
the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and as disclosed in the sales documents
of the Corporation.
The Board of Directors of the Corporation may decide to invest up to one hundred per cent of the total net
assets of the Corporation in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed
by any Member State of the European Union, its local authorities, a non-Member State of the European Union,
as acceptable by the supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Corporation, or public
international bodies of which one or more of such Member States of the European Union are members, provided
that in the case where the Corporation decides to make use of this provision it must hold securities from at least
six different issues and securities from any one issue may not account for more than thirty per cent of the Cor-
poration’s total net assets.
The Board of Directors may decide that investment of the Corporation’s assets be made in financial derivative
instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the
Law and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying
consists of instruments covered by Article 41 (1) of the Law, financial indices, interest rates, foreign exchange
rates or currencies, in which the Corporation may invest according to its investment objectives as disclosed in
the sales documents of the Corporation.
The Board of Directors may decide that investments of the Corporation’s assets being made with the aim to
replicate certain stock indices or bond indices, provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg
supervisory authority on the basis that it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the mar-
ket to which it refers and is published in any appropriate manner.
The Corporation will not invest more than 10% of its net assets in units of undertakings for collective investment
as defined in the Law.
When investments of the Corporation are made in the capital of subsidiary companies which, exclusively on its
behalf carry on only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is lo-
cated, with regard to the redemption of units at the request of unitholders, paragraphs (1) and (2) of Article 48
of the Law do not apply.»

15. Replacement of the words of «law of thirtieth March one thousand nine hundred and eighty eight regarding col-

lective investment undertakings» with «Law» in the first paragraph of Article 20 of the Articles of Incorporation.

16. Delete the words «with or without cause» from the end of the second paragraph of Article 20 of the Articles of

Incorporation.

17. Amend the third sentence of the second paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation so as to read:

«Shares of the capital of the Corporation redeemed by the Corporation shall be cancelled.»

18. Delete the words «(such fee and estimate not to exceed one per cent of such Net Asset Value)» from the end

of the second sentence of the third paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation.

33981

19. Replace the final paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation in its entirety with the following: «Fur-

ther, redemption requests may be deferred under certain circumstances and within certain thresholds as detailed
in the sales documents.»

20. Insert the following paragraph after the current final paragraph of Article 21 of the Articles of Incorporation: «In

addition a dilution levy may be imposed on deals as specified in the sales documents. Such dilution levy should
not exceed 5% of the Net Asset Value and will be calculated taking into account the estimated costs, expenses
and potential impact on security prices that may be incurred to meet redemption and conversion requests.»

21. Insert the following paragraph at the end of Article 21 of the Articles of Incorporation: «There may be deducted

from the Net Asset Value a fee payable to the Corporation with a maximum of 2%.»

22. Delete the words «, unless all such shareholders and their addresses are known to the Corporation» from the

end of the second paragraph of Article 21.bis of the Articles of Incorporation.

23. Insert the following paragraph after paragraph nine of Article 22 of the Articles of Incorporation: «(g) in the event

of the convening of an extraordinary general meeting of the shareholders for the purpose of winding up the Cor-
poration as from the time of such convening.»

24. Amend the last sentence of Section B (ii) of Article 22, Valuation Regulations, of the Articles of Incorporation:

«... securities are to be valued at fair market value in the opinion of the Corporation.»

25. Insert the following sentence after Section B (vi) of Article 22, Valuation Regulations, of the Articles of Incorpo-

ration: «The Board of Directors is authorised to apply other appropriate valuation principles for the assets of the
Corporation if the aforesaid valuation methods may not be applied or are inappropriate due to extraordinary
circumstances or events.»

26. Amend the last paragraph of Article 22 Section C, Valuation Regulations, of the Articles of Incorporation so as

to read: «... any paying agent and permanent representatives in places of registration, directors, managing direc-
tors and officers, any other agent employed by the Corporation, fees for legal and auditing services, insurance,
promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and print-
ing of prospectuses, explanatory memoranda or registration statements, preparing and filing of Articles of Incor-
poration, ...»

27. Insert the following paragraph at the end of section G of Article 22, Valuation Regulations, of the Articles of In-

corporation: «The Net Asset Value may be adjusted as the Board of Directors may deem appropriate to reflect
inter alia any dealing charges, including any dealing spreads, fiscal charges and potential market impact resulting
from shareholder transactions.»

28. Amend the first sentence of Article 22.bis of the Articles of Incorporation so as to read: «The Board of Directors

may decide that all or any part of the pool or pools of assets established for any class of shares referred to in
section F. of Article twenty-two (hereafter referred to as «Participating Fund») will be managed on a pooled basis
together with all or part of the pool or pools of assets established for another class of shares of the Corporation
or for another Luxembourg collective investment scheme where it is appropriate ...»

29. Insert the following paragraph at the end of Article 23 of the Articles of Incorporation: «In addition, a dilution

levy may be imposed on deals as specified in the sales documents. Such dilution levy should not exceed 5% of the
Net Asset Value and will be calculated taking into account the estimated costs, expenses and potential impact on
security prices that may be incurred to meet purchase requests.»

30. Delete the words «and for the first time on the 30th day of April 1991» from the first paragraph of Article 25 of

the Articles of Incorporation.

31. Amend Article 27 of the Articles of Incorporation so as to read: «The Corporation shall enter into an investment

management agreement with an entity of the Fidelity group (the «Fidelity Entity»), under which agreement such
Fidelity Entity will advise upon and manage the portfolio investments of the Corporation.
In the event of the non-conclusion or the termination of the investment management agreement in any manner
whatsoever, the Corporation will at the request of the relevant Fidelity Entity change its name forthwith to a
name not resembling the one specified in Article one hereof, specifically not including the word «Fidelity» or any
similar word in any part thereof.
The investment management agreement shall contain provisions governing its amendment and termination. 
This Article twenty-seven may not be amended or repealed, except by the affirmative vote of the holders of not
less than two thirds (2/3) of the shares of the Corporation present or represented at a shareholders’ meeting
called for such purpose at which the holders of not less than two thirds (2/3) of the outstanding shares of the
Corporation are present or represented and voting. 
The management fee payable to the investment manager in respect of its services shall not, in respect of each
separate pool of assets, exceed the rate specified in the sales documents of the Corporation applicable to the
average of the Net Asset Value of the relevant pool of assets. Any increase of the management fee within the
limits specified herein shall become effective only upon three months’ notice given in writing to all registered
shareholders.
The Corporation shall enter into a custodian agreement with a bank or savings institution which shall satisfy the
requirements of the Law (the «Custodian») who shall assume towards the Corporation and its shareholders the
responsibilities provided by the Law. All securities and other assets of the Corporation are to be held by or to
the order of the Custodian. The fees payable to the Custodian will be determined in the custodian agreement.
In the event of the Custodian desiring to retire the Board of Directors shall within two months appoint another
financial institution to act as custodian and upon doing so the Directors shall appoint such institution to be cus-
todian in place of the retiring Custodian. The Directors shall have power to terminate the appointment of the

33982

Custodian but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed
in accordance with this provision to act in place thereof.
If any cash forming part of the assets of the Corporation is deposited with any investment manager ...»

32. Amend Article 30 of the Articles of Incorporation so as to read: «All matters not governed by these Articles of

Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th August 1915 on Commercial Companies
and amendments thereto, as well as the Law.»

33. Consideration of such other business as may properly come before the meeting.

The resolutions require a majority in favour of at least two thirds of the votes cast. Holders present in person or by

proxy, whatever their number and the number of shares held by them, will constitute a quorum at the adjourned meet-
ing. To be valid proxies must reach the registered office of the Fund on 26 July 2005 at the latest. Proxies received at
the first meeting will be held and valid for the adjourned meeting.

Subject to the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Fund with regard to ownership of shares

by US persons or of shares which constitute in aggregate more than three per cent (3%) of the outstanding shares, each
share is entitled to one vote. Shareholders are invited to attend and vote at the meeting or may appoint another person
in writing to attend and vote at the meeting. Such proxy need not be a shareholder of the Fund.

Holders of Registered Shares may vote by proxy by returning to the registered office of the Fund the form of regis-

tered shareholder proxy sent to them.

Holders of Bearer Shares who wish to attend the Extraordinary General Meeting or vote at the meeting by proxy

should contact the Fund or one of the following institutions:

in Luxembourg:
FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Kansallis House, place de l’Etoile, B.P. 2174, L-1021 Luxembourg
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

29 June 2005.

II (03321/584/241) 

<i>By Order of the Board of Directors.

KOMBASSAN HOLDINGS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks.

H. R. Luxemburg B 70.610. 

Einberufung zur

AUßERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

welche am <i>27. Juli 2005 um 14.00 Uhr in Konya, Türkei, Kombassan Is Merkezi, Nisansasi Mh. Sahinaga Sk., stattfindet.

Da die Außerordentliche Generalversammlung vom 29. Juni 2005 gemäß Artikel 67 Absatz 5 vertagt wurde, ist erneut

über folgende Tagesordnung zu befinden:

<i>Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates,
2. Bericht des Wirtschaftsprüfers,
3. Billigung der geprüften Bilanz zum 31.12.2004 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2004,
4. Beschluß über die Gewinnverwendung,
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder,
6. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten ordentlichen

Generalversammlung,

7. Falls die Bilanzen noch nicht geprüft sein sollten, Vertagung der Generalversammlung bis zum 09.11.2005,
8. Verschiedenes.

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keine Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefaßt.

Um an der Versammlung teilzunehmen müssen Eigentümer von Inhaberaktien wenigstens fünf Tage vor der Ver-

sammlung ihre Aktien bei KOMBASSAN HOLDINGS S.A. oder einem anerkannten Kreditinstitut hinterlegt haben. Sie
Werden auf Vorlage einer Bestätigung der Hinterlegung zur Generalversammlung der Aktionäre zugelassen.
II (03388/000/26) 

<i>Der Verwaltungsrat.

BRAIT S.A., Société Anonyme.

ISIN LU0011857645.

R. C. Luxembourg B 13.861. 

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the BRAIT S.A. Shareowners will be held at the registered office of BRAIT S.A., 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg, at 11.30 on Wednesday <i>27 July 2005 (or, should this Extraordinary General Meeting be postponed for any
reason whatsoever, commencing at the time and on the date to which the Extraordinary General Meeting will be post-
poned, of which BRAIT S.A. Shareowners will be advised by way of a press announcement), for the purpose of consid-
ering and, if deemed fit, passing, with or without modification, the following special and ordinary resolutions:

33983

<i>Special resolution number 1

«Resolved that the Company increase the subscribed capital from its present level of USD 153,383,598.- (USD one

hundred and fifty-three million three hundred and eighty-three thousand five hundred and ninety-eight) to USD 165,730,
981.50 (USD one hundred and sixty-five million seven hundred and thirty thousand nine hundred and eighty-one and
fifty cents) by the issue of 8,231,589 (eight million two hundred and thirty-one thousand five hundred and eighty-nine)
fully paid BRAIT S.A. Shares to the Trustee of the Scheme, which new BRAIT S.A. Shares are to be paid up by the trans-
fer of USD 1.50 per new BRAIT S.A. Share from the share premium reserve account to share capital.»

The reason for special resolution number 1 is to enable the Company to meet its obligations to deliver 19,063,460

BRAIT S.A. Shares in the aggregate to employees and directors of the Group in terms of the Scheme. The effect of
special resolution number 1 is to increase the issued share capital of BAIT S.A. from USD 153,383,598.- to USD
165,730,981.50 by the issue of 8,231,589 new BRAIT S.A. Shares without par value. All the new BRAIT S.A. Shares shall
rank pari passu with all existing issued BRAIT S.A. Shares of the Company in all respects.

<i>Special resolution number 2

«Resolved that, subject to the passing of special resolution number 1, the Articles of incorporation of the Company

be and are hereby amended as follows:

By deleting the following phrase in Article 5.2: «153,383,598.- United States Dollars (USD one hundred and fifty-three

million three hundred and eighty-three thousand five hundred and ninety-eight) represented by 102,255,732 (one
hundred and two million two hundred and fifty-five thousand seven hundred and thirty-two) fully paid-up ordinary
shares» and replacing it with the following. «165,730,981.50 United States Dollars (USD one hundred and sixty-five
million seven hundred and thirty thousand nine hundred and eighty-one and fifty cents) represented by 110,487,321 (one
hundred and ten million four hundred and eighty-seven thousand three hundred and twenty-one) fully paid-up ordinary
shares.»

The reason for and effect of special resolution number 2 is to amend the Articles of incorporation of the Company

for the issue of the additional BRAIT S.A. Shares pursuant to special resolution number 1.

<i>Ordinary resolution number 1

«Resolved that an amount of USD 40 million (USD forty million) be appropriated from the share premium reserve

account of the Company to the distributable reserve account of the Company.»

<i>Ordinary resolution number 2

«Resolved that any two members of the Board be authorised to sign all such documents and do all things necessary

to give effect to special resolution numbers 1 and 2 and ordinary resolution number 1.»

Thursday, 30 June 2005.  

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareowners of the company will be held at the registered office of the company on <i>27 July 2005 at 14.30 (or as soon
thereafter following the EGM to be held at 11.30) for the following purposes:

<i>Agenda:      

By order of the Board
ME King
<i>Chairman

A. Ordinary business

1.

To ratify and confirm the payment of an interim dividend on 22 November 2004;

2.

To receive and adopt the reports of the directors, statutory auditor and independent auditors for the year
ended 31 March 2005;

3.

To receive and adopt the statutory financial statements of the company and the consolidated financial state-
ments of the group for the year ended 31 March 2005;

4.

To grant discharge to the directors, officers and the statutory auditor in respect of the execution of their
mandates to 31 March 2005;

5.

To re-elect the directors for a further term of office in accordance with the provisions of the Articles of In-
corporation;

6.

To elect Paul Adrian Barlow Beecroft as a non-executive director for a term of office in accordance with the
provisions of the Articles of Incorporation;

7.

To elect Brett Ivor Childs as an executive director for a term of office in accordance with the provisions of
the Articles of Incorporation;

8.

To elect John Joseph Coulter as an executive director for a term of office in accordance with the provisions
of the Articles of Incorporation;

9.

To elect John Andrew Gnodde as an executive director for a term of office in accordance with the provisions
of the Articles of Incorporation;

10. To elect Herman Troskie as a non-executive director for a term of office in accordance with the provisions

of the Articles of Incorporation;

11. To receive and act on the statutory nomination of the statutory auditor and the independent auditor for a

term of one year ending at the annual general meeting in 2006;

12. To allocate the company’s profits;

33984

II (03347/1017/121) 

13. To approve the declaration and payment of a final dividend for the year ended 31 March 2005 of USD 10.25

per share (to be paid on 15 August 2005 to those shareowners appearing on the share register as at 4 August
2005);

14. To renew the authority granted to the company to purchase its own shares subject to the following limita-

tions:
14.1 unless a tender offer is made to all shareowners on the same terms and except in case of an emergency

where the purchase is carried out to avoid a material loss which the company would otherwise incur,
each purchase shall be made through a stock exchange on which the shares in the company are regu-
larly traded and the purchase price shall not exceed 5% above the average market value for the shares
on all stock exchanges on which the ordinary shares are listed and have traded for the 10 (ten) business
days before the purchase;

14.2 if purchases are by tender, tenders must be available to all shareowners alike; and
14.3 the maximum number of shares that may be repurchased pursuant to this authority shall not exceed

10% of the issued share capital of the company from time to time.
This authority shall not extend beyond 18 (eighteen) months from the date of this annual general meet-
ing but shall be renewable for further periods by resolution of the annual general meeting of the share-
owners from time to time. 

B. Special business:

15. To renew, in terms of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and the listing re-

quirements of the Luxembourg, London and JSE Securities Exchange, the authority granted to the board, sub-
ject to the terms of the Articles of Incorporation, to issue further ordinary shares, whether for cash or
otherwise, as and when suitable situations arise, up to the total authorised capital, without reserving for the
existing shareowners a preferential subscription right to subscribe to the shares issued, subject to the follow-
ing limitations:
15.1 that this authority shall not extend beyond 15 (fifteen) months from the date of this annual general

meeting but shall be renewable for further periods by resolution of the annual general meeting of the
shareowners from time to time;

15.2 that a paid press announcement giving details, including the impact on net asset value and earnings per

share, will be published at the time of any such issue of shares representing, on a cumulative basis within
one year, 5% or more of the number of ordinary shares in issue prior to any such issues;

15.3 that issues (excluding shares to be issued pursuant to any share purchase or incentive scheme estab-

lished for the benefit of the employees of the company and its subsidiaries &amp;lsqb;«incentive
schemes»&amp;rsqb;) in aggregate in any one year may not exceed 10% of the company’s issued ordinary
share capital, provided further that such issues (excluding shares to be issued pursuant to incentive
schemes) shall not in aggregate in any three-year period exceed 15% of the company’s issued ordinary
share capital;

15.4 that, in determing the price at which such an issue of ordinary shares will be made in terms of this au-

thority, the maximum discount permitted will be 10% of the average market price of the ordinary
shares as determined over the 30 (thirty) day prior to the date that the price of the issue is determined
or agreed by the directors on all stock exchanges on which the ordinary shares are listed and have trad-
ed during that period; and

15.5  that any such securities so issued for cash shall be made to the «public» and will also not result in an

affected transaction.

By order of the board of directors
ME King
<i>Chairman

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Tourtour S.A.

Cifa International S.A.

Tecservices S.A.

Cram S.A.

Cram S.A.

Ikano Finance (Russia) S.A.

Indevo A.G.

Atoz S.A.

Atoz S.A.

Sireal S.A.

Believe Finance S.A.

RSM Henri Grisius &amp; Associés

RSM Henri Grisius &amp; Associés

EFI S.A.

Gulf Distribution Holding S.A.

Agilitas S.A.

Parbat Finance S.A.

Cifa International S.A.

Cifa International S.A.

Speraconsult S.A.

Copanca S.A.

Daimlerchrysler Financial Services S.A.

Hearthistic Prod., A.s.b.l.

Sunrays S.A.

SAB, GmbH

Gestaut S.A.

De Darlion Industries S.A.

Compagnie Financière Ponte Carlo Holding S.A.

Cram S.A.

Cram S.A.

T.H.F., Tréfileries Haute Forêt S.A.

T.H.F., Tréfileries Haute Forêt S.A.

Apei, S.à r.l.

Apei, S.à r.l.

Freemind Holding S.A.

Traction S.A.

Verrinvest Luxembourg S.A.

Business Invest Gestion S.A.

Ebony Investments, S.à r.l.

Morton Fininvestment Holding S.A.

Morton Fininvestment Holding S.A.

Morton Fininvestment Holding S.A.

Morton Fininvestment Holding S.A.

Morton Fininvestment Holding S.A.

Morton Fininvestment Holding S.A.

Janek Holding S.A.

Au Royaume Fleuri, S.à r.l.

Sunshine Properties S.A.

Sunshine Properties S.A.

Chinesco Finance S.A.

Luxembourg International Holding S.A.

D.C. Cars, S.à r.l.

D.C. Cars, S.à r.l.

Hovra S.A.

HSH Nordbank International S.A.

HSH Nordbank International S.A.

Makvalor S.A.

Beltxnea S.A.

Dankalux S.à r.l. and Co. S.C.A.

Dankalux, S.à r.l. and Co. S.C.A.

Pearson Luxembourg N˚ 2, S.à r.l.

Canillac Holding S.A.

Kinase Holding S.A.

Mazfin S.A.

Wic Holding S.A.

CF Services, Corporate and Fiduciary Services

CF Services, Corporate and Fiduciary Services

B.S.A.W-Exploitation S.A.

B.S.A.W-Exploitation S.A.

Golden Tropi Holding S.A.

DS Smith (Holding) B.V., S.à r.l.

DS Smith (Luxembourg), S.à r.l.

Irepa Industrial Research &amp; Patents S.A.

R.C. Lux S.A.

Las Gaviotas S.A.

Jocar Holding S.A.

Jocar Holding S.A.

Jocar Holding S.A.

Jocar Holding S.A.

Growth Invest Holding S.A.

Growth Invest Holding S.A.

Arkinmob Investissements S.A.

Arkinmob Investissements S.A.

Staveley S.A.

Transpacific Fund

Fidelity Funds II Sicav

Alias Mustang International

Recherche Médicale Distribution (R.M.D.) S.A.

Fidelity Funds

Kombassan Holdings S.A.

Brait S.A.