This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
24913
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 520
18 mai 2004
S O M M A I R E
EDITIONS LETZEBURGER JOURNAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 5.056.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00268 et 00269, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027745.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
ABX Logistics (Luxembourg), S.à r.l., Contern . . .
24949
Labatte Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . .
24960
Allmat Locations S.A., Hautcharage . . . . . . . . . . . .
24951
Labatte Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . .
24960
Allmat Locations S.A., Hautcharage . . . . . . . . . . . .
24951
Labatte Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . .
24960
(L’) Atelier Vert, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
24947
Life Care Lux., S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
24940
B.C.S.I., Business Controls & Services International
MainFirst, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
24947
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24914
MainFirst, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24945
Baudes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24956
Martin Losch, S.à r.l. Esch-sur-Alzette, Esch-sur-
Baudes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24956
Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24948
Blicon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24934
NSR Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
24950
Blicon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24936
Overseas Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
24944
Brittany Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
24951
Rimm Technologies Holding S.A., Luxembourg . .
24959
Cyber Vision Holding S.A., Weiswampach . . . . . . .
24948
Rotomade, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24947
Cyber Vision Holding S.A., Weiswampach . . . . . . .
24948
S.C.I. Pilolux, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24936
Didel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
24914
S.C.I. Pilolux, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24936
Dr. Oetker S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
24951
Sacofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24948
Eagle Bay, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
24937
Serfid S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24915
Eagle Bay, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
24938
Somatec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24949
Editions Lëtzeburger Journal S.A., Luxembourg . .
24913
Somatec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24950
ESFIL - Espirito Santo Financière S.A., Luxem-
Steparex, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24948
bourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24938
T.S.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24957
Eurocapital Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
24929
T.S.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24957
Finilux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24956
Visserhuis V 94 SCI, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
24954
Finilux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24957
Visserhuis V 94 SCI, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
24955
General O & R International S.A., Luxembourg . . .
24955
Volga-Dnepr Airlines, Luxembourg Branch S.A.,
ITCIM, IT Consulting and Investment Management,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24915
S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24950
Volga-Dnepr Airlines, Luxembourg Branch S.A.,
Labatte Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
24960
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24916
Luxembourg, le 7 avril 2004.
Signature.
24914
DIDEL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 42.023.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le trente mars.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société DEWEY HOLDING LIMITED, ayant son siège social à Ellen L. Skelton Building Fischer’s Estate, P.O. Box
3820 Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-
1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 27 novembre 2000,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire, restera annexée
en copie au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.
Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Que la société anonyme DIDEL HOLDING S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 42.023, a été constituée suivant acte
reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 10 novembre 1992, publié au Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations numéro 62 du 9 février 1993, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par ledit notaire André Schwachtgen en date du 31 mars 1994, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et As-
sociations numéro 319 du 1
er
septembre 1994.
II.- Que le capital de la société s’élève actuellement à huit millions francs luxembourgeois (LUF 8.000.000,-), repré-
senté par huit mille (8.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, inté-
gralement souscrites et libérées.
III.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la société DIDEL HOLDING S.A. qu’en
conséquence celle-ci se trouve dissoute de plein droit par la réunion de toutes les parts en une seule main.
IV.- Que la comparante se trouve investie de tout l’actif et de tout le passif de la société dissoute dont la liquidation
se trouve dès lors définitivement clôturée.
V.- Que la société ne possède pas d’immeubles.
VI.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
VII.- Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à son ancien siège social
à L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.
VIII.- Pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Ceci exposé la comparante requiert le notaire de constater que la société anonyme DIDEL HOLDING S.A., est dis-
soute de plein droit, et que la comparante, exerçant tous les droits attachés à la propriété de toutes les actions de la
société, est investie de tout l’actif et de tout le passif de la société, dont la liquidation se trouve dès lors définitivement
clôturée.
A l’appui des déclarations et constatations qui précèdent, le comparant, agissant comme dit ci-avant, a produit au
notaire soussigné les huit mille (8.000) actions qui à l’instant et en présence du notaire instrumentant ont été annulées.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.
Signé: J. Lambert, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 30 mars 2004, vol. 356, fol. 71, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(027437.3/201/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
B.C.S.I., BUSINESS CONTROLS & SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 11.398.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06571, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027687.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
Echternach, le 1
er
avril 2004.
H. Beck.
Strassen, le 6 avril 2004.
Signature.
24915
SERFID, Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 81.113.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 16 mars 2004, enregistré à Grevenmacher, le 26 mars 2004, volume 526, folio 37, case 6;
I.- Que la société anonyme SERFID, avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, rue boulevard Napoléon I
er
, R. C.
Luxembourg section B sous le numéro 81.113, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 12 février 2001, publié au Mémorial C numéro 888 du 17 octobre 2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 mars 2001, publié au Mémorial C numéro 985 du 9 novembre 2001.
II.- Que sa mandante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la susdite société SERFID, le
registre des actions nominatives en faisant foi.
que sa mandante prononce la dissolution anticipée de la société anonyme SERFID avec effet immédiat et sa mise en
liquidation.
III.- Que le livres et documents de la société anonyme dissoute SERFID resteront déposés pendant cinq ans au moins
à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de Faïencerie.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027544.3/231/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
VOLGA-DNEPR AIRLINES, LUXEMBOURG BRANCH, Société Anonyme.
Maison-Mère: VOLGA-DNEPR AIRLINES, Société Anonyme.
Siège social: 432072 Ulianovsk, Fédération de Russie, 14, Karbysheva Street.
Adresse de la succursale: L-2889 Luxembourg, Findel, Cargo Center West.
R. C. Luxembourg B 99.945.
—
EXTRAIT
Dénomination et adresse de la succursale:
VOLGA-DNEPR AIRLINES, LUXEMBOURG BRANCH
Cargo Center West, Luxembourg Airport-Findel, L-2889 Luxembourg.
Activité de la succursale:
Commercialisation des services de transport de fret aérien, en particulier l’acceptation et la facturation d’ordres de
fret aérien ainsi que l’exercice de toute activité commerciale liée.
Capital de dotation de la succursale:
EUR 32.500
Droit de l’Etat dont relève la Société:
Société anonyme («Closed-Type Joint Stock Company») régie par le droit de la Fédération de Russie
Numéro d’immatriculation la Société au Registre à Oulianovsk (Fédération de Russie) auprès duquel la Société est
immatriculée:
1027301566610
Conseil d’administration
1 Alexey Isaikin, Président,
2 Tatyana Arslanova,
3 Andrew Baranov,
4 Victor Grigoriev,
5 Anna Korobko,
6 Konstantin Lushakov,
7 Evguenia Tarasova,
8 Sergey Shklianik,
9 Vladimir Davydov,
10 S. Nedoroslev, and
11 G. Novgorodov
Direction («Executive Body»):
La gestion journalière de la société est gérée par directeur général.
Directeur général: M. Vladimir Davydov, 14, Karbysheva Street, 432072 Ulianovsk, Fédération de Russie
Représentation de la succursale:
Monsieur Bernardus Schellens, Directeur Financier, demeurant à Rembrandtlaan 4, 1272 GN Huizen, Pays-Bas, est
nommé gérant de la succursale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.
Junglinster, le 2 avril 2004.
J. Seckler.
24916
Monsieur Bart Schellens, en sa qualité de gérant de la succursale de la société au Luxembourg a le pouvoir d’exécuter
et de signer tout document au nom et pour le compte de la succursale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00466. – Reçu 329 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028176.3/267/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
VOLGA-DNEPR AIRLINES, LUXEMBOURG BRANCH, Société Anonyme.
Maison-Mère: VOLGA-DNEPR AIRLINES, Société Anonyme.
Registered office: 432072 Ulianovsk, Fédération de Russie, 14, Karbysheva Street.
Office of the Luxembourg Branch: L-2889 Luxembourg, Findel, Cargo Center West.
R. C. Luxembourg B 99.945.
—
STATUTES
1. General Provisions
1.1. The Closed-Type JSC VOLGA-DNEPR AIRLINES is a joint Russian-Ukrainian enterprise acting in the form of a
Closed-Type Joint Stock Company.
1.2. The full name of the Company is JSC OF CLOSED TYPE VOLGA-DNEPR AIRLINES, the abbreviated name is
JSC VOLGA-DNEPR AIRLINES, hereinafter referred to as the «Company».
1.3. The Company acts on the basis of the Civil Code of the Russian Federation, the Law of Foreign Investment in
the Russian Federation, Federal Russian Law of Joint Stock Companies, and these Articles.
1.4. The Company is located at: 14 Karbysheva Street, 432072 Ulyanovsk.
1.5. Postal address: 14 Karbysheva Street, 432072 Ulyanovsk.
1.6. The Company is a legal entity having its own independent balance sheet and separate property and able, on its
own behalf, to sign contracts, acquire property and non-property rights, be liable, be a plaintiff and defendant before any
court or arbitration.
The Company independently sets up tariffs and prices for goods, works and services being sold.
The Company independently determines its personnel and employee strength and their salaries, according to the ex-
isting Law.
1.7. As prescribed by the Law the Company opens banking and other accounts on the territory of and outside the
Russian Federation and performs transactions with the above accounts. The Company carries out financial and other
settlement in the Russian or foreign currency according to the existing Law.
1.8. The Company is liable for its obligations by its entire property.
1.9. The State and state authorities are not liable for obligations of the Company and the Company is not liable for
obligations of the State.
1.10. The Company is not liable for its Shareholders’ obligations. The Shareholders are only liable for the Company’s
obligations within the limits of their shares, regardless of amounts paid for the shares.
1.11. The Company has a round seal including its full official name in Russian and its location, as well as a corner stamp,
company (trade) mark and letterheads containing its name.
1.12. The Company acquires rights of a legal entity starting from the moment of its registration by the State.
1.13. Any disputes between the Company and its shareholders related to the Company’s business or their reciprocal
rights and responsibilities are considered in accordance with the Russian legislation by arbitration or common Court at
the Company’s location.
1.14. The Company has the following branch and representative offices:
1.14.1. Representative office in Tianjin
1.14.2. Representative office in Novosibirsk
1.14.3. Representative office in Prague
1.14.4. Representative office in Sharjah
1.14.5. Passenger Services branch in Ulyanovsk Region
1.14.6. Truck Services branch in Ulyanovsk Region
1.14.7. Branch office in Moscow.
1.15. Status of the branches and representative offices is determined by regulations approved by the Chairman of the
Board upon a resolution of the Company’s Board of Directors.
2. Subject and Objectives of the Company’s Business
2.1. Subject of the Company’s business consists of the following:
2.1.1. Conventional and unique commercial air transportation of cargo, passengers, luggage on international and do-
mestic routes by aircraft owned by the Company as well as aircraft owned by other companies, organizations and en-
terprises engaged for this aim according to contracts concluded with them, orders from foreign companies, joint
ventures and other customers.
2.1.2. Research and design works to invent and improve aviation and other equipment, sales of aviation, technology
and other kinds of know-how within the country and abroad.
2.1.3. Emergency search and rescue works, help in case of acts of God and force majeure circumstances requiring
application of aircraft on the territory of the Russian Federation and abroad.
<i>Pour JSC VOLGA-DNEPR AIRLINES.i>
24917
2.1.4. Building, acquisition and lease, both in the Russian Federation and abroad, of any movable property and real
estate.
2.1.5. Organization and participation in exhibitions, shows, auctions and similar events both in the Russian Federation
and abroad.
2.1.6. Promotion and sales of Russian aviation equipment in the international market.
2.1.7. Investment into industry, agriculture, construction and non-production sectors including infrastructure devel-
opment in the areas where the Company’s offices are located; development of agriculture, tourism, entertainment and
leisure industry including international tourism, trade promotion.
2.1.8. Conclusion, both in the Russian Federation and abroad, of all kinds of transactions and other legal acts including
those pertaining to foreign trade and drafts, with both natural and legal entities, comprising sale and purchase, exchange,
lease, contract, loan, transportation, insurance, assignment, commission, storage, joint business as well as involvement
in tenders.
2.1.9. Intermediary business.
2.1.10. Involvement in export, import, re-export and barter transactions aiming at account settlement in foreign eco-
nomic relations.
2.1.11. Purchase and sale of goods, products, raw materials both in the Russian Federation and abroad.
2.1.12. Financial transactions like lease, credit obtaining and granting both in rubles and foreign currency, other ruble
and foreign currency transactions.
2.1.13. Legal protection of the Company’s interests.
2.1.14. Medical services to the Company’s shareholders, employees, outside organizations and physical persons.
2.1.15. Medical examination and preventive medical steps for the Company’s flight and technical personnel and out-
side organizations.
2.1.16. Advertisement, information and publishing business.
2.1.17. Transportation and forwarding business, international passenger and cargo transportation by all types of trans-
port.
2.1.18. Contractual declaration of goods and other inventory transferred across the state border of the Russian Fed-
eration and other states.
2.1.19. Payable advisory and legal services to physical persons and outside organizations.
2.1.20. Charity activities.
2.1.21. Storage business.
2.1.22. Commercial, marketing, dealer, distribution and agent services including barter and goods exchange transac-
tions.
2.1.23. Organization in the Russian Federation or abroad, both independently and on the share basis, of enterprises,
joint-stock companies, joint ventures and other firms corresponding to the subject and objectives of the Company, its
branches and offices.
2.1.24. Maintenance and line repair of aircraft owned by VOLGA-DNEPR AIRLINES and outside organizations.
2.1.25. Education business: further training.
2.1.26. Security services.
2.1.27. Pilot training and retraining for admission to fly on international air routes.
2.1.28. Communication services including international communication.
2.1.29. Other business not prohibited by the existing Russian Law.
2.2. All types of business requiring licenses or other permissions shall be carried out by the Company subject to the
availability of such permissions only.
2.3. The Company’s objectives are as follows:
2.3.1 Obtaining profits, in the interests of the Shareholders and the Company, from commercial operation of AN-
124-100, IL-76, AN-12, AN-225, YAK-40 aircraft, other aviation equipment and trucks both in the Russian and foreign
markets, from the business of its branches, joint ventures, joint stock companies and other organizations with the Com-
pany’s capital involved, carrying out independent business including foreign trade, under the Company’s financial control
and co-ordination.
2.3.2 Setting up the world’s leading cargo airline.
2.3.3 Creating organizational, technical and financial environment for further development, design and production of
freighter and superfreighter aircraft and other aviation equipment.
2.3.4 Engagement in resolution of everyday social problems arising before employees of enterprises, companies and
organizations of shareholders of VOLGA-DNEPR AIRLINES based on mutually beneficial co-operation.
3. The Company’s Property. Funds and Profits
3.1. The Company is the owner of the following:
3.1.1. Property, intellectual property and copyrights assigned to it by the Shareholders.
3.1.2. Products, intellectual property and copyrights worked out by the Company as a result of its business activities.
3.1.3. Property assigned, free of charge, by other organizations, companies or institutions.
3.1.4. Profits obtained.
3.1.5. Other property acquired by the Company in accordance with the existing law.
3.2. The Company forms its Reserve Fund in rubles and Foreign currency comprising 100% of its authorized share
capital.
3.3. The Reserve Fund is formed from the Company’s profits by annual allocation of 5% of net profits according to
the procedure adopted by the Company’s general meeting and the existing Russian Law.
3.4. The meeting may pass a resolution to increase the Reserve Fund.
24918
3.5. Moneys from the Reserve Fund shall be designed and used to cover the Company’s losses, redeem its bonds and
shares buyout in case of lack of other funds. The Reserve Fund cannot be used for any other purposes.
3.6. The Company forms necessary reserves and funds; the procedure of their organization and use being established
in these Articles and the Company’s executive authorities within their competence.
3.7. Shareholders have the right to receive part of profits in the form of dividends in rubles and foreign currency. The
dividends are allocated between the shareholders pro rata their shares paid.
3.8. The Company’s property is formed from the following sources:
contribution from the shareholders and income obtained from sale of products, works, services and other types of
business;
income from allocation of securities;
credits from banks or other creditors;
relief and charity contributions and donations from Russian and foreign legal entities and physical persons.
3.9. The Company may assign part of its property to its affiliates, branches and offices.
3.10. The Company may combine part of its property with property of other legal and natural entities including
through establishing joint ventures.
3.11. Any losses that may arise in the course of the Company’s business shall be covered from the Reserve Fund or
other funds.
4. Company’s Share Capital, Shares and Bonds
4.1. The Company’s authorized share capital comprises 270,000 rubles divided into 27,000 ordinary shares, each hav-
ing a par value of 10 rubles.
4.1.1. The Company has a right to allocate, in addition to the allocated shares, 42,000 ordinary registered shares, each
having a par value of 10 rubles.
4.2. All shares of the Company are registered shares.
4.3. The Company may additionally issue both ordinary and preference shares.
4.4. Total share of privileged shares in the Company’s authorized share capital cannot exceed 25%.
4.5. Amount of dividends on ordinary and privileged shares and liquidation value of privileged shares are to be estab-
lished by shareholders’ general meeting upon recommendations from the Board of Directors.
4.6. The Company does not announce nor pay dividends:
- before the entire authorized share capital is fully paid;
- before all the shares are bought out which are to be bought out according to Clause 4.11 of these Articles;
- if at the time of payment the Company has signs of insolvency (bankruptcy) according to the legal acts of the Russian
Federation pertaining to enterprise insolvency (bankruptcy), or the Company acquires such signs in the course of divi-
dend payment;
- if at the date of such decision the value of the Company’s net assets is less than its authorized share capital and
reserve fund or excess of liquidation price, as prescribed by the Articles, over the par value, or if such value becomes
less than their amount resulting from dividend payment.
4.7. If any additional shares are issued the category of such shares as well as other necessary requirements are decided
upon by the Company shareholders’ general subject to the limitations prescribed by these Articles and existing Russian
legal acts.
4.8. The Company may buy out its shares from the shareholders as determined by the Articles, existing Russian legal
acts and buyout resolution adopted by the Company’s competent authority.
4.9. The Company cannot acquire its allocated ordinary shares:
* before the entire authorized share capital is fully paid;
* if at the time of payment the Company has signs of insolvency (bankruptcy) according to the legal acts of the Russian
Federation pertaining to enterprise insolvency (bankruptcy), or the Company acquires such signs in the course of ac-
quisition of such shares;
* if the value of the Company’s net assets is less than its share capital, reserve fund or excess of liquidation price, as
prescribed by the Articles, over the par value, or if such becomes less than their amount resulting from acquisition of
such shares.
4.10. In case the Company’s shareholders, according to the Company’s Articles and Russian legal acts, obtain the right
to require shares buyout the Company informs the shareholders about their right, price and order of such buyout.
4.11. Information about the Company’s right to buy out shares from the shareholders who are authorized to partic-
ipate in the shareholders’ general meeting, as well as about the order of execution of this right is advised to them not
later than seven days after the resolution is adopted which engendered the Company’s right to require shares buyout.
4.12. The shareholder’s written notice about his wish to buy out his shares is sent to the Company with indication
of his residence (location) and number of shares he wishes to buy out.
4.13. Shareholders’ buyout requests should be sent to the Company not later than 45 days after the appropriate res-
olution is adopted by the shareholders’ general meeting. After this period the Company must buy out the shares from
shareholders who sent their buyout requests within 30 days.
4.14. The Company buys out the shares for price indicated in the notice about the general meeting, with its agenda
comprising issues, which, being voted upon, may engender the right to require the Company to buy out the shares ac-
cording to these Articles and Russian Law.
4.15. Total amount of funds directed by the Company to buy out the shares cannot exceed 10 percent of the Com-
pany’s net asset value as of the date of adopting the resolution that engendered the shareholders’ right to require the
Company to buy out their shares.
24919
4.16. In case the total number of shares required to be bought out exceeds the number of shares that may be bought
out by the Company according to the above limitation the shares are bought out from the shareholders pro rata the
requests received.
4.17. Shares bought out by the Company in case of its reorganization are subject to redemption at the time they are
bought out. Shares bought out by the Company in other cases become its property.
4.18. The above shares do not grant any right of vote, they are not considered when votes are counted, and collect
no dividends.
4.19. Such shares are to be sold at their market price not later than one year after they were bought out; otherwise
the shareholders’ general meeting adopts a resolution to decrease the Company’s authorized share capital by redeeming
the above shares.
4.20. Market price of the property including price of the shares or other securities of the Company, is the price
agreed between the Seller who is completely aware of the property’s price and has no obligations to sell it, and the
Buyer who is completely aware of the property’s price and has no obligations to buy it.
4.21. Property market price is determined by the Board of Directors unless otherwise prescribed by appropriate
Russian legal acts.
4.22. In case any person interested in concluding one or several transactions, where estimation of market price of
the property is required, is a member of the Company’s Board of Directors, then the property market price is estimated
by resolution of the Company’s Directors not interested in concluding the above transaction.
4.23. An independent evaluator (auditor) may be engaged to estimate the property market price.
4.24. Engaging an independent auditor to estimate the property market price is obligatory in case the Company buys
out from its shareholders their shares according to Clause 4.11 of these Articles.
4.25. In case the property to be estimated consists of shares or other securities, purchase, offer or demand price of
which is periodically published in press, then an independent evaluator is not necessary and during estimation of the
market price of such securities this purchase, offer or demand price is to be considered.
4.26. Privileged shares grant no vote in the Company unless otherwise provided by the Law.
4.27. Privileged shares grant their holder a beneficial right to obtain dividends.
4.28. Shares are paid by shareholders in rubles, foreign currency or by transfer to the Company of buildings, facilities,
equipment or other material values, rights to use land and other natural resources as well as property rights (including
rights to intellectual property).
4.29. Price of the property contributed for payment of shares at the foundation of the Company is estimated upon
agreement between the founders. When additional shares are paid with means other than cash funds, the price of the
property contributed for payment of shares is determined by the Company’s Board of Directors in accordance with the
Joint Stock Companies Federal Act.
4.30. Share price is expressed in rubles, regardless of the form the property is contributed in.
4.31. In case property is transferred to the Company on a temporary basis, the amount of this contribution and, cor-
respondingly, the contributor’s share are calculated based on the lease payment for this property for the transfer period,
but not longer than the regulatory property service life, with deduction of actual years worked before the property was
transferred to the Company.
4.32. Shareholders holding ordinary shares have a beneficial right to acquire shares alienated by the Company’s share-
holders, and are entitled to purchase them during timeframes determined by existing legislation.
4.33. In case shareholders do not use or do not wish to use their right of shares beneficial acquisition the right is
transferred to the Company.
4.34. This right grants beneficial acquisition of shares offered by any shareholder or shareholders for sale on other
equal conditions offered to any other buyer or buyers.
4.35. The Company may increase its authorized share capital if all previously issued shares are paid for.
4.36. Share capital increase is decided by the Shareholders’ General Meeting.
4.37. Share capital increase may be executed by issue of new shares, bonds exchange for shares or increase of shares
par value.
4.38. Authorized share capital increase to cover any losses is inadmissible.
4.39. Upon resolution of the Shareholders’ General Meeting, the Company may decrease its share capital by decreas-
ing the shares par value, or by purchase and redemption of part of shares in order to reduce their total number.
4.40. State registration of any changes in the Company’s Articles of Association related to decrease of the Company’s
share capital is executed subject to availability of evidence of notification to creditors as prescribed by existing legisla-
tion.
4.41. Shareholders are informed about any changes in share capital by the Company’s executive authority by regis-
tered mail.
4.42. Date of any shareholder being informed is the date when he receives the appropriate notice, according to the
receipt.
4.43. Privileged shares are allocated as prescribed by existing legislation.
4.44. In order to attract any additional funds the Company, upon resolution by the Board of Directors, may issue
bonds to be distributed among legal entities and physical persons.
4.45. Bonds issue is only admitted after all shares issued by the Company are fully paid.
4.46. Bonds issue to form and replenish the share capital is inadmissible.
4.47. The Company may issue registered and holder bonds. Bonds of all kinds are paid for in rubles and, if prescribed
by special issue terms, in foreign currency.
4.48. Regardless of the bond payment currency, its price is expressed in rubles.
24920
4.49. Types of bonds being issued, amount of annual bond interest and redemption timeframes are determined by
the issue terms.
4.50. The Company remunerates bond holders its par value within the timeframe described in it; it also pays out the
fixed portion of its par value as described in the bond (except for any issue of purpose bonds indicating the coverage
property).
4.51. Timeframe and frequency of interest payment are indicated in the bond.
4.52. Shares movement is registered in the Company Shareholders’ Register kept as required by existing Russian leg-
islation.
4.53. Shares transfer from one holder to another is registered by entering an appropriate record into the Company
Shareholders’ Register. The Company ensures keeping and storage of the Company Shareholders’ Register as required
by legal acts of the Russian Federation.
4.54. The Company is the holder of the Shareholders’ Register.
5. Management Bodies
The management bodies of the Company shall be:
Shareholders’ General Meeting
Board of Directors
General Director
<i>Shareholders’ General Meetingi>
5.1. Shareholders’ General Meeting shall be the supreme management body of the Company.
5.2. Company shall hold a Shareholders’ General Meeting annually-the Annual General Meeting.
5.3. The Annual General Meeting (AGM) shall be held within 2 to 6 months after the end of the Company’s fiscal year.
5.4. The AGM shall make decisions on Board of Directors and Auditing Commission election, approval of the Com-
pany’s Auditors, review the Company Annual Report submitted by the Board of Directors, approve Annual Financial
Statements and Annual Financial Accounts, including Profit and Loss Accounts and Profit (payment/announcement of
dividends) and Loss Distribution Accounts for the end of each fiscal year.
5.5. Shareholders’ General Meetings other than AGMs shall be extraordinary.
5.6. The date and procedures for Shareholders’ General Meeting, notification of Shareholders, list of documents and
information for review shall be set out by the Board of Directors.
5.7. Voting at Shareholders’ General Meeting shall be based on the «one share - one vote» principle, except cumula-
tive voting to elect members of the Board of Directors and Auditing Commission.
5.8. Voting for General Meeting Agenda shall be held by voting bulletins.
5.9. The form and wording of the voting bulletin shall be approved by the Board of Directors.
5.10. Voting bulletins shall be issued to a Shareholder (or his representative) registered to participate in a General
Shareholders’ Meeting.
5.11. Voting bulletin shall contain:
5.11.1. full trade name and location of the Company;
5.11.2. form of the General Meeting (meeting or absent vote);
5.11.3. date and time of the General Meeting and, if the General Meeting is carried out in the form of absent voting,
voting bulletins submission date and postal address where completed bulletins are to be sent;
5.11.4. wording of resolutions for each matter (name of each candidate) for which the voting bulletin is intended;
5.11.5. voting answers for each matter of the agenda in the form of «in favour of», «against», «abstained from»;
5.11.6. note on necessity for each voting bulletin be signed by a Shareholder.
5.12. When voting is held to elect a member of the Board of Directors or Auditing Commission, the bulletin shall
contain details on candidates including their full names.
5.13. Upon results of voting the Company Returning Board shall form minutes on voting results signed by members
of the Returning Board.
5.14. The voting minutes shall be attached to the General Meeting Minutes.
5.15. Voting results shall be delivered to Shareholders after closing of a General Meeting.
5.16. The following matters shall be in the competence of Shareholders’ General Meeting:
5.16.1. amendments and additions to the Articles or approval of the Articles’ new edition,
5.16.2. reorganization of the Company;
5.16.3. liquidation of the Company, appointment of the Liquidation Commission, approval of intermediate and final
liquidation balance sheets;
5.16.4. determination of number of the Board of Directors’ members, their election, early termination of their au-
thorities;
5.16.5. number, par value and category (type) of shares declared and rights peculiar to the shares;
5.16.6. increase of the Company’s share capital by a higher par value or additional issue of shares;
5.16.7. decrease of the Company’s share capital by a lower par value or number of shares using the Company buyout
or deletion of shares paid or bought out by the Company;
5.16.8. election of the Auditing Commission and early termination of its authority;
5.16.9. approval of the Company’s Auditors;
5.16. 10. approval of Annual Financial Statements and Annual Financial Accounts, including Profit and Loss Accounts
and Profit (payment/announcement of dividends) and Loss Distribution Accounts for the end of each fiscal year;
5.16.11. election of the Returning Board and early termination of its authority;
5.16.12. procedure for holding General Shareholders’ Meeting;
24921
5.16.13. share splitting or consolidation;
5.16.14. approval of transactions pursuant to Chapter 11 hereof,
5.16.15. approval of large-scale transactions pursuant to Chapter 10 hereof,
5.16.16. the Company’s buyout of placed shares as set forth in the Joint Stock Companies Federal Act;
5.16.17. participation in holdings, financial and industrial groups, associations and other structures of commercial in-
stitutions;
5.16.18. approval of internal documents regulating activity of the Company’s bodies;
5.16.19. other matters envisaged by the Joint Stock Companies Federal Act.
5.17. Decisions on the matters specified in Clauses 5.16.2; 5.16.6; 5.16.13 - 5.16.18 shall only be made by General
Meeting following the proposal from the Board of Directors.
5.18. General Meeting shall be considered valid if Shareholders participating in it have more than 50% of votes in ag-
gregate.
5.19. Decisions on the matters specified in subclauses 5.16.1 - 5.16.3, 5.16.5 and 5.16.16 of Clause 5.16 hereof shall
be made by the General Shareholders’ Meeting by majority of 3/4 of Shareholders’ votes - holders of voting shares who
participate in the Shareholders’ Meeting.
5.20. When quorum for General Meeting is not available a new date for a recurring General Shareholders’ Meeting
shall be advised.
5.21. The agenda for the recurring General Shareholders’ Meeting shall not be changed.
5.22. The recurring General Shareholders’ Meeting held instead of a void one shall be valid if Shareholders (or their
representatives) with more than 30% of votes of the Company’s allocated voting shares have participated in the Meeting.
5.23. Notice on a recurring General Shareholders’ Meeting shall be delivered in accordance with requirements of the
Joint Stock Companies Federal Act.
5.24. The List of Shareholders entitled to participate in a General Shareholders’ Meeting shall be compiled according
to records of the Shareholders’ Register as of the date determined by the Board of Directors.
5.25. The List of Shareholders compilation date shall not be earlier than the date of the decision on holding a General
Shareholders’ Meeting and more than 50 days prior to the Meeting date.
5.26. The List of Shareholders shall contain the name of each shareholder, information necessary for his identification,
number and category (type) of shares with voting rights, postal address in the Russian Federation, where the General
Shareholder’s Meeting notice, voting bulletins, if appropriate, and voting report be delivered.
5.27. The procedure for decision on a General Shareholders’ Meeting procedure shall be set out in the General Share-
holders’ Meeting Schedule approved by the General Shareholders’ Meeting.
5.28. Decisions made by the General Shareholders’ Meeting and voting results shall be announced at the same Gen-
eral Shareholders’ Meeting or advised to Shareholders not later than 10 days after issue of voting minutes in the form
of a voting results report as prescribed for the General Shareholders’ Meeting notice.
5.29. When arranging a General Shareholders’ Meeting, the Board of Directors shall determine:
5.29.1. form of the General Shareholders’ Meeting (meeting or absent voting);
5.29.2. date, venue and time of the general Shareholders’ Meeting and, if the General Meeting is carried out in the
form of absent voting, the final voting bulletins submission date and postal address where completed bulletins are to be
sent;
5.29.3. agenda of the Meeting;
5.29.4. procedure of the General Shareholders’ Meeting notification to Shareholders;
5.29.5. date for compiling the List of Shareholders participating in the Meeting;
5.29.6. list of documents (materials) to be distributed among Shareholders prior to the Meeting and procedure of
their provision;
5.29.7. form and wording of voting bulletins.
5.30. The notice on the General Shareholders’ Meeting is to be made not later than 20 days, and the notice on the
General Shareholders’ Meeting, where reorganization of the Company is to be discussed, not later than 30 days prior
to its date. Such notice shall specify:
5.30.1. full Company name and location;
5.30.2. form of the General Shareholders’ Meeting (meeting or absent voting);
5.30.3. date, venue and time of the general Shareholders’ Meeting and, if the General Meeting is carried out in the
form of absent voting, the final voting bulletins submission date and postal address where completed bulletins are to be
sent;
5.30.4. date for compiling the List of Shareholders participating in the Meeting;
5.30.5. agenda of the Meeting
5.30.6. procedure for familiarization of Shareholders with documents (materials) to be distributed among Sharehold-
ers prior to the Meeting and an address (addresses), where Shareholders can be advised of such information.
5.31. Shareholder(s) of the Company who has (have) more than 2% of voting shares of the Company shall have the
right to make proposals to an AGM agenda and to propose candidate(s) be elected to the Company’s Board of Direc-
tors, Auditing Commission and Returning Board. The number of such Candidates shall not exceed the total number of
members of these bodies. Such proposals shall be made within 30 days after the end of the Company’s fiscal year.
5.32. A proposal to be included in a General Shareholders’ Meeting agenda and a proposal on candidates shall be
advised in writing. Such notices shall specify name(s) of Shareholder(s) making proposals, number and category of his
(their) shares and be signed by the Shareholder(s).
5.33. When candidates are proposed for election to the Board of Directors and Auditing Commission including self-
proposed candidates, the notice shall specify the candidate’s name (if he is a Shareholder of the Company), name of the
24922
Company body, proposed for him, number and category of his shares, names of Shareholders proposing him, and
number and category of their shares.
5.34. The Board of Directors shall consider the proposals and make decision whether to include them into the Gen-
eral Shareholders’ Meeting agenda or reject them within 5 days after the timeframe specified in Clause 5.31 hereof.
5.35. A matter or candidates proposed by Shareholder(s) shall be included in the agenda or candidates voting list pro-
vided that:
Shareholder(s) comply with the date specified in Clause 5.31 hereof,
Shareholder(s) own the number of shares pursuant to Clause 5.31 hereof,
proposals comply with the requirements of Clauses 5.32 and 5.33 hereof,
proposals made to the General Shareholders’ Meeting agenda are within his competence and (or) comply with re-
quirements of the Joint Stock Companies Federal Act and other legal acts of the Russian Federation.
5.36. A reasonable decision of the Board of Directors to reject a proposal on the General Shareholders’ Meeting
agenda or on a candidate shall be sent to the Shareholder(s) within 3 days of the decision date.
5.37. A General Shareholders’ Meeting shall have no right to pass resolutions on matters beyond the agenda or to
change the agenda.
5.38. An extraordinary General Shareholders’ Meeting shall be hold under the Board of Directors’ decision and its
initiative, or a demand of the Company’s Auditing Commission, Auditors, or Shareholder(s) with more than 10% of the
Company’s voting shares.
5.39. The demand for the extraordinary General Shareholders’ Meeting shall specify the matters to be included into
the agenda.
5.40. The Board of Directors shall have no right to change the wording of the proposed matters on the agenda, if the
extraordinary General Shareholders’ Meeting is held under the demand from the Company’s Auditing Commission, Au-
ditors or Shareholder(s) with more than 10% of the Company’s voting shares.
5.41. If this demand comes from a Shareholder(s) it shall specify the name(s) of the Shareholder(s) and number and
category of his(their) shares.
5.42. The demand for the extraordinary General Shareholders’ Meeting shall be signed by the demanding person (per-
sons).
5.43. The Board of Directors shall make decision on holding or rejection of an extraordinary General Shareholders’
Meeting under the demand of the Company’s Auditing Commission, Auditors or Shareholder(s) with more than 10% of
the Company’s voting shares within 5 days from the date of demand.
5.44. The decision to reject an extraordinary Meeting under the demand of the Company’s Auditing Commission,
Auditors or Shareholder(s) with more than 10% of the Company’s voting shares may be taken provided that:
5.44.1. the procedure for demand of a General Shareholders’ Meeting set forth herein is not followed;
5.44.2. Shareholder(s) demanding an extraordinary General Shareholders’ Meeting does not own 10% of the Com-
pany’s voting shares;
5.44.3. none of the matters proposed on the agenda of the extraordinary General Shareholders’ Meeting belong to
its authority;
5.44.4. matter proposed on the agenda does not meet requirements of these Articles or legal acts of the Russian
Federation.
5.45. A General Shareholders’ Meeting resolution may be adopted without an actual meeting (joint attendance of
Shareholders for discussion of matters on the agenda and decision-making on the matters for voting) by absent voting.
5.45.1. Such voting shall not be arranged on the matters specified in Clause 5.4 hereof.
5.45.2. Absent voting shall be held with voting bulletins pursuant to Clause 5.11 hereof.
5.45.3. A General Shareholders’ Meeting resolution adopted by absent voting shall be valid if Shareholders with more
than 1/2 of the voting shares in aggregate took part in the voting.
5.45.4. Upon results of voting the Returning Board shall prepare voting minutes signed by members of the Returning
Board. The voting minutes shall be attached to the General Meeting minutes.
5.46. The Board of Directors’ reasonable decision to hold an extraordinary General Shareholders’ Meeting or to re-
ject it shall be advised to demanding persons within 3 days of the decision date.
Such notice shall specify the form of the extraordinary General Shareholders’ Meeting (attendance or absent voting)
if the demand does not specify it.
5.47. A Shareholder shall have the right to participate in the General Shareholders’ Meeting in person or through his
representative.
5.48. A Shareholder shall have the right to change his representative or to participate in a General Shareholders’
Meeting personally at any time.
5.49. Managers of companies and enterprises which are the Company’s Shareholders shall participate in a General
Shareholders’ Meeting without any proxy.
5.50. Minutes of the General Shareholders’ Meeting shall be compiled in two copies within 15 days of its closing.
5.51. Each copy of the minutes shall be signed by the Chairman and Secretary of the General Shareholders’ Meeting.
5.52. The minutes of the General Shareholders’ Meeting shall specify:
venue and date of the General Shareholders’ Meeting;
total number of votes of the Shareholders having voting shares of the Company;
number of votes of the Shareholders participating in the Meeting;
Chairman (presidium) and Secretary names;
Agenda of the Meeting.
24923
5.52.1. The minutes of a General Meeting by correspondence shall be compiled in two copies within 15 days of the
deadline for presenting voting bulletins. Each copy of the minutes shall be signed by the Chairman of the Board of Di-
rectors and Secretary of the General Meeting.
The minutes shall specify:
venue and date of minutes compilation:
total number of votes of the Shareholders having voting shares of the Company;
number of votes of the Shareholders taking part in absent voting;
agenda
5.53. Minutes of a General Shareholders’ Meeting shall contain summary of the speeches, matters voted and voting
results, and resolutions adopted by the Meeting.
5.53.1. Minutes of a General Shareholders’ Meeting by correspondence shall contain matters voted and voting results,
and resolutions adopted by the Meeting.
<i>Board of Directorsi>
5.54. The Company’s Board of Directors shall provide general management of the Company’s activities excluding
matters of the sole authority of General Shareholders’ Meeting under the Articles.
5.55. The number of Directors shall be determined by a General Shareholders’ Meeting.
5.56. Only Shareholder or his representative who has ordinary shares amounting to at least 1% of the Company’s
share capital can be a Director.
5.57. The Board of Directors’ Members shall be elected by the Annual General Meeting pursuant to laws of the Rus-
sian Federation and the Articles for a period of one year and may be reelected without any limitations.
5.58. Elections to the Board of Directors shall be held by a cumulative voting, i.e. each voting share shall have a
number of votes equivalent to a total number of the Board of Directors’ members.
5.59. A Shareholder shall have the right to vote by his shares exclusively for one candidate or split his votes for several
candidates to be elected to the Company’ Board of Directors.
5.60. Candidates who received a majority of votes shall be considered to be members of the Board of Directors.
5.61. A General Director of the Company shall not be the Board of Directors’ Chairman at one time.
5.62. The General Shareholders’ Meeting may take the decision on early termination of the Board of Directors’ au-
thority only with respect to all its members.
5.63. The Shareholders’ Meeting may increase the number of Directors and elect additional Directors to carry out
certain functions if only a current Board of Directors terminates its authority.
5.64. The Company’s General Shareholders’ Meeting shall determine remuneration for the period of the Board of
Directors’ responsibilities in accordance with approved Regulations.
5.65. The Board of Directors shall elect its Chairman and one or several Deputy Chairmen for a period of one year.
5.66. The Chairman of the Company’s Board of Directors shall be elected by members of the Board of Directors
from amongst them by majority of their votes. Votes of dropout directors shall not be taken into consideration. The
Chairman of the Board of Directors may be reelected at any time by majority votes of the total number of the Board
of Directors’ members.
5.67. The Chairman of the Board of Directors shall arrange its activity, convene its meetings and be in the chair at
them, arrange minutes compilation, be in the chair at a General Shareholders’ Meeting and act on behalf of the Company
without any Power of Attorney as follows:
5.67.1. sign on behalf of the Company contracts with the sole executive body and (upon recommendation of the sole
executive body) with executive officers directly reporting to the sole executive body;
5.67.2. determine remuneration paid to the sole executive body and executive officers directly reporting to the sole
executive body;
5.67.3. approve job requirements to the sole executive body and executive officers directly reporting to the sole ex-
ecutive body;
5.67.4. give disciplinary punishment to the sole executive body;
5.67.5. require at any time the sole executive body and executive officers directly reporting to the sole executive
body to provide a report on their activities and/or explanations.
5.67.6. arranges buyout of the Company’s shares;
5.67.7. upon decision of the Board of Directors allocate shares of the Company acquired upon decision of the Com-
pany’s Board of Directors in accordance with the Joint Stock Companies Federal Act;
5.67.8. beforehand approve transactions related to acquisition, alienation and possible alienation of the Company’s
real estate with value exceeding USD 500,000 (five hundred thousands) at the moment of transaction;
5.67.9. beforehand approve lease or other term-based and general tenancy agreements on the Company’s real estate
and other property with balance value exceeding equivalent of USD 500,000 (five hundred thousands);
5.67.10. beforehand approve transactions made by the Company’s sole executive body with value of 15% to 20% of
the balance value of the Company’s assets at the moment of transaction;
5.67.11. beforehand approve transactions related to the Company’s granting or drawing up loans, credits, guarantees
and mortgages exceeding USD 1,500,000 (one million five hundred thousands);
5.67.12. beforehand approve note transactions including the Company’s issue of notes, their endorsement, aval, pay-
ments exceeding equivalent of USD 500,000 (five hundred thousands);
5.67.13. beforehand approve decisions of the sole executive body on the Company’s investments exceeding 5% of
the Company’s annual turnover in a preceding year;
5.67.14. beforehand approve appointment or termination of authorities of managers of the Company’s branches and
representative offices by the sole executive body;
24924
5.67.15. make decisions on participation of the Company in other organizations (excluding matters under compe-
tence of the General Shareholders’ Meeting), including the Company’s withdrawal from shareholding (membership etc.);
alienation by the Company of all (partial) share holding (capital stock etc.) belonging to the Company; subsequent addi-
tional acquisition of shares (capital stock etc.) of organizations where the Company already has a share;
5.67.16. propose candidates on behalf of the Company for executive bodies and matters to agenda of organizations
where the Company is a member (has a share, has share holding etc.);
5.67.17. appoint persons representing the Company at shareholders’ (members’) meetings where the Company is a
member (has a share, has share holding etc.).
5.68. Upon decision by the Chairman of the Company’s Board of Directors matters within his competence may be
delegated for decision-making to the Company’s sole executive body.
When the Chairman of the Company’s Board of Directors is not available one of the Deputy Chairmen shall carry
out his functions upon his resolution or, upon resolution of the Board of Directors, one of the Board of Directors’
members if no Deputy Chairman is available. The Deputy Chairman or the Board of Directors’ member acting as the
Chairman shall have the right to make decisions on matters under competence of the Chairman of the Board of Direc-
tors specified in Clauses 5.67.1-5.67.17 hereof only on the basis of a Power of Attorney issued by the acting Chairman
of the Board of Directors.
5.69. Meetings of the Board of Directors shall be convened by the Chairman under his initiative or a demand from a
member of the Board of Directors, Auditing Commission or Auditors, or General Director of the Company.
5.70. The procedure for convening and holding the Company’s Board meetings shall be established by the Company’s
Articles of Association and the Board of Directors’ Regulation.
5.71. Attendance of 1/2 of the Board of Directors’ members shall be considered as quorum. Resolutions shall be taken
by majority of the members present at the meeting.
5.72. When making resolutions each Board member shall have one vote.
5.73. Transfer by any member of the Company’s Board of Directors of his vote to any other person, including other
members of the Board of Directors, is not allowed.
5.74. If a resolution receives equal number of votes the vote of the Chairman of the Board of Directors shall be de-
cisive.
5.75. The Board of Directors shall hold meetings when necessary.
5.76. A resolution by the Board of Directors may be passed without holding a meeting (joint attendance of the Board
of Directors’ members for discussion of matters on the agenda and decision-making on the matters for voting) in a way
of absent voting (polling).
5.76.1. Absent voting shall be held using voting bulletins in accordance with Clause 5.11 hereof.
5.76.2. A resolution adopted by absent voting shall be valid if not less than 50% of the Board of Directors’ members
participate in the voting.
5.76.3. The Company’s Returning Board shall prepare voting minutes signed by members of the Returning Board.
5.76.4. These minutes shall be attached to the Board’s meeting by correspondence minutes.
5.77. The Board of Directors shall be authorized to take decisions on general management of the Company excluding
matters of exclusive authority of the General Shareholders’ Meeting pursuant to these Articles.
5.78. The following matters shall be referred to the authority of the Board of Directors:
5.78.1. determination of the Company’s priority activities;
5.78.2. convening of the Company’s AGM and extraordinary General Shareholders’ Meetings;
5.78.3. approval of agenda for a General Shareholders’ Meeting,
5.78.4. determination of the date for compiling a List of Shareholders for a General Shareholders’ Meeting and other
matters related to arrangement and holding of a General Shareholders’ Meeting under competence of the Board of Di-
rectors;
5.78.5. bringing matters specified in Clause 5.17 hereof for consideration at a General Shareholders’ Meeting;
5.78.6. bonds and other securities allocation by the Company;
5.78.7. property price evaluation; allocation and buy-back price evaluation for issued securities as provided by existing
laws;
5.78.8. estimation of the property market value in accordance with Clause 4.21 hereof,
5.78.9. buy-back of the Company’s shares, bonds and other securities pursuant to the Articles and Russian Law;
5.78.10. executive body formation and early termination of its authorities; determination of its remuneration and fee
amounts;
5.78.11. recommendations for remuneration and compensation to be paid to members of the Company’s Auditing
Commission and Auditors;
5.78.12. recommendations for share dividend and procedure for its payment;
5.78.13. the Company’s reserve and other funds utilization;
5.78.14. approval of the Company’s internal documents excluding internal documents under the competence of the
Company’s General Shareholders’ Meeting as provided by the Joint Stock Companies Federal Act, and other internal
documents of the Company under the competence of the Company’s executive body as provided by these Articles;
5.78.15. set-up of the Company’s branches and representative offices;
5.78.16. approval of large-scale transactions related to property acquisition or alienation by the Company as provided
by Chapter 10 hereof,
5.78.17. approval of transactions as provided by Chapter 11 hereof;
5.78.18. approval of the Company’s registrar and a contract with him, and termination of his contract;
5.78.19. other matters provided by the Joint Stock Companies Federal Act.
24925
5.79. Minutes shall be kept at each meeting of the Company’s Board of Directors.
5.80. Minutes of the meeting of the Company’s Board of Directors shall be compiled within 3 days of the meeting date.
Minutes of the meeting of the Board of Directors held by correspondence shall be compiled in two copies within 3
days of the deadline for presenting voting bulletins. Each copy of the minutes shall be signed by the Chairman of the
Board of Directors (or Deputy Chairman) and Secretary of the General Meeting.
5.81. Minutes of a meeting shall specify:
venue and date of the meeting;
persons present at the meeting;
agenda of the meeting;
matters voted on at the meeting;
voting results;
resolutions made.
5.81.1. Minutes of a meeting of the Board of Directors held by correspondence shall specify:
venue and date of minutes compilation;
voting persons;
agenda of the meeting,
matters voted on at the meeting;
voting results,
resolutions made.
5.82. Minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by the meeting chairman who shall be responsible
for correctness of the minutes.
Minutes of a meeting of the Board of Directors held by correspondence shall he signed by the Chairman or a Deputy
Chairman of the Board of Directors.
<i>Executive Bodiesi>
5.83. The Company’s everyday activities shall be managed by the General Director.
The Company’s executive body shall arrange implementation of decisions made by the General Shareholders’ Meeting
and the Board of Directors.
5.84. General Director’s rights and responsibilities shall be governed by these Articles, laws of the Russian Federation
and the General Director’s Job Description. In addition rights and responsibilities of General Director shall be regulated
by the Company employment contract concluded with him. The General Director’s employment contract shall be
signed by the Chairman of the Board of Directors.
5.85. General Director.
5.85.1. General Director shall have the authority over all the matters of managing Company’s everyday activities ex-
cluding matters of the sole authority of the General Shareholders’ Meeting and the Board of Directors.
5.85.2. General Director shall without any Power of Attorney act on behalf of the Company, inter alia, represent its
interests, conclude transactions on its behalf, approve organization and number of personnel, issue orders and give in-
structions within his authority, which shall be mandatory for implementation by all Company employees.
5.85.3. General Director’s authority shall include but not limited to the following:
To act on behalf of the Company without any Power of Attorney and to delegate his authorities to the Company
divisions’ managers in a way of issuing powers of attorney or orders.
To issue (approve) orders and other regulatory or administrative documents referred to his authority and manda-
tory for implementation by the Company employees.
To approve organizational structure of the Company’s divisions.
To sign (approve) employment contracts and appropriate orders, divisions regulations and job descriptions of all
Company employees.
To conclude any civil transactions amounting up to 25% of the Company’s assets balance value at the date of trans-
action, to manage property of the Company unless such transactions are within competence of the General Sharehold-
ers’ Meeting, the Board of Directors or other executive officers, whose authority shall be specially specified under
authorities assignment contained in the Articles, job descriptions, powers of attorney, orders etc.
To approve lists of commercially sensitive or confidential information of the Company.
To represent the Company in any Russian or foreign organizations or institutions.
To sign any documents (letters, faxes etc.) on the matters within his competence on behalf of the Company.
To grant financial obligations on behalf of the Company amounting up to 25% of the Company’s assets balance value
as of the date of such obligation.
To take disciplinary actions against Company employees in accordance with the existing law.
To give an incentive to Company employees in accordance with current provisions on motivation and authority dis-
tribution between the Company’s top level management.
5.86. When carrying out their rights and responsibilities the Board of Directors’ members, and General Director shall
pursue the Company’s interests and carry out their rights and responsibilities in good faith and reasonably.
5.87. The Board of Directors and General Director shall be liable to the Company for losses inflicted to the Company
by their faulty actions (omissions) unless other reasoning and liability are provided for in federal laws of the Russian
Federation. The Board of Directors’ members, who voted against the decision that caused the loss or who did not take
part in the voting shall not be liable. When measuring cause and range of liability to be attributed to the Board of Di-
rectors’ members or General Director, usual business practices and other important circumstances shall be considered.
5.88. If several persons are liable under this Clause, their liability to the Company shall be joint.
24926
5.89. A company or Shareholder(s) holding at least 1% of the Company’s allocated ordinary shares shall have the right
to submit a claim to a court against any member of the Board of Directors, or General Director to recover losses in-
flicted to the Company in the cases specified above.
6. Auditing Commission and Audit
6.1. Oversight of business activities of the Company shall be carried out by the Auditing Commission elected by the
General Shareholders’ Meeting in accordance with these Articles.
6.2. Activities of the Auditing Commission shall be set forth in the Company’s internal document approved by the
General Shareholders’ Meeting.
6.3. Audit of the Company’s business activities shall be carried out upon performance of the Company for a year and
at any other time following the Auditing Commission’s initiative, a resolution by the General Shareholders’ Meeting or
the Board of Directors or upon demand of the Company’s shareholder(s) holding in aggregate at least 10 per cent of
the Company’s voting shares.
6.4. Upon request of the Auditing Commission executive officers of the Company shall provide documentation re-
lating to business activities of the Company.
6.5. The Auditing Commission shall have the right to call an Extraordinary General Shareholders’ Meeting.
6.6. Members of the Auditing Commission shall not be members of the Company’s Board of Directors or the Com-
pany’s executive officers at the same time.
6.7. Shares held by members of the Board of Directors or executive officers of the Company shall not participate in
voting during election of the Auditing Commission members.
6.8. Auditors of the Company may audit the Company’s business activities in accordance with the Company’s Articles
and legal acts of the Russian Federation based on a contract concluded with the Company.
6.9. The General Shareholders’ Meeting shall approve the Company’s Auditors. Remuneration for services provided
shall be determined by the Company’s Board of Directors.
6.10. A contract with the Auditors shall be signed by the Chairman of the Board of Directors subject to approval by
the Board.
6.11. The Auditing Commission shall report its findings to the General Meeting and Inform the Board of Directors.
6.12. Based on results of the Company’s audit, the Auditing Commission or Auditors of the Company shall draw up
a report:
confirming the accuracy of the data contained in financial statements and other documents of the Company;
providing information about any deviations from due accounting practices and financial statements provision proce-
dures specified in legal acts of the Russian Federation and the Company’s regulations, as well as any deviations from legal
acts of the Russian Federation and the Company’s regulations concerning the Company’s business activities.
6.13. The Auditing Commission shall draw up its opinion on annual financial accounts and balance sheet.
6.14. The General Shareholders’ Meeting shall not have the right to approve the balance sheet without the opinion
formed by the Auditing Commission.
6.15. The Auditing Commission must demand to call an Extraordinary General Shareholders’ Meeting in the event of
any threat to the material interests of the Company or malpractices on the part of the Company’s executive officers.
6.16. For the purposes of control over the foreign economic activities of the Company, the Auditing Commission
shall have the right to contract independent auditors.
7. Rights and Responsibilities of Shareholders
7.1. Shareholders of the Company may be individuals and legal entities holding one or more duly registered Company
shares (ordinary or preference).
7.2. Each ordinary share of the Company gives its holder an equal scope of rights in respect of ordinary shares. Each
preference share of the Company gives its holder an equal scope of rights in respect of preference shares.
7.3. Shareholders shall have the following rights:
7.3.1. Ordinary Shareholders of the Company, pursuant to the Federal Law and the Articles, shall have the right to
vote at the Shareholders’ General Meeting on all matters within its competence and receive dividends and receive part
of the property of the Company in case of liquidation.
7.3.2. Preference Shareholders do not have voting rights at the General Shareholders’ Meeting.
7.3.3. Preference Shareholders shall have the right to vote at the General Shareholders’ Meeting on matters involving
reorganisation or liquidation of the Company.
7.3.4. Preference Shareholders shall obtain the right to vote at the General Shareholders’ Meeting on matters involv-
ing amendments or additions to the Articles, which restrict the rights of the Preference Shareholders.
7.3.5. A Shareholder shall have the right to obtain information from the Company regarding his inclusion in the list
of shareholders, which have the right to attend the General Shareholders’ Meeting.
7.3.6. Any Shareholder shall have the right to take legal action against any resolution approved by the General Share-
holders’ Meeting, in case there is a violation of requirements set out by the Russian Law or the Articles and he has not
participated in the General Shareholders’ Meeting or voted against such resolution, which adversely affected his lawful
rights and interests.
7.3.7. Any Shareholder shall have the right to attend the General Shareholders’ Meeting in person or by proxy
through his representative. A Shareholder may at any time replace his representative at the General Shareholders’ Meet-
ing or participate in it personally.
7.3.8. A Shareholder shall have the right to review and obtain for a fee copies of the following documents of the Com-
pany:
the Company’s Articles of Association;
24927
duly registered amendments and additions to the Articles;
the resolution to establish the Company;
the State Registration Certificate of the Company;
documents confirming the Company’s title to its assets;
internal documents of the Company approved by the General Shareholders’ Meeting, Board of Directors, and Gen-
eral Director of the Company;
regulations on a subsidiary or representative office of the Company;
annual financial statement;
prospectus of issue of Company shares;
accounting records and reports;
minutes of the General Shareholders’ Meetings, meetings of the Board of Directors and Auditing Commission of the
Company;
voting bulletins and proxies (their copies) for participation in the General Shareholders’ Meeting;
reports of independent evaluators;
the list of the Company’s affiliates indicating the number and type of their shares;
reports prepared by the Company’s Auditing Commission, independent auditors, and federal and local tax authori-
ties;
other documents, provided for by the Russian Law, the Articles, internal documents of the Company, resolutions of
the General Shareholders’ Meeting and the Board of Directors.
7.3.9. The fee shall be determined by the Company.
7.3.10. Shareholders shall have the right:
to receive in due course a share in profits (dividends) of the Company;
to have priority in receiving products and services supplied by the Company;
to receive confirmation of their shareholding status within established period;
to have transactions involving Company shares duly registered;
to receive, in case of liquidation of the Company, a part of its property remaining after settlement with creditors or
its value;
to have priority in acquisition of shares sold by other Shareholders or additionally issued by the Company.
7.3.11. Voting Shareholders shall have the right to demand the Company to buy back all or part of their shares in case
of:
any reorganisation of the Company or any large transaction approved by the General Shareholders’ Meeting, if they
voted against such reorganisation or transaction or did not vote on such matters;
introduction of any amendments or additions to the Articles or approval of the revised Articles, which limit their
rights, if they voted against such resolution or did not vote at all.
7.4. Shareholders shall be obliged to:
7.4.1. comply with the Articles and actively assist the Company in its business;
7.4.2. pay for the shares provided for by the Articles in due course asset out by relevant documents of the Company;
7.4.3. not disclose confidential information about activities of the Company (commercial secrets);
7.4.4. enter into agreements with the Company to support its business.
7.5. Shareholders shall be liable for the damage to the Company brought about through their fault. Shareholders shall
be liable for the obligations of the Company limited to their shareholding in the Company, unless otherwise provided
by the Russian law.
7.6. Shareholders shall not be held liable for the events, which resulted from any circumstances beyond their control.
Shareholders shall not have the right to demand of their contributions from the Company except when provided for by
the Russian law.
8. Accounting and Reporting
8.1. The Company’s financial year shall commence on 1 January and end on 31 December of each calendar year.
8.2. Accounting and reporting including statistical reporting shall be performed by the Company as set out by the
existing Russian laws and regulations.
8.3. Responsibility for the accounting arrangements and accuracy of the accounting data in the Company, and for time-
ly submission of annual reports and other financial statements to relevant authorities, and for timely provision of infor-
mation about activities of the Company to Shareholders, creditors and mass media, shall remain with the General
Director of the Company.
8.4. Within six months following the end of the financial year executive bodies of the Company shall submit an annual
activity report and balance sheet to the General Shareholders’ Meeting for review.
8.5. Accuracy of data contained in the Company’s annual report, balance sheet, profit and loss account should be
confirmed by the Auditing Commission.
8.6. Bad debts, inventory shortages and losses, worn-out equipment and costs relating to stopped or unfinished con-
struction projects may be written off by the decision of the Company’s General Director.
8.7. The Company shall keep at its principal place of business all documents required by relevant Russian regulations.
8.8. Provision of information relating to the above documents shall be done as provided for by existing Russian laws.
9. Reorganisation and Liquidation
9.1. The Company may be reorganised or liquidated as provided for by the Russian laws.
9.2. The decision on voluntary reorganisation or liquidation of the Company maybe only made by the General Share-
holders’ Meeting upon proposal by the Board of Directors.
24928
9.3. The proposal made by the Board of Directors shall be justified and contain conditions and procedures for reor-
ganisation or liquidation of the Company.
10. Significant Transactions
10.1. The following transactions shall be considered to be significant ones:
10.1.1. a transaction (including a loan, credit, mortgage or guarantee) or several related transactions involving direct
or indirect acquisition or disposal by the Company of property valued at more than 25% of the Company’s balance value
of assets in accordance with its accounts as of the last reporting date, except for transactions made in the normal course
of business;
10.1.2. a transaction or several related transactions involving placement through subscription (disposal) of ordinary
shares or transactions involving placement of issuing securities convertible into ordinary shares.
10.2. The value of the property being the subject of the significant transaction shall be determined by the Board of
Directors in accordance with Clauses 4.21-4.25 of these Articles.
10.3. Decision to approve a significant transaction involving property valued at 25% to 50% of the Company’s balance
value of assets shall be subject to the unanimous vote of the Board of Directors. Votes of discharged members of the
Board of Directors shall not be taken into account.
10.4. If the Board of Directors fails to reach the unanimous decision on the proposed significant transaction, the
Board of Directors may decide to submit the matter to the General Shareholders’ Meeting for consideration.
10.5. Decision to approve a significant transaction involving property valued at over 50% of the Company’s balance
value of assets shall be made by the General Shareholders’ Meeting subject to the 3/4 majority vote of voting Sharehold-
ers participating at the General Shareholders’ Meeting.
11. Interest in Transactions Concluded by the Company
11.1. A member of the Board of Directors, an officer holding a position in other management bodies of the Company,
a Shareholder (Shareholders) holding together with his affiliated person(s) 20% or more of the Company’s voting shares,
and other persons with the right to give binding orders to the Company shall be recognized as persons interested in a
transaction concluded by the Company if the above persons, their spouses, parents, children, brothers and sisters in-
cluding stepbrothers and stepsisters, and adoptive parents and adopted children and all their affiliated persons:
are a party or beneficiary to such transaction or act as a representative or intermediary in respect of such transac-
tion;
hold (separately or in aggregate) 20% or more of the voting shares of a legal entity being a party or beneficiary to
such transaction or acting as a representative or intermediary in respect of such transaction;
are officers of a legal entity being a party or beneficiary to such transaction or acting as a representative or interme-
diary in respect of such transaction.
11.2. The above persons should make available to the Board of Directors, Auditing Commission and independent
auditors of the Company any information about:
any legal entities where they hold personally or together with their affiliated persons 20% or more of the voting
shares;
any legal entities where they hold positions as officers; any known, pending or proposed transactions in respect of
which they may be deemed interested persons.
11.3. Decision to conclude a transaction when there is an interested person as described above, shall be made by
majority votes of members of the Board of Directors who are not interested in the transaction.
11.4. An independent director is a member of the Board of Directors who has not been within one year preceding
the decision:
a person performing functions of the General Director of the Company;
a person, whose spouse, parents, children, brothers and sisters including stepbrothers and stepsisters, and adoptive
parents and adopted children are officers in the Company’s management bodies;
an affiliated person of the Company excluding the Board of Directors.
11.5. Decision to conclude a transaction when there is an interested person as described above, shall be made by the
General Shareholders’ Meeting by a majority of Shareholders who are not interested in such transaction, in the following
cases:
when the value (property acquisition offer price) of property being the subject of the transaction or several related
transactions according to accounting records of the Company exceeds 2% of the Company’s balance value of assets in
accordance with its accounts as of the last reporting date, except for transactions provided for in paragraphs 3 and 4 of
this Clause;
when the transaction or several related transactions involve placement, through subscription or disposal, of voting
shares of the Company amounting to over 2% of ordinary shares previously placed by the Company and ordinary shares,
into which previously placed issued securities convertible into shares may be converted;
when the transaction or several related transactions involve placement through subscription of issued securities con-
vertible into shares, which may be converted into ordinary shares amounting to over 2% of ordinary shares previously
placed by the Company and ordinary shares, into which previously placed issued securities convertible into shares may
be converted.
11.6. A transaction, when there is an interested person as described above, shall not require an approval by the Gen-
eral Shareholders’ Meeting as provided for in Clause 5.16.16 hereof in cases set forth in the Joint Stock Companies Fed-
eral Act.
24929
11.7. If all members of the Company’s Board of Directors are deemed interested persons as described above and/or
are not independent directors, the transaction may be approved by a resolution of the General Shareholders’ Meeting
by the majority vote of. non-interested Shareholders.
11.8. If a transaction is a significant transaction while there is an interested person as described above and it involves
acquisition or disposal of property by the Company, provisions set out in Chapter 11 of these Articles shall apply.
11.9. When there is an interested person as described above and a transaction has been concluded in violation of
requirements set out in Chapter 11 of these Articles, such transaction may be declared void upon claim of the Company
or a shareholder.
11.10. An interested person shall be liable to the Company for damages caused by him to the Company.
11. 11. When there are several interested persons, they shall be jointly liable to the Company.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00470. – Reçu 68 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(028178.3//854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
EUROCAPITAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 99.906.
—
STATUTES
In the year two thousand four, on the twenty-sixth day of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ATKINS PROPERTIES LIMITED, a limited company incorporated in England, having its registered address at 16
Church Street, Epsom, Surrey KT17 4QB, registered with the Companies House under the registration number 685514,
here represented by Maître Cécile Henle, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on Feb-
ruary 26, 2004.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration au-
thorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association (the Articles of Association) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée),
which is hereby incorporated.
Art. 1. There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares
hereafter issued, a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of EUROCAPITAL HOLD-
INGS, S.à r.l. (the Company).
Art. 2. The Company is established for an indefinite duration. The Company may be dissolved at any time by a res-
olution of the partner(s) adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as pre-
scribed in Article 10 hereof.
Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any com-
panies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may fur-
ther invest in any real property interests in any form whatsoever. The Company may in particular acquire by
subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures,
certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by
any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin whatsoever.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other com-
pany. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge,
transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.
The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.
Art. 4. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. Branches or other offices
may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager(s).
In the event that the manager(s) determine(s) that extraordinary, political, economic, or social developments have
occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
Signature.
24930
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will re-
main a Luxembourg company.
Art. 5. The Company’s corporate capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) represented by
500 (five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five euro) each, all subscribed and fully paid-up.
The corporate capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the Law of 10th August
1915 on commercial companies, as amended.
The Company may redeem its own shares. However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the
shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are avail-
able as regards the excess purchase price. The Company’s decision to redeem its own shares shall be taken by an unan-
imous vote of the partners representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general
meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 6. Shares are freely transferable among partners. The share transfer inter vivos to non partners is subject to
the consent expressed in an partners’ meeting of at least seventy-five per cent of the Company’s share capital. In the
case of the death of an partner, the share transfer shall be made pursuant to applicable legal provisions.
Art. 7. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and dismissed by gen-
eral meeting of partners acting on the votes of a majority of the share capital, which determines their powers and the
duration of their mandates. The general meeting of partners may at any time and ad nutum (without having to state any
reason) revoke and replace the manager(s).
The general meeting of partners shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of
each of the managers.
Towards third parties, in case of single manager, the manager has the most extensive powers for the ordinary admin-
istration of the Company. He may execute any act without exception (other than those acts for which a general meeting
is required by law) which are deemed appropriate with regard to the object of the Company. The Company will be
bound by the single signature of the sole manager.
In case of plurality of managers, the board of managers is composed of one or several A manager(s) and one or several
B manager(s). The A manager(s) and the B manager(s), acting jointly, may execute any act without exception (other than
those acts for which a general meeting is required) which are deemed appropriate with regard to the object of the Com-
pany. The Company will be bound by the joint signature of at least two managers, of which one must be an A manager
and one a B manager.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax
or telex, another manager of the same category as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of
managers by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the
meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting. Meetings may further be held by way of conference call only.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by
ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any ether suitable telecommunication
means.
A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-
tent.
Art. 8. In carrying out their mandate, the manager(s) is/are not held personally responsible. As agent(s) of the Com-
pany, he/they is/are responsible for the correct performance of his/their duty(ies).
Art. 9. 1. If the Company is composed of a simple partner, the latter exercises the powers granted by law to the
general meeting of the partners.
Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th 1915 on commercial companies are not applicable to that
situation.
2. If the Company is composed of several partners, collective decisions are taken by ordinary general or extraordinary
general meetings. The convening of general meetings is not necessary for as long as the Company has less than 25 part-
ners. In this case, collective decisions may be taken by circular resolutions.
Every partner may take part in the collective decisions. His number of votes is equal to the number of shares which
he owns and he may validly act at the meeting either in person or through a special proxy. If the Company has more
than 25 partners, a general meeting must be held at least once a year during a time period determined by the articles.
Extraordinary general meetings may be held under circumstances required by law.
Art. 10. Collective decisions are only valid if the votes east in their favour represent more than half of the share
capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of part-
ners representing three quarters of the share capital, and must be recorded by a notarial deed.
Art. 11. The Company’s accounting year begins on 1st January and ends on 31st December of each year.
Art. 12. Every year the annual accounts are drawn up by the manager or the board of managers, as the case may be.
Art. 13. The financial statements are at the disposal of the partner(s) at the registered office of the Company.
24931
Art. 14. Five per cent (5%) out of the net profit shall be placed into a legal reserve account.
This deduction ceases to be compulsory when this reserve amounts to ten percent (10 %) of the share capital of the
Company.
The balance is at the disposal of the partner(s).
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the sole manager, or in case of plurality of managers, by the board of managers;
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or, in case of plurality of partners, by an extraor-
dinary general meeting of the partners;
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-
pany are not threatened.
Art. 15. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of any of the partners.
The liquidation of the Company, if any, may occur accordingly to provisions of the law.
Art. 16. In the case that the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who need not be partners and who are appointed by the partners who will specify the powers and remuneration of the
liquidators.
Art. 17. If, and as long as one partner holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single partner
company, pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies dated 10th August 1915, as amended. In this
case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 18. For anything not dealt within the present articles of incorporation, the partners refer to Luxembourg law
on commercial companies dated 10th August 1915, as amended.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31st December 2004.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 500 (five hundred) shares have been subscribed by ATKINS PROPERTIES LIMITED, prenamed. The subscribed
capital has been entirely paid up in cash, so that the amount of EUR 12,500.- is as of now at the disposal of the Company,
as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately two thousand euro (EUR 2,000.-).
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1) The registered office is established at 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.
2) The Company will be managed by a two managers.
3) The following are appointed as managers for an unlimited duration:
- Mr Paul Lutgen, born on May 15, 1942 in Consthum, réviseur d’entreprises, with professional address at 16, allée
Marconi, L-2120 Luxembourg, as A manager of the Company; and
- Mr Luc Braun, born on September 24, 1958 in Luxembourg, réviseur d’entreprises, with professional address at 16,
allée Marconi, L-2120 Luxembourg, as B manager of the Company.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with
Us the notary the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-six mars.
Par-devant Nous, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ATKINS PROPERTIES LIMITED, une société limitée de droit anglais, établie et ayant son siège social au 16 Church
Street, Epsom, Surrey KT17 4QB, enregistrée avec le Companies House sous le numéro 685514,
ici représentée par Maître Cécile Henle, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé donnée le 26 février 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts (les Statuts) comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre le(s) souscripteur(s) et tous ceux qui deviendraient associés des parts
sociales émises ci-après, une société à responsabilité limitée sous la raison sociale de EUROCAPITAL HOLDINGS,
S.àr.l. (la Société).
24932
Art. 2. La Société est établie pour une période indéterminée. La Société peut être dissoute à tout moment sur dé-
cision des associés, statuant comme en matière de modification des statuts dans les conditions édictées à l’Article 10 ci-
après.
Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés
ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra également investir
dans toute propriété immobilière sous n’importe quelle forme que ce soit. La Société pourra en particulier acquérir par
souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obliga-
tions, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique
ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entre-
prise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de pro-
priété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, par
voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créan-
ces. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses
filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de
toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de
propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y
rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg. Des succursales ou bureaux tant dans le
Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger peuvent être créés sur simple décision des gérants.
Au cas où les gérants estimeraient que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de
nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de
ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq
cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et intégralement
libérées.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à tout moment conformément à l’article 199 de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
La Société peut racheter ses propres parts sociales. Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale
des parts sociales à racheter, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables suffisantes
sont disponibles au regard du surplus du prix d’achat. La décision de la Société de racheter ses parts sociales sera prise
par un vote unanime des associés représentant cent pour cent (100%) du capital social, réunis en assemblée générale
extraordinaire et entraînera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Un transfert de parts sociales entre vifs à un eu
plusieurs non associés est soumis à l’agrément des associés donné en assemblée des associés représentant au moins
soixante quinze pour cent du capital social. En cas de décès d’un associé, le transfert des parts sociales sera réalisé con-
formément aux dispositions légales applicables.
Art. 7. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituront un conseil de
gérance. Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont només et révoqués par l’assemblée
générale des associés représentant au moins la majorité du capital social, cette dernière déterminant ses (leurs) pouvoirs
et la durée de son (leurs) mandat(s). L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir
justifier d’une raison), révoquer et remplacer le ou les gérants.
L’assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants.
Vis-à-vis des tiers, en cas de gérance unique, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour assurer l’administration
ordinaire de la société. Il peut exécuter tous actes, sans exception (autres que les actes pour lesquels la loi requiert une
assemblée générale), qui semblent appropriés au regard de l’objet de la Société. La Société sera engagée par la seule
signature du gérant.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est composé de un ou plusieurs gérants A et de un ou plusieurs
gérants B. Vis-à-vis des tiers, les gérant(s) A et les gérant(s) B agissant conjointement peuvent exécuter tous actes, sans
exception (autres que les actes pour lesquels la loi requiert une assemblée générale), qui semblent appropriés au regard
de l’objet de la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle de deux gérants, dont un doit être un gérant
de catégorie A et un doit être de catégorie B.
Chaque gérant peut agir à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, par télécopie ou câble, télé-
gramme ou télex, un autre gérant comme son fondé de pouvoir. Chaque gérant peut assister et sera considéré comme
étant présent à une réunion du conseil de gérance, par conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécommu-
nication qui permettra à tous les participants à la réunion de s’entendre et de se parler les uns les autres, et la partici-
24933
pation à une réunion par de tels moyens sera assimilée à une présence physique à une telle réunion. Les réunions
peuvent aussi être tenues par simple conférence téléphonique.
Les résolutions approuvées par écrit et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions adoptées
lors des réunions des gérants.
Dans ces cas, de telles résolutions ou décisions peuvent être prises expressément, soit en étant formulées dans une
résolution circulaire, ou transmise par courrier ordinaire, courrier électronique ou télécopieur, ou par téléphone, té-
léconférence ou par tout autre moyen de télécommunication approprié.
Pareille résolution écrite pourra être prise dans un seul ou plusieurs documents séparés ayant tous le même contenu.
Art. 8. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction(s) aucune responsabilité personnelle. Comme
simples mandataire(s) de la Société, il(s) n’est/ne sont responsable(s) que de l’exécution correcte de son son/leurs man-
dat(s).
Art. 9. 1. Si la Société est composée d’un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs conférés par la loi à l’assemblée
générale des associés.
Les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ne sont pas
applicables dans une telle hypothèse.
2. Si la Société est composée de plusieurs associés, les décisions collectives sont prises par assemblées générales or-
dinaires ou extraordinaires. La convocation des assemblées générales n’est pas nécessaire, si la Société a moins de 25
associés. Dans ce cas, les décisions collectives peuvent être prises par résolution circulaire.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il
possède et peut valablement agir en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire spécial. Si la Société a plus de 25
associés, une assemblée générale devra au minimum être tenue une fois par an à la date déterminée par les Statuts. Des
assemblées générales extraordinaires pourront être tenues dans les circonstances requises par la loi.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les votes exprimés en leur faveur
représentent plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts,
ne pourront être prises que si les votes exprimés en leur faveur représentent au moins les trois quarts du capital social
et devront être enregistrés par acte notarié.
Art. 11. L’exercice social de la Société commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année, le gérant ou le conseil de gérance, le cas échéant, établit les comptes annuels.
Art. 13. Les comptes annuels sont à la disposition de(s) l’associé(s) au siège social de la Société.
Art. 14. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net pour la constitution d’un fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire à partir du moment où la réserve légale atteint dix pour-cent (10%) du capital
social de la Société.
Le solde est à la disposition des associés.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-
tes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de
gérance;
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice;
3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d’acomptes sur dividendes;
4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont
pas menacés.
Art. 15. La Société ne sera pas dissoute par la mort, l’interdiction, la banqueroute ou l’insolvabilité d’un des associés.
La liquidation de la Société, le cas échéant, sera faite conformément aux dispositions légales.
Art. 16. Dans l’hypothèse d’une dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, nommés par les associés qui détermineront les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.
Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société
est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée. Dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, le(s) associés se réfèrent à la loi sur les sociétés
commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2004.
<i>Souscription - Libérationi>
Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par la société ATKINS PROPERTIES LIMITED, prénom-
mée. Toutes ces parts sociales ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que le montant de
EUR 12.500,- est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le reconnaît expres-
sément.
24934
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1) Le siège social de la Société est fixé au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.
2) La Société est administrée par deux gérants.
3) Sont nommés comme gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Paul Lutgen, né le 15 mai 1942 à Consthum, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 16,
allée Marconi, L-2120 Luxembourg, comme gérant A de la Société; et
- Monsieur Luc Braun, né le 24 septembre 1958 à Luxembourg, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle
au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, comme gérant B de la Société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: C. Henle, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, vol. 20CS, fol. 65, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027841.3/230/319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
BLICON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.207.
—
L’an deux mille quatre, le trente mars.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BLICON S.A., avec siège so-
cial à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sous le
numéro B 53.207,
constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, en date du 8 décem-
bre 1995, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 84 du 17 février 1996, et dont les statuts
ont été modifiés comme suit:
- suivant acte reçu par ledit notaire Camille Hellinckx en date du 5 décembre 1996, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations numéro 93 du 27 février 1997;
- suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 2 mars 1998, publié au Mé-
morial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 427 du 13 juin 1998;
- suivant acte reçu par ledit notaire Jean-Joseph Wagner en date du 7 octobre 1999, publié au Mémorial C Recueil
des Sociétés et Associations numéro 961 du 15 décembre 1999, et
- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 juin 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés
et Associations numéro 815 du 8 novembre 2000,
avec un capital social de quarante-cinq millions de francs luxembourgeois (45.000.000,- LUF), représenté par quaran-
te-cinq mille (45.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF), entièrement souscri-
tes et libérées.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150
Luxembourg, 207, route d’Arlon.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandra Mariani, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Décision de modifier la devise d’expression du capital social en Euros avec effet au 1
er
janvier 2004, de sorte que
le capital social s’élève actuellement à un million cent quinze mille cinq cent vingt Euros quatre-vingt-six cents (EUR
1.115.520,86).
3.- Augmentation du capital social à concurrence du montant de quatre cent soixante-dix-neuf Euros quatorze cents
(EUR 479,14), pour le porter de son montant actuel de un million cent quinze mille cinq cent vingt Euros quatre-vingt-
six cents (EUR 1.115.520,86) au montant de un million cent seize mille Euros (EUR 1.116.000,-) par incorporation à
Luxembourg, le 1
er
avril 2004.
A. Schwachtgen.
24935
concurrence du montant de quatre cent soixante-dix-neuf Euros quatorze cents (EUR 479,14) de résultats reportés au
31 décembre 2003.
4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent Euros (EUR 100,-) par action, de sorte que le capital
social de un million cent seize mille Euros (EUR 1.116.000,-) est divisé en onze mille cent soixante (11.160) actions de
cent Euros (EUR 100) chacune.
5.- Fixation d’un capital autorisé d’un montant de trois millions Euros (EUR 3.000.000,-), représenté par trente mille
(30.000) actions de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
6.- Autorisation au conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé
pour une durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités d’usage.
7.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
8.- Mandat au Conseil d’Administration d’exécuter les prédites résolutions.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.
IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la devise d’expression du capital social en Euros avec effet au 1
er
janvier 2004, de
sorte que le capital social s’élève actuellement à un million cent quinze mille cinq cent vingt Euros quatre-vingt-six cents
(EUR 1.115.520,86).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide une augmentation du capital social à concurrence du montant de quatre cent soixante-
dix-neuf Euros quatorze cents (EUR 479,14), pour le porter de son montant actuel de un million cent quinze mille cinq
cent vingt Euros quatre-vingt-six cents (EUR 1.115.520,86) au montant de un million cent seize mille Euros (EUR
1.116.000,-) par incorporation au capital social de résultats reportés, ainsi qu’il résulte d’un bilan daté au 31 décembre
2003, dûment approuvé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
La disponibilité desdits résultats résulte d’une déclaration faite par les administrateurs de la société confirmant que
lesdites réserves n’ont pas été affectées respectivement distribuées et qu’elles existent encore à la date de ce jour.
Ces documents, après avoir été signés ne varietur par le notaire instrumentant et tous les comparants resteront an-
nexés au présent acte avec lequel ils seront enregistrés
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent Euros (EUR 100,-) par ac-
tion, de sorte que le capital social de un million cent seize mille Euros (EUR 1.116.000,-) est divisé en onze mille cent
soixante (11.160) actions de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide la fixation d’un capital autorisé d’un montant de trois millions Euros (EUR 3.000.000,-),
représenté par trente mille (30.000) actions de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration en vue de procéder à l’augmentation du capital dans le cadre du ca-
pital autorisé pour une nouvelle durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités
d’usage.
<i>Septième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée générale décide de modifier en conséquence l’article 3 des statuts,
qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 3. Le capital social est fixé à un million cent seize mille Euros (EUR 1.116.000,-), divisé en onze mille cent soixan-
te Euros (11.160) actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital autorisé est fixé à trois millions Euros (EUR 3.000.000,-), représenté par trente mille (30.000) actions de
cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital,
24936
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles,
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue: cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
<i>Huitième résolutioni>
Le Conseil d’Administration est mandaté d’exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à
cet effet.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par
leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: J. Lambert, E. Mantilaro, S. Mariani, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 30 mars 2004, vol. 356, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(027508.3/201/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
BLICON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.207.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027512.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
S.C.I. PILOLUX, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 26, rue Adolphe.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,
le 18 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, volume 20CS, folio 59, case 10, au droit de douze euros,
que les associés de la société civile immobilière S.C.I. PILOLUX, avec siège social à L-1749 Howald, 1, rue Rudy Her-
ber, constituée suivant acte reçu par le prédit notaire Tom Metzler, le 17 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 224 du 3 juin 2003,
ont pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-1749 Howald, 1, rue Rudy Herber à L-1116
Luxembourg, 26, rue Adolphe et par conséquent de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le siège social est établi à Luxembourg.
Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027466.3/222/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
S.C.I. PILOLUX, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 26, rue Adolphe.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027468.3/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
Echternach, le 1
er
avril 2004.
H. Beck.
Echternach, le 1
er
avril 2004.
H. Beck.
Luxembourg-Bonnevoie, le 30 mars 2004.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 30 mars 2004.
T. Metzler.
24937
EAGLE BAY, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 98.916.
—
L’an deux mille quatre, le dix mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Kim Kaskal, administrateur de société, né à Katarina/Stockholm (Suède), le 18 août 1965, demeurant à En-
gelbrektsgatan 19, SE-114 32 Stockholm (Suède),
ici représenté par:
Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle au 6A Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Stockholm (Suède), le 05 février 2004.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée en même temps avec lui.
Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
<i>Exposé préliminairei>
1.- Que suivant contrat de cession de parts sociales dressé sous seing privé à Stockholm (Suède), le 28 janvier 2004,
le mandant, Monsieur Kim Kaskal, prénommé, est devenu seul et unique propriétaire de la totalité des cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) ayant appartenues à Monsieur Peter Thelin, ancien
associé fondateur et représentatives de l’intégralité du capital social de la société EAGLE BAY, une société à responsa-
bilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 2 rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 98.916, constituée
suivant acte reçu par le prédit notaire Jean-Joseph Wagner, en date du 23 janvier 2004, en voie de publication au Mé-
morial C.
Les statuts de la dite Société n’ont pas été modifiés depuis son acte de constitution.
Le prédit contrat de cession de parts sociales dressé sous seing privé, à Stockholm (Suède), le 23 janvier 2004, après
avoir été signé ne varietur par la personne comparante et mandataire de l’associé unique, Monsieur Kim Kaskal et par
le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.
2.- Que le capital social de la Société EAGLE BAY, prédésignée, s’élève à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR)
et se trouve représenté comme indiqué ci-avant par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq
Euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.
Ceci exposé, l’associé unique, représenté comme il est dit ci-avant et exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée
générale des associés par les dispositions de la section XII (relative aux sociétés à responsabilité limitée) de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique, représenté comme il est dit ci-avant, décide d’accepter la cession de parts sociales faite sous seing
privé, par Monsieur Peter Thelin, portfolio manager, né à Enskede (Suède), le 19 avril 1956, à Monsieur Kim Kaskal,
administrateur de société, né à Katarina/Stockholm (Suède), le 18 août 1965, demeurant à Engelbrektsgatan 19, SE-114
32 Stockholm (Suède), en date du 28 janvier 2004.
Le cessionnaire, Monsieur Kim Kaskal, préqualifié, se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux
parts sociales cédées à partir du 28 janvier 2004. Il participera aux bénéfices à partir de la même date. Le cessionnaire,
par son mandataire susnommé, déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la Société.
Ensuite Messieurs Eric Leclerc et Jos Hemmer, tous deux avec adresse professionnelle au 6A Circuit de la Foire, L-
1347 Luxembourg, et agissant en leur qualité de gérant de classe B de la Société, déclarent accepter au nom et pour
compte de cette dernière, la cession de parts sociales dressée sous seing privé, en date du 28 janvier 2004 et la consi-
dérer comme dûment signifiée à la Société, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil et conformé-
ment à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède et notamment avec la nouvelle détention
des parts sociales, l’associé unique décide de modifier dans les deux versions anglaise et française, l’article six (6) des
statuts de la Société, afin de lui donner désormais la teneur suivante:
Version anglaise:
Art. 6. Capital. «The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR)
divided into one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) each, fully paid
up.
All these shares are owned by Mr Kim Kaskal, company director, born in Katarina/Stockholm (Sweden), on 18, Au-
gust 1965, residing at Engelbrektsgatan 19, SE-114 32 Stockholm (Sweden).»
Version française:
Art. 6. Capital. «Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en cent
(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.
Toutes les parts sociales sont détenues par Monsieur Kim Kaskal, administrateur de société, né à Katarina/Stockholm
(Suède), le 18 août 1965, demeurant à Engelbrektsgatan 19, SE-114 32 Stockholm (Suède).»
24938
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique, par son représentant susnommé, décide d’accepter, avec effet au 28 janvier 2004, date de la cession
de parts sociales, la démission avec décharge de Monsieur Peter Thelin, en tant que gérant de catégorie A et d’assumer
lui-même à l’avenir le poste de gérant A, avec les pouvoirs prévus à l’article quinze (15) des statuts de la Société.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Leclerc, J. Hemmer, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 mars 2004, vol. 883, fol. 63, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (ff)i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027489.3/239/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
EAGLE BAY, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 98.916.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027490.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
ESFIL - ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 46.338.
—
In the year two thousand and four, on the twenty-sixth of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company established in Luxembourg under
the denomination of ESFIL - ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A., R. C. Luxembourg B Number 46.338, having its reg-
istered office in Luxembourg, organized originarily under the denomination of ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A. be-
fore Maître Marthe Thyes-Walch, notary residing in Luxembourg, on December 23, 1993, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Number 131 of April 7, 1994.
The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the undersigned notary, dated
November 16, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 378 of May 22, 2001.
The meeting begins at 11.30 a.m., Mrs Annie Swetenham, corporate manager, with professional address at 231, Val
des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, being in the chair.
The chairman appoints as secretary of the meeting Ms Anne-Marie Charlier, corporate executive, with professional
address at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
The meeting elects as scrutineer Ms Stéphanie Spinelli, secretary, with professional address at 231, Val des Bons Ma-
lades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the four million and
five hundred thousand (4,500,000) shares of fifteen euro (EUR 15.-) each, representing the total capital of sixty-seven
million and five hundred thousand euros (EUR 67,500,000.-) are duly represented at this meeting which is consequently
regularily constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices,
all the persons present or represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present
deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Renewal of the authorisation to the Board of Directors to increase the share capital within the limits of the au-
thorised capital.
2. Information of the death of Mr Mario Augusto Fernandes Cardoso, Director of the Company.
3. Appointment of Mr Jorge Manuel Amaral Penedo, economist, with professional address at 62, Rua de Sao Bernar-
do, 1249-092 Lisbon, Portugal, as Director.
4. Managers: Resignation with immediate effect of Mr Erich Dähler and cessation of the function of Mr Patrice Binder
with effect from 27.02.2004.
5. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolves to renew the authorisation given to the Board of Directors to increase the corporate
capital by the issue of new shares within the limits of the authorised capital for a new period of five (5) years running
Belvaux, le 1
er
avril 2004.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 1
er
avril 2004.
J.-J. Wagner.
24939
from the date of publishing of the Extraordinary General Meeting of March 26, 2004 in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting takes note of the death of Mr Mario Augusto Fernandes Cardoso, Director of the Company.
<i>Third resolutioni>
The General Meeting appoints as new Director of the Company Mr Jorge Manuel Amaral Penedo, economist, born
on August 7, 1963 in Penamacor, Portugal, with professional address at 62, Rua de Sao Bernardo, 1249-092 Lisbon, Por-
tugal.
His mandate shall expire at the same time as those of the other Directors i.e. at the end of the annual general meeting
to be held in 2005
<i>Fourth resolutioni>
The General Meeting accepts the resignation of Mr Erich Dähler as Manager with immediate effect and the cessation
of the function of Mr Patrice Binder as Manager with effect from 27.02.2004.
Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 11.45 a.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-six mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de ESFIL - ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A., R. C. Luxembourg B numéro 46.338, ayant son siège
social à Luxembourg constituée originairement sous la dénomination de ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A. suivant
acte reçu Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 1993, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 131 du 7 avril 1994.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 16 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 378 du 22 mai 2001.
La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec
adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie Charlier, corporate executive, avec
adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Stéphanie Spinelli, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231,
Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre millions
cinq cent mille (4.500.000) actions d’une valeur nominale de quinze euros (EUR 15,-) chacune constituant l’intégralité
du capital social de soixante-sept millions cinq cent mille euros (67.500.000,-) sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration d’augmenter le capital social dans le cadre
du capital autorisé.
2. Information du décès de Monsieur Mario Augusto Fernandes Cardoso, administrateur de la Société.
3. Nomination de M. Jorge Manuel Amaral Penedo, économiste, avec adresse professionnelle au 62, Rua de Sao Ber-
nardo, 1249-092 Lisbonne, Portugal, aux fonctions d’administrateur.
4. Directeurs: Démission avec effet immédiat de M. Erich Dähler et cessation de des fonctions de M. Patrice Binder
avec effet au 27 février 2004.
5. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de renouveler l’autorisation accordée au Conseil d’Administration d’émettre de nou-
velles actions dans le cadre du capital autorisé, pour une nouvelle période de cinq (5) ans commençant à la date de pu-
blication de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mars 2004 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
24940
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale prend acte du décès de Monsieur Mario Augusto Fernandes Cardoso, administrateur de la
Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale nomme comme nouvel administrateur Monsieur Jorge Manuel Amaral Penedo, économiste,
né le 7 août 1963 à Penamacor, Portugal, avec adresse professionnelle au 62, Rua de Sao Bernardo, 1249-092 Lisbonne,
Portugal.
Son mandat prendra fin en même temps que ceux des autres administrateurs c.-à-d. à l’issue de l’assemblée générale
annuelle devant se tenir en 2005.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale accepte la démission avec effet immédiat de Monsieur Erich Dähler de ses fonctions de Direc-
teur et la cessation des fonctions de Directeur de Monsieur Patrice Binder avec effet au 27 février 2004.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: A. Swetenham, A.-M. Charlier, S. Spinelli, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, vol. 20CS, fol. 64, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027775.3/230/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
LIFE CARE LUX., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 99.857.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the twenty-ninth day in the month of March.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
LIFE CARE HOLDING ApS, a company, governed by the laws of Denmark, established and having its registered office
at Rytterskolevej 7, Maarum, DK-3230 Græsted, registered with the Danish Commerce and Companies Agency under
CVR number 21161780,
duly represented by its managing director, Mr Teddy Bønchel Iversen, residing at Rytterskolevej 7, Maarum, DK-3230
Græsted, with individual signing power.
Such appearing party has drawn up the following articles of a limited liability company (société à responsabilité lim-
itée), which it intends to organise as sole partner or with any person who may become partner of this company in the
future.
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The corporation may carry out all trade of foodstuffs other than drugs. It may also carry out any transactions
pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the
administration, management, control and development of those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name LIFE CARE LUX., S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
Luxembourg, le 1
er
avril 2004.
A. Schwachtgen.
24941
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) represented
by one hundred (100) shares with a par value of one hundred twenty-five euros (125.- EUR) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
form a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers, unless otherwise defined by a extraordinary general meet-
ing of the partners.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-
ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January of each year and ends on the 31st of December
the same year.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the
Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The appearing party, represented as stated here above declares to subscribe for the one hundred (100) shares and
to have them fully paid-up by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (12,500.-
24942
EUR) is from now on at the disposal of the company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who
expressly states this.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year begins today and shall end on 31 December 2004.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies
of September 18, 1933 have been fulfilled.
<i>Costsi>
The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately one thousand five hundred euros.
<i>Resolutions of the sole associatei>
Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:
1.- The number of managers of the Company is set at two (2).
Are appointed managers of the company for an unlimited period, with the powers indicated in article twelve (12) of
the articles of incorporation:
a) Technical Manager:
Mr Henrik Lindtofte Christiansen, company director, born in Rødovre (Denmark), on 22 September 1965, residing
at Strandvesen 130.B., DK-2900 Hellerup.
b) Administrative Manager:
Mr Teddy Bønchel Iversen, company director, born in Copenhagen (Denmark), on 27 July 1944, residing at Rytter-
skolevej 7, Maarum, DK-3230 Græsted;
2.- The company is bound by the sole signature of the technical manager up to the amount of one thousand two
hundred and fifty euros (1,250.- EUR). Above this amount the joint signature of both managers is required.
3.- The address of the Company is fixed at 241 route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the
above appearing person, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the date indicated at the beginning thereof.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-neuvième jour du mois de mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
LIFE CARE HOLDING ApS, une société régie par les lois du Danemark, établie et ayant son siège social au Rytters-
kolevej 7, Maarum, DK-3230 Græsted, enregistrée auprès du «Danish Commerce and Companies Agency», sous CVR
numéro 21161780;
ici représentée par son directeur Monsieur Teddy Bønchel Iversen, demeurant au Rytterskolevej 7, Maarum, DK-
3230 Græsted, avec pouvoir de signature individuelle.
Laquelle partie comparante a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle va consti-
tuer en tant qu’associé unique ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de la société par la suite.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet le commerce de tous produits alimentaires à l’exclusion de tous médicaments. Elle
peut également effectuer toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: LIFE CARE LUX., S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
24943
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance, sauf si le(s) associé(s) devaient en décider autrement.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même
année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
La partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire les cent (100) parts sociales et les
avoir entièrement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-
24944
EUR) est dès à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été rapportée au notaire instrumentant, au moyen
d’un certificat bancaire.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commercial commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés à responsa-
bilité limitées (loi du 18.9.1933) se trouvent accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Et aussitôt, la partie comparante représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre de gérants est fixé à deux (2).
Sont nommés gérants de la Société pour une durée illimitée, avec les pouvoirs définis par l’article douze (12) des
statuts:
a) Gérant Technique:
Monsieur Henrik Lindtofte Christiansen, directeur de société, né à Rødovre (Danemark) le 22 septembre 1965, de-
meurant à Strandvesen 130.B. DK-2900 Hellerup.
b) Gérant Administratif:
Monsieur Teddy Bønchel Iversen, directeur de société, né à Copenhagen (Danemark), le 27 juillet 1944, demeurant
au Rytterskolevej 7, Maarum, DK-3230 Græsted.
2.- Le gérant technique peut engager la société par sa seule signature jusqu’au montant de mille deux cent cinquante
euros (1.250,- EUR). Au-delà de ce montant la signature conjointe des deux gérants sera requise.
3.- L’adresse de la Société est fixée au 241, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant sur la demande du
même comparant faire foi en cas de divergences avec la version française.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. B. Iversen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 mars 2004, vol. 883, fol. 87, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027513.3/239/249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
OVERSEAS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 63.865.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 16 mars 2004, enregistré à Grevenmacher, le 30 mars 2004, volume 526, folio 40, case 4;
I.- Que la société anonyme OVERSEAS INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des
Foyers, inscrite au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 63.865, a été cons-
tituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 8 avril 1998, publié au
Mémorial C numéro 641 du 25 juin 1998.
II.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est le seul et unique actionnaire de ladite société;
que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite
société.
III.- Que le livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société
dissoute.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027546.3/231/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
Belvaux, le 2 avril 2004.
J.-J. Wagner.
Junglinster, le 2 avril 2004.
J. Seckler.
24945
MainFirst, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.
H. R. Luxemburg B 89.173.
—
Im Jahre zweitausendundvier, am einunddreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg),
versammelten sich in Ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Gesellschaft MainFirst, eine Invest-
mentgesellschaft («société d’investissement à capital variable») mit Sitz in 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxemburg,
gegründet nach Luxemburger Recht, gemäss einer Urkunde aufgenommen durch den vorgenannten Notar Jean-Joseph
Wagner, am 26. September 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1538 vom 24. Oktober 2002 (hiernach «die
Gesellschaft»).
Die Gesellschaft ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg,
Sektion B unter der Nummer 89.173.
Die Satzung der Gesellschaft wurde seit ihrer Gründung nicht abgeändert.
Die Versammlung wird um 11.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Martin Emmerich, wohnhaft in Trier (Deutsch-
land), eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Catia Paciotti-Luchetti, wohnhaft in Schifflingen (Luxemburg).
Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Frau Stephanie Carl, wohnhaft in Trier (Deutschland).
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar
zu Protokoll genommen werden:
I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer
Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, dem Versammlungsbüro und
dem amtierenden Notar, aufgeführt.
Diese Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber bleiben gegenwärtiger Urkunde bei-
gefügt um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
II.- Die gegenwärtige Generalversammlung wurde einberufen durch Einladung mit der hiernach angegebenen Tages-
ordnung, und zwar:
- im Mémorial C Nummer 239 vom 28. Februar 2004 und Nummer 300 vom 16. März 2004;
- im «deutschen Bundesanzeiger», vom 28. Februar 2004 und vom 16. März 2004;
- in der Tageszeitung «Luxemburger Wort», vom 28. Februar 2004 und vom 16. März 2004;
- in der «Börsenzeitung», vom 28. Februar 2004 und vom 16. März 2004;
- in der Tageszeitung «Lëtzebuerger Journal», vom 28. Februar 2004 und vom 16. März 2004;
- im «Amtsblatt zur Wiener Zeitung», vom 1. März 2004 und vom 16. März 2004.
III.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Änderung der Satzung, insbesondere
- Anpassung an das Gesetz vom 20. Dezember 2002, insbesondere die Änderung der Artikel 4,5,18,21,24,25 und 32;
2.- Sonstiges.
IV.- Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den fünf Millionen neunhundertsechsundzwan-
zigtausend siebenhundertzweiundachtzig (5.926.782) sich im Umlauf befindenden Aktien, fünfunddreissigtausendzwei-
hundertsechs (35.206) Aktien auf gegenwärtiger Generalversammlung anwesend oder vertreten sind.
Der Vorsitzende teilt der Versammlung mit, dass eine erste ausserordentliche Generalversammlung mit der dersel-
ben Tagesordnung schon für den 25. Februar 2004 einberufen worden war und dass diese Generalversammlung nicht
beschlussfähig war, da die notwendige Anwesenheitsquote nicht erreicht wurde.
Gegenwärtige Generalversammlung ist nun gemäss Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-
delsgesellschaften beschlussfähig, gleich wie viele Aktien zugegen anwesend oder vertreten sind.
Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst die Artikel vier (4), einundzwanzig (21), vierundzwanzig (24)
und zweiunddreissig (32) der Gesellschaftsordnung abzuändern und zwar, durch Ersetzen des Gesetzeshinweises auf das
Gesetz vom 30. März 1988 durch den Hinweis auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst Artikel fünf(5) der Satzung abzuändern, um den im ersten Ab-
satz angegeben Betrag des Mindestkapitals auf eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- EUR) festzule-
gen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst Artikel achtzehn (18) der Satzung, betreffend der Anlagepo-
litik und Anlagebeschränkungen der Gesellschaft, abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu verleihen:
«Art. 18. Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen.
Der Verwaltungsrat ist befugt, auf der Grundlage des Prinzips der Risikostreuung, die Anlagepolitik, die für jeden Teil-
fonds der Gesellschaft zu beachtenden Anlagestrategien sowie die Richtlinien der Verwaltung und Geschäftsführung un-
ter Beachtung der in den geltenden Gesetzen und Vorschriften vorgesehenen oder vom Verwaltungsrat festgesetzten
Anlagebeschränkungen zu bestimmen.
24946
Dies vorausgesetzt kann der Verwaltungsrat bestimmen, dass sich die Anlagen der Gesellschaft in nachfolgend be-
schriebener Weise zusammensetzen aus:
(a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden und/
oder
(b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem anderen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union («EU») gehandelt werden, sofern dieser Markt anerkannt, für das Publikum offen und seine Funktionsweise ord-
nungsgemäss ist und/ oder
(c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates amtlich notiert oder
an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise
ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, sofern die Wahl dieser Wertpapierbörse oder dieses Marktes in der Satzung
der Gesellschaft vorgesehen ist und/oder
(d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemissionen, sofern:
- deren Ausgabebedingungen die Verpflichtung zu einer amtlichen Notiz an einer Wertpapierbörse oder zum Handel
auf einem anderen geregelten Markt gemäss vorstehend (b) und (c) enthalten
- sie spätestens ein Jahr nach Emission dort zum amtlichen Handel zugelassen werden und/oder
(e) Anteilen von nach der Richtlinie 85/611/EWG zugelassenen OGAW und/oder anderen Organismen für gemein-
same Anlagen im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 erster und zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 85/611/EWG mit Sitz
in einem Mitgliedstaat oder einem Drittstaat, sofern:
- diese anderen Organismen für gemeinsame Anlagen nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer Auf-
sicht unterstellen, welche nach Auffassung der CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und aus-
reichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht,
- das Schutzniveau der Anteilseigner der anderen Organismen für gemeinsame Anlagen dem Schutzniveau der An-
teilseigner eines OGAW gleichwertig ist und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des Sonder-
vermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 85/611/EWG gleichwertig sind,
- die Geschäftstätigkeit der anderen Organismen für gemeinsame Anlagen Gegenstand von Halbjahres- und Jahresbe-
richten ist, die es erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transak-
tionen im Berichtszeitraum zu bilden,
- der OGAW oder der anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, dessen Anteile erworben werden sollen, nach
seiner Satzung insgesamt 10% seines Sondervermögens in Anteilen anderer OGAW oder Organismen für gemeinsame
Anlagen anlegen darf und/oder
(f) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern das
betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der EU hat oder - falls der Sitz des Kreditinstituts sich in
einem Drittstaat befindet - es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denjenigen des Gemein-
schaftsrechts gleichwertig sind und/oder
(g) abgeleiteten Finanzinstrumenten («Derivaten»), einschliesslich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die
an einem der unter den Buchstaben a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkten gehandelt werden, und/oder abge-
leiteten Finanzinstrumenten die nicht an einer Wertpapierbörse gehandelt werden («OTC-Derivaten»), sofern
- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne des Artikel 41, Absatz 1, oder um Finanzindizes, Zinssätze,
Wechselkurse oder Währungen handelt, in die der OGAW gemäss den in seiner Satzung genannten Anlagezielen inve-
stieren darf,
- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind,
die von der CSSF zugelassen wurden, und
- und die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit
auf Initiative des OGAW zum angemessenen Zeitwert veräussert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt
werden können und/oder
(h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und die unter die Definition des
Artikels 1 des aktuellen Gesetzes fallen, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente bereits Vorschriften
über den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt, sie werden
- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats, der
Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, so-
fern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen Einrichtung öffentlichen-
rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert, oder
- von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter den Buchstaben a), b) und c) bezeichneten
geregelten Märkten gehandelt werden, oder
- von einem Institut, das gemäss den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder
einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der CSSF mindestens so streng sind wie die des Ge-
meinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, oder
- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der CSSF zugelassen wurde, sofern für
Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen des ersten, des zweiten oder des
dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit
einem Eigenkapital von mindestens 10,- Mio. EUR, das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der Richtlinie 78/
660/EWG erstellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere börsennotier-
te Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um einen
Rechtsträger handelt, der die wertpapiermässige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer
Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll.
24947
Die Anlage kann des weiteren in allen sonstigen Wertpapieren, Instrumenten oder sonstigen Vermögenswerten im
Rahmen der innerhalb der geltenden Gesetze und Vorschriften vom Verwaltungsrat bestimmten Anlagebeschränkungen
erfolgen.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst Artikel fünfundzwanzig (25) abzuändern, durch einfache
Streichung des zweiten und letzten Satzes.
Da keine weiteren Angelegenheiten der Versammlung vorliegen, wurde diese daraufhin um 11.30 Uhr geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: M. Emmerich, C. Paciotti-Luchetti, S. Carl, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 1. April 2004, Band 883, Blatt. 89, Feld 2. – Erhalten 12 Euros.
<i>Der Einnehmer ff.i> gezeichnet: Oehmen.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027529.2/239/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
MainFirst, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.173.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027530.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
ROTOMADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, Z.I. rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 96.695.
Constituée par-devant M
e
Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange, en date du 7 novembre 2003, acte publié
au Mémorial C n° 1274 du 3 décembre 2003, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 décembre 2003,
acte publié au Mémorial C n° 66 du 17 janvier 2004.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06596, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027500.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
L’ATELIER VERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 45.318.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
12 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, volume 142S, folio 95, case 4, que la société à responsabilité
limitée L’ATELIER VERT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1220 Luxembourg, 50, rue de Beggen, a été dissoute avec
effet au 1
er
janvier 2004, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans
à l’ancien siège de la société.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(027603.3/227/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
Beles, den 1. April 2004.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 1
er
avril 2004.
J.-J. Wagner.
<i>Pour ROTOMADE, S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Luxembourg, le 25 mars 2004.
E. Schlesser.
24948
MARTIN LOSCH S.à r.l. ESCH-SUR-ALZETTE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 75, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 8.929.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027429.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
CYBER VISION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 19.650.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 2 avril 2004, réf. DSO-AP00009, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 5 avril 2004.
(027552.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
CYBER VISION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 19.650.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 2 avril 2004, réf. DSO-AP00010, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 5 avril 2004.
(027553.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
STEPAREX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.215.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06572, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027689.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
SACOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.183.
—
Par décision prise par l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 27 février 2004:
Mr Johannes Marinus Kat est démis de sa fonction d’administrateur de la société.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. avec siège social sis au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxem-
bourg est nommée à la fonction de commissaire aux comptes de la société en remplacement de TRIUNE CONSUL-
TING S.A.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06012. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027752.3/536/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
Luxembourg, le 31 mars 2004.
P. Frieders.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
Strassen, le 6 avril 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>L’agent domiciliataire
i>Signatures
24949
ABX LOGISTICS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 2, rue de l’Etang, Z.I. Weihergewann.
R. C. Luxembourg B 68.068.
—
L’an deux mille quatre, le cinq mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ABX LOGISTICS (FRANCE) S.A., société anonyme de droit français, avec siège social 18, Place de la Gare à F-59100
Roubaix,
représentée par Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oetrange, en vertu d’une procuration
sous seing privé du 23 février 2004, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le no-
taire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter:
1) Qu’il est l’associé unique de la société à responsabilité limitée ABX LOGISTICS (LUXEMBOURG), S.à r.l., dont il
détient l’intégralité des parts sociales.
2) Que la société ABX LOGISTICS (LUXEMBOURG), S.à r.l., inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous la section B, numéro 68.068, a été constituée sous la dénomination de DUBOIS LOGISTICS SERVI-
CES, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 décembre 1998, publié au Mémorial C, numéro
222 du 31 mars 1999 et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentaire, en date du
14 septembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 211 du 20 mars 2001, en date du 5 décembre 2000, publié par extrait
au Mémorial C, numéro 552 du 20 juillet 2001 et en date du 8 mars 2002, publié au Mémorial C, numéro 904 du 13 juin
2002.
3) Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
4) Que l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a décidé de pas renouveler le mandat de gérant
de Monsieur Antoine Bricout, Directeur Division Logistique, demeurant à 795, Domaine de la Vigne, F-59910 Bondues,
dont le mandat est venu à expiration et de nommer Monsieur Jacques Caillé, Directeur Général de la Société-tête de
groupe ABX LOGISTICS (FRANCE), demeurant à 8, rue Robert Arnaud d’Andilly, F-78470 Magny les Hameaux, en qua-
lité de nouveau gérant de la société ABX LOGISTICS (LUXEMBOURG), S.à r.l., à compter de ce jour pour une durée
qui viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2004, avec pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N.Thoma, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, vol. 142S, fol. 85, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(027452.3/212/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
SOMATEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 93.940.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1) MATEC, S.à r.l., avec siège social à L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent, inscrite au Registre de Commerce à
Luxembourg sous le numéro B 50.586,
Ici représentée par son gérant, Monsieur Pierre Tholl, demeurant à Bereldange,
2) Monsieur Pierre Tholl, administrateur de sociétés, demeurant à L-7214 Bereldange, 29, rue Bellevue.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques actionnaires de la société SOMATEC S.A., avec siège
social à L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous la section B et le numéro 93.940, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 3 juin 2003,
publié au Mémorial C numéro 739 du 11 juillet 2003.
Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et en conséquence modifie le premier alinéa de l’article 4
des statuts comme suit:
Art. 4. La société a pour objet:
* la mécanique d’avions;
Luxembourg, le 30 mars 2004.
P. Frieders.
24950
* l’agence commerciale à l’exclusion de toute vente en gros et en détail;
* la prestation de services administratifs à l’exclusion de toutes activités rentrant dans les professions d’expert-comp-
table et de conseil économique;
* la réalisation d’opérations de gérance de la société AVITEC, S.à r.l.;
Le reste de l’article demeurant inchangé.
<i> Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de sept cents euros (700,- EUR.).
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède aux comparants, tous connus du notaire ins-
trumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Tholl, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, vol. 20CS, fol. 62, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027484.3/202/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
SOMATEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 93.940.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027485.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
NSR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 30.031.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 22 mars 2004 que:
- Monsieur Josef Dorig, Employé de commerce, demeurant à Alte Wolleraustr. 49, CH-8832 Wollerau,
- Monsieur Johannes Matt, Employé de commerce, demeurant à Egertaweg 152, FL-9491 Ruggell,
- Madame Claude Von Hildebrand, Employée de commerce, demeurant à Avenue de Thônex 17, CH-1226 Thônex,
ont été réélus Administrateurs pour une durée de 6 ans jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes annuels au 31
décembre 2009.
Et que:
- FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 25, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg,
a été réélue Commissaire aux Comptes pour la même période.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04935. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027747.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
ITCIM, IT CONSULTING AND INVESTMENT MANAGEMENT, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 93.956.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00438, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027701.3/578/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
Senningerberg, le 30 mars 2004.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 30 mars 2004.
P. Bettingen.
Pour extrait conforme
Signature
Strassen, le 6 avril 2004.
Signature.
24951
ALLMAT LOCATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4934 Hautcharage, 23, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 53.238.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06577, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hautcharage, le 9 avril 2004.
(027555.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
ALLMAT LOCATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4934 Hautcharage, 23, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 53.238.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06580, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hautcharage, le 9 mars 2004.
(027557.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
DR. OETKER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1341 Luxembourg, 7, place Clairefontaine.
R. C. Luxembourg B 5.701.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00462, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027699.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
BRITTANY PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 99.901.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1) Monsieur Patrick Sganzerla, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1840 Luxembourg, 11B, bou-
levard Joseph II; et
2) La société à responsabilité limitée G & P PROPERTIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11B,
boulevard Joseph II, R. C. Luxembourg B 82.889,
ici représentée par Monsieur Patrick Sganzerla, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 17 mars 2004.
Cette procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant ès qualités qu’il agit et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Ces comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de BRITTANY PARTNERS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
A. Haeck
<i>Administrateur-déléguéi>
A. Haeck
<i>Administrateur-déléguéi>
Strassen, le 6 avril 2004.
Signature.
24952
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente, la mise en valeur, la gestion ainsi que la location d’immeubles bâtis
ou à bâtir.
La société a également pour objet la conception et la gestion d’établissements hôteliers et/ou de restauration sous
quelque forme que ce soit.
En outre elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute
société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes
opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
Elle pourra gager ses biens ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, si cette opération
est de nature à favoriser son développement.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature
mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité
ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Exceptionnellement le premier
administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’admi-
nistrateur-délégué, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un commissaire nommé par l’assemblée générale qui fixe sa rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le 1
er
lundi du mois de juin de chaque année à 11.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
24953
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le ou les
commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire au commissaire.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
quatre.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille cinq.
<i>Souscriptioni>
Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) chacune par des versements en espèces,
de sorte que la somme de sept mille sept cents cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros (EUR
1.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité les réso-
lutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Patrick Sganzerla, expert-comptable, né le 28 mars 1968 à Toulon (France), demeurant professionnelle-
ment au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Monsieur Steeve Simonetti, employé privé, né le 30 janvier 1980 à Thionville (France), demeurant professionnelle-
ment au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Monsieur Guy Frisch, gérant de société, né le 2 juillet 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 5,
rue Jules Fischer, L-1522 Luxembourg.
3.- Est nommé administrateur-délégué Monsieur Patrick Sganzerla, préqualifié.
Son mandat d’administrateur-délégué expirera en même temps que celui d’administrateur.
4.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
- La société DALEY STRATEGIES S.A., ayant son siège social à Jasmin Court, 35A, Regent Street, P.O. Box 1777,
Belize City.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale des
actionnaires statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2004.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
1) par Monsieur Patrick Sganzerla, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2) par la société G & P PROPERTIES, S.à r.l., préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
24954
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue de lui connue, donnée au comparant, agissant ès-
dites qualités, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte
avec Nous, notaire.
Signé: P. Sganzerla, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, vol. 143S, fol. 1, case 5. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(027814.3/222/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
VISSERHUIS V 94 SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1927 Luxembourg, 20, rue Lemire.
R. C. Luxembourg E 92.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-six mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
1) Monsieur le Dr Luc Jean Julien Weydert, docteur en médecine, né le 1
er
octobre 1934 à Luxembourg, et son épou-
se Madame Anne-Marie, dite Annemie Speck, sans état particulier, née à Luxembourg, le 30 mars 1938, demeurant en-
semble à L-1927 Luxembourg, 20, rue Lemire,
mariés sous le régime de la communauté universelle suivant modification de leur contrat de mariage par-devant le
notaire instrumentaire en date du 27 août 1996.
2) Madame Anne Weydert, laborantine, née le 17 mars 1963 à CH Lucerne, demeurant à L-5410 Beyren, 5, rue Bierg-
haff,
ici représentée par Monsieur Luc Weydert, préqualifié,
en vertu d’une cession de parts avec procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 mars 2004.
3) Madame Simone Weydert, employée privée, née le 22 mai 1964 à CH St. Gall, demeurant à L-5335 Moutfort, 16,
Soibelwee,
ici représentée par Monsieur Luc Weydert, préqualifié,
en vertu d’une cession de parts avec procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 mars 2004.
4) Madame Martine Weydert, employée privée, née le 22 mai 1964 à CH St. Gall, demeurant à L-4243 Esch-sur-Al-
zette, 104, rue J.P. Michels,
ici représentée par Monsieur Luc Weydert, préqualifié,
en vertu d’une cession de parts avec procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 mars 2004.
5) Madame Antoinette Weydert, employée privée, née le 24 mai 1966 à CH Olten, demeurant à L-1278 Luxembourg,
4, rue Toni Bourg,
ici représentée par Monsieur Luc Weydert, préqualifié,
en vertu d’une cession de parts avec procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 mars 2004.
6) Madame Michelle Weydert, céramiste, née le 19 février 1969 à Luxembourg, demeurant à L-6162 Bourglinster, 8,
rue du Château,
ici représentée par Monsieur Luc Weydert, préqualifié,
en vertu d’une cession de parts avec procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 mars 2004.
Lesquelles cessions de parts avec procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumen-
taire demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Les comparants sont les seuls sociétaires de la société civile immobilière familiale VISSERHUIS V 94 S.C.I., ayant son
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 juin 2003, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 729 du 10 juillet 2003.
Les statuts de ladite société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 janvier
2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
- Le fonds social est représenté par quatre mille neuf cents (4.900) parts d’intérêt d’une valeur nominale de vingt-cinq
(25,-) euros chacune.
II.
1) Par cession de parts avec procuration, prémentionnée, Monsieur le Dr Luc Jean Julien Weydert et son épouse
Madame Anne-Marie, dite Annemie Speck, préqualifiés, ici présents, ont cédé dix-huit (18) parts sociales qu’ils possé-
daient dans la société à Madame Anne Weydert, préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant et ce acceptant par
son mandataire pour un prix de quatre cent cinquante (450,-) euros, ce dont quittance.
2) Par cession de parts avec procuration, prémentionnée, Monsieur le Dr Luc Jean Julien Weydert et son épouse
Madame Anne-Marie, dite Annemie Speck, préqualifiés, ici présents, ont cédé dix-huit (18) parts sociales qu’ils possé-
daient dans la société à Madame Simone Weydert, préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant et ce acceptant par
son mandataire pour un prix de quatre cent cinquante (450,-) euros, ce dont quittance.
Luxembourg-Bonnevoie, le 29 mars 2004.
T. Metzler.
24955
3) Par cession de parts avec procuration, prémentionnée, Monsieur le Dr Luc Jean Julien Weydert et son épouse
Madame Anne-Marie, dite Annemie Speck, préqualifiés, ici présents, ont cédé dix-huit (18) parts sociales qu’ils possé-
daient dans la société à Madame Martine Weydert, préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant et ce acceptant par
son mandataire pour un prix de quatre cent cinquante (450,-) euros, ce dont quittance.
4) Par cession de parts avec procuration, prémentionnée, Monsieur le Dr Luc Jean Julien Weydert et son épouse
Madame Anne-Marie, dite Annemie Speck, préqualifiés, ici présents, ont cédé dix-huit (18) parts sociales qu’ils possé-
daient dans la société à Madame Antoinette Weydert, préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant et ce acceptant
par son mandataire pour un prix de quatre cent cinquante (450,-) euros, ce dont quittance.
5) Par cession de parts avec procuration, prémentionnée, Monsieur le Dr Luc Jean Julien Weydert et son épouse
Madame Anne-Marie, dite Annemie Speck, préqualifiés, ici présents, ont cédé dix-huit (18) parts sociales qu’ils possé-
daient dans la société à Madame Michelle Weydert, préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant et ce acceptant par
son mandataire pour un prix de quatre cent cinquante (450,-) euros, ce dont quittance.
- Ces cessions ont été effectuées de l’accord de tous les sociétaires et, pour autant que de besoin, acceptées pour la
Société par son gérant Monsieur le Dr Luc Jean Julien Weydert, préqualifié.
III. Suite aux cessions qui précèdent, la répartition des parts sociales est désormais la suivante et l’article 5 des statuts
est modifié en conséquence:
Art. 5. Il existe quatre mille neuf cents (4.900) parts d’intérêt d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros cha-
cune attribuées comme suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport:
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ils ont signé avec Nous no-
taire la présente minute.
Signé: L. J. J. Weydert, A-M. Speck, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, vol. 20CS, fol. 68, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027777.3/230/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
VISSERHUIS V 94 SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1927 Luxembourg, 20, rue Lemire.
R. C. Luxembourg E 92.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n° 335 du 26 mars 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027778.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
GENERAL O & R INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 56.738.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00686, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027744.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
1) Monsieur Dr Luc Weydert, et son épouse Madame Annemie Speck, préqualifiés, quatre mille huit cents
parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.800
2) Madame Anne Weydert, préqualifiée, vingt parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3) Madame Simone Weydert, préqualifiée, vingt parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4) Madame Martine Weydert, préqualifiée, vingt parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
5) Madame Antoinette Weydert, préqualifiée, vingt parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
6) Madame Michelle Weydert, préqualifiée, vingt parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Total: quatre mille neuf cents parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.900
Luxembourg, le 1
er
avril 2004.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
FIRELUX S.A.
Signature
24956
BAUDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.540.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06603, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027718.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
BAUDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.540.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06603, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027720.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
FINILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 18, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 96.846.
—
L’an deux mille quatre, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand- Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1) la société anonyme de droit belge EUROPLEX, ayant son siège social au 25, rue de Waroux, B-4000 Liège,
ici représentée par Monsieur Francis Dessard, comptable, demeurant au 61, rue Marexhe, B-4040 Herstal,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Liège, le 13 janvier 2004.
2) la société anonyme de droit belge LOCAPARK, ayant son siège social au 2, rue Tony Ross, B-4053 Chaudfontaine/
Embourg,
ici représentée par Monsieur Francis Dessard, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Liège, le 13 janvier 2004.
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l’enre-
gistrement.
Lesquels comparantes, agissant en leur qualité de seules et uniques associées de la société à responsabilité limitée
FINILUX, S.à r.l., ayant son siège social à Wiltz, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 96.846, constitué suivant acte notarié en date du 2 août 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 60 du 21 février 1992 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en
date du 29 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1068 du 12 juillet 2002, pren-
nent la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Les associées décident de transférer le siège social de la Société de L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers à L-1913
Luxembourg, 18, rue Léandre Lacroix.
En conséquence, l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
« Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre associés.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le mandataire des comparants a signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte.
Signé: F. Dessard, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 2004, vol. 883, fol. 10, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027515.3/239/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
Luxembourg, le 1
er
avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
avril 2004.
Signature.
Belvaux, le 11 février 2004.
J.-J. Wagner.
24957
FINILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 18, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 96.846.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027517.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
T.S.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 247, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.166.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2003i>
Le lundi 5 mai 2003 à 11.00 heures, les actionnaires de T.S.D. S.A. ont tenu une Assemblée Générale Extraordinaire
au siège social sis route d’Arlon 247 à L-1150 Luxembourg.
Une feuille de présence est émargée par les actionnaires à leur entrée en séance.
Monsieur Louis Dethier, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-4950 Waimes, est élu Président de
l’assemblée.
Monsieur Kurt Mertes, administrateur, demeurant à B-4770 Born, est appelé comme scrutateur.
D’accord entre le président et le scrutateur, Monsieur Pierre Archambeau, administrateur, demeurant à B-4950 Thi-
rimont, est appelé à remplir le rôle de secrétaire.
Le bureau constate de la feuille de présence que tous les actionnaires, propriétaires de l’intégralité des actions qui
jouissent du même nombre de voix, sont présents ou représentés.
Tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoins, à toute
publicité.
La feuille de présence est alors arrêtée ne varietur, signée des membres du bureau et annexée au présent procès-
verbal.
Le président met à la disposition de l’assemblée:
1) les statuts;
2) la feuille de présence.
Chaque actionnaire se désiste autant que de dû de tout droit ou action né ou à naître du fait de l’absence de convo-
cation.
L’assemblée peut donc décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite, le président rappelle que les questions suivantes sont portées à l’ordre du jour
1) révocation du commissaire en fonction;
2) nomination d’un nouveau commissaire aux comptes pour l’exercice 2002 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
de l’année 2003.
Le président met aux voix les résolutions suivantes découlant de l’ordre du jour:
I. Monsieur Herbert März, commerçant, demeurant à L-9991 Weiswampach, route de Stavelot 117, est révoqué avec
effet immédiat de son mandat de commissaire. Il lui est donné pleine et entière décharge pour son mandat passé.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
II. FN-SERVICES, S.à r.I., société à responsabilité limitée avec siège social à L-9991 Weiswampach, route de Stavelot
144, est nommée avec effet immédiat comme commissaire aux comptes pour l’exercice 2002 jusqu’à l’assemblée géné-
rale ordinaire de l’année 2003.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Puis, plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11.30 heures
et de tout ce que dessus, le présent procès-verbal est dressé et signé des membres du bureau.
Enregistré à Diekirch, le 17 février 2004, réf. DSO-AN00131. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(027519.3/667/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
T.S.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 247, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.166.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juillet 2003i>
Le lundi, 7 juillet 2003 à 10.00 heures, les actionnaires de T.S.D. S.A. ont tenu l’Assemblée Générale Ordinaire An-
nuelle au siège social sis à L-1150 Luxembourg, route d’Arlon 247.
Une feuille de présence est émargée par les actionnaires à leur entrée en séance.
Monsieur Louis Dethier, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-4950 Waimes, est élu Président de
l’assemblée.
Monsieur Kurt Mertes, administrateur, demeurant à B-4770 Born est appelé comme scrutateur.
Belvaux, le 31 mars 2004.
J.-J. Wagner.
L. Dethier / K. Mertes / P. Archambeau
<i>Le Président / le scrutateur / le secrétairei>
24958
D’accord entre le président et le scrutateur, Monsieur Pierre Archambeau, administrateur, demeurant à B-4950 Thi-
rimont, est appelé à remplir le rôle de secrétaire.
Le bureau constate de la feuille de présence que tous les actionnaires, propriétaires de l’intégralité des actions qui
jouissent du même nombre de voix, sont présent ou représentés.
Tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute
publicité.
La feuille de présence est alors arrêtée ne varietur, signée des membres du bureau et annexée au présent procès-
verbal.
Le président met à la disposition de l’assemblée:
1) les statuts;
2) la feuille de présence;
3) le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2002;
4) le rapport du Conseil d’Administration;
5) le rapport du Commissaire aux comptes.
Chaque actionnaire se désiste autant que de dû de tout droit ou action né ou à naître du fait de l’absence de convo-
cation.
Ensuite, le président rappelle que les questions suivantes sont portés à l’ordre du jour:
1) Lecture des comptes arrêtés au 31 décembre 2002;
2) Lecture du rapport du Conseil d’Administration concernant l’exercice social 2002;
3) Lecture du rapport du Commissaire aux comptes concernant les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.
4) Approbation des comptes;
5) Affectation du résultat;
6) Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
7) Renouvellement des mandats du Conseil d’Administration et du commissaire;
8) Divers.
Puis, le président demande au secrétaire de lire les comptes arrêtés au 31 décembre 2002, le rapport du Conseil
d’Administration et le rapport du Commissaire aux comptes.
Le secrétaire en donne lecture.
Le président ouvre alors les débats.
Divers propos sont échangés entre les membres, puis, plus personne ne demandant la parole, le président met aux
voix les résolutions suivantes découlant de l’ordre du jour
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale ordinaire annuelle, après avoir pris connaissance des comptes arrêtés au 31 décembre 2002,
du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes tels que
présentés.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale ordinaire annuelle décide d’affecter comme suit le bénéfice de 2.421,07 EUR de l’exercice
2002:
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale ordinaire annuelle donne décharge aux administrateurs pour leur gestion au cours de l’exer-
cice écoulé ainsi qu’au Commissaire aux comptes pour son mandat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle décide à l’unanimité de renouveler les mandats des administrateurs et du
commissaire jusqu’à l’Assemblée Générale de l’année 2009. Il s’agit de:
- Monsieur Louis Dethier, ingénieur, demeurant à B-4950 Waimes, Président du Conseil d’Administration et gérant
technique;
- Monsieur Kurt Mertes, employé technique, demeurant à B-4770 Born, administrateur;
- Monsieur Pierre Archambeau, employé d’administration, demeurant à B-4950 Thirimont, administrateur.
- FN SERVICES, S.à r.l., L-9991 Weiswampach, commissaire.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
- Bénéfice de l’exercice à affecter (+):. . . . . . . . . . .
2.421,07 EUR
- Perte de l’exercice à affecter (-):. . . . . . . . . . . . . .
0,00 EUR
- Bénéfice reporté de l’exercice précédent (+): . .
9.724,56 EUR
- Perte reportée de l’exercice précédent (-): . . . . .
0,00 EUR
- Bénéfice à affecter (=): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.145,63 EUR
- Perte à affecter (=): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00 EUR
- Affectation à la réserve légale (-): . . . . . . . . . . . .
0,00 EUR
- Affectation aux autres réserves (-): . . . . . . . . . . .
0,00 EUR
- Distribution de bénéfice (-): . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00 EUR
- Bénéfice à reporter (=): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.145,63 EUR
- Perte à reporter (=): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00 EUR
24959
Puis, plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11.00 heures
et de tout ce que dessus, le présent procès-verbal est dressé et signé des membres du bureau.
Enregistré à Diekirch, le 17 février 2004, réf. DSO-AN00130. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(027432.3/667/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
RIMM TECHNOLOGIES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 78.878.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le dix mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société RIMM TECHNOLOGIES HOLDING CORP., établie et ayant
son siège social à c/o Mossack Fonseca Co., Ltd. Akara Building, 24 De Castro Street, Wickams Cay 1, Road Town,
Tortola, Iles Vierges Britanniques, IBC no 345879, qui est représentée par deux de ses directeurs, à savoir:
Monsieur Michael John Olorenshaw Sutherland, Company Director, demeurant à Plateau de Frontenex 9C, CH-
1280 Genève et Monsieur Barry Kenneth Stamps, Managing Director, demeurant à Chemin du Tilleul 19, B-1380 Ohain,
en vertu d’une procuration donnée à Genève, en date du 26 février 2004,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société anonyme RIMM TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été cons-
tituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 16 novembre 2000,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 396 du 30 mai 2001;
- que le capital social de la société anonyme RIMM TECHNOLOGIES HOLDING S.A. s’élève actuellement à quatre-
vingt-neuf mille quatre cent trente-quatre Euros (89.434,- EUR) représenté par quarante-quatre mille sept cent dix-sept
(44.717) actions d’une valeur nominale de deux Euros (2,- EUR) chacune, entièrement libérées;
- que la société RIMM TECHNOLOGIES HOLDING CORP., étant devenue seule propriétaire des actions dont
s’agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme RIMM TECHNOLOGIES HOLDING S.A., celle-ci ayant
cessé toute activité;
- que la société RIMM TECHNOLOGIES HOLDING CORP., agissant en sa qualité de liquidateur de la société RIMM
TECHNOLOGIES HOLDING S.A., déclare:
* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
* que tous les passifs connus de la société, vis-à-vis des tiers, ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés,
* par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer ir-
révocablement l’obligation de les payer;
de sorte que la liquidation de la société anonyme RIMM TECHNOLOGIES HOLDING S.A. est à considérer comme
clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice
de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la
société à c/o Mossack Fonseca Co. Ltd, Akara Building, 24 De Castro Street, Wickams Cay 1, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Mamane, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, vol. 20CS, fol. 51, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027601.3/220/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
L. Dethier / K. Mertes / P. Archambeau
<i>Le président / le scrutateur / le secrétairei>
Luxembourg, le 26 mars 2004.
G. Lecuit.
24960
LABATTE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 70.854.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06333, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2004.
(027587.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
LABATTE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 70.854.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06331, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2004.
(027586.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
LABATTE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 70.854.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06329, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2004.
(027585.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
LABATTE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 70.854.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06326, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2004.
(027584.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Editions Lëtzeburger Journal S.A.
Didel Holding S.A.
B.C.S.I., Business Controls & Services International S.A.
Serfid
Volga-Dnepr Airlines, Luxembourg Branch
Volga-Dnepr Airlines, Luxembourg Branch
Eurocapital Holdings, S.à r.l.
Blicon S.A.
Blicon S.A.
S.C.I. Pilolux
S.C.I. Pilolux
Eagle Bay
Eagle Bay
ESFIL - Espirito Santo Financière S.A.
Life Care Lux., S.à r.l.
Overseas Investments S.A.
MainFirst
MainFirst
Rotomade, S.à r.l.
L’Atelier Vert, S.à r.l.
Martin Losch, S.à r.l. Esch-sur-Alzette
Cyber Vision Holding S.A.
Cyber Vision Holding S.A.
Steparex, S.à r.l.
Sacofin S.A.
ABX Logistics (Luxembourg), S.à r.l.
Somatec S.A.
Somatec S.A.
NSR Holding S.A.
ITCIM, IT Consulting and Investment Management, S.à r.l.
Allmat Locations S.A.
Allmat Locations S.A.
Dr. Oetker S.A.
Brittany Partners S.A.
Visserhuis V 94 SCI
Visserhuis V 94 SCI
General O & R International S.A.
Baudes S.A.
Baudes S.A.
Finilux, S.à r.l.
Finilux, S.à r.l.
T.S.D. S.A.
T.S.D. S.A.
Rimm Technologies Holding S.A.
Labatte Immobilière S.A.
Labatte Immobilière S.A.
Labatte Immobilière S.A.
Labatte Immobilière S.A.