This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
26449
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 552
21 mai 2003
S O M M A I R E
A Bis Z Promotions S.A., Belvaux . . . . . . . . . . . . . .
26473
Laboratoire Dentaire Hornbeck Jacques, S.à r.l.,
Alice Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26491
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26494
Aline Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26496
Lazare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26495
BHW Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26485
Luxding Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26491
Brussels City Properties S.A.H., Luxembourg . . . .
26485
Master-Finance S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . .
26481
Brussels City Properties S.A.H., Luxembourg . . . .
26485
Menuiserie Majoie Michel S.A., Steinfort . . . . . . . .
26494
Bureau Modugno, S.à r.l., Bergem . . . . . . . . . . . . . .
26473
Munich Invest, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
26484
Business Time Center, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
26460
Outremer Investments S.A., Hesperange . . . . . . .
26458
Business Time Center, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
26462
Panorama, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26482
Caron International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
26467
Panorama, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26483
Cassis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26484
Parsiflor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26479
CESD-Communautaire, Luxembourg . . . . . . . . . . .
26466
Passing Shot S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
26479
Charisma Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . .
26474
PEH Sicav, Luxemburg-Strassen. . . . . . . . . . . . . . .
26459
Citifunds Investment Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26450
Pente Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26495
Coyote Software, S.à r.l., Dalheim . . . . . . . . . . . . . .
26460
Phitex S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26475
Dharma Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26475
Rabo Management Services, S.à r.l., Luxembourg
26495
Dharma Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26479
Rabobank Corporate Services Luxembourg S.A.,
Dumatin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26460
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26496
Fiduciaire Launach S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26496
Rakham Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
26484
Finalourec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26468
Recherche et Développement Européen Holding
Financière du Glacis S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
26486
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26496
Financière du Glacis S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
26486
Sarlat S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26483
Financière du Glacis S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
26486
SBS Broadcasting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26484
Forum pour l’Europe de l’Ouest Princesse Ana-
Sigma Capital Hospitality, Leisure and Tourism
stasia Romanov, A.s.b.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
26462
Holding Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
26487
G.D. Group Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
26463
Sigma Capital Hospitality, Leisure and Tourism
G.D. Group Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
26466
Holding Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
26490
Gargano S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26468
Socepal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26483
Gypsum 2001 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26492
Sodevim S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
26482
HCD Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26473
Spanimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26479
HCD Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26491
Specialty Materials Investors, S.à r.l., Luxem-
Heip Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
26463
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26480
Hines Holdings Luxembourg 1, S.à r.l., Luxem-
Tilburg International S.A., Hesperange . . . . . . . . .
26459
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26495
Tilburg International S.A., Hesperange . . . . . . . . .
26459
IB Management Services S.A., Luxembourg . . . . . .
26494
TMD International Holding S.A., Luxemburg . . . .
26480
Insinger de Beaufort (Luxembourg) S.A., Luxem-
Tuttogratis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26481
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26492
Werkfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26490
J.P. Morgan Multi-Manager Strategies Fund, Sicav,
World Holding Company S.A., Luxembourg. . . . .
26450
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26491
Yerania S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26468
Kapla World S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26474
Zamasport Distribution S.A., Luxembourg . . . . . .
26485
26450
WORLD HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 19.844.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01074, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020253.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2003.
CitiFunds INVESTMENT SERIES, Fonds Commun de Placement.
R. C. Luxembourg B 38.087.
—
These Management Regulations of CitiFunds INVESTMENT SERIES, a mutual investment fund with multiple compart-
ments («fonds commun de placement à compartiments multiples»), organized under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and any future amendments thereto made in compliance with Article 16 below, shall determine the con-
tractual relationship between:
1) the management company CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., a joint stock com-
pany having its registered office in Luxembourg (hereinafter called the «Management Company»),
2) the custodian CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH), a branch of CITIBANK INTER-
NATIONAL PLC, London with its office in Luxembourg at 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-
bourg (hereinafter called the «Custodian») and
3) the subscribers and holders of shares (the «Units») in CitiFunds INVESTMENT SERIES (hereinafter called the
«Unitholders») who shall accept these Management Regulations by the acquisition of such Units.
Art. 1. The Fund
CitiFunds INVESTMENT SERIES (hereinafter called the «Fund») is an open-ended mutual investment fund under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg. The Fund is an unincorporated co-proprietorship of Unitholders of the secu-
rities and other assets of the Fund subject to the provisions of these Management Regulations. It shall be managed in
the interest of the Unitholders by the Management Company. The Fund’s assets shall be held by the Custodian Bank
and are segregated from those of the Management Company.
The Fund’s assets may be segregated in various pools of assets (hereafter a «Sub-Fund»), whereby each Sub-Fund may
issue one or more classes of Units as set forth in Article 4 hereafter.
For the purpose of efficient management, the management of all or part of the assets of a SubFund may be pooled or
co-managed as set forth in article 6 hereafter.
Art. 2. The Management Company
The Fund shall be managed on behalf of the Unitholders by the Management Company, which has its registered office
in Luxembourg.
The Management Company is vested with extensive powers, within the limitations set forth in Article 5 below, to
manage the Fund on behalf of the Unitholders; in particular it shall be entitled to buy, sell, subscribe for, exchange and
receive any securities, and to exercise all the rights directly or indirectly connected with the assets of the Fund.
The Board of Directors of the Management Company shall determine the investment policy of the Fund in accord-
ance with the limitations set out in Article 5 below.
The Board of Directors may appoint managers, advisers, officers and/or administrative agents to implement the in-
vestment policy and the management of the assets of the Fund. It may further for the benefit of the Fund obtain infor-
mation services, investment advice and other services.
The Management Company and any appointed investment manage(s)/adviser(s) («Investment Manager(s) / Advis-
er(s)») shall be entitled to management and advisory fees described in Article 13 hereafter.
Art. 3. The Custodian Bank
The Custodian Bank shall be appointed by the Management Company. CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEM-
BOURG BRANCH), a branch of CITIBANK INTERNATIONAL PLC, London organised under UK law with its office in
Luxembourg, has been appointed Custodian Bank.
Either the Management Company or the Custodian Bank may terminate this appointment at any time in writing upon
ninety days’ prior notice. The Management Company may however only terminate the functions of the Custodian Bank
if a new custodian assumes the functions and responsibilities of the Custodian Bank as laid down in these Management
Regulations. After the termination of its appointment, the Custodian Bank shall continue to carry out its functions as
shall be necessary for the transfer of all the assets of the Fund to the new custodian bank.
In the event of the resignation of the Custodian Bank, the Management Company shall within two months appoint a
new custodian bank to take over the functions and responsibilities of the Custodian Bank in accordance with these Man-
agement Regulations. In this case the duties of the Custodian Bank shall continue until all the assets of the Fund shall
have been transferred to the new custodian bank.
The Fund’s assets, including securities as well as cash and all other assets, shall be held by the Custodian Bank on
behalf of the Unitholders of the Fund or under its supervision. With the approval of the Management Company, the
Custodian Bank may entrust banks and financial institutions with the safe custody of securities. The Custodian Bank may
hold securities in fungible accounts with clearing institutions selected by the Custodian Bank with the consent of the
Luxembourg, le 8 mai 2003.
Signature.
26451
Management Company. The Custodian Bank shall carry out the usual duties of a bank in respect of accounts and deposits
of securities. The Custodian Bank may only dispose of the Fund’s assets or make payments to third parties on behalf of
the Fund upon receipt of instruction from the Management Company and within the scope of these Management Reg-
ulations.
The Custodian Bank shall be entitled to a custodian bank fee out of the assets of the Fund at rates customarily charged
by banks for such services and agreed upon with the Management Company. This fee shall be calculated as a percentage
on the average asset value of the Fund. The Custodian further shall be entitled to repayment of fees and expenses of its
correspondents, who are involved in the safekeeping of assets of the Fund.
Art. 4. The Units
The Management Company may create within the Fund several separate pools of assets (each a «Sub-Fund»). Each
Sub-Fund consists of assets which are held separately from the assets attributable to other Sub-Funds and invested sep-
arately in accordance with the investment policy fixed for a Sub-Fund in accordance with Article 5 of these Management
Regulations.
In respect of each Sub-Fund investments shall be made in accordance with specific investment guidelines to be deter-
mined by the Management Company in respect of each SubFund.
The Management Company may decide to issue, within each Sub-Fund, two or more classes of Units (the «Classes»)
whose assets will be commonly invested but where specific fee structure, investment minimum, hedging policy or other
distinct feature may be applied to each Class.
For the purpose of determining the total net assets of the Fund, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if
not expressed in United States Dollars, be converted into United States Dollars. The Management Company may how-
ever calculate the net asset value per Unit of each Sub-Fund or Class in other currencies.
The Units of the Fund shall be issued and redeemed by the Management Company pursuant to Article 7 hereafter at
prices based on the respective net asset values determined in accordance with Article 10 of these Management Regu-
lations.
Art. 5. Investment Policy
The Management Company shall invest the proceeds paid into the Fund for joint account of Unitholders in transfer-
able securities and other assets permitted by law in conformity with the principle of risk spreading. In this context the
Management Company shall specify the investment guidelines for each Sub-Fund as set forth in the Fund’s offering mem-
orandum (the «Explanatory Memorandum»).
The Management Company shall alone be entitled to fix the date of issue of any further SubFunds of Units and to fix
their investment policy.
If it appears advisable at any time to retain ancillary liquid assets in the Fund, such assets may temporarily be kept in
money market instruments issued or guaranteed by highly rated borrowers having a remaining maturity of less than 12
months or in current or deposit accounts.
Subject to the provisions of the Investment Restrictions, the Management Company can make use of various deriva-
tive instruments to hedge the Sub-Funds against market and currency risks, as well as to enhance returns in accordance
with the principles of prudent and efficient portfolio management.
Investment Restrictions
In making investments on behalf of the Fund, the Management Company shall comply with the following safeguards:
1) The Management Company may not, on behalf of a Sub-Fund, invest in securities of any one issuer, if the value of
the holdings of a Sub-Fund in the securities of such issuer exceeds 10% of such Sub-Fund’s total net assets, except that
such restriction shall not apply to securities issued or guaranteed by Member States of The Organisation for Economic
Cooperation and Development («OECD») or their local authorities or public international bodies with European Union
(«EU»), regional or world-wide scope.
2) The Management Company may not invest, on behalf of any Sub-Fund, in securities of any single issuer if, as a result
of such investment, the Fund owns more than 10% of any class of securities issued by any single issuer. The Management
Company may not purchase securities of any company or other body if, upon such purchase, the Fund, together with
other investment funds managed by the Management Company, would own more than 15% of any class of the securities
of such company or body. This restriction shall not apply to securities issued or guaranteed by member States of the
OECD or their local authorities or public international bodies with EU, regional or world-wide scope.
3) The Management Company may not make investments for the purpose of exercising control or management.
4) The Management Company may invest up to 10% of the net assets of each Sub-Fund in shares or units of other
collective investment funds. The acquisition of shares or units in a collective investment fund managed by the same Man-
agement Company or by any other company with which the Management Company is linked by common management
or control or by substantial direct or indirect holding shall be permitted only if the Management Company and any In-
vestment Managers/Advisers appointed by it, do not charge any fee or cost on account of transactions in connection
with such shares or units.
5) The Management Company may not purchase, on behalf of a Sub-Fund, real estate except that it may purchase and
sell, on behalf of the Sub-Fund, securities that are secured by real estate or interests therein or issued by companies
which invest in real estate or interests therein.
6) The Management Company may not, on behalf of a Sub-Fund, enter into transactions involving commodities, com-
modity contracts or securities representing merchandise or rights to merchandise and for the purposes hereof com-
modities includes precious metals, except that it may purchase and sell, on behalf of a Sub-Fund, securities that are
secured by commodities and securities of companies which invest or deal in commodities.
26452
7) The Management Company may not, on behalf of a Sub-Fund, borrow other than borrowings which in the aggre-
gate do not exceed 10% of the total net assets of such Sub-Fund, which borrowings may, however, only be made on a
temporary basis.
8) The Management Company may not, on behalf of a Sub-Fund, invest more than 10% of the net assets of such Sub-
Fund in securities which are not traded on an official stock exchange or other regulated market, except that such re-
striction shall not apply to securities issued or guaranteed by Member States of the OECD or their local authorities or
public international bodies with EU, regional or world-wide scope; provided however that this restriction shall not apply
to money market instruments which are traded regularly.
9) The Management Company may not use the assets of a Sub-Fund to underwrite or sub underwrite any securities.
10) The Management Company, on behalf of a Sub-Fund, may not grant loans to or act as guarantor in favour of third
parties.
11) The Management Company, acting on behalf of the Sub-Funds, shall not sell, purchase or loan securities, or re-
ceive loans, to or from (a) the Management Company (b) its affiliated companies (c) any director of the Management
Company or its affiliated companies or (d) any major shareholder thereof (meaning a shareholder who holds, on his
own account.whether in his own or other name (as well as a nominee’s name), 10% or more of the total issued out-
standing shares of such a company) acting as principal or for their own account unless the transaction is made within
the restrictions set forth here above, and, either (i) at a price determined by current publicly available quotations, or
(ii) at competitive prices or interest rates prevailing from time to time, on internationally recognised securities markets
or internationally recognised money markets.
12) Within the following limits and within the investment guidelines determined in respect of each Sub-Fund, the Man-
agement Company may on behalf of the Fund employ techniques and instruments relating to transferable securities as
well as instruments intended to provide protection against exchange risks:
(a) Options on securities
It may deal in options on securities, options on stock indices and on other financial instruments, as well as in financial
futures only if such options and futures are traded on a recognised exchange or a regulated market which operates reg-
ularly and is recognised and open to the public.
It may write put options on securities provided it maintains during the lifetime of such options adequate liquid re-
serves in order to cover the full exercise prices payable in respect of the securities to be purchased upon exercise of
such options.
It may write call options on securities provided such options are covered by assets within the Sub-Fund concerned.
In such event the corresponding assets are to be maintained within such Sub-Fund until the exercise date of the options
concerned, except if a sale thereof appears advisable in the context of decreasing markets and provided the liquidity of
the market is sufficient to ensure immediate cover of any open position. In this case the aggregate exercise price of all
uncovered options shall not exceed 25% of the net assets of the relevant Sub-Fund.
It may acquire call and put options on securities provided that the aggregate acquisition prices (in terms of premiums
paid) of all options on securities and such options that are acquired for purposes other than hedging shall not exceed
15% of the net assets of the relevant Sub-Fund.
(b) Futures and Options on indices, interest rates and other financial instruments
It may enter into index futures or interest rate futures contracts or purchase or write options thereon, including:
i) the acquisition of put options or the writing of call options and the entering into futures sales contracts all for hedg-
ing purposes, provided the value of the underlying securities included in such futures sales contracts does not exceed,
together with the underlying securities comprised in options on stock indices or on other financial instruments pur-
chased and/or sold for the same purpose, the market value of the assets to be hedged and provided further that in con-
nection with interest rate futures contracts or options thereon, currency risks shall be avoided, and
ii) the purchase and writing of options on stock indices and other financial instruments and the entering into futures
sales and/or purchase contracts for purposes other than hedging, provided the aggregate commitments in connection
with such purchase and sale transactions together with the amount of the commitments relating to the writing of call
and put options on securities and currencies for purposes other than hedging do not exceed the net assets of the Sub-
Fund concerned.
With respect to options referred to under a) and b) above, the Management Company may enter into over-the-coun-
ter option transactions with first class financial institutions participating in this type of transactions if such transactions
are more advantageous to the Fund, or if quoted options having the required features are not available. It may further
enter into interest swap transactions with highly rated financial institutions.
(c) Currency management and hedging transactions
In order to manage foreign exchange risks and enhance returns through the use of active currency positions, a Sub-
Fund may, if and to the extent permitted by the Explanatory Memorandum, have outstanding commitments in currency
futures and/or hold currency options provided such futures and options are dealt in on a regulated market, or enter
into currency forward contracts or currency swaps with highly rated financial institutions.
In order to hedge foreign exchange risks a Sub-Fund may have outstanding commitments in currency futures and/or
hold currency options provided such futures and options are dealt in on a regulated market, or enter into currency
forward contracts or currency swaps with highly rated financial institutions. It may further for hedging purposes enter
into interest swap transactions with highly rated financial institutions, whereby currency risks shall be avoided. The cur-
rency transactions described herein shall only be entered into for hedging purposes and not for speculative purposes.
The hedging objective of the transactions referred to above presupposes the existence of a direct relationship between
the contemplated transaction and the assets or liabilities to be hedged and implies that, in principle, transactions in a
given currency (including currencies bearing a substantial relation to such given currency) may not exceed the total val-
26453
uation of such assets and liabilities nor may they, as regards their duration, exceed the period during which such assets
are held or anticipated to be acquired or for which such liabilities are incurred or anticipated to be incurred. Cross
currency hedging transactions will only be utilised when there is no market for transacting in the currency, concerned
or when it is uneconomical to do.
13) The Management Company shall not lend portfolio securities of the Fund except against adequate security
blocked in the favour of the Fund either in the form of guarantees issued by highly rated banking institutions or in the
form of a pledge on cash or debt securities issued by Member States of the OECD. The value of such security, at the
conclusion of the lending agreement, must be at least equal to the value of the global valuation of the securities lent. No
securities lending may be made except through recognised clearing houses or highly rated financial institutions special-
ising in this type of transaction and for more than one half of the aggregate market value of securities held by each Sub-
Fund and for periods exceeding 30 days.
The Management Company need not comply with the investment limit percentages above when exercising subscrip-
tion rights attaching to securities which form part of the assets of a specific Sub-Fund.
If such percentages are exceeded for reasons beyond the control of the Management Company or as a result of the
exercise of subscription rights, the Management Company must adopt as a priority objective for its sales transactions
the remedying of that situation, taking due account of the interests of the Unitholders.
Art. 6. Pooling and Co-Management
I) Pooling
The Management Company may invest and manage all or any part of the portfolio of assets established for two or
more Sub-Funds (for the purposes hereof «Participating Sub-Funds») on a pooled basis. Any such asset pool shall be
formed by transferring to it cash or other assets (subject to such assets being appropriate in respect to the investment
policy of the pool concerned) from each of the Participating Sub-Funds. Thereafter, the Management Company may
from time to time make further transfers to each asset pool. Assets may also be transferred back to a Participating Sub-
Fund up to the amount of the participation of the Sub-Fund concerned. The share of a Participating Sub-Fund in an asset
pool shall be measured by reference to notional units of equal value in the asset pool. On formation of an asset pool,
the Management Company shall, in their discretion, determine the initial value of notional units (which shall be ex-
pressed in such currency as the Management Company consider appropriate) and shall allocate to each Participating
Sub-Fund notional units having an aggregate value equal to the amount of cash (or to the value of other assets) contrib-
uted. Thereafter, the value of the unit shall be determined by dividing the net asset value of the asset pool by the number
of notional units subsisting.
When additional cash or assets are contributed to or withdrawn from an asset pool, the allocation of notional units
of the Participating Sub-Fund concerned will be increased or reduced, as the case may be, by a number of notional units
determined by dividing the amount of cash or the value of assets contributed or withdrawn by the current value of a
unit. Where a contribution is made in cash, it will be treated for the purpose of this calculation as reduced by an amount
which the Management Company consider appropriate to reflect fiscal charges and dealing and purchase costs which
may be incurred in investing the cash concerned; in the case of cash withdrawal, a corresponding deduction will be made
to reflect costs which may be incurred in realising securities or other assets of the asset pool.
Dividends, interest and other distributions of an income nature earned in respect of the assets in an asset pool will
be applied to the asset pool and cause the respective net assets to increase. Upon the dissolution of the Fund, the assets
in an asset pool will (subject to the claims of creditors) be allocated to the Participating Sub-Funds in proportion to their
respective participation in the asset pool.
II) Co-Management
In order to reduce operational and administrative charges, while allowing a wider diversification of the investments,
the Management Company may decide that part or all of the assets of one or several Sub-Funds will be co-managed with
assets attributable to other Sub-Funds or assets belonging to other Luxembourg collective investment schemes. In the
following paragraphs, the word «co-managed entities» shall refer globally to the Fund and each of its Sub-Funds and all
entities with and between which there would exist any given comanagement arrangement and the words «co-managed
assets» shall refer to the entire assets of these co-managed entities and co-managed pursuant to the same co-manage-
ment arrangement.
Under the co-management arrangement, the Investment Managers will be entitled to take, on a consolidated basis
for the relevant co-managed entities, investment, disinvestment and portfolio readjustment decisions which will influ-
ence the composition of the assets of the Sub-Funds. Each co-managed entity shall hold a portion of the co-managed
assets corresponding to the proportion of its net assets to the total value of the co-managed assets. This proportional
holding shall be applicable to each and every line of investment held or acquired under co-management. In case of in-
vestment and/or disinvestment decisions, these proportions shall not be affected and additional investments shall be al-
lotted to the comanaged entities pursuant to the same proportion and assets sold shall be levied proportionally on the
co-managed assets held by each co-managed entity.
In case of new subscriptions in one of the co-managed entities, the subscription proceeds shall be allotted to the co-
managed entities pursuant to the modified proportions resulting from the next asset increase of the co-managed entity
which has benefited from the subscriptions and all lines of investment shall be modified by a transfer of assets from one
co-managed entity to the other in order to be adjusted to the modified proportions. In an similar manner, in case of
repurchases in one of the co-managed entities, the cash required may be levied on the cash held by the co-managed
entities pursuant to the modified proportions resulting from the net asset reduction of the co-managed entity which has
suffered from the repurchases and, in such case, all lines of investment shall be adjusted to the modified proportions.
Unitholders should be aware that, in the absence of any specific action by the Management Company or its appointed
agents, the co-management arrangements may cause the composition of assets of the Sub-Funds to be influenced by
26454
events attributable to other co-managed entities such as subscriptions and repurchases. Thus, all things being equal, sub-
scriptions received in one entity with which a Sub-Fund is co-managed will lead to an increase of such Sub-Fund’s reserve
of cash. Conversely, repurchases made in one entity with which a Sub-Fund is comanaged will lead to a reduction of
such Sub-Fund’s reserve of cash. Subscriptions and repurchases may however be kept in the specific account opened
for each co-managed entity outside the co-management arrangement and through which subscriptions and repurchases
must pass. The possibility to allocate substantial subscriptions and repurchases to these specific accounts together with
the possibility for the Management Company or its appointed agents to decide at any time to terminate the co-manage-
ment arrangement permit the Management Company to avoid the readjustments of the assets of its Sub-Funds if these
readjustments are likely to affect the interest of the Management Company or the Fund and its Unitholders.
If a modification of the composition of the Fund or one or several of Sub-Funds’ assets resulting from repurchases or
payments of charges and expenses peculiar to another comanaged entities (i.e. not attributable to the Fund or the Sub-
Fund concerned) is likely to result in a breach of the applicable investment restrictions, the relevant assets shall be ex-
cluded from the co-management arrangement before the implementation of the modification in order for it not to be
affected by the ensuing adjustments.
Co-managed assets shall only be co-managed with assets intended to be invested pursuant to investment objectives
identical to those applicable to the co-managed assets in order to ensure that investments decision are fully compatible
with the investment policy of the Sub-Funds. Co-managed assets shall only be co-managed with assets for which the
Custodian is also acting as depository in order to ensure that the Custodian is able, with respect to the Fund or Sub-
Funds, to fully carry out its functions and responsibilities pursuant to the law of March 30th 1988 on undertakings for
collective investment. The Custodian shall at all times keep the Fund’s assets segregated from the assets of other co-
managed entities and shall therefore be able at all times to identify the assets of the Fund and of each Sub-Fund. Since
co-managed entities may have investment policies, which are not strictly identical to the investment policy of a Sub-Fund,
it is possible that, as a result, the common policy implemented may be more restrictive than that of that Sub-Fund.
The Management Company may decide at any time and without notice, to terminate the comanagement arrangement.
Unitholders may at all times contact the Administrator in Luxembourg to be informed of the percentage of assets
which are co-managed and of the entities with which there is such a comanagement arrangement at the time of their
request. Annual and semi-annual reports shall state the co-managed assets’ composition and percentages.
Art. 7. Issue of Units in the Fund
The Units shall be issued by the Management Company after acceptance of the subscription application by the Fund.
The Management Company shall comply with the laws and regulations of the countries in which the Units are offered.
The Management Company may, at any time and at its discretion, suspend or limit the issue of Units temporarily or
permanently in particular countries or areas. The Management Company may exclude certain individuals or corporate
bodies the purchase of Units when this appears to be necessary to protect the Unitholders and the Fund as a whole.
Moreover, the Management Company may:
a) reject at its discretion subscription applications, in whole or in part; and
b) redeem Units in the Fund held by Unitholders who are excluded from acquiring or holding such Units.
The offer price per Unit shall be based on the net asset value per Unit for the relevant SubFund or Class on the ap-
plicable Valuation Date and may be rounded up or down to the nearest currency unit as determined by the Management
Company. Any issue taxes incurred shall be charged in addition. A sales or subscription charge may be added, not ex-
ceeding five percent of the net asset value which shall be payable to the relevant Sub-Fund or to the Management Com-
pany or to intermediaries involved in the distribution of the Units. The Management Company may on any Valuation
Date differentiate between applicants allowing to persons applying for larger numbers of Units than others a discount
or discounts on the amount of the sales charge to be included (within the permitted limit) in the offer price of the Units
issued to them on such basis or such scale as the Management Company may think fit. Payment for Units issued must
be received (in the reference currency of the Sub-Fund or Class concerned or an equivalent amount in any other cur-
rency as the Management Company may from time to time decide) within seven bank business days in Luxembourg (or
such shorter time limit as the Management Company may from time to time decide) following the determination of the
offer price.
Art. 8. Switching between Classes of Units
Any Unitholder may switch whole or part of his Units of any Sub-Fund or Class («Original Sub-Fund») into Units of
another Sub-Fund or Class («New Sub-Fund») at the respective issue and repurchase prices of the Units of the relevant
Sub-Fund or Class to be exchanged, provided that the Management Company may impose such restrictions as to, inter
alia, frequency of switching, may make switching subject to payment of such charge to be payable to the Management
Company, as it shall determine and may impose restrictions with regard to switching between different Sub-Funds and
or Classes. At the discretion of the Management Company, Unitholders may also switch Units of one Class of a Sub-
Fund (in which case the expression «Original Sub-Fund» shall also apply to this situation) into Units of another Class in
the same Sub-Fund («New Sub-Fund»). A switching fee, not exceeding 1% of net asset value, may be payable if so decided
from time to time by the Management Company.
Art. 9. Unit Certificates, Confirmations of holding
All individuals and corporate bodies, subject to the provisions of Article 7 of these Management Regulations, shall be
entitled to acquire an interest in the Fund by subscribing for one or more Units. In respect of each Sub-Fund or Class,
certificates will be issued in registered form or Unitholders will receive a written confirmation of holding. Unit certifi-
cates (if any) shall bear the signature of the Management Company and the Custodian Bank, both of which may be by
facsimile.
26455
The Management Company may fix, from time to time, minimum holdings in respect of each Sub-Fund or Class. Frac-
tions of Units may be issued.
The Management Company may split or consolidate the Units in the interest of the Unitholders.
Art. 10. Net asset value
The net asset value per Unit shall be expressed in such currency or currencies as the Management Company shall
from time to time determine in respect of each Sub-Fund or Class and shall be computed with respect to the Units of
each Sub-Fund or Class by the Management Company under the supervision of the Custodian Bank at least once a
month on dates specified in the current Explanatory Memorandum («a Valuation Date»). For such purpose the net as-
sets of the Fund to be allocated to each Sub-Fund or Class will be divided by the number of Units of the relevant Sub-
Fund or Class outstanding.
The Management Company shall establish a portfolio of assets in the following manner:
a) the issue price which shall be received upon issue of Units connected with a specific Sub-Fund shall be attributed
in the accounts of the Fund to such Sub-Fund. Assets and liabilities of that Sub-Fund as well as income and expenses
which are related to a specific Sub-Fund, shall be attributed to it taking into account the following provisions;
b) An asset derived from another asset will be applied to the same Sub-Fund as the asset from which it was derived.
On each revaluation of an asset the increase or decrease in value shall be applied to the Sub-Fund concerned;
c) if the Fund incurs liability of any kind in connection with an asset attributable to a Sub-Fund, then such liability shall
be attributed to the same Sub-Fund;
d) if an asset or liability cannot be attributed to any Sub-Fund, then such asset or liability shall be allocated to all the
Sub-Funds prorata to the respective net asset values of the Sub-Funds;
e) upon a distribution to holders of Units of a specific Sub-Fund or Class or upon a payment of expenses on behalf
of holders of Units of a specific Sub-Fund or Class, the proportion of the total net assets attributable to such Sub-Fund
or Class shall be reduced by the amount of the distribution or of such expenses.
If there have been created within the same Sub-Fund two or more Classes, the allocation rules set out above shall
apply, mutatis mutandis, for the purpose of establishing the portfolio of assets related to each such Class.
The valuation of the assets and liabilities of the Fund among the different Sub-Funds is relevant for the respective
relationships between the Unitholders holding units of the SubFunds or Classes concerned, the Management Company
and the Custodian and does not affect rights which third parties may legally have vis-à-vis the Fund, which constitutes
one single collective investment scheme in connection with obligations to be allocated to one or more of the Unit Sub-
Funds.
The assets of the Fund will be valued as follows:
(a) securities listed on a stock exchange will be valued at the last available price. If a security is listed on several stock
exchanges, the last available sales price at the stock exchange which constitutes the main market for such securities, will
be prevailing; for securities, for which trading on the relevant stock exchange is thin and secondary market trading is
done between dealers who, as main market makers, offer prices in response to market conditions, the Management
Company may decide to value such securities in line with the prices so established; fixed income securities are valued
on basis of the latest available middle price on the relevant stock exchange or the middle prices of last available quotes
from market makers which constitute the main market for such securities;
(b) securities dealt in on a regulated market shall be valued in a manner similar to listed securities;
(c) securities which are neither listed on any stock exchange nor dealt in on a regulated market will be valued at their
last available market price; if there is no such market price, they will be valued. in good faith by the Management Com-
pany in accordance with such prudent valuation rules as the Management Company may determine and on the basis of
the reasonable foreseeable sales prices;
(d) liquid assets be valued at their face value with interest accrued;
(e) for short term instruments with maturities of less than 90 days, the value of the instrument based on the net
acquisition cost, is gradually adjusted to the repurchase price thereof while the investment return calculated on the net
acquisition cost is kept constant. In the event of material changes in market conditions, the valuation basis of the invest-
ment is adjusted to the new market yields.
All other short term instruments are valued on the basis of the applicable market rates.
(f) assets denominated in a currency other than that in which the net asset value will be expressed, will be converted
at the latest available middle market rate. In that context account shall be taken of hedging instruments used to cover
foreign exchange risks.
In varying its policies in respect of each Sub-Fund, the Management Company may apply different rules of valuation if
this appears to be appropriate in the light of the investments made, provided that one set of rules shall be applied to
the valuation of all assets allocated to a specific Sub-Fund.
The Management Company is entitled to deviate from the valuation rules set out in (a), (b) and (c) above in valuing
the assets attributable to any given Sub-Fund by adding to the prices referred to in (a), (b) and (c) above an amount
reflecting the estimated cost of the acquisition of corresponding assets in the event the Management Company expects
further investments to be made on behalf of such Sub-Fund, or by deducting from the prices referred to in (a), (b) and
(c) above an amount reflecting the estimated cost of the disposal of such assets, in the event the Management Company
expects investments attributable to such Sub-Fund to be sold.
In the event of it being impossible or incorrect to carry out a valuation in accordance with the above rules owing to
particular circumstances, the Management Company is entitled to use other generally recognised valuation principles,
which can be examined by an auditor, in order to reach a proper valuation of the assets of the Fund.
In exceptional circumstances several valuations may be made on the same day, the second being valid for subsequent
issues or repurchase of Units.
26456
Art. 11. Suspension of the calculation of the net asset value and of the issue, repurchase and switching
of Units
The Management Company may temporarily suspend calculation of the net asset value per Unit of a given Sub-Fund
and hence the issue, repurchase, and switching of Units in each such Sub-Fund when:
a) a market which is the basis for the valuation of a major part of the assets attributable to the relevant Sub-Fund is
closed, or when trading on such a market is limited or suspended;
b) a political, economic, military, monetary or other emergency beyond the control, liability and influence of the Man-
agement Company makes the disposal of the assets of any Sub-Fund impossible under normal conditions or such dis-
posal would be detrimental to the interests of the Unitholders;
c) the disruption of the communications network or any other reason makes it impossible to determine the value of
a major portion of the assets of any Sub-Fund;
d) owing to the limitations on the exchange transactions or other transfers of assets, the business transactions be-
come impracticable in respect of any Sub-Fund, or where it can be objectively demonstrated that purchases and sales
of the assets of any SubFund cannot be effected at normal prices.
If Units of different Sub-Funds are in issue, a suspension with respect to any particular SubFund will have no effect on
the calculation of net asset value, the issue, repurchase and switching of the Units of any other Sub-Funds if such other
Sub-Funds are not affected by such events.
Art. 12. Repurchases
Unitholders may request repurchase of their Units at least once a month on Valuation Dates to be specified by the
Management Company. Units shall be redeemed on the basis of the applicable net asset value per Unit on the applicable
Valuation Date. Such repurchase price per Unit may be rounded to the nearest unit of the relevant currency as the
Management Company shall determine. Upon decision of the Management Company a repurchase charge of up to one
per cent may be deducted from the applicable net asset value per Unit. A contingent deferred sales charge (CDSC)
payable to intermediaries may also be applied to some classes.
The Management Company must ensure that sufficient liquid funds are available in the Fund’s assets of each Sub-Fund,
if different, so that payment for the repurchase of Units can, in normal conditions, be effected (in the reference currency
of the Sub-Fund or Class concerned or an equivalent amount in any other currency as the Management Company may
from time to time decide) within seven bank business days in Luxembourg counting from and including the relevant Val-
uation Date unless there are any specific statutory provisions such as foreign exchange restrictions, or any circumstanc-
es beyond the Custodian Bank’s control which make it impossible to transfer the repurchase proceeds to the country
where the repurchase was requested.
In case of a significant volume of repurchase requests for any given Valuation Date, the Management Company may
decide that part or all such requests for repurchase be deferred until the corresponding assets have been sold.
If the Management Company becomes aware that any Units are owned directly or indirectly by any person in breach
of any law or requirement of a country or governmental or regulatory authority, or otherwise in the circumstances
referred to in Article 7 of these Management Regulations, the Management Company may require the repurchase of
such Units.
Art. 13. Expenses of the Fund
The Fund shall bear the following expenses:
- annual management fees payable to the Management Company, any Investment Manager(s)/Adviser(s), intermedi-
aries and the agent company in Japan which, in aggregate, may not exceed 3% of the net assets of a Sub-Fund;
- custodian fees in accordance with usual practice in Luxembourg. Such fee is based on the total net assets of each
sub-fund and is payable monthly. Any reasonable disbursements and out-of pocket expenses (including without limita-
tion telephone, telex, cable and postage expenses) incurred by the Custodian, and any custody charges of banks and
financial institutions to which custody of assets of a sub-fund is entrusted, all charges and expenses incurred in relation
to the registration of any investments into and the transfer of any investments out of the name of the Custodian, shall
be borne by such sub-fund;
- the Luxembourg taxe d’abonnement and all other taxes which may be payable on the assets, income and expenses
chargeable to the Fund;
- standard brokerage and transaction charges incurred by the Fund’s business transactions;
- the fees and expenses of the Administrator for acting as registrar and transfer agent, administrative agent and dom-
iciliary agent;
- fees and expenses of the Directors of the Management Company;
- fees of agents in places of registration of the Fund and of any paying agents;
- the costs, including that of legal advice, which may be payable by the Management Company or the Custodian for
actions taken in the interests of the Unitholders;
- the fees and expenses incurred in connection with the registration of the Fund with, or the approval or recognition
of the Fund by, the competent authorities in any country or territory and all fees and expenses incurred in connection
with maintaining any such registration, approval or recognition;
- the fees and expenses incurred in connection with the listing of the Units on any stock exchange and all fees and
expenses incurred in connection with maintaining any such listing;
- the cost of preparing, filing and publishing the Management Regulations and other documents in respect of the Fund,
including notifications for registration, prospectuses or memoranda for all governmental authorities and stock exchang-
es (including local securities dealers’ associations) which are required in connection with the Fund or with offering the
Units of the Fund;
26457
- the cost of printing and distributing yearly and semi-annual reports for the Unitholders in all required languages,
together with the cost of printing and distributing all other reports and documents which are required by the relevant
legislation or regulations;
- the cost of bookkeeping and computation of the daily Net Asset Value per Unit, the cost of notifications to Unithold-
ers;
- the fees of the Fund’s auditors and legal advisors, and all other similar administrative expenses;
- legal, audit and other reasonable expenses incurred in the selection and appointment of investment advisors;
- all taxes of any description, payable in respect of the holding of or dealing with income from assets of the Fund or
any Sub-Fund and in respect of allocation and distribution of income to Unitholders;
- membership fees to professional or industry associations and organisations;
- the fees of Rating Agencies.
All recurring fees shall first be deducted from the investment income, then from realized capital gains, and then from
the assets. Other expenses may be written off over a period not exceeding 5 years.
Art. 14. Business year, Auditing
The accounting year of the Fund shall end on 31st December of each year.
The Fund and its accounts shall be audited by an auditor to be appointed by the Management Company.
Art. 15. Distributions
Within the limits set forth by law, the Management Company shall decide once per year or more frequently whether
distributions shall be made to the holder of any Sub-Fund or Class, and in what amount. Distributions so declared (if
any) shall be paid without delay following declaration.
Entitlement to dividends and allocations not claimed within 5 years of the due date shall be forfeited and the corre-
sponding assets shall revert to the specific pool of assets concerned.
Art. 16. Amendments to these Management Regulations
The Management Company may amend these Management Regulations in full or in part at any time with the agree-
ment of the Custodian Bank.
Amendments shall come into force five days after their publication in the Luxembourg «Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations».
Art. 17. Announcements
The latest net asset value per Unit of each Sub-Fund or Class and the issue and repurchase prices per Unit shall be
made public at the address of the Fund in Luxembourg on every bank business day in Luxembourg.
The annual report, which shall be published within 4 months following the close of the accounting year, and all semi-
annual reports of the Fund, shall be made available to Unitholders at the offices of the Fund, the Custodian Bank and all
paying agencies.
The dissolution of the Fund shall be published in the Luxembourg «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations»
and in three other newspapers, including one Luxembourg daily newspaper.
Amendments to the Management Regulations and notices to Unitholders, including notices about the suspension of
the calculation of the net asset value and of the repurchase of Units, shall, if required, be published in the newspapers
of countries where Units are offered and sold.
Art. 18. Duration of the Fund, Liquidation of the Fund; Termination of Sub-Fund or Class, Merger of
the Sub-Funds and Classes
Duration of the Fund
There is no limit to the duration of the Fund. The Fund may, however, be liquidated, any SubFund may be terminated
or merged and a Class of Units may be terminated in the following circumstances:
Liquidation of the Fund
a) The decision to liquidate the Fund will be taken by mutual agreement of the Management Company and the Cus-
todian Bank. The Management Company may, in particular, decide such liquidation where the Net Asset Value of the
Fund has decreased to an amount equal to or less than that determined by the Management Company, from time to
time, to be the minimum Net Asset Value for the Fund to be operated in an efficient manner, or in case of a significant
change in the economic, social or political situation or for any other reasons deemed by the Management Company to
be in the best interest of the Unitholders. No Units of the Fund will be issued after the date of such decision. Redemp-
tion and conversion of the Units remain possible if the equal treatment of the Unitholders is safeguarded. Prior notice
of the liquidation shall be given to Unitholders concerned as deemed appropriate by the Management Company or re-
quired in any relevant jurisdiction where the Fund is distributed. During the period leading up to the liquidation of the
Fund, the redemption price will reflect all estimated expenses and costs relating to the liquidation.
b) The Fund shall be liquidated in any of the other cases provided for by Article 21 of the law of 30 March 1988
relating to collective investment undertakings. The aforementioned provisions of the law provides, among other things,
for the liquidation of the Fund in the event of the bankruptcy of the Management Company or of the Custodian Bank,
in the event that Custodian Bank’s or the Management Company’s respective appointment is terminated or their license
withdrawn, if they are not replaced within two months. As soon as the event that gives rise to liquidation occurs, no
Units will be issued. Notice of the liquidation shall be given without delay by the Management Company or the Custodian
Bank.
The notice of liquidation of the Fund will be published in the «Mémorial» (Official Gazette) and in at least three news-
papers with appropriate distribution to be determined by the Management Company and the Custodian Bank, one of
which at least should be a Luxembourg newspaper.
26458
Termination of any Sub-Fund or any Class of Units
The decision to terminate any Sub-Fund or any Class will be taken by mutual agreement of the Management Company
and the Custodian Bank. The Management Company may, in particular, decide such termination where the Net Asset
Value of the Sub-Fund or Class has decreased to an amount equal to or less than that determined by the Management
Company, from time to time, to be the minimum Net Asset Value for the Sub-Fund or Class to be operated in an effi-
cient manner, or in case of a significant change in the economic, social or political situation or for any other reasons
deemed by the Management Company to be in the best interest of the Unitholders. No Units of the Sub-Fund or Class,
as the case may be, will be issued after the date of such decision. Redemption and conversion of the Units remain pos-
sible if the equal treatment of the Unitholders is safeguarded. Prior notice of the termination shall be given to Unithold-
ers concerned as deemed appropriate by the Management Company or required in any relevant jurisdiction where the
Sub-Fund or Class of Units is distributed in accordance with Announcements (see Article 17 above). During the period
leading to the termination of the Sub-Fund or Class of Units, the redemption price will reflect all estimated expenses
and costs relating to the termination.
The net liquidation or termination proceeds of the Fund or Sub-Fund or Class, as the case may be, will be distributed
to Unitholders in proportion to their respective holdings in the Fund or Sub-Fund or Class as at the date of liquidation
or termination in accordance with the law of March 30, 1988. Liquidation or termination proceeds which are not
claimed by, or cannot be distributed to, Unitholders shall be deposited at the close of liquidation or termination with
the Luxembourg Consignments Office (Caisse des Consignation) for a period of 30 years.
Merger of Sub-Funds or Classes
The Management Company, with the approval of the Custodian Bank, may decide to merge two or more Sub-Funds
or Classes of the Fund as well as merge one or more Sub-Funds or Classes of the Fund into another Luxembourg un-
dertaking for collective investment regulated by Part II of the Luxembourg law of 30 March 1988 where the Net Asset
Value of any SubFund or Class has decreased to an amount equal to or less than that determined by the Management
Company, from time to time, to be the minimum Net Asset Value for such SubFund or Class to be operated in an effi-
cient manner, or in case of a significant change in the economic, social or political situation, or to promote operational
or management efficiencies, or for any other reasons deemed by the Management Company to be in the best interest
of the Unitholders. Prior notice will be given to Unitholders of the Sub-Fund or Class being merged in accordance with
Announcements (see Article 17 above). Unitholders not wishing to participate in the merger may request the redemp-
tion of their respective Units during a period of at least one month following publication of the Notice. The redemption
shall be effected free of redemption charges (other than the CDSC applicable to Class B Units), at the applicable Net
Asset Value determined on the day such instructions are deemed to have been received.
Art. 19. Prescription
Unitholders’ claims against the Management Company or the Custodian Bank shall cease to be valid 5 years after the
date of the occurrence giving rise to the claim.
Art. 20. Applicable Law, Jurisdiction and Binding Languages
The District Court of Luxembourg shall have jurisdiction over any disputes between the Unitholders, the Manage-
ment Company, the Unitholders thereof and the Custodian Bank, and Luxembourg law shall apply. The Management
Company and/or the Custodian Bank may nevertheless submit themselves and the Fund to the jurisdiction of the coun-
tries in which the Units are offered and sold, in respect of claims by investors from such countries.
The English-language version of these Management Regulations shall be binding; the Management Company and the
Custodian Bank may nevertheless accept the use of translations approved by them into the languages of countries in
which Fund Units are offered and sold and these shall be binding in respect of such Units sold to investors in those
countries.
These amended Management Regulations are effective as from 27 May, 2003
Luxembourg, April 23, 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01796. – Reçu 56 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(020828.2//561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.
OUTREMER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 78.755.
—
Le bilan au 15 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE01816, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021352.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Noted and accepted
CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT / CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
Signature / Signature
Luxembourg, le 13 mai 2003.
Signature.
26459
PEH SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 61.128.
—
Die Bilanz zum 31. Dezember 2002 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002 wurden einre-
gistriert in Luxemburg am 12. Mai 2003, Ref. LSO-AE02022, und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg
am 13. Mai 2003 hinterlegt.
<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 7. Mai 2003 in Luxemburg stattfandi>
Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemässe Ausfüh-
rung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2002 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.
Es wird beschlossen:
- Franz Schulz, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg (Vorsitz)
- Stefan Mayerhofer, PEH WERTPAPIER AG, Oberursel
- Julien Zimmer, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg
als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die
über den Jahresabschluß des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2003 abstimmen wird.
Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
gewählt.
Die Generalversammlung beschliesst einstimmig folgende Ausschüttung der ordentlichen Erträge vorzunehmen:
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 7. Mai 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02007. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021341.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
TILBURG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 68.378.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE01814, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021348.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
TILBURG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 68.378.
—
Suivant le mandat donné par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 30 novembre 2000, nous avons
vérifié les comptes annuels de TILBURG INTERNATIONAL S.A. pour la période se terminant le 31 décembre 2002
conformément aux normes de révision généralement admises.
A notre avis, les comptes annuels ci-joints, donnent en conformité avec les prescriptions légales, une image fidèle du
patrimoine et de la situation financière au 31 décembre 2002 de TILBURG INTERNATIONAL S.A. ainsi que du résultat
de ses opérations pour la période clôturée à cette période.
Luxembourg, le 13 janvier 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01813. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021350.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
PH ROYAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,24 Euro
PH EMPIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,41 Euro
PH DIPLOMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,34 Euro
<i>Für die PEH SICAV
i>DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften
Luxembourg, le 13 mai 2003.
Signature.
EHLANGE NOMINEES LTD.
<i>Commissaire
i>Signatures
26460
COYOTE SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5680 Dalheim, 31, Wenkelhiel.
R. C. Luxembourg B 53.771.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE01830, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021383.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
DUMATIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 38.194.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 25 avril 2003 que, suite
à la démission de l’administrateur Madame Gerty Marter, Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse
professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été coopté en fonction d’administrateur en remplacement
de Madame Marter, démissionnaire.
L’élection définitive de Monsieur Pierre Schmit et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant seront vo-
tées par la prochaine assemblée générale.
Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2229 Luxembourg, 12, avenue de
la Porte-Neuve.
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle L-1219 Luxembourg,
23, rue Beaumont.
- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-
mont.
Luxembourg, le 25 avril 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01496. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021387.3/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
BUSINESS TIME CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.333.
—
In the year two thousand three, on the thirty-first of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. IOS S.A., having its registered office in Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
duly represented by Mr Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, residing in Strassen,
by virtue of a proxy dated on February 4, 2003.
2. Mr Vladimir Tchijevski, engineer, born at Kamensk-Uralsky (Russia), on May 17, 1959, residing in L-8031 Strassen,
11, rue du Parc,
duly represented by Mr Pierre Lentz, prenamed,
by virtue of a proxy dated on February 4, 2003.
The said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing parties, represented as there above mentioned, have requested the undersigned notary to enact the
following:
- that they are the actual partners of BUSINESS TIME CENTER, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated
by deed of the undersigned notary, on September 18, 2000, published in the Mémorial, Recueil C number 267 of April
13, 2001;
- that the partners have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The partners decide to increase the subscribed capital by three hundred thousand euro (EUR 300,000.-) to bring it
from its present amount of two hundred and forty thousand euro (EUR 240,000.-) to five hundred and forty thousand
N. J. Holmes
<i>Géranti>
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>G. Schneider / M. Schaeffer
<i>Administrateursi>
26461
euro (EUR 540,000.-) by the issuing of three hundred (300) new shares with a par value of one thousand euro (EUR
1,000.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon:
IOS S.A., prenamed, represented as there above mentioned,
declared to subscribe to 300 new shares and to have them fully paid up in cash so that the amount of three hundred
thousand euro (EUR 300,000.-) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the under-
signed notary.
<i>Second resolutioni>
The partners decide to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following
wording:
«Art. 6. The capital of the company is fixed at EUR 540,000.- (five hundred and forty thousand euro) divided into
540 (five hundred and forty) shares of EUR 1,000.- (one thousand euro) each.
These shares have been subscribed to as follows:
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately four thousand six hundred
euro (EUR 4,600.-).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le trente et un mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. IOS S.A., avec siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 4 février 2003.
2. Monsieur Vladimir Tchijevski, ingénieur, né à Kamensk-Uralsky (Russie), le 17 mai 1959, demeurant à L-8031 Stras-
sen, 1, rue du Parc,
ici représenté par Monsieur Pierre Lentz, prénommé,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 4 février 2003.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’ils sont les associés actuels de la société BUSINESS TIME CENTER, S.à r.l., société à responsabilité limitée, cons-
tituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 18 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil C numéro 267
du 13 avril 2001;
- Qu’ils ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de trois cent mille euros (EUR
300.000,-) pour porter son montant actuel de deux cent quarante mille euros (EUR 240.000,-) à cinq cent quarante mille
euros (EUR 540.000,-) par l’émission de trois cents (300) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de mille euros
(EUR 1.000,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Est alors intervenue aux présentes:
IOS S.A., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant,
laquelle société déclare souscrire les 300 parts sociales nouvelles et les libérer intégralement moyennant versement
en espèces de sorte que la somme de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) se trouve à la disposition de la société,
preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de modifier l’article 6 des statuts comme suit:
1. IOS S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
2. Mr Vladimir Tchijevski, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540»
26462
«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 540.000,- (cinq cent quarante mille euros) représenté par 540 (cinq cent
quarante) parts sociales de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.
Ces parts on été souscrites comme suit par:
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ quatre mille cinq cents euros (EUR 4.500,-).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Lentz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, vol. 138S, fol. 69, case 2. – Reçu 3.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021688.3/220/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
BUSINESS TIME CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.333.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021689.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
FORUM POUR L’EUROPE DE L’OUEST PRINCESSE ANASTASIA ROMANOV,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-1933 Luxembourg, 43, rue Siggy.
—
L’assemblée générale extraordinaire du 3 avril 2003 a voté à l’unanimité de ses membres les résolutions suivantes:
a) Modification de l’article 12:
«L’association est gérée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, élus pour trois ans par
l’assemblée générale.»
b) Un nouveau chapitre est ajouté aux statuts avec la teneur suivante:
Chapitre V. Le conseil de surveillance
«Art. 18. L’association s’adjoint un comité de surveillance composé d’éminentes personnalités issues des milieux po-
litique, scientifique et culturel de la Russie et de l’Europe.
Art. 19. Il a pour mission d’assister le conseil d’administration, d’élaborer des recommandations en matière d’inves-
tissements, d’aide humanitaire et en général de toutes activités rentrant dans l’objet social de l’association, de nouer les
contacts nécessaires à la poursuite de ses objectifs et de suivre ses programmes et projets.
Art. 20. Le président et les membres du comité de surveillance, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont
nommés par l’assemblée générale pour une période de trois ans. Ils sont rééligibles.»
L’ancien chapitre V et les articles relatifs sont numérotés VI, 21, 22, 23 et 24.
c) Messieurs Tom Bergh, Ted Jacoby et Charles Steichen donnent leur démission en tant qu’administrateurs. Est élu
administrateur pour une durée prenant fin avec le mandat des deux autres administrateurs, Monsieur René Steichen,
docteur en droit, demeurant à L-9220 Diekirch, 36, rue Clairefontaine.
d) Le Président Mikhail Gorbachev, demeurant à Moscou, est nommé président du comité de surveillance pour une
durée de trois ans.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01491. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021524.3/250/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
1. IOS S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
2. Mr Vladimir Tchijevski, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540»
Luxembourg, le 6 mai 2003.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 6 mai 2003.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 3 avril 2003.
Signatures.
26463
HEIP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.104.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 février 2003 que le mandat des organes sociaux,
étant venu à échéance, ont été renommés:
<i>a) administrateursi>
- Monsieur Gabriele Bravi, administrateur de société, avec adresse professionnelle à CH-6901 Lugano, Via Degli Ama-
dio, 1
- Monsieur Filippo Dollfus, administrateur de société, avec adresse professionnelle à CH-6901 Lugano, Via Degli Ama-
dio, 1
- Monsieur Dario Garbarino, administrateur de société, demeurant à Gênes (Italie)
<i>b) commissairei>
- Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23,
rue Beaumont
pour une nouvelle période de six années expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2007.
Luxembourg, le 5 février 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00057. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(021397.3/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
G.D. GROUP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 70.204.
—
L’an deux mille deux, le trente décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-
tion de G.D. GROUP INVESTMENTS S.A., R. C. Numéro B 70.204 ayant son siège social à 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg, constituée par acte de Maître Georges d’Huart notaire de résidence à Pétange, en date du 10 juin 1999,
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 632 en date du 20 août 1999.
La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, domiciliée professionnellement
au 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, domicilié professionnellement au 15, Côte
d’Eich, L-1450 Luxembourg,
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les 3.500 (trois mille cinq
cents) actions d’une valeur nominale de 100,- (cent) euros chacune, représentant l’intégralité du capital social de
350.000,- (trois cent cinquante mille) euros sont dûment représentées à la présente Assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Ratification de l’émission de l’emprunt obligataire convertible émis en date du 23 août 1999 sous seing privé.
2. Introduction d’un capital autorisé.
3. Autorisation et délégation au Conseil d’Administration de réaliser le capital autorisé sous la condition de réserver
exclusivement la souscription au capital à augmenter à concurrence de EUR 2.207.000,- (deux millions deux cent et sept
mille euros) aux obligataires de l’emprunt convertible décrit ci-devant
4. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
5. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière de la société.
6. Création de deux catégories d’administrateurs A et B et modification des pouvoirs des administrateurs pour en-
gager la société.
7. Refonte des articles 5 et 6 des statuts.
8. Fixation de la date de l’Assemblée Générale annuelle.
9. Modification subséquente de l’article 9 des statuts.
10. Affectation des administrateurs à leur catégorie respective.
11. Divers.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
26464
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
Les actionnaires existant au 23 août 1999 ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel à l’occasion de
l’émission de l’emprunt obligataire convertible émis à cette même date, l’assemblée générale décide de ratifier l’émission
de l’emprunt obligataire convertible émis en date du 23 août 1999 sous seing privé aux conditions suivantes:
La notice pour le dépôt au greffe de l’émission de l’emprunt obligataire convertible a été enregistrée en date du 5
novembre 1999, Volume 530, Folio 33, case 10 et déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en
date du 8 novembre 1999.
Afin de mettre la société en conformité avec les prescriptions de l’article 32-4 de la loi luxembourgeoise modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, un rapport sur cette émission a été dressé en date du 30 décembre 2002
par la FIDUCIAIRE EVERARD & KLEIN, réviseur d’entreprises, avec siège social à rue de la Libération, 47, L-5969 Itzig,
lequel rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
Ce rapport conclut comme suit:
Conclusion
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous sommes d’avis que:
1°) l’émission est décrite de façon claire et précise;
2°) les modes d’évaluation adoptés sont appropriés;
3°) la valeur totale de EUR 2.207.000,- représentée par un apport en numéraire correspond au moins à 22.070 obli-
gations convertibles d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune émise en contrepartie;
4°) le rapport de conversion de 1 obligation de valeur nominale de EUR 100,- contre 1 action de valeur nominale de
EUR est pertinent et raisonnable»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’introduire un capital autorisé de EUR 2.557.000,- (deux millions cinq cent cinquante-
sept mille euros).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale autorise et instruit le Conseil d’Administration de réaliser le capital autorisé sous la condition
de réserver exclusivement la souscription du capital à augmenter à concurrence de EUR 2.207.000,- (deux millions deux
cent sept mille euros) aux souscripteurs de l’emprunt convertible décrit ci-devant.
<i>Quatrième résolutioni>
Au vu de ce qui précède, l’article trois des statuts est modifié et complété pour lui donner dorénavant le teneur sui-
vante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 350.000,- (trois cent cinquante mille euros), représenté par 3.500 (trois mille
cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à 2.557.000,- (deux millions cinq cent cinquante-
sept mille euros) représenté par 25.570 (vingt-cinq mille cinq cent soixante-dix) actions de EUR 100,- (cent) chacune.
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 30 décembre 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de li part du conseil d’administration en vue de la souscription;
- de procéder à de telles émissions en réservant exclusivement la souscription aux actions représentatives du capital
autorisé à concurrence de EUR 2.207.000,- (deux millions deux cent et sept mille euros) aux titulaires d’obligations con-
vertibles de l’émission 1999/2009 convertible portant un intérêt de 1,5% l’an, remboursable sur simple décision du con-
seil d’administration à partir du 1
er
janvier 2004 et seront librement convertibles en actions au taux d’échange de 1 (une)
obligation au nominal de EUR 100,- (cent) contre 1 (une) action de la même valeur nominale.
- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
1) Valeur nominale de l’émission:
EUR 2.207.000,- (deux millions deux cent sept mille)
2) Coupures:
22.070 coupures de EUR 100,-
3) Taux d’émission:
100%
4) Date de paiement:
au plus tard le 31 août 1999
5) Date d’échéance:
31 août 2009
6) Mode de paiement:
versement sur le compte bancaire de la société ouvert auprès de THE
ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL, Jersey
7) Remboursement:
soit au pair, à l’échéance, soit remboursement anticipé, suivant déci-
sion de la société, à partir du 1
er
janvier 2004 au taux de 100%
8) Taux d’intérêts:
1.5%
9) Echéance:
annuellement au 31.12., pour la première fois le 31.12.1999
10) Conversion:
sur simple demande des obligataires avec un rapport de conversion
d’une action pour une obligation
26465
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-
fectives du capital; et enfin
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
<i>Cinquième résolutioni>
Il est créé deux catégories d’administrateurs A et B, auxquels l’assemblée donnera pouvoir de signature «A» ou pou-
voir de signature «B» lors de leur nomination.
La société se trouve désormais engagée par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie A et d’un
administrateur de la catégorie B.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de supprimer des statuts toute référence à la délégation de la gestion journalière de
la société par le conseil d’administration à un administrateur, directeur, gérant, ou autre agent.
<i>Septième résolutioni>
Suite notamment aux résolutions qui précèdent, les articles 5 et 6 des statuts sont refondus de telle manière qu’ils
auront désormais la teneur suivante:
«Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront de la catégorie A ou de la catégorie B. Lors de la nomination d’un administrateur, l’assem-
blée générale lui donnera pouvoir de signature «A» ou pouvoir de signature «B».
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.»
«Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie A et d’un administrateur
de la catégorie B.»
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée Générale se réunira annuellement de plein droit le 23 mai à 13.30 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Suite à cette résolution, l’article 9 des statuts est modifié de telle manière qu’il aura désormais la teneur suivante:
«Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 23 mai à 13.30 heures à Luxembourg, au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
<i>Neuvième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’appeler aux fonctions d’administrateurs:
- de la catégorie A avec pouvoirs de signature correspondant:
* Madame Milena Divisi, administrateur commerciale, demeurant à Wick Road Englefield Green, Surrey TW OHJ,
Royaume-Uni;
26466
* Monsieur Philip George Bisson, administrateur de sociétés, demeurant à Beg Kaleh, La rue des Vignes, Oak Lane,
St. Peter, Jersey JE3 7YL.
- de la catégorie B avec pouvoirs de signature correspondant:
* Monsieur Jean Hoffmann, Administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg.
* Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
* Madame Nicole Thommes, employée privée, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg.
* Madame Andrea Dany, employée privée, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 16.15 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, R. Uhl, H. Janssen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 44, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021736.3/211/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
G.D. GROUP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 70.204.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Elvinger.
(021741.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
CESD-COMMUNAUTAIRE, Association sans but lucratif.
Registered office: L-1531 Luxembourg, 8, rue de la Fonderie.
—
<i>Minutes of the General Assembly 2001i>
These minutes have been approved during General Assembly 2002, held in Paris 19 December 2002.
1.1. Synthesis
The General Assembly was held in Brussels, 21 November 2001.
After verifying the quorum, a first General Assembly did not reach the required quorum of majority of the members
+ 1.
Thus, a first General Assembly has been dismissed and a second one without need to reach a quorum was held.
Apart for discussion about the present and future situation of CESD-COMMUNAUTAIRE (see below the «verbatim»
of this discussion, the following points have been approved:
a. Points formally adopted
Adoption of the agenda: adopted
Approval of the Minutes of the previous General Assembly: adopted
Election of the new Board of Directors and President: adopted
- President: Alain Tranap
- Vice-Presidents: Wal Moore, Raul Suarez
- Treasurer: Salvatore Favazza
- Secretary: José Antonio Isanta
New Ordinary Members: adopted
- Ms Hernando, Mr Malaguerra former Member ex-officio, will become an ordinary member
Change of the legal address of the Association: 8 rue de la Fonderie L-1531 Luxembourg: adopted
Acceptation of 2000 financial statements: adopted
Discharge of the Board of Directors: adopted
Discharge of the auditors: adopted
Nomination of Auditors for year 2002: adopted
- FIDUCIAIRE BENOY, with a change in his mandate: auditing CESD-COMMUNAUTAIRE according the same Lux-
embourg legal principles as if CESD-COMMUNAUTAIRE, A.s.b.l. would have been an ordinary commercial firm
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06096. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021581.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Luxembourg, le 24 janvier 2003.
J. Elvinger.
Signature.
26467
CARON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 81.756.
—
L’an deux mille trois, le huit mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CARON INTERNATIONAL S.A., une société
anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 81.756, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 4 avril 2001, publié au Mémorial C numéro 1017 du 15 novembre 2001, (ci-après: «la Société»).
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Michelle McGuire, employée privée, avec adresse profession-
nelle à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Marechal-Gerlaxhe, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2002.
2.- Dissolution anticipée de la société.
3.- Nomination d’un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
4.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, actuellement fixé à deux cent mille euros
(200.000,- EUR), représenté par deux mille (2.000) actions, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement,
telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’approuver, sans restriction, ni réserve, le bilan, ainsi
que le compte de profits et pertes de la Société, arrêtés au 31 décembre 2002.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société CARON INTER-
NATIONAL S.A. et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer en tant que liquidateur:
la société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, éta-
blie et ayant son siège social au 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi coordonnée sur les Sociétés
Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accorder pleine et entière décharge aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes de ladite société actuellement en fonction pour l’accomplissement de leurs man-
dats respectifs jusqu’à ce jour.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
26468
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M. McGuire, I. Marechal-Gerlaxhe, C. Day-Royemans, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 2003, vol. 877, fol. 19, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021714.3/239/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
YERANIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.190.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01498, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2003
(021403.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
GARGANO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 86.405.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01500, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021404.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
FINALOUREC, Société Anonyme Holding.
Capital solcial: 1.440.000 Francs.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 13, rue des Dahlias.
R. C. Luxembourg B 1.601.
—
<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration du 2 juin 1994i>
Le Conseil d’Administration s’est réuni 130, rue de Silly à Boulogne (Hauts de Seine) le jeudi 2 juin 1994 à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire convoquée le même jour 15.00 heures.
Etaient présents:
Le procès-verbal du Conseil de la précédente réunion, en date du 29 avril 1994, est approuvé à l’unanimité.
<i>Nomination du Bureau du Conseili>
Le Conseil prend acte de la démission de M. Leenhardt.
Sur la proposition de M. Jean-Claude Verdière, le Conseil désigne comme Président, pour la durée de son mandat
d’Administrateur, M. Jean-Claude Cabre, qui déclare accepter ces fonctions.
Le Conseil renouvelle ensuite comme Administrateur-Délégué, pour la durée de son mandat d’Administrateur, M.
Jean-Claude Verdière, qui accepte ces fonctions.
<i>Pouvoirs du Président et de l’Administrateur-Déléguéi>
Le Conseil, préalablement autorisé par l’Assemblée Générale du 2 juin 1994, confère à M. Jean-Claude Cabre, Prési-
dent et à M. Jean-Claude Verdière, Administrateur-Délégué, chacun agissant séparément, les pouvoirs suivants:
- Gérer et Administrer toutes les affaires de la Société,
- Toucher et recevoir toutes sommes qui pourraient être dues à la Société, faire tous retraits de fonds, payer toutes
sommes dues par la Société,
- Entendre, débattre clore et arrêter tous comptes avec tous débiteurs ou créanciers, en fixer le reliquat actif ou
passif, les recevoir ou payer,
Belvaux, le 12 mai 2003.
J.-J. Wagner.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>G. Schneider / P. Schmit
<i>Administrateursi>
MM.
Jean-Claude Verdière
Jean-Claude Cabre
François Fabre
26469
- Faire ouvrir au nom de la Société auprès de toutes les banques ou organismes de crédit tous les comptes courants
ou autres. Faire fonctionner ces comptes en y déposant et erg y retirant toutes sommes,
- Signer et accepter des billets, traites, lettres de change, chèques et effets de commerce.
- Se faire remettre tous dépôts, donner décharge du tout,
- Prendre toutes participations dans toutes sociétés et affaires industrielles, commerciales et financière,
- Faire à tel bureau qu’il appartiendra toutes déclarations d’existence et souscrire comme il y a lieu l’abonnement au
timbre pour les actions de la Société,
- Demander toutes dispenses d’apposition du timbre sur les titres, acquitter tous droits, faire toutes déclarations,
signer tous registres et pièces et faire le nécessaire,
- Autoriser toutes instances judiciaires, soit en demandant, soit en défendant et représenter la Société en justice,
- Faire tour achats de titres et droits sociaux, souscrire et revendre toutes actions et obligations,
- De toutes sommes perçues, donner quittance,
- Consentir toutes mentions et subrogations avec ou sans garantie,
- Faire mainlevée de toutes inscriptions, saisies et oppositions avec ou sans paiement,
- Désister ladite Société s’il y a lieu de tous droits de privilège, hypothèques et actions résolutoires avec ou sans paie-
ments,
- Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces,
- Elire domicile, conférer à tous mandataires tout ou partie des pouvoirs ci-dessus,
- Et, généralement, faire le nécessaire.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.15 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05182. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 1994i>
Le jeudi 2 juin 1994, à 15.00 heures, les Actionnaires de la Société SEGEVAL se sont réunis en Assemblée Générale
ordinaire, 130, rue de Silly à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine), conformément à la Loi et aux statuts de la Société
sur la convocation faite par lettre envoyée à chacun d’eux, en date du 18 mai 1994.
Le Commissaire aux comptes a également été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à la même
date.
L’Assemblée est présidée par M. Arnaud Leenhardt, Président du Conseil d’Administration.
Le Président appelle comme scrutateurs les deux actionnaires présents disposant du plus grand nombre de voix et
acceptant cette fonction. Ce sont:
- Jean-Claude Cabre, représentant la Société VALLOUREC
- M. Jean-Claude Verdière, représentant la Société SOPRETAC
M. Henri Redig est désigné comme Secrétaire.
Le Bureau ainsi constitué, le Président met à la disposition de l’Assemblée:
- un exemplaire des statuts,
- un duplicata de la lettre de convocation du 18 mai 1994,
- le rapport du Conseil d’Administration
- le rapport du Commissaire aux comptes,
- le bilan et les comptes arrêtés au 31 décembre 1993,
- le texte des résolutions,
- la feuille de présence. Celle-ci faisant apparaître que tous les actionnaires sont présents ou représentés, l’Assemblée
peut donc valablement délibérer.
Le Président donne alors lecture de l’ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
- Approbation des comptes de l’exercice 1993 et du bilan arrêté au 31 décembre 1993.
- Affectation du résultat/ Distribution d’un dividende.
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat.
- Nomination d’un Administrateur.
- Autorisations à donner au Conseil d’Administration.
Le Président rappelle que le rapport de gestion, le texte des résolutions, le rapport du Commissaire aux comptes,
ainsi que les divers documents prévus par la loi ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition dans les
délais légaux, ce dont l’Assemblée lui donne acte.
M. Redig est invité à donner lecture du rapport du Conseil, puis lecture est donnée du rapport du Commissaire aux
comptes.
Enfin, le Président demande aux actionnaires s’ils ont des précisions à demander au des observations à présenter.
Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix:
Signature / Signature
<i>Le Président / Un Administrateuri>
Pour copie conforme
J.J. Wolter
26470
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire
aux comptes, approuve le rapport du Conseil ainsi que les comptes et le bilan de l’exercice 1993 qui se soldent par un
résultat net de 563.709,44 F.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration et décide en con-
séquence la distribution d’un dividende global de 561.600 F, soit 11,70 F par action.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs de leur gestion pour l’exercice 1993. Elle donne égale-
ment décharge au commissaire aux comptes de l’exécution de son mandat pour le même exercice.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Leenhardt de son mandat d’Administrateur.
L’Assemblée Générale désigne M. François Fabre en tant que nouvel Administrateur. Conformément aux dispositions
de l’article 9 des statuts le mandat de M. Fabre prendra fin avec l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exer-
cice 1997.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à fixer les pouvoirs du Président et de l’Administrateur-
Délégué qui seront désignés lors du prochain conseil d’Administration.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal certifié exact par les membres du Bureau soussignés;
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD04984. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration du 4 juin 1992i>
Le Conseil d’Administration s’est réuni 130, rue de Silly à Boulogne (Hauts de Seine), le jeudi 4 juin 1992, à l’issue de
l’Assemblée Générale ordinaire convoquée le même jour à 15.00 heures.
Etaient présents:
Le procès-verbal de la séance du 14 mai 1992 est approuvé à l’unanimité.
<i>Nomination du bureau du Conseili>
Sur la proposition de M. Jean-Claude Verdière, le Conseil renouvelle comme Président, pour la durée de son mandat
d’Administrateur, M. Arnaud Leenhardt, qui déclare accepter ces fonctions.
Le Conseil d’Administration renouvelle ensuite comme Administrateur-Délégué, pour la durée de son mandat d’Ad-
ministrateur, M. Jean-Claude Verdière, qui accepte ces fonctions.
<i>Pouvoirs du Président et de l’Administrateur-Déléguéi>
Le Conseil confère à M. Arnaud Leenhardt, Président, et à M. Jean-Claude Verdière, Administrateur Délégué, chacun
agissant séparément, les pouvoirs suivants:
- gérer et administrer toutes les affaires de la Société,
- toucher et recevoir toutes sommes qui pourraient être dues à la société, faire tous retraits de fonds, payer toutes
sommes dues par la Société,
- Entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes avec tous débiteurs ou créanciers, en fixer le reliquat actif ou
passif, les recevoir ou payer,
- faire ouvrir au nom de la Société auprès de toutes les banques ou organismes de crédit tous les comptes courants
ou autres. Faire fonctionner ces comptes en y déposant et en y retirant toutes sommes,
- signer et accepter des billets, traites, lettres de change, chèques ou effets de commerce,
- se faire remettre tous dépôts, donner décharge du tout,
- prendre toutes participations dans toutes sociétés et affaires industrielles, commerciales et financières,
- faire à tel bureau qu’il appartiendra toutes déclarations d’existence et souscrire comme il y a lieu l’abonnement au
timbre pour les actions de la Société,
- / SOPRETAC / VALLOUREC / -
A. Leenhardt / J.C. Verdière / J.C. Cabre / H. Redig
<i>Le Président / Les Scrutateurs / Le Secrétairei>
Copie certifiée conforme
H. Redig
<i>Le secrétaire de l’Assemblée i>
MM.
Arnaud Leenhardt, Président
Jean-Claude Verdière, Administrateur-Délégué
Jean-Claude Cabre, Administrateur
26471
- demander toutes dispenses d’apposition du timbre sur les titres, acquitter tous droits, faire toutes déclarations, si-
gner tous registres et pièces et faire le nécessaire,
- autoriser toutes instances judiciaires, soit en demandant, soit en défendant et représenter la Société en justice,
- faire tous achats de titres et droits sociaux, souscrire et revendre toutes actions et obligations,
- de toutes sommes perçues, donner quittance et décharge,
- consentir toutes mentions et subrogations avec ou sans garanties,
- faire mainlevée de toutes inscriptions, saisies et oppositions avec ou sans paiement,
- désister ladite Société s’il y a lieu, de tous droits de privilèges, hypothèques et actions résolutoires avec ou sans
paiement,
- aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces,
- élire domicile, conférer à tous mandataires tout ou partie des pouvoirs ci-dessus,
- et généralement faire le nécessaire.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06204. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 juin 1998i>
Le jeudi 4 juin 1998 à 15.00 heures, les Actionnaires de la Société FINALOUREC se sont réunis en Assemblée Gé-
nérale Ordinaire, 15, boulevard Grande Duchesse Charlotte à Luxembourg (Grand Duché), conformément à la Loi et
aux statuts de la Société sur la convocation faite par lettre envoyée à chacun d’eux, en date du 18 mai 1998.
Le Commissaire aux comptes a également été convoqué à la même date et dans les conditions prévues par la Loi.
L’Assemblée est présidée par M. Jean-Claude Cabre, Président du Conseil d’Administration.
Le Président appelle comme scrutateurs les deux actionnaires présents disposant du plus grand nombre de voix et
acceptant cette fonction. Ce sont:
- M. François Fabre, représentant la Société VALLOUREC
- M. Jean-Claude Verdière, représentant la Société SOPRETAC
M. Henri Redig est désigné comme Secrétaire.
Le Bureau ainsi constitué, le Président met à la disposition de l’Assemblée:
- un exemplaire des statuts,
- un duplicata de la lettre de convocation du 18 mai 1998,
- le rapport du Conseil d’Administration
- le rapport du Commissaire aux comptes,
- le bilan et les comptes arrêtés au 31 décembre 1997,
- le texte des résolutions,
- la feuille de présence. Celle-ci faisant apparaître que les 5 actionnaires présents ou représentés possèdent la totalité
des 48.000 actions composant le capital social, l’Assemblée peut donc valablement délibérer.
Le Président donne alors lecture de l’ordre du jour
- Approbation des comptes de l’exercice 1997 et du bilan arrêté au 31 décembre 1997,
- Affectation du résultat/ Distribution d’un dividende,
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat.
- Renouvellement du mandat de 3 Administrateurs.
Autorisation à donner au Conseil pour fixer les pouvoirs du Président et de l’Administrateur-Délégué.
Le Président rappelle que le rapport de gestion, le texte des résolutions, le rapport du Commissaire aux comptes,
ainsi que les divers documents prévus par la loi ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition dans les
délais légaux, ce dont l’Assemblée lui donne acte.
M. Redig est invité à donner lecture du rapport du Conseil, puis lecture est donnée du rapport du Commissaire aux
comptes.
Enfin, le Président demande aux actionnaires s’ils ont des précisions à demander ou des observations à présenter.
Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire
aux comptes, approuve le rapport du Conseil ainsi que les comptes et le bilan de l’exercice 1997 qui se soldent par un
bénéfice net de 476.898,45 F.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration et décide, en con-
séquence, la distribution d’un dividende global de 476.160,00 F, le solde de 738,45 F étant reporté à nouveau.
Il sera donc versé 9,92 F à chaque action.
Le dividende sera mis en paiement le 23 juin 1998.
Nous vous rappelons qu’au titre de l’exercice 1994 il a été versé un dividende unitaire de 26,00 F, qu’au titre de l’exer-
cice 1995, il a été versé un dividende unitaire de 17,00 F et qu’au titre de l’exercice 1996, il a été versé un dividende de
10,40 F par action.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
26472
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs de leur gestion pour l’exercice 1997. Elle donne égale-
ment décharge au Commissaire aux comptes de l’exécution de son mandat pour le même exercice.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Claude Cabre pour une
durée de six années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
2003.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Claude Verdière pour une
durée de six années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
2003.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur François Fabre pour une durée
de six années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2003.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Septième résolutioni>
Les mandats du Président et de l’Administrateur-Délégué arrivant à expiration, l’Assemblée Générale autorise le
Conseil d’Administration à renouveler leurs pouvoirs ou, le cas échéant, à fixer ceux du Président et de l’Administra-
teur-Délégué qui viendraient à être désignés par le prochain Conseil d’Administration.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal certifié exact par les membres du Bureau soussignés
le 26 octobre 1998.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD04987. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration du 4 juin 1998i>
Le Conseil d’Administration s’est réuni 15, boulevard Grande Duchesse Charlotte à Luxembourg (GD) le jeudi 4 juin
1998 à l’issue de l’Assemblée générale Ordinaire convoquée le même jour à 15.00 heures.
Etaient présents:
Le procès-verbal du Conseil de la précédente réunion, en date du 26 février 1998, est approuvé à l’unanimité.
<i>Nomination du Bureau du Conseili>
Sur la proposition de M. Jean-Claude Verdière, le Conseil renouvelle comme Président, pour la durée de son mandat
d’Administrateur, M. Jean-Claude Cabre, qui déclare accepter ces fonctions.
Le Conseil renouvelle ensuite comme Administrateur-Délégué, pour la durée de son mandat d’Administrateur, M.
Jean-Claude Verdière, qui accepte ces fonctions.
<i>Pouvoirs du Président et de l’Administrateur-Déléquéi>
Le Conseil, préalablement autorisé par l’Assemblée Générale du 4 juin 1998, renouvelle à M. Jean-Claude Cabre, Pré-
sident et à M. Jean-Claude Verdière, Administrateur-Délégué, chacun agissant séparément, les pouvoirs suivants:
- Gérer et Administrer toutes les affaires de la Société,
- Toucher et recevoir toutes sommes oui pourraient être dues à la Société, faire tous retraits de fonds, payer toutes
sommes dues par la Société,
- Entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes avec tous débiteurs ou créanciers, en fixer la reliquat actif ou
passif, les recevoir ou payer,
- Faire ouvrir au nom de la Société auprès de toutes les banques ou organismes de crédit tous les comptes courants
ou autres. Faire fonctionner ces comptes en y déposant et en y retirant toutes sommes,
- Signer et accepter des billets, traites, lettres de change, chèques et effets de Commerce,
- Se faire remettre tous dépôts, donner décharge du tout,
- Prendre toutes participations dans toutes sociétés et affaires industrielles, commerciales et financières,
- / SOPRETAC / VALLOUREC / -
J.C Cabre / J.C Verdière / F. Fabre / H. Redig
<i>Le Président, Les Scrutateurs, Le Secrétairei>
Copie certifiée conforme
Signature
<i>Le Président Directeur Générali>
MM.
Jean-Claude Cabre
Jean-Claude Verdière
François Fabre
26473
- Faire à tel bureau qu’il appartiendra toutes déclarations d’existence et souscrire comme il y a lieu l’abonnement au
timbre pour les actions de la Société,
- Demander toutes dispenses d’apposition du timbre sur les titres, acquitter tous droits, faire toutes déclarations,
signer tous registres et pièces et faire le nécessaire,
- Autoriser toutes instances judiciaires, soit en demandant, soit en défendant et représenter la Société en justice,
- Faire tous achats de titres et droits sociaux, souscrire et revendre toutes actions et obligations,
- De toutes sommes perçues, donner quittance,
- Consentir toutes mentions et subrogations avec ou sans garantie,
- Faire mainlevée de toutes inscriptions, saisies et oppositions avec ou sans paiement,
- Désister ladite société s’il y a lieu de tous droits de privilège, hypothèques et actions résolutoires avec au sans paie-
ments,
- Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces,
- Elire domicile, conférer à tous mandataires tout ou partie des pouvoirs ci-dessus,
- Et, généralement, faire le nécessaire.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD04983. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021141.3/000/292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.
A BIS Z PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4412 Belvaux, 23, rue des Alliés.
R. C. Luxembourg B 78.546.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Statutairei>
L’assemblée, à l’unanimité des voix, ratifie la nomination de la société BUREAU MODUGNO, S.à r.l., en qualité de
commissaire aux comptes en remplacement de Madame Mara Schammo.
Suite à cette nomination, la surveillance de la société est confiée au commissaire aux comptes:
- la société BUREAU MODUGNO, S.à r.l., ayant son siège social à L-3313 Bergem, 130, Grand-Rue.
Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire
de l’an 2006.
Belvaux, le 30 avril 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00444. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021433.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
BUREAU MODUGNO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3313 Bergem, 130, Grand-Rue.
R. C. Luxembourg B 35.889.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00439, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bergem, le 13 mai 2003.
(021441.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
HCD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.818.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01618, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2003.
(021516.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Signature / Signature
<i>Le Président / Un Administrateuri>
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
BUREAU MODUGNO, S.à r.l.
Signature
HCD HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
26474
KAPLA WORLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 79.937.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires tenue le 27 janvier 2003i>
Il résulte du procès-verbal:
- que l’Assemblée Générale a approuvé les comptes annuels au 31 décembre 2001;
- que l’Assemblée Générale a accordé pleine et entière décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes
pour l’exercice de leur mandat couvrant l’exercice social courant depuis le jour de la constitution de la société, à savoir
le 6 décembre 2000, jusqu’au 31 décembre 2001.
- que l’Assemblée Générale a reconduit Maître Simone Retter, ci-après qualifiée, dans ses fonctions d’administrateur,
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre
2002;
que l’Assemblée Générale, n’ayant pas reconduit Maître Jean-Paul Goerens et Madame Colette Sadler dans leurs fonc-
tions d’administrateurs, a nommé en remplacement avec effet immédiat, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordi-
naire annuelle appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2002, deux nouveaux administrateurs, à savoir
Madame Catherine Koch et Madame Rita Goujon, ci-après qualifiées.
que dès lors, le Conseil d’Administration se présente désormais comme suit:
- que l’Assemblée Générale, n’ayant pas reconduit la société LUX FIDUCIAIRE, S.à r.l. dans ses fonctions de commis-
saire aux comptes, a nommé en remplacement avec effet immédiat, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
annuelle appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2002, la société THEMIS AUDIT LIMITED, établie
et ayant son siège social à Abbott Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques).
- que l’Assemblée Générale a transféré avec effet au 1
er
mars 2003 le siège social du 14, avenue du X Septembre, L-
2550 Luxembourg, au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02018. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021551.3/1005/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
CHARISMA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 72.483.
—
Die Bilanz zum 31. Dezember 2002 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002 wurden einre-
gistriert in Luxemburg am 12. Mai 2003, Ref. LSO-AE02024, und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg
am 13. Mai 2003 hinterlegt.
<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 9. Mai 2003 in Luxemburg stattfandi>
Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemäße Ausfüh-
rung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2002 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.
Es wird beschlossen:
Carsten Osswald, PEH WERTPAPIER AG, Oberursel
Claude Niedner, Luxemburg (Vorsitz)
Victor Elvinger, Luxemburg
Martin Stürner, PEH WERTPAPIER AG, Oberursel
als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die
über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2003 abstimmen wird.
Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
gewählt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 9. Mai 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02024. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021337.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
- Maître Simone Retter, Maître en droit, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- Madame Catherine Koch, Administrateur de sociétés, demeurant au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxem-
bourg;
- Madame Rita Goujon, Employée privée, demeurant au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
<i>Für CHARISMA SICAV
i>DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften
26475
PHITEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.990.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1
er
avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,
S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 27, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nom-
mée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administra-
teur démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00371. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021523.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
DHARMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.854.
—
L’an deux mille trois, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DHARMA HOLDINGS S.A. (la «Société»), une
société anonyme holding, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro
83.854, établie et ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 7 août 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
231 du 11 février 2002. Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
28 octobre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 5 du 3 janvier 2003.
L’assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en scien-
ces économiques, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique Schmickrath, licenciée en sciences économiques, avec
adresse professionnelle à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Fixation d’une nouvelle date d’échéance du capital autorisé.
2. Autorisation au Conseil d’Administration à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscrip-
tion ou convertibles dans le cadre du capital autorisé.
3. Modification de l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Version française:
Art. 5. Capital social; Capital autorisé; Emprunts obligataires
Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille euros) représenté par 1.200.000
(un million deux cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 13.000.000,- (treize millions d’euros) qui
sera représenté par 10.400.000 (dix millions quatre cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et
vingt-cinq cents) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 28 mars 2008, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
<i>Pour PHITEX S.A.
i>G. Fasbender
<i>Administrateuri>
26476
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Version anglaise:
Art. 5. Subscribed capital; Authorised capital; Bonds
The subscribed capital of the company is fixed at EUR 1,500,000.- (one million five hundred thousand euros) divided
into 1,200,000 (one million two hundred thousand) shares with a nominal value of EUR 1.25 (one euro and twenty-five
cents) each.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at EUR 13,000,000.- (thirteen million euros) to be
divided into 10,400,000 (ten million four hundred thousand) shares with a nominal value of EUR 1.25 (one euro and
twenty-five cents) each.
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.
Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on March 28, 2008, to increase
in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital
may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by
contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the com-
pany, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of
bonds as mentioned below.
The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-
holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in
bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible
bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the
limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.
The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other
terms and conditions thereof.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.
4. Modification de l’année sociale de la société qui commencera désormais le 1
er
janvier pour finir le 31 décembre de
la même année, de sorte que l’exercice social en cours qui a commencé le 1
er
juillet 2002 se terminera le 31 décembre
2003 et que les exercices suivants courront du 1
er
janvier au 31 décembre de chaque année.
5. Modification de l’article 21 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Version française:
«L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le Conseil d’administration pré-
pare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.»
Version anglaise:
«The Company’s financial year begins on the January 1
st
and ends on December 31
st
of each year. The Board of Di-
rectors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and accounting prac-
tice.»
6. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du 30 septembre de chaque année au dernier vendredi du
mois de juin à 14.00 et pour la première fois en 2004.
7. Modification de l’article 18 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Version française:
«L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de
convocations le dernier vendredi du mois de juin à 14.00.»
Version anglaise:
«The annual general meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be
specified in the notice convening the meeting on the last Friday of June of each year, at 2.00 p.m.»
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions que chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les ac-
tionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau de l’assemblée, sera annexée au présent acte pour être
soumise simultanément à l’enregistrement.
26477
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire instru-
mentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis à simultanément l’enregistrement.
III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes actions représentant l’intégralité du capital social souscrit de la
Société sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment informés avant cette as-
semblée.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de renouveler le capital autorisé de la société permettant au conseil d’administration de porter
le capital social souscrit de son montant actuel à treize millions d’euros (13.000.000,- EUR) tel qu’il est prévu dans l’ar-
ticle 5 des statuts.
L’assemblée autorise en outre le conseil d’administration à émettre un ou plusieurs emprunts obligataires ordinaires,
avec bons de souscription ou convertibles dans le cadre du capital autorisé.
Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés com-
merciales, l’assemblée autorise le conseil d’administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du
capital autorisé et notamment avec l’autorisation de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires lors de l’émission d’actions nouvelles et lors de l’émission d’obligations ordinaires, avec bons de souscrip-
tion ou convertibles. Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.
Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans expirant le 28 mars 2008.
En conséquence, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Version française:
«Art. 5. Capital social; Capital autorisé; Emprunts obligataires
Le capital souscrit de la société est fixé à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) représenté par un million
deux cent mille (1.200.000) actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de treize millions d’euros (13.000.000,- EUR) qui
sera représenté par dix millions quatre cent mille (10.400.000) actions d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq
cents (1,25 EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 28 mars 2008, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
Version anglaise:
«Art. 5. Subscribed capital; Authorised capital; Bonds
The subscribed capital of the company is fixed at one million five hundred thousand euros (1,500,000.- EUR) divided
into one million two hundred thousand (1,200,000) shares with a nominal value of one euro and twenty-five cents (1.25
EUR) each.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at thirteen million euros (13,000,000.- EUR) to be
divided into ten million four hundred thousand (10,400,000) shares with a nominal value of one euro and twenty-five
cents (1.25 EUR) each.
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.
Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on March 28, 2008, to increase
in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital
26478
may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by
contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the com-
pany, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of
bonds as mentioned below.
The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-
holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in
bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible
bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the
limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.
The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other
terms and conditions thereof.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’exercice social de la société qui commencera désormais le premier janvier et se
terminera le trente et un décembre de la même année.
Exceptionnellement, l’exercice social ayant commencé le 1
er
juillet 2002 se terminera le 31 décembre 2003.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 21 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Version française:
«Art. 21. Année sociale
L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le Conseil d’Administration prépare
les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.»
Version anglaise:
«Art. 21. Financial year
The Company’s financial year begins on the January 1
st
and ends on December 31
st
of each year. The Board of Di-
rectors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and accounting prac-
tice.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires et en conséquence le pre-
mier alinéa de l’article 18 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Version française:
«Art. 18. Assemblée générale annuelle. Premier alinéa
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de
convocations le dernier vendredi du mois de juin à 14.00.»
Version anglaise:
«Art. 18. Annual General Meeting. First paragraph
The annual general meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be
specified in the notice convening the meeting on the last Friday of June of each year, at 2.00 p.m.»
La prochaine assemblée générale annuelle se tiendra en l’an deux mille quatre.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le notaire soussigné, déclare par les présentes qu’à la requête des personnes comparantes, en cas de divergences
entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues par le notaire instrumentaire,
par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdites personnes comparantes ont toutes signé avec le notaire le pré-
sent acte.
Signé: P. Lentz, A. Uhl, V. Schmickrath, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2003, vol. 875, fol. 79, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021717.3/239/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Belvaux, le 12 mai 2003.
J.-J. Wagner.
26479
DHARMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.854.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021719.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
PASSING SHOT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.449.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1
er
avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,
S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 27, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nom-
mée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administra-
teur démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00372. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021529.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
PARSIFLOR, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 10.316.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1
er
avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,
S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 27, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nom-
mée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administra-
teur démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00373. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021532.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
SPANIMMO, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.692.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1
er
avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,
S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 27, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nom-
mée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administra-
teur démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00375. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021536.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Belvaux, le 12 mai 2003.
J.-J. Wagner.
<i>Pour PASSING SHOT S.A.
i>G. Fasbender
<i>Administrateuri>
<i>Pour PARSIFLOR
i>G. Fasbender
<i>Administrateuri>
<i>Pour SPANIMMO
i>G. Fasbender
<i>Administrateuri>
26480
TMD INTERNATIONAL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.
H. R. Luxemburg B 36.360.
—
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendunddrei, den fünften Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
DAVENPORT FINANCE S.A., mit Sitz in Tortola, British Virgin Islands,
hier vertreten durch Herrn Norbert Wrobel, Geschäftsmann, wohnhaft in 4, Cité Flammant, L-6115 Junglinster,
auf Grund einer Generalvollmacht ausgestellt in Tortola, British Virgin Islands, am 30. März 1999.
Eine beglaubigte Abschrift dieser Generalvollmacht blieb einer Urkunde des instrumentierenden Notars vom 4. April
2003, einregistriert in Luxemburg am 8. April 2003, Band 138S, Folio 72, Fach 3 beigefügt.
Welche Komparentin, durch ihren Bevollmächtigten, den unterfertigten Notar gebeten hat folgendes zu beurkunden:
- Die Aktiengesellschaft TMD INTERNATIONAL HOLDING S.A. mit Sitz in Luxemburg, R.C. Nummer B 36.360,
nachfolgend «die Gesellschaft» genannt, wurde gegründet unter durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-
Paul Hencks, mit dem Amtsitz in Luxemburg, vom 8. März 1991, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, Nummer 329 vom 3. September 1991 veröffentlicht wurde.
Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Christine Doerner,
mit dem Amtsitz in Bettemburg, vom 20. Februar 2001, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 845 vom 4. Oktober 2001 veröffentlicht wurde.
- Die Gesellschaft hat augenblicklich ein Kapital von dreiunddreissigtausendzweihundertvierundfünfzig (33.254,-) Euro
(EUR), eingeteilt in dreizehn (13) Aktien mit einem Nennwert von zweitausendfünfhundertachtundfünfzig (2.558,-) Euro
(EUR) je Aktie, vollständig eingezahlt.
- Die Komparentin ist Besitzerin aller Aktien der Gesellschaft geworden.
- Andurch erklärt die Komparentin als einziger Aktionär und wirtschaftlicher Endnutzniesser dieser Handlung die vor-
zeitige Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung.
- Die Komparentin erklärt, dass sie genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft besitzt.
- Die Komparentin erklärt, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft, dass die Aktivität der Gesellschaft auf-
gehört hat, dass die bekannten Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurden und dass sie sich ausdrücklich dazu
verpflichtet, alle Passiva welche eventuell noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt oder unbekannt
bis zum heutigen Tage sind zu übernehmen, bevor irgendwelche Zuteilung der Aktiva an ihre Person als einziger Gesell-
schafter getätigt wird; mithin ist die Liquidation der Gesellschaft als getan und abgeschlossen zu betrachten.
- Die einzige Aktionärin erteilt dem Verwaltungsrat und dem Kommissar Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate
bis zum heutigen Tage.
- Die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren in L-6115
Junglinster, 4, Cité Flammant aufbewahrt.
Worauf der Bevollmächtigte der Komparentin dem unterfertigten Notar 2 Inhaberaktienzertifikate vorgelegt hat,
welche sofort zerstört wurden.
Somit hat der instrumentierende Notar die endgültige Auflösung der Gesellschaft TMD INTERNATIONAL HOL-
DING S.A. festgestellt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Bevollmächtigten der Komparentin, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Signé: N. Wrobel, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2003, vol. 17CS, fol. 63, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021729.3/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
SPECIALTY MATERIALS INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.912.900,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 78.973.
—
EXTRAIT
Le Conseil de Gérance a décidé de transférer avec effet au 1
er
mars 2003 le siège social du 38-40, rue Sainte Zithe,
L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hartdt, L-1717 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01664. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021573.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Luxembourg, le 12 mai 2003.
A. Schwachtgen.
26481
TUTTOGRATIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 80.521.
—
RECTIFICATIF
L’an deux mille trois, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique);
Agissant en sa qualité de mandataire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois TUTTOGRA-
TIS S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val fleuri, R. C. Luxembourg Section B numéro 80.521, cons-
tituée suivant acte reçu le 8 janvier 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 758 du
14 septembre 2001, en vertu des procurations sous seing privé lui délivrées lors de l’assemblée générale extraordinaire
tenue par acte devant le notaire soussigné en date du 24 décembre 2002, lesquelles procurations sont restées annexées
au dit acte et enregistrées en même temps que lui, et agissant également en sa fonction de président de l’assemblée
générale extraordinaire prénommée.
Le comparant a requis le notaire d’acter ce qui suit:
Il résulte des vérifications effectuées ultérieurement qu’une erreur matérielle a été commise, lors de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire précitée, dans sa huitième résolution, laquelle doit être lue comme suit:
«L’assemblée décide de procéder aux nominations et renouvellements de mandats suivants:
Commissaire aux comptes:
Est nommée commissaire aux comptes: CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Conseil d’administration:
Le mandat des membres actuels du Conseil d’administration est renouvelé, sont donc nommés administrateurs:
Monsieur Dragan Jankovic
Monsieur Giovanni Stucchi
Monsieur Bruno Beernaert
Monsieur Alessandro Di Gioia
Monsieur David De Marco.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l’assemblée générale
qui statuera sur les comptes arrêtés au 28 février 2003.».
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, vol. 138S, fol. 61, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021731.3/211/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
MASTER-FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8311 Capellen, 115, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.508.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 17 mars 2003i>
Le Conseil prend note de la démission de Monsieur P. Henrion dans sa fonction d’administrateur de la société avec
effet immédiat.
A l’unanimité le Conseil accepte que le mandat de Monsieur Paul Henrion sera repris par Monsieur Raynier Van
Outryve d’Ydewalle jusqu’à l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 2003. Il exercera son mandat à travers la société
anonyme de droit belge NV DRIE KONINGEN RVO - Beernem (Belgique). Le Conseil proposera aux actionnaires la
nomination de cette structure représenté par Monsieur Raynier Van Outryve d’Ydewalle pour un nouveau mandat de
6 ans.
Capellen, le 18 mars 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01208. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021588.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Luxembourg, le 2 mars 2003.
J. Elvinger.
Pour extrait analytique
E. Wolf
<i>Administrateur-déléguéi>
26482
SODEVIM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.425.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1
er
avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,
S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 27, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nom-
mée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administra-
teur démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00377. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021539.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
PANORAMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 9.189.
—
L’an deux mille trois, le quinze avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
1) Mademoiselle Marie-Gabrielle dite Gaby Maul, gérante de sociétés, née à Luxembourg, le 23 octobre 1944, de-
meurant à L-8134 Bridel, 9, rue Hemes.
2) La SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION SOGA, société anonyme, inscrite au R. C.S. de Luxembourg
sous le numéro B 19.081, ayant son siège social à L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l’Alzette,
ici représentée par deux de ses administrateurs, Messieurs Alphonse Ley, gérant de sociétés, demeurant à L-1323
Luxembourg, 16, rue des Champs et Monsieur Fernand Simon, administrateur de sociétés, demeurant à L-8028 Strassen,
10, rue Mathias Goergen.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée PA-
NORAMA, S.à r.l., «Agence de Voyages et de Tourisme», ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des
Bains, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 9.189, constituée suivant acte
sous seing privé en date du 31 août 1970, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 197
du 27 novembre 1970 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé du 7 mai 2002
publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1259 du 29 août 2002, déclarent se réunir en assemblée
générale et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Suite à la cession par Madame Alice Felten, veuve Ernest Maul, de sa (1) part sociale dans la Société à Mademoiselle
Gaby Maul et à la cession par cette dernière de mille deux cent soixante-quinze (1.275) parts à la SOCIETE DE GES-
TION ET D’ADMINISTRATION SOGA, prénommée, l’assemblée constate et approuve la répartition des parts sociales
telle qu’elle existe à partir du 14 janvier 2003:
Les comparants, en leur qualité de seuls et uniques associés, acceptent expressément cette cession de parts. Made-
moiselle Gaby Maul déclare en sa qualité de gérante de la Société accepter également les cessions de parts intervenues
au nom et pour compte de la Société conformément à l’article 1690 du Code civil.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui assument tant la gestion technique que commer-
ciale de la société ainsi que la représentation judiciaire et extraordinaire de la société. Les gérants sont nommés par
l’assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir seul au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir seul tous les actes
nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social.»
<i>Pour SODEVIM
i>G. Fasbender
<i>Administrateuri>
1) Mademoiselle Gaby Maul,
mille deux cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.225
2) SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION SOGA,
mille deux cent soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.275
Total: deux mille cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
26483
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer un deuxième gérant en la personne de Monsieur Alphonse Ley pour une durée in-
déterminée.
En conséquence, les gérants sont les suivants:
- Mademoiselle Gaby Maul, gérante de sociétés, née à Luxembourg, le 23 octobre 1944, demeurant à L-8134 Bridel,
9, rue Hemes.
- Monsieur Alphonse Ley, gérant de sociétés, né à Luxembourg, le 20 octobre 1941, demeurant à L-1323 Luxem-
bourg, 16, rue des Champs.
Conformément à l’article 9 des statuts, la société est engagée valablement vis-à-vis des tiers pour toutes affaires par
la signature individuelle de chaque gérant.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M.-G. Maul, A. Ley, F. Simon et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, vol. 138S, fol. 79, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(021764.3/200/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
PANORAMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 9.189.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
F. Baden.
(021765.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
SOCEPAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.536.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1
er
avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,
S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 27, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nom-
mée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administra-
teur démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00379. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021543.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
SARLAT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.111.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1
er
avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,
S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 27, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nom-
mée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administra-
teur démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00381. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021546.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Luxembourg, le 8 mai 2003.
F. Baden.
<i>Pour SOCEPAL
i>G. FASBENDER
<i>Administrateuri>
<i>Pour SARLAT S.Ai>.
G. Fasbender
<i>Administrateuri>
26484
RAKHAM FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.677.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1
er
avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,
S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administrateur dé-
missionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00383. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021549.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
CASSIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.232.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1
er
avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,
S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 27, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nom-
mée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administra-
teur démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00386. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021569.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
SBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.996.
—
Monsieur Jorgen Nilsson, né le 10 février 1949 à Kristianstad, Suède, demeurant à Kallvreten Injaro, SE-134 21 Gus-
tavsberg, Suède, a démissionné en date du 10 avril 2003, avec effet immédiat, de sa fonction de Directeur Général de la
société SBS BROADCASTING S.A.
Luxembourg, le 6 mai 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01680. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021571.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
MUNICH INVEST, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2450 Luxemburg, 10-12, boulevard Roosevelt.
H. R. Luxemburg B 80.087.
Die Gesellschaft wurde am 17. Januar 2001 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Alphonse Lentz, mit Amtssitz in
Remich, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n
°
145 vom 24. Februar 2001.
—
Der geprüfte Jahresbericht zum 31. Dezember 2002, eingetragen in Luxemburg den 9 Mai 2003, Ref. LSO-AE01667,
wurde am 12 Mai 2003 am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.
Zum Vermerk im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(021637.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
<i>Pour RAKHAM FINANCE S.A.
i>G. Fasbender
<i>Administrateuri>
<i>Pour CASSIS HOLDING S.A.
i>G. Fasbender
<i>Administrateuri>
<i>Pour SBS BROADCASTING S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
26485
ZAMASPORT DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 51.881.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Statutaire du 1i>
<i>eri>
<i> avril 2003i>
Fons Mangen, 147, rue Warken, L-9088 Ettelbruck a été nommé Réviseurs d’Entreprises, en remplacement de la so-
ciété GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., à qui décharge pleine et entière a été accordée pour l’exer-
cice de son mandat jusqu’à la date de ce jour. Le mandat de Fons Mangen viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01204. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021584.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
BHW INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.859.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE02435, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2003.
(021662.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
BRUSSELS CITY PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.566.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1i>
<i>eri>
<i> février 2001i>
Les mandats d’Administrateur de Madame Françoise Dumont, employée privée, 22, C. Aischdall, L-8480 Eischen, de
Monsieur Jean-Paul Rondiat, administrateur de sociétés, Allée Verte 60, Groendreef, B-1000 Bruxelles, de Monsieur
François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer, et de la société FINIM LIMITED, 35-37 New
Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-
CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle pé-
riode statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Fait à Luxembourg, le 1
er
février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01639. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021657.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
BRUSSELS CITY PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.566.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 février 2000i>
La cooptation de la société FINIM LIMITED, Jersey, en tant qu’administrateur en remplacement de Monsieur Hubert
Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2001.
Est nommée Administrateur supplémentaire Madame Françoise Dumont, employée privée, 22, C. Aischdall, L-8480
Eischen. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.
Pour extrait sincère et conforme
ZAMASPORT DISTRIBUTION S.A.
Signature
BHW INVEST, S.à r.l.
Signature
Certifié sincère et conforme
BRUSSELS CITY PROPERTIES S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Certifié sincère et conforme
BRUSSELS CITY PROPERTIES S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
26486
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01641. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021667.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
FINANCIERE DU GLACIS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.415.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 mai 1999i>
- La cooptation de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant au 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm en tant
qu’Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, démissionnaire, est ratifiée.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01647. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021728.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
FINANCIERE DU GLACIS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.415.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 mai 2001i>
- Les mandats d’Administrateurs de Messieurs Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687
Differdange, Alain Renard, employé privé, demeurant au 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm, Jean-Paul Reiland, employé
privé, demeurant au 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen et Marc Limpens, employé privé, demeurant au 34, rue de Vianden,
L-2680 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de l’an 2007.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard
Royal, L-2086 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01648. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021732.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
FINANCIERE DU GLACIS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.415.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 mai 2000i>
- La cooptation de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen en tant
que qu’Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.
- Est nommé Administrateur supplémentaire Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant au 34, rue de Vian-
den, L-2680 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01650. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021734.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Certifié sincère et conforme
FINANCIERE DU GLACIS
Signatures
<i>Administrateursi>
Certifié sincère et conforme
FINANCIERE DU GLACIS
Signatures
<i>Administrateursi>
Certifié sincère et conforme
FINANCIERE DU GLACIS
Signatures
<i>Administrateursi>
26487
SIGMA CAPITAL HOSPITALITY, LEISURE AND TOURISM HOLDING COMPANY S.A., Société
Anonyme.
Registered Office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 90.334.
—
In the year two thousand three, on the twenty-eighth of March.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg,
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders (hereafter the Meeting) of SIGMA CAPITAL HOSPI-
TALITY, LEISURE AND TOURISM HOLDING COMPANY S.A., a public limited company (société anonyme) incorpo-
rated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the instrumenting notary, residing in Luxembourg, of 15th
November, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Number 84 of January 28, 2003, having
its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies Registry
under number B 90.334 (the Company).
The Meeting is chaired by Mr José Correia, accountant, residing in Longwy (France),
The Chairman appoints Mrs Annick Braquet, private employee, residing in B-Chantemelle
as Secretary of the meeting.
The Meeting elects Miss Séverine Canova, lawyer, residing in Thionville (France), as Scrutineer of the Meeting (the
Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau).
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that 5,000 ordinary shares
with a nominal value of
€10 each, representing the entirety of the share capital of the Company of €50,000 are duly
represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agen-
da, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet
after examination of the agenda.
The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the
notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.
II. The agenda of the meeting is worded as follows:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the share capital of the Company by
€450,000 in order to bring the corporate share capital from its
current amount of
€50,000 to €500,000 by way of issuance of 45,000 shares, having a nominal value of €10 each;
2. Waiver of the preferential subscription right by the existing shareholders;
3. Subscription and payment to the share capital decided under item 1.;
4. Decision to amend the share register of the Company in order to reflect the increase and subscription of capital
with power and authority to any employee of CITCO (LUXEMBOURG) S.A., to proceed to the registration of the new-
ly issued shares and their holders in the share register of the Company;
5. Amendment of article 5 of the Company’s articles of association;
6. Amendment of article 7 of the Company’s articles of association.
These facts exposed and recognised accurate by the meeting, and after deliberation, the Meeting passes unanimously
the following resolutions:
<i>First resolution i>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by
€450,000 in order to bring the it from its cur-
rent amount of
€50,000 to €500,000 by way of issuance of 45,000 shares, having a nominal value of €10 each.
<i>Second resolution i>
The Meeting acknowledges that one of the existing shareholders has waived its preferential subscription right.
<i>Subscription and paymenti>
The 45,000 shares so issued being subscribed and paid up by SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT
Ltd, with registered office at Wickhams Cay, PO Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, here represented
by Mrs. Séverine Canova, prenamed, and Mr José Correia, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal on March 25, 2003.
All shares have been fully paid up by contribution in cash, so that the sum of 450,000 is forthwith at the free disposal
of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Third resolution i>
The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the increase and subscription
of capital with power and authority to any employee of CITCO (LUXEMBOURG) S.A., a company organised under the
laws of Luxembourg, having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, to proceed to the registration
of the newly issued shares and their holders in the share register of the Company.
<i>Fourth resolution i>
The Meeting resolves to restate article 5 of the articles of association of the Company, which shall henceforth be
worded, in its English version, as follows:
26488
Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at
€500,000, represented by 50,000 shares with a par value
of
€10 each.
The authorised capital of the incorporation is fixed at
€70,000,000 to be divided into 7,000,000 shares with a par
value
€10 each.
The authorised and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.
The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase
the subscribe capital within the limits et the authorised capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.
The board of directors is specifically authorised to make such issues, without reserving for the then existing share-
holders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorised person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.
After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article will be adapted to this modification.
Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Moreover, the board of directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, with any denomination and
payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorised capital.
Bonds issued by the board of directors must be in a registered form and holders of bonds may not request the con-
version of their registered bonds into bonds in a bearer form.
The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-
ment and any other conditions which may be related to such bond issue.
A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
<i>Fifth resolution i>
The Meeting resolves to restate article 7 of the articles of association of the Company, which shall henceforth be
worded, in its English version, as follows:
Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at request of not less
than two directors.
The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.
In case of urgency, resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex
In the case of a tie, the chairman has a casting vote.
<i>Estimate of costsi>
The amount of the expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately six thousand five hun-
dred Euro (6,500.- EUR).
There being no further business on the agenda, the meeting was terminated.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and German version, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zwei tausend und drei, am achtundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtssitz in Luxemburg .
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft SIGMA CAPITAL HOSPITALITY, LEISURE AND TOURISM HOLDING
COMPANY S.A., gegründet gemäß Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 15. November 2002, veröffentlicht im
Mémorial des Grossherzogtums Luxemburg, Sammlung der Vereinigungen und Gesellschaften, Nummer 84 vom 28. Ja-
nuar 2003, mit Sitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxem-
burg unter Sektion B Nummer B 90.334 (die Gesellschaft), zu einer außerordentlichen Generalversammlung
zusammengetreten (die Generalversammlung).
Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr José Correia, Buchhalter, wohnhaft in F-Longwy.
Der Vorsitzende beruft Dame Annick Braquet, Privatbeamtin, wohnhaft zu B-Chantemelle,
zum Schriftführer.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Fräulein Séverine Canova, Rechtsanwältin, wohnhaft in F-Thionville.
(der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler werden zusammen als Büro bezeichnet).
26489
Das Büro zusammengestellt, der Vorsitzender erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, wel-
che von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:
I. Es ergeht aus einer Anwesenheitsliste, erstellt und bestätigt von den Mitgliedern des Büros, dass das gesamte ge-
zeichnete Gesellschaftskapital von
€50.000, eingeteilt in 5.000 Aktien mit einem Nominalwert von je €10, in der Gene-
ralversammlung vertreten sind, somit die Generalversammlung ordnungsgemäß bestellt ist und zu den Punkten der
hiesigen Tagesordnung abstimmen darf, ohne jegliche vorherige Einberufung. Alle in der Generalversammlung vertreten
Aktionäre sind einverstanden abzustimmen nach Überprüfung der Tagesordnung.
Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, welche von den Anteilnehmern oder deren Bevollmächtigten, den Mit-
gliedern des Büros sowie dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurden, werden gegenwärtiger Urkunde
beigefügt und mit einregistriert.
II. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:
1. Kapitalerhöhung der Gesellschaft um
€450.000 um das Gesellschaftskapital von €50.000 auf €500.000 zu erhöhen,
durch Emission von 45.000 neuen Aktien, von einem Nominalwert von
€10 per Aktie;
2. Verzicht des Zeichnungsprivilegs der gegenwärtigen Aktionäre;
3. Zeichnung und Einzahlung des sub. 1 beschlossenen Kapitals;
4. Beschluss zur Abänderung des Aktienregisters um die Erhöhung und die Zeichnung des Kapitals zu reflektieren und
Vollmacht an jeden Angestellten von CITCO (LUXEMBOURG) S.A. diese Eintragung der neu gezeichneten Aktien und
deren Inhaber vorzunehmen;
5. Abänderung von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung;
6. Abänderung von Artikel 7 der Gesellschaftssatzung.
Diese Fakten vorgetragen, als richtig von der Generalversammlung bestätigt, nach Abstimmung, nimmt die General-
versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschluss i>
Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um
€450.000 zu erhöhen um es von €50.000 auf
€500.000 zu erhöhen, durch Emission von 45.000 neuen Aktien, von einem Nominalwert von €10 per Aktie.
<i>Zweiter Beschluss i>
Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass ein Aktionär auf sein Zeichnungsprivileg verzichtet.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die 45.000 neu emittierten Aktien werden von SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT Ltd, mit Sitz
in Wickhams Cay, PO Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, gezeichnet.
hier vertreten durch Fräulein Séverine Canova, vorbenannt und Herrn José Correia, vorbenannt.
durch eine privatschriftliche Vollmacht, ausgestellt am 25. März 2003.
Das gesamte neu emittierte Kapital wurde vollständig in bar eingezahlt. Somit verfügt die Gesellschaft ab sofort über
einen Betrag von
€450.000, worüber dem amtierenden Notar Nachweis erbracht wurde.
Vorgenannte Vollmacht bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den instrumentierenden
Notar, vorliegender Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
<i>Dritter Beschluss i>
Die Generalversammlung beschließt das Aktienregister abzuändern um die Erhöhung und die Zeichnung des Kapitals
zu reflektieren und erstellt Vollmacht an jeden Angestellten von CITCO (LUXEMBOURG) S.A. diese Eintragung der
neu gezeichneten Aktien und deren Inhaber vorzunehmen.
<i>Vierter Beschluss i>
Die Generalversammlung beschließt Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut, in seiner Deut-
schen Fassung, zu geben:
Art.5. Das Gesellschaftskapital wurde festgesetzt auf
€500.000, eingeteilt in 50.000 Aktien mit einem Nominalwert
von je
€10.
Das genehmigte Gesellschaftskapital wird auf
€70.000.000 festgesetzt, eingeteilt in 7.000.000 Aktien mit einem No-
minalwert von je
€10.
Das genehmigte und gezeichnete Gesellschaftskapital kann aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlussfas-
sung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen.
Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, wahrend einer Zeitspanne von fünf Jahren vom Datum der Veröf-
fentlichung dieser Satzung an gerechnet, des gezeichnete Kapital im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese
Kapitalerhöhungen können gezeichnet und ausgegeben werden mittels Aktien mit oder ohne Ausgabeprämie ganz nach
Belieben des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat ist insbesondere ermächtigt diese Aufstockungen vorzunehmen ohne den jetzigen Aktionen ein
Zeichnungsprivileg auf den auszugebenden Aktien vorzubehalten. Der Verwaltungsrat kann jedem Verwaltungsratsmit-
glied, Direktor oder Prokurist oder jeder anderen ermächtigten Person, Vollmacht erteilen und die Zeichnung n zu emp-
fangen und die Zahlung des Preisas der Aktien welche diese ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, zu
erhalten.
Jedesmal wenn der Verwaltungsrat eine solche Kapitalerhöhung amtlich festgestellt hat, wird dieser Artikel an die
vorgenommene Änderung angepasst.
Die Gesellschaft kann, je nach Wunsch der Aktieninhaber, Global - oder Einzelaktien ausstellen.
Die Aktien können als Namens- oder Inhaberaktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre
Die Gesellschaft kann den Wiederkauf ihrer eignen Aktien unter den gesetzlich gegebenen Bedingungen veranlassen.
26490
Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, in Form einfacher Anleihen, Optionsanleihen
oder Wandelaneihen, unter welcher Bezeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Massgabe,
dass die Ausgabe von Wandelobligationen oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Ka-
pitals erfolgen kann.
Vom Verwaltungsrat emittierte Anleihen müssen in der Form von Namensobligationen sein und die Inhaber solcher
Obligationen können nicht die Umwandlung in Inhaberobligationen beantragen.
Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie
alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe.
Ein Register bezüglich der auf den Namen laufen den Schuldverschreibungen wird am Gesellschaftssitz geführt.
<i> Vierter Beschluss i>
Die Generalversammlung beschließt Artikel 7 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut, in seiner Deut-
schen Fassung, zu geben:
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt eines seiner Mitglieder zum Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat tagt auf Einberufung des Vorsitzanden oder auf Anfrage von zwei Verwaltungsratsmitgeliedern.
Die vom Verwaltungsrat getroffenen Entscheidungen und Beschlüsse sind gültig wenn die Mehrheit der Mitglieder
anwesend oder vertreten ist. Eine Vertretung unter Verwaltungsratsrnitgliedern ist möglich und kann durch Brief, Te-
legramm, Telex oder Fax erfolgen. In Dringlichkeitsfällen können die Verwaltungsratsrnitglieder per Brief, Telegramm,
Telex oder Fax ihre Stimme abgeben. Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit getroffen.
In Dringlichkeitsfällen sind Beschlüsse, die durch alle Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet sind, im gleichen Maße
gültig wie Beschlüsse, die in einer ordentlichen und gültig einberufenen Sitzung genommen werden. Solche Unterschrif-
ten können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Kopien eines gleichen Beschlusses erscheinen und können
per Brief, Fax oder Telex erbracht werden.
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
<i>Schätzung der Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr
€6.500,-
Der unterzeichnende Notar, der englisch versteht, erklärt, dass auf Wunsch der Komparenten, diese notarielle Ur-
kunde in englisch ausgefertigt wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwi-
schen dem englischen und dem deutschen Text, der englische Text vorrangig sein soll.
Worauf diese notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem am Anfang dieser Urkunde angegebenen Tag, ausgefertigt
wurde.
Die Urkunde wurde den Komparenten vorgelesen, die mit dem Notar diese originale Urkunde unterzeichneten.
Gezeichnet: J. Correia, A. Braquet, S. Canova, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, vol. 16CS, fol. 95, case 8. – Reçu 4.500 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Für gleichlautende Abschrift zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations er-
teilt.
(021684.3/220/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
SIGMA CAPITAL HOSPITALITY, LEISURE AND TOURISM HOLDING COMPANY S.A., Société
Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 90.334.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021686.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
WERKFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.141.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01502, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021400.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Luxemburg, den 5. Mai 2003.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 5 mai 2003.
G. Lecuit.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>M. Gillardin / F. Ortelli
<i>Administrateursi>
26491
J.P. MORGAN MULTI-MANAGER STRATEGIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Grève.
R. C. Luxembourg B 65.038.
—
Monsieur Eric Laget a démissionné de son poste d’administrateur de J.P. MORGAN MULTI-MANAGER STRATEGIES
FUND, SICAV (la «Société») avec effet au 11 octobre 2001 et le conseil d’administration de la Société a décidé en date
du 4 décembre 2001 de nommer avec effet au 4 décembre 2001 Monsieur Scott E. Stein en tant qu’administrateur de
la Société en remplacement de Monsieur Eric Laget.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01740. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021957.3/0/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.
LUXDING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 29.936.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée ordinaire du 13 mars 2003i>
1. La nouvelle adresse du siège est désormais: p/a FIDUCIAIRE PRINCIPALE, 15, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00435. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(021983.3/0/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.
ALICE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 57.653.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée extraordinaire du 8 avril 2003i>
1. La nouvelle adresse du siège est désormais: p/a FIDUCIAIRE PRINCIPALE, 15, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01105. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(021985.3/0/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.
HCD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.818.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 mars 2003i>
- La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monte-
rey, L-2086 Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire,
est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.
Fait à Luxembourg, le 19 mars 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01646. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021721.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signature
J.-R. Marquilie / R. Bonnet / F. Marquilie
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
J.-R. Marquilie / R. Bonnet / F. Marquilie
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Certifié sincère et conforme
HCD HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
26492
GYPSUM 2001 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 78.452.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 21 juin 2002i>
L’Assemblée procède à l’élection définitive en qualité d’administrateur de Monsieur Giovanni Vittore, coopté en rem-
placement de Madame Giovanna Giustiniani, administrateur démissionnaire, par le Conseil d’Administration en date du
24 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01419. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(021402.3/815/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered Office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.234.
—
In the year two thousand three, on the twenty-seventh of March.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A.,
incorporated under the name of INSINGER ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme, having
its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on December 19, 1997, published
in the Mémorial, Recueil C number 55 of January 24, 1998, the articles of incorporation have been modified by several
deeds of the undersigned notary and for the last time on November 17, 1999, published in the Mémorial, Recueil C
number 38 of January 12, 2000.
The meeting was opened by Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in Nothomb (Belgium),
being in the chair,
who appointed as secretary Mr Christian Tailleur, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Deborah Buffone, private employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. To appoint Mr Christian Tailleur, General Director, born in Metz on May 17, 1967, residing at L-1750 Luxembourg,
66 avenue Victor Hugo, as director of the company and to accept the resignation of Mr Jean-Jacques Druart, private
employee, residing at B-Etalle as director of the company, with honourable discharge, immediately upon execution of
the present deed.
2. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following sole resolution:
<i> Sole resolutioni>
The general meeting decides to appoint Mr Christian Tailleur, General Director, born in Metz on May 17, 1967, re-
siding at L-1750 Luxembourg, 66 avenue Victor Hugo, as director of the company and to accept the resignation of Mr
Jean-Jacques Druart, private employee, residing at B-Etalle as director of the company, and declares that full discharge
is granted to him for the exercise of his mandates.
The board of director of the company is composed henceforth as follows:
- Mr Christian Tailleur, Director, born in Metz on May 17, 1967, residing at L-1750 Luxembourg, 66 avenue Victor
Hugo;
- Mr Peter Sieradzki, Director, born in Durban (South Africa) on February 5, 1957, residing at Herengracht, 537 -
1017 BV Amsterdam, The Netherlands;
- Mr Rob Mooij, Director, born in Amsterdam on May 1, 1953, residing at Herengracht, 537 - 1017 BV Amsterdam,
The Netherlands;
- Mr Frans Kee, Director, born in Krommenie on January 3, 1953, residing at Herengracht, 537 - 1017 BV Amsterdam,
The Netherlands;
- Mr Claude Beffort, Director, born in Luxembourg, on March 20, 1962, residing at L-1750 Luxembourg, 66 avenue
Victor Hugo.
There being no further business, the meeting is terminated.
GYPSUM 2001 S.A.
Signatures
26493
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately seven hundred and fifty Euro
(750.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mil trois, le vingt-sept mars.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INSINGER DE BEAUFORT
(LUXEMBOURG) S.A., constituée sous le dénomination de INSINGER ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 19 décembre 1997, publié
au Mémorial, Recueil C numéro 55 du 24 janvier 1998, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises suivant actes
du notaire instrumentant, et en dernier lieu le 17 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 38 du 12 jan-
vier 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de
Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (Belgique),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Christian Tailleur, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Deborah Buffone, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:
<i> Ordre du jour:i>
1. Nomination de Monsieur Christian Tailleur, directeur général, né à Metz le 17 mai 1967, demeurant à L-1750
Luxembourg, 66 avenue Victor Hugo, en qualité d’administrateur de la société et d’accepter la démission de Monsieur
Jean-Jacques Druart, employé privé, demeurant à B-Etalle, en tant qu’administrateur de la société, avec décharge hono-
rable, avec effet à la signature de l’acte notarié.
2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-
gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de nommer Monsieur Christian Tailleur, Directeur Général, né à Metz le 17 mai 1967, demeurant
à L-1750 Luxembourg, 66 avenue Victor Hugo, en qualité d’administrateur de la société et d’accepter la démission de
Monsieur Jean-Jacques Druart, employé privé, demeurant à B-Etalle, en tant qu’administrateur de la société, et déclare
que décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
Le conseil d’administration est désormais composé comme suit:
- Monsieur Christian Tailleur, Administrateur, né à Metz le 17 mai 1967, demeurant à L-1750 Luxembourg, 66 avenue
Victor Hugo;
- Monsieur Peter Sieradzki, administrateur, né à Durban (Afrique du Sud) le 5 février 1957, demeurant à Herengracht,
537 - 1017 BV Amsterdam (Pays-Bas);
- Monsieur Rob Mooij, administrateur, né à Amsterdam le 1
er
mai 1953, demeurant à Herengracht, 537 - 1017 BV
Amsterdam (Pays-Bas);
- Monsieur Frans Kee, administrateur, né à Krommenie le 3 janvier 1953, demeurant à Herengracht, 537 - 1017 BV
Amsterdam (Pays-Bas);
- Monsieur Claude Beffort, Administrateur, né à Luxembourg, le 20 mars 1962, demeurant à L-1750 Luxembourg, 66
avenue Victor Hugo.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, à environ sept cent cinquante Euros (750,-
EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
26494
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Tassigny, C. Tailleur, D. Buffone, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, vol. 138S, fol. 64, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(021675.3/220/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
IB MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme,
(anc. EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.699.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021666.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
MENUISERIE MAJOIE MICHEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8422 Steinfort, 71, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 73.229.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Steinfort le 9 mai 2003i>
Il résulte dudit procès-verbal décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute
responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.
<i>Administrateur-déléguéi>
Monsieur Michel Majoie, maître menuisier, demeurant 119, route de Luxembourg à L-8077 Bertrange
<i>Administrateursi>
Madame Marlène Knol, éducatrice, demeurant 119, route de Luxembourg à L-8077 Bertrange
Monsieur Henk Knol, directeur d’école, demeurant à NL-3766 ET Soest
<i>Commissaire aux comptesi>
BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
Pétange, le 9 mai 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE01970. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021411.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
LABORATOIRE DENTAIRE HORNBECK JACQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 7, rue Nic. Bové.
R. C. Luxembourg B 51.917.
—
<i>Résolution de l’Associé Unique du 10 avril 2003i>
Le soussigné, Monsieur Jacques Hornbeck, gérant, demeurant à Luxembourg, associé unique de la Société, décide de
transférer le siège de la Société de L-2561 Luxembourg, 105 Rue de Strasbourg, à L-1253 Luxembourg, 7 Rue Nic. Bové.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01564. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021696.3/537/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Luxembourg, le 5 mai 2003.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 5 mai 2003.
G. Lecuit.
<i>Pour la société
i>Signature
Le 29 avril 2003.
J. Hornbeck.
26495
PENTE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.329.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of May 28, 2002i>
The co-option of Mr. Sandro Capuzzo, private employee, professional address at 23, avenue Monterey, L-2086 Lux-
embourg as a Director in replacement of Mr. Giancarlo Cervino who resigned is ratified. His mandate will lapse at the
Annual General Meeting of the year 2005.
Luxembourg, May 28, 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01652. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021737.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
HINES HOLDINGS LUXEMBOURG 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: 64,989,600.- USD.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 79.934.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of March 17th, 2003i>
The cooption of LOUV, S.à r.l. with registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg as a Manager of
the Company in replacement of FINIM LIMITED who resigned is ratified. His mandate will lapse at the Annual General
Meeting of convened for the approval of the annual accounts as of August 31st, 2003.
Luxembourg, March 17th, 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01655. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021745.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
LAZARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 54.288.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée extraordinaire du 14 mars 2003i>
1. La nouvelle adresse du siège est désormais: p/a FIDUCIAIRE PRINCIPALE, 15, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01583. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(021988.3/0/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.
RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 86.683.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE08003, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2003.
(021591.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
For true copy
PENTE HOLDING S.A.
S. Capuzzo / P. Mestdagh
<i>Directorsi>
For true copy
HINES HOLDINGS LUXEMBOURG 1, S.à r.l.
Signatures
<i>Managersi>
J.-R. Marquilie / R. Bonnet / F. Marquilie
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures
26496
RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.363.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02005, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2003.
(021594.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EUROPEEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 71.867.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01434, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021663.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
ALINE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 53.656.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée ordinaire du 31 mars 2003i>
1. Continuation de l’exploitation malgré la perte de plus de la moitié du capital.
2. La nouvelle adresse du siège est désormais: p/a FIDUCIAIRE PRINCIPALE, 15, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01571. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(021986.3/0/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.
FIDUCIAIRE LAUNACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 27.451.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée extraordinaire du 8 avril 2003i>
1. La nouvelle adresse du siège est désormais: p/a FIDUCIAIRE PRINCIPALE, 15, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01107. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(022001.3/0/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.
RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
J.-R. Marquilie / R. Bonnet / F. Marquilie
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
F. Marquilie / R. Bonnet / J.-R. Marquilie
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
World Holding Company S.A.
Citifunds Investment Series
Outremer Investments S.A.
PEH Sicav
Tilburg International S.A.
Tilburg International S.A.
Coyote Software, S.à r.l.
Dumatin S.A.
Business Time Center, S.à r.l.
Business Time Center, S.à r.l.
Forum pour l’Europe de l’Ouest Princesse Anastasia Romanov
Heip Investments S.A.
G.D. Group Investments S.A.
G.D. Group Investments S.A.
CESD-Communautaire
Caron International S.A.
Yerania S.A.
Gargano S.A.
Finalourec
A Bis Z Promotions S.A.
Bureau Modugno, S.à r.l.
HCD Holding S.A.
Kapla World S.A.
Charisma Sicav
Phitex S.A.
Dharma Holdings S.A.
Dharma Holdings S.A.
Passing Shot S.A.
Parsiflor
Spanimmo
TMD International Holding S.A.
Specialty Materials Investors, S.à r.l.
Tuttogratis S.A.
Master-Finance S.A.
Sodevim
Panorama, S.à r.l.
Panorama, S.à r.l.
Socepal
Sarlat S.A.
Rakham Finance S.A.
Cassis Holding S.A.
SBS Broadcasting S.A.
Munich Invest
Zamasport Distribution S.A.
BHW Invest, S.à r.l.
Brussels City Properties S.A.
Brussels City Properties S.A.
Financière du Glacis
Financière du Glacis
Financière du Glacis
Sigma Capital Hospitality, Leisure and Tourism Holding Company S.A.
Sigma Capital Hospitality, Leisure and Tourism Holding Company S.A.
Werkfin S.A.
J.P. Morgan Multi-Manager Strategies Fund
Luxding Holding S.A.
Alice Holding S.A.
HCD Holding S.A.
Gypsum 2001 S.A.
Insinger de Beaufort (Luxembourg) S.A.
IB Management Services S.A.
Menuiserie Majoie Michel S.A.
Laboratoire Dentaire Hornbeck Jacques, S.à r.l.
Pente Holding S.A.
Hines Holdings Luxembourg 1, S.à r.l.
Lazare S.A.
Rabo Management Services, S.à r.l.
Rabobank Corporate Services Luxembourg S.A.
Recherche et Développement Européen Holding S.A.
Aline Holding S.A.
Fiduciaire Launach S.A.