This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
82945
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1729
4 décembre 2002
S O M M A I R E
A Bis Z Promotions S.A., Belvaux . . . . . . . . . . . . . .
82992
Heaters Promotions & Marketing S.A., Luxem-
A Bis Z Promotions S.A., Belvaux . . . . . . . . . . . . . .
82992
bourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82948
A Bis Z Promotions S.A., Belvaux . . . . . . . . . . . . . .
82992
Hymar Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
82991
AB-Road, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82967
Inland Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
82955
Acronic Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
82954
Inland Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
82955
Adhésifs, S.à r.l., Leudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82951
Inland Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
82956
AGEDOC, Association pour la Gestion des Ecoles
Isomax Castellum Investment A.G., Luxembourg-
de la Doctrine Chrétienne, Luxembourg . . . . . . .
82975
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82950
Alcotrade S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .
82950
Itson Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
82985
Andante Vivace S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
82975
Jade Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
82981
Banket S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82961
Kypselux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82946
Big Blue S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82974
Laumar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82954
Bindura S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82975
Lighthouse Holdings Limited S.A., Luxembourg. .
82949
Bonzba Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
82980
Lousseau Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
82955
Box Delivery S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
82981
Lucilinburhuc (LBH) S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
82956
Carter Transport, GmbH, Luxemburg . . . . . . . . . .
82969
M & G Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
82951
Chemical Transport S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
82952
Marcon S.A., Maritime Construction S.A., Luxbg .
82951
Christopher, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
82980
MGO Lux S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . .
82948
Citation Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
82947
Morgana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
82953
City-Image, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . .
82952
Mossi & Ghisolfi International S.A., Luxembourg .
82950
Coleen S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82991
Mossi & Ghisolfi International S.A., Luxembourg .
82950
Crochat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82946
Mossi & Ghisolfi Overseas S.A., Luxembourg . . . .
82952
Edwardian Investments S.A., Luxembourg-Kirch-
Mossi & Ghisolfi Overseas S.A., Luxembourg . . . .
82952
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82949
Net Management Consulting S.A., Luxembourg .
82953
Eiger S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82990
Nicolas International Holding S.A., Luxembourg .
82955
Espirito Santo Fashion Investments S.A., Luxem-
Noble Real Estate S.A., Luxembourg-Kirchberg . .
82948
bourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82951
Outstanding Productions S.A., Olm . . . . . . . . . . . .
82953
Espirito Santo Services S.A., Luxembourg-Kirch-
R.T.C. Group Soparfi S.A., Luxembourg-Kirchberg
82947
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82949
RN Express Line S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
82972
Espirito Santo Services S.A., Luxembourg-Kirch-
Seahorse S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .
82947
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82949
Sirius Transformation Support, S.à r.l., Luxem-
Eurostone S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .
82948
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82962
EWC, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82954
Solage Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
82991
Faircross S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82981
Solid Partners Luxembourg S.A., Bereldange . . . .
82954
Fausis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82985
(Den) Top, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
82953
Fiduciaire Eurolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
82947
Totl S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82946
Financière Versailles, S.à r.l. sub 3, Luxembourg . .
82985
Trinity Management Partners, S.à r.l., Luxem-
Future Vision Consulting S.A., Luxembourg . . . . . .
82991
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82956
Gleniffer S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . .
82948
Wolford Investments S.A., Luxembourg-Kirch-
Global Vision S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82946
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82947
82946
CROCHAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 80.062.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol.
576, fol. 28, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82087/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
GLOBAL VISION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 77.826.
—
<i>Notule du Conseil d’Administration du 21 octobre 2002i>
Sont présents
Monsieur Johan Van den Berg
Monsieur Herman Swannet
Monsieur Sven Janssens
Madame Belgin Kurban
Il est convenu et agréé à la majorité des voix que Monsieur Van Den Berg Johan dispose d’une co-signature obliga-
toire.
Est agrée aussi la démission de Monsieur Van Lieshout en tant que commissaire aux comptes.
L’assemblée nomme en remplacement la société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. en tant que commissaire aux comp-
tes.
Enregistré à Remich, le 11 novembre 2002, vol. 177, fol. 68, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. Molling.
(82093/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
TOTL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 51.533.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 octobre 2002 a renouvelé les mandats des administrateurs
et du commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 décembre
2001. Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 576, fol. 28, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82098/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
KYPSELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 45.106.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82115/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,89 EUR
- Perte de l’exercice 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 20.351,84 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 20.349,95 EUR
Signature.
Fait à Remich, le 21 octobre 2002.
J. Van den Berg / H. Swannet / S. Janssens / B. Kurban.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2002.
F. Kesseler
82947
FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 34.752.
—
Les statuts coordonnés au 1
er
juillet 2002, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82129/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
CITATION HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 17.438.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CITATION
HOLDINGS S.A., tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 30 septembre 2002 que:
- L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue
Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17 avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 576, fol. 1, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82134/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
WOLFORD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 50.884.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 34, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2002.
(82136/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
SEAHORSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 72.949.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2002.
(82139/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
R.T.C. GROUP SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 83.179.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2002.
(82140/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Signature.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
82948
NOBLE REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 63.974.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 34, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2002.
(82141/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
MGO LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 77.060.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 34, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 novembre 2002.
(82145/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
HEATERS PROMOTIONS & MARKETING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 66.587.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2002.
(82146/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
GLENIFFER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 38.485.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 34, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2002.
(82147/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
EUROSTONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 46.542.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 34, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2002.
(82148/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
82949
ESPIRITO SANTO SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 23.930.
—
Le bilan au 31 décembre 2001 enregistré à Luxembourg le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2002.
(82149/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
ESPIRITO SANTO SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 23.930.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors d’une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 octobre 2002i>
«Le Conseil d’Administration prend connaissance, avec un profond regret, du décès de M. Rui Barros Costa, Manager
de la société, survenu en date du 19 avril 2002.
Après délibérations, le Conseil d’Administration à l’unanimité décide d’accepter la démission de M. José Pedro Cal-
deira da Silva de sa fonction de Manager avec effet immédiat.»
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82153/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
EDWARDIAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 81.763.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 34, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2002.
(82150/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
LIGHTHOUSE HOLDINGS LIMITED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 84.993.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire en date du 30 octobre 2002i>
- In accordance with the article 100, Law 10 August 1915, the Meeting decided that the Company shall continue its
activities.
- The Meeting accepted the resignation of Mr. Peter Veenendal as Director of the Company and gave him discharge
for the performance of his mandate until the date of his resignation.
- The Meeting decided to ratify appointment of Mr. Rene van Hemert as Director of the Company; appointment al-
ready approved by a Board Meeting of the Directors held on the 24 April 2002.
- The Meeting accepted the resignation of Mr. Robin Ambler as Director of the Company with effect as from this day
and gave him discharge for the performance of his mandate until the date of his resignation.
- The Meeting accepted the appointment as new Director of the Company for a period expiring on the date of the
Statutory General Meeting to be held in 2007, with immediate effect:
Emma Simmons, Company Director, residing 47, Lewin Road, East Sheen, London S W14 DR, United Kingdom
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576 fol. 48, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82178/587/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Certifié conforme, ce 2 octobre 2002
<i>Pour le Conseil d’administration
i>A. L. Roquette Ricciardi / M. F. M. Galvão Espírito Santo Silva
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société
i>A. Heinz
82950
ALCOTRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 61.375.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 34, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2002.
(82151/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
ISOMAX CASTELLUM INVESTMENT A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 36.721.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 octobre 2002 que M. Marc
Schmit, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a
été nommé aux fonctions d’administrateur, en remplacement de Mme Anneliese Krecké-Nolde, démissionnaire.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82152/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 66.955.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 16 octobre 2002i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée révoque le Commissaire aux Comptes, ANDERSEN REVISEURS D’ENTREPRISES, 6, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, et le remercie pour son activité jusqu’à ce jour.
L’assemblée décide de nommer DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2002 à la fonction de Commissaire aux Comptes.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82159/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 66.955.
—
<i>Convention de domiciliationi>
La Convention de Domiciliation conclue entre la société anonyme MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., avec
siège social à L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.,
avec siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant, pour une durée indéterminée et
susceptible d’être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois, a été résiliée au 31 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82161/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signatures
Aux fins de réquisition
MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signatures
82951
ESPIRITO SANTO FASHION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 66.378.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 août 2002 et de l’assemblée générale gé-
nérale extraordinaire tenue le 14 octobre 2002 que:
- M. Rui Barros Costa, Administrateur, est décédé en date du 19 avril 2002,
- la nomination, en son remplacement et avec effet immédiat, de M. Olivier Thevoz, comptable, demeurant au 20,
chemin de Mourat, 1095 Lutry, Suisse, aux fonctions d’administrateur, a été ratifiée.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82154/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
M & G LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 85.435.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 16 octobre 2002i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée révoque le Commissaire aux Comptes, ANDERSEN REVISEURS D’ENTREPRISES, 6, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, et le remercie pour son activité jusqu’à ce jour.
L’assemblée décide de nommer DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2002 à la fonction de Commissaire aux Comptes.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82158/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
MARCON S.A., MARITIME CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 61.471.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration du 1
er
octobre 2002 que le siège social est trans-
féré, avec effet immédiat, de son adresse actuelle 42, rue de Clausen, L-1342 Luxembourg au 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 72, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82193/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
ADHESIFS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3380 Leudelange, 8, Z.I. Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 67.993.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82206/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
M & G LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
Signatures
MARCON S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Signature.
82952
MOSSI & GHISOLFI OVERSEAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 73.195.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 16 octobre 2002i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée révoque le Commissaire aux Comptes, ANDERSEN REVISEURS D’ENTREPRISES, 6, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, et le remercie pour son activité jusqu’à ce jour.
L’assemblée décide de nommer DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2002 à la fonction de Commissaire aux Comptes.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82160/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
MOSSI & GHISOLFI OVERSEAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 73.195.
—
<i>Convention de domiciliationi>
Contrat de Domiciliation conclu entre la société anonyme MOSSI & GHISOLFI OVERSEAS S.A., avec siège social à
L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., avec siège social
au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant, pour une durée indéterminée et susceptible d’être
dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois, a été résilié au 31 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82162/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
CHEMICAL TRANSPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 59.030.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 7 mai 2002i>
Il résulte du procès-verbal de cette assemblée générale ordinaire des actionnaires qu’à l’unanimité des voix, l’assem-
blée a accordé décharge pleine et entière à l’administrateur démissionnaire Monsieur Leo Staut au 7 juin 2002 et a nom-
mé définitivement Monsieur Noël Delaby afin d’achever le mandat de l’administrateur démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 42, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82196/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
CITY-IMAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3370 Leudelange, Z.I. Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 60.050.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82207/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
MOSSI & GHISOLFI OVERSEAS S.A.
Société Anonyme
Signatures
Aux fins de réquisition
MOSSI & GHISOLFI OVERSEAS S.A.
Société Anonyme
Signatures
Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Signature.
82953
MORGANA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.335.
—
RECTIFICATIF
Erratum à l’enregistrement au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002, Vol. 571, Fol.
100, Case 7, et déposé au registre de commerce des sociétés de Luxembourg le 14 août 2002.
Une réquisition de publication portant sur la démission de M. Simone Strocchi en qualité d’Administrateur et la coop-
tation d’un nouvel Administrateur, M. Guy Nimax, a été présentée de façon erronée en date du 6 août 2002, aux fins
de la publication et déposé au registre de commerce et doit, par conséquent, être modifiée comme suit:
<i>Première résolutioni>
Le Conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Simone Strocchi de sa fonction d’Administrateur,
décide d’accepter cette démission. Le Conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Le Conseil coopte comme nouvel Administrateur, avec effet au 15 juin 2002, Monsieur Guy Nimax, demeurant à
Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par prochaine assemblée générale de la Société, conformé-
ment à la loi et aux Statuts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82164/024/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
DEN TOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 8, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 79.368.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82208/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
OUTSTANDING PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8333 Olm, 22, rue Abraham Lincoln.
R. C. Luxembourg B 76.896.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82209/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
NET MANAGEMENT CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 73.970.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82210/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour extrait conforme
<i>Pour MORGANA HOLDING S.A.
Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Signature.
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Signature.
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Signature.
82954
LAUMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.988.
—
RECTIFICATIF
Erratum à l’enregistrement au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002, Vol. 571, Fol.
30, Case 6, et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 23 juillet 2002.
Une réquisition de publication déposée le 23 juillet 2002, ayant pour objet l’extrait d’une résolution prise par l’As-
semblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002, portant sur la conversion de Lires italiennes en Euro du capital sous-
crit et du capital autorisé de la Société, avec effet au 1
er
janvier 2002, a été présentée en date du 19 juillet 2002, aux fins
de la publication et déposé au registre de commerce, et doit être modifiée, partiellement, comme suit:
«la dénomination sociale exacte de la Société de référence est LAUMAR S.A. (et non pas LAUMAR HOLDING S.A.).»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82165/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
EWC, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 52.000.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82211/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
SOLID PARTNERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 83.534.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82212/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
ACRONIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 70.177.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ACRONIC
HOLDINGS S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 30 septembre 2002 que:
L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue
Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82260/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour extrait conforme
<i>Pour LAUMAR S.A.
Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Signature.
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Signature.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
82955
LOUSSEAU HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 20.987.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 44, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82217/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
NICOLAS INTERNATIONAL HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 61.258.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 44, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82218/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
INLAND SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
R. C. Luxembourg B 69.498.
—
<i>Extract of the minutes of the annual ordinary meeting of shareholders held on the 7th May 2002i>
... After full discussion, the Chairman then submits to the vote of the meeting the following resolutions which were
all adopted by unanimous vote.
The General meeting:
1
°
resolved to approve the Annual Report of the Board of Directors and the report of the Auditor
2
°
resolved to approve the Annual Account as per 31 December 2001 and the profit to be carried forward as follows:
74,568.- LUF for income tax provision and 113,611.- LUF to be carried forward.
3
°
resolved to carry a part of the previous profit (which had been carried forward) as follows: 25,000.- LUF for the
legal reserve and 816,094.- LUF for income tax provision.
4
°
resolved to grant full discharge for the proper performance of the duties of the Directors and the statutory auditor
during the accounting period covered by the accounts submitted.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 42, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82189/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
INLAND SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
R. C. Luxembourg B 69.498.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 7 janvier 2002 que le siège social est transféré,
avec effet au 1
er
janvier 2002, de son adresse actuelle 42, rue de Clausen, L-1342 Luxembourg au 3, rue de la Loge,
L-1945 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 42, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82194/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Signatures.
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Signature.
For true extract
<i>The managing director
i>Signatures
INLAND SHIPPING S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
82956
INLAND SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
R. C. Luxembourg B 69.498.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 7 septembre 2002 que le Conseil a nommé
Monsieur E.E. van Rheede van den Kloot en qualité d’administrateur en remplacement de l’administrateur Monsieur
Marc van der Linden, décédé. Le mandat de Monsieur E.E. van Rheede van den Kloot sera confirmé lors de la prochaine
Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 42, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82195/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
LUCILINBURHUC (LBH), Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 51.242.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 44, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82219/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
TRINITY MANAGEMENT PARTNERS, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
—
STATUTES
In the year two thousand and two, on the twenty-third of October.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
1.- Mr Mariusz Sulmirski, contractor, residing at PL-00-034 Warszawa, 11/18 Warecka Street, (Poland).
2.- Mr Tomasz Olszewski, economist, bank manager, residing at PL-07-306 Brok, 11a Plac Koscielny, (Poland).
3.- Mr Aleksander Jawien, economist, residing at PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street, (Poland).
All are here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, av-
enue de la Faïencerie, by virtue of three proxies given under private seal.
Such proxies having been signed ne varietur by the notary and the attorney, will remain attached to the present deed
in order to be recorded with it.
Such appearing parties, represented as said before, have stated that they have formed a private limited company
whose articles of association have been fixed as follows:
Art. 1. Among the owners of the sharequotas hereinafter issued and those which might be issued later on, there is
hereby established a private limited company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) which will be governed by the
laws in force and by the one of August 10, 1915 concerning trade companies mainly and by the present articles of asso-
ciation.
Art. 2. The company’s name is TRINITY MANAGEMENT PARTNERS.
Art. 3. The company’s object is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations
in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of sup-
port, loans, advances and guarantees to companies in which it has a direct or indirect participation.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-
curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
of the Grand Duchy of Luxembourg by the mere decision of the shareholders.
INLAND SHIPPING S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Signature.
82957
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) represented by 80 (eighty) A
sharequotas of 125.- (one hundred and twenty-five Euros) each, and by 20 (twenty) B sharequotas of 125.- (one hundred
and twenty-five Euros) each, which have been subscribed as follows:
The A and B sharequotas have the same rights.
The subscribers state and acknowledge that the 80 (eighty) A sharequotas have been fully paid up by contribution in
cash of 540,000.- (five hundred and forty thousand Euros); 10,000.- (ten thousand Euros) representing the capital and
530,000.- (five hundred and thirty thousand Euros) representing an agio and that the 20 (twenty) B sharequotas have
been fully paid up by contribution in cash of 2,500.- (two thousand five hundred Euros) so that the amount of 542,500
(five hundred and forty two thousand five hundred Euros) is now at the free disposal of the company, evidence hereof
having been given to the undersigned notary.
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense
of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. that any decision of the sole shareholder as well as any contract between the latter
and the company must be recorded in writing and that the provisions regarding the general shareholders’ meetings are
not applicable.
Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes one owner of each sharequota
only. If there are several owners of one sharequota, the company is entitled to suspend the related rights until one sole
person has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in
case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and
his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the
usufructuary only.
Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to shareholders or to third parties is conditional upon the approval
of the general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of
sharequotas mortis causa to shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general sharehold-
ers’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to compulsory portion or to the
surviving spouse. If the transfer is not approved in either hypothesis, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.
The preemption right which is not exercised by one or several shareholders falls proportionally to the other share-
holders. Use must be made of it within a period of three months after the refusal of approval. If the preemption right is
not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.
Art. 9. Beside his contribution each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make
cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account
between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed by
the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an ad-
ditional contribution and the shareholder will be recognized as creditor of the company with respect to this amount
and the interests.
Art. 10. The death, the interdiction, the bankruptcy or the insolvency will not put an end to the company. In case
of death of a shareholder, the company will go on between the remaining shareholders and the legal heirs.
Art. 11. The creditors, the assignees and the heirs of the shareholders may not for whatever reason affix seals to
the property and the documents of the company, nor may they interfere in any manner in the management of the com-
pany. They have to refer to the company’s inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, shareholders or third parties. The
power of a manager is determined by the general shareholders’ meeting when he is appointed. The mandate of manager
is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting deliberating with a majority of
votes.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the company
judicially and extra judicially.
1.- Mr Mariusz Sulmirski, contractor, residing at PL-00-034 Warszawa, 11/18 Warecka Street, (Poland), eighty
A sharequotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2.- Mr Tomasz Olszewski, economist, bank manager, residing at PL-07-306 Brok, 11a Plac Koscielny, (Poland),
ten B sharequotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.- Mr Aleksander Jawien, economist, residing at PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street, (Poland), ten B sharequotas
10
Total: one hundred sharequotas of the categories A and B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
82958
The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,
but only within the limits to be determined by the power of attorney.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by the board of managers, if there is enough cash. Otherwise, the
decision has to be taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; mere agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by the shareholders who represent more
than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by unan-
imous vote of all the shareholders representing the whole corporate capital.
Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December.
Art. 16. Each year, at the thirty-first of December, the management will draw up the annual accounts and will submit
them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve will amount to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.
Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by
the management or any other person appointed by the shareholders.
When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the sharequotas they are holding.
Possible losses are apportioned alike, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 20. With respect to all that is not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled insofar as the company’s business is concerned by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory provisioni>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2002.
<i>Valuation of the costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand nine hundred
Euros.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the company, the shareholders representing the entire corporate capital, held
an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions after having acknowledged that they
have been validly convened with full knowledge of the agenda and after having deliberated.
<i>First resolutioni>
Mr Aleksander Jawien, economist, residing at PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street, (Poland), and the private limited
company BAC MANAGEMENT, S.à r.l., with its registered office at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,
are appointed as managers for an unlimited duration with the power to bind the company in all circumstances by their
joint signatures.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
attorney, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
attorney and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing attorney, known to the notary, by his surname, Christian name,
civil status and residence, the said appearing party signed together, with us, the notary, the present deed.
82959
Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendzwei, den dreiundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1.- Herr Mariusz Sulmirski, Bauunternehmer, wohnhaft in PL-00-034 Warszawa, 11/18 Warecka Street, (Polen).
2.- Herr Tomasz Olszewski, Betriebswirt, Bankdirektor, wohnhaft in PL-07-306 Brok, 11a Plac Koscielny, (Polen).
3.- Herr Aleksander Jawien, Betriebswirt, wohnhaft in PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street, (Polen).
Alle sind hier vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxembourg, 121,
avenue de la Faïencerie, aufgrund von drei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.
Diese Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden
Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, haben erklärt, dass sie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gegründet haben, deren Satzung sie wie folgt festgelegt haben:
Art. 1. Zwischen den Besitzern der nachstehend geschaffenen Gesellschaftsanteile und derjenigen Anteile, die spä-
terhin noch ausgegeben werden könnten, wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche
den in Kraft befindlichen Gesetzen und insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.
Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung TRINITY MANAGEMENT PARTNERS an.
Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Be-
teiligungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen
und den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss
oder Sicherheit gewähren.
Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,
Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräussern. Darüber hinaus kann die Ge-
sellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwerten und
veräussern.
Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von sowohl
in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.
Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-
licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums
Luxemburg durch einfachen Beschluss der Teilhaber verlegt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur stattfinden oder nahe bevorstehen, wel-
che die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die unbeschwerte Kommunikation dieses Gesellschaftssitzes mit
dem Ausland gefährden, dann kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung der ausserge-
wöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden. Ein solcher Beschluss hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Ge-
sellschaft. Die Mitteilung über die Sitzverlegung erfolgt und wird Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft
übermittelt, welches sich unter den gegebenen Umständen hierzu am besten eignet.
Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) festgesetzt, dargestellt durch 80
(achtzig) A Anteile von je 125,- (hundertfünfundzwanzig Euro) und durch 20 (zwanzig) B Anteile von je 125,- (hundert-
fünfundzwanzig Euro) welche wie folgt gezeichnet worden sind:
Die A und B Anteile haben dieselben Rechte.
Die Komparenten, welche die Anteile gezeichnet haben, erklären und bejahen, dass die 80 (achtzig) A Anteile voll
und ganz eingezahlt worden sind durch Bareinzahlung von 540.000,- (fünfhundertvierzigtausend Euro) wovon 10.000,-
(zehntausend Euro) das Kapital und 530.000,- (fünfhundertdreissigtausend Euro) ein Aufgeld darstellen, und dass die 20
(zwanzig) B Anteile voll und ganz in bar eingezahlt worden sind, so dass die Summe von 542.500,- (fünfhundertzweiund-
vierzigtausendfünfhundert Euro) ab sofort zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, so wie dies dem instrumentie-
renden Notar nachgewiesen worden ist.
Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, dann ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im
Sinne von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen,
die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. dass jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie
jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft schriftlich festgehalten werden muss und dass die Bestimmungen über
die Generalversammlungen der Teilhaber nicht anwendbar sind.
Herr Mariusz Sulmirski, Bauunternehmer, wohnhaft in PL-00-034 Warszawa, 11/18 Warecka Street, (Polen),
achtzig A Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
2. Herr Tomasz Olszewski, Betriebswirt, Bankdiretor, wohnhaft in PL-07-306 Brok, 11a Plac Koscielny, (Polen),
zehn B Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.- Herr Aleksander Jawien, Betriebswirt, wohnhaft in PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street, (Polen), zehn B An-
teile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: hundert Anteile der Kategorien A und B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
82960
Art. 7. Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die für jeden Anteil nur einen einzigen Eigentümer an-
erkennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, dann kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden
Rechte in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, welche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso
verhält es sich bei einem Konflikt zwischen dem Niessbrauchberechtigten und dem «nackten» Eigentümer oder zwi-
schen dem durch Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner. Die Stimmrechte der mit dem Niessbrauch belasteten An-
teile werden jedoch nur vom Niessbrauchberechtigten ausgeübt.
Art. 8. Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer
Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.
Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Ge-
neralversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, welches
den überlebenden Teilhabern gehört.
Diese Genehmigung ist nicht erfordert, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder an den überlebenden
Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, dann haben
die verbleibenden Teilhaber ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.
Das von einem oder mehreren Teilhabern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Teilhaber
über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden.
Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages
nach sich.
Art. 9. Ausser seiner Gesellschaftseinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teil-
haber, der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein
spezielles Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu
einem Satz welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen
werden als allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht.
Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als
zusätzliche Gesellschaftseinlage zu betrachten, und der Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der
Gesellschaft anerkannt.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die
Zahlungsunfähigkeitserklärung eines Teilhabers. Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen
den überlebenden Teilhabern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.
Art. 11. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Doku-
mente der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungs-
handlungen einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche Teilhaber
oder Nichtteilhaber sein können. Die Befugnisse eines Geschäftsführers werden während seiner Ernennung durch die
Generalversammlung bestimmt. Das Geschäftsführungsmandat wird ihm bis zur Abberufung ad nutum durch die Gene-
ralversammlung, welche mehrheitlich berät, anvertraut.
Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft durchzufüh-
ren und um die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.
Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer allei-
nigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.
Zwischendividenden dürfen unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
- Zwischenbilanzen werden auf viertel- oder halbjährlicher Basis erstellt,
- diese Bilanzen müssen genügend Gewinne ausweisen, einschliesslich des Gewinnvortrages,
- der Beschluss, Zwischendividenden auszuschütten, wird von der Geschäftsführung getroffen, wenn genügend Liqui-
ditäten vorhanden sind. Ansonsten ist die Entscheidung von den Teilhabern zu treffen.
Art. 13. In Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungsgemäss
im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung seines
Mandates verantwortlich.
Art. 14. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Teilhabern, welche mehr als die Hälfte des
Kapitals vertreten, angenommen werden. Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur einstimmig von al-
len Teilhabern getroffen werden, welche das gesamte Kapital vertreten.
Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember.
Art. 16. Jedes Jahr zum 31. Dezember wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den Teil-
habern unterbreiten.
Art. 17. Jeder Teilhaber darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den 15 Tagen vor seiner Annah-
me einsehen.
Art. 18. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten, der Sozialab-
gaben, der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Pro-
zent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und
Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müs-
sen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebe-
82961
nen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien
Verfügung der Teilhaber.
Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die
Geschäftsführung oder jede andere von den Teilhabern bestimmte Person durchgeführt.
Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, dann werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Teilhaber im
Verhältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt.
Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Teilhaber gehalten werden könnte Zah-
lungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.
Art. 20. Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Teilhaber auf die in Kraft befindlichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 21. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern
selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr wird heute beginnen und wird am 31. Dezember 2002 enden.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausendneunhundert
Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben sich die Gesellschafter, welche das gesamte Kapital vertreten, in
einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und nachdem sie erklärt haben, dass sie ordnungs-
gemäss in Kenntnis der Tagesordnung einberufen worden sind, haben sie nach Beratung folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Herr Aleksander Jawien, Betriebswirt, wohnhaft in PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street, (Polen) und die Gesellschaft
mit beschränkter Haftung BAC MANAGEMENT, S.à r.l., mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie,
werden zu Geschäftsführern auf unbestimmte Zeit ernannt. Sie sind. befugt, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten
durch ihre gemeinsame Unterschrift zu verpflichten.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon l
er
.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch des Bevollmächtigten gegen-
wärtige Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Ersuchen desselben Bevollmächtigten
und im Falle von Divergenzen zwischen dein deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.
Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dein Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-
men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 octobre 2002, vol. 520, fol. 57, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(82222/231/320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
BANKET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 62.108.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANKET
S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 30 septembre 2002 que:
L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue
Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82261/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Junglinster, den 8. November 2002.
J. Seckler.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
82962
SIRIUS TRANSFORMATION SUPPORT, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
—
STATUTES
In the year two thousand and two, on the twenty-third of October.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
1.- Mr Aleksander Olszowski, economist, residing at PL-32-089 Województwo Malopolskie, 194 Wielka Wies, (Po-
land).
2.- Mr Kamil Klinowski, economist, residing at PL-30-833 Kraków, 15/80 Lilli Wenedy Street, (Poland).
3.- Mr Bartosz Karasinski, economist, residing at PL-30-023 Kraków, 84/28 Mazowiecka Street, (Poland).
4.- Mr Tomasz Olszewski, economist, bank manager, residing at PL-07-306 Brok, 11a Plac Koscielny, (Poland).
5.- Mr Aleksander Jawien, economist, residing at PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street, (Poland).
All are here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, av-
enue de la Faïencerie, by virtue of five proxies given under private seal.
Such proxies having been signed ne varietur by the notary and the attorney, will remain attached to the present deed
in order to be recorded with it.
Such appearing parties, represented as said before, have stated that they have formed a private limited company
whose articles of association have been fixed as follows:
Art. 1. Among the owners of the sharequotas hereinafter issued and those which might be issued later on, there is
hereby established a private limited company (Gesellschaft mit beschränkfer Haftung) which will be governed by the
laws in force and by the one of August 10, 1915 concerning trade companies mainly and by the present articles of asso-
ciation.
Art. 2. The company’s name is SIRIUS TRANSFORMATION SUPPORT.
Art. 3. The company’s object is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations
in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of sup-
port, loans, advances and guarantees to companies in which it has a direct or indirect participation.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-
curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
of the Grand Duchy of Luxembourg by the mere decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at 132,875.- (one hundred and thirty-two thousand eight hundred and seventy-
five Euros) represented by 5,315 (five thousand three hundred and fifteen) sharequotas of 25.- (twenty-five Euros) each,
which have been subscribed as follows:
The subscribers state and acknowledge that 5,125 (five thousand one hundred and twenty-five) sharequotas have
been fully paid up by contribution in kind of 84.85% (eighty-four point eighty-five percent) of the shares of the limited
liability company Ukrainian Trade System, registered under the number 31528774 with the Ukrainian trade registry, and
with its registered office at 80383 Lviv region, Zhovkva district, Malekhiv village, 31«B» Konovaltsya Street, Ukraine,
estimated at an amount exceeding 128,125 (one hundred and twenty-eight thousand one hundred and twenty-five Eu-
1.- Mr Aleksander Olszowski, economist, residing at PL-32-089 Województwo Malopolskie, 194 Wielka Wies,
(Poland), nine hundred and fifteen sharequotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
915
2.- Mr Kamil Klinowski, economist, residing at PL-30-833 Kraków, 15/80 Lilli Wenedy Street, (Poland), three
thousand one hundred and twelve sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,112
3.- Mr Bartosz Karasinski, economist, residing at PL-30-023 Kraków, 84/28 Mazowiecka Street, (Poland), one
thousand and ninety-eight sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,098
4.- Mr Tomasz Olszewski, economist, bank manager, residing at PL-07-306 Brok, 11a Plac Koscielny, (Poland),
ninety-five sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
5.- Mr Aleksander Jawien, economist, residing at PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street, (Poland), ninety-five
sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Total: five thousand three hundred and fifteen sharequotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,315
82963
ros) in accordance with the audit report of LVIV AUDITING AND COUNSELING AGENCY of August 20, 2002, and
that 190 (one hundred and ninety) sharequotas have been fully paid up by contribution in cash so that the amount of
4,750.- (four thousand seven hundred and fifty Euro) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having
been given to the undersigned notary.
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense
of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. that any decision of the sole shareholder as well as any contract between the latter
and the company must be recorded in writing and that the provisions regarding the general shareholders’ meetings are
not applicable.
Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes one owner of each sharequota
only. If there are several owners of one sharequota, the company is entitled to suspend the related rights until one sole
person has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in
case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and
his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the
usufructuary only.
Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to shareholders or to third parties is conditional upon the approval
of the general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of
sharequotas mortis causa to shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general sharehold-
ers’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to compulsory portion or to the
surviving spouse. If the transfer is not approved in either hypothesis, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.
The preemption right which is not exercised by one or several shareholders falls proportionally to the other share-
holders. Use must be made of it within a period of three months after the refusal of approval. If the preemption right is
not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.
Art. 9. Beside his contribution each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make
cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account
between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed by
the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an ad-
ditional contribution and the shareholder will be recognized as creditor of the company with respect to this amount
and the interests.
Art. 10. The death, the interdiction, the bankruptcy or the insolvency will not put an end to the company. In case
of death of a shareholder, the company will go on between the remaining shareholders and the legal heirs.
Art. 11. The creditors, the assignees and the heirs of the shareholders may not for whatever reason affix seals to
the property and the documents of the company nor may they interfere in any manner in the management of the com-
pany. They have to refer to the company’s inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, shareholders or third parties. The
power of a manager is determined by the general shareholders’ meeting when he is appointed. The mandate of manager
is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting deliberating with a majority of
votes.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the company
judicially and extra-judicially.
The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,
but only within the limits to be determined by the power of attorney.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by the board of managers, if there is enough cash. Otherwise, the
decision has to be taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; mere agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by the shareholders who represent more
than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the
majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.
Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December.
Art. 16. Each year, at the thirty-first of December, the management will draw up the annual accounts and will submit
them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
82964
Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve will amount to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.
Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by
the management or any other person appointed by the shareholders.
When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the sharequotas they are holding.
Possible losses are apportioned alike, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 20. With respect to all that is not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled insofar as the company’s business is concerned by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory provisioni>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2002.
<i>Valuation of the costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand three hundred
and fifty Euros.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the company, the shareholders representing the entire corporate capital, held
an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions after having acknowledged that they
have been validly convened with full knowledge of the agenda and after having deliberated.
<i>First resolutioni>
The private limited company A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à.r.l., with its registered
office at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, is appointed as manager for an unlimited duration with the
power to bind the company in all circumstances by its sole signature.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
attorney, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
attorney and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing attorney, known to the notary, by his surname, Christian name,
civil status and residence, the said appearing party signed together with us, the notary, the present deed.
Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendzwei, den dreiundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1.- Herr Aleksander Olszowski, Betriebswirt, wohnhaft in PL-32-089 Województwo Malopolskie,194 Wielka Wies,
(Polen).
2.- Herr Kamil Klinowski, Betriebswirt, wohnhaft in PL-30-833 Kraków, 15/80 Lilli Wenedy Street, (Polen).
3.- Herr Bartosz Karasinski, Betriebswirt, wohnhaft in PL-30-023 Kraków, 84/28 Mazowiecka Street, (Polen).
4.- Herr Tomasz Olszewski, Betriebswirt; Bankdirektor, wohnhaft in 07-306 Brok, 11a Plac Koscielny, (Polen).
5.- Herr Aleksander Jawien, Betriebswirt, wohnhaft in PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street, (Polen).
Alle sind hier vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, ave-
nue de la Faïencerie, aufgrund von fünf ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.
Diese Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden
Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, haben erklärt, dass sie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gegründet haben, deren Satzung sie wie folgt festgelegt haben:
Art. 1. Zwischen den Besitzern der nachstehend geschaffenen Gesellschaftsanteile und derjenigen Anteile, die spä-
terhin noch ausgegeben werden könnten, wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche
82965
den in Kraft befindlichen Gesetzen und insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.
Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung SIRIUS TRANSFORMATION SUPPORT an.
Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Be-
teiligungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen
und den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss
oder Sicherheit gewähren.
Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,
Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräussern. Darüber hinaus kann die Ge-
sellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwerten und
veräussern.
Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von sowohl
in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.
Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-
licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums
Luxemburg durch einfachen Beschluss der Teilhaber verlegt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur stattfinden oder nahe bevorstehen, wel-
che die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die unbeschwerte Kommunikation dieses Gesellschaftssitzes mit
dem Ausland gefährden, dann kann der . Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung der ausser-
gewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden. Ein solcher Beschluss hat keinen Einfluss auf die Nationalität der
Gesellschaft. Die Mitteilung über die Sitzverlegung erfolgt und wird Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft
übermittelt, welches sich unter den gegebenen Umständen hierzu am besten eignet.
Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf 132.875,- (hundertzweiunddreissigtausendachthundertfünfundsiebzig Euro)
festgesetzt, dargestellt durch 5.315 (fünftausenddreihundertfünfzehn) Anteile von je 25,- (fünfundzwanzig Euro), welche
wie folgt gezeichnet worden sind:
Die Komparenten, welche die Anteile gezeichnet haben, erklären und bejahen, dass 5.125 (fünftausendeinhundert-
fünfundzwanzig) Anteile voll und ganz eingezahlt worden sind durch eine Sacheinlage, und zwar 84,85% (vierundachtzig
Komma fünfundachtzig Prozent) der Anteile der Gesellschaft Ukrainian Trade System, eingetragen unter der Nummer
31528774 beim Handelsregister der Ukraine, und mit Sitz in 80383 Lviv region, Zhovkva district, Malekhiv village, 31
“B” Konovaltsya Street, Ukrain, geschätzt auf einen Betrag höher als 128.125 (hundertachtundzwanzigtausendeinhun-
dertfünfundzwanzig Euro) gemäss eines Prüfungsberichtes von LVIV AUDITING AND COUNSELING AGENCY vom
20. August 2002, und dass die 190 (hundertneunzig) Anteile voll und ganz in bar eingezahlt worden sind, so dass die
Summe von 4.750 (viertausendsiebenhundertfünfzig Euro) ab sofort zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, so wie
dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen worden ist.
Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, dann ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im
Sinne von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen,
die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. dass jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie
jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft schriftlich festgehalten werden muss und dass die Bestimmungen über
die Generalversammlungen der Teilhaber nicht anwendbar sind.
Art. 7. Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die für jeden Anteil nur einen einzigen Eigentümer an-
erkennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, dann kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden
Rechte in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, welche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso
verhält es sich bei einem Konflikt zwischen dem Niessbrauchberechtigten und dem «nackten» Eigentümer oder zwi-
schen dem durch Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner. Die Stimmrechte der mit dem Niessbrauch belasteten An-
teile werden jedoch nur vom Niessbrauchberechtigten ausgeübt.
Art. 8. Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer
Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.
1.- Herr Aleksander Olszowski, Betriebswirt, wohnhaft in PL-32-089 Województwo Malopolskie,194 Wielka
Wies, (Polen), neunhundertfünfzehn Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
915
2.- Herr Kamil Klinowski, Betriebswirt, wohnhaft in PL-30-833 Kraków, 15/80 Lilli Wenedy Street, (Polen),
dreitausendeinhundertzwölf Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.112
3.- Herr Bartosz Karasinski, Betriebswirt, wohnhaft in PL-30-023 Kraków, 84/28 Mazowiecka Street, (Polen),
eintausendachtundneunzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.098
4.- Herr Tomasz Olszewski, Betriebswirt, Bankdirektor, wohnhaft in 07-306 Brok, 11a Plac Koscielny, (Polen),
fünfundneunzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
5.- Herr Aleksander Jawien, Betriebswirt, wohnhaft in PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street, (Polen), fünfund-
neunzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Total: fünftausenddreihundertfünfzehn Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.315
82966
Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Ge-
neralversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, welches
den überlebenden Teilhabern gehört.
Diese Genehmigung ist nicht erfordert, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder an den überlebenden
Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, dann haben
die verbleibenden Teilhaber ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.
Das von einem oder mehreren Teilhabern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional, an die anderen Teilhaber
über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden.
Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages
nach sich.
Art. 9. Ausser seiner Gesellschaftseinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teil-
haber, der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein
spezielles Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu
einem Satz welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen
werden als allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht.
Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als
zusätzliche Gesellschaftseinlage zu betrachten, und der Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der
Gesellschaft anerkannt.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die
Zahlungsunfähigkeitserklärung eines Teilhabers. Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen
den überlebenden Teilhabern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.
Art. 11. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Doku-
mente der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungs-
handlungen einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche Teilhaber
oder Nichtteilhaber sein können. Die Befugnisse eines Geschäftsführers werden während seiner Ernennung durch die
Generalversammlung bestimmt. Das Geschäftsführungsmandat wird ihm bis zur Abberufung ad nutum durch die Gene-
ralversammlung, welche mehrheitlich berät, anvertraut.
Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft durchzufüh-
ren und um die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.
Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer allei-
nigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.
Zwischendividenden dürfen unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
- Zwischenbilanzen werden auf viertel- oder halbjährlicher Basis erstellt,
- diese Bilanzen müssen genügend Gewinne ausweisen, einschliesslich des Gewinnvortrages,
- der Beschluss, Zwischendividenden auszuschütten, wird von der Geschäftsführung getroffen, wenn genügend Liqui-
ditäten vorhanden sind. Ansonsten ist die Entscheidung von den Teilhabern zu treffen.
Art. 13. In Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungsgemäss
im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung seines
Mandates verantwortlich.
Art. 14. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Teilhabern, welche mehr als die Hälfte des
Kapitals vertreten, angenommen werden. Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur von der Mehrheit
der Teilhaber getroffen werden, welche drei Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember.
Art. 16. Jedes Jahr zum 31. Dezember wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den Teil-
habern unterbreiten.
Art. 17. Jeder Teilhaber darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den 15 Tagen vor seiner Annah-
me einsehen.
Art. 18. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten, der Sozialab-
gaben, der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Pro-
zent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und
Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müs-
sen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebe-
nen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien
Verfügung der Teilhaber.
Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die
Geschäftsführung oder jede andere von den Teilhabern bestimmte Person durchgeführt.
Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, dann werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Teilhaber im
Verhältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt.
Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Teilhaber gehalten werden könnte Zah-
lungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.
82967
Art. 20. Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Teilhaber auf die in Kraft befindlichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 21. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern
selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr wird heute beginnen und wird am 31. Dezember 2002 enden.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausenddreihun-
dertfünfzig Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben sich die Gesellschafter, welche das gesamte Kapital vertreten, in
einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und nachdem sie erklärt haben, dass sie ordnungs-
gemäss in Kenntnis der Tagesordnung einberufen worden sind, haben sie nach Beratung folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., mit
Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt. Sie ist
befugt, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch des Bevollmächtigten gegen-
wärtige Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung.
Auf Ersuchen desselben Bevollmächtigten und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen
Text, ist die englische Fassung massgebend.
Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-
men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 octobre 2002, vol. 520, fol. 56, case 12. – Reçu 1.328,75 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82223/231/339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
AB-ROAD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Monsieur Philippe Dessoy, administrateur de sociétés, demeurant à B-6700 Arlon, 566 route de Longwy,
ici représenté par Mademoiselle Stéphanie Delonnoy, employée privée, demeurant à F-Gorcy,
en vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 24 septembre 2002,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux
présentes aux fins de formalisation.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par les présentes, savoir:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
y relatives ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. La société a pour objet les transports nationaux et internationaux de marchandises par route.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Junglinster, den 8. November 2002.
J. Seckler.
82968
Art. 4. La société prend la dénomination de AB-ROAD, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Windhof.
II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé
unique.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (12.500,- euro) divisé en six cent vingt-cinq (625) parts
sociales de vingt euro (20,- euro) chacune.
Art. 7. Les six cent vingt-cinq (625) parts sociales sont souscrites en espèces par l’associé unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euro (12.500,- euro) est dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément.
Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les
biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Le produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et
charges constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’associé unique.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2002.
<i>Fraisi>
L’associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-
combent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ six cent vingts euro (620,- euro).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-
parants au paiement desdits frais.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-
saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.
<i>Décisioni>
Et l’associé a pris les résolutions suivantes:
1.- La société est gérée par l’associé unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
2.- Le siège social est établi à L-8399 Windhof, Bâtiments Olympia, 9 route des Trois Cantons.
Dont acte, fait et passé à Mamer, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Delonnoy, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 octobre 2002, vol. 882, fol. 59, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur leur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(82224/203/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Esch-sur-Alzette, le 4 novembre 2002.
A. Biel.
82969
CARTER TRANSPORT, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundzwei, am achtzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
Herr Eigil Jakobsen, Geschäftsführer, wohnhaft in Grundsundsvägen 21, 423 40 Torslanda (Schweden),
hier vertreten durch Herrn Guy Hornick, maître en sciences économiques, wohnhaft in Bartringen,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 17. September 2002.
Welche Vollmacht vom Vollmachtnehmer und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ge-
genwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Vorbenannte Person, handelnd in der vorbenannten Eigenschaft, hat die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung wie folgt festgelegt.
Art. 1. Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der er die nachstehende
Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.
Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Be-
teiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwer-
tung dieser Beteiligungen.
Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-
folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren
und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesell-
schaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere
und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüs-
sen oder Garantien gewähren.
Innerhalb dieses Aufgabenkreises ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die zur Errei-
chung dieses Zweckes notwendig und nützlich erscheinen.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung CARTER TRANSPORT, GmbH.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschaft an jeden
anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 20.000 (zwanzigtausend Euro) eingeteilt in 200 (zweihundert)
Anteile zu je EUR 100 (hundert Euro), welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter, Herr Eigil Jakobsen, wohnhaft
in Grundsundsvägen 21, 423 40 Torslanda (Schweden), gezeichnet wurden.
Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass die Summe von EUR 20.000 (zwanzigtausend Euro) der Gesellschaft
ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Ge-
setzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 9. Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile frei übertragbar. Die Uebertragung von Gesellschafts-
anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent
der Gesellschafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall
kann eine Uebertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überle-
benden Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von
dreissig Tagen nach Verweigerung der Uebertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.
Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-
gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch zwei oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der
Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.
Die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die
Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der
Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm
erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die
Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.
Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch zwei Gesellschafter
gemeinsam geführt werden.
Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen
ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
82970
Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen
kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des
Stammkapitals erreicht hat.
Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 21. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im
Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-
stimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2002.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.
<i>Schätzungi>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-
weise tausendzweihundert Euros.
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte gezeichnete Kapital dar-
stellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:
1. Herr Eigil Jakobsen, Geschäftsführer, wohnhaft in Grundsundsvägen 21, 423 40 Torslanda (Schweden), wird zum
Geschäftsführer der Kategorie A ernannt mit den in Artikel 12 der Satzungen festgesetzten Befugnissen,
Herr Guy Hornick, maître en sciences économiques, wohnhaft in Bertrange, wird zum Geschäftsführer der Kategorie
B ernannt mit den in Artikel 12 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.
Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberu-
fen.
Das Mandat der Geschäftsführer endet anlässlich der Generalversammlung, welche über die Bilanz des ersten Ge-
schäftsjahres befindet. Sie können wiedergewählt werden.
2. Die Anschrift der Gesellschaft lautet 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der oben er-
schienenen Partei die vorliegende Urkunde in Deutsch, gefolgt von einer englischen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag
derselben erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, geht
die deutsche Fassung vor.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, dem Notar nach Namen,
gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unter-
schrieben.
Folgt die englische Übersetzung des vorangegangenen Textes:
In the year two thousand and two, on the eighteenth of October.
Before the undersigned notary Joseph Elvinger, residing in Luxembourg.
There appeared:
1. Mr Eigil Jakobsen, manager, residing in Grundsundsvägen 21, 423 40 Torslanda (Sweden),
here represented by Mister Guy Hornick, maître en sciences économiques, residing at Bertrange,
by virtue of a proxy dated on the 17th of September 2002.
Said proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, acting in the hereabove stated capacity, has drawn up the following articles of a limited liability
company.
82971
Art. 1. A limited liability company is hereby formed by the appearing person that will be governed by these articles
and by the relevant legislation.
Art. 2. The objects for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking
of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The name of the company is CARTER TRANSPORT, GmbH.
Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the
Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the associates.
Art. 6. The capital of the company is fixed at EUR 20,000 (twenty thousand Euro), divided into 200 (two hundred)
shares of EUR 100 (one hundred Euro) each, which have been entirely subscribed by the sole associate, Mr Eigil Jakob-
sen, manager, residing in Grundsundsvägen 21, 423 40 Torslanda (Sweden).
All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 20,000
(twenty thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.
Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-
mercial companies.
Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.
Art. 9. If there are several associates, the shares are freely transferable among them. The share transfer inter vivos
to non associates is subject to the consent of at least seventy five percent of the company’s capital. In the case of the
death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of no less than seventy five percent
of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a preemption right which has to be
exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.
Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.
Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed
to pursue the sealing of property or documents of the company.
Art. 12. The company will be managed by two or several managers who need not to be associates and who are
appointed by the general meeting of associates.
The managers have the most extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances.
Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one
B signatory director or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In
its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature
legally commits the company.
If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by two associates acting under
their joint signature.
Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-
pany, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 14. Every associates may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number
of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.
Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.
However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing three quarters of the capital.
Art. 16. The fiscal year begins on January 1st and ends on December 31st.
Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered offices of the company.
Art. 19. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be
compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.
The balance is at the disposal of the associates.
Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need
not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remunerations.
82972
Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,
pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.
Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant leg-
islation.
<i>Transitory dispositioni>
The first business year begins today and ends on December 31st, 2002.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies
of September 18, 1933 have been fulfilled.
<i>Evaluationi>
The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately thousand two hundred euros.
<i>Decisions of the sole associatei>
The prenamed sole member, represented as here above stated, representing the entire subscribed capital, has im-
mediately taken the following decisions:
1. Mr Eigil Jakobsen, manager, residing in Grundsundsvägen 21, 423 40 Torslanda (Sweden), is appointed manager of
category A of the company with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation,
Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, residing in Bertrange, is appointed manager of category B of the
company with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation.
The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers’ assignment ends on occasion of the general ordinary meeting which decides on the financial statements
of the first business year. They may be reelected.
2. The company’s address is fixed at L-1325 Luxembourg 15, rue de la Chapelle.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in German followed by an English version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the German and the English text, the German version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian
name, civil status and residence, said person appearing signed together with us, Notary, the present original deed.
Signé: G. Hornick, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 136S, fol. 80, case 12. – Reçu 200 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82227/211/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
RN EXPRESS LINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
—
L’an deux mille deux, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Heiko Wolf, demeurant à D-08056 Zwickau, 48, Strabe Wildenfelser.
2) La société INVICT BUSINESS LTD, ayant son siège social à Belize, City-Belize, Jasmine Court, 35A, Regent Street,
ici représenté par Monsieur Laurent Krimou, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 25 octobre 2002.
Ladite procuration restera annexée au présent acte.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les
statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de RN EXPRESS LINE S.A.
Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg
par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet le transport national et international de marchandises et la prise de participations.
La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
Luxembourg, le 31 octobre 2002.
J. Elvinger.
82973
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière, et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,-
€) représenté par cent (100) actions d’une valeur
nominale de trois cent dix Euros (310,-
€) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-
vocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature conjointe de l’administrateur délégué et l’un des
deux administrateurs.
Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion
est prépondérante.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de mai à 10.00 heures au
siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-
tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,
télégramme, télécopie ou E-mail.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités
plus strictes.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-
dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque
fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
82974
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1
er
exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre
2002.
2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2003.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se
trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.
<i>Constatationi>
Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales.
<i>Estimation du coûti>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.245,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Heiko Wolf, demeurant à D-08056 Zwickau, 48, Strabe Wildenfelser.
2) Monsieur Rony Nuyts, demeurant à B-2440 Geel, 14, Grotesteenweg.
3) La société INVICT BUSINESS LTD, ayant son siège social à Belize, City-Belize, Jasmine Court, 35A, Regent Street.
Monsieur Heiko Wolf est nommé administrateur délégué.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2007.
Est nommé commissaire:
La société FID’AUDIT LIMITED, avec siège social à Belize, City-Belize, Jasmine Court, 35A, Regent Street.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2007.
2) Le siège de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Wolf, L. Krimou, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2002, vol. 14CS, fol. 92, case 8. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(82225/216/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
BIG BLUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 66.322.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BIG BLUE
S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 30 septembre 2002 que:
L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue
Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82262/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
1) La société INVICT BUSINESS LTD, prédite, quatre-vingts actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
2) Monsieur Heiko Wolf, prédit, vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Luxembourg, le 11 novembre 2002.
J.-P. Hencks.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
82975
AGEDOC, ASSOCIATION POUR LA GESTION DES ECOLES DE LA DOCTRINE CHRETIENNE.
Siège social: Luxembourg.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 no-
vembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82259/216/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
BINDURA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 61.887.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BINDURA
S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 30 septembre 2002 que:
L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue
Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82263/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
ANDANTE VIVACE S.A., Société Anonyme.
Registered Office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
—
STATUTES
In the year two thousand and two, on the seventeenth of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
1.- WATERSIDE FINANCIAL LTD, a Company formed under the Law of the British Virgin Islands, having its regis-
tered office at Skelton Building, Main Street, PO Box 3136, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
2.- Gérard Becquer, residing at 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg;
Both of them hereby represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium, undersigned, by virtue
of proxies given under private seal.
Both parties sub 1.- acting as founder and as subscriber of the Company and sub 2.- acting as subscriber of the Com-
pany.
The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain an-
nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in their aforesaid capacities, have requested the notary to draw up the following Arti-
cles of Incorporation of a société anonyme which the founders declare to organize among themselves.
Name, Duration, Registered Office, Purpose
Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,
a Luxembourg «société anonyme» is hereby formed under the name ANDANTE VIVACE S.A.
Art. 2. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a
resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-
nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Registered Office of the Company is in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
J.-P. Hencks.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
82976
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred
by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and
until such time as the situation becomes normalised.
Corporate Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 31,000 (thirty-one thousand euro), represented by 1,000 (one thousand)
shares with a nominal value of EUR 31 (thirty-one euro) each, carrying one voting right in the general assembly.
All the shares are in bearer or nominative form.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
Management - Supervision
Art. 6. The Company is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders
or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may renew
their mandate or remove them at any time. Directors will be appointed as type A directors or type B directors.
The number of directors and their term are fixed by the general meeting of the shareholders.
The board of directors convenes as often as the interest of the Corporation so requires. It must be convened each
time two directors so request.
Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other director as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the
directors’ meetings.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take
all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s
business, either to one or more Directors of type B, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who
do not have to be shareholders of the Company.
All acts binding the Company concerning the daily management of the Company’s business must be signed at least by
one Director either A or B type or by an officer duly authorized by the Board of Directors.
All acts binding the Company for all other matters must be signed jointly by two type A Directors or jointly by one
type A Director and one type B Director.
Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of
the Board of Directors, or by the person delegated to this office.
Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.
Shareholders’ Meetings
Art. 10. The annual General Meeting is held on the 25 in the month of March at 1.00 p.m. at the Company’s Regis-
tered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meet-
ing will be held on the next following business day.
Art. 11. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder
himself.
Art. 12. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It de-
cides how the net profit is allocated and distributed.
Business year, Allocation of profits
Art. 13. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 14. After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance
represents the net profit of the Corporation. On the net profit, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
the Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.
The board of directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Dissolution, Liquidation
Art. 15. The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in
the manner provided for amendments to the Articles. The liquidation will be carried out by one or more liquidators,
physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their
remuneration.
82977
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 16. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August
10, 1915 and of the modifying Acts.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first business year will begin today and close on December 31, 2002.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
1.- 999 shares, have been entirely subscribed by WATERSIDE FINANCIAL LTD, prenamed, and fully paid-up in cash;
2.- 1 share, have been entirely subscribed by Mr Gérard Becquer, prenamed, and fully paid-up in cash.
Total: 1,000 shares
All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount
of EUR 31,000 (thirty-one thousand euro) is as now at the disposal of the Company ANDANTE VIVACE S.A., proof of
which has been duly given to the notary.
<i>Statementi>
The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial com-
panies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or
charged to it for its formation, amount to about thousand five hundred euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare
that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.
<i>First resolutioni>
The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.
<i>Second resolutioni>
The following are appointed Directors:
1.- Mr Ulf Gustavsson, residing at Anäsvägen 6d, S-416 67 Göteborg, Sweden, as type A director;
2.- Mr Anders Blennermark, residing at Linnégatan 6, S-413 04 Göteborg, Sweden, as type A director;
3.- Mr Gérard Becquer, residing at 398, route d’Esch, L-1471, Luxembourg, as type B director;
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements
at December 31, 2002.
In accordance with article eleven of the by-laws, concerning the daily management the Company shall be bound by
the sole signature of one Director of type B or by an officer duly authorized by the Board of Directors and for all other
matters the Company shall be bound by the joint signature of one Director of type A together with one Directors of
type B.
<i>Third resolutioni>
Is elected as auditor:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., a company having its registered office at 400 route d’Esch, L-1471.
Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at
December 31, 2002.
<i>Fourth resolutioni>
The address of the Company is fixed at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
<i>Prevailing Languagei>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille deux, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- WATERSIDE FINANCIAL LTD , société régie par le droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à
Skelton Building, Main Street, PO Box 3136, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
82978
2.- M. Gérard Becquer, résidant au 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Tous deux ici représentées par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu de pro-
curations sous seing privé lui délivrées.
Les comparants sub 1.- agissant comme fondateur et souscripteur de la Société et sub 2.- agissant comme souscrip-
teur de la Société.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination, Durée, Siège social, Objet
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: ANDANTE VIVACE S.A.
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision
des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-
prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-
vité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Capital social, actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros), représenté par 1.000 (mille) actions de
EUR 31 (trente et un euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Administration, Surveillance
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur man-
dat ou les révoquer à tout moment. Les administrateurs seront nommés comme administrateur de classe A ou comme
administrateur de classe B.
Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale
de la Société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit ou par te-
lefax, câble, télégramme ou télex un autre administrateur pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs de classe B, directeurs,
gérants et/ou agents, actionnaires ou non-actionnaires.
82979
La Société se trouve engagée pour tous les actes liés à la gestion journalière des affaires de la Société par la signature
individuelle d’un administrateur qu’il soit de classe A ou B ou par la signature individuelle de la personne à ce déléguée
par le conseil.
La Société se trouve engagée pour tous les autres cas par la signature collective de deux administrateurs de classe A
ou par la signature collective d’un administrateur de classe A conjointement avec la signature d’un administrateur de
classe B.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Assemblée générale
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 25 du mois de mars à 13.00 heures au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira
le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le conseil d’administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions
légales.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Dissolution, Liquidation
Art. 15. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification
des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-
ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2002.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- 999 actions, entièrement souscrites par WATERSIDE FINANCIAL LTD, ci-dessus nommé, et entièrement libé-
rées en numéraire;
2.- 1 action, entièrement souscrites par M. Gérard Becquer, ci-dessus nommé, et entièrement libérée en numéraire.
Total: 1.000 actions
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent
pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000 (trente et un mille euro) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euro.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:
82980
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- M. Ulf Gustavsson, résidant à Anäsvägen 6d, S-416 67 Göteborg, Sweden, comme directeur de classe A;
2.- M. Anders Blennermark, résidant à Linnégatan 6, S-413 04 Göteborg, Sweden, comme directeur de classe A;
3.- M. Gérard Becquer, résidant au 398, route d’Esch, L-1471, Luxembourg, comme directeur de classe B;
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2002.
<i>Troisième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., une société ayant son siège social au 400 route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2002.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la Société est fixée à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
<i>Version prépondérantei>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 136S, fol. 79, case 12. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82228/211/306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
BONZBA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 67.402.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BONZBA
HOLDINGS S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 30 septembre 2002 que:
L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue
Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82264/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
CHRISTOPHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1490 Luxembourg, 14, rue d’Epernay.
R. C. Luxembourg B 77.700.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 576, fol. 27, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82403/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Luxembourg, le 31 octobre 2002.
J. Elvinger.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Signature.
82981
BOX DELIVERY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 59.903.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOX DE-
LIVERY S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1
er
octobre 2002 que:
L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue
Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82265/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
FAIRCROSS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 62.112.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FAIR-
CROSS S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 30 septembre 2002 que:
L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue
Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82266/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
JADE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered Office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
—
STATUTES
In the year two thousand and two, on the twenty-second of October.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned:
Appeared:
The company under the laws of the Cayman Islands JADE FORTUNE LIMITED, having its registered office in George
Town, (Cayman Islands),
here represented by Mr Guy Benzeno, lawyer, residing at Strassen, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing mandatory, acting as said before, requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed
of a limited liability company, («société à responsabilité limitée»), as follows:
Chapter I.- Purpose - Name - Duration
Art. 1. A corporation is established between the actual share holder and all those who may become owners in the
future, in the form of a limited liability company, which will be ruled by the concerning laws and the present articles of
incorporation.
Art. 2. The Company’s purpose is to take participation, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, finan-
cial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribu-
tion, underwriting firm purchase or option, negotiation or any other way and namely to acquire patents and licences,
to manage and develop them; to grant to any enterprises any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform
any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July
31st, 1929 on Holding Companies. The company can perform all commercial, technical and financial operations, con-
nected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited duration.
Art. 4. The corporation shall take the name of JADE PARTICIPATIONS.
Art. 5. The registered office shall be in Luxembourg.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
82982
The company is authorised to open branches or offices in the Grand Duchy and in foreign countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.
Chapter II.- Corporate Capital - Shares
Art. 6. The corporate capital is set at three hundred thousand US Dollars (300,000.- USD), consisting of three thou-
sand (3,000) shares with a par value of one hundred US Dollars (100.- USD) each, totally paid up, and subscribed by the
sole shareholder the company under the laws of the Cayman Islands JADE FORTUNE LIMITED, having its registered
office in George Town, (Cayman Islands).
All the shares have been totally paid up so that the amount of three hundred thousand US Dollars (300,000.- USD)
is from this day on at the free disposal of the company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who
expressly attests thereto.
Art. 7. The shares shall be freely transferable between associates. They can only be transferred inter vivos or upon
death to non-associates with the unanimous approval of all the associates.
In this case the remaining associates have a preemption right. They must use this preemption right within 30 days
from the date of refusal to transfer the shares to a non-associate person. In case of use of this preemption right the
value of the shares shall be determined pursuant to par. 6 and 7 of article 189 of the Company law.
Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the
corporation.
Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents
of the corporation under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to
the values established by the last balance-sheet and inventory of the corporation.
Chapter III.- Management
Art. 10. The corporation shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated
and subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.
Art. 11. Each associate, without consideration to the number of shares he holds, may participate to the collective
decisions; each associate has as many votes as shares. Any associate may be represented at general meetings by a special
proxy holder.
Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the cor-
porate capital.
Collective resolutions amending the articles of incorporation must be approved by the votes representing three quar-
ters of the corporate capital.
Art. 13. In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law
or the articles of incorporation, are assigned to the general meeting are exercised by the only shareholder.
Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken
in written form.
Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also
be mentioned in a protocol or be established in written form.
This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.
Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take
regularly in the name of the corporation; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.
Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share
owners.
Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1st of January and terminate on the 31st of December.
Chapter IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be
shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.
Chapter V.- General stipulations
Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.
<i>Special dispositionsi>
The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate 31st of December 2002.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at six thousand Euros.
For the purposes of the registration the amount of the corporate capital is evaluated at 307,875.- EUR.
<i>Decisions of the sole Shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named share owner took the following resolutions:
1.- The registered office is established in L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
2.- Is appointed as manager:
Type A
- Mr Alain Lam, auditor, residing at Mersch.
82983
Type B
- Mr Alasdair G. Nagle, bank director, residing in London (UK.).
3.- The corporation will be validly bound by the single signature of one of the managers from type A or the joint
signature of a manager from type B with that of a manager from type A.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing mandatory, known to the notary, by his surname, Christian name,
civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille deux, le vingt-deux octobre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A comparu:
La société régie par les lois des Iles Cayman JADE FORTUNE LIMITED, ayant son siège social à George Town, (Iles
Cayman),
ici représentée par Monsieur Guy Benzeno, juriste, demeurant à Strassen, en vertu d’une procuration sous seing pri-
vé.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel mandataire, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une
société à responsabilité limitée qu’il constitue par la présente:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque fore que ce soit, dans toutes sociétés commer-
ciales, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition de toutes sûretés et droits par le biais de
participations, apports, garanties, achat, options, négociations ou de toute autre manière, ainsi que l’acquisition de bre-
vets et licences, leur gestion et leur développement. La société a également pour objet de fournir toute assistance, prêts,
avances ou garanties à toutes entreprises et finalement de réaliser toutes opérations directement ou indirectement liées
à son objet social, sans toutefois vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. La société peut
procéder à toutes opérations commerciales, techniques et financières, liées directement ou indirectement aux sujets
décrits ci-dessus, destinées à faciliter l’exécution de son objet social.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de JADE PARTICIPATIONS.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II.- Capital social - parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à trois cent mille dollars US (300.000,- USD), représenté par trois mille (3.000) parts
sociales de cent dollars US (100,- USD) chacune, entièrement libérées et souscrites par l’associé unique la société régie
par les lois des Iles Cayman JADE FORTUNE LIMITED, ayant son siège social à George Town, (Iles Cayman).
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de trois cent mille dol-
lars US (300.000,- USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.
82984
Titre III.- Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérant ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérantpar décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2002.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de six mille euros.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 307.875,- EUR.
<i>Décisions de l’associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
2.- Est désigné comme gérant de la société:
Type A
- Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprise, demeurant à Mersch.
Type B
- Monsieur Alasdair G. Nagle, directeur de banque, demeurant à London (UK).
3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant de type A ou la signature conjointe du gérant de type
B avec celle du gérant de type A.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité qu’il agit, connu du notaire par ses nom, pré-
nom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Benzeno, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 86, case 10. – Reçu 3.071,25 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82236/211/204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Luxembourg, le 30 octobre 2002.
J. Elvinger.
82985
FAUSIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 67.834.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FAUSIS S.A.
tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 30 septembre 2002 que:
L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue
Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82267/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
ITSON CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 67.777.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ITSON
CONSULTING S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 30 septembre 2002 que:
L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue
Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82268/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
FINANCIERE VERSAILLES, S.à r.l. sub 3, Société à responsabilité limitée.
Registered Office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
—
STATUTES
In the year two thousand and two, on the seventeenth of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
FINANCIERE VERSAILLES, S.à r.l. sub 1, a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered
office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
The founder is here represented by Monsieur Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of a
proxy given under private seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which
its declares to incorporate.
Name - Registered Office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed
by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, including its article 209, of July 31, 1929 on Holding Companies, of September 18th, 1933 and
of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.
At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners
may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercices the powers devolved to the General Meeting of partners.
Art. 2. The Company’s name is FINANCIERE VERSAILLES, S.à r.l. sub 3.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-
nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
82986
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any partner.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), represented by 500 (five
hundred) shares of EUR 25 (twenty five euro) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
82987
Partners decisions
Art. 14. Partners decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-
sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-
resented.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-
ners representing the three quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of
the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain
a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of partners together with the balance sheet.
Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-
es and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the partners.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined
by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the
pro-rata of their participation in the share capital of the company.
A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment
of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2002.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by FINANCIERE VERSAILLES,
S.à r.l. sub 1, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred
euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand five hundred euros.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as manager for an undetermined duration
Mr Frédéric Stevenin, partner, residing at 66 Cottesmore Court, Stanford Road, London W8 5QW, England,
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of its single man-
ager.
2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
82988
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille deux, le dix-sept octobre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaît:
FINANCIERE VERSAILLES, S.à r.l. sub 1, une société de droit Luxembourgeois, ayant son siège social à 398, route
d’Esch, L-1471 Luxembourg
Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité
limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.
Art. 2. La dénomination de la société sera FINANCIERE VERSAILLES, S.à r.l. sub 3.
Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-
prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euro), représenté par 500 (cinq cents) parts
sociales de EUR 25 (vingt cinq euro) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
82989
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs
de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
82990
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans
le capital de la Société.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-
tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par FINAN-
CIERE VERSAILLES, S.à r.l sub 1, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de
sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cent euro) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille deux cents euro.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée
M. Monsieur Frédéric Stevenin, associé, demeurant au 66 Cottesmore Court, Stanford Road, London W8 5QW, Eng-
land,
Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son gérant unique.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-
rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 136S, fol. 79, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82235/211/318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
EIGER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 43.838.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2002, vol. 576, fol. 32, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale du 21 octobre 2002i>
AFFECTATION DU RESULTAT
Le bénéfice de EUR 19.833,31 est reporté sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82270/279/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Luxembourg, le 31 octobre 2002.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Signature.
82991
HYMAR HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 77.705.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HYMAR
HOLDINGS S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 2 octobre 2002 que:
L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue
Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82269/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
SOLAGE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 69.607.
—
<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire des Actionnairesi>
<i> tenue au siège social à Luxembourg, le 9 avril 2002i>
Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Monsieur Di Pietro Filippo sont renommés ad-
ministrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Arno’ Vincenzo est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.
Luxembourg, le 9 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2002, vol. 576, fol. 33, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82400/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
COLEEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 82.157.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 576, fol. 27, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82404/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
FUTURE VISION CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 67.465.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FUTURE
VISION CONSULTING S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1
er
octobre 2002 que:
- L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue
Goethe à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich à partir du 7 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82484/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
SOLAGE HOLDING S.A.
Signatures
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Signature.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
82992
A BIS Z PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4412 Belvaux, 23, rue des Alliés.
R. C. Luxembourg B 78.546.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 576, fol. 27, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82401/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
A BIS Z PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4412 Belvaux, 23, rue des Alliés.
R. C. Luxembourg B 78.546.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 576, fol. 27, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82402/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
A BIS Z PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4412 Belvaux, 23, rue des Alliés.
R. C. Luxembourg B 78.546.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i> tenue à Belvaux le 18 septembre 2002i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.
Les comptes au 31 décembre 2001 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.
<i>Administrateur-délégué:i>
Monsieur Fassbinder Christian, indépendant, demeurant à L-4412 Belvaux, 23, rue des Alliés.
<i>Administrateurs:i>
Madame Hintgen-Fassbinder Danielle, mère de famille, demeurant à L-3209 Bettembourg, 45A, Leischemer.
Madame Fassbinder Marcelle, retraitée, demeurant à L-4757 Pétange, 27, rue Marie-Adelaïde.
Monsieur Fassbinder Robert, employé privé, demeurant à L-4970 Bettange-sur-Mess, 54A, rue des Trois Cantons.
<i>Commissaire aux comptes:i>
Madame Schammo Mara, comptable, demeurant à L-4412 Belvaux, 23, rue des Alliés.
Pétange, le 18 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 576, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82414/762/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Signature.
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Crochat S.A.
Global Vision S.A.
Totl S.A.
Kypselux S.A.
Fiduciaire Eurolux S.A.
Citation Holdings S.A.
Wolford Investments S.A.
Seahorse S.A.
R.T.C. Group Soparfi S.A.
Noble Real Estate S.A.
MGO Lux S.A.
Heaters Promotions & Marketing S.A.
Gleniffer S.A.
Eurostone S.A.
Espirito Santo Services S.A.
Espirito Santo Services S.A.
Edwardian Investments S.A.
Lighthouse Holdings Limited S.A.
Alcotrade S.A.
Isomax Castellum Investment A.G.
Mossi & Ghisolfi International S.A.
Mossi & Ghisolfi International S.A.
Espirito Santo Fashion Investments S.A.
M & G Luxembourg S.A.
Maritime Construction S.A.
Adhésifs, S.à r.l.
Mossi & Ghisolfi Overseas S.A.
Mossi & Ghisolfi Overseas S.A.
Chemical Transport S.A.
City-Image, S.à r.l.
Morgana Holding S.A.
Den Top, S.à r.l.
Outstanding Productions S.A.
Net Management Consulting S.A.
Laumar S.A.
EWC, GmbH
Solid Partners Luxembourg S.A.
Acronic Holdings S.A.
Lousseau Holding
Nicolas International Holding
Inland Shipping S.A.
Inland Shipping S.A.
Inland Shipping S.A.
Lucilinburhuc (LBH)
Trinity Management Partners
Banket S.A.
Sirius Transformation Support
AB-Road, S.à r.l.
Carter Transport, GmbH
RN Express Line S.A.
Big Blue S.A.
AGEDOC, Association pour la Gestion des Ecoles de la Doctrine Chrétienne
Bindura S.A.
Andante Vivace S.A.
Bonzba Holdings S.A.
Christopher, S.à r.l.
Box Delivery S.A.
Faircross S.A.
Jade Participations, S.à r.l.
Fausis S.A.
Itson Consulting S.A.
Financière Versailles, S.à r.l. sub 3
Eiger S.A.
Hymar Holdings S.A.
Solage Holding S.A.
Coleen S.A.
Future Vision Consulting S.A.
A Bis Z Promotions S.A.
A Bis Z Promotions S.A.
A Bis Z Promotions S.A.