This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2087
15 juillet 2016
SOMMAIRE
Africa Queen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100137
Banbury Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100175
Bottega S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100176
Callirius Holdco S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100159
CEP III Alphyn I S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100137
Distribution S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100130
Dundeal (International) 27 S.à r.l. . . . . . . . . . .
100130
Edwardian Investments SA . . . . . . . . . . . . . . .
100137
Enet Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100137
General Capital- S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100140
General Capital- S.C.A., SICAV-SIF . . . . . . .
100140
GP-7 Light Industrial LBC Vesta S.à r.l. . . . .
100136
Gutt Drauf s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100136
Invista European RE Marseille PropCo S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100170
Invista European RE Monbonnot HoldCo 1 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100170
Iphias Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100175
JN Consult S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100137
LUX-FUND Advisory S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
100175
Makeland Trading and Investments S.A. . . . .
100153
Marmolux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100154
Martek Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100175
Matrisa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100153
Matrisa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100153
Melica Software S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100152
Memory Keepers S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100176
Merinv S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100176
MG Transports S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100152
Midest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100153
Monlegeac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100176
MPT RHM Flechtingen II S.à r.l. . . . . . . . . . .
100136
MPT RHM Park S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100139
Natixis Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100169
North REOF Kubrat S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
100138
North REOF Moldova S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
100138
Pacôme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100158
Pafema S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100158
PA Holdings Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
100158
Pervinage S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100154
PetroChina Energy Holding Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100154
Phoeturum S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100136
Premier Cru Multi Investments . . . . . . . . . . . .
100155
Prie & Gie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100155
Prodsavor Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100157
Quattro S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100139
Reckitt Benckiser Investments (No 4) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100139
Rhine Luxembourg 2 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . .
100139
RT Holdings II WG (US), LP . . . . . . . . . . . . . .
100150
Schneider Electric Major Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100150
SELP (Bravo Spare 2) S..à r.l. . . . . . . . . . . . . .
100151
Socaro Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100138
Sos Ambu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100151
Tankreederei II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100152
The Enterprise Expansion Fund . . . . . . . . . . .
100152
T.L.O. Diana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100151
T.L.O. Diana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100151
Victoria Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100170
100129
L
U X E M B O U R G
Dundeal (International) 27 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 191.763.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l’associé unique de la Société en date du 9 mai 2016 que M. Cengiz Coelhan a été
révoqué de sa fonction de gérant de catégorie A de la Société, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dundeal (International) 27 S.à r.l.
Référence de publication: 2016105718/13.
(160077847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Distribution S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 158.067.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-eighth day of the month of April,
Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg-Merl, Grand-Duchy of Luxembourg,
There appeared
Vitruvian I Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 1, rue Hildegard von
Bingen, L-1282 Luxembourg (formerly 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg), registered with the Register of
Trade and Companies of Luxembourg under number B 138.092,
represented by Me Perrine Reinhart, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated
27 April 2016 (such proxy to be registered together with the present deed),
being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) and holding all the twelve thousand five hundred (12,500) shares
in issue in Distribution S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée having its registered office at 1, rue
Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg (formerly 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg), registered with the
Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 158.067 and incorporated on 24 December 2010 by
deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (the “Mémorial”) number 652 on 6 April 2011. The articles of association of the Company have been amended
for the last time on 29 May 2015 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial number 1905 on 29 July
2015.
The appearing party declared and requested the notary to record as follows:
(A) The Sole Shareholder holds all the shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on all items
of the agenda.
(B) The items on which resolutions are to be passed are as follows:
1. Amendment of the article 7 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which
determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an unde-
termined period. The managers may be re-elected. They may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class A managers and
class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and
the managers be identified with respect to the class they belong.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another,
provided that such manager is located outside the United Kingdom during the meeting. A meeting may also be held by
conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by
another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
100130
L
U X E M B O U R G
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required (i) for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers or (ii) when all the managers are present or represented and declare that they have had knowledge
of the agenda of the meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
(provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely
class A managers and class B managers) such majority shall always include at least one class A manager (which may be
represented) and one class B manager (which may be represented)).
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
present or represented, provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers present or represented including at least one class A manager.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager provided however that in the
event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers the minutes of any meeting of the
board of managers shall be signed by two managers one of which being always a class A manager unless otherwise resolved
by the board of managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise
shall be signed by any one manager provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed
different classes of managers, copies or extracts of the minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by
two managers, one of which being always a class A manager unless otherwise resolved by the board of managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.
The Company will be bound by the sole signature of the sole manager, and in the case of a board of managers by the
sole signature of any one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has
appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly
bound by the joint signature of two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of
representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom
such signatory powers shall have been delegated by any one of the managers provided that in the event of classes of
managers, by two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation).”
2. Amendment of the article 13 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be com-
pulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company. The Shareholders
may distribute the remainder of the total net profits of the Company or allocate such amount to the reserves of the Company,
but only upon recommendation of the board of managers and provided that the amount so distributed or allocated shall not
exceed the amount recommended by the board of managers.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, but only upon recommendation of the board of managers, showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits
realized since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased
by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.”
Thereupon the Sole Shareholder has passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
It is resolved to amend the article 7 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which
determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an unde-
termined period. The managers may be re-elected. They may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class A managers and
class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and
the managers be identified with respect to the class they belong.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another,
provided that such manager is located outside the United Kingdom during the meeting. A meeting may also be held by
100131
L
U X E M B O U R G
conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by
another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required (i) for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers or (ii) when all the managers are present or represented and declare that they have had knowledge
of the agenda of the meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
(provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely
class A managers and class B managers) such majority shall always include at least one class A manager (which may be
represented) and one class B manager (which may be represented)).
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
present or represented, provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers present or represented including at least one class A manager.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager provided however that in the
event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers the minutes of any meeting of the
board of managers shall be signed by two managers one of which being always a class A manager unless otherwise resolved
by the board of managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise
shall be signed by any one manager provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed
different classes of managers, copies or extracts of the minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by
two managers, one of which being always a class A manager unless otherwise resolved by the board of managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.
The Company will be bound by the sole signature of the sole manager, and in the case of a board of managers by the
sole signature of any one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has
appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly
bound by the joint signature of two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of
representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom
such signatory powers shall have been delegated by any one of the managers provided that in the event of classes of
managers, by two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation).”
<i>Second resolutioni>
It is resolved to amend the article 13 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be com-
pulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company. The Shareholders
may distribute the remainder of the total net profits of the Company or allocate such amount to the reserves of the Company,
but only upon recommendation of the board of managers and provided that the amount so distributed or allocated shall not
exceed the amount recommended by the board of managers.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, but only upon recommendation of the board of managers, showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits
realized since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased
by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.”
All the items of the agenda have been resolved upon.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the above resolutions have been estimated at about one thousand one hundred euros (EUR
1,100.-).
100132
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the party hereto, this
deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same party, in case of divergences between
the English and the French version, the English version shall prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the person appearing, he signed together with us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois d'avril,
par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg-Merl, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu
Vitruvian I Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 1, rue Hildegard von
Bingen, L-1282 Luxembourg (anciennement 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg), immatriculée auprès du Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.092,
représentée par Me Perrine Reinhart, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration datée du 27 avril 2016 (laquelle procuration sera enregistrée avec le présent acte),
étant l'associé unique (l'«Associé Unique») et détenant l'ensemble des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales
émises dans Distribution S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 1, rue Hildegard
von Bingen, L-1282 Luxembourg (anciennement 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg), immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.067, constituée le 24 décembre 2010 par acte
de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial») numéro 652 du 6 avril 2011. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 29 mai 2015
par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial numéro 1905 du 29 juillet 2015.
La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
(A) L'Associé Unique détient l'ensemble des parts sociales émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent
être prises valablement sur tous les points figurant à l'ordre du jour.
(B) Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:
1. Modification de l'article 7 des statuts afin qu'il ait la teneur suivante:
«La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir des gérants de
classe A et des gérants de classe B. Cette classification des gérants sera dûment enregistrée dans les résolutions de l'as-
semblée concernée et les gérants appartenant à chaque classe seront identifiés.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et
de communiquer les uns avec les autres, à condition que ce gérant soit situé en dehors du Royaume-Uni pendant la réunion.
Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue
d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne.
Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre
de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise (i) pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance ou (ii) lorsque tous les gérants sont présents ou représentés et déclarent
avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion.
Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente
ou représentée (à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à
savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours, au moins un gérant de classe
A (qui peut se faire représenter) et un gérant de classe B (qui peut se faire représenter)).
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l'approbation de la majorité des gérants de la Société
présents ou représentés, à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants,
100133
L
U X E M B O U R G
les résolutions du conseil de gérance ne pourront être adoptées qu'à la majorité des gérants présents ou représentés incluant
au moins un gérant de classe A.
Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants, à condition que dans le cas où l'assemblée
générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront signées par deux
gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance. Des copies ou extraits de ces
résolutions qui pourront être notamment versées dans le cadre de procédures judiciaires seront signés par un des gérants à
condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les copies ou extraits de
telles résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision
contraire du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature
d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir
des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe
de deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation). Dans tous
les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature
auront été délégués, par n'importe lequel des gérants, étant entendu que lorsqu'il existe différentes classes de gérants, par
deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation).»
2. Modification de l'article 13 des statuts afin qu'il ait la teneur suivante:
«Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse
d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social. Les associés peuvent distribuer le reste du
total net des profits de la Société ou allouer ce montant aux réserves de la Société, mais seulement sur recommandation du
conseil de gérance et à condition que le montant ainsi distribué ou alloué n'excède pas le montant recommandé par le conseil
de gérance.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé
par le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, mais seulement sur recommandation du conseil de gérance, duquel
il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent
pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des
réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la
loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.»
À la suite de quoi, l'Associé Unique a adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de modifier l'article 7 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:
«La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir des gérants de
classe A et des gérants de classe B. Cette classification des gérants sera dûment enregistrée dans les résolutions de l'as-
semblée concernée et les gérants appartenant à chaque classe seront identifiés.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et
de communiquer les uns avec les autres, à condition que ce gérant soit situé en dehors du Royaume-Uni pendant la réunion.
Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue
d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne.
Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre
de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise (i) pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
100134
L
U X E M B O U R G
préalablement adoptée par le conseil de gérance ou (ii) lorsque tous les gérants sont présents ou représentés et déclarent
avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion.
Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente
ou représentée (à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à
savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours, au moins un gérant de classe
A (qui peut se faire représenter) et un gérant de classe B (qui peut se faire représenter)).
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l'approbation de la majorité des gérants de la Société
présents ou représentés, à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants,
les résolutions du conseil de gérance ne pourront être adoptées qu'à la majorité des gérants présents ou représentés incluant
au moins un gérant de classe A.
Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants, à condition que dans le cas où l'assemblée
générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront signées par deux
gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance. Des copies ou extraits de ces
résolutions qui pourront être notamment versées dans le cadre de procédures judiciaires seront signés par un des gérants à
condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les copies ou extraits de
telles résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision
contraire du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature
d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir
des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe
de deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation). Dans tous
les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature
auront été délégués, par n'importe lequel des gérants, étant entendu que lorsqu'il existe différentes classes de gérants, par
deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation).»
<i>Seconde résolutioni>
Il est décidé de modifier l'article 13 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:
«Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse
d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social. Les associés peuvent distribuer le reste du
total net des profits de la Société ou allouer ce montant aux réserves de la Société, mais seulement sur recommandation du
conseil de gérance et à condition que le montant ainsi distribué ou alloué n'excède pas le montant recommandé par le conseil
de gérance.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé
par le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, mais seulement sur recommandation du conseil de gérance, duquel
il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent
pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des
réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la
loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.»
Tous les points portés à l'ordre du jour ont fait l'objet d'une résolution.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société ou qui lui
seront imputés dans le cadre des résolutions qui précèdent ont été estimés à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française; à la demande de la même partie, la version anglaise fera
foi en cas de divergences entre les versions anglaise et française.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec nous, le notaire, le présent acte
original.
Signé: P. REINHART, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/14114. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
100135
L
U X E M B O U R G
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Référence de publication: 2016105700/331.
(160078110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
Gutt Drauf s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, 85, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 167.926.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105917/9.
(160077293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
MPT RHM Flechtingen II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 191.281.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 3 mai 2016i>
En date du 3 mai 2016, l'associé unique de la Société a décidé avec effet immédiat de remplacer Monsieur Abdelhakim
Chagaâr en tant que gérant de catégorie B de la Société par Madame Laetitia Brion, née le 10 août 1984 à Woippy, France,
demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016106157/16.
(160077629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.
GP-7 Light Industrial LBC Vesta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 132.302.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 15 Avril 2016.
Référence de publication: 2016106805/10.
(160078466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Phoeturum S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 171.912.
<i>Auszug aus dem Beschluss der Gesellschafter vom 10. März 2016i>
Aus dem Beschluss der Gesellschafter vom 10. März 2016 ergibt sich, dass folgende Entscheidung getroffen wurde:
Aufgrund des Ablebens des ehemaligen Verwaltungsratsmitglieds, Herrn Dr. Wolfgang Emil HERZOG, am 5. De-
zember 2014, besteht der Verwaltungsrat der Gesellschaft seither nur aus zwei Mitgliedern.
Um die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft wieder auf die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl
von mindestens 3 Mitgliedern zu bringen, haben die Gesellschafter daher folgenden Beschluss gefasst:
Die Gesellschafter beschließen einstimmig Frau Jutta HERZOG, Rechtsanwältin, geboren am 28. Dezember 1962 in
Hanau (D), wohnhaft in D-63452 Hanau, Frankfurter Landstraße 40a, zum Verwaltungsmitglied der Gesellschaft zu er-
nennen, rückwirkend zum 6. Dezember 2014 und für eine unbestimmte Zeit.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016107102/17.
(160078837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
100136
L
U X E M B O U R G
Edwardian Investments SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 81.763.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2016.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2016106739/11.
(160078879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Enet Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 166.598.
Les comptes annuels au 31 mars 2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2016106744/10.
(160079303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
CEP III Alphyn I S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 176.813.
Les comptes annuels au 31 août 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le
18/05/2015 référencés L150083648 sont dès lors rectifiés par les présents comptes annuels.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
CEP III Alphyn I SCA
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016106644/13.
(160079103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Africa Queen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 118.455.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2016106543/12.
(160079397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
JN Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 925.000,00.
Siège social: L-1351 Luxembourg, 19, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 175.629.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
100137
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Jens Havemann
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016106895/12.
(160079352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
North REOF Kubrat S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 120.910.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 mai 2016.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2016107038/13.
(160078671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
North REOF Moldova S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 120.906.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 mai 2016.
Signataire
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2016107039/13.
(160078673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Socaro Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 35.318,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 173.062.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date 10 mai 2016 que:
- La démission de Madame Sandrine BISARO et Madame Christelle MATHIEU, gérant de classe B de la Société, avec
effet au 10 février 2016, a été accepté.
- Les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérant de classe B, avec effet au 10 février 2016 et ce pour une
durée indéterminée:
* Madame Caroline GOERGEN, née le 09 juin 1979 à Verviers, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg.
* Monsieur Martin HUBERT, né le 28 avril 1982 à Messancy, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Référence de publication: 2016107166/20.
(160078823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
100138
L
U X E M B O U R G
MPT RHM Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 180.231.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 3 mai 2016i>
En date du 3 mai 2016, l'associé unique de la Société a décidé avec effet immédiat de remplacer Monsieur Abdelhakim
Chagaâr en tant que gérant de catégorie B de la Société par Madame Laetitia Brion, née le 10 août 1984 à Woippy, France,
demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016107013/16.
(160078912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Quattro S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9972 Lieler, 7, Hauptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 146.042.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016107127/10.
(160078780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Rhine Luxembourg 2 S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 5.000,00.
Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.
R.C.S. Luxembourg B 185.126.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Référence de publication: 2016107137/10.
(160078946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Reckitt Benckiser Investments (No 4) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg B 114.621.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2016 que:
- Patrick Norris Cléments a démissionné comme gérant avec effet au 30.04.2016
- Richard Greensmith, né le 22 juin 1973, demeurant professionnellement à GB- SL1 3 UH Slough, Berkshire, 103-105
Bath Road, a été élu aux fonctions de gérant avec effet au 30 avril 2016
- Giuseppe Pittari, né le 23 juillet 1975, demeurant professionnellement à L-3364 Leudelange, 1 rue de la Poudrerie, a
été élu aux fonctions de gérant avec effet au 30 avril 2016
Luxembourg, le 9 mai 2016.
Référence de publication: 2016107146/15.
(160079043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
100139
L
U X E M B O U R G
General Capital- S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. General Capital- S.C.A., SICAV-SIF).
Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 186.308.
In the year two thousand and sixteen, on twenty-ninth day of April.
Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.
Was held
an Extraordinary General Meeting of the shareholders of GENERAL CAPITAL - S.C.A., SICAV-SIF, a public corporate
partnership limited by shares (société en commandite par actions) qualified as an investment company with variable capital
(société d'investissement à capital variable) organised as a specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisé)
having its registered office in L - 1616 Luxembourg, 28-32 Place de la Gare, registered with the Luxembourg trade and
companies' register under section B and number 186308 incorporated by notarial deed enacted on 17 April 2014 published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of 28 April 2014 number 1073 (the "Company").
The meeting is presided by Mr Renaud Léonard, employee with professional residence at 11 avenue Emile Reuter, L -
2420 Luxembourg,
who appointed as secretary Mrs Samia Chabane, employee with professional residence at 11 avenue Emile Reuter, L -
2420 Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Aurélien Favier, employee, with professional residence at 28-32 Place de la Gare
L-1616 Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Convening formalities.
2. Change of legal regime of the Company: abandoning of the SIF regime.
3. Maintain of the Company's legal form of a public corporate partnership limited by shares (société en commandite par
actions) and fixation of the share capital at EUR 31,000 represented by 10,000 management shares and 21,000 ordinary
shares of a nominal value of EUR 1 each.
4. Subsequent amendment and full restatement of the articles of association of the Company, and its translation in French,
including the amendment of the Company's name into GCG EUROPE S.C.A., the fixation of the Company's share capital,
and the amendment of the purposes of the Company to be read as follows: “The object of the Company is to take partici-
pations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign
companies or enterprises and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, nego-
tiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other property, rights and interest in property as
the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for
such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the
same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company,
subsidiary, or affiliated company, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding
company, subsidiary or affiliated company, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance,
loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money
borrowed; finally to perform any and all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly
in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose. The Company may, for its own
account, acquire, hold, lend and/or build any real estates properties in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.”
5. Reallocation of the existing 2.1 Class A1 Shares of the Company into 21,000 Ordinary Shares and Reallocation of
the existing Management Share into 10,000 Management Shares as set forth in the amended and restated version of the
articles of association of the Company.
6. Dismissal of the external auditor of the Company.
7. Appointment of a supervisory board composed of 3 members.
8. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the proxies
of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.
The proxies of the represented shareholders initialled “ne varietur” by the appearing parties and the undersigned notary
will remain annexed to the present deed for registration purposes.
III. That the entire share capital being present or represented at the present Extraordinary General Meeting i.e. 2.1 Class
A1 shares and 1 management share and all the shareholders represented declaring that they had due notice and got know-
ledge of the agenda prior to this Extraordinary General Meeting, no convening notices were necessary.
100140
L
U X E M B O U R G
IV. That the present Extraordinary General Meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and
may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting acknowledges that the shareholders of the Company have been duly convened and have perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to them in advance
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves:
- that the Company shall no longer be governed by the Luxembourg law dated 13 February 2007 on specialised invest-
ment funds, as amended;
- to abandon the SIF status of the Company; and
- to continue the Company as an ordinary commercial company subject to the Luxembourg law dated 10 August 1915
on commercial companies, as amended.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to maintain the Company's legal form of a public corporate partnership limited by shares (société
en commandite par actions) and to fix the share capital at EUR 31,000 (THIRTY-ONE THOUSAND Euros) represented
by 10,000 (ten thousand) management shares and 21,000 (twenty-one thousand) ordinary shares of a nominal value of EUR
1 (one Euro) each.
The inventory of the portfolio / interim accounts as at 15 April 2016 initialled “ne varietur” by the appearing parties and
the undersigned notary will remain annexed to the present deed for registration purposes.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the Company's name into GCG EUROPE S.C.A. and the purposes of the Company to
be read hereunder.
As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to fully restate the articles of association of the Company
and to have them translated in French, which will henceforth read as follows:
“A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
issued, a company in the form of a public corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) under
the name of GCG EUROPE S.C.A. (the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. Branches,
subsidiaries or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the
Manager. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the Manager.
In the event that the Manager determines that extraordinary political, military events have occurred or are imminent
which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Com-
pany, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations, con-
tributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences,
and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop,
sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for
shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and
other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or affiliated company, or any other company associated
in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or affiliated company, in which the Company has
a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any
manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any and all commercial, technical and
financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment
of its purpose.
The Company may, for its own account, acquire, hold, lend and/or build any real estates properties in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad.
100141
L
U X E M B O U R G
Art. 5. The Manager is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company.
The holders of Ordinary Shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than
by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to
the Company.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company has a subscribed share capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into twenty-
one thousand (21,000) Ordinary Shares and ten thousand (10,000) Management Share(s) with a par value of one euro (EUR
1.-) each. The Management Shares shall be held by General Capital Group S.àr.l. as unlimited shareholder (actionnaire
commandité).
Art. 7. All shares of the Company shall be issued in registered form.
A register of registered shares shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the
Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile
as indicated to the Company and the number of shares held by him.
The inscription of the shareholder's name in the register of registered shares evidences his right of ownership of such
registered shares.
Any share certificates shall be signed by the Manager.
The Manager may accept and enter in the register of registered shares a transfer on the basis of any appropriate document
(s) recording the transfer between the transferor and the transferee.
Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such
address will also be entered into the register of registered shares. Shareholders may, at any time, change their address as
entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company from time to time.
The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership
of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent
such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such
share(s).
Art. 8. The Management Share held by the Manager is exclusively transferable to a successor or additional manager
with unlimited liability.
The Ordinary Shares may be freely transferred, either free of charge or against consideration, between the shareholders.
The transfer of Ordinary Shares, free of charge or against consideration, to a non-shareholder is subject to prior approval
of the Manager, within the framework of the proceedings outlined in Articles 9 and 10 hereafter. This restriction does
however not apply to mergers, divisions, winding-up, transfer of assets or any similar or analogical process.
A transfer in contradiction with the Articles 8, 9 and 10 of the present articles of incorporation shall be deemed null and
void of right and shall not give the buyer any of the rights attached to the Ordinary Shares.
Art. 9. The shareholder who wishes to transfer all or part of his Ordinary Shares, shall inform the Manager beforehand,
by registered post with acknowledgement of receipt, indicating the number of Ordinary Shares he wishes to transfer and
the asking price.
Within one (1) month of the receipt by the Manager of the application for approval of the transfer by the selling share-
holder to a non-shareholder, the Manager shall notify its decision to the selling shareholder by registered post with
acknowledgement of receipt, without statement of grounds. In case of refusal, the selling shareholder shall advise the
Manager, within fifteen (15) days of receipt of the refusal notice, whether he abandons his transfer plans or not. Should
the selling shareholder not abandon them, the Manager must, within thirty (30) days, present him with a potential buyer of
the Ordinary Shares. The selling shareholder must then sell to this buyer under the conditions of his initial offer regarding
the number of Ordinary Shares and the price, subject to the buying of all offered Ordinary Shares by the third party or
parties chosen by the Manager.
Art. 10. The price payable for the acquisition of the Ordinary Shares offered for transfer shall be ascertained, either by
mutual consent between the selling shareholder and the buying shareholder(s), or by an independent expert, appointed by
mutual consent between the selling shareholder and the buying shareholder(s), or, in case of disagreement, by an indepen-
dent expert appointed by the commercial court under whose jurisdiction the registered office of the Company falls, at the
request of the prosecuting party.
The expert shall ascertain the transfer price of the Ordinary Shares on the basis of a sale by a willing seller to a willing
buyer on the open market (disregarding any effect upon value of the Ordinary Shares forming part of a majority or minority
holding). At receipt of the valuation, the Manager shall advise the selling shareholder and the applying shareholders. They
shall then have a period of fifteen (15) days to maintain their buying and selling offers. If the selling shareholder abandons
his offer, all new transfers must nevertheless observe the entire process outlined in the preceding Article. If the selling
shareholder maintains his offer, the Ordinary Shares shall be allocated between the shareholders who have maintained their
buying offer in proportion to their participation in the capital and within the limits of their applications.
100142
L
U X E M B O U R G
The selling shareholder shall bear half of the costs of the expert appraisal and the buying shareholder(s) shall bear the
other half, in proportion to the number of Ordinary Shares which they acquired. If the sale should not be able to proceed
for several or all the offered Ordinary Shares, the selling shareholder who abandoned his offer shall exclusively bear the
costs and fees of the expert appraisal. The potential buyers who applied for the Ordinary Shares shall exclusively bear the
costs and fees for the expert appraisal if they abandoned their buying offer after the appraisal and thus no Ordinary Shares
could be sold.
C. Management
Art. 11. The Company shall be managed by General Capital Group S.àr.l., prenamed (herein referred to as the “Mana-
ger”).
The Manager may only be removed by the unanimous consent of all the shareholders.
In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as Manager
of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the supervisory board of the
Company (the "Supervisory Board") as provided for in Article 14 hereof appoints an administrator, who need not be a
shareholder, to effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such
administrator shall convene within fifteen days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint,
in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of the articles, a successor manager. Failing such
appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.
Any such appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the Manager.
Art. 12. The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition within the
purpose of the Company.
All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders or
to the Supervisory Board are within the powers of the Manager.
Art. 13. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the signature of the Manager represented by duly
appointed representatives, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the
Manager.
Art. 14. The affairs of the Company and its financial situation including in particular its books and accounts shall be
supervised by the Supervisory Board, comprising at least three members. The Supervisory Board may be consulted by the
Manager on such matters as the Manager may determine and may authorize any actions of the Manager that may, pursuant
to law or regulation or under these articles of incorporation, exceed the powers of the Manager.
The Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period of one year. The
members of the Supervisory Board may be re-elected. The Supervisory Board may elect one of its members as chairman.
The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager.
Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at least
eight (8) days prior to the date set for such meeting, except in urgent circumstances, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram,
telex, facsimile or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at
times and places fixed in a resolution adopted by the Supervisory Board.
Any member may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or facsimile or any other similar means
of communication another member as his proxy. A member may represent several of his colleagues.
The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the members are present or represented.
Resolutions of the Supervisory Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of
extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the
meeting or any two members.
Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all the members of the Supervisory Board shall have the same effect as
resolutions voted at the Supervisory Board meetings; each member shall approve such resolution in writing, by telegram,
telex, facsimile or any other similar means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all documents
shall form the record that proves that such resolution has been taken.
Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call or
by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
Art. 15. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager is interested in, or
is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Manager who
serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
100143
L
U X E M B O U R G
D. Decisions of the shareholders
Art. 16. The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders of the Company. It shall have the powers
to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, provided that, unless otherwise provided herein,
no resolution shall be validly passed unless approved by the Manager.
General meetings of shareholders shall be convened by the Manager or by the Supervisory Board. General meetings of
shareholders shall be convened pursuant to a notice given by the Manager setting forth the agenda and sent by registered
letter at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address recorded in the register of
registered shares.
The annual general meeting shall be held on the first Friday of the month of December at 11:00 am at the registered
office or at any other place in the municipality of the registered office specified in the notice of meeting.
If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
business day.
Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of
meeting.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 17. The Company's year commences on the 1
st
of July and ends on the 30
th
of June of the next year.
Art. 18. From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to the statutory reserve required by
law. This allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached ten percent
(10%) of the subscribed share capital.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager, will determine how the remainder of the
annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
F. Amendments to the articles of incorporation
Art. 19. Subject to the approval of the Manager, these articles of incorporation may be amended from time to time by
a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915
on commercial companies, as amended, unless the articles of incorporation provide differently.
G. Dissolution - Liquidation
Art. 20. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.”
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to reallocate the existing 2.1 Class A1 Shares of the Company into 21,000 Ordinary Shares and
the existing Management Share into 10,000 Management Shares as set forth in the amended and restated version of the
articles of association of the Company.
The Meeting resolves to empower and authorize the Manager to reallocate the existing shares issued by the Company
into the corresponding number and class of shares and to amend the register of shareholders of the Company accordingly.
<i>Sixth and seven resolutionsi>
Upon change of the legal regime, the Meeting resolves to end the mission of the external auditor of the Company with
immediate effect.
The Meeting resolves to fix the number of the members of the supervisory board to 3 (three) and to appoint for a period
of one (1) year:
- Mr Claude Schmitz, born on 23 September 1955 in Luxembourg, Conseil fiscal, with professional address at 2, Avenue
Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg;
- Mr Pierre Lentz, born on 22 April 1959 in Luxembourg, Expert-comptable, with professional address at 2, Avenue
Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg;
- Mr Gerdy Roose, born on 14 February 1966 in Wevelgem (Belgium), Expert-comptable, with professional address at
2, Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg.
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are
estimated to about one thousand five hundred euros Euro (EUR 1,500).
100144
L
U X E M B O U R G
<i>Powersi>
The appearing parties, acting in the same interest, do hereby grant power to any clerc and / or employee of the firm of
the undersigned notary, acting individually, in order to document and sign any deed of amendment (typing error(s)) to the
present deed.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in English
followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English text and
the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status
and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mil seize, le vingt-neuf avril.
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions GENERAL CAPITAL-
S.C.A., SICAV-SIF, qualifiée de société d'investissement à capital variable organisée comme fonds d'investissement
spécialisé avec siège social au 28-32 Place de la Gare, L - 1616 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 186308, constituée suivant acte notarié en date du 17 avril 2014,
publié au Mémorial , Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1073 du 28 avril 2014 (la "Société").
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Renaud Léonard, employé, demeurant professionnellement au
11 avenue Emile Reuter, L - 2420 Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Samia Chabane, employée, demeurant professionnellement au 11 avenue Emile
Reuter, L - 2420 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Mr Aurélien Favier, employé, demeurant professionnellement au 28-32 Place de
la Gare L-1616 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Formalités de convocation;
2. Changement de statut de la Société: abandon du régime FIS.
3. Maintien de la forme juridique de la Société de société en commandite par actions et fixation du capital social à EUR
31.000 représenté par 21.000 Actions Ordinaires et 10.000 Actions de Commandité d'une valeur nominale de EUR 1
chacune.
4. Modification subséquente et nouvelle rédaction des statuts de la Société suivie de leur traduction en français, y compris
la modification du nom de la Société en GCG EUROPE S.C.A., la fixation du capital social et la modification de l'objet
social de la Société, qui se lira comme suit:«L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous
quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxem-
bourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et
intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en
disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou
de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commer-
ciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d'une manière
ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou société apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt
financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations commer-
ciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités pré décrites se rattachant directement ou
indirectement à son objet aux fins de faciliter l'accomplissement de celui-ci. Enfin, la société pourra, pour son propre
compte, acquérir, détenir, donner en location et/ou éventuellement construire tout bien immobilier sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg ou à l'étranger.»
5. Réattribution des 2,1 Actions de Classe A1 existantes de la Société en 21.000 Actions Ordinaires et de l'Action de
Commandité en 10.000 Actions de Commandité comme définis dans la version modifiée et reformulée des statuts de la
Société.
6. Révocation du réviseur d'entreprises agréé de la Société.
7. Nomination d'un conseil de surveillance composé de 3 membres.
8. Divers.
100145
L
U X E M B O U R G
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-
tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
„ne varietur“ par les comparants et le notaire soussigné aux fins d'enregistrement.
III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée à savoir 2,1 actions de classe
A1 et 1 action de commandité, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés
se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'Assemblée a connaissance du fait que les actionnaires de la Société ont été dûment convoqués et ont une parfaite
connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolution:i>
L'Assemblée décide:
- que la Société ne sera plus régie par la loi du Luxembourg du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement
spécialisés, telle que modifiée;
- de l'abandon du statut FIS de la Société; et
- de poursuivre la Société comme une société commerciale ordinaire soumise à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de maintenir la forme juridique de la Société en société en commandite par actions et de fixer le
capital social à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 21.000 Actions Ordinaires et 10.000 Actions de
Commandité d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.
Un inventaire du portefeuille / bilan intermédiaire au 15 avril 2016 après avoir été paraphé „ne varietur“ par les com-
parants et le notaire soussigné restera annexé aux présentes aux fins d'enregistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société en GCG EUROPE S.C.A. et l'objet social qui
aura la teneur telle que reprise ci-dessous.
En conséquence des résolutions ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier et entièrement reformuler les statuts de la
Société suivis d'une traduction en français qui seront dorénavant lus comme suit:
«A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-après
créées, une société en commandite par actions sous la dénomination de "GCG EUROPE S.C.A." (la "Société"), qui sera
soumise à la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi qu'aux présents statuts.
Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Par décision du Gérant,
des succursales, des filiales ou d'autres bureaux peuvent être établis tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par simple décision du Gérant.
Au cas où le Gérant estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire, de nature à compromettre
les activités normales de la Société à son siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se déclarent ou sont
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances
anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par
voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière
tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié,
et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société
jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part,
d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale
ou société apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales
100146
L
U X E M B O U R G
ou société apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou
garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme
empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités pré décrites se rattachant directement ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l'accomplissement
de celui-ci.
Enfin, la société pourra, pour son propre compte, acquérir, détenir, donner en location et/ou éventuellement construire
tout bien immobilier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Art. 5. Le Gérant est conjointement et solidairement responsable de toutes les dettes qui ne peuvent être payées par les
actifs de la Société. Les porteurs d'Actions Ordinaires s'abstiendront d'agir pour le compte de la Société de quelque manière
ou en quelque qualité que ce soit autrement qu'en exerçant leurs droits d'actionnaire lors des assemblées générales, et ne
sont tenus que dans la limite de leurs apports à la Société.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. La Société a un capital souscrit de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par vingt et un mille (21.000)
Actions Ordinaires et par dix mille (10.000) Actions de Commandité, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-)
chacune. Les Actions de Commandité seront détenues par General Capital Group S.àr.l., en tant qu'actionnaire commandité.
Art. 7. Toutes les actions de la Société seront émises sous forme nominative.
Un registre des actions nominatives sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par
la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu,
tels qu'ils ont été communiqués à la Société, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient.
Le droit de propriété de l'actionnaire sur l'action nominative s'établit par l'inscription de son nom dans le registre des
actions nominatives.
Tous les certificats d'actions seront signés par le Gérant.
Le Gérant peut accepter et inscrire dans le registre des actions nominatives un transfert sur base de tout document
approprié constatant le transfert entre le cédant et le cessionnaire.
Les actionnaires devront fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront
être envoyées. Cette adresse sera également portée au registre des actions nominatives. Les actionnaires peuvent à tout
moment changer leur adresse enregistrée dans le registre des actions nominatives par le biais d'une communication écrite.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si la propriété de l'action est indivise ou litigieuse, les per-
sonnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société.
L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés à l'action.
Art. 8. L'Action de Commandité appartenant au Gérant ne peut être cédée qu'à un gérant remplaçant ou additionnel
ayant une responsabilité illimitée.
Les Actions Ordinaires peuvent être librement cédées, soit à titre gratuit ou soit à titre onéreux, entre actionnaires. La
cession d'Actions Ordinaires à titre gratuit ou onéreux au profit d'une personne non actionnaire est soumise à l'autorisation
du Gérant dans le cadre de la procédure exposée aux articles 9 et 10 ci-après. Cette limitation ne concerne cependant pas
les fusions, scissions, liquidations, transferts d'actifs ou autres procédés similaires ou analogues.
Un transfert en contradiction avec les articles 8, 9 et 10 des présents statuts est nul de plein droit et ne donne au
cessionnaire aucune des prérogatives attachées à l'Action Ordinaire.
Art. 9. L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses Actions Ordinaires doit en informer au préalable le Gérant par
lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant le nombre de titres à céder et le prix demandé.
Dans la période d'un (1) mois à compter de la réception par le Gérant de la demande d'agrément de cession par l'ac-
tionnaire cédant à un non actionnaire, le Gérant doit notifier au cédant sa décision, par lettre recommandée avec avis de
réception, sans indication de motifs. En cas de refus d'agrément, le cédant dispose d'un délai de quinze (15) jours, à compter
de la réception de la notification du refus, pour notifier au Gérant s'il renonce ou non à son projet de cession. Dans le cas
où le cédant n'y renonce pas, le Gérant est tenu, dans un délai de trente (30) jours de lui présenter un acquéreur potentiel
des Actions Ordinaires. Le cédant est alors tenu de vendre à cet acquéreur dans les conditions de son offre initiale, en ce
qui concerne le nombre d'Actions Ordinaires et le prix, sous réserve toutefois que le ou les tiers, choisis par le Gérant se
soient portés acquéreurs de la totalité des Actions Ordinaires offertes.
Art. 10. Le prix payable pour l'acquisition des Actions Ordinaires à céder est déterminé, soit de commun accord entre
l'actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) acquéreur(s), soit par un expert indépendant, désigné de commun accord par
l'actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) acquéreur(s), soit, en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé
par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la Société, à la requête de la partie la plus diligente.
L'expert devra évaluer le prix de cession des Actions Ordinaires sur base d'une cession par un vendeur de bonne foi à
un acheteur de bonne foi sur un marché de pleine concurrence (sans prendre en compte l'incidence qu'aurait sur la valeur
de l'Action Ordinaire le fait d'appartenir à un groupement majoritaire ou minoritaire). Dès réception de cette évaluation, le
Gérant informera le cédant et les actionnaires intéressés. Ceux-ci disposeront alors d'un délai de quinze (15) jours pour
100147
L
U X E M B O U R G
maintenir leurs offres de vente et d'achat. Dans le cas où le cédant renoncerait à son offre, toute nouvelle cession devra
respecter l'ensemble de la procédure décrite à l'article précédent. Dans le cas où le cédant maintiendrait son offre, les Actions
Ordinaires sont attribués aux actionnaires qui ont maintenu leurs offres d'achat au prorata de leur participation dans le
capital et dans la limite de leurs demandes.
Les frais d'expertise sont supportés moitié par l'actionnaire cédant, moitié par le ou les actionnaire(s) acquéreur(s) au
prorata du nombre d'Actions Ordinaires pour lesquelles ils sont acquéreurs. Si la vente ne peut avoir lieu pour tout ou partie
des Actions Ordinaires proposées, les frais et honoraires d'expertise restent à charge exclusive du cédant qui a retiré son
offre de vente. Ils restent à charge exclusive du ou des candidat(s) cessionnaire(s) si celui-ci ou ceux-ci ont retiré leur offre
d'achat après évaluation d'expert et si ainsi aucune Action Ordinaire n'a pu être vendue.
C. Gérance
Art. 11. La Société sera administrée par General Capital Group S.àr.l. (dans cet acte le “Gérant”).
Le Gérant peut seulement être remplacé par l'accord unanime de tous les actionnaires.
En cas d'incapacité légale, de liquidation ou d'une autre situation permanente empêchant le Gérant d'exercer ses fonctions
au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le conseil de surveillance
de la Société (le "Conseil de Surveillance"), suivant l'article 14, nomme un administrateur, qui n'a pas besoin d'être ac-
tionnaire, afin d'exécuter les actes de gestion simples ou urgents, jusqu'à ce que se tienne une assemblée générale
d'actionnaires, convoquée par cet administrateur dans les quinze jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale,
les actionnaires pourront nommer un gérant remplaçant, en respectant les règles de quorum et de majorité requises pour la
modification des statuts. L'absence d'une telle nomination entraînera la dissolution et la liquidation de la Société.
Une telle nomination d'un gérant remplaçant n'est pas soumise à l'approbation du Gérant.
Art. 12. Le Gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour faire tous les actes d'administration et de disposition
relevant de l'objet de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des
actionnaires ou au Conseil de Surveillance de la Société relèvent du Gérant.
Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature du Gérant, représenté par des repré-
sentants dûment nommés ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil
pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant.
Art. 14. Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris notamment la tenue de sa comptabilité, seront
surveillées par le Conseil de Surveillance composé d'au moins trois membres. Le Conseil de Surveillance peut être consulté
par le Gérant sur toutes les matières que le Gérant déterminera et pourra autoriser les actes du Gérant qui, selon la loi, les
règlements ou les présents statuts, excèdent les pouvoirs du Gérant.
Le Conseil de Surveillance sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période d'un an. Les
membres du Conseil de Surveillance peuvent être ré-élus. Le Conseil de Surveillance peut élire un de ses membres comme
président.
Le Conseil de Surveillance est convoqué par son président ou par le Gérant.
Une notification écrite de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donnée à tous ses membres au moins huit (8)
jours avant la date fixée pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature des circonstances constitutives de l'urgence
sera contenue dans la convocation. Cette convocation peut être outrepassée par écrit, télégramme, télex ou télécopie ou
tout autre moyen de communication similaire. Il ne sera pas nécessaire d'établir des convocations spéciales pour des réunions
qui seront tenues à des dates et lieux prévus préalablement par une résolution du Conseil de Surveillance.
Chaque membre peut agir lors de toute réunion du Conseil de Surveillance en nommant par écrit, par télégramme, télex,
télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, un autre membre pour le représenter. Chaque membre peut
représenter plusieurs de ses collègues.
Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité de ses membres sont présents
ou représentés.
Les résolutions du Conseil de Surveillance sont inscrites dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion.
Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président de la
réunion ou deux membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Les décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance ont le même effet que les
décisions votées lors d'une réunion du Conseil; chaque membre doit approuver une telle décision par écrit, télégramme,
télex, télécopie ou tout autre mode de communication analogue. Une telle approbation doit être confirmée par écrit et tous
les documents constitueront la preuve qu'une telle décision a été adoptée.
Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à une réunion du Conseil de surveillance par conférence télé-
phonique ou d'autres moyens de communication similaires par lesquels toutes les personnes prenant part à cette réunion
peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion.
100148
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Aucune convention ou autre transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourra
être affectée ou annulée par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir du
Gérant auraient un intérêt dans telle autre société ou firme ou par le fait qu'ils seraient administrateurs, associés, directeurs,
fondés de pouvoir ou employés de cette autre société ou firme. Tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir du Gérant
qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des
contrats ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de
voter et d'agir en toutes matières relatives à de pareils contrats ou pareilles affaires.
D. Décisions des actionnaires
Art. 16. L'assemblée générale des actionnaires de la Société représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les
pouvoirs pour ordonner, faire ou ratifier les actes relatifs aux opérations de la Société, sous réserve que, sauf si les présents
statuts en disposent autrement, une résolution ne sera valablement adoptée que si elle est approuvée par le Gérant.
L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Gérant ou par le Conseil de Surveillance. Les assemblées
générales d'actionnaires seront convoquées par une convocation donnée par le Gérant indiquant l'ordre du jour et envoyé
par courrier recommandé au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion à chaque actionnaire à l'adresse des
actionnaires telle qu'inscrite au registre des actions nominatives.
L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de décembre à 11:00 heures, au siège social ou
dans tout autre lieu de la commune du siège social indiqué dans la convocation.
Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l'assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable
suivant.
D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les convocations.
E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 17. L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de juillet et se termine le trente juin de l'année
suivante.
Art. 18. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront affectés à la réserve légale. Cette affectation
cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour-cent (10%) du capital social souscrit.
L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du Gérant, déterminera comment disposer du restant des
bénéfices nets annuels.
Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions légales.
F. Modification des statuts
Art. 19. Les présents statuts pourront être modifiés, sous condition de l'approbation du Gérant, par une assemblée
générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée, à moins que les présents statuts n'en disposent autrement.
G. Dissolution - Liquidation
Art. 20. En cas de dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommés par
l'assemblée générale des actionnaires qui a décidé la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs ainsi que leur rémuné-
ration, procéderont à la liquidation.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée générale décide de réattribuer les 2,1 actions de classe A1 existantes en 21.000 Actions Ordinaires et
l'action de commandité en 10.000 Actions de Commandité, telles que définies à la version modifiée et mise à jour des
statuts de la Société.
L'assemblée générale décide de donner pouvoir à et d'autoriser l'Associé commandité à réattribuer les actions existantes
émises par la Société au nombre et à la classe d'actions correspondant et de modifier en conséquence le registre des
actionnaires de la Société.
<i>Sixième et septième résolutionsi>
Compte tenu du changement de régime juridique, l'assemblée générale décide de mettre fin, avec effet immédiat, aux
activités du Réviseur d'entreprises agréé.
L'assemblée générale décide de fixer le nombre de membre du conseil de surveillance à 3 (trois) et de nommer pour une
durée d'un (1) an:
- Monsieur Claude Schmitz, né le 23 septembre 1955 à Luxembourg, Conseil fiscal, demeurant professionnellement au
2, Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, Expert-comptable, demeurant professionnellement au 2,
Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg; et
- Monsieur Gerdy Roose, né le 14 février 1966 à Wevelgem (Belgique), Expert-comptable, demeurant professionnel-
lement 2, Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg.
100149
L
U X E M B O U R G
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500).
<i>Pouvoirsi>
Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude
du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au
présent acte.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent acte
de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants, et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus
du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent
acte.
Signé: Renaud Léonard, Samia Chabane, Aurélien Favier, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 02 mai 2016. 1LAC/2016/14349. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole Frising.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016109345/572.
(160081827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
RT Holdings II WG (US), LP, Société en Commandite simple.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 176.509.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
Exequtive Management S.à r.l.
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2016107152/13.
(160078750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Schneider Electric Major Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 35, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 105.764.
<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique du 22 mars 2016i>
<i>Première Résolutioni>
L'Associé Unique prend acte et accepte la démission de Monsieur Mohamed BENABDA en date du 22 mars 2016 de
ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 23 mars 2016.
<i>Deuxième Résolutioni>
L'Associé Unique nomme pour une durée indéterminée, Monsieur Nicolas MONTEL, Ingénieur Financier, né le 4 avril
1985 a Annecy et résidant professionnellement au 35, route de Longwy à L-8080 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg,
en qualité de gérant de la Société avec effet au 23 mars 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
100150
L
U X E M B O U R G
Etabli Grand-Duché de Luxembourg, le 10 mai à Bertrange.
SEMI Sàrl
Référence de publication: 2016107160/18.
(160078578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Sos Ambu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 186.826.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/05/2016.
GMT Fiduciaire SA
Luxembourg
Référence de publication: 2016107170/12.
(160079359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
SELP (Bravo Spare 2) S..à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 35-37, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 190.007.
En date du 2 juillet 2015, l’associé unique SELP (Bravo Germany) S.à r.l., avec siège social au 35-37, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg, a cédé la totalité de ses 12.500 parts sociales à SELP Administration S.à r.l., avec siège social
au 35-37, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, qui les acquiert.
En conséquence, l’associé unique de la société est SELP Administration S.à r.l., précité, avec 12.500 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2016.
Référence de publication: 2016107188/14.
(160078901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
T.L.O. Diana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 63.647.
Les Comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 10/05/2016.
<i>Pour T.L.O. DIANA S.A.
i>J. REUTER
Référence de publication: 2016107215/12.
(160078782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
T.L.O. Diana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 63.647.
Les Comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 10/05/2016.
<i>Pour T.L.O. DIANA S.A.
i>J. REUTER
Référence de publication: 2016107216/12.
(160078783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
100151
L
U X E M B O U R G
The Enterprise Expansion Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 184.554.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions des Actionnaires de la Société prises en date du 18 novembre 2015 que:
- M. Tolga Kirhan, né le 24 avril 1978 à Bonn/Bad Honnef en Allemagne, demeurant à Rossbacherstrasse 8B, 53547
Breitscheid, Allemagne, a été nommé en tant qu'administrateur de la Société, en remplacement de M. Wilhelm Icke, avec
effet au 19 avril 2016 et ce pour une durée déterminée pouvant se renouveler jusqu'à l'assemblée générale approuvant les
comptes annuels 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
The Enterprise Expansion Fund
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2016107223/17.
(160079457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Tankreederei II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 76.034.
<i>Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates Abgehalten am 14. Januar 2016 um 14.30 Uhri>
Der Verwaltungsrat beschließt, das Mandat des Depositars FIDUCIAIRE MOSELLAN Sari., eingetragen im Handels-
register Luxemburg unter der Nummer B120014 mit Sitz in L-5401 Ahn, 7, route du Vin, mit heutigem Datum aufzuheben.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2016107231/12.
(160079345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2016.
Melica Software S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 175.562.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
Référence de publication: 2016107971/11.
(160080565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
MG Transports S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4984 Sanem, P.A.E. Gadderscheier.
R.C.S. Luxembourg B 108.192.
Le Bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2016107972/10.
(160080091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
100152
L
U X E M B O U R G
Midest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 127.868.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration du 13 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg,Président
- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
Référence de publication: 2016107973/18.
(160080346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Matrisa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 134.544.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration du 13 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653, au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg, Président
- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
Référence de publication: 2016107963/18.
(160080572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Matrisa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 134.544.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
Référence de publication: 2016107964/11.
(160080572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Makeland Trading and Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 90.830.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 3 novembrei>
<i>2015i>
Il résulte du procès-verbal que:
Monsieur Lex BENOY a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.
100153
L
U X E M B O U R G
La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social 45-47, route d’Arlon, L-1140
Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’année
2017.
Luxembourg, le 3 novembre 2015.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016107950/16.
(160079881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Marmolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-7348 Heisdorf, 3, rue Jean Koenig.
R.C.S. Luxembourg B 44.956.
Constituée le 14 septembre 1993 par-devant le notaire Maître Alphonse Lentz, de résidence à Remich
CLÔTURE DE LA LIQUIDATION
<i>Extrait des décisions des associés prises en date du 11 mai 2016i>
Les associés décident de prononcer la clôture de la liquidation de la Société.
Les associés décident que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant cinq ans, à
partir de la date de la publication des présentes dans le Journal Official du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des
Sociétés et Associations, Mémorial C, à l'adresse suivante: 3, rue Jean Koenig, L-7348 Heisdorf.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MARMOLUX S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016107959/17.
(160079896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Pervinage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 294.962.500,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 115.755.
EXTRAIT
En date du 10 Mai 2016, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Madame Barbara Neuerburg en tant que gérant de la Société avec effet au 10 Mai 2016;
- La nomination de Madame An-An Shong, née à Taipei, Taiwan, le 25 Septembre 1984 avec adresse professionnelle
au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en tant que gérant de la Société est acceptée avec effet au 10 Mai 2016
et pour une période indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 10 Mai 2016.
Référence de publication: 2016108040/16.
(160080461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
PetroChina Energy Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 25.000,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 149.286.
EXTRAIT
En date du 10 mai 2016, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- la démission de Madame Barbara Neuerburg en tant que gérant B de la Société avec effet au 10 mai 2016;
- la nomination de Madame An-An Shong, née à Taipei, Taiwan, le 25 Septembre 1984 avec adresse professionnelle
au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société est acceptée avec effet au 10 mai 2016
et pour une période indéterminée.
100154
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016108041/16.
(160080637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Premier Cru Multi Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 75.337.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
Référence de publication: 2016108047/11.
(160080577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Prie & Gie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7794 Bissen, 9, rue M.C. de Bertrand.
R.C.S. Luxembourg B 206.029.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechszehn, den dritten Tag im Monat Mai.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz zu Niederanven.
Sind erschienen:
1.- Herr Alain Pries, privater Angestellter, geboren am 10. August 1968, in Luxemburg, wohnhaft in L-7794 Bissen, 9,
rue M.C. de Bertrand.
2.- Herr Ronny Giesa, privater Angestellter, geboren am 18. Dezember 1976, in Wismar (D), wohnhaft in D-20459
Klein Rönau, Wilhelm-Kistenmacher Str. 2a.
Diese Erschienenen ersuchen den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft
mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Die vorbenannten Erschienenen errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeich-
nung "Prie&Gie S.à r.l.".
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Bissen.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist Beratung & Service Provider für Solvium Capital Portfolio GmbH & Co. KG mit
Hauptsitz in D- 20459 Hamburg, Englische Planke 2.
Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck
der Gesellschaft in Verbindung stehen.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jede Art finanzieller, beweglicher und unbeweglicher, kommerzieller und in-
dustrieller Operationen tätigen, welche sie zur Verwirklichung und Förderung ihres Zweckes für notwendig erachtet.
Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in zwei hundert
(200) Geschäftsanteile zu je zweiundsechzig Euros und fünfzig Cents (EUR 62,50,-).
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen
und Verlusten der Gesellschaft.
Jeder Anteilsinhaber hat ein Stimmrecht verhältnisgleich seiner Anteile zu den Gesamtanteilen. Kollektive Beschlüsse
können die Anteilsinhaber bei ihren Versammlungen nur fassen, wenn sie zusammen mehr als die Hälfte des Gesell-
schaftskapitals vertreten.
Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 bedürfen Beschlüsse zur
Änderung der Satzung jedoch einer Mehrheit von Anteilen, die zusammen mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
100155
L
U X E M B O U R G
Art. 8. Die Anteile sind frei übertragbar zwischen den Gesellschaftern. Die Anteile können nur an Nicht-Gesellschafter
übertragen werden mit der Genehmigung der Gesellschafterversammlung.
Ein Gesellschafter, welcher seine Anteile ganz oder teilweise an Nicht-Gesellschafter übertragen möchte, muss die
übrigen Gesellschafter per Einschreiben davon informieren, wie viele Anteile er an wen übertragen möchte unter Angabe
von Namen, Vornamen, Beruf und Wohnort des Übernehmers sowie des angebotenen Preises.
Die übrigen Gesellschafter haben ein Vorkaufsrecht für die zur Übertragung anstehenden Anteile im Verhältnis ihrer
jeweiligen Beteiligung.
Verzichtet ein Gesellschafter auf sein Vorkaufsrecht, so geht dieses auf die verbleibenden Gesellschafter über.
Ein Gesellschafter muss sein Vorkaufsrecht innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Erhalt der im zweiten Absatz
erwähnten Information geltend machen indem er die Gesellschaft per Einschreibebrief von seiner Absicht in Kenntnis setzt.
Geschieht dies nicht in der genannten Frist, so verliert dieser Gesellschafter sein Vorkaufsrecht.
Spätestens 60 Tage nachdem die Gesellschafter von der Übertragungsofferte informiert wurden, müssen die übrigen
Gesellschafter dem abtretenden Gesellschafter mitteilen, wieviele Anteile und von welchen Gesellschaftern im Rahmen
des Vorkaufsrechtes erworben werden möchten. Der Preis dieser Anteile entspricht ihrem Buchwert zum Ende des letzten
Geschäftsjahres. Der Buchwert eines Anteiles ist in einer vereinfachten Formel definiert als Eigenmittel der Gesellschaft,
vermindert um eine eventuelle vor dem Anteilverkauf getätigten Gewinnverteilung und geteilt durch die Gesamtanzahl der
Anteile der Gesellschaft. Die Eigenmittel (fonds propres) ergeben sich aus dem Jahresabschluss des letzten Geschäftsjahres
der Gesellschaft vor dem Verkauf der Anteile. Der Preis ist zahlbar unter den von den Gesellschaftern festgelegten Be-
dingungen und Fristen.
Falls kein Gesellschafter fristgerecht Gebrauch von seinem Vorkaufsrecht gemacht hat, ist der abtretende Gesellschafter
frei, seine Anteile an den Nicht-Gesellschafter zu den abgemachten Bedingungen zu veräußern.
Die Übertragung der Gesellschaftsanteile an Nichtgesellschafter infolge Sterbefalls unterliegt der Regelung von Art.
189, Absatz 2 bis 8, des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden
von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Ums-
tänden im Namen der Gesellschaft zu handeln.
Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen
für die Gesellschaft zu handeln.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung
ihres Mandates verantwortlich.
Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-
sellschaft nicht auf.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die,
in der letzten Bilanz aufgeführte Werte halten.
Im Todesfalle eines Gesellschafters fallen dessen Gesellschaftsanteile an die bleibenden Gesellschafter und sind zum
Buchwert an den Nachfolger auszuzahlen.
Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den
Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Dieser
Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern
ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Vorübergehende Bestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2016.
100156
L
U X E M B O U R G
<i>Zeichnung der Anteilei>
Die zwei-hundert (200) Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
1.- Herr PRIES Alain, vorbenannt, einhundert (100) Anteile
2.- Herr GIESA Ronny, vorbenannt, einhundert (100) Anteile
TOTAL: zweihundert (200) Anteile
Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von
zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen
wurde.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden auf eintausend einhundert Euro (EUR 1.100,-) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschließend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusam-
mengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Zum technischen Geschäftsführer wird Herr PRIES ALAIN, vorbenannt, ernannt.
2.- Zum administrativen Geschäftsführer wird Herr GIESA RONNY, vorbenannt, ernannt.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des technischen Geschäftsführers bis zu einem Betrag
von eintausend Euros (EUR 1.000,-), durch die alleinige Unterschrift des administrativen Geschäftsführers im adminis-
trativen Bereich bis zu einem Betrag von eintausend Euros (EUR 1.000,-) oder durch die gemeinsame Unterschrift des
technischen und des administrativen Geschäftsführers.
3.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-7794 Bissen, 9, rue M.C. de Bertrand
Der Notar hat die Erschienenen darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-
sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist, was
die Erschienenen ausdrücklich anerkennen.
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Pries Alain, Giesa Ronny, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 04 mai 2016. 1LAC / 2016 / 14749. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 11. Mai 2016.
Référence de publication: 2016108048/125.
(160080917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Prodsavor Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 150.000,00.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 182.534.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 21 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des gérants est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Lu-
xembourg.
100157
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Référence de publication: 2016108049/20.
(160080269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
PA Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.967.935,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 131.840.
Le bilan de la société au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016108051/12.
(160080260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Pacôme, Société Anonyme.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 141.818.
La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2014 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2016108052/11.
(160079895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Pafema S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 19/21, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 155.507.
Suite à une cession de parts intervenues sous seing privé, le capital social de la société se répartit comme suit:
Monsieur Paulo José ALVES ROLO né le 3 février 1967 à Samuel/Soure (P),
demeurant à L-3323 Bivange, 23, Rue de Kockelscheuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120 parts sociales
120 parts sociales
Ensuite l'associé unique a pris la résolution suivante:
La démission du gérant administratif Monsieur Abilio Filipe MOREIRA GUEDES est acceptée.
Monsieur Paulo José ALVES ROLO né le 3 février 1967 à Samuel/Soure (P), demeurant à
L-3323 Bivange, 23, Rue de Kockelscheuer
est confirmé dans son poste de gérant unique.
Le pouvoir de signature est désormais défini de cette façon:
La société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique
Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Luxembourg, le 14 avril 2016.
Paulo José ALVES ROLO.
Référence de publication: 2016108053/21.
(160079518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
100158
L
U X E M B O U R G
Callirius Holdco S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 6-8, op der Ahlkerrech.
R.C.S. Luxembourg B 205.767.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the fourteenth day of April.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Callirius, S.C.S., a company governed by the laws of Luxembourg, having its registered office in Grevenmacher, Lu-
xembourg, in the process of being registered with the Luxembourg trade and companies register,
here represented by Mrs. Solange Wolter-Schieres, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party have requested the notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société
à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Callirius Holdco
S. à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, public offering, exchange or otherwise.
2.2 The Company may - directly and/or (several times if required) indirectly through its subsidiaries - realize real estate
related investments, in particular acquire, hold, manage, design and sell real property.
2.3 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.4 The Company may act as general partner with unlimited liability in Luxembourg and foreign partnerships.
2.5 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.6 The objects of the Company as specified in the preceding paragraphs shall be construed in the widest sense as to
include any activity, operation, transaction or purpose which is directly or indirectly related or conductive thereto it being
understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that
would be considered as a regulated activity by the financial sector.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may
be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders, adopted in
the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
100159
L
U X E M B O U R G
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of shareholders not exceeding forty
(40).
6.4 The death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any
of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office, where it shall be available for inspection by any shareholder.
This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration may be issued upon
request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until one person has been designated as representative in relation to the Company.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the
shareholders, at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the other shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such
approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, to his wife/husband or any other legal
heir of the deceased shareholder.
C. Management
Art. 8. Powers of the sole manager; composition and powers of the board of managers.
8.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers composed of at least one (1) Class A manager and one (1) Class B manager. If the Company is
managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these
articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of association is to be construed as a
reference to the "sole manager".
8.2 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, including, for the avoidance of doubt, the power to make
all elections (whether tax or non-tax) for and on behalf of the Company, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 9. Election, removal and term of office of managers.
9.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
9.2 The managers are elected and may be removed from office at any time, with or without cause, by a vote of the
shareholders representing more than half of the Company's share capital.
Art. 10. Vacancy in the office of a manager.
10.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
10.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
100160
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Convening meetings of the board of managers.
11.1 The board of managers shall meet upon call by any manager, at the place indicated in the notice of meeting. The
meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company, unless otherwise indicated in the
notice of meeting.
11.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of
such emergency must be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient
proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers.
11.3 No prior notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at
such meeting and have waived any convening requirement, or in the case of resolutions in writing approved and signed by
all members of the board of managers.
Art. 12. Conduct of meetings of the board of managers.
12.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
12.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the
board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.
12.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy in
writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more, but not all of his colleagues.
12.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
12.5 The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is and at least one
(1) Class A manager and one Class B manager are present or represented at a meeting of the board of managers..
12.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote.
12.7 Save as otherwise provided by the Law, any manager who has, directly or indirectly, an interest in a transaction
submitted to the approval of the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of
managers of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The
relevant manager may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict
of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to taking any resolution on any other item.
12.8. The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. The manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.
Art. 13. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
13.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or, in his absence,
by the chairman pro tempore. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or
otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any manager.
13.2 The decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies
or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole
manager.
Art. 14. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, (ii) if the Company has several managers, by the joint signatures of one (1) Class A
Manager and one (1) Class B Manager, or (iii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such
signatory power may have been delegated by the board of managers.
D. Decisions of the shareholders
Art. 15. Collective decisions of the shareholders. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective
of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 16. Powers of the general meeting of shareholders; written shareholders' resolutions.
16.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders on such date, an annual general meeting of
shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg at the registered office
100161
L
U X E M B O U R G
of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting. If such day
is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of share-
holders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting.
16.2 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association. Save a higher majority as provided herein, collective decisions of the Company's shareholders are only
validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
16.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25), collective decisions otherwise conferred
on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each shareholder
shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing. Such
written resolutions are only validly taken in accordance with the Law in so far as such written resolution is approved by
shareholders owning more than half of the share capital.
Art. 17. Change of nationality. The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by
unanimous consent.
Art. 18. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
Art. 19. Powers of the sole shareholder. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted
to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Law. In such case, any reference made
herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the
context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole
shareholder.
E. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 20. Financial year. The financial year of the Company shall begin on first January of each year and shall end on
thirty-first December of the same year.
Art. 21. Annual accounts and Allocation of profits.
21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
21.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
21.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
21.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
21.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
21.6 Unless otherwise provided in these articles of association, each share is entitled to the same fraction of such balance.
Art. 22. Interim dividends - Share premium.
22.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to an reserve which the law or these articles of
association do not allow to be distributed.
22.2 Any share premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the
foregoing provisions.
F. Supervision of the Company
Art. 23. Auditor(s).
23.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the statutory auditor(s) and shall determine their term of office.
23.2 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
23.3 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Com-
pany.
100162
L
U X E M B O U R G
23.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditor'(s) (reviseur(s) d'entreprises agree(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting
and annual accounts of undertakings, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.
23.5. Any independent auditor may only be removed with cause or with its approval by the general meeting of share-
holders.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who
are appointed by the general meeting of shareholders, deciding such dissolution and which shall determine their powers
and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation
of the assets and payment of the liabilities of the Company.
24.2 Unless otherwise provide in these articles of association, the surplus resulting from the realisation of the assets and
the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the
Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing Law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
I. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on the thirty-first
December 2016.
2. Interim dividends may also be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) issued shares have been subscribed as follows:
- twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by Callirius, S.C.S. aforementioned, for the price
of one Euro (EUR 1.-) each;
All the shares so subscribed are fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Resolutions of the shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and considering himself as duly
convened, has thereupon passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 6-8, op der Ahlkerrech, 6776 Grevenmacher, Grand
Duchy of Luxembourg;
2. The following person is appointed as Class A Manager of the Company for an unlimited term:
- Richard Kohl, professionally residing at 6-8, op der Ahlkerrech, 6776 Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg.
3. The following person is appointed as Class B Manager of the Company for an unlimited term:
- Rolf Elgeti, professionally residing at c/o Obotritia Capital KGaA, Försterweg 2, 14482 Potsdam, Germany.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary this deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundsechzehn, den vierzehnten April.
Vor uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
100163
L
U X E M B O U R G
Callirius, S.C.S., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischen Recht mit Sitz in Grevenmacher,
Luxemburg, derzeit im Eintragungsprozess in das luxemburgische Handels- und Gesellschaftsregister befindlich,
vertreten durch Frau Solange Wolter-Schieres, geschäftsansässig in Luxemburg, kraft einer ihr erteilten Vollmacht.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die erschienene Partei hat den Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée) urkundlich festzustellen, welche sie mit der folgenden Satzung gründen:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Firmenname. Nunmehr besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter
dem Firmennamen Callirius Holdco S. à r.l., (die „Gesellschaft“) nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915") und dieser Satzung.
Art. 2. Zweck.
2.1 Gesellschaftszweck ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an inund ausländischen Gesellschaften und sons-
tigen Vermögensanlagen in jeder Form; der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und Ent-
wicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, ein öffentliches Angebot, Tausch oder auf
sonstige Art.
2.2 Die Gesellschaft kann - direkt und/oder (ggf. auch mehrfach) indirekt über ihre Tochtergesellschaften - grundstück-
bezogene Investitionen tätigen, insbesondere Grundstücke erwerben, halten, verwalten, entwickeln und veräußern.
2.3 Die Gesellschaft kann weiter für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Recht
jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicherheiten
einräumen, Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.
2.4 Die Gesellschaft kann als Komplementär mit unbeschränkter Haftung in Kommanditgesellschaften nach Luxem-
burger oder ausländischem Recht tätig werden.
2.5 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, Finanzmittel beschaffen, insbesondere Auf-
nahme von Darlehen oder Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen,
Obligationen und generell jede Form von Schuldscheinen.
2.6 Die in den vorangehenden Absätzen dargestellten Ziele sind im weitest möglichen Sinne zu verstehen und schließen
daher jegliche Aktivitäten, Rechtsgeschäfte oder Zwecke ein, die sich direkt oder indirekt hierauf beziehen, wobei die
Gesellschaft keine Rechtsgeschäfte eingehen darf, welche eine regelungsbedürftige Aktivität im Finanzsektor darstellen
würde.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt
werden. Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Form gefasst wird, in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-
herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen können, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölf tausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in zwölf
tausend fünf hundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil.
Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme an ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
5.2 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in
der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
100164
L
U X E M B O U R G
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit gleichem Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz oder
ein anderes, ähnliches, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, das von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann.
Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf Kosten
des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem von mehreren Personen gehaltenen Anteil auszusetzen,
bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Die Anteile dürfen inter vivos neuen Gesellschaftern nur mit der Zustimmung von Gesellschaftern in einer Gesell-
schafterversammlung, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten wirksam, nachdem die Gesellschaft
von der Übertragung gemäß Artikel 1690 des Code Civil in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur mit Zustimmung von Gesellschaftern, die
mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Rechte vertreten, an neue Gesellschafter übertragen werden.
Ein derartiger Beschluss ist jedoch nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/
n Ehepartner/in oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
C. Geschäftsführung
Art. 8. Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
8.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Sollte die Gesellschaft durch mehrere
Geschäftsführer geleitet werden, dann bilden diese den Geschäftsführungsrat, sich aus mindestens einem (1) Geschäfts-
führer der Klasse A und einem (1) Geschäftsführer der Klasse B zusammensetzt. Sofern die Gesellschaft von einem
einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird
ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.
8.2 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und
alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, einschließlich,
zur Klarstellung der Ausübung von Wahlrechten steuerlicher oder nichtsteuerlicher Natur, mit Ausnahme der durch das
Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Handlungen.
Art. 9. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
9.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
9.2 Geschäftsführer können jederzeit ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr
als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, abberufen werden.
Art. 10. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
10.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderem Grund
aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüngliche
Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum, kommissarisch bis zur nächsten Gesellschafterversammlung besetzt werden,
in welcher diese im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entschei-
det.
10.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-
züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 11. Einladung zu Sitzung des Geschäftsführungsrats.
11.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Vorsitzenden oder durch eines seiner
Mitglieder an dem in der Ladung angegebenen Ort. Die Geschäftsführungsratssitzungen finden, soweit in der Ladung nichts
anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
11.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum
zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dring-
100165
L
U X E M B O U R G
lichkeit in der Ladung zu bezeichnen sind. Eine solche Ladung ist nicht notwendig, falls alle Geschäftsführer per Post,
Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels, ihre Zustimmung abgegeben haben, wo-
bei eine Kopie des unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Auch ist eine Ladung
zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats dann nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Geschäftsführungsrats bestimmt worden sind.
11.3 Eine Ladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle La-
dungsvoraussetzungen abbedungen haben, oder im Falle von schriftlichen und von allen Mitgliedern des Geschäftsfüh-
rungsrats unterzeichneten Umlaufbeschlüssen.
Art. 12. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
12.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat
kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.
12.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats geleitet, sofern
dieser anwesend ist. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat jedoch ein anderes Mitglied des Geschäfts-
führungsrats durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
12.3 Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Mitglied des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es
ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch ein unterzeichnetes Dokument, welches per Faxschreiben, E-Mail
oder ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie der
Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere
aber nicht alle Kollegen aus dem Verwaltungsrat vertreten.
12.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-
deres Kommunikationsmittel, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an
der Sitzung teilzunehmen, abgehalten werden. Eine solche Teilnahme ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme
an einer solchen Sitzung und eine derartig abgehaltene Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft abgehalten erachtet.
12.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist, davon mindestens ein (1) Geschäftsführer der Klasse A und min-
destens ein (1) Geschäftsführer der Klasse B.
12.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats hat im Falle von
Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme.
12.7 Unbeschadet etwaiger gesetzlicher Vorschriften muss jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats, das an einer
Transaktion, die dem Geschäftsführungsrat zur Entscheidung vorliegt, ein direktes oder indirektes ein Interesse hat, welches
dem Interesse der Gesellschaft entgegensteht, den Geschäftsführungsrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und
diese Erklärung muss ins Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen werden. Das betreffende Mitglied des Ge-
schäftsführungsrats kann weder an der Beratung über die in Frage stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber
abstimmen. Die nächste Gesellschafterversammlung muss über einen solchen Interessenskonflikt vor der Beschlussfassung
über andere Tagesordnungspunkte informiert werden.
12.8 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung per
Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines so gefassten Beschlusses.
Art. 13. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
13.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates oder,
im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore unterzeichnet. Jede Kopie und jeder Auszug solcher
Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgezeigt werden müssen, müssen vom Vorsitzenden
des Geschäftsführungsrates, unterzeichnet werden.
13.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers müssen in ein Protokoll aufgenommen werden, welches von dem
Einzelgeschäftsführer unterzeichnet werden muss. Jede Kopie und jeder Auszug solcher Protokolle, die in einem Ge-
richtsverfahren oder aus sonstigen Gründen benötigt werden, müssen vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet werden.
Art. 14. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen (i) durch die Unterschrift
des Einzelgeschäftsführers oder, (ii) für den Fall, dass die Gesellschaft über mehrere Geschäftsführer verfügt, durch die
gemeinsame Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Klasse A und eines (1) Geschäftsführers der Klasse B, oder (iii)
durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbe-
fugnis durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist.
D. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 15. Kollektive Entscheidungen der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl der von
ihm gehaltenen Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie
er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.
100166
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Befugnisse der Gesellschafterversammlung; Schriftliche Gesellschafterbeschlüsse.
16.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, soll eine jährliche Hauptver-
sammlung innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Ende jedes Geschäftsjahres in Luxembourg am eingetragenem Sitz
der Gesellschaft, oder an jedem anderen in der Ladung bezeichneten Ort in Luxemburg, stattfinden. Falls der Tag der
Hauptversammlung ein gesetzlicher Feiertag ist, wird sie auf nächsten Werktag verschoben. Andere Gesellschafterver-
sammlungen finden an demjenigen Ort und zu demjenigen Zeitpunkt statt, der in der Ladung festgelegt worden ist.
16.2 Die Gesellschafterversammlung verfügt über die vom Gesetz und von dieser Satzung vorgesehene Befugnisse.
Außer im Fall von durch diese Satzung vorgesehenen strengeren Mehrheitserfordernissen sind Gesellschafterbeschlüsse
nur dann wirksam gefasst, wenn eine Anzahl von Gesellschaftern zustimmt, die gemeinsam mehr als die Hälfte des Ge-
sellschaftskapitals hält.
16.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, können gemeinschaft-
liche Entscheidungen, die an sich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, wirksam im Wege eines Umlaufbe-
schlusses getroffen werden. Diese gemeinschaftlichen Entscheidungen sind nur dann im Sinne des Gesetzes wirksam
getroffen, wenn der betreffende Umlaufbeschluss von Gesellschaftern unterzeichnet wird, die gemeinsam mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 17. Änderung der Nationalität. Die Nationalität der Gesellschaft kann nur durch einstimmigen Beschluss der Ge-
sellschafter geändert werden.
Art. 18. Änderung der Satzung. Vorbehaltlich anderer Regelungen in dieser Satzung erfordert die Änderung der Satzung
einen Beschluss (i) der Mehrheit der Gesellschafter und (ii) einer Mehrheit von mindestens Dreiviertel des gehaltenen
Gesellschaftskapitals.
Art. 19. Befugnisse des Einzelgesellschafters. Für den Fall, dass ein Einzelgesellschafter die Gesellschaft hält, übt dieser
die Befugnisse der Gesellschafterversammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 aus. Für diesen Fall ist jeder
Hinweis auf die „Gesellschafterversammlung“ je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, als Verweis auf den Ein-
zelgesellschafter zu verstehen, und die Befugnisse, die an sich der Gesellschafterversammlung zustehen, stehen in diesem
Fall dem Einzelgesellschafter zu.
F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden
Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Jahresabschluss und Gewinne.
21.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang
mit den gesetzlichen Bedingungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.
21.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die Gesamtsumme
der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft beträgt.
21.3 Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können mit Zustimmung dieses Gesell-
schafters ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
21.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann im Verhältnis dazu die gesetzliche Rücklage der Ge-
sellschaft herabgesetzt werden, so dass sie stets zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
21.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung, wie der verbleibende Rest
des Jahresnettogewinns der Gesellschaft nach den gesetzlichen Regelungen und den Regelungen dieser Satzung verwendet
werden soll.
21.6 Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt wird, berechtigt jeder Anteil zur gleichen Teilhabe am Jahres-
nettogewinn.
Art. 22. Zwischendividenden - Ausgabeagio.
22.1 Der Geschäftsführungsrat kann Zwischendividenden zahlen auf Grundlage von durch den Geschäftsführungsrat
vorzulegenden Zwischenabschlüssen, welche belegen, dass ausreichende Mittel für eine Zwischendividende zur Verfügung
stehen. Der ausgegebene Betrag darf die seit Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls
erhöht durch vorgetragene Gewinne und Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Bei-
träge, welche nach den Regelungen dieser Satzung und des Gesetzes einer Rücklage zugeführt werden müssen, nicht
übersteigen.
22.2 Das Ausgabeagio und andere ausschüttbare Rücklagen können gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915
frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.
100167
L
U X E M B O U R G
F. Aufsicht der Gesellschaft
Art. 23. Rechnungsprüfer.
23.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere satzungsmäßigen Rechnungsprüfer beaufsichtigt
(commissaire(s)), vorausgesetzt, sie hat mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter. Die Gesellschafterversammlung
ernennt die satzungsmäßigen Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
23.2 Jeder satzungsmäßige Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung der Gesell-
schafter abberufen werden.
23.3 Die satzungsmäßigen Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht zur Aufsicht und Kontrolle bezüglich aller
Geschäfte der Gesellschaft.
23.4 Wenn die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19.
Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen einen oder
mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernannt hat, ersetzen diese die satzungsmäßigen
Rechnungsprüfer.
23.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidator.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidator ausgeführt,
welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die die Auflösung der Gesellschaft beschließt und
die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren
unbegrenzte Rechte bei Verwertung der Vermögenswerten und Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Soweit in dieser Satzung nicht anderes bestimmt ist, wird der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und
Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der
Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddrei-
ßigsten Dezember 2016.
2. Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zwölf tausend fünf hundert (12.500) -) auszugebenden Anteile werden wie folgt gezeichnet:
Callirius, S.C.S., vorbenannt, zeichnete zwölf tausend fünf hundert (12.500) - Anteile zum Preis von einem Euro (EUR
1.-) jeweils;
Alle gezeichneten Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von zwölf tausend
fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.
Der Ausgabebetrag besteht aus zwölf tausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) die dem Gesellschaftskapital zukom-
men.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.500,- geschätzt.
<i>Hauptversammlung des Gesellschaftersi>
Der Gründer der Gesellschaft, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt und die sich als ordnungsgemäß geladen
erachtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist in 6-8, op der Ahlkerrech, 6776 Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg;
2. Die folgende Person wird als Geschäftsführer der Klasse A der Gesellschaft für eine unbeschränkte Zeit ernannt:
- Richard Kohl, geschäftsansässig in in 6-8, op der Ahlkerrech, 6776 Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg.
3. Die folgende Person wird als Geschäftsführer der Klasse B der Gesellschaft für eine unbeschränkte Zeit ernannt:
- Rolf Elgeti, geschäftsansässig in c/o Obotritia Capital KGaA, Försterweg 2, 14482 Potsdam, Deutschland.
Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
100168
L
U X E M B O U R G
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, bestätigt hiermit auf Ersuchen der erschienenen
Partei, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Text soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Parten, die dem Notar mit Name, Vorname und
Wohnsitz bekannt ist, verlesen wurde, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: S. WOLTER-SCHIERES und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/13318. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 2. Mai 2016.
Référence de publication: 2016101791/552.
(160073040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2016.
Natixis Trust, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 35.141.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 19 avril 2016i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date
du 19 avril 2016:
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale ordinaire acte la démission, en date du 12 octobre 2015, de M. Stéphane Leroy de son mandat
d'administrateur.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale décide de ratifier la cooptation en qualité d'administrateur, intervenue lors du conseil d'adminis-
tration du 13 octobre 2015, de M. Olivier Gayraud, né le 3 juillet 1962 à Paris (13
ème
), domicilié professionnellement
68-76 Quai de la Rapée F-75012 Paris, en remplacement de M. Stéphane Leroy, démissionnaire, pour la durée du mandat
de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2015.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat d'administrateur, venu à échéance de M. Georges Eric
Nivelleau de la Brunière, domicilié professionnellement 50 avenue Montaigne F-75008 Paris, pour une durée de six (6)
années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat d'administrateur, venu à échéance de M. Jacques-Antoine
Allain, domicilié professionnellement 50 avenue Montaigne F-75008 Paris, pour une durée de six (6) années, soit jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat d'administrateur, venu à échéance de Mme Valérie
Derambure, domiciliée professionnellement 50 avenue Montaigne F-75008 Paris, pour une durée de six (6) années, soit
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
<i>Neuvième résolutioni>
L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat d'administrateur, venu à échéance de M. Olivier Gayraud,
domicilié professionnellement 68-76 Quai de la Rapée F-75012 Paris, pour une durée de six (6) années, soit jusqu'à l'issue
de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
<i>Onzième résolutioni>
L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler pour une durée d'une (1) année le mandat du réviseur d'entreprises,
la société Deloitte Audit, société à responsabilité limitée.
Le mandat se terminera lors de l'assemblée générale statutaire approuvant les comptes de l'exercice 2016.
100169
L
U X E M B O U R G
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016109592/42.
(160081460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Invista European RE Marseille PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 112.739.
Les comptes annuels au 30 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105011/9.
(160077266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Invista European RE Monbonnot HoldCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 119.879.
Les comptes annuels au 30 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105012/9.
(160077267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Victoria Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 101.716.
In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of March.
Before Us, Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
Is held
an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of VICTORIA HOLDING S.à R.L. (the “Com-
pany”), a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered office at 61, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés, section B, under number 101716
and incorporated pursuant to a deed dated 29 June 2004 drawn up by Me Joseph ELVINGER, then notary residing in
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Memorial C”) number 917 dated
14 September 2004 (page 44010). The articles of association of the Company (the “Articles”) have been amended for the
last time by a deed dated 16 July 2007 drawn up by the same notary, published in the Memorial C, number 2128 dated 28
September 2007 (page 102119).
The meeting elects as chairman Mr Julien DEMELIER-MOERENHOUT, employee, residing professionally in Lu-
xembourg.
The chairman appoints as secretary and the Meeting elects as scrutineer Mrs Rachel BERNARD, employee, residing
professionally in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to enact that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the
proxies signed “ne varietur” will be registered with this deed.
II. It appears from the attendance list that the totality of the two million six hundred twenty-two thousand four hundred
ninety-one (2,622,491) class A shares, two million five hundred thousand one (2,500,001) class B shares, two million five
hundred thousand one (2,500,001) class C shares, two million five hundred thousand one (2,500,001) class D shares, two
million five hundred thousand one (2,500,001) class E shares, two million five hundred thousand one (2,500,001) class F
shares, two million five hundred thousand one (2,500,001) class G shares, two million five hundred thousand one
(2,500,001) class H shares, two million five hundred thousand one (2,500,001) class I shares and two million five hundred
thousand one (2,500,001) class J shares with a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each, representing the entirety
of the share capital of the Company are represented in this extraordinary general meeting. All the shareholders declare
having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities.
The Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the agenda.
III The agenda of the meeting (the “Agenda”) is the following:
100170
L
U X E M B O U R G
<i>Agendai>
(A) To acknowledge and approve the repurchase by the Company pursuant to a resolution of the board of managers
passed on 22 March 2016 and based on interim accounts dated 21 March 2016, of the 2,500,001 class J shares in the
Company each having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) per share.
(B) To complete the consequent reduction of the Company's current share capital of EUR 251,225 by an amount of EUR
25,000.01 to the amount of EUR 226,224.99 by the cancellation of the repurchased shares.
(C) To amend articles 5 and 20 of the Articles to reflect the proposed resolutions.
(D) Miscellaneous.
Then the Meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting acknowledges and approves the repurchase by the Company of the two million five hundred thousand one
(2,500,001) class J shares in the Company, having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) per share, for a total
amount of twenty-five thousand Euros and one cent (EUR 25,000.01), pursuant to a resolution of the board of managers
passed on 22 March 2016 and based on interim accounts dated 21 March 2016, with effect as of 22 March 2016.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to proceed to a capital reduction by the amount of twenty-five thousand Euros and one cent (EUR
25,000.01), so as to decrease the share capital from its current amount of two hundred fifty-one thousand two hundred
twenty-five Euros (EUR 251,225) to the amount of two hundred twenty-six thousand two hundred twenty-four Euros and
ninety-nine cents (EUR 226,224.99), through the cancellation of the totality of the two million five hundred thousand one
(2,500,001) class J shares that the Company repurchased pursuant to the aforementioned board of managers held on 22
March 2016.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above, the Meeting resolves to amend articles 5.1 and 20 of the Articles, which shall now read
as follows:
“ Art. 5.1 Corporate Capital. The share capital is fixed at two hundred twenty-six thousand two hundred twenty-four
Euros and ninety-nine cents (EUR 226,224.99) represented by two million six hundred twenty-two thousand four hundred
and ninety-one (2,622,491) class A shares, two million five hundred thousand and one (2,500,001) class B shares, two
million five hundred thousand and one (2,500,001) class C shares, two million five hundred thousand and one (2,500,001)
class D shares, two million five hundred thousand and one (2,500,001) class E shares, two million five hundred thousand
and one (2,500,001) class F shares, two million five hundred thousand and one (2,500,001) class G shares, two million five
hundred thousand and one (2,500,001) class H shares and two million five hundred thousand and one (2,500,001) class I
shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Euro cent) each (hereafter together referred to as the "Shares". The holders
of the Shares are together referred to as the "Shareholders".”
“ Art. 20. Distribution right of shares.
20.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company, in accordance with the Law and the accounting principles.
20.2 Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.
20.3 At anytime, the Company may decide that a specific entire class of Shares starting in the reverse alphabetical order
with Class I shares first, shall be redeemed under the terms and conditions to be determined by the Board of Managers and
subsequently to proceed with the reduction of the share capital by cancellation of the redeemed class of Shares.
20.4 The holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares,
Class G Shares, Class H Shares and Class I Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend
representing 0.2% of the nominal value of each share issued by the Company (the "Preferred Dividend"). After the payment
of the Preferred Dividend, all remaining income available for distribution in the Company, if any, shall be paid to the
holders of Class I Shares.
In the case where there shall no longer be any Class I Shares outstanding in the Company, the holders of Class H Shares
shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any, after the pro rata payment of
the Preferred Dividend to the holders of Class A, Class B, Class C, Class D, Class E, Class F, Class G and Class H Shares.
In the case where there shall no longer be any Class H and Class I Shares outstanding in the Company, the holders of
Class G Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any, after the pro rata
payment of the Preferred Dividend to the holders of Class A, Class B, Class C, Class D, Class E, Class F and Class G
Shares.
In the case where there shall no longer be any Class G, Class H and Class I Shares outstanding in the Company, the
holders of Class F Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any, after
100171
L
U X E M B O U R G
the pro rata payment of the Preferred Dividend to the holders of Class A, Class B, Class C, Class D, Class E and Class F
Shares.
In the case where there shall no longer be any Class F, Class G, Class H and Class I Shares outstanding in the Company,
the holders of Class E Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any,
after the pro rata payment of the Preferred Dividend to the holders of Class A, Class B, Class C, Class D and Class E Shares.
In the case where there shall no longer be any Class E, Class F, Class G, Class H and Class I Shares outstanding in the
Company, the holders of Class D Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution,
if any, after the pro rata payment of the Preferred Dividend to the holders of Class A, Class B, Class C and Class D Shares.
In the case where there shall no longer be any Class D, Class E, Class F, Class G, Class H and Class I Shares outstanding
in the Company, the holders of Class C Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for
distribution, if any, after the pro rata payment of the Preferred Dividend to the holders of Class A, Class B and Class C
Shares.
In the case where there shall no longer be any Class C, Class D, Class E, Class F, Class G, Class H and Class I Shares
outstanding in the Company, the holders of Class B Shares shall be granted the right to receive all remaining income
available for distribution, if any, after the pro rata payment of the Preferred Dividend to the holders of Class A and Class
B Shares.
In the case where there shall no longer be any Class B, Class C, Class D, Class E Shares, Class F, Class G, Class H and
Class I Shares, outstanding in the Company, the holders of Class A Shares shall be granted the right to receive all remaining
income available for distribution, if any, after the payment of the Preferred Dividend...
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred and fifty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons,
the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons, and in
case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by name, first name, civil status and
residence, they signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le trente mars.
Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
S'est tenue
l'assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) des associés de VICTORIA HOLDING S.à R.L. (la “Société”), une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 61, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
101716 et constituée en vertu d'un acte du 29 juin 2004 reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le “Mémorial C”) numéro 917 du 14 septembre
2004 (page 44010). Les statuts de la Société (les “Statuts”) ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte du 16
juillet 2007 reçu par ce même notaire, publié au Mémorial C, numéro 2128, du 28 septembre 2007 (page 102119).
L'assemblée élit en tant que président Monsieur Julien DEMELIERMOERENHOUT, employé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Le président nomme en tant que secrétaire et l'Assemblée élit en tant que scrutateur Madame Rachel BERNARD,
employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président requiert le notaire instrumentant de prendre acte que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales détenues par chacun d'entre eux sont mentionnés
sur une liste de présence signée par les associés ou leurs mandataires, le bureau de l'assemblée et le notaire. Ladite liste
ainsi que les procurations signées ne varietur seront enregistrées avec le présent acte.
II. La liste de présence montre que la totalité des deux millions six cent vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-onze
(2.622.491) parts sociales de catégorie A, deux millions cinq cent mille une (2.500.001) parts sociales de catégorie B, deux
millions cinq cent mille une (2.500.001) parts sociales de catégorie C, deux millions cinq cent mille une (2.500.001) parts
sociales de catégorie D, deux millions cinq cent mille une (2.500.001) parts sociales de catégorie E, deux millions cinq
cent mille une (2.500.001) parts sociales de catégorie F, deux millions cinq cent mille une (2.500.001) parts sociales de
100172
L
U X E M B O U R G
catégorie G, deux millions cinq cent mille une (2.500.001) parts sociales de catégorie H, deux millions cinq cent mille une
(2.500.001) parts sociales de catégorie I et deux millions cinq cent mille une (2.500.001) parts sociales de catégorie J ayant
une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. Tous les associés déclarent avoir été informés à l'avance de
l'ordre du jour et ont renoncé à toutes exigences et formalités de convocation. L'Assemblée est ainsi régulièrement constituée
et peut valablement délibérer et décider sur son ordre du jour.
III. L'ordre du jour de l'Assemblée (l'“Ordre du Jour”) est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
(A) Reconnaître et approuver le rachat par la Société, conformément à une résolution du conseil de gérance adoptée le
22 mars 2016 et basée sur des comptes intérimaires datés du 21 mars 2016, des 2.500.001 parts sociales de catégorie J de
la Société ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) par part sociale.
(B) Procéder à la réduction du capital social de la Société qui en résulte pour un montant de vingt-cinq mille un euros
(25.001,- EUR), afin de le réduire du montant de 251.225 EUR à celui de 226.224,99 EUR par l'annulation des parts sociales
rachetées.
(C) Modifier les articles 5 et 20 des Statuts afin de refléter les résolutions présentées.
(D) Divers.
Ensuite, l'Assemblée, après délibération, a adopté unanimement les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée prend acte de et approuve le rachat par la Société des deux millions cinq cent mille une (2.500.001) parts
sociales de catégorie J de la Société, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) par part sociale, pour un
montant total de vingt-cinq mille euros et un centime (25.000,01 EUR), conformément à une résolution du conseil de
gérance adoptée le 22 mars 2016 et basée sur des comptes intérimaires datés du 21 mars 2016, ayant effet au 22 mars 2016.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de procéder à une réduction de capital d'un montant de vingt-cinq mille euros et un centime
(25.000,01 EUR), de façon à réduire le capital social de son montant actuel de deux cent cinquante et un mille deux cent
vingt-cinq euros (251.225,- EUR) au montant de deux cent vingt-six mille deux cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-
dix-neuf centimes (226.224,99 EUR), par l'annulation de la totalité des deux millions cinq cent mille une (2.500.001) parts
sociales de catégorie J que la Société a racheté conformément à la résolution du conseil de gérance précédemment men-
tionnée adoptée le 22 mars 2016.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée décide de modifier les articles 5.1 et 20 des Statuts qui seront désormais
lus comme suit:
“ Art. 5.1. Capital social. Le capital social est fixé à deux cent vingt-six mille deux cent vingt-quatre euros et quatre-
vingt-dix-neuf centimes (226.224,99 EUR) représenté par deux millions six cent vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-
onze (2.622.491) parts sociales de catégorie A, deux millions cinq cent mille une (2.500.001) parts sociales de catégorie
B, deux millions cinq cent mille une (2.500.001) parts sociales de catégorie C, deux millions cinq cent mille une (2.500.001)
parts sociales de catégorie D, deux millions cinq cent mille une (2.500.001) parts sociales de catégorie E, deux millions
cinq cent mille une (2.500.001) parts sociales de catégorie F, deux millions cinq cent mille une (2.500.001) parts sociales
de catégorie G, deux millions cinq cent mille une (2.500.001) parts sociales de catégorie H et deux millions cinq cent mille
une (2.500.001) parts sociales de catégorie I ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune (ci-après
ensemble désignées les "Parts Sociales"). Les détenteurs des Parts Sociales sont ensemble désignés les "Associés".”
“ Art. 20. Droit de distribution des parts.
20.1 Le solde créditeur des comptes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, provisions et charges
représente le bénéfice net de la Société, conformément à la Loi et aux principes de comptabilité.
20.2 Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront transférés à la réserve légale. Cette déduction cesse d'être
obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital émis.
20.3 A tout moment, la Société peut décider qu'une catégorie spécifique entière de Parts Sociales commençant par ordre
alphabétique inverse avec la Catégorie I en premier soit rachetée selon les termes et conditions déterminés par le Conseil
de Gérance et de procéder subséquemment à la réduction du capital social par l'annulation de la catégorie de Parts Sociales
rachetée.
20.4 Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A, Parts Sociales de Catégorie B, Parts Sociales de Catégorie C, Parts
Sociales de Catégorie D, Parts Sociales de Catégorie E, Parts Sociales de Catégorie F, Parts Sociales de Catégorie G, Parts
Sociales de Catégorie H et Parts Sociales de Catégorie I se verront accorder le droit de recevoir, au prorata de leur détention,
un dividende préférentiel représentant 0,2% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société (le «Dividende
100173
L
U X E M B O U R G
Préférentiel»). Après le paiement du Dividende Préférentiel, le solde disponible pour distribution dans la Société, le cas
échéant, sera payé aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I.
Dans le cas où il n'y aurait plus de détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I dans la Société, les détenteurs de Parts
Sociales de Catégorie H se verront le droit de recevoir tout le solde disponible pour distribution, le cas échéant, après le
paiement au prorata de leur détention du Dividende Préférentiel aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A, Catégorie
B, Catégorie C, Catégorie D, Catégorie E, Catégorie F, Catégorie G et Catégorie H.
Dans le cas où il n'y aurait plus de détenteurs de Parts Sociales de Catégorie H ni de Catégorie I dans la Société, les
détenteurs de Parts Sociales de Catégorie G se verront le droit de recevoir tout le solde disponible pour distribution, le cas
échéant, après le paiement au prorata de leur détention du Dividende Préférentiel aux détenteurs de Parts Sociales de
Catégorie A, Catégorie B, Catégorie C, Catégorie D, Catégorie E, Catégorie F et Catégorie G.
Dans le cas où il n'y aurait plus de détenteurs de Parts Sociales de Catégorie G, Catégorie H ni de Catégorie I dans la
Société, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F se verront le droit de recevoir tout le solde disponible pour distri-
bution, le cas échéant, après le paiement au prorata de leur détention du Dividende Préférentiel aux détenteurs de Parts
Sociales de Catégorie A, Catégorie B, Catégorie C, Catégorie D, Catégorie E et Catégorie F.
Dans le cas où il n'y aurait plus de détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F, Catégorie G, Catégorie H ni de Catégorie
I dans la Société, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E se verront le droit de recevoir tout le solde disponible pour
distribution, le cas échéant, après le paiement au prorata de leur détention du Dividende Préférentiel aux détenteurs de Parts
Sociales de Catégorie A, Catégorie B, Catégorie C, Catégorie D et Catégorie E.
Dans le cas où il n'y aurait plus de détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E, Catégorie F, Catégorie G, Catégorie H
ni de Catégorie I dans la Société, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D se verront le droit de recevoir tout le solde
disponible pour distribution, le cas échéant, après le paiement au prorata de leur détention du Dividende Préférentiel aux
détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A, Catégorie B, Catégorie C et Catégorie D.
Dans le cas où il n'y aurait plus de détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D, Catégorie E, Catégorie F, Catégorie G,
Catégorie H ni de Catégorie I dans la Société, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C se verront le droit de recevoir
tout le solde disponible pour distribution, le cas échéant, après le paiement au prorata de leur détention du Dividende
Préférentiel aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A, Catégorie B et Catégorie C.
Dans le cas où il n'y aurait plus de détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C, Catégorie D, Catégorie E, Catégorie F,
Catégorie G, Catégorie H ni de Catégorie I dans la Société, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B se verront le
droit de recevoir tout le solde disponible pour distribution, le cas échéant, après le paiement au prorata de leur détention
du Dividende Préférentiel aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A et Catégorie B.
Dans le cas où il n'y aurait plus de détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B, Catégorie C, Catégorie D, Catégorie E,
Catégorie F, Catégorie G, Catégorie H ni de Catégorie I dans la Société, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A
se verront le droit de recevoir tout le solde disponible pour distribution, le cas échéant, après le paiement du Dividende
Préférentiel...
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne prenant la parole, l'assemblée a été clôturée.
<i>Coûtsi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement mille trois cent cinquante euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des personnes comparantes, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, et qu'à la demande de ces mêmes personnes comparantes, et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Ce document ayant été lu aux personnes comparantes, connues du notaire par nom, prénom, état civil et résidence, elles
ont signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: J. DEMELIER-MOERENHOUT, R. BERNARD, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 6 avril 2016. 2LAC/2016/7353. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Yvette THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 13 avril 2016.
Référence de publication: 2016116567/252.
(160089939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2016.
100174
L
U X E M B O U R G
Iphias Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 76, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 83.321.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105035/9.
(160076900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
LUX-FUND Advisory S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 30.522.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105107/9.
(160077091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Martek Power, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 101.039.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105136/9.
(160077146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Banbury Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1474 Luxembourg, 3A, Sentier de l'Espérance.
R.C.S. Luxembourg B 201.588.
<i>Extract of the unique resolution adopted by the Board of the Sole Manager on December 18 i>
<i>thi>
<i> , 2015i>
<i>Unique resolutioni>
The Sole Manager decides to transfer the legal seat and registered office of the Company from the 17, Boulevard Royal,
L-2449 to the 3A Sentier de l'Espérance, L-1474, Luxembourg with effect on 15 January 2016.
For publication purposes,
Done in Luxembourg, on December 18
th
, 2015.
Hance Law Avocats
Olivier Hance
<i>The Domiciliating Agent / Avocat à la Couri>
Suit en français la traduction de ce qui précède:
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil de gérance du gérant unique en date du 18 décembre 2015i>
<i>Résolution uniquei>
Le gérant unique décide de transférer le siège social de la Société établit actuellement au 17 Boulevard Royal, L-2449,
Luxembourg au 3A Sentier de l'Espérance, L-1474, Luxembourg avec effet au 15 janvier 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Hance Law Avocats
Olivier Hance
<i>Le domiciliataire / Avocat à la Couri>
Référence de publication: 2016109948/27.
(160083308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
100175
L
U X E M B O U R G
Memory Keepers S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 50.085.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105141/9.
(160076780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Merinv S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 93.639.
Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105142/9.
(160077225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Monlegeac S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 97.464.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016105155/9.
(160077166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
Bottega S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 714.285,71.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 203.156.
<i>Extrait des Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société du 10 mai 2016i>
Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société que:
1. La démission de Lux Business Management S.à r.l, Gérant unique de la Société a été accepté avec effet au 11 avril
2016;
2. La création de deux catégories de Gérants de la Société. Une catégorie de type A et une catégorie de type B ont été
acceptées avec effet au 11 avril 2016;
3. Monsieur Nana BAFFOUR-GYEWU, né le 15 mai 1972 à Ghana, Ghana, résidant professionnellement au 6, TR
Newton Feitoza, 01424-030 à São Paulo, Brésil et Monsieur Frank ASANTE-KISSI, né le 9 juin 1971 à Ghana, Ghana,
résidant professionnellement au 205, 10
th
St Unit H2, Jersey City, NJ 07302-1402, États-Unis d'Amérique, ont été nommés
Gérants de catégorie A de la Société avec effet au 11 avril 2016 et ce pour une durée indéterminée.
4. Monsieur Benjamin CHOURAKI, né le 31 mars 1983 à Senlis, France, résidant professionnellement au 9, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommé Gérant de catégorie B de la Société avec effet au 11 avril 2016 et ce pour une
durée indéterminée.
Au 10 mai 2016, le Conseil de Gérance se compose comme suit:
- Monsieur Nana BAFFOUR-GYEWU, gérant de catégorie A
- Monsieur Frank ASANTE-KISSI, gérant de catégorie A
- Monsieur Benjamin CHOURAKI, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016110732/27.
(160084136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
100176
Africa Queen S.A.
Banbury Capital S.à r.l.
Bottega S.à r.l.
Callirius Holdco S. à r.l.
CEP III Alphyn I S.C.A.
Distribution S.à r.l.
Dundeal (International) 27 S.à r.l.
Edwardian Investments SA
Enet Investments S.A.
General Capital- S.C.A.
General Capital- S.C.A., SICAV-SIF
GP-7 Light Industrial LBC Vesta S.à r.l.
Gutt Drauf s.à r.l.
Invista European RE Marseille PropCo S.à r.l.
Invista European RE Monbonnot HoldCo 1 S.à r.l.
Iphias Holding S.A.
JN Consult S.à r.l.
LUX-FUND Advisory S.A.
Makeland Trading and Investments S.A.
Marmolux S.à r.l.
Martek Power
Matrisa S.A.
Matrisa S.A.
Melica Software S.A.
Memory Keepers S.A.
Merinv S.A.
MG Transports S.A.
Midest S.A.
Monlegeac S.A.
MPT RHM Flechtingen II S.à r.l.
MPT RHM Park S.à r.l.
Natixis Trust
North REOF Kubrat S.à r.l.
North REOF Moldova S.à r.l.
Pacôme
Pafema S. à r.l.
PA Holdings Luxembourg S.à r.l.
Pervinage S.à r.l.
PetroChina Energy Holding Luxembourg S.à r.l.
Phoeturum S.A.
Premier Cru Multi Investments
Prie & Gie S.à r.l.
Prodsavor Lux S.à r.l.
Quattro S.àr.l.
Reckitt Benckiser Investments (No 4) S.à r.l.
Rhine Luxembourg 2 S.C.S.
RT Holdings II WG (US), LP
Schneider Electric Major Investments S.à r.l.
SELP (Bravo Spare 2) S..à r.l.
Socaro Invest S.à r.l.
Sos Ambu S.à r.l.
Tankreederei II S.A.
The Enterprise Expansion Fund
T.L.O. Diana S.A.
T.L.O. Diana S.A.
Victoria Holding S.à r.l.