This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1798
20 juin 2016
SOMMAIRE
Advanzia Bank S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86258
ARISTEA SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86304
Aurisys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86261
Aurisys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86261
CKM Promotion Immobiliere S.à r.l. . . . . . . .
86262
CMP German Opportunity . . . . . . . . . . . . . . .
86261
CMS control of medical systems S.à r.l. . . . . .
86262
CMS control of medical systems S.à r.l. . . . . .
86262
Compagnie Financiere de Participations Im-
mobilières S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86262
Copefi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86263
Habacker LogPark Site Eight S. à r.l. . . . . . . .
86279
Habacker LogPark Site Five S. à r.l. . . . . . . . .
86280
Habacker LogPark Site Nine S. à r.l. . . . . . . .
86275
Habacker LogPark Site Six S. à r.l. . . . . . . . . .
86274
Habacker LogPark Site Three S. à. r.l. . . . . . .
86272
Habacker LogPark Site Two S. à r.l. . . . . . . . .
86273
Harry Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86274
HayFin Onyx LuxCo 2 S.C.A. . . . . . . . . . . . . .
86302
Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . .
86275
HICL Infrastructure 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
86275
Highstreet V PropCo III S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
86302
Highway Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86276
Hilbri S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86263
HPS Groupe Participations S.à r.l. . . . . . . . . .
86276
HYNSH Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86277
JP Residential VIII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
86271
JV Holdings S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86271
Kairos International Sicav . . . . . . . . . . . . . . . .
86272
K&D Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86271
Kerta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86278
KFC International Holdings I S.à r.l. . . . . . . .
86264
Kinetik S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86279
Kington S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86279
L'ODAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86270
Luxembourg Investment Company 139 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86270
MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l. . . . . .
86302
Private Placement Opportunities SICAV-SIF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86281
RE Galaxy III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86295
Rose HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86302
Spectrum Brands Lux III S.à r.l. . . . . . . . . . . .
86304
SUDTHERM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86291
Wow LuxCo 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86298
86257
L
U X E M B O U R G
Advanzia Bank S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 109.476.
In the year two thousand and sixteen, on the eighteenth day of the month of February.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting of ADVANZIA Bank S.A. (the "Company"), a société anonyme having its registered
office at 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, incorporated by deed of Maître Henri
Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 19
th
July 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the “Mémorial”) number 1315 of 2
nd
December 2005.
The articles of incorporation of the Company (the “Articles”) have been amended several times and for the last time by
a deed of Maître Blanche Moutrier of 22 April 2015, published in the Mémorial number 1527 of 18 June 2015.
The meeting was presided by Me Linda Funck, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Me Laurent Constant, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Me Laurent Constant, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I) All shareholders represented declared having had sufficient prior knowledge of the agenda of the meeting and waived
their rights to any prior convening notice thereof so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.
II) It appears from an attendance list which has been signed “ne varietur” by the undersigned notary and the members
of the bureau and which will be registered with this deed, that out of the issued share capital in the amount of seventeen
million two hundred seventy thousand two hundred fifty-three euros (€17,270,253) represented by (i) thirty thousand three
hundred and eighty-three (30,383) class A shares (the "Class A Shares"), seventeen thousand eight hundred and forty-eight
(17,848) class B shares (the "Class B Shares"), one hundred fifty-eight thousand five hundred forty-seven (158,547) class
C Shares (the "Class C Shares"), having a nominal value of eighty-three euros and fifty cents (€83.50) each, representing
in total two hundred six thousand seven hundred seventy-eight (206,778) shares with voting rights, and (ii) three thousand
four hundred thirty-two (3,432) non-voting preferred class F shares (the "Class F Shares") with a nominal value of one
euro and twenty-five cents (€1.25) each, a total of one hundred ninety-three thousand two hundred fifty-three (193,253)
shares represented by one hundred eighty-nine thousand eight hundred twenty-one (189,821) shares with voting rights and
three thousand four hundred thirty-two (3,432) non-voting shares, are duly represented at the present meeting.
The present meeting noted that the quorum required for the valid deliberations on all agenda items is met and that
consequently the present meeting was validly and regularly constituted and able to validly deliberate on the agenda as set
out in the proxies.
The attendance list, signed by the shareholders present, the proxyholders of the shareholders represented, the members
of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached together with the proxies to the present deed and shall be
filed at the same time with the registration authorities.
III) The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agendai>
1. Amendment of the first sentence of Article 9 (Annual general meeting of shareholders) of the articles of association
of the Company, so as to read as follows:
“The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office
of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on 28
th
February of
each year at 10 a.m.”
2. Amendment of the Article 5 of the articles of incorporation of the Company as follows:
“ Art. 5. Share Capital - Authorised Share Capital - Increase and reduction of subscribed/authorised share capital. The
subscribed capital of the Company is set at seventeen million two hundred seventy thousand two hundred fifty three euros
(EUR 17,270,253) divided into (i) thirty thousand three hundred eighty-three (30,383) class A shares (the “Class A Shares”),
seventeen thousand eight hundred forty-eight (17,848) class B shares (the “Class B Shares”), one hundred fifty-eight
thousand five hundred forty-seven (158,547) class C Shares (the “Class C Shares”) having a nominal value of eighty-three
euros and fifty cents (EUR 83.50) each and (ii) three thousand four hundred thirty two (3,432) preferred non-voting class
F shares (the “Class F Shares”) with a nominal value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, representing in
total two hundred ten thousand two hundred and ten (210,210) shares.
Class F Shares may be converted into Class B Shares in accordance with the provisions of the law of August tenth,
nineteen hundred and fifteen on commercial companies as amended. Non-voting preferred shares (other than Class F Shares)
may also be converted into ordinary voting shares subject to applicable quorum and majority requirements provided for
by law.
86258
L
U X E M B O U R G
The subscribed share capital of the Company may be increased or decreased by resolution of the general meeting of
shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation. Except in case of issue within
the limits of the authorised share capital, shares of any class in issue in the Company to be subscribed for in cash shall be
offered on a pre-emptive basis first to the shareholders of the class of shares in which the shares are issued second to the
other shareholders of the Company in accordance with Article 32-3 (2) of the Luxembourg law on commercial companies.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.”
3. Removal of Articles 7.1 to 7.8 of the articles of incorporation and consequent renumbering of the following articles
of the articles of incorporation of the Company.
After deliberation, the meeting took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved with 189,821 votes in favour, 0 votes against and 0 votes abstaining, to amend the first sentence
of Article 9 (Annual general meeting of shareholders) of the articles of incorporation of the Company in the form set out
in the agenda, item 1.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved with 189,821 votes in favour, 0 votes against and 0 votes abstaining, to amend Article 5 of the
articles of association of the Company as set forth in the agenda.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolved to remove Articles 7.1 to 7.8 of the articles of incorporation of the Company and consequently
renumber the following articles of the articles of incorporation.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent on the Company and charged to it by
reason of the present deed and its execution, are assessed at one thousand four hundred Euros (1,400.- EUR).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and French texts, the English version of it will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named in the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with us, the notary
the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois de février.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue
une assemblée générale extraordinaire d’ADVANZIA Bank S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège
social au 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, constituée suivant acte reçu de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 19 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial») numéro 1315 du 2 décembre 2005.
Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 22 avril 2015
suivant acte reçu de Maître Blanche Moutrier, publié au Mémorial numéro 1527 du 18 juin 2015.
L’assemblée a été présidée par Me Linda Funck, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président a nommé comme secrétaire Me Laurent Constant, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à
Luxembourg.
L’assemblée a élu comme scrutateur Me Laurent Constant, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d’acter que:
I) Tous les actionnaires représentés ont déclaré avoir eu suffisamment connaissance de l’ordre du jour préalablement à
l’assemblée et ont renoncé à leur droit de convocation préalable à l’assemblée de sorte que cette dernière peut statuer
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
II) Il ressort d’une liste de présence qui a été signée ne varietur par le notaire soussigné et les membres du bureau et qui
sera enregistrée avec le présent acte, que sur le capital social émis de dix-sept millions deux cent soixante-dix mille deux
cent cinquante-trois euros (17.270.253 €) représenté par (i) trente mille trois cent quatre-vingt- trois (30.383) actions de
classe A (les «Actions de Classe A»), dix-sept mille huit cent quarante-huit (17.848) actions de classe B (les «Actions de
Classe B»), cent cinquante-huit mille cinq cent quarante-sept (158.547) actions de classe C (les «Actions de Classe C»)
ayant une valeur nominale de quatre-vingt-trois euros et cinquante centimes (83,50 €) chacune, représentant au total deux
cent six mille sept cent soixante-dix- huit (206.778) actions avec droit de vote et (ii) trois mille quatre cent trente-deux
86259
L
U X E M B O U R G
(3.432) actions privilégiées sans droit de vote de classe F (les «Actions de Classe F») ayant une valeur nominale d’un euro
et vingt-cinq centimes (1,25 €) chacune, soit un total de cent quatre-vingt-treize mille deux cent cinquante-trois (193.253)
actions représentées par cent quatre-vingt-neuf mille huit cent vingt et une (189.821) actions avec droit de vote et trois
mille quatre cent trente-deux (3.432) actions sans droit de vote, sont dûment représentées à la présente assemblée.
La présente assemblée a noté que le quorum requis afin de pouvoir valablement délibérer sur tous les points de l’ordre
du jour est réuni et que la présente assemblée était par conséquent valablement et régulièrement constituée et pouvait
valablement délibérer sur l’ordre du jour figurant dans les procurations.
La liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du
bureau et le notaire soussigné, ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte et seront soumises avec celui-
ci aux formalités de l’enregistrement.
III) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de la première phrase de l’article 9 (Assemblée générale annuelle des actionnaires) des statuts de la
Société afin qu'il ait la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de
la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 28 février de chaque année à
10.00 heures.»
2. Modification de l’article 5 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 5. Capital social - Capital social autorisé - Augmentation et réduction du capital social souscrit/autorisé. Le capital
souscrit de la Société est fixé à dix-sept millions deux cent soixante-dix mille deux cent cinquante-trois euros (17.270.253
EUR) divisé en (i) trente mille trois cent quatre-vingt-trois (30.383) actions de classe A (les «Actions de Classe A»), dix-
sept mille huit cent quarante-huit (17.848) actions de classe B (les «Actions de Classe B»), cent cinquante-huit mille cinq
cent quarante-sept (158.547) actions de classe C (les «Actions de Classe C») ayant une valeur nominale de quatre-vingt-
trois euros et cinquante centimes (83,50 EUR) chacune et (ii) trois mille quatre cent trente-deux (3.432) actions privilégiées
sans droit de vote de classe F (les «Actions de Classe F») ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq centimes (1,25
EUR) chacune, représentant un total de deux cent dix mille deux cent dix (210.210) actions.
Les Actions de Classe F peuvent être converties en Actions de Classe B conformément aux dispositions de la loi du dix
août mille neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Les actions privilégiées sans droit
de vote (autres que les Actions de Classe F) peuvent également être converties en actions ordinaires avec droit de vote,
sous réserve des dispositions légales applicables en matière de quorum et de majorités.
Le capital social souscrit peut être augmenté ou réduit par résolution de l’assemblée générale des actionnaires adoptée
de la manière requise pour la modification de ces statuts. Sauf en cas d’émission dans les limites du capital social autorisé,
les actions à émettre dans la Société dans une classe, à être souscrites en contrepartie d’un apport en numéraire seront
offertes sur base d’un droit de préemption en premier lieu aux actionnaires de la classe d’actions dans laquelle les actions
sont émises et ensuite aux autres actionnaires de la Société conformément à l’article 32-3 (2) de la loi luxembourgeoise
sur les sociétés commerciales.
La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.»
3. Suppression des articles 7.1 à 7.8 des statuts et renumérotation en conséquence des articles suivants des statuts de la
Société.
Après délibération, l’assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a décidé avec 189.821 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, de modifier la première phrase de l’article
9 (Assemblée générale annuelle des actionnaires) des statuts de la Société tel qu'énoncé au point 1 de l’ordre du jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée a décidé avec 189.821 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, de modifier l’article 5 des statuts de la
Société tel qu'énoncé dans l’ordre du jour.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée a décidé de supprimer les articles 7.1 à 7.8 des statuts de la Société et de renuméroter en conséquence les
articles suivants des statuts.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte et de sa signature, sont estimés à mille quatre cents Euros (1.400.- EUR).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des personnes compa-
rantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction en langue française; à la demande des mêmes
personnes comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
86260
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux personnes comparantes, lesdites personnes comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent
acte original.
Signé: L. FUNCK, L. COJNSTANT et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 25 février 2016. Relation: 1LAC/2016/6142. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 23 mars 2016.
Référence de publication: 2016084596/177.
(160052139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Aurisys S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8290 Kehlen, 13, Domaine de Brameschhof.
R.C.S. Luxembourg B 139.404.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRODESSE S.à r.l.
19, rue de la Gare
L-3237 BETTEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2016091843/13.
(160061361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Aurisys S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8290 Kehlen, 13, Domaine de Brameschhof.
R.C.S. Luxembourg B 139.404.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRODESSE S.à r.l.
19, rue de la Gare
L-3237 BETTEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2016091844/13.
(160061362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
CMP German Opportunity, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 157.944.
Par résolutions circulaires prises en date du 23 mars 2016, le conseil de gérance a pris connaissance de la décision de
la ville de Luxembourg de modifier le nom et le code postal de la rue Robert Stümper.
En conséquence, le siège social de la Société est au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
Référence de publication: 2016091907/13.
(160061373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
86261
L
U X E M B O U R G
CMS control of medical systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 167.530.
Die Bilanz zum 31. Dezember 2012 und Anhang wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxembourg
hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 13. April 2016.
Référence de publication: 2016091910/11.
(160061400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
CKM Promotion Immobiliere S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 23, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 204.895.
AUSZUG
Aus einer ausserordentlichen Generaiversammiung der Gesellschaft mit beschrankter Haftung CKM Promotion Im-
mobilière S.à r.l., mit Sitz in L-6630 Wasserbillig, 23, Grand-Rue, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister
Luxemburg unter der Nummer B 204.895, vom 7. April 2016 geht hervor dass:
- Herr Nikolaus Ludwin MAYER, geboren in Bitburg, am 12. September, wohnhaft in D-54636 Sülm, Denkmalstraße
6, zum zusätzlichen Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde,
- Herr Antonio CASTELLANETA, geboren in Luxemburg, am 30. Juni 1973, wohnhaft in L-8210 Mamer, 54, route
d'Arlon, zum zusätzlichen Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde.
Das Mandat von Herrn Jürgen Matthias KOHL als Geschäftsführer wurde bestätigt.
Jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig vertreten und verpflichtet.
Echternach, den 15. März 2016.
Référence de publication: 2016091906/18.
(160061317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
CMS control of medical systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 167.530.
Die Bilanz zum 31. Dezember 2013 und Anhang wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxembourg
hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 13. April 2016.
Référence de publication: 2016091911/11.
(160061401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Compagnie Financiere de Participations Immobilières S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.083.100,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 116, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 201.043.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par le gérant en date du 3 février 2016i>
Le Gérant de la Société a décidé:
- de transférer le siège social de la Société, du 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au 116 rue de Rollingergrund,
L-2440 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2016.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2016091913/15.
(160061258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
86262
L
U X E M B O U R G
Hilbri S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Copefi).
Siège social: L-3590 Dudelange, 59, place de l'Hôtel de Ville.
R.C.S. Luxembourg B 52.307.
L'an deux mille seize,
Le trente-et-un mars,
Par devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange,
Ont comparu:
1) Monsieur Jean CONTESTABILE, commerçant, né à Rocca Di Mezzo (Italie) le 29 mars 1939, demeurant à L-3510
Dudelange, 20, rue de la Libération;
2) Madame Elodie BRISTOT, serveuse, née à Hayange (France) le 6 mai 1981, demeurant à F-57330 Hettange-Grande,
44, rue du Général Patton,
3) Monsieur Christophe HILT, employé, né à Thionville (France) le 24 juin 1982, demeurant à F-57330 Hettange-
Grande, 44, rue Général Patton
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentaire ce qui suit:
Monsieur Jean CONTESTABILE est l'associé unique de la société à responsabilité limitée «COPEFI», établie et ayant
son siège social à L-3590 Dudelange, 59, Place de l'Hôtel de Ville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg sous le numéro B 52.307, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de rési-
dence à Dudelange, en date du 21 septembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
598 de 1995.
Le capital social est fixé à la somme de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros
(12.394,68.-€) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-
neuf euros (24,79.-€) chacune, entièrement souscrites et libérées comme suit:
- 500 parts sociales par Monsieur Jean CONTESTABILE, commerçant, né à Rocca di Mezzo (Italie), demeurant à
L-3510 Dudelange, 20, rue de la Libération.
Ceci exposé, l'associé unique représentant l'intégralité du capital social, a déclaré vouloir se considérer comme dûment
convoqué en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
1) Monsieur Jean CONTESTABILE, préqualifié, déclare céder et transporter en pleine propriété, deux cent cinquante
(250) parts sociales, inscrites à son nom de la société «COPEFI», prénommée, à Madame Elodie BRISTOT, préqualifiée,
ici présente et ce acceptant, pour le prix de six mille cent quatre-vingt-dix-sept virgule cinquante euros (6197,50.-€).
2) Monsieur Jean CONTESTABILE, préqualifié, déclare céder et transporter en pleine propriété, deux cent cinquante
(250) parts sociales, inscrites à son nom de la société «COPEFI», prénommée, à Monsieur Christophe HILT, préqualifié,
ici présent et ce acceptant, pour le prix de six mille cent quatre-vingt-dix-sept virgule cinquante euros (6197,50.-€).
Les présentes cessions sont faites moyennant le prix total de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixan-
te-huit euros (12.394,68.-€), que le cédant reconnaît avoir reçu des cessionnaires avant la passation des présentes et hors
la présence du notaire instrumentaire, ce dont il consent bonne et valable quittance aux cessionnaires.
Les cessionnaires Madame Elodie BRISTOT et Monsieur Christophe HILT, préqualifiés, seront propriétaires des parts
cédées à partir des présentes et ils auront droit aux revenus et bénéfices dont ces parts sont productives à compter de ce
jour.
<i>Deuxième résolutioni>
En conformité avec la cession de parts ci-avant faite, l'article six des statuts de la société à responsabilité limitée «CO-
PEFI», est modifié pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros
(12.394,68.-€) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-
neuf euros (24,79.-€) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
- Madame Elodie BRISTOT, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 44, rue du Général Patton,
deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
- Monsieur Christophe HILT, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 44, rue du Général Patton,
deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
TOTAL: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500»
86263
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
- L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Jean CONTESTABILE, préqualifié, de ses fonctions de gérant
et lui donne décharge quant à l'exécution de son mandat.
- L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de gérant technique de la Société, pour une durée indéterminée:
Madame Elodie BRISTOT, préqualifiée.
- L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de gérant administratif de la Société, pour une durée indéter-
minée:
Monsieur Christophe HILT, préqualifié.
Vis-à-vis des tiers la Société est engagée par la signature individuelle du gérant technique à concurrence d'un montant
de mille cinq cents euros (1.500.-€), au delà de ce montant par la signature conjointe du gérant technique et du gérant
administratif.
<i>Quatrième résolutioni>
Madame Elodie BRISTOT et Monsieur Christophe HILT, préqualifiés, en leur qualité de gérant technique, respective-
ment gérant administratif de la Société déclarent accepter la prédite cession de parts pour compte de la Société et ils la
considèrent comme dûment signifiée à la Société, conformément à l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales respectivement à l'article 1690 du Code civil.
<i>Cinquième résolution.i>
L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société à responsabilité limitée de «COPEFI» en «HILBRI
S.à r.l.», d'ajouter une enseigne commerciale sous laquelle la Société exercera son activité et de modifier par conséquent
l'article quatre (4) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. La société prend la dénomination de «HILBRI S.à r.l.»» exerçant son activité sous l'enseigne commerciale de
«U-TURN KFÉ».
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de cette assemblée générale à environ neuf cent cinquante
euros (950.-€).
DONT ACTE, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures,
ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. CONTESTABILE, E. BRISTOT, C. HILT, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 avril 2016. Relation: EAC/2016/8499. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 11 avril 2016.
C. GOEDERT.
Référence de publication: 2016091915/92.
(160060828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
KFC International Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 12.218.722.678,30.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 151.211.
In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. KFC Global Holdings, Inc., a Delaware corporation, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America (“KFC Global”);
2. Yum! Restaurants International Management LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office
at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of
America (“YRIM”); and
3. KFC International Holdings II S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) organized
under the laws of the Grand- Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855
86264
L
U X E M B O U R G
Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 190.204 (together with
KFC Global and YRIM, the “Shareholders”),
hereby represented by Mr. Régis Galiotto, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, by virtue
of proxies given under private seal.
Such proxies having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing parties are the shareholders of KFC International Holdings I S.à r.l., a private limited liability company
(“société à responsabilité limitée”) organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated by a deed enacted by the undersigned notary,
on 17 December 2009, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 582 on 18 March 2010
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 151.211 (the “Company”).
II.- The 983,319,063,118 (nine hundred eighty-three billion three hundred nineteen million sixty-three thousand one
hundred eighteen) shares, without nominal value, representing the whole share capital of the Company, are represented so
that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Shareholders expressly state having been
duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Creation of a new class of preferred shares and related amendments to the Company's articles of association;
3. Conversion of the ordinary shares held by KFC Global Holdings, Inc. into preferred shares;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment to the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
The Shareholders resolve to waive their right to the prior notice of the current meeting; the Shareholders acknowledge
being sufficiently informed on the agenda and considers the meeting to be validly convened and therefore agree to deliberate
and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the
disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.
<i>Second resolution:i>
The Shareholders resolve to authorize the Company to create, with effect as at the date hereof (the "Effective Date"), a
new class of shares, namely the preferred shares, without nominal value, having specific financial rights, as further described
below.
As a consequence, it is resolved to amend, with effect as at the Effective Date, articles 8, 11, 21, 22 and 24 of the articles
of association of the Company (the "Articles"), so as to read as follows:
" Art. 8. The share capital of the Company is set at USD 12,218,722,678.30 (twelve billion two hundred eighteen million
seven hundred twenty-two thousand six hundred seventy-eight United States Dollars and thirty cents), represented by
983,319,063,118 (nine hundred eighty-three billion three hundred nineteen million sixty-three thousand one hundred eigh-
teen) ordinary shares, without nominal value (the "Ordinary Shares").
The Company is allowed to issue preferred shares, without nominal value (the "Preferred Shares").
The financial rights and conditions attached to the Preferred Shares are further detailed in Art. 11, 21, 22 and 24.
All the Ordinary Shares and Preferred Shares will be collectively referred to as the "shares" as the case may be, or
individually as a "share".
The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the extraordinary
general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for
amendment of the Articles."
" Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares, subject to the conditions specified below.
Redemption of the Preferred Shares
The redemption of all or part of the Preferred Shares may only occur by mutual agreement of the Company and the
holder(s) of the Preferred Shares to be redeemed. In such a case, the redemption shall be carried out by means of a resolution
of an extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the
conditions required for amendment of the Articles, provided that such redemption has been proposed to each holder of
Preferred Shares in the proportion of its shareholding in Preferred Shares.
86265
L
U X E M B O U R G
The redemption price of a Preferred Share shall be equal to (i) the fair market value of a Preferred Share at the time of
the issuance of such Preferred Share or at the time of the conversion of an Ordinary Share into such Preferred Share (the
"Preferred Amount") (ii) plus accrued and unpaid dividends on the redeemed Preferred Share at the time of redemption.
However, if the redemption price for the Preferred Shares is in excess of the par value of the Preferred Shares to be
redeemed, the redemption may only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits
made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried
forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to
reserve pursuant to the requirements of the Law or of Articles.
Such redeemed Preferred Shares shall be cancelled by reduction of the share capital.
Redemption of the Ordinary Shares
Subject to the prior redemption of all the Preferred Shares, the Company may redeem the Ordinary Shares.
The redemption of the Ordinary Shares shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting
of the shareholders or of the single shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment
of the Articles.
If the redemption price for the Ordinary Shares is in excess of the par value of the Ordinary Shares to be repaid, such
redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase
price.
" Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year 5% (five percent) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital, as
decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such one
tenth.
Each Preferred Share entitles its holder to a preferential and cumulative dividend equal to 6.65% (six point sixty-five
percent) of the Preferred Amount, which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 day financial year (the
"Preferred Dividend").
If part or all of the Preferred Dividend is not approved due to the absence of sufficient net profit or for any other reason,
the amount equivalent to such Preferred Dividend shall accrue and be approved at the time of the subsequent approval of
Preferred Dividend by the Company in addition to the Preferred Dividend relating to such subsequent financial year.
The balance of the net profit, after full payment of the Preferred Dividend, may be distributed upon a decision of the
shareholders at a shareholders' meeting to the holder(s) of the Ordinary Shares only, in proportion to the number of Ordinary
Shares held in the Company".
" Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company,
or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may
be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts
prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the
last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Interim dividends shall be distributed in the same manner as described in Article 21 above. In case of a distribution to
the holder(s) of the Ordinary Shares and the holder(s) of the Preferred Shares, the Preferred Dividend will be computed on
a pro rata basis."
" Art. 24. The general meeting of shareholders shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and
determine the method of liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.
The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities (the "Liquidation Bonus") is distributed
to the shareholders as follows:
i. First, in priority to the holder(s) of the Preferred Shares, an amount equal to the Preferred Amount per Preferred Share
plus any accrued but unpaid Preferred Dividend;
ii. Secondly, after and subject to the payment to the holder(s) of the Preferred Shares in accordance with the preceding
paragraph, the balance shall be paid to the holder(s) of the Ordinary Shares only, in proportion to the number of Ordinary
Shares held in the Company."
<i>Third resolution:i>
The Shareholders further resolve to accept the conversion, with effect as at the Effective Date, of the 216,512,908,494
(two hundred sixteen billion five hundred twelve million nine hundred eight thousand four hundred ninety-four) ordinary
shares, without nominal value, held by KFC Global into 216,512,908,494 (two hundred sixteen billion five hundred twelve
million nine hundred eight thousand four hundred ninety-four) preferred shares, without nominal value.
86266
L
U X E M B O U R G
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is composed as follows:
- KFC Global Holdings, Inc.: 216,512,908,494 (two hundred sixteen billion five hundred twelve million nine hundred
eight thousand four hundred ninety-four) preferred shares;
- Yum! Restaurants International Management LLC: 664,559,958,680 (six hundred sixty-four billion five hundred fifty-
nine million nine hundred fifty-eight thousand six hundred eighty) ordinary shares; and
- KFC International Holdings II S.à r.l.: 102,246,195,944 (one hundred two billion two hundred forty-six million one
hundred ninety-five thousand nine hundred forty-four) ordinary shares.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it is resolved to amend, with effect as at the Effective
Date, the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“ Art. 8. The Company's share capital is set at USD 12,218,722,678.30 (twelve billion two hundred eighteen million
seven hundred twenty-two thousand six hundred seventy-eight United States Dollars and thirty cents), represented by
983,319,063,118 (nine hundred eighty-three billion three hundred nineteen million sixty-three thousand one hundred eigh-
teen) shares without nominal value, divided into 766,806,154,624 (seven hundred sixty-six billion eight hundred six million
one hundred fifty-four thousand six hundred twenty-four) ordinary shares (the "Ordinary Shares") and 216,512,908,494
(two hundred sixteen billion five hundred twelve million nine hundred eight thousand four hundred ninety-four) preferred
shares (the "Preferred Shares").
"No other amendments shall be made to this article.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this deed, have been estimated at about one thousand five hundred Euros (1,500.- Euro).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de mars,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire public établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. KFC Global Holdings, Inc., une société régie par les lois du Delaware, ayant sont siège social sis au Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique («KFC Global»);
2. Yum! Restaurants International Management LLC, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Delaware,
ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware
19801, Etat-Unis d'Amérique («YRIM»); et
3. KFC International Holdings II S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.204 (ensemble avec KFC Global et YRIM,
les «Associés»),
ici représentés par M. Régis Galiotto, avec adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, en vertu de
procurations données sous seing privé.
Lesdites procurations après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire agissant au nom des parties comparantes
et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci auprès des autorités
de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- Les parties comparantes sont les associés de KFC International Holdings I S.à r.l., une société à responsabilité limitée
organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, constituée selon un acte reçu par le notaire soussigné, le 17 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 582 le 18 mars 2010 et immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 151.211 (la «Société»).
II.- Les 983.319.063.118 (neuf cent quatre-vingt-trois milliards trois cent dix-neuf millions soixante-trois mille cent dix-
huit) parts sociales, sans valeur nominale, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte
86267
L
U X E M B O U R G
que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour dont les Associés reconnaissent expressé-
ment en avoir été dûment informés au préalable.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Création d'une nouvelle classe de parts sociales préférentielles et modifications relatives des statuts de la Société;
3. Conversion des parts sociales ordinaires détenues par KFC Global Holdings, Inc. en parts sociales préférentielles;
4. Nouvelle composition de la participation dans le capital social de la Société;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par les Associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
Les Associés décident de renoncer à leur droit de convocation préalable à la présente assemblée; les Associés recon-
naissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et se considèrent valablement convoqués et, en conséquence,
acceptent de délibérer et de voter sur tous les points de l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation
pertinente a été mise à la disposition des Associés dans un délai suffisant afin de leur permettre un examen attentif de
chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Les Associés décident d'autoriser la Société à créer, avec effet à la date des présentes (la «Date d'Effet»), une nouvelle
classe de parts sociales, dénommée les parts sociales préférentielles, sans valeur nominale, auxquelles sont attachés des
droits financiers particuliers, tels que décrits ci-dessous.
En conséquence, il est décidé de modifier, avec effet à la Date d'Effet, les articles 8, 11, 21, 22 et 24 des statuts de la
Société (les «Statuts»), de sorte qu'ils devront être lus de la manière suivante:
« Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 12.218.722.678,30 USD (douze milliards deux cent dix-huit millions
sept cent vingt-deux mille six cent soixante-dix-huit Dollars Américains et trente cents), représenté par 983.319.063.118
(neuf cent quatre-vingt-trois milliards trois cent dix-neuf millions soixante-trois mille cent dix-huit) parts sociales ordi-
naires, sans valeur nominale (les «Parts Ordinaires»).
La Société est autorisée à émettre des parts sociales préférentielles, sans valeur nominale (les «Parts Préférentielles»).
Les droits financiers et les conditions attachés aux Parts Préférentielles sont détaillés ci-après aux Art. 11, 21, 22 et 24.
Toutes les Parts Ordinaires et les Parts Préférentielles seront désignées collectivement comme les «parts sociales», et
le cas échéant, individuellement comme une «part sociale».
Le montant du capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit au moyen d'une décision de l'assemblée générale
extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les conditions requises pour une modification
des Statuts.»
« Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales, dans les conditions définies ci-dessous.
Rachat des Parts Préférentielles
Le rachat de tout ou partie des Parts Préférentielles ne peut avoir lieu qu'avec le consentement mutuel de la Société et
du/des détenteur(s) des Parts Préférentielles à racheter. Dans un tel cas, le rachat sera décidé par une résolution de l'as-
semblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas), adoptée selon les conditions requises
pour la modification des Statuts, à condition qu'un tel rachat ait été proposé à chaque détenteur de Parts Préférentielles en
proportion de sa détention de Parts Préférentielles.
Le prix de rachat d'une Part Préférentielle devra être égal à (i) la valeur de marché d'une Part Préférentielle au moment
de l'émission d'une telle Part Préférentielle ou au moment de la conversion d'une Part Ordinaire en une telle Part Préfé-
rentielle (le «Montant Préférentiel») (ii) augmenté des dividendes cumulés et non payés sur les Parts Préférentielles
rachetées au moment du rachat.
Néanmoins, si le prix de rachat des Parts Préférentielles excède la valeur au pair des Parts Préférentielles devant être
rachetées, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le total des
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bé-
néfices reportés et de toutes sommes issues des réserves disponibles à cet effet, et diminué des pertes reportées ainsi que
des sommes à porter en réserve conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts.
Les Parts Préférentielles ainsi rachetées seront annulées par réduction du capital social.
Rachat des Parts Ordinaires
Sous réserve du rachat préalable de toutes les Parts Préférentielles, la Société peut racheter les Parts Ordinaires.
86268
L
U X E M B O U R G
Le rachat des Parts Ordinaires ne peut être décidé qu'au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire
des associés ou de l'associé unique (selon le cas), adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts.
Si le prix de rachat des Parts Ordinaires excède la valeur au pair des Parts Ordinaires à racheter, un tel rachat ne peut
être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes sont disponibles au regard du supplément du prix
de rachat.»
« Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, coûts, amortissements, charges
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel
qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil d'un dixième.
Chaque Part Préférentielle confère à son détenteur le droit à un dividende préférentiel et cumulatif égal à 6,65% (six
virgule soixante-cinq pourcent) du Montant Préférentiel, qui s'accumulera quotidiennement et sera calculé sur la base d'un
exercice social de 365 jours (le «Dividende Préférentiel»).
Si une partie ou la totalité du Dividende Préférentiel n'est pas approuvée en raison de l'absence de profit net suffisant
ou pour toute autre raison, le montant équivalent à ce Dividende Préférentiel devra s'accumuler et être approuvé au moment
de l'approbation subséquente du Dividende Préférentiel par la Société en plus du Dividende Préférentiel relatif à cet exercice
social subséquent.
L'excédent favorable du profit net, après paiement intégral du Dividende Préférentiel, pourra être distribué au(x) dé-
tenteur(s) des Parts Ordinaires uniquement, sur décision des associés prise lors d'une assemblée des associés, en proportion
du nombre de Parts Ordinaires détenues dans la Société.»
« Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé
unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en
réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.
Les dividendes intérimaires seront distribués de la même manière que décrite à l'Article 21 ci-dessus. En cas de distri-
bution au profit du/des détenteur(s) de Parts Ordinaires et du/des détenteur(s) de Parts Préférentielles, le Dividende
Préférentiel sera calculé prorata temporis.»
« Art. 24. L'assemblée générale des associés nommera un ou plusieurs liquidateur(s), personne(s) physique(s) ou morale
(s) et déterminera la méthode de liquidation, les pouvoirs du/des liquidateur(s) et sa/leur rémunération.
Le surplus après réalisation des actifs et paiement des dettes (le «Boni de Liquidation») est distribué aux associés comme
suit:
i. Premièrement, en priorité au(x) détenteur(s) de Parts Préférentielles, un montant égal au Montant Préférentiel par Part
Préférentielle augmenté de tout Dividende Préférentiel cumulé mais non payé;
ii. Deuxièmement, après et sous réserve du paiement au(x) détenteur(s) de Parts Préférentielles conformément au pa-
ragraphe précédent, l'excédent sera payé au(x) détenteur(s) de Parts Ordinaires uniquement, en proportion du nombre de
Parts Ordinaires détenues dans la Société.»
<i>Troisième résolution:i>
Les Associés décident, ensuite, d'accepter la conversion, avec effet à la Date d'Effet, des 216.512.908.494 (deux cent
seize milliards cinq cent douze millions neuf cent huit mille quatre cent quatre-vingt-quatorze) parts sociales ordinaires,
sans valeur nominale, détenues par KFC Global en 216.512.908.494 (deux cent seize milliards cinq cent douze millions
neuf cent huit mille quatre cent quatre-vingt-quatorze) parts préférentielles, sans valeur nominale.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et des résolutions précédentes, la participation dans le capital social de la Société est
désormais composée de la manière suivante:
- KFC Global Holdings, Inc.: 216.512.908.494 (deux cent seize milliards cinq cent douze millions neuf cent huit mille
quatre cent quatre-vingt-quatorze) parts sociales préférentielles;
- Yum! Restaurants International Management LLC: 664.559.958.680 (six cent soixante-quatre milliards cinq cent
cinquante-neuf millions neuf cent cinquante-huit mille six cent quatre-vingts) parts sociales ordinaires; et
- KFC International Holdings II S.à r.l.: 102.246.195.944 (cent deux milliards deux cent quarante-six millions cent
quatre-vingt-quinze mille neuf cent quarante-quatre) parts sociales ordinaires.
86269
L
U X E M B O U R G
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des déclarations et des résolutions précédentes, il est décidé de modifier, avec effet à la Date d'Effet,
le premier paragraphe de l'article 8. des statuts de la Société, de sorte qu'il devra désormais être lu de la manière suivante:
« Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 12.218.722.678,30 USD (douze milliards deux cent dix-huit millions
sept cent vingt-deux mille six cent soixante-dix-huit Dollars Américains et trente cents), représenté par 983.319.063.118
(neuf cent quatre-vingt-trois milliards trois cent dix-neuf millions soixante-trois mille cent dix-huit) parts sociales sans
valeur nominale, divisées en 766.806.154.624 (sept cent soixante-six milliards huit cent six millions cent cinquante-quatre
mille six cent vingt-quatre) parts sociales ordinaires (les «Parts Ordinaires») et 216.512.908.494 (deux cent seize milliards
cinq cent douze millions neuf cent huit mille quatre cent quatre-vingt-quatorze) parts sociales préférentielles (les «Parts
Préférentielles»).
Aucune autre modification ne sera faite à cet article.
<i>Estimation des coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, de quelque type que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés
par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à environ mille cinq cents Euros (1.500.- Euros).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont Acte, à la suite de quoi le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour indiqué en tête du présent
document.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original
du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte, qu'à la requête de la personne compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
- Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 6 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/11173. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 14 avril 2016.
Référence de publication: 2016092715/316.
(160061928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
L'ODAS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 7, rue de la Sapinière.
R.C.S. Luxembourg B 104.453.
Les statuts coordonnés suivant le répertoire n° 2202 du 31 mars 2016 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Paul MEYERS
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016092729/12.
(160061585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Luxembourg Investment Company 139 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 204.766.
<i>Extrait des décisions prises par l’associé unique en date du 8 avril 2016i>
1. La société à responsabilité limitée RCS Management (Luxembourg) S.à r.l. a démissionné de son mandat de gérant.
2. M. Elliot GREENBERG, administrateur de sociétés, né à New York (États-Unis d’Amérique), le 19 janvier 1959,
demeurant professionnellement à 10019 New York (États-Unis d’Amérique), 40, West 57
th
Street, a été nommé comme
gérant A pour une durée indéterminée.
3. M. Joshua LEVINE, administrateur de sociétés, né à New York (États-Unis d’Amérique), le 7 novembre 1975,
demeurant professionnellement à 10019 New York (États-Unis d’Amérique), 40, West 57
th
Street, a été nommé comme
gérant A pour une durée indéterminée.
86270
L
U X E M B O U R G
4. M. Pierre CLAUDEL, administrateur de sociétés, né à Schiltigheim (France), le 23 mai 1978, demeurant profession-
nellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée.
5. M. Jérôme DEVILLET, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 21 mai 1986, demeurant profession-
nellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 14.4.2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Luxembourg Investment Company 139 S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016092741/23.
(160062000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
K&D Development, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 189.439.
Je vous informe par la présente de ma démission en qualité de gérant unique au sein de votre société qui prend effet à
compter de ce jour.
Luxembourg, le 14 avril 2016.
Hassane DIABATE.
Référence de publication: 2016092705/10.
(160062115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
JP Residential VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 110.832.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée a décidé de prononcer la clôture de la liquidation de la Société lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue le 04 décembre 2015.
L'Assemblée a décidé que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant une durée
de cinq ans à l'adresse suivante:
6, rue Dicks, 1417 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
JP Residential VIII S.à r.l.
Jargonannt Partners S.à r.l.
Par procuration
Diane Wolf
Référence de publication: 2016092703/18.
(160061810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
JV Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.566.000,00.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 195.728.
EXTRAIT
Veuillez noter que l'associé Lee Alan Lawrence a son domicile à
2 Brunswick Place, London, NW1 4PN.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Gentoo Financial Services (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliataire de sociétési>
Référence de publication: 2016092704/15.
(160061555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
86271
L
U X E M B O U R G
Kairos International Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 119.723.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 2016.
Référence de publication: 2016092707/10.
(160061986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Habacker LogPark Site Three S. à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 135.039.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendsechzehn, den einundreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Danielle KOLBACH, mit dem Amtssitz in Redange/Attert, (Großherzogtum Luxem-
burg) handelnd in Vertretung ihres verhinderten Kollegen Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster,
(Großherzogtum Luxemburg), welch letzt genannter Depositar der Urkunde bleibt.
IST ERSCHIENEN:
HABACKER LogPark HOLDING S. à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in L-1128 Luxemburg, 37, Val Saint André, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 134.784 hier vertreten durch Herrn Daniel
FONDU, Direktor, berufsansässig in Howald, 45, rue des Scillas, aufgrund einer ihm ausgestellten privatschriftlichen
Vollmacht, welche nach „ne varietur“ Signatur, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
Welche Komparentin, durch ihren Bevollmächtigte, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
1. Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Habacker LogPark Site Three S. à r.l", mit Sitz in L-1128 Luxemburg,
37, Val Saint André, eingetragen im Handels - und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
135.039, (hiernach die "Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Martine SCHAEFFER,
damals Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 4. Dezember 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 293 vom 5. Februar 2008.
2. Dass das Gesellschaftskapital zwölf tausend fünf hundert Euros (EUR 12.500.-) beträgt, eingeteilt in fünf hundert
(500) Anteile mit einem Nennwert von fünf und zwanzig Euros (EUR 25.-).
3. Dass die Unterzeichnete Besitzerin sämtlicher Anteile der Gesellschaft, die das Kapital darstellen, ist.
4. Dass die Unterzeichnete, als alleinige Gesellschafterin, beschließt die Gesellschaft, welche ihre Tätigkeit eingestellt
hat, mit sofortiger Wirkung aufzulösen und sie in Liquidation zu setzen.
5. Dass die Unterzeichnete, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft erklärt, dass sie sämtliche Vermögens-
werte übernehmen wird, dass die bekannte Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurde und dass sie sich
ausdrücklich dazu verpflichtet, alle Verbindlichkeiten welche noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt
sind, sowie auch unbekannt bis zum heutigen Tage sind, zu übernehmen.
6. Dass die Liquidation der Gesellschaft vollendet ist und dass die Gesellschaft als endgültig aufgelöst und beendet zu
betrachten ist.
7. Dass die Unterzeichnete den Geschäftsführern Entlastung erteilt.
8. Dass die Geschäftsbücher und Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft für die Dauer von mindestens fünf Jahren an
folgender Adresse, aufbewahrt werden: 45, rue des Scillas L-2529 Howald.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.100,- EUR.
WORÜBER URKUNDE errichtet wurde in Howald, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Daniel FONDU, Danielle KOLBACH.
86272
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 avril 2016. Relation GAC/2016/2700. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016092661/48.
(160061696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Habacker LogPark Site Two S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 135.040.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendsechzehn, den einundreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Danielle KOLBACH, mit dem Amtssitz in Redange/Attert, (Großherzogtum Luxem-
burg) handelnd in Vertretung ihres verhinderten Kollegen Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster,
(Großherzogtum Luxemburg), welch letzt genannter Depositar der Urkunde bleibt.
IST ERSCHIENEN:
HABACKER LogPark HOLDING S. à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in L-1128 Luxemburg, 37, Val Saint André, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 134.784 hier vertreten durch Herrn Daniel
FONDU, Direktor, berufsansässig in Howald, 45, rue des Scillas, aufgrund einer ihm ausgestellten privatschriftlichen
Vollmacht, welche nach „ne varietur“ Signatur, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
Welche Komparentin, durch ihren Bevollmächtigte, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
1. Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Habacker LogPark Site Two S. à r.l", mit Sitz in L-1128 Luxemburg,
37, Val Saint André, eingetragen im Handels - und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
135.040, (hiernach die "Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Martine SCHAEFFER,
damals Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 4. Dezember 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 281 vom 2. Februar 2008.
2. Dass das Gesellschaftskapital zwölf tausend fünf hundert Euros (EUR 12.500.-) beträgt, eingeteilt in fünf hundert
(500) Anteile mit einem Nennwert von fünf und zwanzig Euros (EUR 25.-).
3. Dass die Unterzeichnete Besitzerin sämtlicher Anteile der Gesellschaft, die das Kapital darstellen, ist.
4. Dass die Unterzeichnete, als alleinige Gesellschafterin, beschließt die Gesellschaft, welche ihre Tätigkeit eingestellt
hat, mit sofortiger Wirkung aufzulösen und sie in Liquidation zu setzen.
5. Dass die Unterzeichnete, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft erklärt, dass sie sämtliche Vermögens-
werte übernehmen wird, dass die bekannte Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurde und dass sie sich
ausdrücklich dazu verpflichtet, alle Verbindlichkeiten welche noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt
sind, sowie auch unbekannt bis zum heutigen Tage sind, zu übernehmen.
6. Dass die Liquidation der Gesellschaft vollendet ist und dass die Gesellschaft als endgültig aufgelöst und beendet zu
betrachten ist.
7. Dass die Unterzeichnete den Geschäftsführern Entlastung erteilt.
8. Dass die Geschäftsbücher und Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft für die Dauer von mindestens fünf Jahren an
folgender Adresse, aufbewahrt werden: 45, rue des Scillas L-2529 Howald.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.100,- EUR.
WORÜBER URKUNDE errichtet wurde in Howald, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Daniel FONDU, Danielle KOLBACH.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 avril 2016. Relation GAC/2016/2698. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016092662/48.
(160061695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
86273
L
U X E M B O U R G
Habacker LogPark Site Six S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 135.012.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendsechzehn, den einundreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Danielle KOLBACH, mit dem Amtssitz in Redange/Attert, (Großherzogtum Luxem-
burg) handelnd in Vertretung ihres verhinderten Kollegen Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster,
(Großherzogtum Luxemburg), welch letzt genannter Depositar der Urkunde bleibt.
IST ERSCHIENEN:
HABACKER LogPark HOLDING S. à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in L-1128 Luxemburg, 37, Val Saint André, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 134.784 hier vertreten durch Herrn Daniel
FONDU, Direktor, berufsansässig in Howald, 45, rue des Scillas, aufgrund einer ihm ausgestellten privatschriftlichen
Vollmacht, welche nach „ne varietur“ Signatur, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
Welche Komparentin, durch ihren Bevollmächtigte, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
1. Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Habacker LogPark Site Six S. à r.l", mit Sitz in L-1128 Luxemburg,
37, Val Saint André, eingetragen im Handels - und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
135.012, (hiernach die "Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Martine SCHAEFFER,
damals Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 4. Dezember 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 293 vom 5. Februar 2008.
2. Dass das Gesellschaftskapital zwölf tausend fünf hundert Euros (EUR 12.500.-) beträgt, eingeteilt in fünf hundert
(500) Anteile mit einem Nennwert von fünf und zwanzig Euros (EUR 25.-).
3. Dass die Unterzeichnete Besitzerin sämtlicher Anteile der Gesellschaft, die das Kapital darstellen, ist.
4. Dass die Unterzeichnete, als alleinige Gesellschafterin, beschließt die Gesellschaft, welche ihre Tätigkeit eingestellt
hat, mit sofortiger Wirkung aufzulösen und sie in Liquidation zu setzen.
5. Dass die Unterzeichnete, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft erklärt, dass sie sämtliche Vermögens-
werte übernehmen wird, dass die bekannte Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurde und dass sie sich
ausdrücklich dazu verpflichtet, alle Verbindlichkeiten welche noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt
sind, sowie auch unbekannt bis zum heutigen Tage sind, zu übernehmen.
6. Dass die Liquidation der Gesellschaft vollendet ist und dass die Gesellschaft als endgültig aufgelöst und beendet zu
betrachten ist.
7. Dass die Unterzeichnete den Geschäftsführern Entlastung erteilt.
8. Dass die Geschäftsbücher und Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft für die Dauer von mindestens fünf Jahren an
folgender Adresse, aufbewahrt werden: 45, rue des Scillas L-2529 Howald.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.100,- EUR.
WORÜBER URKUNDE errichtet wurde in Howald, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Daniel FONDU, Danielle KOLBACH.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 avril 2016. Relation GAC/2016/2703. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016092660/48.
(160061699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Harry Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.246,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 203.092.
Par résolutions signées en date du 13 avril 2016, les associés de la Société ont pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de M. Ralf Nocker de son mandat de gérant MIRA avec effet au 11 avril 2016; et
86274
L
U X E M B O U R G
- nomination de M. Jiri Zrust, né le 16 novembre 1974 à Praha (République Tchèque), ayant son adresse professionnelle
au 28, Ropemaker Street, EC2Y 9HD London (Royaume-Uni), en tant que gérant MIRA de la Société avec effet au 11
avril 2016 et pour une durée indéterminée.
Dès lors, le conseil de gérance se compose ainsi:
<i>Gérants AWLi>
M. Thomas FAHL M.
Frédéric MICHELS
<i>Gérants MIRAi>
Mme Rosa VILLALOBOS
M. Jiri ZRUST
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 2016.
Référence de publication: 2016092664/22.
(160061867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 418.984.658,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 149.974.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 2016.
Référence de publication: 2016092665/10.
(160062201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
HICL Infrastructure 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 115.239.
Les statuts coordonnés suivant le répertoire n° 2194 du 30 mars 2016 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Paul MEYERS
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016092669/12.
(160062244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Habacker LogPark Site Nine S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 135.009.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendsechzehn, den einundreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Danielle KOLBACH, mit dem Amtssitz in Redange/Attert, (Großherzogtum Luxem-
burg) handelnd in Vertretung ihres verhinderten Kollegen Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster,
(Großherzogtum Luxemburg), welch letzt genannter Depositar der Urkunde bleibt.
IST ERSCHIENEN:
HABACKER LogPark HOLDING S. à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in L-1128 Luxemburg, 37, Val Saint André, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 134.784 hier vertreten durch Herrn Daniel
FONDU, Direktor, berufsansässig in Howald, 45, rue des Scillas, aufgrund einer ihm ausgestellten privatschriftlichen
Vollmacht, welche nach „ne varietur“ Signatur, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
Welche Komparentin, durch ihren Bevollmächtigte, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
86275
L
U X E M B O U R G
1. Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Habacker LogPark Site Nine S. à r.l", mit Sitz in L-1128 Luxemburg,
37, Val Saint André, eingetragen im Handels - und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
135.009, (hiernach die "Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Martine SCHAEFFER,
damals Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 4. Dezember 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 280 vom 2. Februar 2008.
2. Dass das Gesellschaftskapital zwölf tausend fünf hundert Euros (EUR 12.500.-) beträgt, eingeteilt in fünf hundert
(500) Anteile mit einem Nennwert von fünf und zwanzig Euros (EUR 25.-).
3. Dass die Unterzeichnete Besitzerin sämtlicher Anteile der Gesellschaft, die das Kapital darstellen, ist.
4. Dass die Unterzeichnete, als alleinige Gesellschafterin, beschließt die Gesellschaft, welche ihre Tätigkeit eingestellt
hat, mit sofortiger Wirkung aufzulösen und sie in Liquidation zu setzen.
5. Dass die Unterzeichnete, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft erklärt, dass sie sämtliche Vermögens-
werte übernehmen wird, dass die bekannte Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurde und dass sie sich
ausdrücklich dazu verpflichtet, alle Verbindlichkeiten welche noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt
sind, sowie auch unbekannt bis zum heutigen Tage sind, zu übernehmen.
6. Dass die Liquidation der Gesellschaft vollendet ist und dass die Gesellschaft als endgültig aufgelöst und beendet zu
betrachten ist.
7. Dass die Unterzeichnete den Geschäftsführern Entlastung erteilt.
8. Dass die Geschäftsbücher und Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft für die Dauer von mindestens fünf Jahren an
folgender Adresse, aufbewahrt werden: 45, rue des Scillas L-2529 Howald.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.100,- EUR.
WORÜBER URKUNDE errichtet wurde in Howald, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Daniel FONDU, Danielle KOLBACH.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 avril 2016. Relation GAC/2016/2706. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016092657/48.
(160061702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Highway Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 203.634.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 2016.
Référence de publication: 2016092670/10.
(160061916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
HPS Groupe Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 154.718.
DISSOLUTION
L'an deux mille seize, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange/Attert, Grand-duché de Luxembourg, agissant
en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-duché de
Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.
A comparu:
La société Laurad Groupe Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social 121, avenue de la Faïencerie, L - 1511 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B137024,
86276
L
U X E M B O U R G
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de HPS Groupe
Participations S.à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg
numéro B 154718, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du
30 juin 2010, publié au Mémorial C numéro 1973 du 22 septembre 2010 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement
de Maître Jean Seckler, le 22 avril 2011, publié au Mémorial C numéro 1472 du 05 juillet 2011;
- Le capital social de la Société est fixé à cinquante mille deux cent euros (EUR 50.200,-), représenté par cent mille
quatre cents (100.400) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante cents (EUR 0,50,-) chacune, intégralement libérées
et réparties en trois catégories, respectivement A, B, C.
- La comparante prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.
- La comparante déclare qu'elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la situation
financière de la Société.
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu
de ladite Société a été payé ou provisionné, que la comparante est investie de tout l'actif et qu'elle s'engage expressément
à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce
jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
- La comparante donne décharge pleine et entière au gérant unique pour son mandat jusqu'à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés pendant cinq ans à L-1511 Luxembourg, 121,
avenue de la Faïencerie.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société HPS Groupe Participations S.à r.l..
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s'élève à environ 1.100,- EUR
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Danielle KOLBACH.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 avril 2016. Relation GAC/2016/2647. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016092673/51.
(160061670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
HYNSH Group, Société Anonyme.
Siège social: L-8057 Bertrange, 15, rue du Chemin de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 181.489.
DISSOLUTION
L'an deux mille seize, le trente-et-un mars.
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg),
soussignée;
A COMPARU:
Madame Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange/Attert, agissant en tant que
mandataire de:
1. Madame Hélène SCHWEITZER, née HENDRIX, employée privée, née à Metz (F), le 07 janvier 1987, demeurant à
F-57155 Marly, 32, Rue du Longeau, et
2. Monsieur Yves SCHWEITZER, employé privé, né à Papeete (F), le 05 mai 1987, demeurant à F-57155 Marly, 32,
Rue du Longeau,
en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées; lesquelles procurations, après avoir été signées “ne
varietur” par la mandataire des comparants et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être
enregistrées avec lui.
86277
L
U X E M B O U R G
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent et requièrent le notaire instrumentant d'acter:
1) Que la société anonyme HYNSH Group, ayant son siège social au 15, rue du Chemin de Fer, L-8057 Bertrange, a
été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en date du 31 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 3233 du
19 décembre 2013, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 181.489 (la
«Société»);
2) Que le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,-EUR), représenté par trente-deux mille (32.000)
actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, entièrement libérées;
3) Que les comparants sont les seuls propriétaires de toutes les actions de la Société (les “Actionnaires”);
4) Que les Actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société;
5) Que les Actionnaires prononcent explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet
rétroactif au 31 décembre 2015;
6) Que les Actionnaires se désignent comme liquidateurs de la Société, lesquels auront pleins pouvoirs d'établir, de
signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou
utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;
7) Que les liquidateurs requièrent le notaire d'acter qu'ils déclarent que tout le passif de la Société est réglé ou provisionné
et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre déclarent les liquidateurs que par
rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, les Actionnaires assument l'obligation
irrévocable de payer, chacun d'eux en proportion de sa participation dans la Société, ce passif éventuel et qu'en conséquence
de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé;
8) Que les Actionnaires acceptent expressément le bilan de clôture du 31 décembre 2015;
9) Que les Actionnaires déclarent qu'ils reprennent tout l'actif de la Société et qu'ils s'engageront à régler tout le passif
de la Société indiqué au point 7), proportionnellement à leur participation dans la Société;
10) Que les Actionnaires déclarent formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;
11) Que les Actionnaires déclarent que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société
relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres valeurs seront annulés;
12) Que décharge pleine et entière est donnée aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes
pour l'exécution de leur mandat;
13) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social de la Société.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire des comparants, agissant comme dit ci-avant, agissant comme dit ci-avant,
connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, celle-ci a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: V.PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 4 avril 2016. Relation: DAC/2016/5124. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 14 avril 2016.
Référence de publication: 2016092675/58.
(160061644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Kerta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 169.561.
Les statuts coordonnés au 18 mars 2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016092708/11.
(160061920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
86278
L
U X E M B O U R G
Kinetik S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 191.311.
Les statuts coordonnés suivant le répertoire n° 2237 du 7 avril 2016 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Paul MEYERS
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016092709/12.
(160061589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Kington S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 191.873.
Il convient de noter que l'adresse professionnelle de Monsieur Taavi Davies a été transférée au 24, rue de Bragance,
L-1255 Luxembourg
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Kington S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016092710/14.
(160061870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Habacker LogPark Site Eight S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 135.010.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendsechzehn, den einundreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Danielle KOLBACH, mit dem Amtssitz in Redange/Attert, (Großherzogtum Luxem-
burg) handelnd in Vertretung ihres verhinderten Kollegen Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster,
(Großherzogtum Luxemburg), welch letzt genannter Depositar der Urkunde bleibt.
IST ERSCHIENEN:
HABACKER LogPark HOLDING S. à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in L-1128 Luxemburg, 37, Val Saint André, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 134.784 hier vertreten durch Herrn Daniel
FONDU, Direktor, berufsansässig in Howald, 45, rue des Scillas, aufgrund einer ihm ausgestellten privatschriftlichen
Vollmacht, welche nach „ne varietur“ Signatur, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
Welche Komparentin, durch ihren Bevollmächtigte, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
1. Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Habacker LogPark Site Eight S. à r.l", mit Sitz in L-1128 Luxemburg,
37, Val Saint André, eingetragen im Handels - und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
135.010, (hiernach die "Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Martine SCHAEFFER,
damals Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 4. Dezember 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 284 vom 4. Februar 2008.
2. Dass das Gesellschaftskapital zwölf tausend fünf hundert Euros (EUR 12.500.-) beträgt, eingeteilt in fünf hundert
(500) Anteile mit einem Nennwert von fünf und zwanzig Euros (EUR 25.-).
3. Dass die Unterzeichnete Besitzerin sämtlicher Anteile der Gesellschaft, die das Kapital darstellen, ist.
4. Dass die Unterzeichnete, als alleinige Gesellschafterin, beschließt die Gesellschaft, welche ihre Tätigkeit eingestellt
hat, mit sofortiger Wirkung aufzulösen und sie in Liquidation zu setzen.
5. Dass die Unterzeichnete, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft erklärt, dass sie sämtliche Vermögens-
werte übernehmen wird, dass die bekannte Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurde und dass sie sich
86279
L
U X E M B O U R G
ausdrücklich dazu verpflichtet, alle Verbindlichkeiten welche noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt
sind, sowie auch unbekannt bis zum heutigen Tage sind, zu übernehmen.
6. Dass die Liquidation der Gesellschaft vollendet ist und dass die Gesellschaft als endgültig aufgelöst und beendet zu
betrachten ist.
7. Dass die Unterzeichnete den Geschäftsführern Entlastung erteilt.
8. Dass die Geschäftsbücher und Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft für die Dauer von mindestens fünf Jahren an
folgender Adresse, aufbewahrt werden: 45, rue des Scillas L-2529 Howald.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.100,- EUR.
WORÜBER URKUNDE errichtet wurde in Howald, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Daniel FONDU, Danielle KOLBACH.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 avril 2016. Relation GAC/2016/2705. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016092654/48.
(160061701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Habacker LogPark Site Five S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 135.029.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendsechzehn, den einundreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Danielle KOLBACH, mit dem Amtssitz in Redange/Attert, (Großherzogtum Luxem-
burg) handelnd in Vertretung ihres verhinderten Kollegen Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster,
(Großherzogtum Luxemburg), welch letzt genannter Depositar der Urkunde bleibt.
IST ERSCHIENEN:
HABACKER LogPark HOLDING S. à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in L-1128 Luxemburg, 37, Val Saint André, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 134.784 hier vertreten durch Herrn Daniel
FONDU, Direktor, berufsansässig in Howald, 45, rue des Scillas, aufgrund einer ihm ausgestellten privatschriftlichen
Vollmacht, welche nach „ne varietur“ Signatur, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
Welche Komparentin, durch ihren Bevollmächtigte, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
1. Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Habacker LogPark Site Five S. à r.l", mit Sitz in L-1128 Luxemburg,
37, Val Saint André, eingetragen im Handels - und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
135.029, (hiernach die "Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Martine SCHAEFFER,
damals Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 4. Dezember 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 284 vom 4. Februar 2008.
2. Dass das Gesellschaftskapital zwölf tausend fünf hundert Euros (EUR 12.500.-) beträgt, eingeteilt in fünf hundert
(500) Anteile mit einem Nennwert von fünf und zwanzig Euros (EUR 25.-).
3. Dass die Unterzeichnete Besitzerin sämtlicher Anteile der Gesellschaft, die das Kapital darstellen, ist.
4. Dass die Unterzeichnete, als alleinige Gesellschafterin, beschließt die Gesellschaft, welche ihre Tätigkeit eingestellt
hat, mit sofortiger Wirkung aufzulösen und sie in Liquidation zu setzen.
5. Dass die Unterzeichnete, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft erklärt, dass sie sämtliche Vermögens-
werte übernehmen wird, dass die bekannte Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurde und dass sie sich
ausdrücklich dazu verpflichtet, alle Verbindlichkeiten welche noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt
sind, sowie auch unbekannt bis zum heutigen Tage sind, zu übernehmen.
6. Dass die Liquidation der Gesellschaft vollendet ist und dass die Gesellschaft als endgültig aufgelöst und beendet zu
betrachten ist.
7. Dass die Unterzeichnete den Geschäftsführern Entlastung erteilt.
8. Dass die Geschäftsbücher und Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft für die Dauer von mindestens fünf Jahren an
folgender Adresse, aufbewahrt werden: 45, rue des Scillas L-2529 Howald.
86280
L
U X E M B O U R G
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.100,- EUR.
WORÜBER URKUNDE errichtet wurde in Howald, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Daniel FONDU, Danielle KOLBACH.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 avril 2016. Relation GAC/2016/2702. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016092655/48.
(160061698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.
Private Placement Opportunities SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.
R.C.S. Luxembourg B 195.919.
In the year two thousand sixteen, on the fourteenth day of March,
Before Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg),
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Shareholders”) of Private Placement Opportunities SICAV-
SIF, a société d’investissement à capital variable, governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 2, rue
d'Alsace, L-1122 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated by a notarial deed of Maître
Jean-Paul MEYERS, then notary residing in Rambrouch, on March 12, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N°956 on April 10, 2015.
The extraordinary general meeting is declared open at 2.15 p.m. and was presided by Tom DECLOEDT, residing
professionally in Roeselare, appointed as chairman (the “Chairman”), who appointed as secretary, Virginie MASSON,
residing professionally in Luxembourg (the “Secretary”) and elected as scrutineer, Richard MAISSE, residing professio-
nally in Luxembourg (the “Scrutineer”).
The board of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the
notary to state that:
(i) The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of the articles 1 and 3 of the articles of association of the Company (the “Articles”) in order to replace
the mention of “private placement memorandum” by “offering memorandum” and to add references to the AIFM Law, as
follows:
Art. 1. Form. There is hereby formed among the subscriber(s) and all persons who may become holder of shares hereafter
issued, a company (the “Company”) in the form of a public limited company (“société anonyme”), formed as an investment
company with variable capital (“SICAV”) and specialized investment fund (“Specialized Investment Fund”), governed by
these Articles of Association and by the current Luxembourg laws and regulations, notably by the law on commercial
companies of 10 August 1915, as amended (the “1915 Law”) and the law of 13 February 2007 on Specialized Investment
Funds, as amended (the “2007 Law”). The Company qualifies as alternative investment fund under the law of 12 July 2013
on alternative investment fund managers (the “AIFM Law”) and is registered as alternative investment fund manager
(“AIFM”) in compliance with Article 3(3) of the AIFM Law.”
“ Art. 3. Purpose. The Company’s exclusive object is the collective investment of its funds in assets in order to spread
the investment risks and to ensure for the investors the benefit of the results of the management of these assets according
to its investment objectives and policies in accordance with the provisions of the 2007 Law, the AIFM Law and the
applicable Luxembourg Financial Supervisory Authority’s (the “CSSF”) circulars.
The investment objectives and strategy of the Company are more fully described in the Company’s offering memoran-
dum (the “Offering Memorandum”).
The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and in
particular, without limitation, grant any assistance, loan, advance or guarantee and raise money in any manner and secure
the repayment of any money borrowed from third parties or from its shareholders (the “Shareholders”).
In addition, the Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly
to all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the
2007 Law and the AIFM Law.”
2. Amendment of the articles 8 and 10 of the Articles in order to add more flexibility for the Company.
86281
L
U X E M B O U R G
3. Amendment of the articles 12, 19, 26, 28 and 32 of the Articles in order to add references to the AIFM Law.
4. Amendment of the articles 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22 and 27 of the Articles in order to replace the mention of
“private placement memorandum” by “offering memorandum”.
5. Authorization and approval of the restatement of the Company's Articles to reflect the previous amendments of some
articles.
(ii) The proxies of the Shareholders represented and the number of their shares are shown on an attendance list which
is signed by the Shareholders present, the proxies of the Shareholders represented and the members of the bureau of the
meeting, and which will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented Shareholders, initialised “ne varietur” by the appearing parties, will also remain attached to
the present deed.
(iii) This meeting has been convened by notices containing the agenda, sent to each registered Shareholder by registered
mail on 16 February 2016.
(iv) The attendance list of the meeting shows that out of 31,346 shares representing the entire corporate capital of the
Company, 16,646 shares are represented at the present extraordinary general meeting of Shareholders.
(v) In consideration of the agenda and of the provisions of Article 67 and 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended from time to time, the minimum quorum of fifty percent of the shares issued or in circulation being
reached, the present Meeting is validly constituted and is accordingly authorised to deliberate on the items of the agenda.
After this has been set forth by the Chairman and acknowledged by the persons attending the meeting, the meeting
proceeded to the Agenda.
The meeting having considered the Agenda, the following resolutions have been adopted unanimously by the share-
holders present or represented at this extraordinary general meeting:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting RESOLVES TO amend articles 1 and 3 of the Articles in order to replace the mention
of “private placement memorandum” by “offering memorandum” and to add references to the AIFM Law, as follows:
Art. 1. Form. There is hereby formed among the subscriber(s) and all persons who may become holder of shares hereafter
issued, a company (the “Company”) in the form of a public limited company (“société anonyme”), formed as an investment
company with variable capital (“SICAV”) and specialized investment fund (“Specialized Investment Fund”), governed by
these Articles of Association and by the current Luxembourg laws and regulations, notably by the law on commercial
companies of 10 August 1915, as amended (the “1915 Law”) and the law of 13 February 2007 on Specialized Investment
Funds, as amended (the “2007 Law”). The Company qualifies as alternative investment fund under the law of 12 July 2013
on alternative investment fund managers (the “AIFM Law”) and is registered as alternative investment fund manager
(“AIFM”) in compliance with Article 3(3) of the AIFM Law.”
Art. 3. Purpose. The Company’s exclusive object is the collective investment of its funds in assets in order to spread the
investment risks and to ensure for the investors the benefit of the results of the management of these assets according to
its investment objectives and policies in accordance with the provisions of the 2007 Law, the AIFM Law and the applicable
Luxembourg Financial Supervisory Authority’s (the “CSSF”) circulars.
The investment objectives and strategy of the Company are more fully described in the Company’s offering memoran-
dum (the “Offering Memorandum”).
The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and in
particular, without limitation, grant any assistance, loan, advance or guarantee and raise money in any manner and secure
the repayment of any money borrowed from third parties or from its shareholders (the “Shareholders”).
In addition, the Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly
to all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the
2007 Law and the AIFM Law.”
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting RESOLVES TO amend the articles 8 and 10 of the Articles in order to add more
flexibility for the Company, as shown in the attached updated version of the Articles.
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting RESOLVES TO amend the articles 12, 19, 26, 28 and 32 of the Articles in order to
add references to the AIFM Law, as shown in the attached updated version of the Articles.
<i>Fourth resolutioni>
The extraordinary general meeting RESOLVES TO amend the articles 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22 and 27 of the
Articles in order to replace the mention of “private placement memorandum” by “offering memorandum”, as shown in the
attached updated version of the Articles.
86282
L
U X E M B O U R G
<i>Fifth resolutioni>
The extraordinary general meeting RESOLVES to restate the Articles in their entirety in order to reflect the previous
amendments of some articles and which shall read henceforth as follows:
“ Art. 1. Form. There is hereby formed among the subscriber(s) and all persons who may become holder of shares
hereafter issued, a company (the “Company”) in the form of a public limited company (“société anonyme”), formed as an
investment company with variable capital (“SICAV”) and specialized investment fund (“Specialized Investment Fund”),
governed by these Articles of Association and by the current Luxembourg laws and regulations, notably by the law on
commercial companies of 10 August 1915, as amended (the “1915 Law”) and the law of 13 February 2007 on Specialized
Investment Funds, as amended (the “2007 Law”). The Company qualifies as alternative investment fund under the law of
12 July 2013 on alternative investment fund managers (the “AIFM Law”) and is registered as alternative investment fund
manager (“AIFM”) in compliance with Article 3(3) of the AIFM Law.
Art. 2. Name. The Company’s name is Private Placement Opportunities SICAV-SIF.
Art. 3. Purpose. The Company’s exclusive object is the collective investment of its funds in assets in order to spread the
investment risks and to ensure for the investors the benefit of the results of the management of these assets according to
its investment objectives and policies in accordance with the provisions of the 2007 Law, the AIFM Law and the applicable
Luxembourg Financial Supervisory Authority’s (the “CSSF”) circulars.
The investment objectives and strategy of the Company are more fully described in the Company’s offering memoran-
dum (the “Offering Memorandum”).
The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and in
particular, without limitation, grant any assistance, loan, advance or guarantee and raise money in any manner and secure
the repayment of any money borrowed from third parties or from its shareholders (the “Shareholders”).
In addition, the Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly
to all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the
2007 Law and the AIFM Law.
Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company (the “Registered Office”) is established in the city of
Luxembourg, in the Grand Duchy of Luxembourg. If and to the extent permitted by law, the board of directors of the
Company (the “Board of Directors”) may decide to transfer the Registered Office within the municipality by a resolution
of the Board of Directors. The Board of Directors shall further have the right to set up branches, offices, administrative
centers and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.
Where the Board of Directors determines that extraordinary political, economical or social developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company
at the Registered Office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the Registered Office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
Registered Office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 5. Duration. The Company is constituted for an unlimited duration.
The Company may be terminated at any time by a decision of the general meeting of Shareholders in the manner required
for the amendment of these Articles of Association.
The life of the Company does not come to an end upon the death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any Shareholder or member of the Board of Directors (each a “Director”).
Art. 6. Share Capital. The initial share capital of the Company is set at thirty one thousand Euros (EUR 31,000) divided
into thirty-one (31) fully paid-up Company shares (the “Shares”), with no par value.
The minimum subscribed capital of the Company, which must be achieved within twelve (12) months as from the date
on which the Company has been authorized as a Specialized Investment Fund by the CSSF, shall be one million two hundred
fifty thousand Euros (EUR 1,250,000.-) as required by the 2007 Law (the “Minimum Capital”).
The capital of the Company shall at any time be equal to the total net assets of the Company as determined in accordance
with article twelve (12) hereafter.
Art. 7. The sub-funds and classes of Shares. The Company is a multi-compartment structure consisting of one or several
sub-funds, each one representing a specific portfolio of assets and liabilities. There is no cross liability between sub-funds.
Each sub-fund is invested in accordance with the investment objective and policy applicable to it. The investment objective
and policy as well as other specific features of each sub-fund will be set forth in the Offering Memorandum. The Board of
Directors may decide to create at any time additional sub-funds or to close an existing sub-fund.
The Board of Directors may decide to issue, within each sub-fund, separate classes of Shares, which may carry different
rights and obligations, inter alia with regard to their distribution policy and right to revenues, their fee structure, their
minimum initial subscription and holding amounts or their target investors. The specific features of the classes within each
86283
L
U X E M B O U R G
sub-fund will be set forth in the Offering Memorandum. The Board of Directors may create at any time additional classes
or close an existing class. Series of class may be issued as further specified in the Offering Memorandum.
Art. 8. Shares’ form / Shareholder register. The Board of Directors of the Company shall determine whether the Company
shall issue Shares in bearer and/or in registered form and/or in dematerialized form.
Shares issued in bearer form may, at the Board of Director's entire discretion, be issued without certificates (book entry
bearer form) or with certificates. Shareholders may in principle apply for bearer Share certificates, unless otherwise sti-
pulated by the Board of Directors in the sales documents of the Shares of the Company. In the event of application for
certificates, the Shareholder may be charged with the related costs and a fee for delivery of these physical Share certificates
may be levied.
If bearer Share certificates are to be issued, they will be issued in such denominations as the Board of Directors shall
prescribe.
All issued registered Shares of the Company shall be registered in the register of Shareholders which shall be kept by
the Company or by its agent, and such register shall contain the name of each owner of registered Shares, his residence as
indicated to the Company, the number of registered Shares held by him and the amounts paid.
The inscription of the Shareholder's name in the register of Shareholders evidences his right of ownership on such
registered Shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the Shareholder
or whether the Shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.
The Share certificates shall be signed by two Directors of the Company. Such signatures shall be either manual, or
printed, or in facsimile. However, one of such signatures may be made by a person duly authorised thereto by the Board
of Directors; in the latter case, it shall be manual. The Company may issue temporary Share certificates in such form as
the Board of Directors may determine.
Shareholders entitled to receive registered Shares shall provide the Company with their residence address to which all
notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of Shareholders.
In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered
into the register of Shareholders and the Shareholder's address will be deemed to be at the Registered Office, or at such
other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another address shall be provided to the
Company by such Shareholder. A Shareholder may, at any time, change his address as entered into the register of Share-
holders by means of a written notification to the Company at its Registered Office, or at such other address as may be set
by the Company from time to time.
If any Shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his Share certificate has been mislaid, mutilated
or destroyed, then, at his request, a duplicate Share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including
but not restricted to a bond issued by an insurance company, as the Company may determine. At the issuance of the new
Share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original Share certificate in replacement of which
the new one has been issued shall become void.
Mutilated Share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.
The Company may, at its election, charge to the Shareholder the costs of a duplicate or of a new Share certificate and
all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection
with the annulment of the original Share certificate.
Dematerialized Shares may be held through collective depositories. In such cases, Shareholders shall receive a confir-
mation in relation to their shares from the depository of their choice (for example, their bank or broker), or Shares may be
held by Shareholders directly in a registered account kept for the Company and its Shareholders by the Company’s central
administration. These Shareholders will be registered by the central administration. Shares held by a depository may be
transferred to an account of the Shareholder with the central administration or to an account with other depositories approved
by the Company or with an institution participating in the securities and fund clearing systems. Conversely, Shares held in
a Shareholder’s account kept by the central administration may at any time be transferred to an account with a depository.
The Company recognises only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the ownership
of Shares is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint one single attorney to represent such
Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise of all rights attached
to such Shares.
The Company may decide to issue fractional Shares. Such fractional Shares shall not be entitled to vote but shall be
entitled to participate in the net assets attributable to the relevant class of Shares on a pro rata basis. In the case of bearer
Shares, only certificates evidencing full Shares will be issued.
Fractions of Shares may be issued, up to three (3) decimal places.
Art. 9. Shareholders. The holding of Shares is exclusively restricted to well-informed investors as defined in the 2007
Law (the “Well-Informed Investors”).
The Board of Directors shall have the power to impose such restrictions as it may think necessary for the purpose notably
of ensuring that no Shares are acquired or held by:
86284
L
U X E M B O U R G
(a) any person in breach of these Articles of Association, the Offering Memorandum, the law or requirement of any
country or governmental authority, or
(b) any person in circumstances which in the opinion of the Board of Directors might result in the Company incurring
any liability to taxation or suffering any other pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have
incurred or suffered.
For such purposes the Board of Directors may at its discretion and without liability:
a) decline to issue any Share and decline to register any transfer of a Share where it appears to it that such registration
or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such Share being held by a person who is precluded
from holding Shares;
b) at any time require any person whose name is entered in the Shareholder register to furnish it with any information,
supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not legal or beneficial
ownership of such Shares rests or will rest in a person who is precluded from holding Shares; and
c) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding Shares, is a legal or beneficial owner
of Shares or holds Shares, resolve that the Company compulsorily repurchase from any such Shareholder all Shares held
by such Shareholder.
The Company may also, at its discretion and without liability, decline to accept the vote of any person who is precluded
from holding Shares at any meeting of Shareholders.
Specifically, the Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership of Shares by any “US person” or any
other restricted person as defined in the Offering Memorandum or compulsorily redeem Shares directly or indirectly held
by them.
Art. 10. Issue of Shares. Whenever Shares of the Company shall be offered by the Company for subscription, potentially
through a commitment process, the price per Share at which such Shares shall be issued shall be the net asset value thereof
as determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof. The Board of Directors may also decide that an issue
commission has to be paid as more described in the Offering Document. The allotment of Shares is conditional upon
payment and if timely payment has not been received within the settlement period, the subscription may lapse and be
cancelled at the cost of the investor or the investor’s financial intermediary. If payment is not received in full, the relevant
allotment of Shares may be reduced accordingly. The Board of Directors may in its discretion determine the minimum
amount of any subscription in any class of Share of any sub-fund.
Subscriptions received before a certain hour (“cut-off time”) on a specific date (which does not need to be the valuation
date) as determined by the Board of Directors from time to time shall be processed at the net asset value determined for
the applicable valuation date. If subscriptions are received after that cut-off time as determined by the Board of Directors
from time to time, they shall be processed at the net asset value determined for the following valuation date. The investor
will bear any taxes or other expenses attaching to the application.
The Board of Directors may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities by any
Shareholder who agrees to comply with any conditions set forth by the Board of Directors from time to time including, but
not limited to, the obligation to deliver a valuation report from the auditor of the Company which shall be available for
inspection, and provided that such securities comply with the investment restrictions and policies of the relevant sub-fund,
as set forth in the Company’s Offering Document. Any costs incurred in connection with a contribution in kind of assets,
including the auditor’s costs for preparing any valuation report required, shall be borne by the Shareholder making such
contribution.
The Board of Directors reserves the right to accept or refuse any application of subscription for Shares in whole or in
part.
Art. 11. Transfer and conversion of Shares. A Shareholder may transfer Shares to the existing Shareholders or to any
third party solely with the prior written approval of the Board of Directors, and the Board of Directors may in its discretion
and without indicating any reason decline to approve or register such transfer.
No transfer of all or any part of any Shares, whether direct or indirect, voluntary or involuntary (including, without
limitation, to an affiliate or by operation of law), shall be valid or effective if:
a) the Transfer of Shares would result in a violation of any law or regulation of Luxembourg or any other jurisdiction
or effect the Fund or any Sub-Fund to any other adverse tax, legal or regulatory consequences as determined by the Fund
or result in a violation of any term or condition of the Articles of Association of the Fund or of this Offering Memorandum;
and/or
b) the transfer would result in a violation of any term or condition of the Articles of Association or Offering Memoran-
dum;
c) the transfer would result in the Company being required to register as a restricted person as defined in the Offering
Memorandum; and;
It shall be a condition of any transfers that:
86285
L
U X E M B O U R G
a) the transferee represents in a form acceptable to the Company that such transferee is a Well-Informed Investor, and
that the proposed transfer itself does not violate any laws or regulations (including, without limitation, any securities laws)
applicable to it;
b) the transferee undertakes to fully and completely assume all outstanding obligations of the transferor towards the
Company under the transferor's subscription agreement setting out the terms of the participation of the transferor in the
Company.
The Shareholder wishing to transfer its Shares will be responsible for all costs associated with any attempted or realized
transfer.
Unless otherwise provided for within the Offering Memorandum, Shares of a sub-fund may not be converted for Shares
in another sub-fund at the request of the Shareholders.
Art. 12. Net asset value. The net asset value of the Company shall be determined as often as the Board of Directors may
think useful, but in no event less than once a year. The frequency and way of calculation of the net asset value calculation
are further described in the Offering Memorandum.
The net asset value will be expressed in Euro and shall be determined by the administrative agent of the Company, under
the responsibility of the alternative investment fund manager (the “AIFM”) under the ultimate control of the Board of
Directors, acting in its own name and on behalf of the Company, as more described in the Offering Document of the
Company. The Valuation principles used for this purpose will be described in the Offering Memorandum and may differ
from one sub-fund to another one depending on the type of invested assets.
Art. 13. Suspension. The Board of Directors may temporarily suspend the calculation of the net asset value during:
a) any period when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstance outside the
control, responsibility and power of the Board of Directors, or the existence of any state of affairs in the market, disposal
of the assets owned by the Fund on account of each Sub-Fund is not reasonably practicable without this being seriously
detrimental to the interests of the Shareholder or if in the opinion of the Board of Directors issue, sale and/or redemption
prices cannot fairly be calculated; or
b) any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the Fund’s or
on the accounts of such Sub-Fund assets or if for any reason the value of any asset of the Fund on account of each Sub-
Fund which is material in relation to the determination of the Net Asset Value (as to which materiality the Board of Directors
shall have sole discretion) may not be determined as rapidly and accurately as required; or
c) any period when the value of any fully-owned (direct or indirect) subsidiary of the Fund or on the account of such
Sub-Fund may not be determined accurately; or
d) any period when the Fund is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of the
Shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or payments due on
redemption of Shares cannot in the opinion of the Board of Directors be effected at normal rates of exchange; or
e) any period when any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments cannot in the opinion
of the Board of Directors be effected at normal rates of exchange; or
f) upon the decision to wind up the Fund or on the account of such Sub-Fund; or
g) when for any other reason, the prices of any investment cannot be promptly or accurately ascertained.
The suspension of the calculation of the net asset value of any particular sub-fund and/or class shall have no effect on
the determination of the net asset value per Share of the relevant class or on the issue, redemption and conversion of Shares
of any class and/or sub-fund that is not suspended.
The suspension of the calculation of the net asset value and/or, where applicable, of the subscription, redemption and/
or conversion of Shares, shall be notified to the relevant persons through all means reasonably available to the Company,
unless the Board of Directors is of the opinion that a publication is not necessary considering the short period of the
suspension.
Such a suspension decision shall be notified to any Shareholder requesting redemption or conversion of their Shares.
The suspension period should in principle not exceed three (3) months otherwise the Board of Directors may decide
either to redeem Shares or to liquidate the Company at the best interests of the Shareholders.
Art. 14. Shares’ redemption. The Company is an open-ended Specialized Investment Fund. However, the Board of
Directors may decide, depending on the investment strategy and objectives of each sub-fund to launch closed-ended sub-
funds.
Redemptions will be made in accordance with the principles set forth in the Offering Memorandum for each sub-fund.
Shareholders wishing to have all or any of their Shares redeemed (where possible) at the redemption price on a valuation
date, should deliver to the Registered Office or the office of the central administration and paying agent before the relevant
cut-off time indicated in the Offering Memorandum, the written request for redemption in the prescribed form duly signed.
Redemptions received before that cut-off time will be dealt with on the basis of the relevant net asset value established on
the relevant valuation date. Redemption requests received after that cut-off time will be dealt with on the basis of the net
86286
L
U X E M B O U R G
asset value of the next valuation date. In all cases, the decision to redeem Shares shall be irrevocable, except under excep-
tional circumstances and subject to the prior approval of the Board of Directors and of the concerned Shareholder.
The payment of the redemption price may be made in cash or consideration in kind at the Board of Directors’ request,
subject however to the prior approval of the concerned Shareholders. The allotment of Company’s assets in respect of
redemption for consideration in kind shall be fair and not detrimental to the interests of the other Shareholders of the
Company. Any redemption for consideration in kind shall be subject, if necessary, to the confirmation by an auditor’s
special report of the valuation of the Company and of the Company’s assets to be allocated, the costs of which shall be
borne by the Company.
Any redemption request which would reduce the value of a Shareholder's holding below the minimum holding amount
as stipulated in the Offering Memorandum may be treated, at the discretion of the Board of Directors, as a request for the
redemption of the Shareholder's entire holding. However, Shareholders will not be required to redeem their entire holding
if the value of that holding has declined to less than the minimum holding amount as a result of a decline in the net asset
value per Share of the relevant class and series.
All redeemed Shares or fractions thereof shall be automatically cancelled.
If, following redemption requests, it is necessary on a given valuation date to redeem more than the percentage indicated
in the Offering Memorandum of the Shares of any given sub-fund, the Board of Directors may decide that part or all of
redemptions within that sub-fund be deferred until the next valuation date. When the net asset value is next calculated,
redemption applications that have been deferred will have priority over redemption applications received for that particular
valuation date.
The Board of Directors may decide to compulsorily redeem Shares wholly or in part in the following circumstances:
a) The Shares are held by Shareholders not authorized to buy or own Shares in the Company, e.g. a Shareholder that no
longer qualifies as Well-Informed Investors or such Shareholder (or an affiliate of the same) that becomes a US person as
referred to in the Offering Memorandum;
b) In the event that a Shareholder is declared bankrupt, enters into an arrangement for the benefit of its creditors or goes
into liquidation;
c) In case of liquidation or merger of sub-funds or classes of Shares;
d) If Shareholders transfer Shares to other entities without the Board of Directors’ knowledge, e.g. heritage, pledge;
e) In all other circumstances as the Board of Directors may deem appropriate if in the interest of the Company.
Redemption prices shall be calculated according to the principles laid down in the Offering Memorandum. Except in
the case c) above, the Board of Directors may impose such penalty as it deems fair and appropriate.
All redeemed Shares or fractions thereof shall be automatically cancelled.
Art. 15. Board of Directors. The Company will be managed by the Board of Directors, composed of not less than three
(3) Directors. At least 50% of the Board of Directors should be representatives of Quaestor Vermogensbeheer NV or its
group. The Directors need not be Shareholders.
The Directors shall be elected by the Shareholders at their annual general meeting for a period not exceeding six (6)
years and shall hold office until their successor are elected. A Director may be removed with or without cause and replaced
at any time by resolution adopted by the Shareholders.
In the event of vacancy in the office of Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors may
meet and elect, by majority of vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of the Shareholders.
Art. 16. Chairman. The Board of Directors shall elect from among its members a chairman (the “Chairman”) who should
be a representative of Quaestor Vermogensbeheer NV or its group and may choose from among its members one or more
vice-chairmen (each a “Vice-Chairman”). It may also choose a secretary, who needs not to be a Director, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the Shareholders. The Board of
Directors shall meet upon call by the Chairman, or two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The Chairman shall preside at all meetings of Shareholders or in his absence or inability to act, the Vice-Chairman or
another Director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore, or in their absence or inability
to act, the Shareholders may appoint another Director or an officer of the Company as chairman pro tempore by vote of
the majority of Shares present or represented at any such meeting.
The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors, or in his absence or inability to act, the Vice-
Chairman or another Director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore.
The Board of Directors shall from time to time appoint any officer or agent of the Company considered necessary for
the operation and management of the Company, who need not be Directors or Shareholders. Any such appointment may
be revoked at any time by the Board of Directors. The officers appointed unless otherwise stipulated in these Articles of
Association, shall have the power and duties granted to them by the Board of Directors.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four (24) hours
in advance of the hour set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by e-mail, telefax or any
86287
L
U X E M B O U R G
other similar or electronic communication means from each Director. Separate notice shall not be required for meetings
held at times and places set out in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy, which
appointment shall be in writing or by e-mail, telefax or any other similar or electronic communication means.
Directors may also assist at board meetings and board meetings may be held by telephone link or telephone conference,
provided that the vote is confirmed in writing or by e-mail, telefax or any other similar or electronic communication means.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Company by
their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.
The Board of Directors can deliberate or act with due authority if at least a majority of the Directors is present or
represented at such meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at
such meeting, the Chairman having a casting vote.
Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may
be evidenced by facsimile or any other similar or electronic communication means. The date of such a resolution shall be
the date of the last signature.
Art. 17. Minutes. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman or, in his
absence, by the chairman protempore who presided at such meeting or by two (2) Directors.
Copies or extracts of such minutes which are to be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the
Chairman or by the chairman pro-tempore of that meeting, or by two (2) Directors or the secretary.
Art. 18. Power. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration, dispo-
sition and execution in the Company’s interest. All powers not expressly restricted by law or by the Articles of Association
to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, in case of
liquidation, the Board of Directors is empowered to appoint the liquidators of the Fund.
Art. 19. Delegation of Power. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and
affairs of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers to carry out acts
in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need not
be Directors, who shall have the powers determined by the Board of Directors and who may, if the Board of Directors so
authorizes, sub-delegate their powers.
The Board of Directors may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
The Board of Directors may further decide to create either at the level of the Company or for a specific sub-fund any
committee the members of which need not be Directors. The Board of Directors shall organize such committee functioning
and determine the powers of their members as further described in the Offering Memorandum.
The Company may also designate an AIFM in compliance with the provisions of the AIFM Law.
The AIFM shall be responsible for the asset management, the risk management, the administration and marketing of
the Company and / or of its sub-funds for the account and in the exclusive interest of the Shareholders of the Company in
accordance with the provisions of the AIFM Law. The AIFM is also responsible for ensuring the compliance with the
AIFM Law.
Art. 20. Conflicts of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers or agent or daily manager or
employee of the Company is interested in, or is a director, associate, officer, agent, daily manager or employee of such
other company or firm. Any Director, officer, agent, daily manager or employee of the Company who serves as a director,
officer, agent, daily manager or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matter with respect to such contract or other business.
In the event that any Director, officer, agent, daily manager or employee of the Company may have, in any transaction
of the Company, an interest opposite to the interests of the Company, such Director, officer, agent, daily manager or
employee shall make known to the Board of Directors such opposite interest and shall not consider or vote on any such
transaction, and such transaction and such Director's, officer’s, agent’s, daily manager’s or employee’s interest therein shall
be reported to the next succeeding general meeting of Shareholders.
The term “opposite interest”, as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any
matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be determined by the
Board of Directors in its discretion.
Art. 21. Signature. The Company shall be bound by the joint signature of any two (2) Directors or by the individual
signature(s) of any duly authorized Director or officer, or agent or daily manager of the Company or by the individual
signature of the Chairman or any other person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors.
Art. 22. Indemnification. The Company will indemnify, out of its assets only, the managers, officers, employees and
agents of the Company, the Board of Directors and any appointed investment manager (the “Investment Manager”) for any
86288
L
U X E M B O U R G
claim, damage and liability to which they may become subject because of their status as managers, officers, employees or
agents of the Company, the Board of Directors, or the Investment Manager, or by reason of any action taken or omitted to
be taken by them in connection with the Company. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which they may be entitled.
No indemnity shall be provided to the managers, officers, employees and agents of the Company, the Board of Directors
and the Investment Manager for losses sustained (a) by reason of willful misfeasance, bad faith, negligence or reckless
disregard of the duties involved in the conduct of their office; (b) where they shall have been finally adjudicated not to
have acted in good faith and in the reasonable belief that their action was in the best interests of the Company; and/or (c)
in the event of a settlement, unless there has been a suitable determination that such manager, officer, employee, agent of
the Company, the Board of Directors or the Investment Manager did not engage in willful misfeasance, bad faith, negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office.
Art. 23. General meetings of Shareholders. The general meeting of Shareholders shall represent the entire body of
Shareholders. Its resolutions shall be binding upon all Shareholders. It shall have the broadest powers to order, carry out
or ratify acts relating to the operations of the Company.
If all Shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of the
agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
The annual general meeting of Shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law at the Registered Office
or elsewhere as may be specified in the notice of meeting at 2 p.m. (Luxembourg time) on the thirty-first of May each year.
The first annual general meeting of Shareholders shall be held on the thirty-first of May 2016.
If such day is a legal or bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting of Shareholders shall be held on the
next banking day.
Other meetings of Shareholders, including meetings of Shareholders of one specific sub-fund or class of shares, may
be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.
The quorum and time-limits provided by law shall govern the convening notices and the conduct of the general meetings
of Shareholders unless otherwise provided herein.
Any Shareholder may participate in a general meeting of Shareholders by video conference, or by conference call or
similar means of communication equipment which enables his/her identification and participating in a meeting by such
means shall constitute presence in person at such meeting. The means of communication used must allow all the persons
taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an effective participation of all such
persons in the meeting. The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders
in order to attend any general meeting of Shareholders.
The business transacted at any meeting of the Shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which
shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
Each whole Share is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles of Association. A
Shareholder may act at any meeting of Shareholders by giving a proxy to another person in writing or by facsimile trans-
mission or any other similar or electronic communication means, who need not be a Shareholder and who may be a Director.
Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the
votes validly cast, unless the item to be resolved upon relates to an amendment of the Articles of Association, in which
case the resolution will be passed with a majority of the two thirds (2/3) of the votes validly cast.
Art. 24. Financial Year. The Company’s financial year begins on 1
st
January and closes on 31
st
December of the same
year. The first financial year of the Company shall begin on the date of its incorporation and end on 31 December 2015.
Art. 25. Accounts. Each year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the Company. The annual
accounts shall be approved by the annual general meeting of Shareholders upon proposal of the Board of Directors. The
accounts shall be expressed in Euro.
Art. 26. Supervision. The operations of the Company and its financial situation shall be supervised by one independent
auditor qualifying as a “réviseur d’entreprises agree” who shall be appointed by the Shareholders. The independent auditor
shall be remunerated by the Company and shall remain in office until its successor is appointed. The independent auditor
shall fulfill all duties prescribed by the 2007 Law and the AIFM Law.
Art. 27. Distribution. Subject to permitted reinvestments, and the requirements of Luxembourg law, distributions shall
be payable by the Company on its Shares upon decision by the Board of Directors in accordance with the Offering Me-
morandum.
No distribution may be made if after the declaration of such distribution the net asset value of the Company would fall
below the Minimum Capital.
Dividends not claimed within six (6) years of their due date will lapse and revert to Company.
Art. 28. Depositary. The Company shall enter into a depositary agreement with a financial institution, which shall satisfy
the requirements of the 2007 Law. The depositary shall assume towards the Company and the Shareholders the responsi-
bilities set out in the depositary agreement, the 2007 Law, the AIFM Law and any other applicable law.
86289
L
U X E M B O U R G
In the event of termination of the depositary agreement or the resignation of the depositary, the Board of Directors shall
use its best endeavors to find a financial institution to act as depositary and upon doing so the Board of Directors shall
appoint such financial institution to be depositary in place of the former depositary.
Art. 29. Other contractual parties. The Company may enter into an investment advisory agreement in order to be advised
and assisted while managing its portfolio, as well as enter into investment management agreements with one or more fund
managers. In addition the Company may enter into any service agreement with other contractual parties, for example with
regards to an administrative, registrar and transfer agent function.
Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several
liquidators (whether natural persons or legal entities) named pursuant to a general meeting of Shareholders effecting such
dissolution, in accordance with and subject to the provisions of the 1915 Law, and at which meeting the liquidators’ powers
and compensation shall be determined. The operations of liquidation will be carried out pursuant to Luxembourg law.
The net proceeds of liquidation in respect of each sub-fund or, as the case may be, of each class within each sub-fund,
shall be distributed by the liquidators to the Shareholders of the relevant class in proportion to their holding of such Shares
in such sub-fund or class, and whether such proceeds shall be distributed in cash or kind.
If the Company’s Share capital (i.e. the aggregate of all sub-funds) falls below two-thirds (2/3) of the Minimum Capital,
the Board of Directors must submit a proposal for the Company’s termination to a general meeting of Shareholders for
deliberation. No quorum requirements will be applied; winding-up may be pronounced by a simple majority of the validly
cast votes.
If the Company’s Share capital falls below one quarter (1/4) of the Minimum Capital, the Board of Directors must submit
a proposal for the Company’s termination to the general meeting of Shareholders for deliberation. No quorum requirements
will be applied; winding-up may be pronounced by the Shareholders owning one quarter (1/4) of the validly cast votes.
The aforesaid meetings shall be convened within forty (40) days of the date at which it was ascertained that the net assets
fell below two-thirds or one quarter (1/4) of the Minimum Capital, respectively. Moreover, the Company may be terminated
by resolution of the general meeting of Shareholders.
The resolutions of the general meeting of Shareholders or of a court of law pronouncing the termination and winding-
up of the Company are to be published in the Mémorial and in two (2) newspapers with sufficiently wide circulation, at
least one of which must be a Luxembourg newspaper. The choice of which newspapers are to carry the publication is made
at the discretion of the liquidator(s).
The amounts that have not been claimed by the Shareholders or their beneficiaries at the close of liquidation shall be
deposited with the “Caisse de Consignation” in Luxembourg.
Art. 31. Termination, liquidation and merger of sub-funds or classes of shares. The Board of Directors may decide to
close one or more classes or sub-funds if the net asset value of a sub-fund or of a class has decreased to, or has not reached,
an amount determined by the Board of Directors to be the minimum level for such sub-fund, or such class of Shares, to be
operated in an economically efficient manner or if a substantial modification in the political, economic, regulatory or
monetary situation pertinent to a class or sub-fund would justify such liquidation or if necessary in the interest of the
Shareholders.
In such event, the assets of the sub-fund or class will be realized, the liabilities discharged and the net proceeds distributed
to Shareholders in proportion to their holding of Shares in that sub-fund or class. Notice of the termination of the sub-fund
or class will be given in writing to the Shareholders and/or will be published in a Luxembourg newspaper or elsewhere, if
required by law.
The amounts that have not been claimed by the Shareholders or their beneficiaries at the close of liquidation of a class
or sub-fund shall be deposited with the “Caisse de Consignation” in Luxembourg.
Unless otherwise decided in the interest of, or in order to ensure equal treatment of Shareholders, the Shareholders of
the relevant sub-fund or class of Shares may continue to request the redemption or the conversion of their shares, free of
any redemption and conversion charges (except disinvestment costs) prior the effective date of the liquidation. Such re-
demption or conversion will then be executed by taking into account the liquidation costs and expenses related thereto.
A sub-fund or class may be merged (including by way of contribution) with another sub-fund or class of another sub-
fund by decision of the Board of Directors if for any reason the value of the total net assets in any sub-fund or the net assets
value of any class of Shares within a sub-fund has decreased to, or has not reached, an amount determined by the Board
of Directors to be the minimum level for such sub-fund, or such class of Shares, to be operated in an economically efficient
manner or if a substantial modification in the political, economic, regulatory or monetary situation pertinent to a class or
sub-fund would justify such merger or if necessary in the interests of the Shareholders or the Company. Notice of the merger
will be given in writing to Shareholders at least one (1) month before the entry into effect of such merger.
Art. 32. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the 1915 Law, the 2007 Law and the AIFM Law for
which no specific provision is made in these Articles of Association.
Art. 33. Definitions and Interpretation. References to articles are to the articles of these Articles of Association. Words
importing gender include each gender. References to persons include corporate bodies firms and unincorporated associa-
tions. The singular includes the plural and vice versa. Headings of articles are included for convenience only and do not
86290
L
U X E M B O U R G
affect their interpretation. References to all or any part of any statute or statutory instrument include any statutory amend-
ment, modification or re-enactment in force from time to time and references to any statute include any statutory instrument
or regulations made under it. Any reference to the Company, the Board of Directors, agents, etc., includes a reference to
its or their duly authorized agents or delegates.”
Nothing else being in the Agenda, the extraordinary general meeting was then closed at 3.00 p.m. and these minutes
signed by the members of the board and by the notary.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English.
Whereof this notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the notary by their name, first name, civil
status and residence, the appearing persons signed together with the notary, the present original deed.
Signé: T. Decloedt, V. Masson, R. Maisse, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 mars 2016. Relation: EAC/2016/7124. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Amédé SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2016.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2016084907/572.
(160051889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
SUDTHERM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4750 Pétange, 56, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 204.898.
STATUTS
L'an deux mille seize, le premier mars.
Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU
1. - La société RAINIER INVEST SA, avec siège social à L-2430 Luxembourg, 27, rue Michel Rodange, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.653, ici représentée par M. Jean-Paul DUAR-
TE, agent immobilier, né à Pétange le 26 mai 1971, demeurant professionnellement à L-4873 Lamadelaine, 84, avenue de
la Gare, agissant en sa qualité d’administrateur.
2. - La société SYSTHERM S. à r.l., avec siège social à L-3890 Foetz, 9, rue du Brill, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 177033, ici représentée par Monsieur José Antonio DO ROSARIO
OLIVEIRA, chauffagiste, né le 12 avril 1971 à Clermont-Ferrand (France), demeurant professionnellement à L-3898 Foetz,
9, rue du Brill, agissant en sa qualité de gérant.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif
d'une société anonyme qu’elles déclarent vouloir constituer et dont elles ont arrêté, les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SUDTHERM S.A..
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Pétange.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d’une résolution
de l’actionnaire unique ou en cas de pluralité d’actionnaires, au moyen d’une résolution de l’assemblée générale des
actionnaires.
Le siège de la société pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'admi-
nistration ou de l'administrateur unique.
Le conseil d’administration respectivement l’administrateur unique aura le droit d’instituer des bureaux, centres admi-
nistratifs, agences et succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de chauffage-sanitaire, de ventilation et de climatisation.
La société pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
86291
L
U X E M B O U R G
La société pourra accorder des hypothèques ou garanties, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour
d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes. Elle pourra également s'intéresser
par voie d'apport, de fusion, d'absorption, de constitution, de participation, de crédits, d'achats d'actions, parts, obligations
ou toute autre à toutes autres sociétés ou entreprises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le
développement de ses affaires.
La Société pourra donner en location à l'intérieur du groupe de sociétés dont elle fait partie les installations techniques,
machines et matériel roulant dont elle dispose et faire de la mise à disposition de personnel.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), représenté par cent (100) actions d'une
valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310,-) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives.
Pour autant qu’il y ait des actions au porteur, celles-ci sont soumises aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action.
S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés
jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.
Administration - Surveillance
Art. 8. En cas de pluralité d’actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d’une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d’administration peut être limitée à
un membre, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d’un actionnaire.
Les administrateurs ou l’administrateur unique seront élus par l’assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut
excéder six ans et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-
présidents du conseil d’administration. Le premier président pourra être désigné par l’assemblée générale. En l’absence du
président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-
blement représentés.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqué dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou
valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour
voter en ses lieu et place.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors
d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d’une résolution identique.
Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation
du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la
réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les action-
naires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité
des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations
intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.
86292
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un
registre spécial et signés par au moins un administrateur.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d’administration ou par deux
administrateurs ou l’administrateur unique.
Art. 11. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir
tous les actes de disposition et d’administration dans l’intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les statuts
de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration ou de l’administrateur unique.
Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d’admi-
nistration ou l’administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps.
Le conseil d’administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.
Art. 13. Le conseil d’administration ou l’administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit
en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 14. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances comme suit:
- en cas d’administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur,
- en cas de pluralité d’administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle de
M. Jean-Paul DUARTE et M. José Antonio DO ROSARIO OILIVEIRA.
Art. 15. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,
nommés par l’assemblée générale ou l’actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats,
laquelle ne peut pas dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Assemblées
Art. 16. S’il y a seulement un actionnaire, l’actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l’assemblée des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d’actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 17. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le deuxième vendredi du mois de juin à 13:00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement par
l’administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant dix pour cent (10%) du capital social.
Art. 19. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des Bénéfices
Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire
au(x) commissaire(s).
Art. 21. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des
règles y relatives.
Dissolution - Liquidation
Art. 22. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale ou par l'associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
86293
L
U X E M B O U R G
Disposition générale
Art. 23. Pour tous les cas non prévus par les présents statuts, il est renvoyé à a loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2017.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit:
1.- La société RAINIER INVEST SA, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- La société SYSTHERM S. à r.l., prénommée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme de
TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31.000,- euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Évaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce
soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents Euros
(1.500,- euros).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes, représentées comme dit ci-avant, représentant l'intégralité
du capital social et se considérant comme dûment convoquées, déclarent se réunir à l'instant en Assemblée Générale
Extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
<i>Sont nommés administrateurs:i>
- M. Jean-Paul DUARTE demeurant professionnellement au 84, av. de la Gare à L-4873 LAMADELAINE.
- M. José Antonio DO ROSARIO OILIVEIRA demeurant professionnellement au 9, rue du Brill à L-3898 FOETZ
- Mme Maria da Graça ALMEIDA OLIVEIRA demeurant professionnellement au 84, av. de la Gare à L-4873 LA-
MADELAINE.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
<i>Est nommé commissaire:i>
M. Fabrice GRAINDORGE, demeurant professionnellement au 84, av. de la Gare à L-4873 LAMADELAINE.
3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2021.
4) Le siège social est fixé à L-4750 Pétange, 56, route de Longwy.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné à la comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Duarte, Do Rosario Oliveira, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 mars 2016. Relation: EAC/2016/5636. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016083894/185.
(160050729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.
86294
L
U X E M B O U R G
RE Galaxy III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 202.860,90.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 144.037.
In the year two thousand sixteen, on the twenty-third day of March.
Before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1. Mr. Bruce Charles Bossom, professionally residing at 2 Cavendish Square, W1G 0PD, London (United Kingdom),
being the holder of forty two thousand five hundred (42,500) preference shares of the Company,
here represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, professionally residing in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 22 and 23 March 2016,
2. Mr. Aref Hisham Lahham, professionally residing at 2 Cavendish Square, W1G 0PD, London (United Kingdom),
being the holder of forty two thousand five hundred (42,500) preference shares of the Company,
here represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 22 and 23 March 2016,
3. Mr. Van James Stults, professionally residing at 2 Cavendish Square, W1G 0PD, London (United Kingdom),
being the holder of forty two thousand five hundred (42,500) preference shares of the Company,
here represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 22 and 23 March 2016,
4. Mrs. Lisa Feifer, professionally residing at 2 Cavendish Square, W1G 0PD, London (United Kingdom),
being the holder of one hundred thirty eight thousand five hundred fifty five (138,555) ordinary shares of the Company,
here represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 22 and 23 March 2016,
5. Mr. Roberto Roca, professionally residing at Calle Pinar 5, 28006 Madrid (Spain),
being the holder of one million (1,000,000) ordinary shares of the Company,
here represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 21 and 23 March 2016,
6. Mr. Anthony Patrick Halligan, professionally residing at 2 Cavendish Square, W1G 0PD, London (United Kingdom),
being the holder of one hundred forty eight thousand five hundred eighty seven (148,587) ordinary shares of the Com-
pany,
here represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 22 and 23 March 2016,
7. Mrs. Elaine Susan Alison Halligan, personally residing at 43, Cambridge Road, SW20 0QB London (United King-
dom),
being the holder of one hundred forty eight thousand five hundred eighty six (148,586) ordinary shares of the Company,
here represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 22 and 23 March 2016,
8. Mr. John Mayor, professionally residing at 2 Cavendish Square, W1G 0PD, London (United Kingdom),
being the holder of fifty two thousand seventy six (52,076) ordinary shares of the Company,
here represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 22 and 23 March 2016, and
9. Mrs. Britta Harper, professionally residing at 2 Cavendish Square, W1G 0PD, London (United Kingdom),
being the holder of four hundred thirteen thousand three hundred five (413,305) ordinary shares of the Company,
here represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 22 and 23 March 2016.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are all the shareholders (the “Shareholders”) of RE Galaxy III S.à r.l. (hereinafter the “Compa-
ny”), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 11/13, boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 144.037, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem
86295
L
U X E M B O U R G
(Grand Duchy of Luxembourg), dated 19 December 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions dated 3 February 2009, number 236.
The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary dated 22 March 2016 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing parties, representing the entire share capital, declare having waived any notice requirement, the general
meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Approval of the interim balance sheet as opening balance sheet of the liquidation.
2. Dissolution and liquidation of the Company.
3. Appointment of a liquidator and determination of its powers.
4. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires
the notary to enact, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to approve the interim balance sheet dated 23 March 2016 as opening
balance sheet of the liquidation.
<i>Second resolutioni>
In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the “Law”)
the general meeting of shareholders resolves to dissolve and liquidate the Company.
<i>Third Resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders resolves to appoint Mr. Van James
Stults, born on 30 September 1954 in Illinois (United States of America), professionally residing at 2 Cavendish Square,
W1G 0PD, London (United Kingdom) as liquidator of the Company (the “Liquidator”).
The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law.
The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 of the Law without
requesting further authorisations of the general meeting of shareholders.
The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.
The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders
such powers as he determines and for the period as he thinks fit.
The Liquidator may distribute the Company's assets to the Shareholders in cash and/or in kind in its sole discretion.
Such distribution may take the form of advance payments on future liquidation proceeds.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at two thousand five hundred euro (EUR 2,500).
Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the
day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de mars.
Par-devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
ONT COMPARU:
1. Monsieur Bruce Charles Bossom, résidant professionnellement à 2 Cavendish Square, W1G 0PD, Londres (Royaume-
Uni),
détenteur de quarante-deux mille cinq cents (42.500) parts sociales préférentielles de la Société,
ici représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, résidant professionnellement à Mondorf-les-Bains,
en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution donnée en date des 22 et 23 mars 2016,
86296
L
U X E M B O U R G
2. Monsieur Aref Hisham Lahham, résidant professionnellement à 2 Cavendish Square, W1G 0PD, Londres (Royaume-
Uni),
détenteur de quarante-deux mille cinq cents (42.500) parts sociales préférentielles de la Société,
ici représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution donnée en date des 22 et 23 mars 2016,
3. Monsieur Van James Stults, résidant professionnellement à 2 Cavendish Square, W1G 0PD, Londres (Royaume-Uni),
détenteur de quarante-deux mille cinq cents (42.500) parts sociales préférentielles de la Société,
ici représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution donnée en date des 22 et 23 mars 2016,
4. Madame Lisa Feifer, résidant professionnellement à 2 Cavendish Square, W1G 0PD, Londres (Royaume-Uni),
détentrice de cent trente-huit mille cinq cent cinquante-cinq (138.555) parts sociales ordinaires de la Société,
ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution donnée en date des 22 et 23 mars 2016,
5. Monsieur Roberto Roca, résidant professionnellement à Calle Pinar 5, 28006 Madrid (Espagne),
détenteur d'un million (1.000.000) de parts sociales ordinaires de la Société,
ici représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution donnée en date des 21 et 23 mars 2016,
6. Monsieur Anthony Patrick Halligan, résidant professionnellement à 2 Cavendish Square, W1G 0PD, Londres (Roy-
aume-Uni),
détenteur de cent quarante-huit mille cinq cent quatre-vingt-sept (148.587) parts sociales ordinaires de la Société,
ici représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution donnée en date des 22 et 23 mars 2016,
7. Madame Elaine Susan Alison Halligan, résidant personnellement à 43, Cambridge Road, SW20 0QB, Londres (Roy-
aume-Uni),
détentrice de cent quarante-huit mille cinq cent quatre-vingt-six (148.586) parts sociales ordinaires de la Société,
ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution donnée en date des 22 et 23 mars 2016,
8. Monsieur John Mayor, résidant professionnellement à 2 Cavendish Square, W1G 0PD, Londres (Royaume-Uni),
détenteur de cinquante-deux mille soixante-seize (52.076) parts sociales ordinaires de la Société,
ici représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution donnée en date des 22 et 23 mars 2016, et
9. Madame Britta Harper, résidant personnellement à 43, Cambridge Road, SW20 0QB, Londres (Royaume-Uni),
détentrice de quatre cent treize mille trois cent cinq (413.305) parts sociales ordinaires de la Société,
ici représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution donnée en date des 22 et 23 mars 2016.
Les procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.
Les comparantes sont tous les associés (les “Associés“) de RE Galaxy III S.à r.l. (ci-après la “Société”), une société à
responsabilité limitée, ayant son siège social au 11/13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.037,
constituée selon acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg
en date du 19 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 236 en date du 3 février 2009.
Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 mars 2016, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Les comparants, représentant l'intégralité du capital social, déclarent avoir renoncé à toute formalité de convocation.
L'assemblée générale des associés est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant
à l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Approbation du bilan intérimaire comme bilan d'ouverture de la liquidation.
2. Dissolution et liquidation de la Société.
3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
4. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des associés adopte à l'una-
nimité et requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
86297
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des associés décide d'approuver le bilan intérimaire en date du 23 mars 2016 comme bilan d'ou-
verture de la liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»), l'assemblée générale des associés décide de dissoudre et de liquider la Société.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale des associés décide de nommer M. Van James Stults,
né le 30 septembre 1954, en Illinois (Etats-Unis d'Amérique) résidant professionnellement à 2 Cavendish Square, W1G
0PD, Londres (Royaume-Uni), en tant que liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).
Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi.
Le Liquidateur est par la présente expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi sans
devoir requérir des autorisations supplémentaires auprès de l'assemblée générale des associés.
Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
La Société est engagée par la seule signature du Liquidateur.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l'étendue et la durée.
Le liquidateur pourra distribuer, à sa discrétion, les actifs de la Société aux associés en espèce et/ou en nature. Cette
distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liquidation.
<i>Frais et Dépensesi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est
évalué à environ deux mille cinq cents euros (EUR 2.500).
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparants et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire des comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit
mandataire des comparants a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 mars 2016. GAC/2016/2509. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 4 avril 2016.
Référence de publication: 2016087962/193.
(160056071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2016.
Wow LuxCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.446.176,19.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 202.911.
In the year two thousand and sixteen, the fifteenth day of March, before Me Henri BECK, notary residing in Echternach,
Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Wow LuxCo 2 S.à r.l, a Luxembourg société
à responsabilité limitée with registered office at 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 202.911 (the Company). The
Company has been incorporated on December 28, 2015 pursuant to a deed of Me Henri Beck, notary residing in Echternach,
not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C. The articles of association have not been modified
since.
There appeared:
Wow LuxCo 1 S.àr.l, a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 61, rue de Rollingergrund,
L-2440 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of ninety-three million six hundred nineteen
86298
L
U X E M B O U R G
thousand three hundred ninety-nine euro and eighty cents (EUR 93,619,399.80) and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 202.843 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Peggy Simon, employee, residing professionally at L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a
proxy given under private seal, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of
the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with
the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Reduction of the nominal value of the shares of the Company from one euro (EUR 1) to one euro cent (EUR 0.01)
without reducing the amount of the share capital of the Company, so that the share capital of the Company amounting to
twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) be represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000)
shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred million four hundred thirty-three thousand
six hundred seventy-six euro and nineteen cents (EUR 100,433,676.19) so as to raise it from its present amount of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares, with
a par value of one euro cent (EUR 0.01) each, to one hundred million four hundred forty-six thousand one hundred seventy-
six euro and nineteen cents (EUR 100,446,176.19) by the creation and issue of ten billion forty-three million three hundred
sixty-seven thousand six hundred nineteen (10,043,367,619) new shares with a par value of one euro cent (EUR 0.01);
3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. above;
4. Subsequent amendment and restatement of the article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect
the amendments to the share capital adopted under items 1 and 2.;
5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given
to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. or employee of Avega
S.à r.l to proceed on behalf of the Company the necessary bookkeeping amendments and to the registration of the above
changes in the share register of the Company; and
6. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to reduce the nominal value of the shares of the Company from one euro (EUR 1) to one
euro cent (EUR 0.01) without reducing the amount of the share capital of the Company, so that the share capital of the
Company amounting to twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) be represented by one million two hundred fifty
thousand (1,250,000) shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred million four
hundred thirty-three thousand six hundred seventy-six euro and nineteen euro cents (EUR 100,433,676.19) so as to raise
it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by one million two hundred
fifty thousand (1,250,000) shares, with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each, to one hundred million four hundred
forty-six thousand one hundred seventy-six euro and nineteen cents (EUR 100,446,176.19) by the creation and issue of ten
billion forty-three million three hundred sixty-seven thousand six hundred nineteen (10,043,367,619) new shares with a
par value of one euro cent (EUR 0.01).
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to ten billion forty-
three million three hundred sixty-seven thousand six hundred nineteen (10,043,367,619) new shares with a par value of
one euro cent (EUR 0.01), by way of a contribution in cash amounting to one hundred million four hundred thirty-three
thousand six hundred seventy-six euro and nineteen cents (EUR 100,433,676.19), to be entirely allocated to the share capital
of the Company.
The amount of one hundred million four hundred thirty-three thousand six hundred seventy-six euro and nineteen cents
(EUR 100,433,676.19) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder further resolves to amend article 5 of the Articles so that it reads henceforth as follows:
86299
L
U X E M B O U R G
“ Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at one hundred million four hundred forty-six thousand one hundred seventy-six euro and
nineteen cents (EUR 100,446,176.19), represented by ten billion forty-four million six hundred seventeen thousand six
hundred nineteen (10,044,617,619) shares in registered form, having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.
5.2 The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.”
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes with
power and authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à
r.l. or employee of Avega S.à r.l to proceed on behalf of the Company to the necessary bookkeeping amendments and the
registration of the above changes in the share register of the Company.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, said appearing party signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le quinzième jour de mars, par-devant Me Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-
Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Wow LuxCo 2 S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social est établi au 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
202.911 (la Société). La Société a été constituée le 28 décembre 2015 suivant un acte de Me Henri Beck, notaire de résidence
à Echternach, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société (les
Statuts) n’ont pas été modifiés depuis cette date.
A comparu:
Wow LuxCo 1 S.àr.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social est établi au 61,
rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, disposant d’un capital social de quatre-vingt-
treize millions six cent dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt centimes (EUR 93.619.399,80)
et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202.843 (l’Associé Unique),
ici représenté par Peggy Simon, employée, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumises avec celui-ci aux autorités de l’enregistrement.
L’Associé Unique a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales du capital social de la Société.
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Diminution de la valeur nominale des parts sociales de la Société de un euro (EUR 1) à un centime d’euro (EUR 0,01)
sans réduction du montant du capital social de la Société, de sorte que le capital social de la Société s’élevant à douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500) soit représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales, d’une
valeur nominale de un centime d’euro (EUR 0,01) chacune;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de cent millions quatre cent trente-trois mille six cent
soixante-seize euros et dix-neuf centimes (EUR 100.433.676,19) afin de le porter de son montant actuel de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales, d’une valeur
nominale de un centime d’euro (EUR 0,01) chacune, à cent millions quatre cent quarante-six mille cent soixante-seize
euros et dix-neuf centimes (EUR 100.446.176,19) par la création et l’émission de dix milliards quarante-trois millions trois
cent soixante-sept mille six cent dix-neuf (10.043.367.619) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de un centime
d’euro (EUR 0,01);
3. Souscription à et libération de l’augmentation de capital social spécifiée au point 2. ci-dessus;
4. Modification subséquente et reformulation de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter les modifications
apportées au capital social adoptées aux points 1 et 2.;
86300
L
U X E M B O U R G
5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. ou employé de
Avega S.à r.l. de procéder pour le compte de la Société aux modifications comptables nécessaires et à l’enregistrement des
changements ci-dessus dans le registre des parts sociales de la Société; et
6. Divers.
III. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de diminuer la valeur nominale des parts sociales de la Société de un euro (EUR 1) à un
centime d’euro (EUR 0,01) sans réduction du montant du capital social de la Société, de sorte que le capital social de la
Société s’élevant à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) soit représenté par un million deux cent cinquante mille
(1.250.000) parts sociales, d’une valeur nominale de un centime d’euro (EUR 0,01) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cent millions quatre cent trente-
trois mille six cent soixante-seize euros et dix-neuf centimes (EUR 100.433.676,19) afin de le porter de son montant actuel
de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales,
d’une valeur nominale de un centime d’euro (EUR 0,01) chacune, à cent millions quatre cent quarante-six mille cent
soixante-seize euros et dix-neuf centimes (EUR 100.446.176,19) par la création et l’émission de dix milliards quarante-
trois millions trois cent soixante-sept mille six cent dix-neuf (10.043.367.619) nouvelles parts sociales d’une valeur
nominale de un centime d’euro (EUR 0,01).
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ces faits, l’Associé Unique, susnommé et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à dix milliards
quarante-trois millions trois cent soixante-sept mille six cent dix-neuf (10.043.367.619) nouvelles parts sociales d’une
valeur nominale de un centime d’euro (EUR 0,01), par un apport en numéraire de cent millions quatre cent trente-trois
mille six cent soixante-seize euros et dix-neuf centimes (EUR 100.433.676,19), a affecter intégralement au capital social
de la Société.
Le montant de cent millions quatre cent trente-trois mille six cent soixante-seize euros et dix-neuf centimes d’euro (EUR
100.433.676,19) est immédiatement à la libre disposition de la Société, ce dont la preuve a été apportée au notaire instru-
mentant.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide en outre de modifier l’article 5 des Statuts, de sorte qu’il a désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à cent millions quatre cent quarante-six mille cent soixante-seize euros et dix-neuf centimes
(EUR 100.446.176,19), représenté par dix milliards quarante-quatre millions six cent dix-sept mille six cent dix-neuf
(10.044.617.619) parts sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale de un centime d’euro (EUR 0,01) chacune.
5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter les changements ci-
dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg
S.à r.l. ou employé de Avega S.à r.l. de procéder pour le compte de la Société aux modifications comptables nécessaires
et à l’enregistrement des changements ci-dessus dans le registre des parts sociales de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande de partie comparante ci-dessus, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise prévaudra.
EN FOI DE QUOI, le présent acte est passé à Echternach, à la date qu’en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 17 mars 2016. Relation: GAC/2016/2176. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. BENTNER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
86301
L
U X E M B O U R G
Echternach, le 23 mars 2016.
Référence de publication: 2016083939/179.
(160050714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.
HayFin Onyx LuxCo 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 172.941.
<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil de gérance de l'actionnaire commandité de la Société le 1 i>
<i>eri>
<i> avrili>
<i>2016i>
Le conseil de gérance de l'actionnaire commandité de la Société a décidé, avec effet immédiat, de transférer le siège
social de la Société de son adresse actuelle au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
HayFin Onyx LuxCo 2 S.C.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016087734/14.
(160055790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2016.
MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 122.880.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 15 mars 2016i>
Il résulte des dites résolutions que:
1. Le nombre de gérants de la Société a diminué de quatre à trois.
2. Monsieur Joel Davidson, né le 20 juillet 1968 à Newtownards, Royaume-Uni et demeurant professionnellement au
35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 15 Mars
2016.
Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Delloula Aouinti - gérante
- Joanne Fitzgerald - gérante
- Christopher McCormack - gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 15 Mars 2016.
<i>Pour BR Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l.
i>Joanne Fitzgerald
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2016088256/23.
(160056364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.
Rose HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Highstreet V PropCo III S.à r.l.).
Capital social: EUR 35.000,00.
Siège social: L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 201.485.
In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of April.
Before, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Corestate Capital Holding S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 199.780 (the “Sole Shareholder”),
86302
L
U X E M B O U R G
hereby represented by Mr. Ben BROUSCHER, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of
a proxy given on 5 April 2016.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the
present deed.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Sole Shareholder is the sole shareholder
of HIGHSTREET V PropCo III S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of thirty-five thousand Euro (EUR 35,000.-), whose
registered office is at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following
a deed of the undersigned notary of 12 November 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 216 dated 27 January 2016 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 201.485 (the “Company”). The articles of association of the Company have not yet been amended.
The Sole Shareholder, represented as above mentioned, has recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To change the name of the Company into “ROSE HoldCo S.à r.l.”.
2. Amendment of article 1 of the articles of association of the Company.
3. Miscellaneous.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the name of the Company into ROSE HoldCo S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolved to amend article 1 of the articles of asso-
ciation of the Company which shall forthwith read as follows:
“ Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of “ROSE
HoldCo S.à r.l.” (the Company).”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result
of the present deed, are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and German texts, the English version shall prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechszehn, am achten April.
Vor Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN,
Corestate Capital Holding S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unterliegend dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und einge-
tragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 199.780 (die „Alleingesellschafterin“),
hier vertreten durch Herrn Ben BROUSCHER, Privatangestellter, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer
Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 5. April 2016.
Vorbezeichnete Vollmacht wird nach Unterzeichnung durch die erschienene Person und den Notar dieser Urkunde als
Anlage beigefügt bleiben.
Die Alleingesellschafterin hat den amtierenden Notar gebeten, zu beurkunden, dass die Alleingesellschafterin die al-
leinige Gesellschafterin der HIGHSTREET V PropCo III S.à r.l. ist, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société
à responsabilité limitée) unterliegend dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe
von fünfunddreißigtausend Euro (EUR 35.000,-), mit Gesellschaftssitz in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß Urkunde erstellt durch den unterzeichneten Notar vom 12. November 2015,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 216 vom 27. Januar 2016 und eingetragen im
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 201.485 (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Ge-
sellschaft wurde noch nicht abgeändert.
86303
L
U X E M B O U R G
Die Alleingesellschafterin, wie vorstehend vertreten, erkennt ausdrücklich an, von den aufgrund der folgenden Tages-
ordnung zu fassenden Beschlüssen umfassende Kenntnis gehabt zu haben:
<i>Tagesordnungi>
1. Änderung der Firmierung der Gesellschaft in „ROSE HoldCo S.à r.l.“.
2. Änderung von Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft.
3. Verschiedenes.
Die Alleingesellschafterin hat den amtierenden Notar gebeten folgende Beschlussfassungen aufzunehmen:
<i>Erster Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin hat beschlossen, die Firmierung der Gesellschaft in ROSE HoldCo S.à r.l. abzuändern.
<i>Zweiter Beschlussi>
Im Nachgang zu vorgehendem Beschluss hat die Alleingesellschafterin beschlossen, Artikel 1 der Satzung der Gesell-
schaft abzuändern, um nunmehr wie folgt zu lauten:
„ Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter
der Bezeichnung „ROSE HoldCo S.à r.l.“ (die Gesellschaft).“
<i>Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft in Zusammenhang mit vorliegender Urkunde entstehen oder die sie zu
tragen hat, belaufen sich auf ungefähr eintausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-).
WORÜBER, Urkunde erstellt in Luxemburg am Datum, wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.
Nachdem die Urkunde der erschienenen Person, welche dem Notar mit Nachname, Vorname, Personenstand und Ad-
resse bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die erschienene Person zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: B. BROUSCHER, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 11 avril 2016. Relation: 1/LAC/2016/11665. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Luxemburg, den 15. April 2016.
Référence de publication: 2016093936/98.
(160063110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
Spectrum Brands Lux III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 204.926.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 2490 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016087995/9.
(160055893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2016.
ARISTEA SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 193.297.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2016.
Référence de publication: 2016085685/10.
(160053796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
86304
Advanzia Bank S.A.
ARISTEA SICAV
Aurisys S.A.
Aurisys S.A.
CKM Promotion Immobiliere S.à r.l.
CMP German Opportunity
CMS control of medical systems S.à r.l.
CMS control of medical systems S.à r.l.
Compagnie Financiere de Participations Immobilières S.à r.l.
Copefi
Habacker LogPark Site Eight S. à r.l.
Habacker LogPark Site Five S. à r.l.
Habacker LogPark Site Nine S. à r.l.
Habacker LogPark Site Six S. à r.l.
Habacker LogPark Site Three S. à. r.l.
Habacker LogPark Site Two S. à r.l.
Harry Holdings S.à r.l.
HayFin Onyx LuxCo 2 S.C.A.
Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l.
HICL Infrastructure 2 S.à r.l.
Highstreet V PropCo III S.à r.l.
Highway Holding S.à r.l.
Hilbri S.à r.l.
HPS Groupe Participations S.à r.l.
HYNSH Group
JP Residential VIII S.à r.l.
JV Holdings S.à.r.l.
Kairos International Sicav
K&D Development
Kerta S.à r.l.
KFC International Holdings I S.à r.l.
Kinetik S.à r.l.
Kington S.à r.l.
L'ODAS
Luxembourg Investment Company 139 S.à r.l.
MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l.
Private Placement Opportunities SICAV-SIF
RE Galaxy III S.à r.l.
Rose HoldCo S.à r.l.
Spectrum Brands Lux III S.à r.l.
SUDTHERM S.A.
Wow LuxCo 2 S.à r.l.