logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1699

10 juin 2016

SOMMAIRE

AB Acquisitions Luxco 9 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

81509

Aero-Flux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81508

Aero-Flux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81507

AMP Capital Investors (CLH No. 1) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81508

Am Wenkel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81508

Am Wenkel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81508

Ascoma Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81512

Assistance à la GESTION EVENCE MAR-

CHAND LUXEMBOURG S.A.  . . . . . . . . . . .

81507

Assistance à la GESTION EVENCE MAR-

CHAND LUXEMBOURG S.A.  . . . . . . . . . . .

81507

Athalia VI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81512

Athalia VI B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81511

Athalia Vi Infra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81512

AZA Technology S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81512

Bamboleo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81510

Banque Degroof Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

81510

BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEM-

BOURG S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81510

Banyan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81509

Batiram S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81513

Batiram S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81513

Bureau de Gérances René Kitzler S.à r.l.  . . . .

81508

Cazelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81510

CEP III Co-Investment S.à r.l. SICAR  . . . . . .

81513

Coal Energy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81510

Coal Energy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81511

Corning Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

81511

Crèche Nanny Mc Fee s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

81511

Crédit Agricole Réinsurance S.A.  . . . . . . . . . .

81550

Herbalux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81543

Kensington UK Office (Crewe) S.à r.l.  . . . . . .

81545

LM Equity S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81552

Lock Syndication S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81552

Lynxis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81543

NDT Operations Germany S.à r.l.  . . . . . . . . . .

81548

Rue de la Paix 15 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81514

Sapinda Invest Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

81533

Vrucht Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81508

Yachting Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

81506

Yachting Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

81507

Yamatu S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81507

Yolande Coop  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81507

ZEN High-Tech S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81506

ZEN High-Tech S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81509

ZG & Golugi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81506

ZG & Golugi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81506

Zhelezniak Investments S.à r.l. SPF  . . . . . . . .

81506

Zoetheo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81506

ZXY Luxembourg Investment S.à r.l.  . . . . . . .

81509

81505

L

U X E M B O U R G

ZEN High-Tech S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 104.070.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090474/9.
(160058759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.

ZG & Golugi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1238 Luxembourg, 7, Bisserwee.

R.C.S. Luxembourg B 137.409.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090476/9.
(160058552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.

ZG & Golugi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1238 Luxembourg, 7, Bisserwee.

R.C.S. Luxembourg B 137.409.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090477/9.
(160058553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.

Zhelezniak Investments S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 155.802.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090478/9.
(160058650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.

Zoetheo S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 178.357.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090479/9.
(160058875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.

Yachting Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 151.335.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090470/9.
(160058640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.

81506

L

U X E M B O U R G

Yamatu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 196.983.

Le siège social de la société est transféré au 8 rue de Beggen L-1220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090469/9.
(160058778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.

Yachting Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 151.335.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090471/9.
(160058641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.

Yolande Coop, Société Coopérative.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 33, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 113.637.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090472/9.
(160058762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.

LUXAGEM, Assistance à la GESTION EVENCE MARCHAND LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 47.819.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090517/9.
(160059388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

LUXAGEM, Assistance à la GESTION EVENCE MARCHAND LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 47.819.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090518/9.
(160059389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

Aero-Flux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3250 Bettembourg, 18, rue Klensch.

R.C.S. Luxembourg B 106.620.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090543/9.
(160059783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

81507

L

U X E M B O U R G

Aero-Flux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3250 Bettembourg, 18, rue Klensch.

R.C.S. Luxembourg B 106.620.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090544/9.
(160059790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

Am Wenkel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8081 Bertrange, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 99.085.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090553/9.
(160059782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

Am Wenkel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8081 Bertrange, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 99.085.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090554/9.
(160059789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

AMP Capital Investors (CLH No. 1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 850.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 141.774.

Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090555/9.
(160059698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

Vrucht Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 159.516.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090458/9.
(160058718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.

Bureau de Gérances René Kitzler S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8058 Bertrange, 3, Beim Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 83.096.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090599/9.
(160059787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

81508

L

U X E M B O U R G

ZEN High-Tech S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 104.070.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 06 avril 2016

Les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
- Renouvellement des mandats de deux administrateurs: Monsieur Marc BRAMI, demeurant à 14, rue des Prunelles,

L-5639 Mondorf les Bains et Monsieur Eric BLAIR, demeurant à MC-98000 Monaco, 20 Boulevard de France jusqu'à
l'assemblée statutaire de 2021;

- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes: la société LE COMITIUM INTERNATIONAL SA, 15-17,

Avenue Guillaume L-1651 Luxembourg, (RCS B83527), jusqu'à l'assemblée statutaire de 2021.

Le Conseil d'Administration réuni le même jour a décidé de renouveler le mandat de l'administration délégué Monsieur

Marc BRAMI demeurant à 14, rue des Prunelles, L-5639 Mondorf les Bains pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc BRAMI
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2016090473/19.
(160058758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.

ZXY Luxembourg Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 176.087.

Le bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2016.

Référence de publication: 2016090480/10.
(160058810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.

AB Acquisitions Luxco 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 180.688.

Les comptes consolidés de Walgreens Boots Alliance, Inc. au 31 août 2015 ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016090539/11.
(160059885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

Banyan, Société Anonyme.

Capital social: EUR 246.000,00.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 76.957.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 10 Mars 2016 que:
- L'assemblée a décidé d'accepter la démission de Maître Daniel PHONG en tant que dépositaire professionnel en charge

de la tenue du registre des actions.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2016090582/14.
(160059443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

81509

L

U X E M B O U R G

Bamboleo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 105.183.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 10 mars 2016

1. L'Assemblée accepte les démissions en tant qu'administrateurs de catégorie A, de Monsieur Ernesto Lejeune Valcàrel,

administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 6-1 Legazpi, E-20004 San Sebastian et de Monsieur Enrique
Vallejo Inchausti, avec adresse professionnelle au 6-1 Legazpi, E-20004 San Sebastian avec effet au 10 mars 2016.

2. L'Assemblée nomme avec effet au 10 mars 2016 en remplacement de l'administrateur démissionnaire Ernesto Lejeune

Valcàrel, la société Lux Business Management S.à r.l., avec siège social au 40, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg.
Ce mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.

Luxembourg, le 8 avril 2016.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016090580/17.
(160059305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. Banque Degroof Luxembourg S.A.).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 25.459.

<i>Extrait du Conseil d'Administration du 26 novembre 2015

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d'administration tenu au siège social le 26 novembre 2015, que:
Le Conseil d'administration, décide de renouveler le mandat de réviseur d'entreprises de la société KPMG Audit établie

et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer, pour une période d'un an expirant à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2017.

Référence de publication: 2016090581/12.
(160059551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

Coal Energy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 154.144.

Il est à noter que Mademoiselle Gwenaëlle, Bernadette, Andrée, Dominique Cousin et Monsieur Jacob Mudde, ont

démissionné de leur fonction d'administrateurs de Classe B avec effet au 10 avril 2016 de la société Coal Energy S.A., sise
au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 154144.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 avril 2016.

Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2016090612/16.
(160059470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

Cazelia, Société Anonyme.

Siège social: L-7526 Mersch, 5, allée John W. Leonard.

R.C.S. Luxembourg B 147.139.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016090606/9.
(160059394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

81510

L

U X E M B O U R G

Coal Energy S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 154.144.

Le siège social de la société anonyme Coal Energy S.A., sise au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et

enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154144 a été dénoncée avec
effet au 10 avril 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 avril 2016.

Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2016090613/14.
(160059595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

Corning Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 180.981.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 de la Société Corning Luxembourg S.à r.l. ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Corning Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2016090616/11.
(160059686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

Crèche Nanny Mc Fee s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 22, rue Roudewee.

R.C.S. Luxembourg B 168.766.

Il résulte d'une cession de parts sociales intervenue le 29 mars 2016 que le capital est désormais détenu comme suit:
- Yasmine AZZOUZI, éducatrice, demeurant à B-6860 Leglise, 80, rue de Luxembourg, 100 parts sociales (soit 100 %

du capital);

La société prend également acte du changement d'adresse de Madame Yasmine AZZOUZI, gérant, demeurant à B-6860

Leglise, 80, rue de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Yasmine AZZOUZI
<i>Gérant

Référence de publication: 2016090617/15.
(160059224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

Athalia VI B, Société Civile.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg E 5.584.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 18 mars 2016, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Maximilien Dambax, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

2. Nomination de Sandra Legrand, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au

mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2016.

Référence de publication: 2016090566/14.
(160059700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

81511

L

U X E M B O U R G

Ascoma Luxembourg, Société Anonyme.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue JF Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 128.564.

Nous vous informons que Monsieur Anthony Stevenson, Administrateur et Administrateur-Délégué de la SA ASCOMA

LUXEMBOURG depuis le 6 décembre 2013, demeure désormais à l'adresse suivante:

- 1, rue des Romains - L-8284 Kehlen - Grand-Duché du Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Monsieur Hervé Husson
<i>Le Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2016090562/13.
(160059332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

Athalia VI, Société Civile.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg E 5.582.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 18 mars 2016, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Maximilien Dambax, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

2. Nomination de Sandra Legrand, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au

mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2016.

Référence de publication: 2016090565/14.
(160059699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

Athalia Vi Infra, Société Civile.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg E 5.616.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 18 mars 2016, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Maximilien Dambax, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

2. Nomination de Sandra Legrand, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au

mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2016.

Référence de publication: 2016090567/14.
(160059702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

AZA Technology S.C.S., Société en Commandite simple.

R.C.S. Luxembourg B 186.447.

Suivant lettre recommandée du 17 mars 2016 à la société AZA TECHNOLOGY S.C.S., société à responsabilité limitée,

6 place de Nancy L-2212 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 186.447, le siège de la société est dénoncé avec effet au 17
mars 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2016.

<i>Pour la société
ABAX Trust

Référence de publication: 2016090571/13.
(160059169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

81512

L

U X E M B O U R G

Batiram S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4410 Soleuvre, 12, Zone Um Woeller.

R.C.S. Luxembourg B 134.590.

- En vertu de l'acte de cession de parts du 17 mars 2016,
Madame Marie MEDELA, née le 03/11/1964 à BANDE (Espagne), employée, demeurant à 4 Impasse des Abeilles

57390 REDANGE (France), a transféré 50 parts sociales détenues dans la société à Madame Christel DIDIER, esthéticienne,
née le 26/04/1986 à Metz (France), demeurant au 44 rue de l'Amitié 57535 Marange-Silvange (France).

Les associés de la société sont à présent:

Madame Christel DIDIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Parts Sociales
Monsieur Jordan MEDELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Parts Sociales
Monsieur Ramon MEDELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Parts Sociales

Fait à Livange, le 17 mars 2016.

<i>Le gérant

Référence de publication: 2016090583/17.
(160059220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

Batiram S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4410 Soleuvre, 12, Zone Um Woeller.

R.C.S. Luxembourg B 134.590.

<i>Première résolution

L'assemblée décide de révoquer:
- Madame MEDELA Marie, née le 03/11/1964 à BANDE (Espagne), demeurant au 4, impasse des Abeilles 57390

REDANGE (France), de sa fonction de gérante administrative.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de révoquer
- Monsieur MEDELA Ramon, né le 20/12/1973 à ROMBAS (France), demeurant au 29 route de Malancourt 57120

ROMBAS, de sa fonction de gérant technique.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer:
- Monsieur MEDELA Ramon, né le 20/12/1973 à ROMBAS (France), demeurant au 29 route de Malancourt 57120

ROMBAS, à la fonction de gérant unique pour une durée indéterminée.

Fait à Livange, le 22 mars 2016.

<i>L'administrateur

Référence de publication: 2016090584/21.
(160059220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

CEP III Co-Investment S.à r.l. SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement

en Capital à Risque.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 134.839.

Il résulte des résolutions datées du 20 octobre 2015, que la totalité des parts sociales de la Société détenues par Carlyle

Numericable Partner I, L.P. et Carlyle Numericable Partner II, L.P. ont été rachetées et annulées.

En conséquence, Carlyle Numericable Partner I, L.P. et Carlyle Numericable Partner II, L.P. ont cessé d'être associées

de la Société à compter du 20 octobre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2016.

CEP III Co-Investment S.à r.l. SICAR
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016090629/16.
(160059673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2016.

81513

L

U X E M B O U R G

Rue de la Paix 15 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 200.742.

In the year two thousand and sixteen, on the eleventh day of March.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, a company incorporated under the

laws of Germany, having its registered office at Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg, Germany, registered with the Com-
mercial Register B of the District Court of Hamburg (Handelregister B des Amtsgerichts Hamburg) under number HRB
12891, acting for the account of Best Value Europe I, a German Open Ended Real Estate Spezial-AIF incorporated under
the law of Germany (the “Sole Member”);

here represented by Mr. Gérald STEVENS, lawyer, residing professionally at 3b, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:
I. state that HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung is the Sole Member of

Rue de la Paix 15 S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) having its registered office
at 1, rue Isaac Newton, L-2242 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number
B 200.742, incorporated by a deed enacted by Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains on October 6,
2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Company”);

II. record the following resolutions which have been taken in the best corporate interest of the Company, according to

the agenda below:

<i>Agenda

1. Change of the registered office of the Company to 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange and subsequent amendment of

articles 2.1 of the articles of association of the Company to read as follows:

“The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the “Board”). The registered office
may  be  transferred  to  any  other  place  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  by  a  resolution  of  the  members,  acting  in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles”.

2. Deletion of article 3.3. of the articles of association of the Company and subsequent renumbering of the articles 3.4,

3.5 and 3.6 of the articles of association of the Company;

3. Amendment of article 8.2.vi of the articles of association of the Company to read as follows:
“The Board shall elect a chairman among its members and as the case may be, a secretary for each meeting. The secretary,

or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board of managers, which
shall be signed by the chairman and by the secretary or, if no secretary was appointed, by the chairman and one manager.
The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions. Any copy and excerpt of
any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by
the chairman and by the secretary or a by manager in case no secretary was appointed, or by the sole manager, as the case
may be”;

4. Amendment of articles 5, last paragraph, 15.2 and 16.2 of the articles of association of the Company to read as follows:

Art. 5. Last paragraph, definition of “Units”. ““Units” means each share of the Company, having a par value of ten Euro

(EUR 10) each”.

Art. 15.2. “The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

All the distributions shall be made in accordance with the following order:
- the holders of class A Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point sixty per cent (0.60%) of the par value of the class A Units held by them, then,

- the holders of class B Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the par value of the class B Units held by them, then,

- the holders of class C Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point fifty per cent (0.50%) of the par value of the class C Units held by them, then,

- the holders of class D Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point forty-five per cent (0.45%) of the par value of the class D Units held by them, then,

81514

L

U X E M B O U R G

- the holders of class E Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point forty per cent (0.40%) of the par value of the class E Units held by them, then,

- the holders of class F Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the par value of the class F Units held by them, then,

- the holders of class G Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point thirty per cent (0.30%) of the par value of the class G Units held by them, then,

- the holders of class H Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the par value of the class H Units held by them, then,

- the holders of class I Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of

zero point twenty per cent (0.20%) of the par value of the class I Units held by them, then,

- the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class in the reverse

alphabetical order (i.e. first Class J units, then if no Class J units are in existence, Class I units and in such continuation
until only Class A units are in existence).

Should the whole last outstanding class of Units (by reverse alphabetical order, e.g. Class J Units) have been cancelled

following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution
shall then be allocated to the preceding last outstanding class of Units in the reverse alphabetical order (e.g. Class I Shares
if Class J Units has been cancelled)”.

Art. 16.2. “After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the

net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate
basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions”.

5. Revision of the articles of association of the Company in order to replace the French version by a German version;

and

6. Any other business.

<i>First resolution

The Sole Member resolved to change the registered office of the Company to 1, rue Pletzer in L-8080 Bertrange and to

amend subsequently article 2.1. of the articles of association of the Company to read as follows:

“The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the “Board”). The registered office
may  be  transferred  to  any  other  place  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  by  a  resolution  of  the  members,  acting  in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles”.

<i>Second resolution

The Sole Member resolved to delete article 3.3. of the articles of association of the Company and to subsequently

renumber articles 3.4, 3.5 and 3.6 into articles 3.3, 3.4 and 3.5 of the articles of association of the Company.

<i>Third resolution

The Sole Member resolved to amend article 8.2.vi of the articles of association of the Company to read as follows:
“The Board shall elect a chairman among its members and as the case may be, a secretary for each meeting. The secretary,

or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board of managers, which
shall be signed by the chairman and by the secretary or, if no secretary was appointed, by the chairman and one manager.
The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions. Any copy and excerpt of
any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by
the chairman and by the secretary or a by manager in case no secretary was appointed, or by the sole manager, as the case
may be”.

<i>Fourth resolution

The Sole Member resolved to amend articles 5, last paragraph, 15.2 and 16.2 of the articles of association of the Company

to read as follows:

Art. 5. Last paragraph, definition of “Units”. ““Units” means each share of the Company, having a par value of ten Euro

(EUR 10) each”.

Art. 15.2. “The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

All the distributions shall be made in accordance with the following order:
- the holders of class A Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point sixty per cent (0.60%) of the par value of the class A Units held by them, then,

- the holders of class B Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the par value of the class B Units held by them, then,

81515

L

U X E M B O U R G

- the holders of class C Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point fifty per cent (0.50%) of the par value of the class C Units held by them, then,

- the holders of class D Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point forty-five per cent (0.45%) of the par value of the class D Units held by them, then,

- the holders of class E Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point forty per cent (0.40%) of the par value of the class E Units held by them, then,

- the holders of class F Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the par value of the class F Units held by them, then,

- the holders of class G Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point thirty per cent (0.30%) of the par value of the class G Units held by them, then,

- the holders of class H Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the par value of the class H Units held by them, then,

- the holders of class I Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of

zero point twenty per cent (0.20%) of the par value of the class I Units held by them, then,

- the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class in the reverse

alphabetical order (i.e. first Class J units, then if no Class J units are in existence, Class I units and in such continuation
until only Class A units are in existence).

Should the whole last outstanding class of Units (by reverse alphabetical order, e.g. Class J Units) have been cancelled

following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution
shall then be allocated to the preceding last outstanding class of Units in the reverse alphabetical order (e.g. Class I Shares
if Class J Units has been cancelled)”.

Art. 16.2. “After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the

net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate
basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions”.

<i>Fifth resolution

The Sole Member resolved, in consideration of the before resolution, to replace the French version of the articles of

association of the Company by a German version to be read as follows:

I. Name - Eingetragener Sitz - Gegenstand - Dauer

Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist „Rue de la Paix 15 S.à r.l.“ (das „Ge-

sellschaft“). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) (société à responsabilité limitée), die
den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz“) und dieser Satzung (die „Satzung“) unterliegt.

Art. 2. Eingetragener Sitz.
2.1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft liegt in der Gemeinde Bertrange, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann

innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Vorstands (der „Vorstand“) verlegt werden. Der eingetragene Sitz
kann an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg durch einen Beschluss der Gesellschafter, die im Einklang mit
den für die Änderung der Satzung vorgeschriebenen Vorschriften handeln, verlegt werden.

2.2. Zweigstellen, Tochtergesellschaften oder andere Büros können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland

durch Beschluss des Vorstands gegründet werden. Wenn der Vorstand feststellt, dass außergewöhnliche politische oder
militärische Entwicklungen oder Vorfälle eingetreten sind oder bevorstehen, und dass diese Entwicklungen oder Vorfälle
die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die gewöhnliche Kommunikation zwischen
solch einem Büro und Personen im Ausland stören könnten, kann der eingetragene Sitz zeitweilig bis zur vollständigen
Beendigung dieser Umstände ins Ausland verlegt werden. Diese zeitweiligen Maßnahmen haben keine Auswirkung auf
die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet der temporären Verlegung ihres eingetragenen Sitzes eine in Luxemburg
eingetragene Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1.  Die  Gesellschaft  ist  eine  Immobiliengesellschaft  gemäß  §§  234  ff.  des  deutschen  Kapitalanlagegesetzbuches

(KAGB) und unterliegt daher den Bestimmungen des KAGB. Der Gesellschaftszweck ist beschränkt auf diejenigen Ak-
tivitäten,  welche  die  HANSAINVEST  Hanseatische  Investment-Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  („HANSAIN-
VEST“)  im  Namen  des  alternativen  Investmentfonds  mit  feststehenden  Investitionsregeln  mit  Schwerpunkt  auf
Immobilienvermögen mit dem Namen „Best Value Europe I“ („der Fonds“) ausüben darf.

Der Gesellschaftszweck besteht daher im Erwerb, Halten, in der Verwaltung und Veräußerung von Immobilien, die von

der HANSAINVEST auf Rechnung des Fonds gemäß §§ 231 ff. KAGB sowie gemäß den Investmentregeln des Fonds
erworben werden können, und im Erwerb, Halten, in der Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Immobiliengesellschaften gemäß §§ 234 ff. KAGB, deren Ziel auf diejenigen Aktivitäten beschränkt ist, welche die HAN-

81516

L

U X E M B O U R G

SAINVEST  im  Namen  des  Fonds  gemäß  dem  deutschen  Kapitalanlagegesetzbuch  (KAGB)  sowie  den  anwendbaren
Investitionsregeln des Fonds ausführen darf.

3.2. Die Gesellschaft kann in Übereinstimmung mit § 235 Abs. 1 Nr. 2 und § 231 Abs. 3 KAGB Waren erwerben, die

für die Verwaltung ihres Gesellschaftsvermögens benötigt werden. Der Erwerb von Immobilienvermögen ist nur gestattet,
wenn die Beteiligung an Immobilienvermögen zuvor von (einem) kompetenten Sachverständigen, der von HANSAIN-
VEST benannt wurde, bewertet wurde. Der Erwerb einer Beteiligung an einer Immobiliengesellschaft ist des Weiteren nur
gestattet, wenn die Beteiligung zuvor von einem Wirtschaftsprüfer gemäß 319 Abs. 1 des deutschen Handelsgesetzbuchs
(HGB) bewertet wurde.

3.3. Die Gesellschaft kann, innerhalb der Beschränkungen des KAGB, in jedweder Form Geld leihen, mit Ausnahme

eines öffentlichen Kaufangebots. Den Beschränkungen des KAGB unterliegend, kann sie nur im Wege einer Privatplat-
zierung Schuldscheine, Obligationen, Pfandbriefe und jede Art von Schulden bzw. Beteiligungspapiere herausgeben. Den
Beschränkungen des KAGB unterliegend, kann die Gesellschaft Beteiligungen an Krediten erwerben bzw. Gelder verleihen
einschließlich der Erlöse von Anleihen bzw. Herausgabe von Schuldverschreibungen an ihre Tochterunternehmen, ver-
bundene  Unternehmen  oder  an  jedes  andere  Unternehmen,  das  einen  Teil  der  Unternehmensgruppe  bildet,  zu  der  die
Gesellschaft gehört. Den Beschränkungen des KAGB unterliegend, ist es der Gesellschaft gestattet, Kredite aufzunehmen
und zu halten sowie Wertpapiere als Sicherheiten (auch in der Form eines Sicherheitenrechts oder einer Grundstückslast)
zum beabsichtigten Erwerb von Vermögenswerten zu verwenden.

3.4. Die Gesellschaft kann jegliche Techniken und Instrumente in Bezug auf seine Investitionen zum Zweck von deren

effizienten Verwaltung einsetzen, einschließlich Techniken und Instrumente, die ausgelegt sind, die Gesellschaft gegen
Risiken, wie z.B. Kreditrisiken, Währungsumtausch, Zinsrisiko und andere Risiken zu schützen.

3.5. Die Gesellschaft kann alle Geschäftstransaktionen durchführen und alle Maßnahmen ergreifen, die im Hinblick auf

das Erreichen des oben detailliert beschriebenen Zwecks erforderlich sind, insofern diese gemäß KAGB und den anwend-
baren Investitionsregeln des Fonds gestattet sind.

Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Zeit gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund von Tod, Außerkraftsetzung der bürgerlichen Rechte, Unfähigkeit, Insolvenz,

Bankrott oder ähnlichen Anlässen, die einen oder mehrere Gesellschafter betreffen, aufgelöst.

II. Gesellschaftskapital - Gesellschaftsanteile

Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft wird auf vierzehntausendvierhundert Euro (14,400 Euro) festgesetzt, vertreten

durch:

- Eintausendzweihundertsechzig (1.260) Klasse-A-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-A-Anteile“);
- Zwanzig (20) Klasse-B-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-B-Anteile“);
- Zwanzig (20) Klasse-C-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-C-Anteile“);
- Zwanzig (20) Klasse-D-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-D-Anteile“);
- Zwanzig (20) Klasse-E-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-E-Anteile“);
- Zwanzig (20) Klasse-F-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-F-Anteile“);
- Zwanzig (20) Klasse-G- Gesellschaftsanteile (die „Klasse-G-Anteile“);
- Zwanzig (20) Klasse-H-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-H-Anteile“);
- Zwanzig (20) Klasse-I-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-I-Anteile“);
- Zwanzig (20) Klasse-J-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-J-Anteile“);
wobei alle einen Nennwert von zehn Euro (10 Euro) pro Stück haben und jeweils gezeichnet und voll eingezahlt sind.
5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann ein oder mehrere Male durch einen Beschluss der Gesellschafter, die im

Einklang mit den für die Änderung der Satzung vorgeschriebenen Bedingungen handeln, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.2.1. Das Stammkapital der Gesellschaft kann durch den Rückkauf oder die Annullierung von Anteilen reduziert wer-

den, vorausgesetzt, dass diese Annullierung die Gesamtheit der herausgegebenen Anteile in einer oder mehreren Klassen
der Einheiten betrifft. Solche Rückkäufe oder Annullierungen von Anteilsklassen sind in umgekehrter alphabetischer Rei-
henfolge vorzunehmen (beginnend mit den Klasse-J-Anteilen).

Im Fall einer Herabsetzung des Stammkapitals durch den Rückkauf und die Annullierung einer Anteilsklasse erhalten

die Halter der zurückgekauften und annullierten Anteilsklassen von der Gesellschaft den Betrag, der dem Annullierungs-
wert pro Anteil für jeden Anteil der relevanten Klasse, die von ihnen gehalten wird und die zurückgekauft und annulliert
wurden, entspricht.

5.2.2. Der Annullierungswert pro Anteil ist durch Division des Gesamtannullierungsbetrags durch die Anzahl der in der

Anteilsklasse, die zurückgekauft und annulliert wird, enthaltenen Anteile zu ermitteln.

5.2.3. Der Gesamtannullierungsbetrag ist der Betrag, der vom Vorstand auf Basis der relevanten Zwischenabschlüsse

festgelegt und von den Gesellschaftern genehmigt wird. Der Gesamtannullierungsbetrag ist der verfügbare Betrag der

81517

L

U X E M B O U R G

relevanten Anteilsklasse zum Zeitpunkt der Annullierung der relevanten Anteilsklassen, soweit die Generalversammlung,
die im Einklang mit den für die Satzungsänderung vorgeschriebenen Bestimmungen handelt, nichts anderes beschlossen
hat. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass der Gesamtannullierungsbetrag niemals höher sein darf als der verfügbare
Betrag.

5.2.4. Nach dem Rückkauf und der Annullierung der Anteile der betreffenden Anteilsklasse wird der Annullierungswert

pro Anteil fällig und ist von der Gesellschaft zu zahlen.

5.3. Zusätzlich zum Stammkapital kann eine Einzahlung auf das Agio getätigt werden, auf das jegliche Agiozahlung

für jeglichen Anteil angerechnet wird. Der Betrag des besagten Agios steht, je nach Situation, den Gesellschaftern oder
dem Vorstand zur freien Verfügung.

Für die Zwecke dieses Artikels 5 werden die nachstehenden Wörter wie folgt definiert:
- „Verfügbarer Betrag“ bezeichnet (ohne Doppelzählung) den Betrag der Nettogewinne, die einer Anteilsklasse der

Gesellschaft (einschließlich Gewinnvorträge) zugeordnet werden kann, insofern die Gesellschafter, die Anteile von der
besagten Anteilsklasse halten, einen Anspruch auf Dividendenausschüttung haben, zuzüglicher (i) aller frei ausschüttbarer
Reserven (zur Klarstellung: dazu zählt auch die Agiorücklage) und (ii) gegebenenfalls des Betrags der Stammkapitalhe-
rabsetzung und der Minderung der gesetzlichen Rücklagen, die sich auf die Anteilsklasse bezieht, die annulliert wird, sofern
diese Herabsetzung den gesetzlich verfügbaren Beträgen entspricht, abzüglich (i) aller Verluste (einschließlich Verlust-
vorträge)  und  (ii)  aller  Summen,  die  gemäß  den  gesetzlichen  Anforderungen  oder  gemäß  Satzung  in  die  Rücklage(n)
eingestellt werden müssen, jedes Mal wie in den relevanten Zwischenkonten ausgewiesen (zur Klarstellung: ohne Dop-
pelzählung) so dass:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR)
Wodurch:
AA = Verfügbarer Betrag;
NP = Nettogewinn, der der Anteilsklasse zuzurechnen ist (einschließlich Gewinnvorträge gemäß Festlegung für die

relevante Anteilsklasse);

P = alle frei ausschüttbaren Reserven;
CR = der Betrag der Herabsetzung des Stammkapitals und der Herabsetzung der gesetzlichen Reserve in Bezug auf die

zu annullierende Anteilsklasse soweit das den gesetzlich verfügbaren Beträgen entspricht;

L= Verluste (einschließlich Verlustvorträge);
LR = alle Summen, die gemäß den Anforderungen des Gesetzes oder der Satzung in die Rücklage(n) einzustellen sind.
- „Annullierungsbetrag pro Anteil“ bezeichnet den Annullierungsbetrag pro Anteil, der an einen Gesellschafter einer

zurückgekauften und annullierten Anteil zu zahlen ist.

- „Zwischenkonten“ bezeichnet die Zwischenkonten der Gesellschaft zum Datum des relevanten Zwischenabschlusses.
- „Datum des Zwischenabschlusses“ bezeichnet das Datum, frühestens acht (8) Tage vor dem Datum des Rückkaufs

und der Annullierung der relevanten Anteilsklassen.

- „Gesamtannullierungsbetrag“ bezeichnet den als Rückkaufpreis für alle Anteile einer Anteilsklasse, die zurückgekauft

und annulliert werden sollen, zu zahlenden Gesamtbetrag.

- „Anteile“ bezeichnet jeden Anteil des Unternehmens, der einen Nennwert von zehn Euro (10 Euro) pro Stück hat.“

Art. 6. Gesellschaftsanteile.
6.1. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Eigentümer pro Gesellschaftsanteil

an. Im Fall des gemeinsamen Eigentums eines oder mehrerer Gesellschaftsanteils(e), müssen die Gesellschafter einen (1)
Eigentümer pro Gesellschaftsanteil benennen.

6.2. Gesellschaftsanteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar.
Wenn die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, sind die Gesellschaftsanteile frei auf Dritte übertragbar.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat, bedarf die Übertragung von Gesellschaftsanteilen (unter Leb-

enden)  an  Dritte  der  vorherigen  Genehmigung  der  Gesellschafter,  die  mindestens  dreiviertel  (3/4)  des  Stammkapitals
repräsentieren.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte von Todes wegen muss von den Gesellschaftern, die mindestens

dreiviertel (3/4) der Rechte, die im Besitz der Hinterbliebenen sind, repräsentieren, genehmigt werden.

Die Übertragung eines Gesellschaftsanteils ist der Gesellschaft oder Dritten gegenüber nur entgegenzuhalten innerhalb

der Beschränkungen der Klausel 6.5 und sofern eine Zustellung an die Gesellschaft oder die Genehmigung der Gesellschaft
in Einklang mit Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuchs erfolgt ist.

6.3. Ein Gesellschafterregister wird am eingetragenen Sitz aufbewahrt und kann von jedem Mitglied auf Nachfrage

eingesehen werden.

6.4. Die Gesellschaft darf ihre eigenen Anteile zurückkaufen, vorausgesetzt dass die Gesellschaft ausreichend aus-

schüttbare Rückstellungen für diesen Zweck zur Verfügung hat oder wenn die Rücknahme aus einer Herabsetzung des
Stammkapitals der Gesellschaft resultiert.

81518

L

U X E M B O U R G

6.5. Insofern und solange die Beteiligungen der HANSAINVEST auf Rechnung des Fonds gehalten werden, ist eine

Verfügung über Aktien (oder über einen Teil derselben), die der HANSAINVEST gehören, nur zulässig mit der vorherigen
Genehmigung des von HANSAINVEST gemäß §§ 80 ff. KAGB für den Fonds benannten Verwahrers (§ 84 Abs. 1 Z. 5
KAGB) (der „Verwahrer“). Dasselbe gilt für jede Belastung von Anteile, die Gewährung von Unter-Beteiligungen an einem
Anteil und die Verfügung über gesonderte Rechte und Forderungen aus dem Gesellschaftsverhältnis. Zusätzlich bedürfen
Verfügungen über das Vermögen der Gesellschaft der Genehmigung des Verwahrers.

III. Geschäftsführung - Vertretung

Art. 7. Ernennung und Entlassung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführer(n) geleitet, die durch einen Beschluss der Gesell-

schafter, welche deren Amtsdauer festlegen, ernannt werden. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter sein.

7.2. Die Geschäftsführer können durch einen Beschluss der Gesellschafter jederzeit entlassen werden (mit oder ohne

Grund).

Art. 8. Vorstand. Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt worden sind, dann bilden sie den Vorstand (den „Vorstand“).

Der/die  Gesellschafter  kann/können  entscheiden,  die  ernannten  Geschäftsführer  als  Kategorie-A-Geschäftsführer  (die
„Kategorie-A-Geschäftsführer“) und Kategorie-B-Geschäftsführer (die „Kategorie-B-Geschäftsführer“) zu qualifizieren.

8.1. Befugnisse des Vorstands
(i) Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich vom Gesetz oder gemäß Satzung für den/die Gesellschafter reserviert sind,

fallen unter die Zuständigkeit des Vorstands, der alle Befugnisse hat, alle Handlungen und Tätigkeiten, die mit den Ge-
sellschaftszweck in Einklang stehen, auszuführen und zu genehmigen.

(ii) Spezielle und begrenzte Befugnisse können für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Vertretern des

Vorstands übertragen werden.

(iii) Der Vorstand kann von Zeit zu Zeit seine Befugnisse für bestimmte Aufgaben an einen oder mehrere Ad-Hoc-

Vertreter, der/die kein/e Mitglied/er oder Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen, delegieren. Der Vorstand legt die
Befugnisse, Pflichten und Entlohnung (falls zutreffend) ihres/ihrer Vertreter/s, die Dauer des Vertretungszeitraums und
andere relevanten Bedingungen seiner/ihrer Vertretung fest.

8.2. Verfahren
(i) Der Vorstand trifft sich auf Anfrage eines Geschäftsführers, an dem in der Einberufung genannten Ort, der grund-

sätzlich im Großherzogtum Luxemburg liegt.

(ii) Eine schriftliche Mitteilung über jede Vorstandssitzung wird an alle Geschäftsführer mindestens vierundzwanzig

(24) Stunden im voraus an alle Geschäftsführer verschickt, ausgenommen in Notfällen, deren Art und Umstände in der
Einberufung der Besprechung dargelegt werden.

(iii) Eine Einberufung ist nicht erforderlich, wenn alle Vorstandsmitglieder zugegen oder vertreten sind und wenn sie

erklären, dass sie vollständige Kenntnis der Tagesordnung der Besprechung haben. Auf eine Einberufung der Sitzung kann
auch von einem Geschäftsführer, entweder vor oder nach der Sitzung, verzichtet werden. Separate schriftliche Einberu-
fungen sind nicht erforderlich für Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten abgehalten werden, die in einem zuvor vom
Vorstand angenommenen Zeitplan angegeben sind.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Vorstandssitzungen

vertreten zu lassen.

(v) Der Vorstand kann nur beraten oder rechtskräftig handeln, wenn bei Vorstandssitzungen eine Mehrheit der Ge-

schäftsführer  anwesend  oder  vertreten  ist,  einschließlich  mindestens  eines  Kategorie-A-Geschäftsführers  und  eines
Kategorie-B-Geschäftsführers im Fall, dass das/die Gesellschafter die Geschäftsführer als Kategorie-A-Geschäftsführer
und Kategorie-B-Geschäftsführer qualifiziert hat/haben. Entscheidungen sind durch Mehrheitsbeschluss der bei einer Sit-
zung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer zu treffen, einschließlich der Stimme von mindestens einem Kategorie-
A-Geschäftsführer  und  der  Stimme  von  einem  Kategorie-B-Geschäftsführer  im  Fall,  dass  das/die  Gesellschafter  die
Geschäftsführer als Kategorie-A-Geschäftsführer und Kategorie-B-Geschäftsführer qualifiziert hat/haben.

(vi) Bei jeder Sitzung wählt der Vorstand einen Präsidenten aus seinen Mitgliedern, und gegebenfalls einen Sekretär.

Der Sekretär, oder wenn kein Sekretär ernannt wurde, der Präsident verfasst das Protokoll der Sitzung welches durch den
Präsidenten und den Sekretär oder, wenn kein Sekretär ernannt wurde, durch den Präsidenten und einen Geschäftsführer
unterzeichnet wird. Gegebenfalls werden die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters von ihn/ihr auch schriftlich verfasst
und unterzeichnet. Kopien und Auszüge von solchen Originalprotokollen die in Prozessverfahren oder an Dritte geliefert
werden müssen werden, wie es der Fall sein kann, vom Präsidenten und vom Sekretär oder von einem Geschäftsführer
falls kein Sekretär ernannt wurde, oder durch den alleinigen Gesellschafter unterzeichnet.

(vii) Jeder Geschäftsführer kann an einer Vorstandssitzung per Telefon oder Videokonferenz oder über ein anderes

Kommunikationsmedium teilnehmen, das allen an der Sitzung teilnehmenden Personen erlaubt, einander zu identifizieren,
zu hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme über diese Medien gilt als persönliche Teilnahme an einer ord-
nungsgemäß  einberufenen  und  abgehaltenen  Sitzung.  Die  Sitzung  wird  mit  dem  Datum  der  Abhaltung  datiert.  Die
Entscheidung wird mit dem Datum der Abhaltung der Sitzung wirksam. Das Protokoll wird von dem Geschäftsführer, der
über diese Medien an der Sitzung teilgenommen hat, später unterzeichnet.

81519

L

U X E M B O U R G

(viii) Umlaufbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterschrieben sind (die „Umlaufbeschlüsse der Geschäfts-

führer“) sind gültig und verbindlich, als ob diese bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung
gefasst worden wären, und sie tragen das Datum der letzten Unterschrift.

8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers oder die gemeinsame

Unterschrift eines Kategorie-A-Geschäftsführers und eines Kategorie-B-Geschäftsführers der Gesellschaft vertreten, für
den Fall, dass der/die Gesellschafter die Geschäftsführer als Kategorie-A-Geschäftsführer und Kategorie-B-Geschäftsfüh-
rer qualifiziert hat/haben, oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift von jeder/allen Person/en, an die solch
eine Unterschriftsvollmacht rechtsgültig gemäß den Artikeln 8.1 (ii) und 8.3 (ii) dieser Artikel übertragen worden.

(ii) Das Unternehmen wird gegenüber Dritten auch durch die Unterschrift einer/aller Person/en, der/denen vom Vorstand

spezielle Befugnisse übertragen worden sind, vertreten.

Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer.
9.1 Wenn die Gesellschaft von einem einzigen Geschäftsführer geführt wird, dann ist jede Bezugnahme in der Satzung

auf den Vorstand oder auf die Geschäftsführer als Bezugnahme auf diesen alleinigen Geschäftsführer zu lesen, soweit
angemessen.

9.2. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers gebunden.
9.3. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten auch durch die Unterschrift einer/aller Person/en, der/denen spezielle

Befugnisse übertragen worden sind, gebunden.

Art. 10. Haftung der Geschäftsführer und Entschädigung.
10.1. Die Geschäftsführer können nicht, aufgrund ihres Mandats, persönlich haftbar gemacht werden für von ihnen

rechtmäßig im Namen des Unternehmens eingegangene Verpflichtungen, vorausgesetzt, dass diese Verpflichtungen den
Statuten und dem Gesetz entsprechen.

10.2. Gemäß Artikel 10.3, aber unbeschadet der Entschädigung auf die ein jeweiliger Geschäftsführer anderweitig ein

Anrecht hat:

(a) Ist jeder betroffene Geschäftsführer aus dem Vermögen der Gesellschaft schadlos zu halten für alle Kosten, Gebühren,

Verluste, Ausgaben und Haftungen, die ihm als jeweiliger Geschäftsführe entstehen in der tatsächlichen oder behaupteten
Wahrnehmung bzw. Erfüllung seiner Pflichten, oder in Bezug auf diese, und einschließlich (in jedem Fall) einer Haftung,
die ihm bei der Verteidigung in einem Zivil- oder Strafverfahren entsteht, in dem zu seinen Gunsten entschieden wird oder
in dem er freigesprochen wird oder wenn das Verfahren anderweitig beendet wird, ohne dass eine wesentliche Pflichtver-
letzung seinerseits festgestellt wird, oder in Verbindung mit einem Antrag, in dem das Gericht ihm in seiner Eigenschaft
als jeweiliger Geschäftsführer die Haftungsfreistellung für Fahrlässigkeit, Verzug, Pflichtverletzung oder Vertrauensbruch
in Bezug auf die Geschäfte des Unternehmens (oder eines verbundenen Unternehmens) gewährt hat; und

(b) die Gesellschaft kann jedem betroffenem Geschäftsführer Geldmittel zur Verfügung stellen, um ihm entstandene

oder noch entstehende Ausgaben in Zusammenhang mit Verfahren oder einem Antrag, auf den in Artikel 10.2(a) Bezug
genommen wird, zu bestreiten, und kann alle Schritte ergreifen, um einen den jeweiligen Geschäftsführer in die Lage zu
versetzen, zu vermeiden, dass ihm solche Ausgaben entstehen.

10.3. Dieser Artikel autorisiert keine Entschädigung, die nach den Bestimmungen des anwendbaren Rechts verboten

oder unwirksam ist; die vorstehenden Ausführungen gelten insbesondere im Hinblick auf die Beschränkungen des KAGB,
die auf das Unternehmen anwendbar sind.

10.4. Die Geschäftsführer können entscheiden, eine Versicherung auf Kosten des Unternehmens zum Nutzen jedes

jeweiligen Geschäftsführers abzuschließen und aufrechtzuerhalten in Bezug auf Verluste oder Haftungen, die einem be-
troffenen Geschäftsführer bereits entstanden sind oder noch entstehen werden, in Zusammenhang mit den Pflichten oder
Befugnissen der Gesellschaft und jedes verbundenen Unternehmens.

10.5. In diesem Artikel:
(a) gelten Gesellschaften als verbunden, wenn eines ein Tochterunternehmen des anderen oder beide Tochterunterneh-

men derselben juristischen Person sind; und

(b) der Begriff „Geschäftsführer“ bezeichnet einen Geschäftsführer oder De-facto-Geschäftsführer (oder ehemaligen

Geschäftsführer oder andere De-facto-Geschäftsführer) des Unternehmens oder eines verbundenen Unternehmens.

IV. Gesellschafter

Art. 11. Generalversammlung der Gesellschafter und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter.
11.1. Befugnisse und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden bei einer Generalversammlung der Gesellschafter (die „Generalversammlung“)

oder im Wege von Umlaufbeschlüssen (die „Umlaufbeschlüsse der Mitglieder“) falls die Anzahl der Gesellschafter der
Gesellschaft weniger oder gleich fünfundzwanzig (25) ist, angenommen.

(ii) Wenn Beschlüsse im Wege von Umlaufbeschlüssen der Gesellschaft anzunehmen sind, wird der Text der Beschlüsse

in Übereinstimmung mit der Satzung an alle Gesellschafter gesendet. In solch einem Fall gibt jeder Gesellschafter Mitglied
seine  Stimme  schriftlich  ab.  Wenn  die  Beschlüsse  angenommen  sind,  dann  sind  Umlaufbeschlüsse  der  Gesellschafter

81520

L

U X E M B O U R G

rechtsgültig und verbindlich, so als ob sie bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Generalversammlung
angenommen worden wären, und sie tragen das Datum der letzten Unterschrift.

(iii) Jeder Anteil berechtigt zu einer (1) Stimme.
11.2. Einberufungen, Beschlussfähigkeit, Mehrheit und Abstimmungsverfahren
(i)  Die  Gesellschafter  werden  zu  Generalversammlungen  einberufen  oder  schriftlich  konsultiert  auf  Initiative  eines

Geschäftsführers oder Gesellschafters, der mehr als eine Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals vertritt.

(ii) Eine schriftliche Einberufung jeder Generalversammlung wird an alle Gesellschafter mindestens acht (8) Kalen-

dertage vor dem Versammlungsdatum verschickt, ausgenommen in Notfällen, deren Art und Umstände in der Einberufung
der Sitzung festgelegt sind.

(iii) Generalversammlungen werden an den Orten und zu den Zeiten abgehalten, die in den Einberufungen spezifiziert

sind.

(iv) Wenn alle Gesellschafter zugegen oder vertreten sind und sich als ordnungsgemäß geladen und über die Tagesord-

nung  der  Versammlung  informiert  erachten,  kann  die  Generalversammlung  ohne  vorherige  Einberufung  abgehalten
werden.

(v) Ein Mitglied kann einer anderen Person eine Vollmacht geben, unabhängig davon, ob diese Person ein Gesellschafter

ist oder nicht, um sich bei einer Generalversammlung vertreten zu lassen.

(vi) Beschlüsse, die auf Generalversammlungen oder im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter anzunehmen

sind, werden von Gesellschaftern verabschiedet, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals besitzen. Wenn
diese Mehrheit bei der ersten Generalversammlung oder der ersten schriftlichen Konsultation nicht erreicht wird, werden
die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Generalversammlung einberufen oder ein zweites Mal konsultiert,
und die Beschlüsse werden bei der Generalversammlung oder durch Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter von der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen verabschiedet, unabhängig vom Anteil des Gesellschaftskapitals, den diese vertreten.

(vii) Die Satzung wird geändert mit der Zustimmung einer (zahlenmäßigen) Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens

dreiviertel (3/4) des Gesellschaftskapitals besitzen. Änderungen der Satzung der Gesellschaft bedürfen der Genehmigung
des Verwahrers.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters der

Gesellschaft erfordern die Einstimmigkeit der Gesellschafter.

Art. 12. Alleiniger Gesellschafter.
12.1. Wenn die Anzahl der Gesellschafter auf eins (1) reduziert ist, übt der alleinige Gesellschafter alle Befugnisse aus,

die ihm per Gesetz durch die Generalversammlung eingeräumt wurden.

12.2. Jede Bezugnahme in der Satzung auf die Gesellschafter und die Generalversammlung oder auf Umlaufbeschlüsse

der Gesellschafter ist als Bezugnahme auf diesen alleinigen Gesellschafter oder die Beschlüsse des zuletzt genannten zu
lesen, soweit angebracht.

12.3. (vi) Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafter werden in Protokollen aufgezeichnet oder schriftlich abgefasst.

V. Jahresabschlüsse - Zuweisung von Gewinnen - Überwachung

Art. 13. Finanzjahr und Genehmigung von Jahresabschlüssen.
13.1. Das Finanzjahr beginnt am ersten (1.) Juli jeden Jahres und endet am dreißigsten (30.) Juni des Folgejahres.
13.2. Der Vorstand erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar, das den Wert

der Aktiva und Passiva der Gesellschaft angibt, mit einem Anhang, der die Verpflichtungen des Unternehmens und die
Schulden des/der Geschäftsführer/s und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

13.3. Jeder Gesellschafter darf das Inventar und die Bilanz am eingetragenen Sitz überprüfen.
13.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden bei der jährlichen Generalversammlung oder im Wege

des Umlaufbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Ende des Finanzjahrs genehmigt.

13.5. Falls die Anzahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) übersteigt, ist die jährliche Generalver-

sammlung jedes Jahr am dritten Dienstag im Juni um 15:00 Uhr am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abzuhalten. Falls
dieser kein Tag sein sollte, an dem Banken für den allgemeinen Geschäftsverkehr in der Stadt Luxemburg geöffnet sind
(d.h. ein „Werktag“), dann ist diese am darauf folgenden Geschäftstag zur selben Zeit und am selben Ort abzuhalten.

Art. 14. Abschlussprüfer - unabhängige/r Wirtschaftsprüfer.
14.1. Falls die Anzahl der Mitglieder der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) übersteigt, ist die Überwachung der Ge-

sellschaft einem oder mehreren Abschlussprüfer(n) (commissaire(s)) anzuvertrauen, welche(r) Gesellschafter sein können
aber nicht müssen.

14.2. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird von einem oder mehreren unabhängigen Wirtschaftsprüfer(n) (révi-

seur(s) d'entreprises) überwacht, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

14.3. Die Gesellschafter ernennen den Abschlussprüfer (commissaire), falls anwendbar und den unabhängigen Wirt-

schaftsprüfer (réviseur d'entreprises), falls anwendbar, und bestimmen deren Anzahl, Entlohnung und die Amtsdauer, die

81521

L

U X E M B O U R G

sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf. Der Abschlussprüfer (commissaire) und der unabhängige Wirtschaftsprüfer (ré-
viseur d'entreprises) können wieder ernannt werden.

14.4. Die Gesellschaft Unternehmen stellt HANSAINVEST und dem Verwahrer monatliche Vermögensaufstellungen

zur Verfügung, die den in § 249 Abs. 2 und 3 KAGB definierten Anforderungen entsprechen. Die Aktionäre erhalten
jährliche Jahresabschlüsse an jedem Abschlussstichtag. Der Jahresabschluss ist von einem Wirtschaftsprüfer zu überprüfen
und mit einem Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers zu versehen.

Art. 15. Zuweisung von Gewinnen.
15.1. Aus den jährlichen Nettogewinnen der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgeschriebenen

Rückstellung zugeführt. Diese Zuweisung ist nicht länger erforderlich, wenn die gesetzlichen Rücklagen einen Betrag
erreichen, der zehn Prozent (10%) des Stammkapitals entspricht.

15.2. Die Gesellschafter entscheiden, wie über den Saldo der Jahresnettogewinne verfügt wird. Sie können diesen der

Auszahlung von Dividenden zuweisen, ihn auf ein Rücklagenkonto überweisen oder ihn vortragen.

Alle Ausschüttungen sind in der folgenden Reihenfolge vorzunehmen:
- die Halter von Klasse-A-Anteilen sind berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma

Sechzig Prozent (0,60%) des Nennwerts der Klasse-A-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,

- sind die Halter von Klasse-B-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma

Fünfundfünfzig Prozent (0,55%) des Nennwerts der Klasse-B-Anteile, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,

- sind die Halter von Klasse-C-Anteile berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma

fünfzig Prozent (0,50%) des Nennwerts der Klasse-C-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,

- sind die Halter von Klasse-D-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma

Fünfundvierzig Prozent (0,45%) des Nennwerts der Klasse-D-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,

- sind die Halter von Klasse-E-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma

Vierzig Prozent (0,40%) des Nennwerts der Klasse-E-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,

- sind die Halter von Klasse-F-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma

Fünfunddreißig Prozent (0,35%) des Nennwerts der Klasse-F-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,

- sind die Halter von Klasse-G-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma

Dreißig Prozent (0,30%) des Nennwerts der Klasse-G-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,

- sind die Halter von Klasse-H-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma

Fünfundzwanzig Prozent (0,25%) des Nennwerts der Klasse-H-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,

- sind die Halter von Klasse-I-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma

Zwanzig Prozent (0,20%) des Nennwerts der Klasse-I-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,

- Ist der Saldo des gesamten ausgeschütteten Betrags in der Gesamtheit den Haltern der letzten Klasse in der umgekehrten

alphabetischen Reihenfolge zuzuweisen (d.h. zuerst Klasse-J-Anteile, dann, wenn keine Klasse-J-Anteile vorhanden sind,
Klasse-I-Anteile und so weiter bis nur noch Klasse-A-Anteile vorhanden sind).

Sollte die ganze letzte ausstehende Anteilsklasse zum Zeitpunkt der Ausschüttung (nach umgekehrter alphabetischer

Reihenfolge, z.B. Klasse-J-Anteile) infolge von Rücknahme annulliert, zurückgekauft oder anderweitig aufgehoben wor-
den sein, dann wird der Rest einer Dividendenausschüttung der vorangegangenen letzten ausstehenden Anteilsklasse in
umgekehrter alphabetischer Reihenfolge (z.B. Klasse-I-Anteile wenn Klasse-J-Anteile annulliert worden sind), zugewie-
sen.

15.3. Zwischendividenden können jederzeit unter den folgenden Voraussetzungen ausgeschüttet werden:
(i) Der Vorstand erstellt Zwischenabschlüsse;
(ii)  diese  Zwischenabschlüsse  weisen  aus,  dass  ausreichend  Gewinne  und  andere  verfügbare  Rückstellungen  (ein-

schließlich Agio) für die Ausschüttung verfügbar sind; und

(iii) die Entscheidung, Zwischendividenden auszuschütten muss vom Vorstand innerhalb von zwei (2) Monaten nach

dem Datum der Zwischenabschlüsse getroffen werden.

VI. Auflösung - Liquidation

Art. 16.
16.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss von Gesellschaftern aufgelöst werden, wenn der Beschluss

von einer Hälfte (1/2) der Gesellschafter, die dreiviertel (3/4) des Gesellschaftskapitals halten, angenommen wird. Die
Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Liquidatoren, die nicht Gesellschafter sein müssen, um die Liquidation ab-
zuwickeln und bestimmen deren Anzahl, Befugnisse und die Entlohnung. Wenn von den Gesellschaftern nichts anderes
entschieden wird, haben die Liquidatoren die weitest gehenden Befugnisse, die Aktiva zu verwerten und die Verbindlich-
keiten der Gesellschaft zu bezahlen.

16.2. Nach Bezahlung aller Schulden und aller Belastungen der Gesellschaft und der Kosten der Liquidation, werden

die Netto-Liquidationsgewinne an die Gesellschafter ausgeschüttet in Übereinstimmung mit den Ausschüttungsregeln um
wirtschaftlich betrachtet dasselbe Resultat wie die Ausschüttungsregeln, die für die Ausschüttung von Dividenden festge-
legt worden sind, zu erreichen.

81522

L

U X E M B O U R G

VII. Allgemeine Bestimmungen

Art. 17.
17.1. Jegliche Mitteilungen und Kommunikationen oder deren Verzicht, die Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer

sowie die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter können schriftlich, per Fax, E-Mail über andere elektronischen Kommu-
nikationsmedien ergehen.

17.2. Vollmachten werden über eines der oben beschriebenen Kommunikationsmittel gewährt. Vollmachten in Zusam-

menhang mit Vorstandssitzungen können auch von einem Geschäftsführer in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen,
die der Vorstand annehmen kann, gewährt werden.

17.3. Unterschriften können handschriftlich oder in elektronischer Form erfolgen, vorausgesetzt, dass sie alle rechtlichen

Anforderungen erfüllen und als den handschriftlichen Unterschriften gleichwertig anerkannt werden. Unterschriften der
Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer oder der Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter, je nachdem wie der Fall liegt, werden
auf einem Original oder auf mehreren Gegenstücken desselben Dokuments angebracht, wobei alle zusammen ein und
dasselbe Dokument darstellen.

17.4. Alle Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich in der Satzung geregelt sind, werden per Gesetz bestimmt sowie den

Verträgen welche von den Gesellschaftern von Zeit zu Zeit eingegangen werden können, sofern diese nicht zwingendem
gesetzlichen Bestimmungen widersprechen.“

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase have been estimated at about one thousand two hundred Euro (€ 1,200).

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by his name, first name,

civil status and residence, the said proxyholder has signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le onze mars.
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, une société constituée selon les lois

allemandes, ayant son siège social à Kapstadtring 8, D-22297 Hambourg, Allemagne, rinscrite au Registre de Commerce
B du District Court de Hambourg (Registre de Commerce B du Tribunal de Hambourg) sous le numéro HRB 12891, agissant
pour le compte de Best Value Europe I, une Open Ended Real Estate Spezial-AIF allemande constituée suivant la loi
allemande (l'“Associé Unique”);

ici représentée par Monsieur Gérald STEVENS, avocat, demeurant professionnellement au 3b, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle partie comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire de:
III. constater que HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung est l'Associé Uni-

que de Rue de la Paix 15 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 1, rue Isaac Newton, L-2242
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 200.742, constituée suivant acte reçu par
Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains en date du 6 octobre 2015, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (la “Société”);

IV. enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, suivant l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Transfert du siège social de la Société au 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange et modification subséquente de l'article 2.1

des statuts de la Société, comme suit:

“The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the “Board”). The registered office
may  be  transferred  to  any  other  place  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  by  a  resolution  of  the  members,  acting  in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles”.

81523

L

U X E M B O U R G

2. Suppression de l'article 3.3. des statuts de la Société et renumérotation subséquente des articles 3.4, 3.5 and 3.6 des

statuts de la Société;

3. Modification de l'article 8.2.vi des statuts de la Société comme suit:
“The Board shall elect a chairman among its members and as the case may be, a secretary for each meeting. The secretary,

or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board of managers, which
shall be signed by the chairman and by the secretary or, if no secretary was appointed, by the chairman and one manager.
The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions. Any copy and excerpt of
any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by
the chairman and by the secretary or a by manager in case no secretary was appointed, or by the sole manager, as the case
may be”;

4. Modification des articles 5, dernier paragraphe, 15.2 et 16.2 des statuts de la Société comme suit:

Art. 5. Last paragraph, definition of “Units”. ““Units” means each share of the Company, having a par value of ten Euro

(EUR 10) each”.

Art. 15.2. “The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

All the distributions shall be made in accordance with the following order:
- the holders of class A Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point sixty per cent (0.60%) of the par value of the class A Units held by them, then,

- the holders of class B Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the par value of the class B Units held by them, then,

- the holders of class C Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point fifty per cent (0.50%) of the par value of the class C Units held by them, then,

- the holders of class D Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point forty-five per cent (0.45%) of the par value of the class D Units held by them, then,

- the holders of class E Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point forty per cent (0.40%) of the par value of the class E Units held by them, then,

- the holders of class F Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the par value of the class F Units held by them, then,

- the holders of class G Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point thirty per cent (0.30%) of the par value of the class G Units held by them, then,

- the holders of class H Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the par value of the class H Units held by them, then,

- the holders of class I Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of

zero point twenty per cent (0.20%) of the par value of the class I Units held by them, then,

- the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class in the reverse

alphabetical order (i.e. first Class J units, then if no Class J units are in existence, Class I units and in such continuation
until only Class A units are in existence).

Should the whole last outstanding class of Units (by reverse alphabetical order, e.g. Class J Units) have been cancelled

following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution
shall then be allocated to the preceding last outstanding class of Units in the reverse alphabetical order (e.g. Class I Shares
if Class J Units has been cancelled)”.

Art. 16.2. “After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the

net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate
basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions”.

5. Refonte des statuts de la Société afin de remplacer la version française par une version allemande; et
6. Divers.

<i>Première résolution

L'Associée Unique décide de transférer le siège social de la Société au 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange et de modifier

en conséquence l'article 2.1. des statuts de la Société comme suit:

“The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the “Board”). The registered office
may  be  transferred  to  any  other  place  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  by  a  resolution  of  the  members,  acting  in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles”.

81524

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'Associée Unique décide de supprimer l'article 3.3. des statuts de la Société et de renuméroter de façon subséquente

les articles 3.4, 3.5 and 3.6 en articles 3.3, 3.4 and 3.5 des statuts de la Société.

<i>Troisième résolution

L'Associée Unique décide de modifier l'article 8.2.vi des statuts de la Société comme suit:
“The Board shall elect a chairman among its members and as the case may be, a secretary for each meeting. The secretary,

or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board of managers, which
shall be signed by the chairman and by the secretary or, if no secretary was appointed, by the chairman and one manager.
The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions. Any copy and excerpt of
any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by
the chairman and by the secretary or a by manager in case no secretary was appointed, or by the sole manager, as the case
may be”.

<i>Fourth resolution

L'Associée Unique décide de modifier les articles 5, dernier alinéa, 15.2 et 16.2 des statuts de la Société comme suit:

Art. 5. Last paragraph, definition of “Units”. ““Units” means each share of the Company, having a par value of ten Euro

(EUR 10) each”.

Art. 15.2. “The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

All the distributions shall be made in accordance with the following order:
- the holders of class A Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point sixty per cent (0.60%) of the par value of the class A Units held by them, then,

- the holders of class B Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the par value of the class B Units held by them, then,

- the holders of class C Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point fifty per cent (0.50%) of the par value of the class C Units held by them, then,

- the holders of class D Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point forty-five per cent (0.45%) of the par value of the class D Units held by them, then,

- the holders of class E Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point forty per cent (0.40%) of the par value of the class E Units held by them, then,

- the holders of class F Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the par value of the class F Units held by them, then,

- the holders of class G Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point thirty per cent (0.30%) of the par value of the class G Units held by them, then,

- the holders of class H Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the par value of the class H Units held by them, then,

- the holders of class I Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of

zero point twenty per cent (0.20%) of the par value of the class I Units held by them, then,

- the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class in the reverse

alphabetical order (i.e. first Class J units, then if no Class J units are in existence, Class I units and in such continuation
until only Class A units are in existence).

Should the whole last outstanding class of Units (by reverse alphabetical order, e.g. Class J Units) have been cancelled

following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution
shall then be allocated to the preceding last outstanding class of Units in the reverse alphabetical order (e.g. Class I Shares
if Class J Units has been cancelled)”.

Art. 16.2. “After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the

net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate
basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions”.

<i>Cinquième résolution

L'Associée Unique décide, en conséquence de la résolution qui précède de remplacer la version française des statuts de

la Société par une version allemande comme suit:

I. Name - Eingetragener Sitz - Gegenstand - Dauer

Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist „Rue de la Paix 15 S.à r.l.“ (das „Ge-

sellschaft“). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) (société à responsabilité limitée), die

81525

L

U X E M B O U R G

den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz“) und dieser Satzung (die „Satzung“) unterliegt.

Art. 2. Eingetragener Sitz.
2.1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft liegt in der Gemeinde Bertrange, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann

innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Vorstands (der „Vorstand“) verlegt werden. Der eingetragene Sitz
kann an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg durch einen Beschluss der Gesellschafter, die im Einklang mit
den für die Änderung der Satzung vorgeschriebenen Vorschriften handeln, verlegt werden.

2.2. Zweigstellen, Tochtergesellschaften oder andere Büros können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland

durch Beschluss des Vorstands gegründet werden. Wenn der Vorstand feststellt, dass außergewöhnliche politische oder
militärische Entwicklungen oder Vorfälle eingetreten sind oder bevorstehen, und dass diese Entwicklungen oder Vorfälle
die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die gewöhnliche Kommunikation zwischen
solch einem Büro und Personen im Ausland stören könnten, kann der eingetragene Sitz zeitweilig bis zur vollständigen
Beendigung dieser Umstände ins Ausland verlegt werden. Diese zeitweiligen Maßnahmen haben keine Auswirkung auf
die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet der temporären Verlegung ihres eingetragenen Sitzes eine in Luxemburg
eingetragene Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1.  Die  Gesellschaft  ist  eine  Immobiliengesellschaft  gemäß  §§  234  ff.  des  deutschen  Kapitalanlagegesetzbuches

(KAGB) und unterliegt daher den Bestimmungen des KAGB. Der Gesellschaftszweck ist beschränkt auf diejenigen Ak-
tivitäten,  welche  die  HANSAINVEST  Hanseatische  Investment-Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  („HANSAIN-
VEST“)  im  Namen  des  alternativen  Investmentfonds  mit  feststehenden  Investitionsregeln  mit  Schwerpunkt  auf
Immobilienvermögen mit dem Namen „Best Value Europe I“ („der Fonds“) ausüben darf.

Der Gesellschaftszweck besteht daher im Erwerb, Halten, in der Verwaltung und Veräußerung von Immobilien, die von

der HANSAINVEST auf Rechnung des Fonds gemäß §§ 231 ff. KAGB sowie gemäß den Investmentregeln des Fonds
erworben werden können, und im Erwerb, Halten, in der Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Immobiliengesellschaften gemäß §§ 234 ff. KAGB, deren Ziel auf diejenigen Aktivitäten beschränkt ist, welche die HAN-
SAINVEST  im  Namen  des  Fonds  gemäß  dem  deutschen  Kapitalanlagegesetzbuch  (KAGB)  sowie  den  anwendbaren
Investitionsregeln des Fonds ausführen darf.

3.2. Die Gesellschaft kann in Übereinstimmung mit § 235 Abs. 1 Nr. 2 und § 231 Abs. 3 KAGB Waren erwerben, die

für die Verwaltung ihres Gesellschaftsvermögens benötigt werden. Der Erwerb von Immobilienvermögen ist nur gestattet,
wenn die Beteiligung an Immobilienvermögen zuvor von (einem) kompetenten Sachverständigen, der von HANSAIN-
VEST benannt wurde, bewertet wurde. Der Erwerb einer Beteiligung an einer Immobiliengesellschaft ist des Weiteren nur
gestattet, wenn die Beteiligung zuvor von einem Wirtschaftsprüfer gemäß 319 Abs. 1 des deutschen Handelsgesetzbuchs
(HGB) bewertet wurde.

3.3. Die Gesellschaft kann, innerhalb der Beschränkungen des KAGB, in jedweder Form Geld leihen, mit Ausnahme

eines öffentlichen Kaufangebots. Den Beschränkungen des KAGB unterliegend, kann sie nur im Wege einer Privatplat-
zierung Schuldscheine, Obligationen, Pfandbriefe und jede Art von Schulden bzw. Beteiligungspapiere herausgeben. Den
Beschränkungen des KAGB unterliegend, kann die Gesellschaft Beteiligungen an Krediten erwerben bzw. Gelder verleihen
einschließlich der Erlöse von Anleihen bzw. Herausgabe von Schuldverschreibungen an ihre Tochterunternehmen, ver-
bundene  Unternehmen  oder  an  jedes  andere  Unternehmen,  das  einen  Teil  der  Unternehmensgruppe  bildet,  zu  der  die
Gesellschaft gehört. Den Beschränkungen des KAGB unterliegend, ist es der Gesellschaft gestattet, Kredite aufzunehmen
und zu halten sowie Wertpapiere als Sicherheiten (auch in der Form eines Sicherheitenrechts oder einer Grundstückslast)
zum beabsichtigten Erwerb von Vermögenswerten zu verwenden.

3.4. Die Gesellschaft kann jegliche Techniken und Instrumente in Bezug auf seine Investitionen zum Zweck von deren

effizienten Verwaltung einsetzen, einschließlich Techniken und Instrumente, die ausgelegt sind, die Gesellschaft gegen
Risiken, wie z.B. Kreditrisiken, Währungsumtausch, Zinsrisiko und andere Risiken zu schützen.

3.5. Die Gesellschaft kann alle Geschäftstransaktionen durchführen und alle Maßnahmen ergreifen, die im Hinblick auf

das Erreichen des oben detailliert beschriebenen Zwecks erforderlich sind, insofern diese gemäß KAGB und den anwend-
baren Investitionsregeln des Fonds gestattet sind.

Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Zeit gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund von Tod, Außerkraftsetzung der bürgerlichen Rechte, Unfähigkeit, Insolvenz,

Bankrott oder ähnlichen Anlässen, die einen oder mehrere Gesellschafter betreffen, aufgelöst.

II. Gesellschaftskapital - Gesellschaftsanteile

Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft wird auf vierzehntausendvierhundert Euro (14.400 Euro) festgesetzt, vertreten

durch:

- Eintausendzweihundertsechzig (1.260) Klasse-A-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-A-Anteile“);

81526

L

U X E M B O U R G

- Zwanzig (20) Klasse-B-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-B-Anteile“);
- Zwanzig (20) Klasse-C-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-C-Anteile“);
- Zwanzig (20) Klasse-D-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-D-Anteile“);
- Zwanzig (20) Klasse-E-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-E-Anteile“);
- Zwanzig (20) Klasse-F-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-F-Anteile“);
- Zwanzig (20) Klasse-G- Gesellschaftsanteile (die „Klasse-G-Anteile“);
- Zwanzig (20) Klasse-H-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-H-Anteile“);
- Zwanzig (20) Klasse-I-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-I-Anteile“);
- Zwanzig (20) Klasse-J-Gesellschaftsanteile (die „Klasse-J-Anteile“);
wobei alle einen Nennwert von zehn Euro (10 Euro) pro Stück haben und jeweils gezeichnet und voll eingezahlt sind.
5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann ein oder mehrere Male durch einen Beschluss der Gesellschafter, die im

Einklang mit den für die Änderung der Satzung vorgeschriebenen Bedingungen handeln, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.2.1. Das Stammkapital der Gesellschaft kann durch den Rückkauf oder die Annullierung von Anteilen reduziert wer-

den, vorausgesetzt, dass diese Annullierung die Gesamtheit der herausgegebenen Anteile in einer oder mehreren Klassen
der Einheiten betrifft. Solche Rückkäufe oder Annullierungen von Anteilsklassen sind in umgekehrter alphabetischer Rei-
henfolge vorzunehmen (beginnend mit den Klasse-J-Anteilen).

Im Fall einer Herabsetzung des Stammkapitals durch den Rückkauf und die Annullierung einer Anteilsklasse erhalten

die Halter der zurückgekauften und annullierten Anteilsklassen von der Gesellschaft den Betrag, der dem Annullierungs-
wert pro Anteil für jeden Anteil der relevanten Klasse, die von ihnen gehalten wird und die zurückgekauft und annulliert
wurden, entspricht.

5.2.2. Der Annullierungswert pro Anteil ist durch Division des Gesamtannullierungsbetrags durch die Anzahl der in der

Anteilsklasse, die zurückgekauft und annulliert wird, enthaltenen Anteile zu ermitteln.

5.2.3. Der Gesamtannullierungsbetrag ist der Betrag, der vom Vorstand auf Basis der relevanten Zwischenabschlüsse

festgelegt und von den Gesellschaftern genehmigt wird. Der Gesamtannullierungsbetrag ist der verfügbare Betrag der
relevanten Anteilsklasse zum Zeitpunkt der Annullierung der relevanten Anteilsklassen, soweit die Generalversammlung,
die im Einklang mit den für die Satzungsänderung vorgeschriebenen Bestimmungen handelt, nichts anderes beschlossen
hat. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass der Gesamtannullierungsbetrag niemals höher sein darf als der verfügbare
Betrag.

5.2.4. Nach dem Rückkauf und der Annullierung der Anteile der betreffenden Anteilsklasse wird der Annullierungswert

pro Anteil fällig und ist von der Gesellschaft zu zahlen.

5.3. Zusätzlich zum Stammkapital kann eine Einzahlung auf das Agio getätigt werden, auf das jegliche Agiozahlung

für jeglichen Anteil angerechnet wird. Der Betrag des besagten Agios steht, je nach Situation, den Gesellschaftern oder
dem Vorstand zur freien Verfügung.

Für die Zwecke dieses Artikels 5 werden die nachstehenden Wörter wie folgt definiert:
- „Verfügbarer Betrag“ bezeichnet (ohne Doppelzählung) den Betrag der Nettogewinne, die einer Anteilsklasse der

Gesellschaft (einschließlich Gewinnvorträge) zugeordnet werden kann, insofern die Gesellschafter, die Anteile von der
besagten Anteilsklasse halten, einen Anspruch auf Dividendenausschüttung haben, zuzüglicher (i) aller frei ausschüttbarer
Reserven (zur Klarstellung: dazu zählt auch die Agiorücklage) und (ii) gegebenenfalls des Betrags der Stammkapitalhe-
rabsetzung und der Minderung der gesetzlichen Rücklagen, die sich auf die Anteilsklasse bezieht, die annulliert wird, sofern
diese Herabsetzung den gesetzlich verfügbaren Beträgen entspricht, abzüglich (i) aller Verluste (einschließlich Verlust-
vorträge)  und  (ii)  aller  Summen,  die  gemäß  den  gesetzlichen  Anforderungen  oder  gemäß  Satzung  in  die  Rücklage(n)
eingestellt werden müssen, jedes Mal wie in den relevanten Zwischenkonten ausgewiesen (zur Klarstellung: ohne Dop-
pelzählung) so dass:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR)
Wodurch:
AA = Verfügbarer Betrag;
NP = Nettogewinn, der der Anteilsklasse zuzurechnen ist (einschließlich Gewinnvorträge gemäß Festlegung für die

relevante Anteilsklasse);

P = alle frei ausschüttbaren Reserven;
CR = der Betrag der Herabsetzung des Stammkapitals und der Herabsetzung der gesetzlichen Reserve in Bezug auf die

zu annullierende Anteilsklasse soweit das den gesetzlich verfügbaren Beträgen entspricht;

L= Verluste (einschließlich Verlustvorträge);
LR = alle Summen, die gemäß den Anforderungen des Gesetzes oder der Satzung in die Rücklage(n) einzustellen sind.
- „Annullierungsbetrag pro Anteil“ bezeichnet den Annullierungsbetrag pro Anteil, der an einen Gesellschafter einer

zurückgekauften und annullierten Anteil zu zahlen ist.

- „Zwischenkonten“ bezeichnet die Zwischenkonten der Gesellschaft zum Datum des relevanten Zwischenabschlusses.

81527

L

U X E M B O U R G

- „Datum des Zwischenabschlusses“ bezeichnet das Datum, frühestens acht (8) Tage vor dem Datum des Rückkaufs

und der Annullierung der relevanten Anteilsklassen.

- „Gesamtannullierungsbetrag“ bezeichnet den als Rückkaufpreis für alle Anteile einer Anteilsklasse, die zurückgekauft

und annulliert werden sollen, zu zahlenden Gesamtbetrag.

- „Anteile“ bezeichnet jeden Anteil des Unternehmens, der einen Nennwert von zehn Euro (10 Euro) pro Stück hat.“

Art. 6. Gesellschaftsanteile.
6.1. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Eigentümer pro Gesellschaftsanteil

an. Im Fall des gemeinsamen Eigentums eines oder mehrerer Gesellschaftsanteils(e), müssen die Gesellschafter einen (1)
Eigentümer pro Gesellschaftsanteil benennen.

6.2. Gesellschaftsanteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar.
Wenn die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, sind die Gesellschaftsanteile frei auf Dritte übertragbar.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat, bedarf die Übertragung von Gesellschaftsanteilen (unter Leb-

enden)  an  Dritte  der  vorherigen  Genehmigung  der  Gesellschafter,  die  mindestens  dreiviertel  (3/4)  des  Stammkapitals
repräsentieren.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte von Todes wegen muss von den Gesellschaftern, die mindestens

dreiviertel (3/4) der Rechte, die im Besitz der Hinterbliebenen sind, repräsentieren, genehmigt werden.

Die Übertragung eines Gesellschaftsanteils ist der Gesellschaft oder Dritten gegenüber nur entgegenzuhalten innerhalb

der Beschränkungen der Klausel 6.5 und sofern eine Zustellung an die Gesellschaft oder die Genehmigung der Gesellschaft
in Einklang mit Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuchs erfolgt ist.

6.3. Ein Gesellschafterregister wird am eingetragenen Sitz aufbewahrt und kann von jedem Mitglied auf Nachfrage

eingesehen werden.

6.4. Die Gesellschaft darf ihre eigenen Anteile zurückkaufen, vorausgesetzt dass die Gesellschaft ausreichend aus-

schüttbare Rückstellungen für diesen Zweck zur Verfügung hat oder wenn die Rücknahme aus einer Herabsetzung des
Stammkapitals der Gesellschaft resultiert.

6.5. Insofern und solange die Beteiligungen der HANSAINVEST auf Rechnung des Fonds gehalten werden, ist eine

Verfügung über Aktien (oder über einen Teil derselben), die der HANSAINVEST gehören, nur zulässig mit der vorherigen
Genehmigung des von HANSAINVEST gemäß §§ 80 ff. KAGB für den Fonds benannten Verwahrers (§ 84 Abs. 1 Z. 5
KAGB) (der „Verwahrer“). Dasselbe gilt für jede Belastung von Anteile, die Gewährung von Unter-Beteiligungen an einem
Anteil und die Verfügung über gesonderte Rechte und Forderungen aus dem Gesellschaftsverhältnis. Zusätzlich bedürfen
Verfügungen über das Vermögen der Gesellschaft der Genehmigung des Verwahrers.

III. Geschäftsführung - Vertretung

Art. 7. Ernennung und Entlassung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführer(n) geleitet, die durch einen Beschluss der Gesell-

schafter, welche deren Amtsdauer festlegen, ernannt werden. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter sein.

7.2. Die Geschäftsführer können durch einen Beschluss der Gesellschafter jederzeit entlassen werden (mit oder ohne

Grund).

Art. 8. Vorstand. Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt worden sind, dann bilden sie den Vorstand (den „Vorstand“).

Der/die  Gesellschafter  kann/können  entscheiden,  die  ernannten  Geschäftsführer  als  Kategorie-A-Geschäftsführer  (die
„Kategorie-A-Geschäftsführer“) und Kategorie-B-Geschäftsführer (die „Kategorie-B-Geschäftsführer“) zu qualifizieren.

8.1. Befugnisse des Vorstands
(i) Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich vom Gesetz oder gemäß Satzung für den/die Gesellschafter reserviert sind,

fallen unter die Zuständigkeit des Vorstands, der alle Befugnisse hat, alle Handlungen und Tätigkeiten, die mit den Ge-
sellschaftszweck in Einklang stehen, auszuführen und zu genehmigen.

(ii) Spezielle und begrenzte Befugnisse können für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Vertretern des

Vorstands übertragen werden.

(iii) Der Vorstand kann von Zeit zu Zeit seine Befugnisse für bestimmte Aufgaben an einen oder mehrere Ad-Hoc-

Vertreter, der/die kein/e Mitglied/er oder Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen, delegieren. Der Vorstand legt die
Befugnisse, Pflichten und Entlohnung (falls zutreffend) ihres/ihrer Vertreter/s, die Dauer des Vertretungszeitraums und
andere relevanten Bedingungen seiner/ihrer Vertretung fest.

8.2. Verfahren
(i) Der Vorstand trifft sich auf Anfrage eines Geschäftsführers, an dem in der Einberufung genannten Ort, der grund-

sätzlich im Großherzogtum Luxemburg liegt.

(ii) Eine schriftliche Mitteilung über jede Vorstandssitzung wird an alle Geschäftsführer mindestens vierundzwanzig

(24) Stunden im voraus an alle Geschäftsführer verschickt, ausgenommen in Notfällen, deren Art und Umstände in der
Einberufung der Besprechung dargelegt werden.

81528

L

U X E M B O U R G

(iii) Eine Einberufung ist nicht erforderlich, wenn alle Vorstandsmitglieder zugegen oder vertreten sind und wenn sie

erklären, dass sie vollständige Kenntnis der Tagesordnung der Besprechung haben. Auf eine Einberufung der Sitzung kann
auch von einem Geschäftsführer, entweder vor oder nach der Sitzung, verzichtet werden. Separate schriftliche Einberu-
fungen sind nicht erforderlich für Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten abgehalten werden, die in einem zuvor vom
Vorstand angenommenen Zeitplan angegeben sind.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Vorstandssitzungen

vertreten zu lassen.

(v) Der Vorstand kann nur beraten oder rechtskräftig handeln, wenn bei Vorstandssitzungen eine Mehrheit der Ge-

schäftsführer  anwesend  oder  vertreten  ist,  einschließlich  mindestens  eines  Kategorie-A-Geschäftsführers  und  eines
Kategorie-B-Geschäftsführers im Fall, dass das/die Gesellschafter die Geschäftsführer als Kategorie-A-Geschäftsführer
und Kategorie-B-Geschäftsführer qualifiziert hat/haben. Entscheidungen sind durch Mehrheitsbeschluss der bei einer Sit-
zung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer zu treffen, einschließlich der Stimme von mindestens einem Kategorie-
A-Geschäftsführer  und  der  Stimme  von  einem  Kategorie-B-Geschäftsführer  im  Fall,  dass  das/die  Gesellschafter  die
Geschäftsführer als Kategorie-A-Geschäftsführer und Kategorie-B-Geschäftsführer qualifiziert hat/haben.

(vi) Bei jeder Sitzung wählt der Vorstand einen Präsidenten aus seinen Mitgliedern, und gegebenfalls einen Sekretär.

Der Sekretär, oder wenn kein Sekretär ernannt wurde, der Präsident verfasst das Protokoll der Sitzung welches durch den
Präsidenten und den Sekretär oder, wenn kein Sekretär ernannt wurde, durch den Präsidenten und einen Geschäftsführer
unterzeichnet wird. Gegebenfalls werden die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters von ihn/ihr auch schriftlich verfasst
und unterzeichnet. Kopien und Auszüge von solchen Originalprotokollen die in Prozessverfahren oder an Dritte geliefert
werden müssen werden, wie es der Fall sein kann, vom Präsidenten und vom Sekretär oder von einem Geschäftsführer
falls kein Sekretär ernannt wurde, oder durch den alleinigen Gesellschafter unterzeichnet.

(vii) Jeder Geschäftsführer kann an einer Vorstandssitzung per Telefon oder Videokonferenz oder über ein anderes

Kommunikationsmedium teilnehmen, das allen an der Sitzung teilnehmenden Personen erlaubt, einander zu identifizieren,
zu hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme über diese Medien gilt als persönliche Teilnahme an einer ord-
nungsgemäß  einberufenen  und  abgehaltenen  Sitzung.  Die  Sitzung  wird  mit  dem  Datum  der  Abhaltung  datiert.  Die
Entscheidung wird mit dem Datum der Abhaltung der Sitzung wirksam. Das Protokoll wird von dem Geschäftsführer, der
über diese Medien an der Sitzung teilgenommen hat, später unterzeichnet.

(viii) Umlaufbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterschrieben sind (die „Umlaufbeschlüsse der Geschäfts-

führer“) sind gültig und verbindlich, als ob diese bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung
gefasst worden wären, und sie tragen das Datum der letzten Unterschrift.

8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers oder die gemeinsame

Unterschrift eines Kategorie-A-Geschäftsführers und eines Kategorie-B-Geschäftsführers der Gesellschaft vertreten, für
den Fall, dass der/die Gesellschafter die Geschäftsführer als Kategorie-A-Geschäftsführer und Kategorie-B-Geschäftsfüh-
rer qualifiziert hat/haben, oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift von jeder/allen Person/en, an die solch
eine Unterschriftsvollmacht rechtsgültig gemäß den Artikeln 8.1 (ii) und 8.3 (ii) dieser Artikel übertragen worden.

(ii) Das Unternehmen wird gegenüber Dritten auch durch die Unterschrift einer/aller Person/en, der/denen vom Vorstand

spezielle Befugnisse übertragen worden sind, vertreten.

Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer.
9.1 Wenn die Gesellschaft von einem einzigen Geschäftsführer geführt wird, dann ist jede Bezugnahme in der Satzung

auf den Vorstand oder auf die Geschäftsführer als Bezugnahme auf diesen alleinigen Geschäftsführer zu lesen, soweit
angemessen.

9.2. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers gebunden.
9.3. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten auch durch die Unterschrift einer/aller Person/en, der/denen spezielle

Befugnisse übertragen worden sind, gebunden.

Art. 10. Haftung der Geschäftsführer und Entschädigung.
10.1. Die Geschäftsführer können nicht, aufgrund ihres Mandats, persönlich haftbar gemacht werden für von ihnen

rechtmäßig im Namen des Unternehmens eingegangene Verpflichtungen, vorausgesetzt, dass diese Verpflichtungen den
Statuten und dem Gesetz entsprechen.

10.2. Gemäß Artikel 10.3, aber unbeschadet der Entschädigung auf die ein jeweiliger Geschäftsführer anderweitig ein

Anrecht hat:

(a) Ist jeder betroffene Geschäftsführer aus dem Vermögen der Gesellschaft schadlos zu halten für alle Kosten, Gebühren,

Verluste, Ausgaben und Haftungen, die ihm als jeweiliger Geschäftsführe entstehen in der tatsächlichen oder behaupteten
Wahrnehmung bzw. Erfüllung seiner Pflichten, oder in Bezug auf diese, und einschließlich (in jedem Fall) einer Haftung,
die ihm bei der Verteidigung in einem Zivil- oder Strafverfahren entsteht, in dem zu seinen Gunsten entschieden wird oder
in dem er freigesprochen wird oder wenn das Verfahren anderweitig beendet wird, ohne dass eine wesentliche Pflichtver-
letzung seinerseits festgestellt wird, oder in Verbindung mit einem Antrag, in dem das Gericht ihm in seiner Eigenschaft

81529

L

U X E M B O U R G

als jeweiliger Geschäftsführer die Haftungsfreistellung für Fahrlässigkeit, Verzug, Pflichtverletzung oder Vertrauensbruch
in Bezug auf die Geschäfte des Unternehmens (oder eines verbundenen Unternehmens) gewährt hat; und

(b) die Gesellschaft kann jedem betroffenem Geschäftsführer Geldmittel zur Verfügung stellen, um ihm entstandene

oder noch entstehende Ausgaben in Zusammenhang mit Verfahren oder einem Antrag, auf den in Artikel 10.2(a) Bezug
genommen wird, zu bestreiten, und kann alle Schritte ergreifen, um einen den jeweiligen Geschäftsführer in die Lage zu
versetzen, zu vermeiden, dass ihm solche Ausgaben entstehen.

10.3. Dieser Artikel autorisiert keine Entschädigung, die nach den Bestimmungen des anwendbaren Rechts verboten

oder unwirksam ist; die vorstehenden Ausführungen gelten insbesondere im Hinblick auf die Beschränkungen des KAGB,
die auf das Unternehmen anwendbar sind.

10.4. Die Geschäftsführer können entscheiden, eine Versicherung auf Kosten des Unternehmens zum Nutzen jedes

jeweiligen Geschäftsführers abzuschließen und aufrechtzuerhalten in Bezug auf Verluste oder Haftungen, die einem be-
troffenen Geschäftsführer bereits entstanden sind oder noch entstehen werden, in Zusammenhang mit den Pflichten oder
Befugnissen der Gesellschaft und jedes verbundenen Unternehmens.

10.5. In diesem Artikel:
(a) gelten Gesellschaften als verbunden, wenn eines ein Tochterunternehmen des anderen oder beide Tochterunterneh-

men derselben juristischen Person sind; und

(b) der Begriff „Geschäftsführer“ bezeichnet einen Geschäftsführer oder De-facto-Geschäftsführer (oder ehemaligen

Geschäftsführer oder andere De-facto Geschäftsführer) des Unternehmens oder eines verbundenen Unternehmens.

IV. Gesellschafter

Art. 11. Generalversammlung der Gesellschafter und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter.
11.1. Befugnisse und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden bei einer Generalversammlung der Gesellschafter (die „Generalversammlung“)

oder im Wege von Umlaufbeschlüssen (die „Umlaufbeschlüsse der Mitglieder“) falls die Anzahl der Gesellschafter der
Gesellschaft weniger oder gleich fünfundzwanzig (25) ist, angenommen.

(ii) Wenn Beschlüsse im Wege von Umlaufbeschlüssen der Gesellschaft anzunehmen sind, wird der Text der Beschlüsse

in Übereinstimmung mit der Satzung an alle Gesellschafter gesendet. In solch einem Fall gibt jeder Gesellschafter Mitglied
seine  Stimme  schriftlich  ab.  Wenn  die  Beschlüsse  angenommen  sind,  dann  sind  Umlaufbeschlüsse  der  Gesellschafter
rechtsgültig und verbindlich, so als ob sie bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Generalversammlung
angenommen worden wären, und sie tragen das Datum der letzten Unterschrift.

(iii) Jeder Anteil berechtigt zu einer (1) Stimme.
11.2. Einberufungen, Beschlussfähigkeit, Mehrheit und Abstimmungsverfahren
(i)  Die  Gesellschafter  werden  zu  Generalversammlungen  einberufen  oder  schriftlich  konsultiert  auf  Initiative  eines

Geschäftsführers oder Gesellschafters, der mehr als eine Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals vertritt.

(ii) Eine schriftliche Einberufung jeder Generalversammlung wird an alle Gesellschafter mindestens acht (8) Kalen-

dertage vor dem Versammlungsdatum verschickt, ausgenommen in Notfällen, deren Art und Umstände in der Einberufung
der Sitzung festgelegt sind.

(iii) Generalversammlungen werden an den Orten und zu den Zeiten abgehalten, die in den Einberufungen spezifiziert

sind.

(iv) Wenn alle Gesellschafter zugegen oder vertreten sind und sich als ordnungsgemäß geladen und über die Tagesord-

nung  der  Versammlung  informiert  erachten,  kann  die  Generalversammlung  ohne  vorherige  Einberufung  abgehalten
werden.

(v) Ein Mitglied kann einer anderen Person eine Vollmacht geben, unabhängig davon, ob diese Person ein Gesellschafter

ist oder nicht, um sich bei einer Generalversammlung vertreten zu lassen.

(vi) Beschlüsse, die auf Generalversammlungen oder im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter anzunehmen

sind, werden von Gesellschaftern verabschiedet, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals besitzen. Wenn
diese Mehrheit bei der ersten Generalversammlung oder der ersten schriftlichen Konsultation nicht erreicht wird, werden
die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Generalversammlung einberufen oder ein zweites Mal konsultiert,
und die Beschlüsse werden bei der Generalversammlung oder durch Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter von der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen verabschiedet, unabhängig vom Anteil des Gesellschaftskapitals, den diese vertreten.

(vii) Die Satzung wird geändert mit der Zustimmung einer (zahlenmäßigen) Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens

dreiviertel (3/4) des Gesellschaftskapitals besitzen. Änderungen der Satzung der Gesellschaft bedürfen der Genehmigung
des Verwahrers.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters der

Gesellschaft erfordern die Einstimmigkeit der Gesellschafter.

Art. 12. Alleiniger Gesellschafter.
12.1. Wenn die Anzahl der Gesellschafter auf eins (1) reduziert ist, übt der alleinige Gesellschafter alle Befugnisse aus,

die ihm per Gesetz durch die Generalversammlung eingeräumt wurden.

81530

L

U X E M B O U R G

12.2. Jede Bezugnahme in der Satzung auf die Gesellschafter und die Generalversammlung oder auf Umlaufbeschlüsse

der Gesellschafter ist als Bezugnahme auf diesen alleinigen Gesellschafter oder die Beschlüsse des zuletzt genannten zu
lesen, soweit angebracht.

12.3. (vi) Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafter werden in Protokollen aufgezeichnet oder schriftlich abgefasst.

V. Jahresabschlüsse - Zuweisung von Gewinnen - Überwachung

Art. 13. Finanzjahr und Genehmigung von Jahresabschlüssen.
13.1. Das Finanzjahr beginnt am ersten (1.) Juli jeden Jahres und endet am dreißigsten (30.) Juni des Folgejahres.
13.2. Der Vorstand erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar, das den Wert

der Aktiva und Passiva der Gesellschaft angibt, mit einem Anhang, der die Verpflichtungen des Unternehmens und die
Schulden des/der Geschäftsführer/s und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

13.3. Jeder Gesellschafter darf das Inventar und die Bilanz am eingetragenen Sitz überprüfen.
13.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden bei der jährlichen Generalversammlung oder im Wege

des Umlaufbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Ende des Finanzjahrs genehmigt.

13.5. Falls die Anzahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) übersteigt, ist die jährliche Generalver-

sammlung jedes Jahr am dritten Dienstag im Juni um 15:00 Uhr am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abzuhalten. Falls
dieser kein Tag sein sollte, an dem Banken für den allgemeinen Geschäftsverkehr in der Stadt Luxemburg geöffnet sind
(d.h. ein „Werktag“), dann ist diese am darauf folgenden Geschäftstag zur selben Zeit und am selben Ort abzuhalten.

Art. 14. Abschlussprüfer - unabhängige/r Wirtschaftsprüfer.
14.1. Falls die Anzahl der Mitglieder der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) übersteigt, ist die Überwachung der Ge-

sellschaft einem oder mehreren Abschlussprüfer(n) (commissaire(s)) anzuvertrauen, welche(r) Gesellschafter sein können
aber nicht müssen.

14.2. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird von einem oder mehreren unabhängigen Wirtschaftsprüfer(n) (révi-

seur(s) d'entreprises) überwacht, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

14.3. Die Gesellschafter ernennen den Abschlussprüfer (commissaire), falls anwendbar und den unabhängigen Wirt-

schaftsprüfer (réviseur d'entreprises), falls anwendbar, und bestimmen deren Anzahl, Entlohnung und die Amtsdauer, die
sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf. Der Abschlussprüfer (commissaire) und der unabhängige Wirtschaftsprüfer (ré-
viseur d'entreprises) können wieder ernannt werden.

14.4. Die Gesellschaft Unternehmen stellt HANSAINVEST und dem Verwahrer monatliche Vermögensaufstellungen

zur Verfügung, die den in § 249 Abs. 2 und 3 KAGB definierten Anforderungen entsprechen. Die Aktionäre erhalten
jährliche Jahresabschlüsse an jedem Abschlussstichtag. Der Jahresabschluss ist von einem Wirtschaftsprüfer zu überprüfen
und mit einem Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers zu versehen.

Art. 15. Zuweisung von Gewinnen.
15.1. Aus den jährlichen Nettogewinnen der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgeschriebenen

Rückstellung zugeführt. Diese Zuweisung ist nicht länger erforderlich, wenn die gesetzlichen Rücklagen einen Betrag
erreichen, der zehn Prozent (10%) des Stammkapitals entspricht.

15.2. Die Gesellschafter entscheiden, wie über den Saldo der Jahresnettogewinne verfügt wird. Sie können diesen der

Auszahlung von Dividenden zuweisen, ihn auf ein Rücklagenkonto überweisen oder ihn vortragen.

Alle Ausschüttungen sind in der folgenden Reihenfolge vorzunehmen:
- die Halter von Klasse-A-Anteilen sind berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma

Sechzig Prozent (0,60%) des Nennwerts der Klasse-A-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,

- sind die Halter von Klasse-B-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma

Fünfundfünfzig Prozent (0,55%) des Nennwerts der Klasse-B-Anteile, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,

- sind die Halter von Klasse-C-Anteile berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma

fünfzig Prozent (0,50%) des Nennwerts der Klasse-C-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,

- sind die Halter von Klasse-D-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma

Fünfundvierzig Prozent (0,45%) des Nennwerts der Klasse-D-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,

- sind die Halter von Klasse-E-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma

Vierzig Prozent (0,40%) des Nennwerts der Klasse-E-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,

- sind die Halter von Klasse-F-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma

Fünfunddreißig Prozent (0,35%) des Nennwerts der Klasse-F-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,

- sind die Halter von Klasse-G-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma

Dreißig Prozent (0,30%) des Nennwerts der Klasse-G-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,

- sind die Halter von Klasse-H-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma

Fünfundzwanzig Prozent (0,25%) des Nennwerts der Klasse-H-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,

- sind die Halter von Klasse-I-Anteilen berechtigt, Dividendenausschüttungen für dieses Jahr in Höhe von Null Komma

Zwanzig Prozent (0,20%) des Nennwerts der Klasse-I-Anteilen, die von Ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann,

81531

L

U X E M B O U R G

- Ist der Saldo des gesamten ausgeschütteten Betrags in der Gesamtheit den Haltern der letzten Klasse in der umgekehrten

alphabetischen Reihenfolge zuzuweisen (d.h. zuerst Klasse-J-Anteile, dann, wenn keine Klasse-J-Anteile vorhanden sind,
Klasse-I-Anteile und so weiter bis nur noch Klasse-A-Anteile vorhanden sind).

Sollte die ganze letzte ausstehende Anteilsklasse zum Zeitpunkt der Ausschüttung (nach umgekehrter alphabetischer

Reihenfolge, z.B. Klasse-J-Anteile) infolge von Rücknahme annulliert, zurückgekauft oder anderweitig aufgehoben wor-
den sein, dann wird der Rest einer Dividendenausschüttung der vorangegangenen letzten ausstehenden Anteilsklasse in
umgekehrter alphabetischer Reihenfolge (z.B. Klasse-I-Anteile wenn Klasse-J-Anteile annulliert worden sind), zugewie-
sen.

15.3. Zwischendividenden können jederzeit unter den folgenden Voraussetzungen ausgeschüttet werden:
(i) Der Vorstand erstellt Zwischenabschlüsse;
(ii)  diese  Zwischenabschlüsse  weisen  aus,  dass  ausreichend  Gewinne  und  andere  verfügbare  Rückstellungen  (ein-

schließlich Agio) für die Ausschüttung verfügbar sind; und

(iii) die Entscheidung, Zwischendividenden auszuschütten muss vom Vorstand innerhalb von zwei (2) Monaten nach

dem Datum der Zwischenabschlüsse getroffen werden.

VI. Auflösung - Liquidation

Art. 16.
16.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss von Gesellschaftern aufgelöst werden, wenn der Beschluss

von einer Hälfte (1/2) der Gesellschafter, die dreiviertel (3/4) des Gesellschaftskapitals halten, angenommen wird. Die
Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Liquidatoren, die nicht Gesellschafter sein müssen, um die Liquidation ab-
zuwickeln und bestimmen deren Anzahl, Befugnisse und die Entlohnung. Wenn von den Gesellschaftern nichts anderes
entschieden wird, haben die Liquidatoren die weitest gehenden Befugnisse, die Aktiva zu verwerten und die Verbindlich-
keiten der Gesellschaft zu bezahlen.

16.2. Nach Bezahlung aller Schulden und aller Belastungen der Gesellschaft und der Kosten der Liquidation, werden

die Netto-Liquidationsgewinne an die Gesellschafter ausgeschüttet in Übereinstimmung mit den Ausschüttungsregeln um
wirtschaftlich betrachtet dasselbe Resultat wie die Ausschüttungsregeln, die für die Ausschüttung von Dividenden festge-
legt worden sind, zu erreichen.

VII. Allgemeine Bestimmungen

Art. 17.
17.1. Jegliche Mitteilungen und Kommunikationen oder deren Verzicht, die Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer

sowie die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter können schriftlich, per Fax, E-Mail über andere elektronischen Kommu-
nikationsmedien ergehen.

17.2. Vollmachten werden über eines der oben beschriebenen Kommunikationsmittel gewährt. Vollmachten in Zusam-

menhang mit Vorstandssitzungen können auch von einem Geschäftsführer in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen,
die der Vorstand annehmen kann, gewährt werden.

17.3. Unterschriften können handschriftlich oder in elektronischer Form erfolgen, vorausgesetzt, dass sie alle rechtlichen

Anforderungen erfüllen und als den handschriftlichen Unterschriften gleichwertig anerkannt werden. Unterschriften der
Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer oder der Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter, je nachdem wie der Fall liegt, werden
auf einem Original oder auf mehreren Gegenstücken desselben Dokuments angebracht, wobei alle zusammen ein und
dasselbe Dokument darstellen.

17.4. Alle Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich in der Satzung geregelt sind, werden per Gesetz bestimmt sowie den

Verträgen welche von den Gesellschaftern von Zeit zu Zeit eingegangen werden können, sofern diese nicht zwingendem
gesetzlichen Bestimmungen widersprechen.“

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents
euros (€ 1.200).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par

nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. STEVENS, C. WERSANDT.

81532

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 15 mars 2016. 2LAC/2016/5627. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 17 mars 2016.

Référence de publication: 2016082272/1061.
(160048268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Sapinda Invest Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 204.772.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the fourth day of March.
Before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Sapinda Invest S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg,

registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 187.176, having its registered office at 2,
avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Maître Philippe Harles, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on 18 February 2016.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company

(société à responsabilité limitée) which they wish to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Sapinda  Invest  Services  S.à  r.l.  (hereinafter  the  “Company”)  which  shall  be  governed  by  the  law  of  10  August  1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The Purpose of the Company is to provide any office management, portfolio management, risk management, IT or

human resources services, as well as any other services in relation to the management of a company to its parent company
and any other company that belongs to the same group.

2.2 The Company may further carry out any commercial, financial, real estate or intellectual property activities which

it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve

thousand five hundred (12,500.-) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

81533

L

U X E M B O U R G

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Authorised capital.
6.1 The authorised capital, excluding the share capital, is set at one million euro (EUR 1,000,000.-), consisting of one

million (1,000,000) shares with a nominal value of one euro EUR (1.-) each. During a period of time of five (5) years from
the date of the publication of these articles of association or, as the case may be, of the resolution to renew or to increase
the authorised capital pursuant to this article, the board of directors is hereby authorised to issue shares, to grant options to
subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares within the limits of the authorised capital to
such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving a preferential
right to subscribe to the shares issued for the existing shareholders. Such authorisation may be renewed through a resolution
of the general meeting of the shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association,
each time for a period not exceeding five (5) years.

6.2 The authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders adopted in the manner required for amendments of these articles of association.

Art. 7. Shares.
7.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
7.2 The shares of the Company are in registered form.
7.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
7.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 8. Register of shares - Transfer of shares.
8.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

8.3 The shares are freely transferable among shareholders.
8.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by

the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

8.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the

transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

8.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by the
surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, des-
cendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 9. Collective decisions of the shareholders.
9.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

9.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
9.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.

9.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.

Art. 10. General meetings of shareholders. Meetings of shareholders may be held at such place and time as may be

specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general
meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or
publication.

81534

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Quorum and vote.
11.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
11.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second
time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are
validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share
capital represented.

Art. 12. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 13. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 14. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
14.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

14.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.

14.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 15. Appointment, removal and term of office of managers.
15.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office. The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class
A managers (the “Class A Managers”) and class B managers (the “Class B Managers”). Any reference made hereinafter
to the “managers” shall be construed as a reference to the Class A Managers and/or the Class B Managers, depending on
the context and as applicable.

15.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

Art. 16. Vacancy in the office of a manager.
16.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment.

16.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers shall meet upon call by any two managers. The meetings of the board of managers shall be

held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

17.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any

convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

18.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.

81535

L

U X E M B O U R G

18.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

18.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means

of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

18.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers, the board of managers may deliberate or act validly only if at least one (1) Class A Manager and one
(1) Class B Manager is present or represented at the meeting.

18.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. In the event

the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers, decisions shall be taken by a majority of
the managers present or represented including at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager. The chairman,
if any, shall not have a casting vote.

18.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.

Art. 19. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
19.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by (i) the chairman, if any or in his absence

by the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or (ii) by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.

19.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 20. Dealing with third parties.
20.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or

if the Company has several managers, by the joint signatures of any two (2) managers, or by the joint signatures of one (1)
Class A Manager and one (1) Class B Manager if applicable, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 21. Auditor(s).
21.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the statutory auditor(s) and shall determine their term of office.

21.2 A statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

21.3 The statutory auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
21.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))

in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.

21.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 22. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 23. Annual accounts and allocation of profits.
23.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the

Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

23.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.

23.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

81536

L

U X E M B O U R G

23.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

23.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 24. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
24.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year of which the annual accounts have been approved, increased
by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

24.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation.
25.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators  shall  have  the  most  extensive  powers  for  the  realisation  of  the  assets  and  payment  of  the  liabilities  of  the
Company.

25.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 26. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2016.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.

<i>Subscription and payment

All the twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Sapinda Invest S.à r.l., aforemen-

tioned, represented as stated above, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five

hundred euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is entirely allocated to the

share capital.

Proof of the existence and the value of the above-mentioned contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne

by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR
1,500).

<i>Resolutions of the shareholders

The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, have passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 2, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
(i) TICHEL Gordon Mager, born in New York, United States of America on 14 September 1966, residing at 2, um Haff,

1898 Kockelscheuer, Grand Duchy of Luxembourg;

(ii) MUCKLE Richard Anthony, born in Kingston-Upon-Thames, United Kingdom of Great Britain and Northern Ire-

land on 13 August 1976, residing at The Holt, Church Lane, Warlingham, CR6 9PG, Surrey, United Kingdom;

(iii) VAN DAELE Dirk Karel Judith, born in Ekeren, Belgium on 27 April 1961, residing at 6, Bergstrasse, 8810 Horgen,

Belgium.

81537

L

U X E M B O U R G

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this

deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and

residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède.

L’an deux mille seize, le quatre mars.
Par-devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorfles-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

Sapinda Invest S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.176, ayant
son siège social à 2, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

dûment représentée par Maître Philippe Harles, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 18 février 2016.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

Le comparant a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte de constitution d’une société à responsabilité limitée

qu’il souhaite constituer avec les statuts suivants:

A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom - Forme.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination Sapinda Invest Services S.à

r.l. (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet de fournir à sa maison mère ou tout autre société qui appartient au même group toute service

de gestion de bureau, gestion de portefeuille, gestion de risque, services de IT ou ressources humaines, de même que tout
service en relation avec la gestion d'une société.

2.2 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle

qu’elle estime utile pour l’accomplissement de ces objets.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l’assemblée générale des associés, adoptée

selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être

transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand- Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision

du conseil de gérance.

4.4 Dans l’hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, écono-

mique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité
normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation
complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de
la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille

cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des associés

de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

81538

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Capital autorisé.
6.1 Le capital autorisé, excluant le capital social, est fixé à un montant d’un million euros (EUR 1.000.000,-), représenté

par un million (1.000.000) parts sociales avec une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune. Pendant une période de
cinq (5) ans à compter de la date de publication des présents statuts ou, le cas échéant, de la décision de renouveler ou
d’augmenter le capital autorisé conformément à cet article, le conseil de gérance est autorisé à émettre des actions, à attribuer
des bons de souscription d’actions et à émettre tout autre type d’instrument convertible en parts sociales dans les limites
du capital autorisé au profit des personnes et aux conditions qu’il estimera opportunes lui permettant notamment de procéder
à cette émission sans qu’un droit préférentiel de souscription aux parts sociales nouvellement émises ne soit réservé aux
associés existants. Cette autorisation pourra être renouvelée par une décision de l’assemblée générale des associés, prise
aux conditions requises pour la modification des statuts, à chaque fois pour une période ne pouvant excéder une durée de
cinq (5) ans.

6.2 Le capital autorisé de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des associés,

prise aux conditions requises pour la modification des statuts.

Art. 7. Parts sociales.
7.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
7.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
7.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
7.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l’insolvabilité ou tout autre

événement similaire d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 8. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
8.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour

consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d’inscription peuvent être émis
sur demande et aux frais de l’associé demandeur.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant

unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à
cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

8.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
8.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu’une telle

cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

8.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après

l’acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

8.6 En cas de décès, les parts sociales de l’associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous

réserve qu’un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants représentant les trois quarts des droits des survivants.
Un tel agrément n’est cependant pas requis dans l’hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants,
descendants ou au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l’associé décédé.

C. Décisions des associés

Art. 9. Décisions collectives des associés.
9.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les

présents statuts.

9.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu’il

détient.

9.3 Dans l’hypothèse où et tant que la Société n’a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui

relèveraient d’ordinaire de la compétence de l’assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.

9.4 En cas d’associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés en vertu des

dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l’assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l’associé unique selon le contexte et le cas échéant et
les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés seront exercés par l’associé unique.

Art. 10. Assemblées générales des associés. Des assemblées générales d’associés pourront être tenues aux lieux et heures

indiquées dans les convocations aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés
à l’assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée pourra être tenue sans con-
vocation ou publication préalable.

Art. 11. Quorum et vote.
11.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.

81539

L

U X E M B O U R G

11.2 Sous réserve d’un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés

de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu’elles auront été adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social. Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés
peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec le même ordre du jour et les décisions
sont valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Art. 12. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu’avec le consentement

unanime des associés.

Art. 13. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l’accord d’une (i) majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social.

D. Gérance

Art. 14. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
14.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un

conseil de gérance.

14.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n’est pas

expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme
une référence au «gérant unique».

14.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute

mesure nécessaire ou utile pour l’accomplissement de l’objet social de la Société, à l’exception des pouvoirs réservés par
la Loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale des associés.

Art. 15. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
15.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l’assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et

la durée de son (leur) mandat. L’assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de catégories diffé-
rentes, à savoir des gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et des gérants de catégorie B (les «Gérants de
Catégorie B»). Toute référence faite ci-après aux «gérants» doit s’interpréter comme une référence aux Gérants de Catégorie
A et/ou Gérants de Catégorie B en fonction du contexte et le cas échéant.

15.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, sans motif, par une

décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Art. 16. Vacance d’un poste de gérant.
16.1 Dans l’hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l’incapacité juridique, la faillite, la

démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne pouvant
excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu’à la prochaine assemblée des associés
appelée à statuer sur la nomination permanente.

16.2 Dans l’hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est

comblée sans délai par l’assemblée générale des associés.

Art. 17. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de deux gérants. Les réunions du conseil de gérance sont tenues

au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

17.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures

à l’avance par rapport à l’heure fixée dans la convocation, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs d’une
telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d’accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d’un tel document signé
constituera une preuve suffisante d’un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance
dont le lieu et l’heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d’un précédent conseil de gérance, communiquée
à tous les membres du conseil de gérance.

17.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l’hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés

à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l’hypothèse de décisions écrites et approu-
vées par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 18. Conduite des réunions du conseil de gérance.
18.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner

un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance.

18.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,

le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.

18.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme

son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du

81540

L

U X E M B O U R G

mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l’intégralité des membres
du conseil de gérance.

18.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout

autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans
discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s’être tenue
au siège social de la Société.

18.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente

ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des associés a nommé des
gérants de catégories différentes, le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins un (1) Gérant
de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B est présent ou représenté à la réunion du conseil de gérance.

18.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de

gérance. Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des associés a nommé des gérants de catégories différentes, les décisions
doivent être adoptées par une majorité de gérants présents ou représentés comprenant au moins un (1) Gérant de Catégorie
A et un (1) Gérant de Catégorie B. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d’une voix prépon-
dérante.

18.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l’ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions
sera la date de la dernière signature.

Art. 19. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
19.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par (i) le président, le cas échéant,

ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou (ii) par deux (2) gérants. Les copies ou
extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président
le cas échéant, ou par deux (2) gérants.

19.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés
par le gérant unique.

Art. 20. Rapports avec les tiers.
20.1 La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par la signature du gérant unique,

ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, ou (ii) par la signature conjointe d’un
(1) Gérant de Catégorie A et d’un (1) Gérant de Catégorie B, le cas échéant, ou (ii) la signature conjointe ou la seule
signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance,
dans les limites de cette délégation.

E. Audit et surveillance

Art. 21. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
21.1 Dans l’hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront

surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la
durée de leurs fonctions.

21.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.
21.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
21.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69

de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.

21.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif

ou avec son accord.

F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 22. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le

trente et un décembre de la même année.

Art. 23. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
23.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif

et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

23.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.

81541

L

U X E M B O U R G

23.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve

légale, si cet associé consent à cette affectation.

23.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

23.5  Sur  proposition  du  conseil  de  gérance,  l'assemblée  générale  des  associés  décide  de  l’affectation  du  solde  des

bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

23.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu’ils détiennent dans la

Société.

Art. 24. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
24.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d’un état comptable

intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social
pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais
diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts
interdisent la distribution.

24.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-

formément à la Loi et aux présents statuts.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation.
25.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l’article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée

par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera
les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l’actif et du passif de la Société.

25.2 Le surplus résultant de la réalisation de l’actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre

de parts sociales qu’ils détiennent dans la Société.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 26. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2016.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

<i>Souscription et paiement

Les douze mille cinq cent parts sociales émises ont été souscrites par Sapinda Invest S.à r.l., susmentionnée, représentée

comme indiqué ci-dessus, pour un prix de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d’apport en numéraire, de sorte que le

montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été
justifié au notaire soussigné.

L’apport global d’un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est entièrement affecté au capital social.
La preuve de l’existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

<i>Résolutions des associés

Les associés fondateurs, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de

convocation, ont adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 2, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg.

2. Les personnes suivantes sont nommées gérant pour une durée indéterminée:
(i) TICHEL Gordon Mager, né à New York, Etats-Unis d’Amérique le 14 septembre 1966, résidant à 2, um Haff, 1898

Kockelscheuer, Grand-Duché de Luxembourg;

(ii) MUCKLE Richard Anthony, né à Kingston-Upon-Thames, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

le 13 août 1976, résidant à The Holt, Church Lane, Warlingham, CR6 9PG, Surrey, Royaume- Uni; et

(iii) VAN DAELE Dirk Karel Judith, né à Ekeren, Belgique le 27 avril 1961, résidant à 6, Bergstrasse, 8810 Horgen,

Belgique.

81542

L

U X E M B O U R G

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande du comparant que le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande du même comparant et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire du/des comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Harles, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 11mars 2016. GAC/2016/2018. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. BENTNER.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 18 mars 2016.

Référence de publication: 2016082284/547.
(160048708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Lynxis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7594 Beringen, 17, rue des Noyers.

R.C.S. Luxembourg B 132.669.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016091469/9.
(160060657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.

Herbalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9838 Eisenbach, 13, Wuelesser Wée.

R.C.S. Luxembourg B 204.784.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausendsechzehn, den dritten März.
Vor der unterzeichneten Notarin Leonie GRETHEN, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxem-

burg).

Ist erschienen:

1. Frau Dr. Sigrid Dagmar Lieselotte TEUPE geb. WEYGAND, Ärztin, geboren in Berlin (D) am 4. Dezember 1956,

wohnhaft in D-46282 Dorsten, Fährstraße 55;

2. Frau Freya Bernadette TEUPE, Ärztin, geboren in St. Petersburg (USA) am 10. August 1987, wohnhaft in D-06108

Halle (Saale), Geiststraße 21;

3. Frau Laura Bernice TEUPE, Studentin, geboren St. Petersburg (USA) am 23. Januar 1990, wohnhaft in D-06108

Halle (Saale), Geiststraße 21,

Hier vertreten durch Frau Dr. Sigrid TEUPE, vorbenannt, gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht, welche ne varietur

von der Bevollmächtigten der erschienen Person sowie der amtierenden Notarin paraphiert und dieser Urkunde beigebogen
bleibt,

4. Frau Phyllis Isabelle TEUPE, Studentin, geboren in St. Petersburg (USA) am 2. April 1992, wohnhaft in D-44803

Bochum, Andreas-Hoferstraße 10.

Welche Komparenten die instrumentierende Notarin ersuchten, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie

durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung Herbalux S.a r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Parc Hosingen.
Er kann durch einen Beschluss des oder der Geschäftsführer der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Der Sitz kann ebenfalls an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg durch einen Beschluss des alleinigen Ge-
sellschafters oder der Hauptversammlung der Gesellschafter verlegt werden, der auf die Art und Weise gefasst wird, wie
er für Satzungsänderungen vorgesehen ist

81543

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand die Entwicklung, Marketing und Vertrieb von Medizinprodukten, Nah-

rungsergänzungsmittel und Medikamenten.

Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Ge-

sellschaft  in  Verbindung  stehen.  Auch  kann  sie  sämtliche  kaufmännische,  finanzielle,  mobiliare  oder  immobiliare
Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. - Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundert fünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral gezeichnet und voll eingezahlt wurden.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. - Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäß Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September

1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die

Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht wor-
den,  so  werden  die  Gesellschafter  ein  zweites  Mal  durch  Einschreibebrief  zusammengerufen  oder  befragt  und  die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesell-

schaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschaf-

terversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der

Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt.

Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. - Auflosung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch-
geführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit

beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

81544

L

U X E M B O U R G

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2016.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden wie folgt gezeichnet und der Nennwert zu

einhundert Prozent (100%) in bar eingezahlt:

Gesellschafter

gezeichnetes

Kapital

Anzahl der

Anteile

eingezahlter

Betrag

Frau Dr. Sigrid Dagmar Lieselotte TEUPE geb. WEYGAND,
vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 8.750,-

70

EUR 8.750,-

Frau Freya Bernadette TEUPE, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 1.250,-

10

EUR 1.250,-

Frau Laura Bernice TEUPE, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 1.250,-

10

EUR 1.250,-

Frau Phyllis Isabelle TEUPE, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 1.250,-

10

EUR 1.250,-

Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12.500,-

100 EUR 12.500,-

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) steht der Gesellschaft daher von diesem Moment an

zur Verfügung. Der Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht, welcher erklärt, dass die Vorausse-
tzungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden
Fassung, gewahrt wurden.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr eintausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-).

<i>Erklärung

Die Komparenten erklären, dass die unterfertigte Notarin ihnen Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst

nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschließend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusam-

mengefunden, zu welcher sie sich als gehörig einberufen betrachten, und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins (1) festgesetzt.
2. Folgende Person wird auf unbegrenzte Zeit als Geschäftsführerin ernannt:
- Frau Dr. Sigrid TEUPE, Ärztin, geboren in Berlin (D) am 4. Dezember 1956, wohnhaft in D-46282 Dorsten, Fährstraße

55.

Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift der Geschäftsführerin rechtsgültig verpflichtet.
3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9838 Eisenbach, 13, Wuelesser Wée, Gemeinde Parc Hosingen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an die Komparenten, der Notarin nach Namen, gebräu-

chlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit der Notarin unters-
chrieben.

Gezeichnet: S. Teupe, F. Teupe, P. Teupe, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 08 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/7691. Reçu soixante-quinze (75.-)

euros.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Luxemburg, den 11. März 2016.

Référence de publication: 2016082017/126.
(160048821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Kensington UK Office (Crewe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 182.217.

In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of March.
Before us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

81545

L

U X E M B O U R G

Cains Trustees (Jersey) Limited, incorporated and registered with the Jersey Companies Registry under the registration

number 114731 and Cains Fiduciaries (Jersey) Limited, incorporated and registered with the Jersey Companies Registry
under the registration number 114717, both having their registered office at PO BOX 83, Ordnance House, 31 Pier Road,
St Helier, Jersey JE4 8PW, acting in their capacity of joint trustees of Webb Commerce Property Unit Trust,

here represented by Ariane Klaps, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given

on 3 

rd

 March 2016.

Said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for

the purpose of registration.

Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Kensington UK Office (Crewe) S.à r.l., a société

à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of fifteen
thousand British pounds sterling (GBP 15,000.-), registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 182217 (hereinafter the “Company”) and incorporated pursuant to a notarial deed dated 27 November 2013 and
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 119 on 14 January 2014. The articles of association
have been lastly amended pursuant to a notarial deed dated 29 May 2015 and published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n° 2044 on 11 August 2015.

The Sole Shareholder, represented as stated above, then reviewed the following agenda:

<i>Agenda

1. Dissolution and liquidation of the Company;
2. Discharge to be granted to the managers of the Company;
3. Appointment of a liquidator and determination of its powers; and
4. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder takes, and requires the notary to enact, the

following resolutions:

<i>First resolution

In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”),

the Sole Shareholder resolves to dissolve and liquidate the Company.

<i>Second Resolution

The Sole Shareholder resolves to grant discharge and release from liability the managers of the Company for their

conduct of the Company's affairs during their mandates.

<i>Third Resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to appoint FIDES (Luxembourg) S.A., a

Luxembourg société anonyme having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 41469, as liquidator of the Company (the “Liqui-
dator”).

The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law, it being however specified

that the Liquidator may not dispose of any real estate asset of the Company other than by way of distribution in specie to
the Sole Shareholder. The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.
The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders

such powers as it determines and for the period as it thinks fit.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the Sole Shareholder in cash and/or in kind in its sole discretion.

Such distribution may take the form of one or more advance payments on future liquidation proceeds.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this

deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and

residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

81546

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le huitième jour du mois de mars.
Par-devant nous, Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Cains Trustees (Jersey) Limited, constitué et inscrit auprès du Jersey Companies Registry sous le numéro d'enregistre-

ment 114731, et Cains Fiduciaries (Jersey) Limited, constitué et inscrit auprès du Jersey Companies Registry sous le numéro
d'enregistrement 114717, les deux ayant leur siège social à PO BOX 83, Ordnance House, 31 Pier Road, St Helier, Jersey
JE4 8PW, agissant en leur capacité de trustees conjoints de Webb Commerce Property Unit Trust,

ici représentée par Ariane Klaps, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing

privé donnée le 3 mars 2016. La procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de Kensington UK Office (Crewe) S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de quinze mille Livres
Sterling anglaises (GBP 15.000,-), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le
numéro B 182217 (ci-après la «Société») et constituée selon acte notarié du 27 novembre 2013, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n° 119 en date du 14 janvier 2014. Les statuts ont été récemment modifiés selon acte
notarié du 29 mai 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2044 en date du 11 août 2015.

L'Associé Unique, représenté comme mentionné ci-dessus, a examiné l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Dissolution et liquidation de la Société;
2. Quitus aux gérants de la Société;
3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs; et
4. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'Associé Unique adopte et requiert le notaire

instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée

(la «Loi»), l'Associé Unique décide de dissoudre et de liquider la Société.

<i>Deuxième résolution

L'Associé unique décide de donner quitus aux gérants de la Société pour la gestion des affaires sociales durant leurs

mandats.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé unique décide de nommer FIDES (Luxembourg) S.A., une société

anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B41469, en tant que liquidateur de la
Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi étant toutefois

précisé que le Liquidateur ne peut céder aucun actif immobilier de la Société autrement que par une distribution en nature
au profit de l'Associé Unique.

Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
La Société est engagée par la seule signature du Liquidateur.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l'étendue et la durée.

Le liquidateur pourra distribuer, à sa discrétion, les actifs de la Société à l'Associé Unique en espèce et/ou en nature.

Cette distribution pourra prendre la forme d'une ou plusieurs avances sur le boni de liquidation futur.

<i>Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est

évalué à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande de la même comparante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

81547

L

U X E M B O U R G

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. KLAPS, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/8140. Reçu douze (12.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 21 mars 2016.

Référence de publication: 2016082077/122.
(160048955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

NDT Operations Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 166.113.

In the year two thousand and sixteen, on the seventh of March.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

NDT European Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and

existing under the law of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 166094,

here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750

Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on February 26 

th

 , 2016.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder appearing and the undersigned notary, will remain attached to

the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The sole shareholder is present or represented and declares that it has had due notice and knowledge of the agenda

prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

II. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)

established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name of “NDT Operations Germany S.à r.l.” (he-
reinafter  “the  Company”),  with  registered  office  at  5,  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882  Luxembourg,  registered  with  the
Luxembourg  Trade  and  Companies  Register  under  number  B  166113,  incorporated  by  a  deed  of  Maître  Henri  HEL-
LINCKX, notary residing in Luxembourg, dated December 15 

th

 , 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations of February 23 

rd

 , 2012 under number 482 and which by laws have been last amended pursuant to a deed

of the undersigned notary of September 6 

th

 , 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of

October 28 

th

 , 2013, under number 2691.

III. The Company’s share capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000) represented by twenty-five thousand

(25,000) shares, all with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

IV. The agenda of the meeting is the following:

1. To change the Company's financial year closing date, from September 30 

th

 to March 31 

st

 ;

2. To fix the next closing date year on March 31 

st

 , 2016.

3. To amend articles 16 and 17 of the Articles of Association.
V. The sole shareholder, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to change the Company's financial year closing date, from September 30 

th

 to March 31

st

 .

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to fix the closing date for this year, having started on October 1 

st

 , 2015, to March 31 

st

 ,

2016.

The next financial year will start on April 1 

st

 , 2016 and end on March 31 

st

 , 2017.

81548

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the sole shareholder decides to amend articles 16 and 17 of the Articles

of Association and to give them the following wording:

“ Art. 16. The Company's financial year begins on April 1 

st

 of each year and closes on March 31 

st

 of the following

year.”

“ Art. 17. Each year, as of March 31 

st

 , the management will draw up the balance sheet which will contain a record of

the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary
of all its commitments and the debts of the manager(s) and shareholders toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting

of shareholders together with the balance sheet.”

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with this operation, have been estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le sept mars.
Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

NDT European Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit du Luxembourg,

ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée avec le Registre de Commerce et des
Sociétés, sous le numéro B166.094,

ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, résidant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing-privé au Luxembourg le 26 février 2016.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, l’associé unique étant présent ou représenté et se reconnaissant

dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

II. La personne comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie dans le Grand-Duché de

Luxembourg sous la dénomination «NDT Operations Germany S.à r.l.» (ci-après «la Société»), ayant son siège social au
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 166113, constituée par acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg en date
du 15 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 482 du 23 février 2012 et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentaire en date du 6 septembre 2013, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2691 du 28 octobre 2013.

III. Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000.- EUR) représenté par vingt-cinq mille (25.000)

Parts Sociales, d’une valeur nominale d’un euro (1.- EUR) chacune.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Changement de la date de clôture de l'exercice social de la société du 30 septembre au 31 mars.
2. Fixation de la date de la prochaine clôture au 31 mars 2016.
3. Modification des articles 16 et 17 des statuts.
V. L’associé unique, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer la date de clôture de l'exercice social de la société du 30 septembre au 31 mars.

81549

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de fixer la date de clôture de cette année au 31 mars, de sorte que l'exercice social ayant débuté

le 1 

er

 octobre 2015 se termine le 31 mars 2016.

Le prochain exercice social commencera le 1 

er

 avril 2016 et se terminera le 31 mars 2017.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’associé unique décide de modifier les

articles seize et dix-sept des statuts pour leur donner la signification suivante:

« Art. 16. L’exercice social commence le 1 

er

 avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.»

« Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 mars, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la

Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant un résumé de tous ses engagements, ainsi que
les dettes des gérants et associés envers la société.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cette opération, s'élève à environ mille trois cents euros (1.300.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 15 mars 2016. 2LAC/2016/5659. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2016.

Référence de publication: 2016082204/118.
(160048554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Crédit Agricole Réinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 29.439.

L'an deux mille seize, le quatorze mars.
Par-devant Nous Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Se réunit

l'assemblée  générale  extraordinaire  (l’«Assemblée»)  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  CREDIT  AGRICOLE

REINSURANCE S.A., ayant son siège social au 31-33, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 29439, constituée suivant acte reçu le 5 décembre
1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 72 de 1989, et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à Grevenmacher, le 19
décembre 2014, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 224 du 28 janvier 2015 (la
«Société»).

<i>Bureau

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mathieu DELAPLACE, responsable juridique, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Alexandra RUSNAC,

souscriptrice en réassurance, demeurant professionnellement à Luxembourg.

<i>Composition de l'assemblée

Le capital social de la Société, d’un montant de treize millions huit cent trente-huit mille trois cent soixante-huit euros

cinquante-cinq cents (EUR 13.838.368,55), est représenté par trois cent vingt mille (320.000) actions nominatives sans

81550

L

U X E M B O U R G

désignation de valeur nominale. La désignation des actionnaires présents ou représenté à l'Assemblée a été portée sur une
liste de présence.

<i>Exposé du Président

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- Que l'Assemblée a l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification du premier alinéa de l’article 8 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 8. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président. Le Conseil d'Administration se réunit

aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, et chaque fois que deux administrateurs le demandent, sur convocation
et sous la présidence du président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur désigné par ses collègues. Le
Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée. Tout administrateur empêché ou absent peut désigner par écrit, par téléfax, télégramme, télex ou courriel un de ses
collègues du Conseil pour le représenter aux réunions du Conseil et y voter en ses lieu et place.»;

2. Modification de l’article 10 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 10. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception de ceux que la loi où les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration peut déléguer, en précisant dans une délibération particulière la portée de la délégation

opérée, ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui
peuvent mais n'ont pas besoin d'être administrateurs.

Le Conseil d'Administration peut également conférer des pouvoirs et mandats spéciaux ou des fonctions permanentes

ou temporaires à des agents de son choix.

Le Conseil d'Administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions prévues par

la loi.»;

3. Modification du premier alinéa de l’article 15 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 15. L'Assemblée Générale annuelle se réunit au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans les

convocations, le premier mercredi du mois de mars à 11:00 heures.»;

4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne

varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

<i>Délibération et résolutions prises par l’Assemblée

Ces faits reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 8 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la

teneur suivante:

« Art. 8. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président. Le Conseil d'Administration se réunit

aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, et chaque fois que deux administrateurs le demandent, sur convocation
et sous la présidence du président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur désigné par ses collègues. Le
Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée. Tout administrateur empêché ou absent peut désigner par écrit, par téléfax, télégramme, télex ou courriel un de ses
collègues du Conseil pour le représenter aux réunions du Conseil et y voter en ses lieu et place.»;

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

81551

L

U X E M B O U R G

« Art. 10. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception de ceux que la loi où les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration peut déléguer, en précisant dans une délibération particulière la portée de la délégation

opérée, ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui
peuvent mais n'ont pas besoin d'être administrateurs.

Le Conseil d'Administration peut également conférer des pouvoirs et mandats spéciaux ou des fonctions permanentes

ou temporaires à des agents de son choix.

Le Conseil d'Administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions prévues par

la loi.».

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 15 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la

teneur suivante:

« Art. 15. L'Assemblée Générale annuelle se réunit au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans les

convocations, le premier mercredi du mois de mars à 11:00 heures.».

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à

raison des présentes est évalué à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau et les

mandataires des actionnaires représentés ont signé le présent procès-verbal avec Nous, notaire.

Signé: M. DELAPLACE, A. RUSNAC, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/8606. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016081894/107.
(160048889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

LM Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 72, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 117.661.

Les comptes annuels au 30-09-2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016091455/9.
(160059923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.

Lock Syndication S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 127.968.

Les comptes annuels au 30 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016091457/9.
(160060414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

81552


Document Outline

AB Acquisitions Luxco 9 S.à r.l.

Aero-Flux S.àr.l.

Aero-Flux S.àr.l.

AMP Capital Investors (CLH No. 1) S.à r.l.

Am Wenkel S.à r.l.

Am Wenkel S.à r.l.

Ascoma Luxembourg

Assistance à la GESTION EVENCE MARCHAND LUXEMBOURG S.A.

Assistance à la GESTION EVENCE MARCHAND LUXEMBOURG S.A.

Athalia VI

Athalia VI B

Athalia Vi Infra

AZA Technology S.C.S.

Bamboleo S.A.

Banque Degroof Luxembourg S.A.

BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG S.A.

Banyan

Batiram S.à r.l.

Batiram S.à r.l.

Bureau de Gérances René Kitzler S.à r.l.

Cazelia

CEP III Co-Investment S.à r.l. SICAR

Coal Energy S.A.

Coal Energy S.A.

Corning Luxembourg S.à r.l.

Crèche Nanny Mc Fee s.à r.l.

Crédit Agricole Réinsurance S.A.

Herbalux S.à r.l.

Kensington UK Office (Crewe) S.à r.l.

LM Equity S.A.

Lock Syndication S.C.A.

Lynxis S.A.

NDT Operations Germany S.à r.l.

Rue de la Paix 15 S.à r.l.

Sapinda Invest Services S.à r.l.

Vrucht Holding S.A.

Yachting Management S.A.

Yachting Management S.A.

Yamatu S.à r.l.

Yolande Coop

ZEN High-Tech S.A.

ZEN High-Tech S.A.

ZG &amp; Golugi S.A.

ZG &amp; Golugi S.A.

Zhelezniak Investments S.à r.l. SPF

Zoetheo S.A.

ZXY Luxembourg Investment S.à r.l.