logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1590

2 juin 2016

SOMMAIRE

AI Global Investments & CY S.C.A.  . . . . . . . .

76296

Altice Entertainment News & Sport S.A.  . . . .

76320

Altice Entertainment & Sport S.A.  . . . . . . . . .

76320

Crif S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76313

Crismar Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . .

76311

Danieli Ecologia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76311

DE Investment Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

76311

DevStrat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76311

Diajewel Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76313

Dièdre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76311

Dimant S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76313

Edinburgh Georges Street S.à r.l.  . . . . . . . . . .

76274

ESCO Finance International S.à r.l.  . . . . . . . .

76310

Etoile Centuria S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76313

Etoile Centuria S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76313

Fidugia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76312

Firebird Mongolia Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . .

76312

Fisogest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76312

FSS - Financial Services Solutions S.à r.l. . . . .

76312

GGC Boch Lux 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76312

GGC Boch Lux 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76312

Gramimmo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76310

L.01 Laurus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76310

Liga Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76310

Liga Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76310

LKS 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76310

Perspective Croissance Holding S.A.  . . . . . . . .

76309

Republika Luxembourg Holdings S.à r.l.  . . . .

76317

RubySphere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76306

Salveo Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76316

Sangre Pura SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76316

Sani Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76318

Schroder Investment Management (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76318

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.  . . . . . . .

76315

Skytec Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76314

Skytec Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76314

SMC Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76314

Société Immobilière de Vente et d'Achat  . . . .

76315

Sole Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76318

Solferino Acquisition SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76314

Sportfield International 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

76315

Superstella S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76315

Tetraktys S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76309

Tilford Marine Investments  . . . . . . . . . . . . . . .

76317

Titanium Bloomsbury S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

76317

Universal Management Services Sàrl  . . . . . . .

76316

VCST Holdco Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76319

Viclux Soparfi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76319

76273

L

U X E M B O U R G

Edinburgh Georges Street S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 3.245.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 14, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 202.989.

In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth day of January.
Before the undersigned notary Maître Jacques Kesseler, notary established in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, having its registered seat in Frankfurt am Main with registered business

address at THE SQUAIRE 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Germany, registered with the “Handelsregister
B des Amtsgericht Frankfurt am Main“ under number HRB 91062, acting for the account of RAGS - Immo IVG, a German
real estate investment fund (the “Sole Shareholder”),

Hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address in Pétange,

Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such power of attorney having been signed “ne varietur” by the power of attorney holder acting on behalf of the appearing

party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration autho-
rities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of Edinburgh George Street S.à r.l., a private limited liability company

(“société à responsabilité limitée”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
located at 14, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register (“Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg”) under number R.C.S. Luxembourg
B 202.989 (the “Company”), incorporated by a deed enacted by the undersigned notary, on 29 December 2015, not published
yet in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations”.

The articles of association of the Company have not been amended since the incorporation of the Company.
II.- That the 1,000 (one thousand) corporate units with a nominal value of GBP 25 (twenty-five Great Britain pounds)

each, representing the entire share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of GBP 3,220,000 (three million two hundred twenty

thousand Great Britain pounds) so as to raise it from its current amount of GBP 25,000 (twenty-five thousand Great Britain
pounds) to GBP 3,245,000 (three million two hundred forty-five thousand Great Britain pounds) by the issue of 128,800
(one hundred twenty-eight thousand eight hundred) new corporate units with a nominal value of GBP 25 (twenty-five Great
Britain pounds) each;

3. Subscription and payment by TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, acting for the account of RAGS - Immo

IVG, a German real estate investment fund, of the new corporate units by way of a contribution in cash;

4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company;
6. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company so as to create (i) 1 (one) class of ordinary

corporate units and (ii) 9 (nine) classes of alphabet corporate units in the share capital of the Company and subsequent
reclassification of all the issued and outstanding corporate units in the Company;

7. Amendment of article 9 of the articles of association of the Company;
8. Creation of a new article 20 of the articles of association of the Company;
9. Amendment of article 21, formerly article 20, of the articles of association of the Company;
10. Insertion of a new third paragraph to article 22, formerly article 21, of the articles of association of the Company;
11. Approval of the full restatement of the articles of association of the Company further to the resolutions above; and
12. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder ack-

nowledges being sufficiently informed on the agenda and considers the meeting to be validly convened and therefore agrees
to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been

76274

L

U X E M B O U R G

put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each
document.

<i>Second resolution:

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 3,220,000 (three

million two hundred twenty thousand Great Britain pounds) so as to raise it from its current amount of GBP 25,000 (twenty-
five thousand Great Britain pounds) to GBP 3,245,000 (three million two hundred forty-five thousand Great Britain pounds)
by the issue of 128,800 (one hundred twenty-eight thousand eight hundred) new corporate units with a nominal value of
GBP 25 (twenty-five Great Britain pounds) each (the “New Corporate Units”).

<i>Third resolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Corporate Units by a

contribution in cash in an amount of GBP 3,220,000 (three million two hundred twenty thousand Great Britain pounds)
(the “Contribution”).

A proof of the Contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed of:
- TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, acting for the account of RAGS -Immo IVG: 129,800 (one hundred

twenty-nine thousand eight hundred) corporate units.

The undersigned notary acts that all the 129,800 (one hundred twenty-nine thousand eight hundred) corporate units,

representing the entire share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution
to be taken below.

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, the

Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

“ Art. 5. The corporate capital of the Company is fixed at GBP 3,245,000 (three million two hundred forty-five thousand

Great Britain pounds) divided into 129,800 (one hundred ninety-nine thousand eight hundred) corporate units with a no-
minal value of GBP 25.-(twenty-five Great Britain pounds) each.”

No other amendments to be made to this article.
It is noted that the formalities set forth in article 23 of the articles of association of the Company have been duly satisfied.

<i>Sixth resolution:

The Sole Shareholder resolves to create (i) 1 (one) class of ordinary corporate units and (ii) 9 (nine) classes of alphabet

corporate units in the share capital of the Company and to subsequently proceed to the reclassification of any and all of the
issued and outstanding corporate units in the Company as follows:

- 1,000 (one thousand) corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five Great Britain Pounds) each, are

reclassified into 1,000 (one thousand) ordinary corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five Great Britain
Pounds) each;

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five Great

Britain Pounds) each, are reclassified into 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class A corporate units, with
a nominal value of GBP 25 (twenty-five Great Britain Pounds) each;

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five Great

Britain Pounds) each, are reclassified into 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven)class B corporate units, with a
nominal value of GBP 25 (twenty-five Great Britain Pounds) each;

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five Great

Britain Pounds) each, are reclassified into 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class C corporate units, with a
nominal value of GBP 25 (twenty-five Great Britain Pounds) each;

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five Great

Britain Pounds) each, are reclassified into 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class D corporate units, with
a nominal value of GBP 25 (twenty-five Great Britain Pounds) each;

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five Great

Britain Pounds) each, are reclassified into 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class E corporate units, with a
nominal value of GBP 25 (twenty-five Great Britain Pounds) each;

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five Great

Britain Pounds) each, are reclassified into 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class F corporate units, with a
nominal value of GBP 25 (twenty-five Great Britain Pounds) each;

76275

L

U X E M B O U R G

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five Great

Britain Pounds) each, are reclassified into 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class G corporate units, with
a nominal value of GBP 25 (twenty-five Great Britain Pounds) each;

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five Great

Britain Pounds) each, are reclassified into 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class H corporate units, with
a nominal value of GBP 25 (twenty-five Great Britain Pounds) each;

- 14,312 (fourteen thousand three hundred twelve) corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five Great

Britain Pounds) each, are reclassified into 14,312 (fourteen thousand three hundred twelve) class I corporate units, with a
nominal value of GBP 25 (twenty-five Great Britain Pounds) each.

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed of:
TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, acting for the account of RAGS - Immo IVG:
- 1,000 (one thousand) ordinary corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five Great Britain Pounds)

each;

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class A corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-

five Great Britain Pounds) each;

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class B corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-

five Great Britain Pounds) each;

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class C corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-

five Great Britain Pounds) each;

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class D corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-

five Great Britain Pounds) each;

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class E corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five

Great Britain Pounds) each;

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class F corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five

Great Britain Pounds) each;

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class G corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-

five Great Britain Pounds) each;

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class H corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-

five Great Britain Pounds) each;

- 14,312 (fourteen thousand three hundred twelve) class I corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five

Great Britain Pounds) each.

As a result of the abovementioned resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Company’s articles

of association so as to be read as follows:

“ Art. 5. The corporate capital of the Company is fixed at GBP 3,245,000 (three million two hundred forty-five thousand

Great Britain pounds) divided into 129,800 (one hundred twenty-nine thousand eight hundred) corporate units with a
nominal value of GBP 25.-(twenty-five Great Britain pounds) each, divided into:

- 1,000 (one thousand) ordinary corporate units, with a nominal value of GBP 25.-(twenty-five Great Britain pounds)

each (the “Ordinary Corporate Units”);

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class A corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-

five Great Britain Pounds) each (the “Class A Corporate Units”);

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class B corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-

five Great Britain Pounds) each (the “Class B Corporate Units”);

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class C corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-

five Great Britain Pounds) each (the “Class C Corporate Units”);

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class D corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-

five Great Britain Pounds) each (the “Class D Corporate Units”);

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class E corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five

Great Britain Pounds) each (the “Class E Corporate Units”);

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class F corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five

Great Britain Pounds) each (the “Class F Corporate Units”);

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class G corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-

five Great Britain Pounds) each (the “Class G Corporate Units”);

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class H corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-

five Great Britain Pounds) each (the “Class H Corporate Units”); and

- 14,312 (fourteen thousand three hundred twelve) class I corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five

Great Britain Pounds) each (the “Class I Corporate Units”).

76276

L

U X E M B O U R G

All the Class A Corporate Units, the Class B Corporate Units, the Class C Corporate Units, the Class D Corporate Units,

the Class E Corporate Units, the Class F Corporate Units, the Class G Corporate Units, the Class H Corporate Units and
the Class I Corporate Units will be collectively referred to as the “Classes of Corporate Units” as the case may be, or
individually as a “Class of Corporate Units”. All the Classes of Corporate Units and the Ordinary Corporate Units will be
collectively referred to as the “corporate units” as the case may be, or individually as a “corporate unit”.

<i>Seventh resolution:

The Sole Shareholder resolves to amend article 9 of the Company’s articles of association so as to be read as follows:

“ Art. 9. The share capital of the Company may be reduced through the repurchase and cancellation of one or more

entire Classes of Corporate Units provided however that the Company may not at any time repurchase and cancel the
Ordinary Corporate Units. In the case of repurchases and cancellations of Classes of Corporate Units such repurchases and
cancellations of Classes of Corporate Units shall be made in the following order:

(i) Class I Corporate Units;
(ii) Class H Corporate Units;
(iii) Class G Corporate Units;
(iv) Class F Corporate Units;
(v) Class E Corporate Units;
(vi) Class D Corporate Units;
(vii) Class C Corporate Units;
(viii) Class B Corporate Units; and
(ix) Class A Corporate Units.
Such repurchase of any Class of Corporate Units shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general

meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for the
amendment of the articles of association of the Company.

In the event of a reduction of the share capital of the Company through the repurchase and the cancellation of any Class

of Corporate Units (in the order provided for above), such Class of Corporate Units being redeemed entitles the holders
thereof (pro rata to their holding in such Class of Corporate Units) to such portion of the Total Cancellation Amount as is
determined by the board of managers or the sole manager (as the case may be) and approved by the general meeting of
shareholders or the sole shareholder (as the case may be), and the holders of corporate units of the repurchased and cancelled
Class of Corporate Units shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Corporate Unit
for each corporate unit of the relevant Class of Corporate Units held by them and cancelled.

The Company may redeem its own corporate units within the limits set forth by the Commercial Companies Law.
For the purpose of these articles of association, the capital terms mentioned above shall have the following meaning:

Available Amount

means the total amount of net profits of the Company, including profits made since the end
of the last financial year, for which the annual accounts have been approved, increased by
(i) any freely distributable reserves, including all funds available for distribution plus any
profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, (ii) the
amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class(es)
of Corporate Units to be cancelled, knowing that the amount to be distributed may not exceed
the total available sums for distribution as calculated in accordance with Article 72.2 b) of
the Commercial Companies Law, but reduced by (i) any losses (including carried forward
losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the
Commercial Companies Law or of these articles of association, each as set out in the relevant
Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) - (L+ LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits), including profits made since the end of
the last financial year, for which the annual accounts have been approved
P = any freely distributable reserve
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the
Class of Corporate Units to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Commercial
Companies Law or of these articles of association.

Cancellation Value Per

Corporate Unit

shall be an amount calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of
corporate units in
issue in the Class of Corporate Units to be repurchased and cancelled.

76277

L

U X E M B O U R G

Total Cancellation
Amount

shall be an amount determined by the board of managers or the sole manager (as the case
may be) in accordance with article 72.2 b) of Commercial Companies Law and approved
by the general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be)
on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each Class
of Corporate Units shall be the Available Amount of such class as at the time of its
cancellation. Nevertheless the board of managers or the sole manager (as the case may be)
may provide for a Total Cancellation Amount different from the Available Amount provided
however that (i) the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available
Amount, (ii) such different Total Cancellation Amount shall be notified by the board of
managers or the sole manager (as the case may be) to all the shareholders of the Company
through written notice and that (iii) this Total Cancellation Amount has not been disputed
in writing by any shareholder of the Company within 3 (three) days following receipt of the
written notice from the board of managers or the sole manager (as the case may be).

Interim Accounts

means the interim accounts of the Company, including a profit and loss account made in
accordance with Luxembourg generally accepted accounting principles, as at the relevant
Interim Account Date.

Interim Account Date

means the date no earlier than 8 (eight) days before the date of the repurchase and
cancellation of the relevant Class of Corporate Units.

<i>Eighth resolution:

The Sole Shareholder resolves to create a new article 20 of the articles of association of the Company to be read as

follows:

“ Art. 20. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the

reserve required by Commercial Companies Law. That allocation to the legal reserve will cease to be required as soon and
as long as the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be)

shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of, (i) by allocating the whole or part of the
remainder to a reserve or to a provision, (ii) by carrying it forward to the next following financial year or (iii) by distributing
it, together with carried forward profits, distributable reserves to the shareholders or sole shareholder (as the case may be).

In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available

reserves derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect shall be distributed
in the following order of priority:

- First, the holders of Class A Corporate Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such

year in an amount of zero point sixty per cent (0.60%) of the nominal value of the Class A Corporate Units held by them,
then,

- the holders of Class B Corporate Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in

an amount of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the nominal value of the Class B Corporate Units held by them, then,

- the holders of Class C Corporate Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in

an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class C Corporate Units held by them, then,

- the holders of Class D Corporate Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in

an amount of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class D Corporate Units held by them,
then,

- the holders of Class E Corporate Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in

an amount of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the Class E Corporate Units held by them, then,

- the holders of Class F Corporate Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in

an amount of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class F Corporate Units held by them,
then

- the holders of Class G Corporate Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in

an amount of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the Class G Corporate Units held by them, then

- the holders of Class H Corporate Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in

an amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class H Corporate Units held by them,
and then

- the holders of Class I Corporate Units shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
Should the whole last outstanding Class of Corporate Units (by alphabetical order, e.g. Class I Corporate Units) have

been cancelled following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any
dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding Class of Corporate Units in the reverse
alphabetical order (e.g. initially Class H Corporate Units) in addition to the initial dividend distribution rights of such Class
of Corporate Units as above set forth.”

76278

L

U X E M B O U R G

<i>Ninth resolution:

The Sole Shareholder resolves to amend article 21, formerly article 20, of the articles of association so as to be read as

follows:

“ Art. 21. Subject to the provisions of article 20 above of these articles of association, interim dividends may be distri-

buted, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the board of managers,
2. These accounts show sufficient distributable funds it being understood that the amount to be distributed may not

exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves,
less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the law or these articles of
association,

3. The decision to pay interim dividends is taken by the general meeting of the members or the sole member (as the case

may be),

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.”

<i>Tenth resolution:

The Sole Shareholder resolves to insert a new third paragraph to article 22, formerly article 21, of the articles of asso-

ciation of the Company so as to be read as follows:

“ Art. 22. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be

members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

After  payment  of  all  the  debts  of  and  charges  against  the  Company,  including  the  expenses  of  liquidation,  the  net

liquidation proceeds shall be distributed to the members or the sole member (as the case may be) so as to achieve on an
aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.”

<i>Eleventh resolution:

As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to fully restate the Company’s articles of

association so as to read as follows:

Art. 1. A private limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant

Luxembourg legislation and in particular the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended from
time to time (the “Commercial Companies Law”).

The name of the company is “Edinburgh George Street S.à r.l.” (the “Company”).

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by decision of the board of ma-

nagers.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of

a resolution of an extraordinary general meeting of members or of the sole member (as the case may be) adopted under the
conditions as laid down in article 199 of the Commercial Companies Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in the Grand Duchy of

Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain
a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of
managers of the Company.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the Company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the ac-

quisition of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control, the development and the disposal of such participating interests subject to the provisions of the German Capital
Investment Act (Kapitalanlagegesetzbuch - KAGB).

In  that  framework,  the  Company  shall  not  render  any  activities  which  differ  from  the  activities  which  its  member

TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Germany (“Triuva”) may exercise for the open-ended
real estate investment fund called RAGS - Immo IVG (the “Fund”) in accordance with the KAGB.

76279

L

U X E M B O U R G

In this frame, the Company shall only acquire and hold certain assets (the “Eligible Assets”) as set out below:
(a) interests in other property companies;
(b) residential real estate designated for tenanting, commercial real estate and mixeduse real estate;
(c) real estate under development;
(d) undeveloped real estate designated and suitable for a development in due course in accordance with (b) above;
(e) hereditary building rights (Erbbaurecht) subject to the conditions mentioned in (b) to (d) above;
(f) other real estate and hereditary building rights as well as ownership rights in condominium property, co-ownership

rights, hereditary building rights in condominium property and partial hereditary building rights if a long-term income can
reasonably be expected from the assets;

and any assets, that are necessary for the management of the Eligible Assets held by Triuva for the account of the Fund.
The  Company  is  only  allowed  to  acquire  Eligible  Assets  if  these  have  been  evaluated  prior  to  their  acquisition  in

accordance with the Fund rules.

The Company may borrow funds in any form subject to the provisions of the KAGB. Furthermore, the Company may

develop, promote, manage, lease and sell Eligible Assets located in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The corporate capital of the Company is fixed at GBP 3,245,000 (three million two hundred forty-five thousand

Great Britain pounds) divided into 129,800 (one hundred twenty-nine thousand eight hundred) corporate units with a
nominal value of GBP 25.-(twenty-five Great Britain pounds) each, divided into:

- 1,000 (one thousand) ordinary corporate units, with a nominal value of GBP 25.-(twenty-five Great Britain pounds)

each (the “Ordinary Corporate Units”);

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class A corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-

five Great Britain Pounds) each (the “Class A Corporate Units”);

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class B corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-

five Great Britain Pounds) each (the “Class B Corporate Units”);

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class C corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-

five Great Britain Pounds) each (the “Class C Corporate Units”);

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class D corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-

five Great Britain Pounds) each (the “Class D Corporate Units”);

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class E corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five

Great Britain Pounds) each (the “Class E Corporate Units”);

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class F corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five

Great Britain Pounds) each (the “Class F Corporate Units”);

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class G corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-

five Great Britain Pounds) each (the “Class G Corporate Units”);

- 14,311 (fourteen thousand three hundred eleven) class H corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-

five Great Britain Pounds) each (the “Class H Corporate Units”); and

- 14,312 (fourteen thousand three hundred twelve) class I corporate units, with a nominal value of GBP 25 (twenty-five

Great Britain Pounds) each (the “Class I Corporate Units”).

All the Class A Corporate Units, the Class B Corporate Units, the Class C Corporate Units, the Class D Corporate Units,

the Class E Corporate Units, the Class F Corporate Units, the Class G Corporate Units, the Class H Corporate Units and
the Class I Corporate Units will be collectively referred to as the “Classes of Corporate Units” as the case may be, or
individually as a “Class of Corporate Units”. All the Classes of Corporate Units and the Ordinary Corporate Units will be
collectively referred to as the “corporate units” as the case may be, or individually as a “corporate unit”Art. 6. The capital
may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the Commercial Companies Law.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner an identical voting right and each member has voting rights commensurate

to his shareholding. The corporate units are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per
corporate unit.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. A corporate unit transfer “inter vivos” to non-members

may  only  be  done  in  accordance  with  the  Commercial  Companies  Law.  Any  kind  of  disposition  (Verfügung)  of  the
Company’s shares owned by Triuva, including the transfer of such shares, is subject to the approval of the Fund’s custodian
bank.

Art. 9. The share capital of the Company may be reduced through the repurchase and cancellation of one or more entire

Classes of Corporate Units provided however that the Company may not at any time repurchase and cancel the Ordinary

76280

L

U X E M B O U R G

Corporate Units. In the case of repurchases and cancellations of Classes of Corporate Units such repurchases and cancel-
lations of Classes of Corporate Units shall be made in the following order:

(x) Class I Corporate Units;
(xi) Class H Corporate Units;
(xii) Class G Corporate Units;
(xiii) Class F Corporate Units;
(xiv) Class E Corporate Units;
(xv) Class D Corporate Units;
(xvi) Class C Corporate Units;
(xvii) Class B Corporate Units; and
(xviii) Class A Corporate Units.
Such repurchase of any Class of Corporate Units shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general

meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for the
amendment of the articles of association of the Company.

In the event of a reduction of the share capital of the Company through the repurchase and the cancellation of any Class

of Corporate Units (in the order provided for above), such Class of Corporate Units being redeemed entitles the holders
thereof (pro rata to their holding in such Class of Corporate Units) to such portion of the Total Cancellation Amount as is
determined by the board of managers or the sole manager (as the case may be) and approved by the general meeting of
shareholders or the sole shareholder (as the case may be), and the holders of corporate units of the repurchased and cancelled
Class of Corporate Units shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Corporate Unit
for each corporate unit of the relevant Class of Corporate Units held by them and cancelled.

The Company may redeem its own corporate units within the limits set forth by the Commercial Companies Law.
For the purpose of these articles of association, the capital terms mentioned above shall have the following meaning:

Available Amount

means the total amount of net profits of the Company, including profits made since the end
of the last financial year, for which the annual accounts have been approved, increased by
(i) any freely distributable reserves, including all funds available for distribution plus any
profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, (ii) the
amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class(es)
of 14 Corporate Units to be cancelled, knowing that the amount to be distributed may not
exceed the total available sums for distribution as calculated in accordance with Article 72.2
b) of the Commercial Companies Law, but reduced by (i) any losses (including carried
forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements
of the Commercial Companies Law or of these articles of association, each as set out in the
relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) - (L+ LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits), including profits made since the end of
the last financial year, for which the annual accounts have been approved
P = any freely distributable reserve
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the
Class of Corporate Units to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Commercial
Companies Law or of these articles of association.

Cancellation Value Per
Corporate Unit

shall be an amount calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of
corporate units in issue in the Class of Corporate Units to be repurchased and cancelled.

Total Cancellation
Amount

shall be an amount determined by the board of managers or the sole manager (as the case
may be) in accordance with article 72.2 b) of the Commercial Companies Law and approved
by the general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be)
on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each Class
of Corporate Units shall be the Available Amount of such class as at the time of its
cancellation. Nevertheless the board of managers or the sole manager (as the case may be)
may provide for a Total Cancellation Amount different from the Available Amount provided
however that (i) the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available
Amount, (ii) such different Total Cancellation Amount shall be notified by the board of
managers or the sole manager (as the case may be) to all the shareholders of the Company
through written notice and that (iii) this Total Cancellation Amount has not been disputed

76281

L

U X E M B O U R G

in writing by any shareholder of the Company within 3 (three) days following receipt of the
written notice from the board of managers or the sole manager (as the case may be).

Interim Accounts

means the interim accounts of the Company, including a profit and loss account made in
accordance with Luxembourg generally accepted accounting principles, as at the relevant
Interim Account Date.

Interim Account Date

means the date no earlier than 8 (eight) days before the date of the repurchase and
cancellation of the relevant Class of Corporate Units.

Art. 10. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to

pursue the sealing of property or documents of the Company.

Art. 12. The Company will be managed by at least two managers who need not to be members and who are appointed

by the general meeting of members or the sole member (as the case may be). The managers constitute a board of managers.

The general meeting of members or the sole member (as the case may be) may, at any time and “ad nutum”, remove

and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the law or the articles to the general meeting of members or to the sole member

(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

In dealing with third parties, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object, provided the
terms of these articles shall have been complied with.

The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent

(s) who need not be member(s) or manager(s) of the Company. The board of managers will determine the powers, duties
and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
his/their agency.

Towards third parties, the Company is in all circumstances committed (i) by the signature of any manager in case there

are only two managers or by the joint signature of any two managers in case there are more than two managers or (ii) by
the sole or joint signature(s) of any agent(s) to which powers have been delegated by the board of managers.

In its current relations with any public administration, the Company is validly represented by any one manager, whose

signature legally commits the Company.

The decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers may appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a

casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the
board of managers may be chaired by a manager present and appointed for that purpose. The board of managers may also
appoint a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by any one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the

time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the
meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other

suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or any other

electronic means any another manager as his/her/its proxy.

A manager may represent more than one manager.
The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable tele-

communication  means  allowing  all  persons  participating  in  the  meeting  to  hear  each  other  at  the  same  time.  Such
participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the board of managers.

The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented.
Decisions of the board of managers are adopted by the majority of the managers participating to the meeting or duly

represented thereto.

76282

L

U X E M B O U R G

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or any manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or any manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a managers'

meeting. In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents
having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other

suitable telecommunication means.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the Company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy. If all members are present or represented
at a general meeting and state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the general meeting may be
held without prior notice.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the Commercial

Companies Law.

Art. 16. A sole member exercises alone the powers devolved to the meeting of members. Resolutions of the sole member

are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Art. 17. The business year begins on January 1 

st

 and ends on December 31 

st

 . The first business year begins with the

incorporation of the Company and ends on December 31 

st

 2016 being a prolonged business year.

Art. 18. Every year as of December 31 

st

 the annual accounts are drawn up by the board of managers and will be audited

by an auditor (“réviseurs d'entreprises agréé”) to be appointed by the general meeting of members or the sole member (as
the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate(s); the first annual accounts to be audited
are the ones as of December 31 

st

 , 2016.

Art. 19. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company in accordance

with the Commercial Companies Law.

Art. 20. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve

required by the Commercial Companies Law. That allocation to the legal reserve will cease to be required as soon and as
long as the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be)

shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of, (i) by allocating the whole or part of the
remainder to a reserve or to a provision, (ii) by carrying it forward to the next following financial year or (iii) by distributing
it, together with carried forward profits, distributable reserves to the shareholders or sole shareholder (as the case may be).

In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available

reserves derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect shall be distributed
in the following order of priority:

- First, the holders of Class A Corporate Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such

year in an amount of zero point sixty per cent (0.60%) of the nominal value of the Class A Corporate Units held by them,
then,

- the holders of Class B Corporate Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in

an amount of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the nominal value of the Class B Corporate Units held by them, then,

- the holders of Class C Corporate Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in

an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class C Corporate Units held by them, then,

- the holders of Class D Corporate Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in

an amount of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class D Corporate Units held by them,
then,

- the holders of Class E Corporate Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in

an amount of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the Class E Corporate Units held by them, then,

- the holders of Class F Corporate Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in

an amount of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class F Corporate Units held by them,
then

- the holders of Class G Corporate Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in

an amount of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the Class G Corporate Units held by them, then

- the holders of Class H Corporate Units shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in

an amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class H Corporate Units held by them,
and then

76283

L

U X E M B O U R G

- the holders of Class I Corporate Units shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
Should the whole last outstanding Class of Corporate Units (by alphabetical order, e.g. Class I Corporate Units) have

been cancelled following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any
dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding Class of Corporate Units in the reverse
alphabetical order (e.g. initially Class H Corporate Units) in addition to the initial dividend distribution rights of such Class
of Corporate Units as above set forth.

Art. 21. Subject to the provisions of article 20 above of these articles of association, interim dividends may be distributed,

at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the board of managers,
2. These accounts show sufficient distributable funds it being understood that the amount to be distributed may not

exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves,
less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the law or these articles of
association,

3. The decision to pay interim dividends is taken by the general meeting of the members or the sole member (as the case

may be),

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.

Art. 22. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be

members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

After  payment  of  all  the  debts  of  and  charges  against  the  Company,  including  the  expenses  of  liquidation,  the  net

liquidation proceeds shall be distributed to the members or the sole member (as the case may be) so as to achieve on an
aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Art. 23. If, and as long as one member holds all the corporate units, the Company shall exist as a single member company,

pursuant to article 179 (2) of the Commercial Companies Law; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the
same law are applicable.

Art. 24. Any amendment of these articles and any disposition (Verfügung) of the Eligible Assets including sale and

encumbrances during the time of (direct or indirect) ownership of any of the Company shares by Triuva requires the approval
of the Fund’s custodian bank.

Art. 25. For anything not dealt with in the present articles, the members refer to the relevant legislation.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, she signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version shall prevail.

Follows the german translation of the above text:

Am neunzehnten Januar zweitausend und sechszehn.
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Jacques Kesseler, mit dem Amtssitz in Pétange, Großherzogtum Luxemburg,

erschien:

TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in Frankfurt am Main und einge-

tragener Geschäftsadresse in 60549 Frankfurt am Main, THE SQUAIRE 18, Am Flughafen, Deutschland, registriert im
Handelsregister B des Amtsgericht Frankfurt am Main unter HRB 91062, handelnd für Rechnung des Immobiliensonder-
vermögens RAGS - Immo IVG (die „Alleingesellschafterin“),

wirksam  vertreten  von  Frau  Sofia  Afonso-Da  Chao  Conde,  Notariatsangestellte,  mit  Geschäftsadresse  in  Pétange,

Großherzogtum Luxemburg, handelnd aufgrund Vollmacht.

Diese Vollmacht durch den Bevollmächtigten, handelnd für die erschienene Partei, und dem Notar als “ne varietur”

gezeichnet, wird dieser Urkunde für Eintragungszwecke beigefügt.

Die erschienene Patei, vertreten wie oben angegeben, bat den unterzeichnenden Notar um die Beurkundung des Fol-

genden:

I. Die erschienene Partei ist die Alleingesellschafterin der Edinburgh George Street S. à r.l., einer Gesellschaft mit

beschränkter Haftung (société á responsabilité limitée), die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, mit

76284

L

U X E M B O U R G

eingetragenem Gesellschaftssitz in 14, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen
im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (“Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg”) unter der
Nummer R.C.S. Luxemburg B 202.989 (die “Gesellschaft”), gegründet gemäß Urkunde ausgefertigt durch den unter-
zeichnender  Notar  am  29.  Dezember  2015,  bisher  noch  nicht  veröffentlicht  im  “Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations”.

Die Satzung der Gesellschaft wurde seit Gründung der Gesellschaft nicht geändert.
II. Die 1,000 (ein tausend) Gesellschaftsanteile im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling), die das

gesamte Stammkapital der Gesellschaft darstellen, sind vertreten, so dass die Gesellschafterversammlung beschlussfähig
ist im Hinblick auf sämtliche Tagesordnungspunkte der nachstehenden Agenda, über die der Alleingesellschafter vorab
ordnungsgemäß unterrichtet wurde, was er hiermit ausdrücklich bestätigt.

III. Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Verzicht auf das Recht der Benachrichtigung;
2.  Erhöhung  des  Stammkapitals  der  Gesellschaft  um  einen  Betrag  von  GBP  3,220,000  (dreimillionenzweihundert-

zwanzigtausend Pfund Sterling), um das Gesellschaftskapital von dem derzeitigen Betrag von GBP 25,000 (fünfundzwan-
zigtausend Pfund Sterling) auf GBP 3,245,000 (drei millionenzweihundertfünfundvierzigtausend Pfund Sterling) durch
Ausgabe von 128,800 (einhundertachtundzwanzigtausendachthundert) neuer Gesellschaftsanteile im Nennwert von je GBP
25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling) zu erhöhen;

3. Zeichnung und Zahlung der neuen Gesellschaftsanteile durch TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, han-

delnd für Rechnung des RAGS - Immo IVG, eines deutschen Immobiliensondervermögens, durch Bareinzahlung;

4. Neue Zusammensetzung des Gesellschaftsanteilsbestandes;
5. Änderung des Artikels 5 der Satzung als Folge der vorangegangenen Beschlüsse;
6. Änderung des Artikels 5 der Satzung, um (i) 1 (eine) Klasse von Stammgesellschaftsanteilen und (ii) 9 (neun) al-

phabetische Klassen von Gesellschaftsanteilen zu schaffen und nachfolgende Umklassifizierung aller ausgegebener und
ausstehender Gesellschaftsanteile der Gesellschaft;

7. Änderung des Artikels 9 der Satzung;
8. Schaffung eines neuen Artikel 20 der Satzung;
9. Änderung des Artikels 21 der Satzung, bisher Artikel 20 der Satzung;
10. Ergänzung eines neuen dritten Absatzes des Artikels 22, bisher Artikel 21 der Satzung;
11. Zustimmung zur vollständigen Neufassung der Satzung als Folge der vorangegangenen Beschlüsse, und
12. Sonstiges.
Nach Zustimmung der Alleingesellschafterin zum Vorangegangenen wurden folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss:

Die Alleingesellschafterin beschließt, auf ihr Recht auf vorherige Benachrichtigung über die aktuelle Gesellschafter-

versammlung zu verzichten; die Alleingesellschafterin bestätigt, zur Tagesordnung ausreichend unterrichtet worden zu
sein, und hält die Gesellschafterversammlung für ordnungsgemäß einberufen und erklärt sich daher einverstanden, zu allen
Tagesordnungspunkten zu beraten und abzustimmen. Es wurde des Weiteren beschlossen, dass alle relevanten Dokumente
der Alleingesellschafterin innerhalb eines Zeitrahmens zur Verfügung gestellt wurden, der es der Alleingesellschafterin
ermöglicht, jedes Dokument sorgfältig zu prüfen.

<i>Zweiter Beschluss:

Die  Alleingesellschafterin  beschließt  die  Erhöhung  des  Stammkapitals  der  Gesellschaft  um  einen  Betrag  von  GBP

3,220,000 (dreimillionenzweihundertzwanzigtausend Pfund Sterling), um das Gesellschaftskapital von dem derzeitigen
Betrag von GBP 25,000 (fünfundzwanzigtausend Pfund Sterling) auf GBP 3,245,000 (drei millionenzweihundertfünfund-
vierzigtausend Pfund Sterling) durch Ausgabe von 128,800 (einhundretachtundzwanzigtausendachthundert) neuer Gesell-
schaftsanteile im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling) zu erhöhen („Neue Gesellschaftsanteile“).

<i>Dritter Beschluss:

Die Alleingesellschafterin beschließt die Annahme der Zeichnung und Zahlung der Neuen Gesellschaftsanteile durch

die Alleingesellschafterin durch eine Bareinzahlung in Höhe von GBP 3,220,000 (dreimillionenzweihundertzwanzigtau-
send Pfund Sterling) (die „Einzahlung“).

Ein Nachweis über die Einzahlung wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht.

<i>Vierter Beschluss:

Als Folge der vorstehenden Erklärungen und Beschlüsse setzt sich der Gesellschaftsanteilsbestand nun wie folgt zu-

sammen:

76285

L

U X E M B O U R G

- TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, handelnd für Rechnung des RAGS -Immo IVG: 129,800 (einhun-

dertneunundzwanzigtausendachthundert) Gesellschaftsanteile.

Der unterzeichnende Notar stellt fest, dass alle 129,800 (einhundertneunundzwanzigtausendachthundert) Gesellschafts-

anteile, die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft darstellen, vertreten sind, so dass die Gesellschafterversammlung
ordnungsgemäß die folgenden Beschlüsse fassen kann.

<i>Fünfter Beschluss:

Als Folge der vorstehenden Erklärungen und Beschlüsse und vollständig getätigten Einzahlung beschließt die Allein-

gesellschafterin, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft gemäß nachfolgendem Wortlaut zu ändern:

„  Art. 5.  Das  Gesellschaftskapital  beträgt  GBP  3,245,000  (drei  Millionen  zweihundertfünfundvierzigtausend  Pfund

Sterling), aufgeteilt in 129,800 (einhundertneunundzwanzigtausendachthundert) Gesellschaftsanteile im Nennwert von je
GBP 25.- (fünfundzwanzig Pfund Sterling).“

Es werden keine weiteren Änderungen zu diesem Artikel vorgenommen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Formalitäten gemäß Artikel 23 der Satzung der Gesellschaft ordnungsgemäß erfüllt

sind.

<i>Sechster Beschluss:

Die Alleingesellschafterin beschließt die Schaffung (i) 1 (einer) Klasse von Stammgesellschaftsanteilen und (ii) 9 (neun)

alphabetischen Klassen von Gesellschaftsanteilen im Stammkapital der Gesellschaft und nachfolgende Umklassifizierung
aller ausgegebener und ausstehender Gesellschaftsanteile der Gesellschaft wie folgt:

- 1.000 (eintausend) Gesellschaftsanteile im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling) werden um-

klassifiziert in 1.000 (eintausend) Stammgesellschaftsanteile im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund

Sterling) werden umklassifiziert in 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile Klasse A im Nennwert
von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund

Sterling) werden umklassifiziert in 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile Klasse B im Nennwert
von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund

Sterling) werden umklassifiziert in 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile Klasse C im Nennwert
von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund

Sterling) werden umklassifiziert in 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile Klasse D im Nennwert
von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund

Sterling) werden umklassifiziert in 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile Klasse E im Nennwert von
je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund

Sterling) werden umklassifiziert in 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile Klasse F im Nennwert von
je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund

Sterling) werden umklassifiziert in 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile Klasse G im Nennwert
von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund

Sterling) werden umklassifiziert in 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile Klasse H im Nennwert
von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling); und

- 14,312 (vierzehntausenddreihundertzwölf) Gesellschaftsanteile im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund

Sterling) werden umklassifiziert in 14,312 (vierzehntausenddreihundertzwölf) Gesellschaftsanteile Klasse I im Nennwert
von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling).

Als Folge der vorstehenden Erklärungen und Beschlüsse setzt sich der Gesellschaftsanteilsbestand nun wie folgt zu-

sammen:

TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, handelnd für Rechnung des RAGS -Immo IVG::
- 1,000 (eintausend) Stammgesellschaftsanteile im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling);
- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile Klasse A im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile Klasse B im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling);

76286

L

U X E M B O U R G

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile Klasse C im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile Klasse D im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile Klasse E im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile Klasse F im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile Klasse G im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile Klasse H im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling); und

- 14,312 (vierzehntausenddreihundertzwölf) Gesellschaftsanteile Klasse I im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling).

Als Ergebnis der vorstehenden Beschlüsse beschließt die Alleingesellschafterin, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft

gemäß nachfolgendem Wortlaut zu ändern:

„  Art. 5.  Das  Gesellschaftskapital  beträgt  GBP  3,245,000  (drei  Millionen  zweihundertfünfundvierzigtausend  Pfund

Sterling), aufgeteilt in 129,800 (einhundertneunundzwanzigtausendachthundert) Gesellschaftsanteile im Nennwert von je
GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling), unterteilt in:

- 1.000 (eintausend) Stammgesellschaftsanteile im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling) (die

„Stammgesellschaftsanteile“);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile Klasse A im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling) (die „Gesellschaftsanteile Klasse A“);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschafts-anteile Klasse B im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling) (die „Gesellschaftsanteile Klasse B“);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschafts-anteile Klasse C im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling) (die „Gesellschaftsanteile Klasse C“);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschafts-anteile Klasse D im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling) (die „Gesellschaftsanteile Klasse D“);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschafts-anteile Klasse E im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling) (die „Gesellschaftsanteile Klasse E“);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschafts-anteile Klasse F im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling) (die „Gesellschaftsanteile Klasse F“);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschafts-anteile Klasse G im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling) (die „Gesellschaftsanteile Klasse G“);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschafts-anteile Klasse H im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling) (die „Gesellschaftsanteile Klasse H“); und

- 14,312 (vierzehntausenddreihundertzwölf) Gesellschafts-anteile Klasse I im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwan-

zig Pfund Sterling) (die „Gesellschaftsanteile Klasse I“);

Alle Gesellschaftsanteile Klasse A, Gesellschaftsanteile Klasse B, Gesellschaftsanteile Klasse C, Gesellschaftsanteile

Klasse D, Gesellschaftsanteile Klasse E, Gesellschaftsanteile Klasse F, Gesellschaftsanteile Klasse G, Gesellschaftsanteile
Klasse H und Gesellschaftsanteile Klasse I werden zusammen als die „Klassen von Gesellschaftsanteilen“ oder einzeln als
eine „Klasse von Gesellschaftsanteilen“ bezeichnet. Alle Klassen von Gesellschaftsanteilen und die Stammgesellschafts-
anteile werden zusammen als die „Gesellschaftsanteile“ oder einzeln als ein „ Gesellschaftsanteil“ bezeichnet.“

<i>Siebter Beschluss:

Die Alleingesellschafterin beschließt, Artikel 9 der Satzung der Gesellschaft gemäß nachfolgendem Wortlaut zu ändern:

„ Art. 9. Das Gesellschaftskapital kann durch Rückkauf und Annullierung einer oder mehrerer gesamter Klassen von

Gesellschaftsanteilen herabgesetzt werden, jedoch unter der Bedingung, dass die Gesellschaft zu keinem Zeitpunkt die
Stammgesellschaftsanteile zurückkaufen und annullieren kann. Im Falle des Rückkaufs und der Annullierung der Klassen
von Gesellschaftsanteilen erfolgt dieser Rückkauf und diese Annullierung der Klassen von Gesellschaftsanteilen in der
nachstehenden Reihenfolge:

(i) Gesellschaftsanteile Klasse I;
(ii) Gesellschaftsanteile Klasse H;
(iii) Gesellschaftsanteile Klasse G;
(iv) Gesellschaftsanteile Klasse F;
(v) Gesellschaftsanteile Klasse E;

76287

L

U X E M B O U R G

(vi) Gesellschaftsanteile Klasse D;
(vii) Gesellschaftsanteile Klasse C;
(viii) Gesellschaftsanteile Klasse B; und
(ix) Gesellschaftsanteile Klasse A.
Ein solcher Rückkauf einer Klasse von Gesellschaftsanteilen erfolgt durch Beschluss einer außerordentlichen General-

versammlung  der  Gesellschafter  bzw.  der  alleinigen  Gesellschafterin,  der  gemäß  den  für  eine  Satzungsänderung  der
Gesellschaft vorgeschriebenen Bedingungen verabschiedet wird.

Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals durch den Rückkauf und die Annullierung von Gesellschaftsan-

teilen (in der vorstehend angegebenen Reihenfolge) berechtigt eine solche einzuziehende Klasse von Gesellschaftsanteilen
die Inhaber derselben (anteilig zu ihrer Beteiligung an dieser Klasse von Gesellschaftsanteilen) zu dem Anteil am annul-
lierten Gesamtbetrag, der vom Geschäftsführerrat bzw. dem alleinigen Geschäftsführer festgelegt und von der General-
versammlung  der  Gesellschafter  bzw.  der  alleinigen  Gesellschafterin  genehmigt  wurde,  und  die  Inhaber  von
Gesellschaftsanteilen der zurückgekauften und annullierten Klasse von Gesellschaftsanteilen erhalten von der Gesellschaft
einen dem Annullierungswert entsprechenden Betrag je Gesellschaftsanteil für jeden annullierten und von ihnen gehaltenen
Gesellschaftsanteil der betreffenden Klasse von Gesellschaftsanteilen.

Die  Gesellschaft  kann  ihre  eigenen  Gesellschaftsanteile  in  dem  im  Gesetz  über  Handelsgesellschaften  festgelegten

Umfang einziehen.

Für die Zwecke dieser Satzung haben die vorgenannten als definiert gekennzeichneten Begriffe folgende Bedeutung:

Verfügbarer Betrag

bezeichnet den Gesamtbetrag der Nettogewinne der Gesellschaft, einschließlich der
Gewinne, die seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss
genehmigt wurde, erzielt wurden, erhöht um (i) frei ausschüttbare Rücklagen, einschließlich
aller zur Ausschüttung verfügbaren Mittel zuzüglich aller Gewinnvorträge und Beträge, die
zu diesem Zweck aus den verfügbaren Rücklagen entnommen werden, (ii) den Betrag der
Herabsetzung des Gesellschaftskapitals und der Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage
für die zu annullierende(n) Klasse(n) von Gesellschaftsanteilen, wobei bekannt ist, dass der
auszuschüttende Betrag nicht höher sein kann als die Summe der zur Ausschüttung
verfügbaren Beträge, berechnet gemäß Artikel 72.2 Buchstabe b) des Gesetzes über
Handelsgesellschaften, jedoch vermindert um (i) alle Verluste (einschließlich
Verlustvorträgen) und (ii) alle gemäß den gesetzlichen
Anforderungen bzw. den Anforderungen dieser Satzung in die Rücklage(n) einzustellenden
Beträge, jeweils gemäß dem betreffenden Zwischenabschluss (zur Klarstellung ohne
Doppelerfassung), so dass:
AA = (NP + P+ CR) - (L+ LR)
Darin bedeuten:
AA = Verfügbarer Betrag
NP = Nettogewinne (einschließlich Gewinnvorträgen), einschließlich der Gewinne, die seit
dem Ende des letzten Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss genehmigt wurde, erzielt
wurden
P = jede frei ausschüttbare Rücklage
CR = der Betrag der Herabsetzung des Gesellschaftskapitals und der Herabsetzung der
gesetzlichen Rücklage für die zu annullierende(n) Klasse(n) von Gesellschaftsanteilen,
L = Verluste (einschließlich Verlustvorträgen)
LR = alle gemäß den Vorschriften des Gesetzes über Handelsgesellschaften oder den
Vorschriften dieser Satzung in die Rücklage(n) einzustellenden Beträge.

Annullierungswert je

Gesellschaftsanteil

bezeichnet einen Betrag, der berechnet wird durch Division des annullierten Gesamtbetrages
durch die Anzahl der Gesellschaftsanteile, die in der zurückzukaufenden und zu
annullierenden Klasse von Gesellschaftsanteilen ausgegeben wurden.

Annullierter
Gesamtbetrag

ist ein Betrag auf der Grundlage des betreffenden Zwischenabschlusses, der vom
Geschäftsführerrat bzw. dem alleinigen Geschäftsführer gemäß Artikel 72.2 Buchstabe b)
des Gesetzes über Handelsgesellschaften festgelegt und von der Generalversammlung der
Gesellschafter bzw. der alleinigen Gesellschafterin genehmigt wird. Der Annullierte
Gesamtbetrag für jede Klasse von Gesellschaftsanteilen ist der Verfügbare Betrag dieser
Klasse zum Zeitpunkt seiner Annullierung. Der Geschäftsführerrat bzw. der alleinige
Geschäftsführer kann dennoch einen vom Verfügbaren Betrag abweichenden Annullierten
Gesamtbetrag vorsehen, soweit (i) der Annullierte Gesamtbetrag niemals höher ist als der
betreffende Verfügbare Betrag, (ii) dieser abweichende Annullierte Gesamtbetrag vom
Geschäftsführerrat bzw. dem alleinigen Geschäftsführer allen Gesellschaftern der
Gesellschaft schriftlich mitgeteilt wird und (iii) dieser Annullierte Gesamtbetrag nicht
innerhalb von 3 (drei) Tagen nach Zugang der schriftlichen Mitteilung vom
Geschäftsführerrat bzw. dem alleinigen Geschäftsführer von einem Gesellschafter der

76288

L

U X E M B O U R G

Gesellschaft schriftlich angefochten wird.

Zwischenabschluss

bezeichnet den Zwischenabschluss der Gesellschaft, einschließlich einer nach den in
Luxemburg geltenden Grundsätzen ordnungsmäßiger Rechnungslegung erstellten
Gewinn- und Verlustrechnung, zum betreffenden Stichtag des Zwischenabschlusses.

Stichtag des
Zwischenabschlusses

bezeichnet das Datum frühestens 8 (acht) Tage vor dem Datum des Rückkaufs und der
Annullierung der betreffenden Klasse von Gesellschaftsanteilen.“

<i>Achter Beschluss:

Die Alleingesellschafterin beschließt die Schaffung eines neuen Artikel 20 der Satzung der Gesellschaft gemäß nach-

folgendem Wortlaut:

„ Art. 20. Vom Jahresnettogewinn der Gesellschaft sind mindestens fünf Prozent (5%) jährlich für die Bildung einer

Rücklage entsprechend dem Gesetz über Handelsgesellschaften zu verwenden. Diese Einstellung in die gesetzliche Rück-
lage  ist  nicht  mehr  erforderlich,  wenn  und  solange  die  gesetzliche  Rücklage  zehn  Prozent  (10%)  des  ausgegebenen
Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Nach der Einstellung in die gesetzliche Rücklage entscheidet die Generalversammlung der Gesellschafter bzw. die

alleinige Gesellschafterin über die Verwendung des übrigen Jahresnettogewinns (i) durch Einstellung des Restbetrages
ganz oder teilweise in eine Rücklage oder eine Rückstellung, (ii) durch Gewinnvortrag auf das darauf folgende Geschäfts-
jahr oder (iii) durch Ausschüttung, zusammen mit den ausschüttbaren Rücklagen und Gewinnvorträgen an die Gesell-
schafter bzw. die alleinige Gesellschafterin.

In jedem Jahr, in dem die Gesellschaft die Ausschüttung von Dividenden beschließt, die aus dem Nettogewinn und den

verfügbaren Rücklagen aus einbehaltenen Gewinnen einschließlich Agiorücklagen entnommen werden, wird der hierfür
ausgeschüttete Betrag in folgender Reihenfolge ausgeschüttet:

-  Zunächst  haben  die  Inhaber  von  Gesellschaftsanteilen  Klasse  A  Anspruch  auf  Dividendenausschüttungen  für  das

betreffende  Jahr  in  Höhe  von  null  Komma  sechzig  Prozent  (0,60%)  des  Nennwerts  der  von  ihnen  gehaltenen  Gesell-
schaftsanteile Klasse A, und dann

- haben die Inhaber von Gesellschaftsanteilen Klasse B Anspruch auf Dividendenausschüttungen für das betreffende

Jahr in Höhe von null Komma fünfundfünfzig Prozent (0,55%) des Nennwerts der von ihnen gehaltenen Gesellschaftsan-
teile Klasse B, und dann

- haben die Inhaber von Gesellschaftsanteilen Klasse C Anspruch auf Dividendenausschüttungen für das betreffende

Jahr in Höhe von null Komma fünfzig Prozent (0,50%) des Nennwerts der von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteile Klasse
C, und dann

- haben die Inhaber von Gesellschaftsanteilen Klasse D Anspruch auf Dividendenausschüttungen für das betreffende

Jahr in Höhe von null Komma fünfundvierzig Prozent (0,45%) des Nennwerts der von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteile
Klasse D, und dann

- haben die Inhaber von Gesellschaftsanteilen Klasse E Anspruch auf Dividendenausschüttungen für das betreffende

Jahr in Höhe von null Komma vierzig Prozent (0,40%) des Nennwerts der von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteile Klasse
E, und dann

- haben die Inhaber von Gesellschaftsanteilen Klasse F Anspruch auf Dividendenausschüttungen für das betreffende

Jahr in Höhe von null Komma fünfunddreißig Prozent (0,35%) des Nennwerts der von ihnen gehaltenen Gesellschaftsan-
teile Klasse F, und dann

- haben die Inhaber von Gesellschaftsanteilen Klasse G Anspruch auf Dividendenausschüttungen für das betreffende

Jahr in Höhe von null Komma dreißig Prozent (0,30%) des Nennwerts der von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteile Klasse
G, und dann

- haben die Inhaber von Gesellschaftsanteilen Klasse H Anspruch auf Dividendenausschüttungen für das betreffende

Jahr in Höhe von null Komma fünfundzwanzig Prozent (0,25%) des Nennwerts der von ihnen gehaltenen Gesellschafts-
anteile Klasse H, und dann

- haben die Inhaber von Gesellschaftsanteilen Klasse I Anspruch auf den Rest der Dividendenausschüttungen.
Sollte die gesamte letzte ausstehende Klasse von Gesellschaftsanteilen (in alphabetischer Reihenfolge, z.B. Gesell-

schaftsanteile Klasse I) nach ihrer Einziehung, ihrem Rückkauf oder anderweitig zum Zeitpunkt der Ausschüttung annulliert
worden sein, wird der Rest einer Dividendenausschüttung zusätzlich zu den vorstehend angegebenen ursprünglichen Di-
videndenausschüttungsansprüchen der betreffenden Klasse von Gesellschaftsanteilen der vorangegangenen letzten aus-
stehenden Klasse von Gesellschaftsanteilen in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge (z.B. zunächst Gesellschaftsanteile
Klasse H) zugewiesen.“

<i>Neunter Beschluss:

Die Alleingesellschafterin beschließt, Artikel 21 (vormals Artikel 20) der Satzung der Gesellschaft gemäß nachfolgen-

dem Wortlaut zu ändern:

76289

L

U X E M B O U R G

„ Art. 21. Vorbehaltlich der Bestimmungen des vorstehenden Artikels 20 dieser Satzung können Zwischenausschüt-

tungen jederzeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:

1. Der Geschäftsführerrat stellt einen Zwischenabschluss auf,
2. dieser Abschluss weist ausreichend ausschüttbare Mittel auf, wobei der auszuschüttende Betrag nicht den seit Ende

des letzten Geschäftsjahres erzielten Gewinn, zuzüglich dem Gewinnvortrag und den verfügbaren Rücklagen, abzüglich
Verlustvortrag und den kraft Gesetz oder gemäß dieser Satzung vorgeschriebenen und in eine Rücklage einzustellenden
Beträge übersteigen darf,

3. die Entscheidung, eine Zwischenausschüttung auszuzahlen, wird durch die Generalversammlung der Gesellschafter

bzw. die alleinige Gesellschafterin gefasst,

4. die Auszahlung erfolgt, sobald die Gesellschaft die Sicherheit hat, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft

nicht gefährdet sind.“

<i>Zehnter Beschluss:

Die Alleingesellschafterin beschließt, einen neuen dritten Absatz in Artikel 22 (vormals Artikel 21) der Satzung der

Gesellschaft gemäß nachfolgendem Wortlaut zu ergänzen:

„ Art. 22. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter derselben

Beschlussfähigkeit gefasst werden muss wie bei Statutenänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und
Vergütungen ernannt werden.

Nach Zahlung aller Schulden und Kosten der Gesellschaft, einschließlich der Aufwendungen für die Liquidation, wird

der Nettoliquidationserlös an die Gesellschafter bzw. die alleinige Gesellschafterin in der Weise ausgeschüttet, dass ins-
gesamt das gleiche wirtschaftliche Ergebnis wie gemäß den für Dividendenausschüttungen festgelegten Ausschüttungs-
regeln erreicht wird.“

<i>Elfter Beschluss:

Als Folge der vorstehenden Beschlüsse beschließt die Alleingesellschafterin die vollständige Neufassung der Satzung

gemäß nachfolgendem Wortlaut:

„ Art. 1. Hiermit wird eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die durch diese Statuten sowie die

einschlägige luxemburgische Gesetzgebung und insbesondere durch das Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10. Au-
gust 1915 in der jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz über Handelsgesellschaften“) geregelt wird.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Edinburgh George Street S.à r.l.“ (die „Gesellschaft“).

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft liegt in Luxemburg-Stadt.
Der Sitz kann innerhalb der Kommune von Luxemburg-Stadt durch Beschluss des Geschäftsführerrates verlegt werden.
Der Sitz kann durch einen nach den in Artikel 199 des Gesetzes über Handelsgesellschaften festgelegten Bedingungen

verabschiedeten Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter bzw. der alleinigen Gesell-
schafterin an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg oder im Ausland verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen (unabhängig davon, ob mit oder ohne ständige Niederlassung)

sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland haben.

Für den Fall, dass der Geschäftsführerrat beschließen sollte, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder

soziale Entwicklungen eingetreten sind oder einzutreten drohen, welche die üblichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem
Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Büro und Personen im Ausland an ihrem Sitz beeinträchtigen
würden, kann der Sitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese außerge-
wöhnlichen Umstände vollständig weggefallen sind; diese vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die
Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes eine luxemburgische Gesellschaft
bleiben wird. Diese vorübergehenden Maßnahmen werden beteiligten Dritten durch den Geschäftsführerrat der Gesellschaft
zur Kenntnis gebracht und dieser wird die beteiligten Dritten darüber informieren.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4.  Die  Gesellschaft  hat  zum  Zweck,  alle  Tätigkeiten  auszuüben,  welche  direkt  oder  indirekt  zum  Erwerb  von

Beteiligungen in jeglicher Form an beliebigen Unternehmen führen, sowie die Verwaltung, Leitung, Kontrolle, Entwick-
lung und Veräußerung dieser Beteiligungen, vorbehaltlich der Bestimmungen des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches
(„KAGB“).

In diesem Rahmen darf die Gesellschaft keine Tätigkeiten erbringen, die von denen abweichen, die ihre Gesellschafterin,

die TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland („Triuva“), für das offene Immobi-
lien-Sondervermögen RAGS - Immo IVG („Fonds“) gemäß dem KAGB ausüben darf.

In diesem Rahmen darf die Gesellschaft nur die folgenden Vermögensgegenstände erwerben und halten („zulässige

Vermögensgegenstände“):

76290

L

U X E M B O U R G

(a) Anteile an Immobilien-Gesellschaften;
(b) Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke;
(c) Grundstücke im Zustand der Bebauung;
(d) unbebaute Grundstücke, die für eine alsbaldige eigene Bebauung nach Maßgabe von (b) oben bestimmt und geeignet

sind;

(e) Erbbaurechte unter den Voraussetzungen von (b) bis (d) oben;
(f) andere Grundstücke und andere Erbbaurechte sowie Rechte in Form des Wohnungseigentums, Teileigentums, Woh-

nungserbbaurechts und Teilerbbaurechts, wenn hiervon ein dauernder Ertrag erwartet werden kann;

und alle Gegenstände, die zur Bewirtschaftung der von Triuva für Rechnung des Fonds gehaltenen zulässigen Vermö-

gensgegenstände erforderlich sind.

Die Gesellschaft darf zulässige Vermögensgegenstände nur erwerben, wenn diese vor deren Erwerb entsprechend dem

Fondsvertragswerk bewertet wurden.

Die Gesellschaft kann Kredite in jeglicher Form aufnehmen vorbehaltlich der Bestimmungen des KAGB. Die Gesell-

schaft  darf  außerdem  im  Großherzogtum  Luxemburg  oder  im  Ausland  belegene  zulässige  Vermögensgegenstände
entwickeln, fördern, verwalten, vermieten und veräußern.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,

die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt GBP 3,245,000 (drei Millionen zweihundertfünfundvierzigtausend Pfund Ster-

ling), aufgeteilt in 129,800 (einhundertneunundzwanzigtausendachthundert) Gesellschaftsanteile im Nennwert von je GBP
25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling), unterteilt in:

- 1.000 (eintausend) Stammgesellschaftsanteile im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig Pfund Sterling) (die

„Stammgesellschaftsanteile“);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschaftsanteile Klasse A im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling) (die „Gesellschaftsanteile Klasse A“);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschafts-anteile Klasse B im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling) (die „Gesellschaftsanteile Klasse B“);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschafts-anteile Klasse C im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling) (die „Gesellschaftsanteile Klasse C“);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschafts-anteile Klasse D im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling) (die „Gesellschaftsanteile Klasse D“);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschafts-anteile Klasse E im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling) (die „Gesellschaftsanteile Klasse E“);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschafts-anteile Klasse F im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling) (die „Gesellschaftsanteile Klasse F“);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschafts-anteile Klasse G im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling) (die „Gesellschaftsanteile Klasse G“);

- 14,311 (vierzehntausenddreihundertelf) Gesellschafts-anteile Klasse H im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwanzig

Pfund Sterling) (die „Gesellschaftsanteile Klasse H“); und

- 14,312 (vierzehntausenddreihundertzwölf) Gesellschafts-anteile Klasse I im Nennwert von je GBP 25 (fünfundzwan-

zig Pfund Sterling) (die „Gesellschaftsanteile Klasse I“);

Alle Gesellschaftsanteile Klasse A, Gesellschaftsanteile Klasse B, Gesellschaftsanteile Klasse C, Gesellschaftsanteile

Klasse D, Gesellschaftsanteile Klasse E, Gesellschaftsanteile Klasse F, Gesellschaftsanteile Klasse G, Gesellschaftsanteile
Klasse H und Gesellschaftsanteile Klasse I werden zusammen als die „Klassen von Gesellschaftsanteilen“ oder einzeln als
eine „Klasse von Gesellschaftsanteilen“ bezeichnet. Alle Klassen von Gesellschaftsanteilen und die Stammgesellschafts-
anteile werden zusammen als die „Gesellschaftsanteile“ oder einzeln als ein „ Gesellschaftsanteil“ bezeichnet.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter den in Artikel 199 des Gesetzes über Handelsgesellschaften fest-

gesetzten Bedingungen erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt seinen Anteilseigner zu einem entsprechenden Stimmrecht, und jeder Ge-

sellschafter hat Stimmrechte entsprechend seiner Beteiligung. Die Gesellschaftsanteile sind im Hinblick auf die Gesell-
schaft unteilbar, was nur einen Anteilseigner je Gesellschaftsanteil zulässt.

Art. 8. Zwischen Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Eine Übertragung von Gesellschafts-

anteilen unter Lebenden (inter vivos) an Dritte unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften.
Jede  Verfügung  über  die  von  TRIUVA  gehaltenen  Gesellschaftsanteile  einschließlich  der  Übertragung  dieser  Gesell-
schaftsanteile bedarf der Zustimmung der Verwahrstelle des Fonds.

Art. 9. Das Gesellschaftskapital kann durch Rückkauf und Annullierung einer oder mehrerer gesamter Klassen von

Gesellschaftsanteilen herabgesetzt werden, jedoch unter der Bedingung, dass die Gesellschaft zu keinem Zeitpunkt die

76291

L

U X E M B O U R G

Stammgesellschaftsanteile zurückkaufen und annullieren kann. Im Falle des Rückkaufs und der Annullierung der Klassen
von Gesellschaftsanteilen erfolgt dieser Rückkauf und diese Annullierung der Klassen von Gesellschaftsanteilen in der
nachstehenden Reihenfolge:

(i) Gesellschaftsanteile Klasse I;
(ii) Gesellschaftsanteile Klasse H;
(iii) Gesellschaftsanteile Klasse G;
(iv) Gesellschaftsanteile Klasse F;
(v) Gesellschaftsanteile Klasse E;
(vi) Gesellschaftsanteile Klasse D;
(vii) Gesellschaftsanteile Klasse C;
(viii) Gesellschaftsanteile Klasse B; und
(ix) Gesellschaftsanteile Klasse A.
Ein solcher Rückkauf einer Klasse von Gesellschaftsanteilen erfolgt durch Beschluss einer außerordentlichen General-

versammlung  der  Gesellschafter  bzw.  der  alleinigen  Gesellschafterin,  der  gemäß  den  für  eine  Satzungsänderung  der
Gesellschaft vorgeschriebenen Bedingungen verabschiedet wird.

Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals durch den Rückkauf und die Annullierung von Gesellschaftsan-

teilen (in der vorstehend angegebenen Reihenfolge) berechtigt eine solche einzuziehende Klasse von Gesellschaftsanteilen
die Inhaber derselben (anteilig zu ihrer Beteiligung an dieser Klasse von Gesellschaftsanteilen) zu dem Anteil am annul-
lierten Gesamtbetrag, der vom Geschäftsführerrat bzw. dem alleinigen Geschäftsführer festgelegt und von der General-
versammlung  der  Gesellschafter  bzw.  der  alleinigen  Gesellschafterin  genehmigt  wurde,  und  die  Inhaber  von
Gesellschaftsanteilen der zurückgekauften und annullierten Klasse von Gesellschaftsanteilen erhalten von der Gesellschaft
einen dem Annullierungswert entsprechenden Betrag je Gesellschaftsanteil für jeden annullierten und von ihnen gehaltenen
Gesellschaftsanteil der betreffenden Klasse von Gesellschaftsanteilen.

Die  Gesellschaft  kann  ihre  eigenen  Gesellschaftsanteile  in  dem  im  Gesetz  über  Handelsgesellschaften  festgelegten

Umfang einziehen.

Für die Zwecke dieser Satzung haben die vorgenannten als definiert gekennzeichneten Begriffe folgende Bedeutung:

Verfügbarer Betrag

bezeichnet den Gesamtbetrag der Nettogewinne der Gesellschaft, einschließlich der
Gewinne, die seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss
genehmigt wurde, erzielt wurden, erhöht um (i) frei ausschüttbare Rücklagen, einschließlich
aller zur Ausschüttung verfügbaren Mittel zuzüglich aller Gewinnvorträge und Beträge, die
zu diesem Zweck aus den verfügbaren Rücklagen entnommen werden, (ii) den Betrag der
Herabsetzung des Gesellschaftskapitals und der Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage
für die zu annullierende(n) Klasse(n) von Gesellschaftsanteilen, wobei bekannt ist, dass der
auszuschüttende Betrag nicht höher sein kann als die Summe der zur Ausschüttung
verfügbaren Beträge, berechnet gemäß Artikel 72.2 Buchstabe b) des Gesetzes über
Handelsgesellschaften, jedoch vermindert um (i) alle Verluste (einschließlich
Verlustvorträgen) und (ii) alle gemäß den gesetzlichen Anforderungen bzw. den
Anforderungen dieser Satzung in die Rücklage(n) einzustellenden Beträge, jeweils gemäß
dem betreffenden Zwischenabschluss (zur Klarstellung ohne Doppelerfassung), so dass:
AA = (NP + P+ CR) - (L+ LR)
Darin bedeuten:
AA = Verfügbarer Betrag
NP = Nettogewinne (einschließlich Gewinnvorträgen), einschließlich der Gewinne, die seit
dem Ende des letzten Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss genehmigt wurde, erzielt
wurden
P = jede frei ausschüttbare Rücklage
CR = der Betrag der Herabsetzung des Gesellschaftskapitals und der Herabsetzung der
gesetzlichen Rücklage für die zu annullierende(n) Klasse(n) von Gesellschaftsanteilen,
L = Verluste (einschließlich Verlustvorträgen)
LR = alle gemäß den Vorschriften des Gesetzes über Handelsgesellschaften oder den
Vorschriften dieser Satzung in die Rücklage(n) einzustellenden Beträge.

Annullierungswert je

Gesellschafts-anteil

bezeichnet einen Betrag, der berechnet wird durch Division des annullierten Gesamtbetrages
durch die Anzahl der Gesellschaftsanteile, die in der zurückzukaufenden und zu
annullierenden Klasse von Gesellschaftsanteilen ausgegeben wurden.

Annullierter

Gesamtbetrag

ist ein Betrag auf der Grundlage des betreffenden Zwischenabschlusses, der vom
Geschäftsführerrat bzw. dem alleinigen Geschäftsführer gemäß Artikel 72.2 Buchstabe b)
des Gesetzes über Handelsgesellschaften festgelegt und von der Generalversammlung der
Gesellschafter bzw. der alleinigen Gesellschafterin genehmigt wird. Der Annullierte

76292

L

U X E M B O U R G

Gesamtbetrag für jede Klasse von Gesellschaftsanteilen ist der Verfügbare Betrag dieser
Klasse zum Zeitpunkt seiner Annullierung. Der Geschäftsführerrat bzw. der alleinige
Geschäftsführer kann dennoch einen vom Verfügbaren Betrag abweichenden Annullierten
Gesamtbetrag vorsehen, soweit (i) der Annullierte Gesamtbetrag niemals höher ist als der
betreffende Verfügbare Betrag, (ii) dieser abweichende Annullierte Gesamtbetrag vom
Geschäftsführerrat bzw. dem alleinigen Geschäftsführer allen Gesellschaftern der
Gesellschaft schriftlich mitgeteilt wird und (iii) dieser Annullierte Gesamtbetrag nicht
innerhalb von 3 (drei) Tagen nach Zugang der schriftlichen Mitteilung vom
Geschäftsführerrat bzw. dem alleinigen Geschäftsführer von einem Gesellschafter der
Gesellschaft schriftlich angefochten wird.

Zwischenabschluss

bezeichnet den Zwischenabschluss der Gesellschaft, einschließlich einer nach den in
Luxemburg geltenden Grundsätzen ordnungsmäßiger Rechnungslegung erstellten
Gewinn- und Verlustrechnung, zum betreffenden Stichtag des Zwischenabschlusses.

Stichtag des
Zwischenabschlusses

bezeichnet das Datum frühestens 8 (acht) Tage vor dem Datum des Rückkaufs und der
Annullierung der betreffenden Klasse von Gesellschaftsanteilen.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte der Gesellschafter können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung

des Firmeneigentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch mindestens zwei Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen, geführt.

Diese  werden  von  der  Generalversammlung  der  Gesellschafter  bzw.  der  alleinigen  Gesellschafterin  bestellt.  Die  Ge-
schäftsführer stellen einen Geschäftsführerrat dar.

Die Generalversammlung der Gesellschafter bzw. die alleinige Gesellschafterin können jederzeit und „ad nutum“ Ge-

schäftsführer abberufen oder ersetzen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich kraft Gesetz oder den Statuten der Generalversammlung der Gesellschafter

bzw. der alleinigen Gesellschafterin vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführerrates.

Im Außenverhältnis verfügt der Geschäftsführerrat über sämtliche Befugnisse, um im Namen der Gesellschaft unter

allen Umständen zu handeln und sämtliche mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehenden Handlungen und Tätigkeiten
durchzuführen und diese zu genehmigen, soweit die Bestimmungen dieser Statuten eingehalten werden.

Der Geschäftsführerrat kann von Zeit zu Zeit einem oder mehreren Sonderbevollmächtigten, die nicht Mitglied(er) oder

Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen, für bestimmte Aufgaben Untervollmachten erteilen. Der Geschäftsführerrat
wird die Befugnisse, Pflichten und die Vergütung (sofern vorhanden) seines bzw. seiner Sonderbevollmächtigten, die Dauer
des Vertretungszeitraums und sonstige einschlägige Bedingungen seiner bzw. ihrer Vertretung bestimmen.

Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft unter allen Umständen vertreten (i) im Falle von lediglich zwei Geschäftsfüh-

rern durch die Unterschrift eines Geschäftsführers, oder im Falle von mehr als zwei Geschäftsführern durch die Unterschrift
von zwei gemeinschaftlich handelnden Geschäftsführern oder (ii) durch die Unterschrift eines oder mehrerer Sonderbe-
vollmächtigter, dem / denen Befugnisse durch den Geschäftsführerrat übertragen wurden.

Im laufenden Verkehr mit Behörden wird die Gesellschaft unter allen Umständen durch einen beliebigen Geschäftsführer

vertreten, dessen Unterschrift die Gesellschaft rechtswirksam bindet.

Die Entscheidungen der Geschäftsführer werden vom Geschäftsführerrat getroffen.
Der Geschäftsführerrat kann aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen, der bei Stimmengleichheit keine

ausschlaggebende Stimme hat. Der Vorsitzende hat bei sämtlichen Sitzungen des Geschäftsführerrates den Vorsitz inne.
Sollte der Vorsitzende abwesend sein, kann ein anwesender Geschäftsführer, zu diesem Zweck ernannt, den Vorsitz über-
nehmen. Der Geschäftsführerrat kann auch einen Protokollführer (secretary) ernennen, der nicht Geschäftsführer sein muss
und für die Protokollführung bei den Sitzungen des Geschäftsführerrates oder für eine andere, vom Geschäftsführerrat
festgelegte Angelegenheit verantwortlich ist.

Der Geschäftsführerrat hält eine Sitzung ab, wenn sie von einem Geschäftsführer einberufen wird.
Die Mitteilung einer Sitzung des Geschäftsführerrates erfolgt gegenüber sämtlichen Geschäftsführern mindestens 2

(zwei) Tage vor dem für diese Sitzung angesetzten Termin außer in Notfällen, deren Art im Sitzungsprotokoll darzulegen
ist.

In der Einberufungsmitteilung ist der Zeitpunkt und Ort der Sitzung sowie die Art der zu behandelnden Punkte anzu-

geben.

Einberufungsmitteilungen können gegenüber jedem Geschäftsführer mündlich, schriftlich oder per Fax, Mitteilung über

das Kabelnetz, Telegramm, Fernschreiben, durch elektronische Mittel oder durch sonstige geeignete Telekommunikati-
onsmittel abgegeben werden.

Auf die Mitteilung kann durch schriftliche Zustimmung oder Zustimmung per Fax, Mitteilung über das Kabelnetz,

Telegramm, Fernschreiben, durch elektronische Mittel oder durch sonstige geeignete Telekommunikationsmittel von jedem
Geschäftsführer verzichtet werden.

76293

L

U X E M B O U R G

Die Sitzung wird ordnungsgemäß ohne vorherige Mitteilung abgehalten, wenn sämtliche Geschäftsführer anwesend

oder ordnungsgemäß vertreten sind.

Es ist keine gesonderte Mitteilung für Versammlungen erforderlich, die zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden,

die vorab in einer durch Beschluss des Geschäftsführerrates verabschiedeten Auflistung angegeben wurden.

Geschäftsführer können bei einer Sitzung der Geschäftsführer handeln, indem sie schriftlich oder per Fax, Mitteilung

über das Kabelnetz, Telegramm, Fernschreiben oder durch elektronische Mittel einen anderen Geschäftsführer als seinen /
ihren Bevollmächtigten ernennen.

Ein Geschäftsführer kann mehr als einen Geschäftsführer vertreten.
Die Geschäftsführer können an einer Sitzung des Geschäftsführerrates per Telefon, Videokonferenz oder sonstigem

Telekommunikationsmittel teilnehmen, das es sämtlichen, an der Sitzung teilnehmenden Personen ermöglicht, einander
zur selben Zeit zu hören. Diese Teilnahme an einer Sitzung gilt als gleichwertig mit einer persönlichen Teilnahme an einer
Sitzung des Geschäftsführerrates.

Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam beraten und handeln, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Entscheidungen des Geschäftsführerrates werden durch Mehrheitsbeschluss der an der Sitzung teilnehmenden oder dort

ordnungsgemäß vertretenen Geschäftsführer verabschiedet.

Die  Beratung  des  Geschäftsführerrates  wird  im  Protokoll  festgehalten,  das  von  dem  Vorsitzenden  oder  einem  Ge-

schäftsführer zu unterzeichnen ist. Eine Abschrift dieses Protokolls oder ein Auszug aus diesem Protokoll wird von dem
Vorsitzenden oder von einem Geschäftsführer unterzeichnet.

Schriftliche und von sämtlichen Geschäftsführern genehmigte und unterzeichnete Beschlüsse haben dieselbe Wirkung

wie bei der Sitzung der Geschäftsführer verabschiedete Beschlüsse. In diesen Fällen können schriftliche Beschlüsse ent-
weder in einem einzigen Dokument oder in verschiedenen separaten Dokumenten mit ein und demselben Inhalt doku-
mentiert werden.

Schriftliche Beschlüsse können durch normale Postsendungen, per Fax, Mitteilung über das Kabelnetz, Telegramm,

Fernschreiben, durch elektronische Mittel oder durch sonstige geeignete Telekommunikationsmittel übertragen werden.

Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Be-

auftragte der Gesellschaft sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Die Anzahl seiner Stimmen entspricht

der Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtswirksam
vertreten lassen. Wenn sämtliche Mitglieder bei einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und erklären,
dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, kann die Generalversammlung ohne
vorherige Mitteilung abgehalten werden.

Art. 15. Gemeinsame Entscheidungen sind nur wirksam, wenn sie entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über

Handelsgesellschaften beschlossen wurden.

Art. 16. Eine alleinige Gesellschafterin übt die der Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse allein aus.

Beschlüsse der alleinigen Gesellschafterin werden in einem Protokoll oder in Schriftform festgehalten.

Art. 17. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit

Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 2016 und ist daher ein verlängertes Geschäftsjahr.

Art. 18. Zum 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt der Geschäftsführerrat den Jahresabschluss, der von einem Ab-

schlussprüfer („réviseurs d’entreprises agrée“) geprüft wird, wobei dieser Abschlussprüfer von der Generalversammlung
der Gesellschafter bzw. der alleinigen Gesellschafterin bestellt wird, die bzw. der die Bedingungen seines Mandats / ihrer
Mandate bestimmt; der erste zu prüfende Jahresabschluss ist der zum 31. Dezember 2016.

Art. 19. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz gemäß dem Gesetz über Handelsgesellschaften Einsicht in den

Jahresabschluss nehmen.

Art. 20. Vom Jahresnettogewinn der Gesellschaft sind mindestens fünf Prozent (5%) jährlich für die Bildung einer

Rücklage entsprechend dem Gesetz über Handelsgesellschaften zu verwenden. Diese Einstellung in die gesetzliche Rück-
lage  ist  nicht  mehr  erforderlich,  wenn  und  solange  die  gesetzliche  Rücklage  zehn  Prozent  (10%)  des  ausgegebenen
Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Nach der Einstellung in die gesetzliche Rücklage entscheidet die Generalversammlung der Gesellschafter bzw. die

alleinige Gesellschafterin über die Verwendung des übrigen Jahresnettogewinns (i) durch Einstellung des Restbetrages
ganz oder teilweise in eine Rücklage oder eine Rückstellung, (ii) durch Gewinnvortrag auf das darauf folgende Geschäfts-
jahr oder (iii) durch Ausschüttung, zusammen mit den ausschüttbaren Rücklagen und Gewinnvorträgen an die Gesell-
schafter bzw. die alleinige Gesellschafterin.

In jedem Jahr, in dem die Gesellschaft die Ausschüttung von Dividenden beschließt, die aus dem Nettogewinn und den

verfügbaren Rücklagen aus einbehaltenen Gewinnen einschließlich Agiorücklagen entnommen werden, wird der hierfür
ausgeschüttete Betrag in folgender Reihenfolge ausgeschüttet:

76294

L

U X E M B O U R G

-  Zunächst  haben  die  Inhaber  von  Gesellschaftsanteilen  Klasse  A  Anspruch  auf  Dividendenausschüttungen  für  das

betreffende  Jahr  in  Höhe  von  null  Komma  sechzig  Prozent  (0,60%)  des  Nennwerts  der  von  ihnen  gehaltenen  Gesell-
schaftsanteile Klasse A, und dann

- haben die Inhaber von Gesellschaftsanteilen Klasse B Anspruch auf Dividendenausschüttungen für das betreffende

Jahr in Höhe von null Komma fünfundfünfzig Prozent (0,55%) des Nennwerts der von ihnen gehaltenen Gesellschaftsan-
teile Klasse B, und dann

- haben die Inhaber von Gesellschaftsanteilen Klasse C Anspruch auf Dividendenausschüttungen für das betreffende

Jahr in Höhe von null Komma fünfzig Prozent (0,50%) des Nennwerts der von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteile Klasse
C, und dann

- haben die Inhaber von Gesellschaftsanteilen Klasse D Anspruch auf Dividendenausschüttungen für das betreffende

Jahr in Höhe von null Komma fünfundvierzig Prozent (0,45%) des Nennwerts der von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteile
Klasse D, und dann

- haben die Inhaber von Gesellschaftsanteilen Klasse E Anspruch auf Dividendenausschüttungen für das betreffende

Jahr in Höhe von null Komma vierzig Prozent (0,40%) des Nennwerts der von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteile Klasse
E, und dann

- haben die Inhaber von Gesellschaftsanteilen Klasse F Anspruch auf Dividendenausschüttungen für das betreffende

Jahr in Höhe von null Komma fünfunddreißig Prozent (0,35%) des Nennwerts der von ihnen gehaltenen Gesellschaftsan-
teile Klasse F, und dann

- haben die Inhaber von Gesellschaftsanteilen Klasse G Anspruch auf Dividendenausschüttungen für das betreffende

Jahr in Höhe von null Komma dreißig Prozent (0,30%) des Nennwerts der von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteile Klasse
G, und dann

- haben die Inhaber von Gesellschaftsanteilen Klasse H Anspruch auf Dividendenausschüttungen für das betreffende

Jahr in Höhe von null Komma fünfundzwanzig Prozent (0,25%) des Nennwerts der von ihnen gehaltenen Gesellschafts-
anteile Klasse H, und dann

- haben die Inhaber von Gesellschaftsanteilen Klasse I Anspruch auf den Rest der Dividendenausschüttungen.
Sollte die gesamte letzte ausstehende Klasse von Gesellschaftsanteilen (in alphabetischer Reihenfolge, z.B. Gesell-

schaftsanteile Klasse I) nach ihrer Einziehung, ihrem Rückkauf oder anderweitig zum Zeitpunkt der Ausschüttung annulliert
worden sein, wird der Rest einer Dividendenausschüttung zusätzlich zu den vorstehend angegebenen ursprünglichen Di-
videndenausschüttungsansprüchen der betreffenden Klasse von Gesellschaftsanteilen der vorangegangenen letzten aus-
stehenden Klasse von Gesellschaftsanteilen in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge (z.B. zunächst Gesellschaftsanteile
Klasse H) zugewiesen.

Art. 21. Vorbehaltlich der Bestimmungen des vorstehenden Artikels 20 dieser Satzung können Zwischenausschüttungen

jederzeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:

1. Der Geschäftsführerrat stellt einen Zwischenabschluss auf,
2. dieser Abschluss weist ausreichend ausschüttbare Mittel auf, wobei der auszuschüttende Betrag nicht den seit Ende

des letzten Geschäftsjahres erzielten Gewinn, zuzüglich dem Gewinnvortrag und den verfügbaren Rücklagen, abzüglich
Verlustvortrag und den kraft Gesetz oder gemäß dieser Satzung vorgeschriebenen und in eine Rücklage einzustellenden
Beträge übersteigen darf,

3. die Entscheidung, eine Zwischenausschüttung auszuzahlen, wird durch die Generalversammlung der Gesellschafter

bzw. die alleinige Gesellschafterin gefasst,

4. die Auszahlung erfolgt, sobald die Gesellschaft die Sicherheit hat, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft

nicht gefährdet sind.

Art. 22. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter derselben

Beschlussfähigkeit gefasst werden muss wie bei Statutenänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und
Vergütungen ernannt werden.

Nach Zahlung aller Schulden und Kosten der Gesellschaft, einschließlich der Aufwendungen für die Liquidation, wird

der Nettoliquidationserlös an die Gesellschafter bzw. die alleinige Gesellschafterin in der Weise ausgeschüttet, dass ins-
gesamt das gleiche wirtschaftliche Ergebnis wie gemäß den für Dividendenausschüttungen festgelegten Ausschüttungs-
regeln erreicht wird.

Art. 23. Wenn und solange ein Gesellschafter alle Gesellschaftsanteile hält, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft

im Sinne von Artikel 179 (2) des Gesetzes über Handelsgesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem Artikel 200-1
und 200-2 dieses Gesetzes Anwendung.

Art. 24. Jede Änderung dieser Statuten und jede Verfügung über zulässige Vermögensgegenstände, einschließlich deren

Veräußerung und Belastung während der Zeit, in der Triuva Gesellschaftsanteile der Gesellschaft (direkt oder indirekt)
hält, bedarf der Zustimmung der Verwahrstelle des Fonds.

76295

L

U X E M B O U R G

Art. 25. Für alle Punkte, die nicht in den vorliegenden Statuten geregelt sind, verweisen die Gesellschafter auf die

einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.“

Da es keine weiteren Themen in der Gesellschafterversammlung gibt, wurde diese daraufhin geschlossen.

Worüber die vorliegende notarielle, Urkunde in Pétange, Großherzogtum Luxemburg, an dem auf der ersten Seite dieses

Dokuments angegebenen Tag in Luxemburg, erstellt wurde.

Nach Verlesung des Dokuments vor der erschienenen Person hat dieselbe mit uns, dem Notar, die gegenwärtige Urkunde

unterzeichnet.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der erschie-

nenen Person die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen
derselben erschienenen Person und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die
englische Fassung maßgeblich sein.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 janvier 2016. Relation: EAC/2016/2032. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016071532/1245.
(160034959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

AI Global Investments &amp; CY S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 140.619.

In the year two thousand and sixteen, on the twelfth of February.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

is held

an extraordinary general meeting of shareholders of “AI Global Investments &amp; CY S.C.A.”, (hereinafter the “Company”)

a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 140.619, incorporated pursuant to a notarial deed dated 23 July
2008, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
(the “Mémorial C”) dated 25 August 2008 (number 2055, page 98594). The articles of association have been amended for
the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 21 December 2015, not yet published in the Memorial C.

The meeting is presided by Mrs. Linda HARROCH, lawyer, residing in Howald, Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary by Mrs. Valérie-Anne BASTIAN, private employee, residing in Howald, Luxembourg, who

is also elected as scrutineer by the general meeting.

I. That the agenda of the meeting is the following.

<i>Agenda

1. To create four new classes of shares referred to as.
a. the LP tracking shares 14A (the “LP Tracking Shares 14A”), subdivided into.
i. the LP tracking shares 14A1 (the “LP Tracking Shares 14A1”);
ii. the LP tracking shares 14A2 (the “LP Tracking Shares 14A2”);
iii. the LP tracking shares 14A3 (the “LP Tracking Shares 14A3”);
iv. the LP tracking shares 14A4 (the “LP Tracking Shares 14A4”);
v. the LP tracking shares 14A5 (the “LP Tracking Shares 14A5”);
vi. the LP tracking shares 14A6 (the “LP Tracking Shares 14A6”);
b. the LP tracking shares 14B (the “LP Tracking Shares 14B”), subdivided into.
i. the LP tracking shares 14B1 (the “LP Tracking Shares 14B1”);
ii. the LP tracking shares 14B2 (the “LP Tracking Shares 14B2”);
iii. the LP tracking shares 14B3 (the “LP Tracking Shares 14B3”);
iv. the LP tracking shares 14B4 (the “LP Tracking Shares 14B4”);
v. the LP tracking shares 14B5 (the “LP Tracking Shares 14B5”);
vi. the LP tracking shares 14B6 (the “LP Tracking Shares 14B6”);
c. the GP management share 14A (the “GP Management Share 14A”); and
d. the GP management share 14B (the “GP Management Share 14B”).

76296

L

U X E M B O U R G

2. To increase the Company's share capital by an amount of two million six hundred thousand Euro and two cents (EUR

2,600,000.02), so as to raise it from its present amount of forty million four hundred thirty thousand Euro and thirty-two
cents (EUR 40,430,000.32) up to forty-three million thirty thousand Euro and thirty-four cents (EUR 43,030,000.34) by
the issue of two hundred sixty million and two (260,000,002) new shares, divided into.

(i) one hundred thirty million (130,000,000) LP Tracking Shares 14A, divided into (a) one hundred twenty million

(120,000,000) LP Tracking Shares 14A1, (b) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14A2, (c) two million (2,000,000)
LP Tracking Shares 14A3, (d) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14A4, (e) two million (2,000,000) LP Tracking
Shares 14A5 and (f) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14A6 (the “New LP Tracking Shares 14A”);

(ii) one hundred thirty million (130,000,000) LP Tracking Shares 14B, divided into (a) one hundred twenty million

(120,000,000) LP Tracking Shares 14B1, (b) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14B2, (c) two million (2,000,000)
LP Tracking Shares 14B3, (d) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14B4, (e) two million (2,000,000) LP Tracking
Shares 14B5 and (f) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14B6 (the “New LP Tracking Shares 14B”);

(iii) One (1) GP Management Share 14A (the “New GP Management Share 14A”; and
(iv) One (1) GP Management Share 14B (the “New GP Management Share 14B” and together with the New LP Tracking

Shares 14A, the New LP Tracking Shares 14B, the New GP Management Share 14A, the “New Shares”),

each having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) and having the same rights and obligations as set out in the

articles of incorporation. The total contribution for the New Shares will be allocated to (i) the share capital of the Company
and (ii) the Company's share premium account.

3. To amend article 5.1 of the Company's articles of incorporation.
4. Miscellaneous.
II. That the shareholders represented, the proxyholder of the represented shareholders and the number of their shares

are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholders and by the
board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the
present deed.

III. That the entire share capital being represented at the present meeting and all the shareholders represented declaring

that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions.

<i>First resolution

The shareholders' meeting decides to create four new classes of shares referred to as.
a. the LP tracking shares 14A (the “LP Tracking Shares 14A”), subdivided into.
i. the LP tracking shares 14A1(the “LP Tracking Shares 14A1”);
ii. the LP tracking shares 14A2 (the “LP Tracking Shares 14A2”);
iii. the LP tracking shares 14A3 (the “LP Tracking Shares 14A3”);
iv. the LP tracking shares 14A4 (the “LP Tracking Shares 14A4”);
v. the LP tracking shares 14A5 (the “LP Tracking Shares 14A5”);
vi. the LP tracking shares 14A6 (the “LP Tracking Shares 14A6”);
b. the LP tracking shares 14B (the “LP Tracking Shares 14B”), subdivided into.
i. the LP tracking shares 14B1 (the “LP Tracking Shares 14B1”);
ii. the LP tracking shares 14B2 (the “LP Tracking Shares 14B2”);
iii. the LP tracking shares 14B3 (the “LP Tracking Shares 14B3”);
iv. the LP tracking shares 14B4 (the “LP Tracking Shares 14B4”);
v. the LP tracking shares 14B5 (the “LP Tracking Shares 14B5”);
vi. the LP tracking shares 14B6 (the “LP Tracking Shares 14B6”);
c. the GP management share 14A (the “GP Management Share 14A”); and
d. the GP management share 14B (the “GP Management Share 14B”).

<i>Second resolution

The shareholders' meeting decides to increase the Company's share capital by an amount of two million six hundred

thousand Euro and two cents (EUR 2,600,000.02), so as to raise it from its present amount of forty million four hundred
thirty thousand Euro and thirty-two cents (EUR 40,430,000.32) up to forty-three million thirty thousand Euro and thirty-
four cents (EUR 43,030,000.34) by the issue of two hundred sixty million and two (260,000,002) new shares, divided into.

(i) one hundred thirty million (130,000,000) LP Tracking Shares 14A, divided into (a) one hundred twenty million

(120,000,000) LP Tracking Shares 14A1, (b) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14A2, (c) two million (2,000,000)

76297

L

U X E M B O U R G

LP Tracking Shares 14A3, (d) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14A4, (e) two million (2,000,000) LP Tracking
Shares 14A5 and (f) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14A6 (the “New LP Tracking Shares 14A”);

(ii) one hundred thirty million (130,000,000) LP Tracking Shares 14B, divided into (a) one hundred twenty million

(120,000,000) LP Tracking Shares 14B1, (b) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14B2, (c) two million (2,000,000)
LP Tracking Shares 14B3, (d) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14B4, (e) two million (2,000,000) LP Tracking
Shares 14B5 and (f) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14B6 (the “New LP Tracking Shares 14B”);

(iii) One (1) GP Management Share 14A (the “New GP Management Share 14A”; and
(iv) One (1) GP Management Share 14B (the “New GP Management Share 14B” and together with the New LP Tracking

Shares 14A, the New LP Tracking Shares 14B, the New GP Management Share 14A, the “New Shares”),

each having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) and having the same rights and obligations as set out in the

articles of incorporation.

THE NEW SHARES ARE SUBSCRIBED AS FOLLOWS.
(i) the one hundred thirty million (130,000,000) New LP Tracking Shares 14A, divided into (a) one hundred twenty

million (120,000,000) LP Tracking Shares 14A1, (b) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14A2, (c) two million
(2,000,000) LP Tracking Shares 14A3, (d) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14A4, (e) two million (2,000,000)
LP Tracking Shares 14A5 and (f) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14A6, are subscribed in cash by “AI Ark
Mirror (Luxembourg) Holding S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is pending, here represented by Mrs.
Linda HARROCH, previously named, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on the 11 February 2016, hereto annexed.

The total contribution for New LP Tracking Shares 14A of one million three hundred forty-three thousand four hundred

Euro (EUR 1,343,400.00) is allocated (i) to the Company's share capital for an amount of one million three hundred thousand
Euro (EUR 1,300,000.00) and (ii) to the Company's share premium account for an amount of forty-three thousand four
hundred Euro (EUR 43,400.00). The amount of the contribution is the equivalent amount of USD 1,514,000.00 using the
exchange rate as at the 11 of February 2016;

(ii) the one hundred thirty million (130,000,000) New LP Tracking Shares 14B, divided into (a) one hundred twenty

million (120,000,000) LP Tracking Shares 14B1, (b) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14B2, (c) two million
(2,000,000) LP Tracking Shares 14B3, (d) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14B4, (e) two million (2,000,000)
LP Tracking Shares 14B5 and (f) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14B6, are subscribed in cash by “AI Ark
(Luxembourg) Holding S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is pending, here represented by Mrs. Linda HAR-
ROCH, previously named, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on the 11 February 2016, hereto annexed.

The total contribution for New LP Tracking Shares 14B of one million three hundred thirty thousand nine hundred eighty

Euro (EUR 1,330,980.00) is allocated (i) to the Company's share capital for an amount of one million three hundred thousand
Euro (EUR 1,300,000.00) and (ii) to the Company's share premium account for an amount of thirty thousand nine hundred
eighty Euro (EUR 30,980.00). The amount of the contribution is the equivalent amount of USD 1,500,000.00 using the
exchange rate as at the 11 of February 2016; and

(iii) the New GP Management Share 14A and the New GP Management Share 14B are subscribed in cash by “AI Global

Investment GP S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 186.176, here represented by Mrs. Linda HARROCH,
previously named, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on the 11 February 2016, hereto annexed.

The total contribution for the New GP Management Share 14A and the New GP Management Share 14B of two Euro

cents (EUR 0.02) is entirely allocated to the Company's share capital.

The other shareholders waive their preferential subscription rights.
The proof of the existence of the contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Third resolution

The shareholders' meeting decides to amend article 5.1 of the Company's articles of incorporation, as a result of the

above capital increase, which shall now be read as follows.

“ 5. Share capital.
5.1  The  Company'  share  capital  is  set  at  forty-three  million  thirty  thousand  Euro  and  thirty-four  cents  (EUR

43,030,000.34) divided into.

A. Four billion three hundred three million (4,303,000,000) ordinary shares (actions de commanditaires) having a no-

minal value of one cent (EUR 0.01) each (the “LP Tracking Shares”), subdivided into.

1. one hundred and forty-five million (145,000,000) LP tracking shares B (the “LP Tracking Shares B”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares B1, five million (5,000,000) LP Tracking Shares B2,

76298

L

U X E M B O U R G

five million (5,000,000) LP Tracking Shares B3, five million (5,000,000) LP Tracking Shares B4, five million (5,000,000)
LP Tracking Shares B5 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares B6;

2. one hundred and forty-five million (145,000,000) LP tracking shares D (the “LP Tracking Shares D”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares D1 and twenty-five million (25,000,000) LP Tracking
Shares D2;

3. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares E (the “LP Tracking Shares E”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares E1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
E2;

4. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares G (the “LP Tracking Shares G”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares G1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
G2;

5. one hundred and forty-five million (145,000,000) LP tracking shares H (the “LP Tracking Shares H”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares H1, five million (5,000,000) LP Tracking Shares H2,
five million (5,000,000) LP Tracking Shares H3, five million (5,000,000) LP Tracking Shares H4, five million (5,000,000)
LP Tracking Shares H5 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares H6;

6. one hundred and forty-five million (145,000,000) LP tracking shares J (the “LP Tracking Shares J”), subdivided into

one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares J1, five million (5,000,000) LP Tracking Shares J2, five
million (5,000,000) LP Tracking Shares J3, five million (5,000,000) LP Tracking Shares J4, five million (5,000,000) LP
Tracking Shares J5 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares J6;

7. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares K (the “LP Tracking Shares K”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares K1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
K2;

8. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares L (the “LP Tracking Shares L”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares L1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
L2;

9. one hundred and forty-five million (145,000,000) LP tracking shares N (the “LP Tracking Shares N”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares N1, five million (5,000,000) LP Tracking Shares N2,
five million (5,000,000) LP Tracking Shares N3, five million (5,000,000) LP Tracking Shares N4, five million (5,000,000)
LP Tracking Shares N5 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares N6;

10. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares Q (the “LP Tracking Shares Q”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares Q1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
Q2;

11. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares R1 (the “LP Tracking Shares R”);
12. eighteen million (18,000,000) LP tracking shares S1 (the “LP Tracking Shares S”);
13. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares T (the “LP Tracking Shares T”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares T1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
T2;

14. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares U (the “LP Tracking Shares U”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares U1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
U2;

15. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares V (the “LP Tracking Shares V”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares V1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
V2;

16. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares W (the “LP Tracking Shares W”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares W1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
W2;

17. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares X (the “LP Tracking Shares X”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares X1 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
X2;

18. one hundred and forty-five million (145,000,000) LP tracking shares Y (the “LP Tracking Shares Y”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares Y1, five million (5,000,000) LP Tracking Shares Y2,
five million (5,000,000) LP Tracking Shares Y3, five million (5,000,000) LP Tracking Shares Y4, five million (5,000,000)
LP Tracking Shares Y5 and five million (5,000,000) LP Tracking Shares Y6;

19. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 1 (the “LP Tracking Shares 1”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 1A and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
1B;

20. one hundred and forty-five million (145,000,000) LP tracking shares 2 (the “LP Tracking Shares 2”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 2A, five million (5,000,000) LP Tracking Shares 2B,

76299

L

U X E M B O U R G

five million (5,000,000) LP Tracking Shares 2C, five million (5,000,000) LP Tracking Shares 2D, five million (5,000,000)
LP Tracking Shares 2E and five million (5,000,000) LP Tracking Shares 2F;

21. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 4A, divided into one hundred twenty million

(120,000,000) LP tracking shares 4A1 and five million (5,000,000) LP tracking shares 4A2 (the “LP Tracking Shares 4A”);

22. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 4B, divided into one hundred twenty million

(120,000,000) LP tracking shares 4B1 and five million (5,000,000) LP tracking shares 4B2 (the “LP Tracking Shares 4B”);

23. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 5 (the “LP Tracking Shares 5”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 5A and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
5B;

24. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 6A, divided into one hundred twenty million

(120,000,000) LP tracking shares 6A1 and five million (5,000,000) LP tracking shares 6A2 (the “LP Tracking Shares 6A”);

25. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 6B, divided into one hundred twenty million

(120,000,000) LP tracking shares 6B1 and five million (5,000,000) LP tracking shares 6B2 (the “LP Tracking Shares 6B”);

26. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 7 (the “LP Tracking Shares 7”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 7A and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
7B;

27. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 8 (the “LP Tracking Shares 8”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 8A and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
8B;

28. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 9 (the “LP Tracking Shares 9”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 9A and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
9B;

29. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares 10 (the “LP Tracking Shares 10”), subdivided

into one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 10A and five million (5,000,000) LP Tracking Shares
10B;

30. one hundred and thirty million (130,000,000) LP tracking shares 11 (the “LP Tracking Shares 11”), subdivided into

one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 11A and ten million (10,000,000) LP Tracking Shares 11B;

31. one hundred and thirty million (130,000,000) LP tracking shares 12 (the “LP Tracking Shares 12”), subdivided into

one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 12A and ten million (10,000,000) LP Tracking Shares 12B;

32. one hundred and thirty million (130,000,000) LP tracking shares 13 (the “LP Tracking Shares 13”), subdivided into

one hundred twenty million (120,000,000) LP Tracking Shares 13A and ten million (10,000,000) LP Tracking Shares 13B;
and

33. one hundred thirty million (130,000,000) LP Tracking Shares 14A, divided into (a) one hundred twenty million

(120,000,000) LP Tracking Shares 14A1, (b) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14A2, (c) two million (2,000,000)
LP Tracking Shares 14A3, (d) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14A4, (e) two million (2,000,000) LP Tracking
Shares 14A5 and (f) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14A6 (the “LP Tracking Shares 14A”);

34. one hundred thirty million (130,000,000) LP Tracking Shares 14B, divided into (a) one hundred twenty million

(120,000,000) LP Tracking Shares 14B1, (b) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14B2, (c) two million (2,000,000)
LP Tracking Shares 14B3, (d) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14B4, (e) two million (2,000,000) LP Tracking
Shares 14B5 and (f) two million (2,000,000) LP Tracking Shares 14B6 (the “LP Tracking Shares 14B”), and

B. thirty-four (34) management shares (actions de commandités) having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each

(the “GP Management Shares”), subdivided into.

1. one (1) GP management share B (the “GP Management Share B”),
2. one (1) GP management share D (the “GP Management Share D”),
3. one (1) GP management share E (the “GP Management Share E”),
4. one (1) GP management share G (the “GP Management Share G”),
5. one (1) GP management share H (the “GP Management Share H”),
6. one (1) GP management share J (the “GP Management Share J”),
7. one (1) GP management share K (the “GP Management Share K”),
8. one (1) GP management share L (the “GP Management Share L”),
9. one (1) GP management share N (the “GP Management Share N”),
10. one (1) GP management share Q (the “GP Management Share Q”),
11. one (1) GP management share R (the “GP Management Share R”),
12. one (1) GP management share S (the “GP Management Share S”),
13. one (1) GP management share T (the “GP Management Share T”),
14. one (1) GP management share U (the “GP Management Share U”),
15. one (1) GP management share V (the “GP Management Share V”),

76300

L

U X E M B O U R G

16. one (1) GP management share W (the “GP Management Share W”),
17. one (1) GP management share X (the “GP Management Share X”),
18. one (1) GP management share Y (the “GP Management Share Y”),
19. one (1) GP management share 1 (the “GP Management Share 1”),
20. one (1) GP management share 2 (the “GP Management Share 2”),
21. one (1) GP management share 4A (the “GP Management Share 4A”),
22. one (1) GP management share 4B (the “GP Management Share 4B”),
23. one (1) GP management share 5 (the “GP Management Share 5”),
24. one (1) GP management share 6A (the “GP Management Share 6A”),
25. one (1) GP management share 6B (the “GP Management Share 6B”),
26. one (1) GP management share 7 (the “GP Management Share 7”),
27. one (1) GP management share 8 (the “GP Management Share 8”),
28. one (1) GP management share 9 (the “GP Management Share 9”),
29. one (1) GP management share 10 (the “GP Management Share 10”),
30. one (1) GP management share 11 (the “GP Management Share 11”),
31. one (1) GP management share 12 (the “GP Management Share 12”),
32. one (1) GP management share 13 (the “GP Management Share 13”),
33. one (1) GP management share 14A (the “GP Management Share 14A”), and
34. one (1) GP management share 14B (the “GP Management Share 14B”).

<i>Costs and Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result

of the presently deed are estimated at approximately three thousand five hundred euro.

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,

followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English and the
French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their surnames, first names, civil status

and residences, these persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le douze février.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «AI Global Investments &amp; CY S.C.A.» (ci-après la «Société»),

une société en commandite par actions constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.619, constituée suivant acte notarié en date du 23 juillet
2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 25 août 2008, numéro 2055, page
98594. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
21 décembre 2015, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est sous la présidence de Madame Linda HARROCH, avocat, demeurant à Howald, Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Valérie-Anne BASTIAN, employée, demeurant à Howald, Luxembourg, qui est

aussi choisie comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter.
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour.

<i>Ordre du jour

1. Créer quatre nouvelles classes d'actions référencées comme étant.
a. les LP tracking actions 14A (les «LP Tracking Actions 14A»), subdivisées en.
i. LP tracking actions 14A1 (les «LP Tracking Actions 14A1»);
ii. LP tracking actions 14A2 (les «LP Tracking Actions 14A2»);
iii. LP tracking actions 14A3 (les «LP Tracking Actions 14A3»);
iv. LP tracking actions 14A4 (les «LP Tracking Actions 14A4»);

76301

L

U X E M B O U R G

v. LP tracking actions 14A5 (les «LP Tracking Actions 14A5»);
vi. LP tracking actions 14A6 (les «LP Tracking Actions 14A6»);
b. les LP tracking actions 14B (les «LP Tracking Actions 14B»), subdivisées en.
i. LP tracking actions 14B1 (les «LP Tracking Actions 14B1»);
ii. LP tracking actions 14B2 (les «LP Tracking Actions 14B2»);
iii. LP tracking actions 14B3 (les «LP Tracking Actions 14B3»);
iv. LP tracking actions 14B4 (les «LP Tracking Actions 14B4»);
v. LP tracking actions 14B5 (les «LP Tracking Actions 14B5»);
vi. LP tracking actions 14B6 (les «LP Tracking Actions 14B6»);
c. la GP action de commandité 14A (la «GP Action de Commandité 14A»); et
d. la GP action de commandité 14B (la «GP Action de Commandité 14B»).
2. Augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux millions six cent mille euros et deux centimes (EUR

2.600.000,02), afin de le porter de son montant actuel de quarante millions quatre cent trente mille euros et trente-deux
centimes  (EUR  40.430.000,32)  jusqu'à  quarante-trois  millions  trente  mille  euros  et  trente-quatre  centimes  (EUR
43.030.000,34) par l'émission de deux cent soixante millions et deux (260.000.002) nouvelles actions, divisées en.

(i) cent-trente millions (130.000.000) LP Tracking Actions 14A, divisées en (a) cent-vingt millions (120.000.000) LP

Tracking  Actions  14A1,  (b)  deux  millions  (2.000.000)  LP  Tracking  Actions  14A2,  (c)  deux  millions  (2.000.000)  LP
Tracking  Actions  14A3,  (d)  deux  millions  (2.000.000)  LP  Tracking  Actions  14A4,  (e)  deux  millions  (2.000.000)  LP
Tracking Actions 14A5 et (f) deux millions (2.000.000) LP Tracking Actions 14A6 (les «Nouvelles LP Tracking Actions
14A»);

(ii) cent-trente millions (130.000.000) LP Tracking Actions 14B, divisées en (a) cent-vingt millions (120.000.000) LP

Tracking  Actions  14B1,  (b)  deux  millions  (2.000.000)  LP  Tracking  Actions  14B2,  (c)  deux  millions  (2.000.000)  LP
Tracking  Actions  14B3,  (d)  deux  millions  (2.000.000)  LP  Tracking  Actions  14B4,  (e)  deux  millions  (2.000.000)  LP
Tracking Actions 14B5 et (f) deux millions (2.000.000) LP Tracking Actions 14B6 (les «Nouvelles LP Tracking Actions
14B»);

(iii) une (1) Action de Commandité 14A (la «Nouvelle Action de Commandité 14A»); et
(iv) une (1) Action de Commandité 14B (la «Nouvelle Action de Commandité 14B» et ensemble avec les Nouvelles LP

Tracking Actions 14A, les Nouvelles LP Tracking Actions 14B, la Nouvelle Action de Commandité 14A, les «Nouvelles
Actions»),

chacune d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) et ayant les droits et obligations tels qu'indiqués par les

statuts de la Société. L'apport total pour les Nouvelles Actions sera alloué au (i) capital social de la Société et au (ii) compte
de prime d'émission de la Société.

3. Modifier l'article 5.1 des statuts de la Société.
4. Divers.
II. Que les actionnaires représentés, la mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils

détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par la mandataire des
actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires
représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant représenté à la présente assemblée et tous les actionnaires représentés se

reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable, aucune notice de convocation n'a été nécessaire.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide de quatre nouvelles classes d'actions référencées comme étant.
a. les LP tracking actions 14A (les «LP Tracking Actions 14A»), subdivisées en.
i. LP tracking actions 14A1 (les «LP Tracking Actions 14A1»);
ii. LP tracking actions 14A2 (les «LP Tracking Actions 14A2»);
iii. LP tracking actions 14A3 (les «LP Tracking Actions 14A3»);
iv. LP tracking actions 14A4 (les «LP Tracking Actions 14A4»);
v. LP tracking actions 14A5 (les «LP Tracking Actions 14A5»);
vi. LP tracking actions 14A6 (les «LP Tracking Actions 14A6»);
b. les LP tracking actions 14B (les «LP Tracking Actions 14B»), subdivisées en.

76302

L

U X E M B O U R G

i. LP tracking actions 14B1 (les «LP Tracking Actions 14B1»);
ii. LP tracking actions 14B2 (les «LP Tracking Actions 14B2»);
iii. LP tracking actions 14B3 (les «LP Tracking Actions 14B3»);
iv. LP tracking actions 14B4 (les «LP Tracking Actions 14B4»);
v. LP tracking actions 14B5 (les «LP Tracking Actions 14B5»);
vi. LP tracking actions 14B6 (les «LP Tracking Actions 14B6»);
c. la GP action de commandité 14A (la «GP Action de Commandité 14A»); et
d. la GP action de commandité 14B (la «GP Action de Commandité 14B»).

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux millions six cent mille euros

et deux centimes (EUR 2.600.000,02), afin de le porter de son montant actuel de quarante millions quatre cent trente mille
euros et trente-deux centimes (EUR 40.430.000,32) jusqu'à quarante-trois millions trente mille euros et trente-quatre cen-
times (EUR 43.030.000,34) par l'émission de deux cent soixante millions et deux (260.000.002) nouvelles actions, divisées
en.

(i) cent-trente millions (130.000.000) de LP Tracking Actions 14A, divisées en (a) cent-vingt millions (120.000.000)

de LP Tracking Actions 14A1, (b) deux millions (2.000.000) de LP Tracking Actions 14A2, (c) deux millions (2.000.000)
de LP Tracking Actions 14A3, (d) deux millions (2.000.000) de LP Tracking Actions 14A4, (e) deux millions (2.000.000)
de LP Tracking Actions 14A5 et (f) deux millions (2.000.000) de LP Tracking Actions 14A6 (les «Nouvelles LP Tracking
Actions 14A»);

(ii) cent-trente millions (130.000.000) de LP Tracking Actions 14B, divisées en (a) cent-vingt millions (120.000.000)

de LP Tracking Actions 14B1, (b) deux millions (2.000.000) de LP Tracking Actions 14B2, (c) deux millions (2.000.000)
de LP Tracking Actions 14B3, (d) deux millions (2.000.000) de LP Tracking Actions 14B4, (e) deux millions (2.000.000)
de LP Tracking Actions 14B5 et (f) deux millions (2.000.000) de LP Tracking Actions 14B6 (les «Nouvelles LP Tracking
Actions 14B»);

(iii) une (1) Action de Commandité 14A (la «Nouvelle Action de Commandité 14A»); et
(iv) une (1) Action de Commandité 14B (la «Nouvelle Action de Commandité 14B» et ensemble avec les Nouvelles LP

Tracking Actions 14A, les Nouvelles LP Tracking Actions 14B, la Nouvelle Action de Commandité 14A, les «Nouvelles
Actions»),

chacune d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) et ayant les droits et obligations tels qu'indiqués par les

statuts de la Société.

LES NOUVELLES ACTIONS SONT SOUSCRITES COMME SUIT.
(i)  Les  cent  trente  millions  (130.000.000)  Nouvelles  LP  Tracking  Actions  14A,  divisées  en  (a)  cent-vingt  millions

(120.000.000) de LP Tracking Actions 14A1, (b) deux millions (2.000.000) de LP Tracking Actions 14A2, (c) deux millions
(2.000.000) de LP Tracking Actions 14A3, (d) deux millions (2.000.000) de LP Tracking Actions 14A4, (e) deux millions
(2.000.000) de LP Tracking Actions 14A5 et (f) deux millions (2.000.000) de LP Tracking Actions 14A6, sont souscrites
en numéraire par «AI Ark Mirror (Luxembourg) Holding S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant
selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, dont l'immatriculation auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours,
représentée par Madame Linda HARROCH, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg
le 11 février 2016, ci-annexée.

L'apport total des Nouvelles LP Tracking Actions 14A d'un million trois cent quarante-trois mille quatre cents euros

(EUR 1.343.400,00) est alloué (i) au capital social de la Société pour un montant d'un million trois cent mille euros (EUR
1.300.000,00) et (ii) au compte de prime d'émission de la Société pour un montant de quarante-trois mille quatre cents
euros (EUR 43.400,00). Le montant de l'apport représentant un montant équivalent d'USD 1.514.000,00, d'après les taux
de change en vigueur en date du 11 février 2016;

(ii) Les cent-trente millions (130.000.000) Nouvelles LP Tracking Actions 14B, divisées en (a) cent-vingt millions

(120.000.000) de LP Tracking Actions 14B1, (b) deux millions (2.000.000) LP Tracking Actions 14B2, (c) deux millions
(2.000.000) de LP Tracking Actions 14B3, (d) deux millions (2.000.000) de LP Tracking Actions 14B4, (e) deux millions
(2.000.000) de LP Tracking Actions 14B5 et (f) deux millions (2.000.000) de LP Tracking Actions 14B6, sont souscrites
en numéraire par «AI Ark (Luxembourg) Holding S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant selon
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, dont l'immatriculation auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours, repré-
sentée par Madame Linda HARROCH, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le
11 février 2016, ci-annexée.

L'apport total des Nouvelles LP Tracking Actions 14B d'un million trois cent trente mille neuf cent quatre-vingts euros

(EUR 1.330.980,00) est alloué (i) au capital social de la Société pour un montant d'un million trois cent mille euros (EUR
1.300.000,00) et (ii) au compte de prime d'émission de la Société pour un montant de trente mille neuf cent quatre-vingts

76303

L

U X E M B O U R G

euros (EUR 30.980,00). Le montant de l'apport représentant un montant équivalent d'USD 1.500.000,00, d'après les taux
de change en vigueur en date du 11 février 2016;

(iii) la Nouvelle GP Action de Commandité 14A et la Nouvelle GP Action de Commandité 14B sont souscrites par «AI

Global Investments GP S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.176, représentée par Madame Linda
HARROCH, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 11 février 2016, ci-annexée.

L'apport total de la Nouvelle GP Action de Commandité 14A et de la Nouvelle GP Action de Commandité 14B de deux

centimes d'euro (EUR 0,02) est entièrement alloué au capital social de la Société.

Les autres actionnaires renoncent à leur droit de souscription préférentiel.
Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société suite à l'augmentation de capital,

qui sera désormais rédigé comme suit.

« 5. Capital social.
5.1  Le  capital  social  de  la  Société  est  de  quarante-trois  millions  trente  mille  euros  et  trente-quatre  centimes  (EUR

43.030.000,34), divisé en.

A. quatre milliards trois cent trois millions (4.303.000.000) actions de commanditaires, ayant une valeur nominale d'un

centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les «LP Tracking Actions»), subdivisées en.

1. Cent-quarante-cinq millions (145.000.000) LP tracking actions B (les «LP Tracking Actions B»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions B1, cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions B2, cinq millions
(5.000.000) LP Tracking Actions B3, cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions B4, cinq millions (5.000.000) LP
Tracking Actions B5 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions B6;

2. Cent-quarante-cinq millions (145.000.000) LP tracking actions D (les «LP Tracking Actions D»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions D1 et vingt-cinq millions (25.000.000) LP Tracking Actions D2;

3. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions E (les «LP Tracking Actions E»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions E1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions E2;

4. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions G (les «LP Tracking Actions G»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions G1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions G2;

5. Cent-quarante-cinq millions (145.000.000) LP tracking actions H (les «LP Tracking Actions H»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions H1, cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions H2, cinq millions
(5.000.000) LP Tracking Actions H3, cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions H4, cinq millions (5.000.000) LP
Tracking Actions H5 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions H6;

6. Cent-quarante-cinq millions (145.000.000) LP tracking actions J (les «LP Tracking Actions J»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions J1, cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions J2, cinq millions
(5.000.000) LP Tracking Actions J3, cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions J4, cinq millions (5.000.000) LP
Tracking Actions J5 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions J6;

7. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions K (les «LP Tracking Actions K»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions K1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions K2;

8. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions L (les «LP Tracking Actions L»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions L1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions L2;

9. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions N (les «LP Tracking Actions N»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions N1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions N2;

10. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions Q (les «LP Tracking Actions Q»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions Q1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions Q2;

11. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions R1 (les «LP Tracking Actions R»);
12. Dix-huit millions (18.000.000) LP tracking actions S1 (les «LP Tracking Actions S»);
13. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions T (les «LP Tracking Actions T»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions T1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions T2;

14. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions U (les «LP Tracking Actions U»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions U1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions U2;

15. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions V (les «LP Tracking Actions V»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions V1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions V2;

16. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions W (les «LP Tracking Actions W»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions W1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions W2;

76304

L

U X E M B O U R G

17. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions X (les «LP Tracking Actions X»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions X1 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions X2;

18. Cent-quarante-cinq millions (145.000.000) LP tracking actions Y (les «LP Tracking Actions Y»), subdivisées en

cent-vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions Y1, cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions Y2, cinq mil-
lions (5.000.000) LP Tracking Actions Y3, cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions Y4, cinq millions (5.000.000)
LP Tracking Actions Y5 et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions Y6;

19. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 1 (les «LP Tracking Actions 1»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions 1A et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions 1B;

20. Cent-quarante-cinq millions (145.000.000) LP tracking actions 2 (les «LP Tracking Actions 2»), subdivisées en

cent-vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions 2A, cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions 2B, cinq mil-
lions (5.000.000) LP Tracking Actions 2C, cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions 2D, cinq millions (5.000.000)
LP Tracking Actions 2E et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions 2F;

21. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 4A, divisées en cent-vingt millions (120.000.000) LP

tracking actions 4A1 et cinq millions (5.000.000) LP tracking actions 4A2 (les «LP Tracking Actions 4A»);

22. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 4B, divisées en cent-vingt millions (120.000.000) LP

tracking actions 4B1 et cinq millions (5.000.000) LP tracking actions 4B2 (les «LP Tracking Actions 4B»);

23. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 5 (les «LP Tracking Actions 5»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions 5A et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions 5B;

24. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 6A, divisées en cent-vingt millions (120.000.000) LP

tracking actions 6A1 et cinq millions (5.000.000) LP tracking actions 6A2 (les «LP Tracking Actions 6A»);

25. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 6B, divisées en cent-vingt millions (120.000.000) LP

tracking actions 6B1 et cinq millions (5.000.000) LP tracking actions 6B2 (les «LP Tracking Actions 6B»);

26. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 7 (les «LP Tracking Actions 7»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions 7A et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions 7B;

27. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 8 (les «LP Tracking Actions 8»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions 8A et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions 8B;

28. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 9 (les «LP Tracking Actions 9»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions 9A et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions 9B;

29. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions 10 (les «LP Tracking Actions 10»), subdivisées en cent-

vingt millions (120.000.000) LP Tracking Actions 10A et cinq millions (5.000.000) LP Tracking Actions 10B;

30. Cent-trente millions (130.000.000) LP tracking actions 11 (les «LP Tracking Actions 11»), subdivisées en cent-vingt

millions (120.000.000) LP Tracking Actions 11A et dix millions (10.000.000) LP Tracking Actions 11B;

31. Cent-trente millions (130.000.000) LP tracking actions 12 (les «LP Tracking Actions 12»), subdivisées en cent-vingt

millions (120.000.000) LP Tracking Actions 12A et dix millions (10.000.000) LP Tracking Actions 12B;

32. Cent-trente millions (130.000.000) LP tracking actions 13 (les «LP Tracking Actions 13»), subdivisées en cent-vingt

millions (120.000.000) LP Tracking Actions 13A et dix millions (10.000.000) LP Tracking Actions 13B; et

33. Cent-trente millions (130.000.000) LP tracking actions 14A, subdivisées en (a) cent-vingt millions (120.000.000)

LP tracking actions 14A1, (b) deux millions (2.000.000) LP tracking actions 14A2, (c) deux millions (2.000.000) LP
tracking actions 14A3, (d) deux millions (2.000.000) LP tracking actions 14A4, (e) deux millions (2.000.000) LP tracking
actions 14A5 et (f) deux millions (2.000.000) LP tracking actions 14A6 (les «LP Tracking Actions 14A»);

34. Cent-trente millions (130.000.000) LP tracking actions 14B, subdivisées en (a) cent-vingt millions (120.000.000)

LP  tracking  actions  14B1,  (b)  deux  millions  (2.000.000)  LP  tracking  actions  14B2,  (c)  deux  millions  (2.000.000)  LP
tracking actions 14B3, (d) deux millions (2.000.000) LP tracking actions 14B4, (e) deux millions (2.000.000) LP tracking
actions 14B5 et (f) deux millions (2.000.000) LP tracking actions 14B6 (les «LP Tracking Actions 14B»), et

B. Trente-quatre (34) actions de commandités, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les

«GP Actions de Commandités»), subdivisées en.

1. Une (1) GP action de commandité B (la «GP Action de Commandité B»),
2. Une (1) GP action de commandité D (la «GP Action de Commandité D»),
3. Une (1) GP action de commandité E (la «GP Action de Commandité E»),
4. Une (1) GP action de commandité G (la «GP Action de Commandité G»),
5. Une (1) GP action de commandité H (la «GP Action de Commandité H»),
6. Une (1) GP action de commandité J (la «GP Action de Commandité J»),
7. Une (1) GP action de commandité K (la «GP Action de Commandité K»),
8. Une (1) GP action de commandité L (la «GP Action de Commandité L»),
9. Une (1) GP action de commandité N (la «GP Action de Commandité N»),
10. Une (1) GP action de commandité Q (la «GP Action de Commandité Q»),
11. Une (1) GP action de commandité R (la «GP Action de Commandité R»),

76305

L

U X E M B O U R G

12. Une (1) GP action de commandité S (la «GP Action de Commandité S»),
13. Une (1) GP action de commandité T (la «GP Action de Commandité T»),
14. Une (1) GP action de commandité U (la «GP Action de Commandité U»),
15. Une (1) GP action de commandité V (la «GP Action de Commandité V»),
16. Une (1) GP action de commandité W (la «GP Action de Commandité W»),
17. Une (1) GP action de commandité X (la «GP Action de Commandité X»),
18. Une (1) GP action de commandité Y (la «GP Action de Commandité Y»),
19. Une (1) GP action de commandité 1 (la «GP Action de Commandité 1»),
20. Une (1) GP action de commandité 2 (la «GP Action de Commandité 2»),
21. Une (1) GP action de commandité 4A (la «GP Action de Commandité 4A»),
22. Une (1) GP action de commandité 4B (la «GP Action de Commandité 4B»),
23. Une (1) GP action de commandité 5 (la «GP Action de Commandité 5»),
24. Une (1) GP action de commandité 6A (la «GP Action de Commandité 6A»),
25. Une (1) GP action de commandité 6B (la «GP Action de Commandité 64B»),
26. Une (1) GP action de commandité 7 (la «GP Action de Commandité 7»),
27. Une (1) GP action de commandité 8 (la «GP Action de Commandité 8»),
28. Une (1) GP action de commandité 9 (la «GP Action de Commandité 9»),
29. Une (1) GP action de commandité 10 (la «GP Action de Commandité 10»),
30. Une (1) GP action de commandité 11 (la «GP Action de Commandité 11»),
31. Une (1) GP action de commandité 12 (la «GP Action de Commandité 12»),
32. Une (1) GP action de commandité 13 (la «GP Action de Commandité 13»),
33. Une (1) GP action de commandité 14A (la «GP Action de Commandité 14A»), et
34. Une (1) GP action de commandité 14B (la «GP Action de Commandité 14B»).»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, supportés par la Société à raison du présent

acte, sont approximativement estimés à trois mille cinq cents euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé. L. HARROCH, V.A. BASTIAN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 février 2016. Relation. EAC/2016/3990. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2016077703/578.
(160043612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

RubySphere, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 204.620.

STATUTS

L'an deux mille seize.
Le sept mars.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Claude SCHLESSER, programmeur-analyste, demeurant à L-3340 Huncherange, 82, route d'Esch.
2.- Monsieur Robert SCHLESSER, maître-électricien, demeurant à L-3340 Huncherange, 36, rue de la Résistance.
3.- La société anonyme FISOGEST S.A., avec siège social à L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44.696,

76306

L

U X E M B O U R G

représentée par Madame Sophie BATARDY, employée privée, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg,

681, rue de Neudorf, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 23 février 2016,

laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par les comparants et le notaire, restera annexée au présent

acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter

ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils entendent constituer:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933

telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou

plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère unipersonnel
de la société.

Art. 2. La Société a pour objet le commerce et le développement de produits et logiciels informatiques, notamment dans

le domaine Internet, ainsi que l’information, le conseil et le service sur Internet et plus particulièrement la mise à disposition
de produits et services facilitant la gestion des ressources humaines.

La société a encore pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle pourra s’intéresser
à toutes valeurs mobilières, dépôts d’espèces, certificats de trésorerie, et toute autre forme de placement, les acquérir par
achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger. La société pourra également prêter ou emprunter
avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissance de dettes.

Plus spécialement, l’objet social pourra s’étendre pour son compte propre à l’acquisition, la détention, l’exploitation, la

mise en valeur, la vente ou la location d’immeubles et de terrains industriels et autres, situés au Luxembourg ou à l’étranger,
ainsi qu’à toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières y rattachées directement
ou indirectement.

Elle pourra accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse, de façon directe ou indirecte, tous concours, prêts, avances

ou garanties. Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations quelconques, qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en asso-

ciation, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des
intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opé-

rations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de RubySphere.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision de

l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent

(100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-

dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée

générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Dans le cas de l'alinéa 2 le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires,

soit au conjoint survivant et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas

trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois
mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à
la poste.

Toutefois, pendant le dit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous

réserve de la prescription de la dernière phrase de l'art. 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses

76307

L

U X E M B O U R G

modifications ultérieures, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions
exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne

compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par

l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit

opposable à la société.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle

dans un acte notarié conformément à l'art. 1690 du Code civil.

Art. 10. Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne

pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique

ou par l'assemblée des associés.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite

de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal

ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 15. En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant

l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à
l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortis-

sements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci

atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.

<i>Souscription et libération du capital social

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Claude SCHLESSER, prénommé, soixante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

2.- Monsieur Robert SCHLESSER, prénommé, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

3.- La société anonyme FISOGEST S.A., préqualifiée, trente parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE

MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire qui le constate expressément.

76308

L

U X E M B O U R G

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2016.

<i>Evaluation

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille Euros (€ 1.000.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité

des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.

1.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Claude SCHLESSER, programmeur-analyste, né à Luxembourg, le 1 

er

 décembre 1979, demeurant à L-3340

Huncherange, 82, route d'Esch.

2.- Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Nico HANSEN, employé, né à Differdange, le 31 mars 1969, demeurant professionnellement à L-2220 Lu-

xembourg, 681, rue de Neudorf.

3.- La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
4.- L'adresse de la société est fixée à L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire instru-

mentant d'après leur noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. SCHLESSER, R. SCHLESSER, S. BATARDY, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 09 mars 2016. Relation: GAC/2016/1890. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 15 mars 2016.

Référence de publication: 2016080408/149.
(160045971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.

Tetraktys S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 193.190.

EXTRAIT

Sur base de l'article 2 des statuts, l'associé commandité a pris la décision de:
Transférer le siège social de la société TETRAKTYS S.C.A.
du 18 rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg,
au 34 A rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
Le transfert de siège sera effectif au 15 mars 2016.
Référence de publication: 2016085008/13.
(160051933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.

Perspective Croissance Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 154.290.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016088591/9.
(160056661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

76309

L

U X E M B O U R G

ESCO Finance International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.512,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 155.501.

Les comptes annuels au 30 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2016.

Référence de publication: 2016087643/10.
(160056167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2016.

Liga Holding S.à r.l., Groupement Européen d'Intérêt Economique,

(anc. Liga Holding S.A.).

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht.

R.C.S. Luxembourg B 172.226.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2016088515/10.
(160056797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

LKS 1, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 171.326.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016088516/9.
(160056875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

L.01 Laurus, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-3980 Wickrange, 7, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 92.159.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour L.01 LAURUS
Signature

Référence de publication: 2016088498/11.
(160056412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

Gramimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 162.973.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en

date du 10 août 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2501 du 17 octobre 2011.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GRAMIMMO S.A.
Signature

Référence de publication: 2016088414/14.
(160056545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

76310

L

U X E M B O U R G

DevStrat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 180.583.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DevStrat S.A.
Société anonyme
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2016088314/12.
(160056336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

Crismar Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 105.622.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Signature
<i>L'ADMINISTRATEUR UNIQUE

Référence de publication: 2016088306/12.
(160056490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

Dièdre, Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 95.133.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016088315/10.
(160056576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

Danieli Ecologia S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 67.626.

Les comptes annuels au 30 juin 2014, le rapport du conseil d'administration, le rapport du réviseur d'entreprise ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016088325/10.
(160056229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

DE Investment Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 74.341.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 97.015.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2016.

Référence de publication: 2016088328/10.
(160056285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

76311

L

U X E M B O U R G

Firebird Mongolia Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 154.863.

Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016088369/9.
(160056732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

Fidugia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 32, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 135.257.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016088379/9.
(160056828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

Fisogest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 44.696.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016088384/9.
(160056694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

FSS - Financial Services Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 198.755.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016088388/9.
(160056798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

GGC Boch Lux 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 201.225.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016088409/9.
(160056555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

GGC Boch Lux 2, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 201.226.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016088410/9.
(160056554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

76312

L

U X E M B O U R G

Diajewel Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 76.851.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 Avril 2016.

Diajewel Finance S.A.
Fides (Luxembourg) S.A.
<i>Liquidator

Référence de publication: 2016088330/14.
(160056786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

Dimant S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 147.526.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 avril 2016.

Référence de publication: 2016088333/10.
(160056956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

Etoile Centuria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 131.999.

<i>Rectificatif du dépôt initial L140199611 datant du 11/11/2014

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016088344/11.
(160056288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

Etoile Centuria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 131.999.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016088345/10.
(160056524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

Crif S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 192.173.

Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016088305/9.
(160056609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

76313

L

U X E M B O U R G

Skytec Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 77.692.

Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2016.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2016087387/12.
(160054784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

Skytec Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 77.692.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2016.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2016087388/12.
(160055121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

SMC Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 40.001.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2016.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2016087389/14.
(160055174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

Solferino Acquisition SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 175.989.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 23 mars 2016

L'associé unique de Solferino Acquisition (la "Société") a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de C.A.S. Services S.A. en tant que commissaire aux comptes;
et
- de nommer commissaire aux comptes, avec effet au 23 mars 2016 et pour une durée déterminée (jusqu'à la prochaine

assemblée générale en 2017 pour approuver les comptes annuels de la société):

* Guido Seleski, né le 29 juin 1972 à Hillegom, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 64 Avenue de la Liberté,

L-1930 Luxembourg

Luxembourg, le 31 mars 2016.

Référence de publication: 2016087368/16.
(160054873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

76314

L

U X E M B O U R G

Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 10.831.

EXTRAIT

Monsieur Magnus Wallberg a démissionné de son poste de délégué à la gestion journalière de Skandinaviska Enskilda

Banken S.A. (ci-après la „Société“) avec effet au 31 mars 2016. Le conseil d'administration de la Société a décidé de
nommer Monsieur Alan Hennebery domicilié professionnellement à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen, en tant que
délégué à la gestion journalière de la Société. Cette nomination a été approuvée par la Commission de Surveillance du
Secteur Financier et prend effet au 1 

er

 avril 2016 pour une durée illimitée. Monsieur Alan Hennebery a tous les pouvoirs

nécessaires pour représenter la Banque dans le cadre de la gestion journalière ainsi qu'un pouvoir de signature de catégorie
A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016087365/16.

(160055040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

SIVA, Société Immobilière de Vente et d'Achat, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5440 Remerschen, 21, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 9.890.

Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016087367/9.

(160054998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

Sportfield International 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 114.627.

DISSOLUTION

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 3 mars 2016 que:
1. L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du liqui-

dateur ainsi que les comptes de liquidation.

2. L'assemblée donne décharge pleine et entière au Liquidateur et au Commissaire à la liquidation, en ce qui concerne

l'exécution de leur mandat.

3. L'assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société;
4. Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au siège de la société, et en outre

que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associes qui ne se seraient pas présentés à la clôture
de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Luxembourg, le 31 mars 2016.

Signature
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2016087369/20.

(160055198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

Superstella S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 124.973.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016087373/9.

(160054801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

76315

L

U X E M B O U R G

Salveo Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 145.379.

La  convention  de  domiciliation  conclue  entre  TRUSTCONSULT  LUXEMBOURG  S.A.,  127  rue  de  Mühlenbach,

L-2168 Luxembourg, et la société SALVEO HOLDING S.A., société anonyme, enregistrée au registre de commerce de
Luxembourg sous le numéro RCS B 145379, a été dénoncée avec effet immédiat par le domiciliataire en date du 23 décembre
2015; le siège de la société est ainsi dénoncé.

Trustconsult Luxembourg S.A.
Signature
<i>Le Domiciliataire

Référence de publication: 2016087375/13.
(160054786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

Sangre Pura SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 183.882.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 31 mars 2016

Transfert du siège social de la Société du 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg au 1, Avenue de la Gare, L-1611

Luxembourg.

Démission de Monsieur Alfred GUETTI, administrateur unique de la société et démission du commissaire aux comptes

à savoir AUDIT TRUST S.à r.l.

Nomination de Monsieur Claude SCHROEDER, né le 02/03/1973 à Ettelbruck, demeurant professionnellement à 1,

Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2016.

<i>Pour: SANGRE PURA SPF S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2016087376/20.
(160055212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

Universal Management Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 64.474.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique

En date du 29 février 2016, l'associé unique a décidé de révoquer Monsieur Johan DEJANS en tant que gérant de la

société, et ce avec effet au 1 

er

 avril 2016.

Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- Madame Virginie DOHOGNE;
- Monsieur Hugo FROMENT;
- Monsieur Andrew O’SHEA;
- Monsieur Hille-Paul SCHUT;
- Monsieur Douwe TERPSTRA;
- Monsieur Frank WELMAN.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2016.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016087423/21.
(160054997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

76316

L

U X E M B O U R G

Titanium Bloomsbury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 110.000,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 202.878.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des associés, tenue en date du 29 février 2016 que:
- la démission de Monsieur Michael Furth, Monsieur Sam Agnew and Madame Yvanna Essomba en tant que gérants

de la Société est acceptée avec effet au 29 février 2016;

- GS Lux Management Services S.à r.l., ayant son siège social au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 88045, est nommé gérant de la Société avec effet au 29 février 2016 et ce pour une
durée indéterminée;

- Eloïse N’Takpé, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg, est nommé gérant de la Société avec effet au 29 février 2016 et ce pour une durée indéterminée;

- Stephen Leung, ayant son adresse professionnelle au 15 Finsbury Circus, 6 

ème

 étage, EC2M 7EB Londres, Royaume-

Uni, est nommé gérant de la Société avec effet au 29 février 2016 et ce pour une durée indéterminée;

- Iliya Blazic, ayant son adresse professionnelle au 15 Finsbury Circus, 6 

ème

 étage, EC2M 7EB Londres, Royaume-

Uni, est nommé gérant de la Société avec effet au 29 février 2016 et ce pour une durée indéterminée.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 29 février 2016, composé comme suit:
- GS Lux Management Services S.à r.l. Gérant
- Marielle STIJGER, Gérant
- Alexis DE MONTPELLIER D’ANNEVOIE, Gérant
- Eloise N’TAKPE, Gérant
- Stephen LEUNG, Gérant
- Iliya BLAZIC, Gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016087402/28.
(160055108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

Tilford Marine Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 169.766.

Il est porté à la connaissance de tous:
- que Monsieur KASSIDOKOSTAS Christian Paris associé de la société Tilford Marine Investments (société sise au

24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 169.766) est domicilié à l'adresse suivante:

2, rue Anemon and Diogenous
16671, Vouliagmeni
Grèce
Référence de publication: 2016087401/14.
(160055270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

Republika Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 178.648.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
Republika Luxembourg Holdings S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2016087345/12.
(160055109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

76317

L

U X E M B O U R G

Sani Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 69.312.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 202.074.

EXTRAIT

En date du 29 décembre 2015 M. Justin Bickle a démissionné de son poste de gérant de la Société, avec effet au 29

décembre 2015.

Le même jour, l'associé unique de la Société a nommé M. Andreas Andreadis, né le 1 

er

 janvier 1951 à Thessalonique,

Grèce, ayant son adresse professionnelle sise au N. Plastira Str. 55, 542 50 Thessalonique, Grèce, en tant que gérant de la
Société, avec effet au 29 décembre 2015 et pour une durée indéterminée.

Par la suite et par décision prise en date du 2 Mars 2016, l'associé unique de la Société a accepté la démission de M.

Andreas Andreadis, susmentionné, de son mandat de gérant de la Société, avec effet au 2 mars 2016.

Il en résulte que le conseil de surveillance de la Société se compose désormais comme suit:
- Mathieu Guillemin, gérant de catégorie A;
- Arnold Spruit, gérant de catégorie A;
- Catherine Koch, gérant de catégorie B;
- Anne-Catherine Grave, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2016.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2016087362/24.
(160055115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 37.799.

EXTRAIT

Au 1 

er

 avril 2016 Monsieur Alastair Woodward a été nominé administrateur de la société pour une durée déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra le 19 avril 2016.

L'adresse de Monsieur Woodward est la suivante:
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
G.D. Luxembourg

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2016.

Nathalie Wolff
<i>Director

Référence de publication: 2016087378/17.
(160055107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

Sole Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1540 Luxembourg, 36, rue Benjamin Franklin.

R.C.S. Luxembourg B 143.517.

<i>Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 10 février 2016

Le conseil d'administration décide de nommer l'Etude d'Avocat de Maître Dogan DEMIRCAN, Avocat à la Cour et dont

l'Etude est sise au 36 rue Benjamin Franklin à L-1540 Luxembourg, en tant que dépositaire des titres au porteur de la
société.

Luxembourg, le 18 février 2016.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2016087391/13.
(160054874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

76318

L

U X E M B O U R G

VCST Holdco Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 147.362.

EXTRAIT

En date du 24 mars 2016, l'actionnaire unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
1) Phimadran Management AB, representé par Monsieur Olof Joakim Olsson a été révoqué de son mandat d'adminis-

trateur de la Société avec effet immédiat;

2) l'actionnaire unique a pris connaissance de la démission des personnes suivantes de leurs postes d'administrateur de

la Société:

- Verpal NV, representé par Monsieur Robert Verhoeven, avec effet immédiat;
- Monsieur Guy Mampaey, avec effet immédiat;
- Monsieur Carlo Soors, avec effet immédiat;
- Monsieur Nick Medaer, avec effet immédiat;
- Monsieur Hansjorg Gerhard Sage, avec effet au 22 septembre 2015;
- Monsieur Gerard Simon Jozef Burgers, avec effet au 1 

er

 janvier 2015; et

- et pour autant que nécessaire de la démission de Monsieur Robert Ian Oei, avec effet immédiat.
3) l'actionnaire unique a décidé de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateur avec effet immédiat et pour

une période de 6 ans:

- Monsieur Jean-Christophe Seynaeve, né à Kortrijk, Belgique le 5 novembre 1969 résidant au 1 Blommeke, Beernem

B-8730 Belgique;

- Monsieur Johan De Lille, né à Bruges, Belgique le 12 juin 1962 résidant au 604 Gaversesteenweg, Merelbeke B-9820

Belgique; et

- Monsieur Hans De Vuyst, né à Aalst, Belgique le 13 février 1958 et résidant au 35 rue Giselbert L-1627 Luxembourg;
En conformité avec l'article 11 des statuts de la Société, la Société sera engagée envers les tiers par la signature conjointe

de deux membres du conseil d'administration.

Il en résulte que le conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit:
- Monsieur Jean-Christophe Seynaeve, administrateur;
- Monsieur Johan De Lille, administrateur;
- Monsieur Hans De Vuyst, administrateur;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2016.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2016087427/36.
(160055066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

Viclux Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 196.990.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue le 01.04.2016 que:
- Le siège social de la Société a été transféré du 1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 7, route d'Esch, L-1470

Luxembourg;

- Les démissions de (i) M. Francesco Olivieri, (ii) M. Roberto Peroni and (iii) Mme Kristen Simat de leurs fonctions

d'administrateur de la Société ont été acceptées;

- La démission de LARFIN S.A. de ses fonctions de commissaire aux comptes de la Société a été acceptée;
- REVYS S.à.r.l, ayant son siège social au 23, rue des Jardiniers L-1835 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre

du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 198 210 a été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes de la
Société. Son mandat d'administrateur prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société
qui se tiendra en 2021;

- Louis FELICETTI, salarié, né le 25 juin 1966 à L- Echternach et demeurant professionnellement au 7, route d'Esch à

L-1470 Luxembourg a été nommé aux fonctions d'administrateur de la société. Son mandat d'administrateur prendra fin à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2021;

76319

L

U X E M B O U R G

- Fernand SASSEL, expert-comptable, né le 16 avril 1959 à L-Clervaux et demeurant professionnellement au 7, route

d'Esch à L-1470 Luxembourg a été nommé aux fonctions d'administrateur de la société. Son mandat d'administrateur
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2021;

- Edith REUTER, comptable, née le 05 janvier 1958 à L-Luxembourg et demeurant professionnellement au 7, route

d'Esch à L-1470 Luxembourg a été nommée aux fonctions d'administrateur de la société. Son mandat d'administrateur
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2021.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016087429/28.

(160055182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2016.

Altice Entertainment News &amp; Sport S.A., Société Anonyme,

(anc. Altice Entertainment &amp; Sport S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 170.036.

L'an deux mille seize, le vingt-six février.
Par-devant nous Maître Jacques KESSELE R, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU

La société ALTICE CONTENT S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social

est situé 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.647, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Pétange en vertu d'une procuration donnée sous seing privé (le «Manda-
taire»).

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le Mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au

présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

ALTICE CONTENT S.à r.l., précitée, représentée comme décrit ci-dessus, prie le notaire soussigné d'acter qu'elle est

l'actionnaire unique (l'«Actionnaire Unique») de la société ALTICE ENTERTAINMENT &amp; SPORT S.A. ayant son siège
social à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg  sous  le  numéro  B  170.036,  (ci-après  la  «Société»),  constituée  suivant  un  acte  reçu  par  Maître  Francis
KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 3 juillet 2012, lequel acte a été publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1987 du 9 août 2012. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière
fois en date du 28 mai 2015, par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1906 du 29 juillet 2015.

Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d'Actionnaire Unique de la Société, a de-

mandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Actionnaire Unique décide de changer la dénomination sociale de la Société en «Altice Entertainment News &amp; Sport

S.A.».

<i>Deuxième résolution

Dans le prolongement de la résolution qui précède, l'Actionnaire Unique décide de procéder à la modification de l'article

1 des statuts de la Société, afin de lui donner le contenu suivant:

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "ALTICE ENTERTAINMENT NEWS &amp; SPORT

S.A." (ci-après la «Société»), soumises aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle
qu'amendée (ci-après, la «Loi») ainsi qu'aux dispositions des présents statuts (les «Statuts»)».

DONT ACTE, le présent acte est fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au Mandataire du comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, celui-ci a

signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 mars 2016. Relation: EAC/2016/5591. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016082478/45.
(160049476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

76320


Document Outline

AI Global Investments &amp; CY S.C.A.

Altice Entertainment News &amp; Sport S.A.

Altice Entertainment &amp; Sport S.A.

Crif S.à r.l.

Crismar Investissements S.A.

Danieli Ecologia S.A.

DE Investment Group S.à r.l.

DevStrat S.A.

Diajewel Finance S.A.

Dièdre

Dimant S.A.

Edinburgh Georges Street S.à r.l.

ESCO Finance International S.à r.l.

Etoile Centuria S.à r.l.

Etoile Centuria S.à r.l.

Fidugia S.A.

Firebird Mongolia Holdings S.à r.l.

Fisogest S.A.

FSS - Financial Services Solutions S.à r.l.

GGC Boch Lux 1

GGC Boch Lux 2

Gramimmo S.A.

L.01 Laurus

Liga Holding S.A.

Liga Holding S.à r.l.

LKS 1

Perspective Croissance Holding S.A.

Republika Luxembourg Holdings S.à r.l.

RubySphere

Salveo Holding S.A.

Sangre Pura SPF S.A.

Sani Luxco S.à r.l.

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Skytec Group S.A.

Skytec Group S.A.

SMC Real Estate S.A.

Société Immobilière de Vente et d'Achat

Sole Invest S.A.

Solferino Acquisition SA

Sportfield International 1 S.à r.l.

Superstella S.à r.l.

Tetraktys S.C.A.

Tilford Marine Investments

Titanium Bloomsbury S.à r.l.

Universal Management Services Sàrl

VCST Holdco Lux S.A.

Viclux Soparfi S.A.