This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1523
26 mai 2016
SOMMAIRE
Advent Therapy (Luxembourg) Finance S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73101
Advent Therapy (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . .
73099
Avocado Partnership Luxembourg S.C.A. . . .
73068
Berlys Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
73104
Cauren S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73065
CMS Management Services S.A. . . . . . . . . . . .
73059
CNR International (Luxembourg) S.A. . . . . . .
73059
Davmar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73067
De Gier & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73058
Delta International Holding S.à r.l. . . . . . . . . .
73058
Deutsche Bank Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .
73059
Devon Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73058
DH Blythe Valley S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73067
Digital Services LIII (GP) S.à r.l. . . . . . . . . . . .
73079
Domain Tools Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73067
DROPINVEST S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73066
Dune Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73066
Eren Grece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73066
Eridanus Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
73058
Financière Vasco de Gama . . . . . . . . . . . . . . . .
73066
H3 Group s. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73061
Honos Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . . . .
73090
Inreca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73062
IQS Avantiq Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
73063
Jandvi Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73063
KOR Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73059
KOR Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73063
LKS 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73064
Luxbauhaus Promotions . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73064
MBERP II (Luxembourg) 27 S.à r.l. . . . . . . . .
73062
Melpa International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
73061
Memba S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73065
Montreux Regard Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
73062
MPC International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73062
NEXT AM Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73060
PBG Soda Can Holdings S. à r.l. . . . . . . . . . . .
73060
Pearl Luxury Information Technology . . . . . .
73060
PepsiCo Global Investments S.à r.l. . . . . . . . . .
73061
PepsiCo Group Spotswood Holdings S.C.S. . .
73061
PepsiCo Investments Luxembourg S.à r.l. . . .
73063
PHR Investments Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73103
PRB Luxembourg International S. à r.l. . . . . .
73060
RREEF EuCoReF 1 S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
73104
Silvertower 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73103
Sistema Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73064
SL2AC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73064
VHPE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73065
Wellness House S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73065
73057
L
U X E M B O U R G
De Gier & Co, Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 184.539.
Par lettre recommandée datée du 16 mars 2016, KPMG Luxembourg Société Coopérative, inscrite auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B149133, a procédé à la dénonciation avec effet du 16 mars
2016 du siège social actuel de la société De Gier & Co, située au 39 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, et
inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B184539.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2016.
Eric Wilhelm.
Référence de publication: 2016081267/12.
(160047405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Devon Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 100.004,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 185.751.
L'adresse du gérant de classe A suivant a changé comme suit:
Geoffrey D.L. Picrit, avec adresse professionnelle au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Devon Holdings S.à r.l.
Domenico Latronico
<i>Gérant de classe Bi>
Référence de publication: 2016081271/14.
(160047513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Delta International Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 98.433.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 10 mars 2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a déclaré rouverte la liquidation de la société DELTA INTERNATIONAL HOLDING SARL, dont le siège
social à L-1840 Luxembourg, 11A, Boulevard Joseph II, a été dénoncé en date du 21 juin 2005.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anick WOLFF et liquidateur Maître Yasemin CENGIZ-
KIYAK, avocat, demeurant à Luxembourg.
Pour extrait conforme
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016081279/14.
(160047694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Eridanus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.010,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 104.239.
L'adresse du gérant A suivant a changé comme suit:
Geoffrey D.L. Picrit, avec adresse professionnelle au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Eridanus Investments S.à r.l.
Domenico Latronico
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2016081305/14.
(160047512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
73058
L
U X E M B O U R G
CMS Management Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 81.525.
Une liste des fondés de pouvoirs de la Société CMS Management Services S.A. en fonction au 7 Mars 2016 a été déposée
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CMS Management Services S.A.
Signatures
Référence de publication: 2016081258/12.
(160047701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 9.164.
<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 17. März 2016:i>
Herr Karl von Rohr hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates mit Ablauf des 14. März 2016 niedergelegt.
Herr Frank Rückbrodt, geschäftsansässig in Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt, wird mit Wirkung zum 15. März
2016 als Mitglied des Aufsichtsrates ernannt. Die Laufzeit des Mandats ist begrenzt auf die Generalversammlung, die im
Jahre 2016 stattfindet.
Luxemburg.
Référence de publication: 2016081281/13.
(160047790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
KOR Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 159.660.
Il résulte d'une décision du gérant unique du 11 mars 2016 que:
Le siège social de la société a été transféré à L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen, avec effet au 1
er
février 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016081416/12.
(160047922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
CNR International (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 88.245.
En date du 16 mars 2016, l'actionnaire unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de monsieur Douglas Proll de son poste d'administrateur de catégorie A de la Société avec
effet au 31 janvier 2016; et
- nomination de monsieur Murray Glenn Harris, né le 24 septembre 1963 à Swan River, Canada et résidant au 561
Sunmills Drive SE, à Calgary au Canada, au poste d'administrateur de catégorie A avec effet au 1
er
février 2016 et ce
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'actionnaire unique de la Société qui approuvera les comptes de la Société au 31
octobre 2015 et qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016081891/17.
(160048517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
73059
L
U X E M B O U R G
PBG Soda Can Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.400,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 108.205.
L'adresse du gérant A suivant a changé comme suit:
Geoffrey D.L. Picrit, avec adresse professionnelle au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
L'adresse du siège social de l'associé suivant a changé comme suit:
PBG Midwest Holdings, S.à r.l. se situe désormais au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PBG Soda Can Holdings S.à r.l.
Domenico Latronico
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2016081549/16.
(160048121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
PRB Luxembourg International S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 272.098.600,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 140.891.
L'adresse du gérant A suivant a changé comme suit:
Geoffrey D.L. Picrit, avec adresse professionnelle au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRB Luxembourg International S.à r.l.
Domenico Latronico
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2016081560/14.
(160048116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Pearl Luxury Information Technology, Société Anonyme.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 92, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 169.213.
Le commissaire aux comptes LUX-FIDUCIAIRE Consulting SARL ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12,
rue Ste Zithe a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet au 15/03/2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2016.
Référence de publication: 2016081530/11.
(160047764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
NEXT AM Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Hesperange, 60, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 168.626.
<i>Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration du 10 février 2016i>
En date du 10 février 2016, le Conseil D'Administration prend note de la démission de M. Philippe Verdier en tant
qu'administrateur de la Société
En date du 10 février 2016, le Conseil D'Administration décide de coopter Mme Isabelle Kintz, résidant professionnel-
lement au 2, Boulevard de la Foire, L 1528 Luxembourg en tant qu'administrateur à partir du 10 février 2016 pour une
durée déterminée qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016
Référence de publication: 2016081510/13.
(160047984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
73060
L
U X E M B O U R G
PepsiCo Global Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 5.018.003,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 131.094.
L'adresse du gérant A suivant a changé comme suit:
Geoffrey D.L. Picrit, avec adresse professionnelle au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg à partir du 1
er
janvier 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PepsiCo Global Investments S.à r.l.
Domenico Latronico
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2016081531/15.
(160048120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
PepsiCo Group Spotswood Holdings S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: USD 1.000.035,00.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 163.853.
L'adresse du siège social de l'associé et de l'associé gérant commandité suivant a changé:
PepsiCo Group, société coopérative, se situe désormais au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PepsiCo Group
<i>Associé Commandité
i>Représenté par Domenico Latronico
<i>Administrateur Bi>
Référence de publication: 2016081532/15.
(160048119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Melpa International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 145.519.
<i>Extrait de la résolution prise par l'actionnaire unique en date du 11 mars 2016i>
- La démission de Monsieur Ahcène BOULHAIS de son mandat d'Administrateur est acceptée, avec effet immédiat.
Fait à Luxembourg, le 11 mars 2016.
Certifié sincère et conforme
MELPA INTERNATIONAL S.A.
Référence de publication: 2016081487/12.
(160047501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
H3 Group s. à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 144.911.
Le contrat de domiciliation, et en conséquence le siège social de la société H3 GROUP S.à.r.l., RCS B 144 911, au 5,
Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ont été dénoncés en date du 17 mars 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2016.
Signature
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2016081360/12.
(160047771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
73061
L
U X E M B O U R G
Montreux Regard Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 39, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 189.908.
Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société au 39, Avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, avec effet rétroactif au 1
er
Janvier 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 Mars 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016081472/13.
(160047464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
MBERP II (Luxembourg) 27 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 1.434.709,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 198.538.
Il résulte des résolutions du conseil de gérance prises en date du 02 mars 2016 que:
- le siège social de la Société est transféré au 12C Impasse Drosbach à L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2016.
MBERP II (Luxembourg) 27 S.à r.l.
Référence de publication: 2016081480/13.
(160047758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
MPC International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 88.792.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Firma «MPC International S.A.»i>
<i>Abgehalten am 16. März 2016 um 13.00 Uhr in Luxemburgi>
Die Generalversammlung beschließt das Mandat des Rechnungskommissars „Jean Kayser“ nicht zu verlängern und
bestimmt zum neuen Rechnungskommissar die Gesellschaft «AUDIEX SA.» mit Sitz in L-1911 Luxembourg, 9, rue du
Laboratoire, Handelsregisternummer: B 65 469. Sie wird zum neuen Rechnungskommissar ernannt, bis zur Generalver-
sammlung die im Jahre 2017 stattfindet.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Ein Verwaltungsratsmitgliedi>
Référence de publication: 2016081499/15.
(160047528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Inreca S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 103.380.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 10 mars 2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société INRECA S.A., dont le siège social
à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, a été dénoncé en date du 24 mars 2009 et a mis les frais à charge de
la masse.
Pour extrait conforme
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016081386/13.
(160047695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
73062
L
U X E M B O U R G
IQS Avantiq Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.312.875,00.
Siège social: L-5850 Howald, 2, rue Sangenberg.
R.C.S. Luxembourg B 119.285.
Par courrier du 16 novembre 2015, Madame Catherine McGirr a démissionné avec effet immédiat de sa fonction de
gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IQS Avantiq Luxembourg S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016081393/13.
(160047812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Jandvi Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 182.097.
EXTRAIT
L'actionnaire unique a pris note de ce qui suit:
Madame Yeliz Bozkir démissionne de son mandat d'Administrateur de classe A de la Société avec effet à la date du 15
mars 2016.
Monsieur Victor Hugo Froes de Melo démissionne de son mandat d'Administrateur de classe B de la Société avec effet
à la date du 15 mars 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016081396/14.
(160047532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
KOR Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 159.660.
Il résulte d'une décision du gérant unique du 11 mars 2016 que:
Madame Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, née le 30 août 1969 à Villerupt (F), a changé de résidence profes-
sionnelle, avec effet au 1
er
janvier 2016, résidant dorénavant au L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016081417/13.
(160047922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
PepsiCo Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.001,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 150.391.
L'adresse du gérant A suivant a changé comme suit:
Geoffrey D.L. Picrit, avec adresse professionnelle au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PepsiCo Investments Luxembourg S.à r.l.
Domenico Latronico
<i>Gérant de classe Bi>
Référence de publication: 2016081534/14.
(160048117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
73063
L
U X E M B O U R G
LKS 1, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 171.326.
Nach dem Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30 Juni 2015 wird:
- Herr Ian Kent als Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung abgerufen und
- Frau Kathryn O'Sullivan, geboren am 28 Juni 1963 in San Jose, Vereinigte Staaten, mit professioneller Adresse 47,
avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg, als Geschäftsführer (Franz.: administrateur) der Gesellschaft und Mitglied
des Verwaltungsrates (Franz.: conseil d'administration) mit sofortiger Wirkung genannt. Ihr Mandat dauert bis zur Haupt-
versammlung der Gesellschaft an deren die Entscheidung über den Jahresabschluss vom 31 Dezember 2018 getroffen wird.
Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates (Franz.: conseil d'administration) besteht hiermit wie folgend:
- Daniel Setton,
- Jennifer Ferrand und
- Kathryn O‘ Sullivan
Das Verwaltungsreglement wurde einregistriert und beim Handels- und Firmenregister hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016081447/19.
(160047424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Luxbauhaus Promotions, Société Anonyme.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 36, rue du Dernier Sol.
R.C.S. Luxembourg B 182.482.
Est nommé à la fonction d'administrateur délégué et de Président: Monsieur Jean-Daniel HAMET demeurant 29, Rue
Jean-Pierre Brasseur L - 1258 Luxembourg en lieu et place de Monsieur ZUPANOSKI Robert décédé Durée du mandat:
déterminée Date de nomination: 02/03/2016 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2019.
Référence de publication: 2016081451/11.
(160047919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Sistema Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 93.023.
Il résulte qu'en date du 3 Mars 2016:
1. Le siège social de la société est transféré avec effet au 1
er
Mars 2016 du 26-28, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg au 26, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
Luxembourg, le 17 mars 2016.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016081620/13.
(160047627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
SL2AC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 192.710.
Il résulte d'une décision du conseil d'administration du 11 mars 2016 que:
Le siège de la société a été transféré à L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen, avec effet au 1
er
février 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016081622/11.
(160047923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
73064
L
U X E M B O U R G
VHPE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 148.182.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 19 février 2016, que:
L'Assemblée Générale nomme comme gérants, avec effet à ce jour, Monsieur Hans VANOORBEEK et Monsieur John
BLYDENSTEIN ayant leur adresse professionnelle au 25C, Boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG. Ils sont élus avec
un pouvoir de signature conjoint.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2016.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016081690/16.
(160047674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Wellness House S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 141.513.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement du 3 mars 2016, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a
déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société:
- WELLNESS HOUSE SA, avec siège social à L-2449 LUXEMBOURG, 8 bd Royal, inscrite au registre de commerce
sous le numéro B 141513
Pour extrait conforme
Maître Marie-Christine GAUTIER
<i>Le liquidateur
i>22, rue Marie-Adélaïde
L-2128 Luxembourg
Référence de publication: 2016081704/17.
(160047820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Cauren S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 29.619.
Le soussigné Etienne GILLET, 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, démissionne avec effet immédiat
de son poste d'administrateur de la société CAUREN S.A., 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, RCS
Luxembourg B 29.619.
Luxembourg, le 18 mars 2016.
Etienne GILLET.
Référence de publication: 2016081878/11.
(160048766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
Memba S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 76.178.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2016.
Référence de publication: 2016077337/10.
(160042874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
73065
L
U X E M B O U R G
DROPINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 202.682.
<i>Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société eni>
<i>date du 8 février 2016i>
Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:
- d'accepter la démission de DATA GRAPHIC S.A. de ses fonctions de Commissaire aux comptes.
- de nommer à la fonction de Commissaire aux comptes de la Société, Monsieur Nicolas GODFREY, né à Courtrai
(Belgique) le 27/01/1984 et résidant au 4C Fleeschgaass, 6665 Herborn (Luxembourg) jusqu'à l'Assemblée générale an-
nuelle des actionnaires qui se tiendra en l'année 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016082662/17.
(160049656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.
Dune Lux, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1950 Luxembourg, 14, rue Auguste Lumière.
R.C.S. Luxembourg B 185.397.
<i>Extrait rectificatif du dépôt N°L150042902i>
Par résolutions prises en date du 27 Février 2014, les statuts mentionnent Mademoiselle Alix le LEVREUR-BARTON
en tant que gérante à durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016082672/12.
(160049400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.
Eren Grece, Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 4, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 180.272.
<i>Extrait des résolutionsi>
Il résulte d'une décision de la réunion du Conseil d'Administration, adoptée lors de sa réunion du 1
er
mars 2016, que le
siège social est transféré au 4, rue Willy Goergen L-1636 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 21 mars 2016.
Référence de publication: 2016082706/12.
(160049379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.
Financière Vasco de Gama, Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 61.097.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société tenu en date du 14 mars 2016 que Monsieur Jean-
Marc FABER, né le 7 avril 1966 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg, a été nommé Président du Conseil d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2016082745/13.
(160049375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.
73066
L
U X E M B O U R G
Davmar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 374.874.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 117.181.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 23 novembre 2015i>
1) La démission de Mr. Christiaan Van Arkel et de Ms. Jana Strischek, de leur mandat de Gérant B de la société est
acceptée;
2) Monsieur Thierry JACOB, diplômé de l'Institut Commercial de Nancy, né le 7 juillet 1967 à Thionville, France,
demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommé Gérant de catégorie B avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée.
3) Monsieur Christian MOGNOL, Dipl.-Kfm/ESCP Europe, né le 15 janvier 1962 à Esch-Sur-Alzette, Luxembourg, et
résidant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommé Gérant de catégorie B avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée.
4) Monsieur Maxime TOQUE, employé privé, né le 6 février 1987 à Cholet, France et demeurant professionnellement
au 412F Route d'Esch, L-2086 Luxembourg est nommé Gérant de catégorie B avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.
5) Le siège social de la société est transféré du 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg au 412F, Route d'Esch
L2086 Luxembourg, avec effet immédiat.
Référence de publication: 2016082654/22.
(160049520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.
DH Blythe Valley S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 129.074.
Par la présente, il est pris acte que:
- DHCRE Holdco S.à r.l., ayant son adresse domicile à 28 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a mis fin à son mandat
de gérant de la Société le 14 mars 2016.
- Monsieur Ludovic Colle, ayant son adresse professionnelle à 28 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé
gérant de la Société avec effet le 14 mars 2016 et ce, pour une durée indéterminée.
- Monsieur Richard Lund, ayant son adresse professionnelle à 45, Pall Mall, GB - SW1Y 5JG London, a été nommé
gérant de la Société avec effet le 14 mars 2016 et ce, pour une durée indéterminée.
- Monsieur Gérard Becquer, ayant son adresse professionnelle à 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été
nommé gérant de la Société avec effet le 14 mars 2016 et ce, pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg le 14 mars 2016.
Ludovic Colle
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016082656/21.
(160049409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.
Domain Tools Holdings, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-3372 Leudelange, 21, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 147.569.
Le siège social de la société est désormais établi au 21, rue Léon Laval L-3372 Leudelange
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2016.
Référence de publication: 2016082651/11.
(160049357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.
73067
L
U X E M B O U R G
Avocado Partnership Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 202.138.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-sixth day of the month of February.
Before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
was held
a general meeting of the shareholders of Avocado Partnership Luxembourg S.C.A., a société en commandite par actions,
incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (the “RCS”) in Luxembourg under number B 202138, incorpo-
rated by a deed of Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg dated 20 November
2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 524 of 23 February 2016 (the “Mémorial”),
acting through its general partner Avocado General Partner Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having
its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred
euros (EUR 12,500), being registered with the RCS in Luxembourg under number B 203916 (the “Company”). The articles
of association of the Company have been amended for the last time by deed of the undersigned notary, residing in Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 10 February 2016, not yet published in the Mémorial.
The meeting was presided by Maître Vianney de Bagneaux, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
There was appointed as secretary and scrutineer Maître Justine Peduzzi, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to record that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the
proxyholder(s), the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will remain attached
to this document to be filed with the registration authorities.
As it appears from said attendance list, all the shares in issue in the Company were represented at the present general
meeting. The same meeting waived the convening notices, the shareholders represented considering themselves as having
perfect knowledge of the agenda which was communicated to them in advance.
2. As a result of the foregoing, the present meeting was regularly constituted and could validly deliberate on all items
of the agenda.
3. The agenda of the meeting was as follows:
<i>Agendai>
A. Restructuration of the issued share capital of the Company by Changing the nominal value of the existing shares
from one euro (EUR 1) to 10 cents of euro (EUR 0.10) and reclassifying all the fifty-two thousand five hundred (52,500)
existing shares of the Company into ten (10) unlimited shares and five hundred twenty-four thousand nine hundred ninety
(524,990) limited shares of a nominal value of 10 cents of euro (EUR 0.10) each;
B. Authorisation for the creation and issuance by the Company of redeemable shares in accordance with article 49-8 of
the law of 10 August 1915 on commercial companies (the “Company Law”);
C. Creation of ten (10) different classes of shares within the limited shares of the Company, namely (i) ordinary limited
shares (the “Ordinary Limited Shares”) and (ii) class A redeemable limited shares, class B redeemable limited shares, class
C redeemable limited shares, class D redeemable limited shares, class E redeemable limited shares, class F redeemable
limited shares, class G redeemable limited shares, and class I redeemable limited shares (the class A to I redeemable shares
being referred together as the “Alphabet Shares”), the Alphabet Shares being redeemable shares in accordance with article
49-8 of the Company Law. The Alphabet Shares shall be sub-divided into five sub-categories of redeemable limited shares
each, namely sub-category A1 limited shares, sub-category A2 limited shares, sub-category B limited shares, sub-category
C1 limited shares, and sub-category C2 limited shares and determining the rights and obligations thereof by amending the
articles of association as set forth below;
D. Reclassifying all the five hundred twenty-four thousand nine hundred ninety (524,990) existing limited shares of a
nominal value of 10 cents of euro (EUR 0.10) into five hundred twenty-four thousand nine hundred ninety (524,990)
Ordinary Limited Shares of a nominal value of 10 cents of euro (EUR 0.10);
E. Increase the issued share capital of the Company from its current amount of fifty-two thousand five hundred Euros
(EUR 52,500) to two hundred fifty-three thousand four hundred seventy-nine Euros and thirty cents (EUR 253,479.30) by
the issue of two hundred twenty-three thousand three hundred thirteen (223,313) class A redeemable limited shares, being
one hundred and eleven thousand six hundred fifty-six (111,656) class A-A1 redeemable limited shares and one hundred
and eleven thousand six hundred fifty-seven (111,657) class A-A2 redeemable limited shares, two hundred twenty-three
thousand three hundred ten (223,310) class B redeemable limited shares, being one hundred and eleven thousand six hundred
fifty-five (111,655) class B-A1 redeemable limited shares and one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five
(111,655) class B-A2 redeemable limited share, two hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310) class C
redeemable limited shares, being one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class C-A1 redeemable
73068
L
U X E M B O U R G
limited shares and one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class C-A2 redeemable limited shares,
two hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310) class D redeemable limited shares, being one hundred and
eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class D-A1 redeemable limited shares and one hundred and eleven thou-
sand six hundred fifty-five (111,655) class DA2 redeemable limited shares, two hundred twenty-three thousand three
hundred ten (223,310) class E redeemable limited shares, being one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five
(111,655) class E-A1 redeemable limited shares and one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655)
class E-A2 redeemable limited shares, two hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310) class F redeemable
limited shares, being one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class F-A1 redeemable limited
shares and one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class F-A2 redeemable limited shares, two
hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310) class G limited shares, being one hundred and eleven thousand
six hundred fifty-five (111,655) class G-A1 redeemable limited shares and one hundred and eleven thousand six hundred
fifty-five (111,655) class G-A2 redeemable limited shares, two hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310)
class H redeemable limited shares, being one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class H-A1
redeemable limited shares and one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class HA2 redeemable
limited shares, and two hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310) class I redeemable limited shares, being
one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class I-A1 redeemable limited shares and one hundred
and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class I-A2 redeemable limited shares, of a nominal value of 10 cents
of euro (EUR 0.10) each, for a total subscription price of two million nine thousand seven hundred and ninety-three Euros
(EUR 2,009,793) (the “Subscription Price”); subscription to the new shares by Avocado Topco Luxembourg S.à r.l.;
payment of the Subscription Price by Avocado Topco Luxembourg S.à r.l. by way of a contribution in cash; allocation of
the nominal value of the new shares of an amount of two hundred thousand nine hundred seventy-nine Euros and thirty
cents (EUR 200,979.30) so issued to the share capital and an aggregate amount of one million eight hundred eight thousand
eight hundred thirteen Euros and seventy cents (EUR 1,808,813.70) to the freely distributable share premium account;
F. Amendment of article 5, 16, 17 of the articles of association of the Company and insertion of a new article 19 of the
articles of association of the Company as set forth below:
Art. 5. Share Capital.
5.1. The issued share capital of the Company shall be represented by two classes of shares, namely (i) unlimited share
(s) (“Unlimited Shares”) held by the Manager (as defined below) as unlimited liability Shareholder (actionnaire comman-
dité) and (ii) limited shares (“Limited Shares”) held by the limited liability Shareholders (actionnaires commanditaires) of
the Company. The Limited Shares shall be divided into ten (10) different classes of Limited Shares, namely (i) the ordinary
Limited Shares (the “Ordinary Limited Shares”) and (ii) the class A Redeemable Limited Shares, the class B Redeemable
Limited Shares, the class C Redeemable Limited Shares, the class D Redeemable Limited Shares, the class E Redeemable
Limited Shares, the class F Redeemable Limited Shares, the class G Redeemable Limited Shares, the class H Redeemable
Limited Shares and the class I Redeemable Limited Shares (the class A Limited Shares to the class I Limited Shares being
collectively referred to as the “Alphabet Shares”). Each class of Alphabet Shares is itself sub-divided into five (5) subca-
tegories, namely sub-category A1, A2, B, C1 and C2 so that the Company's share capital is represented as set forth in article
5.2 below.
Limited Shares (including the Ordinary Limited Shares and the Alphabet Shares) and Unlimited Shares shall be referred
to as a “Share” and collectively as the “Shares”, whenever the reference to a specific class of shares is not justified or
required.
5.2. The issued share capital of the Company is set at two hundred fifty-three thousand four hundred seventy-nine Euros
and thirty cents (EUR 253,479.30) represented by:
- ten (10) fully paid up Unlimited Share;
- five hundred twenty-four thousand nine hundred ninety (524,990) Ordinary Limited Shares;
- two hundred twenty-three thousand three hundred thirteen (223,313) class A Redeemable Limited Shares divided into:
* one hundred and eleven thousand six hundred fifty-six (111,656) class A-A1 Limited Shares;
* one hundred and eleven thousand six hundred fifty-seven (111,657) class A-A2 Limited Shares;
- two hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310) class B Redeemable Limited Shares divided into:
* one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class B-A1 Limited Shares;
* one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class B-A2 Limited Shares;
- two hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310) class C Redeemable Limited Shares divided into:
* one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class C-A1 Limited Shares;
* one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class C-A2 Limited Shares;
- two hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310) class D Redeemable Limited Shares divided into:
* one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class D-A1 Limited Shares;
* one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class D-A2 Limited Shares;
- two hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310) class E Redeemable Limited Shares divided into:
* one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class E-A1 Limited Shares;
73069
L
U X E M B O U R G
* one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class E-A2 Limited Shares;
- two hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310) class F Redeemable Limited Shares divided into:
* one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class F-A1 Limited Shares;
* one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class F-A2 Limited Shares;
- two hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310) class G Redeemable Limited Shares divided into:
* one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class G-A1 Limited Shares;
* one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class G-A2 Limited Shares;
- two hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310) class H Redeemable Limited Shares divided into:
* one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class H-A1 Limited Shares;
* one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class H-A2 Limited Shares;
- two hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310) class I Redeemable Limited Shares divided into:
* one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class I-A1 Limited Shares;
* one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class I-A2 Limited Shares;
each with nominal value of 10 cents of euro (EUR 0.10).
5.3. The Unlimited Shares shall be held by Avocado General Partner Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité
limitée, incorporated under Luxembourg law by deed of notary Cosita Delvaux on 10 February 2016, having its registered
office at 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, in the process of being registered
with the Registre de Commerce et des Sociétés, as unlimited liability Shareholder (actionnaire commandité) (the “General
Partner”).
5.4. The issued share capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the
general meeting of the Shareholders (the “General Meeting”) adopted in compliance with the quorum and majority rules
set by these Articles or, as the case may be, by law for any amendment of these Articles or any shareholder agreement to
be entered into from time to time (if any).
5.5. Each Share whatever the class and the sub-category shall have the same rights and obligations attached thereto
unless otherwise provided for in the present articles of association or any shareholder agreement to be entered into between
the shareholders from time to time (if any).
5.6. The Company may redeem the Alphabet Shares, subject to and in accordance with the provisions of article 49-8 of
the law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, and these Articles, by the redemption of one or more
entire classes of Alphabet Shares through the repurchase of all the Alphabet Shares in issue in such class(es) including for
the avoidance of doubt all the Limited Shares in each sub-category of such class of Alphabet Shares forming part of the
class of Limited Shares. In the case of repurchases of classes of shares repurchases of shares shall be made in the reverse
alphabetical order (starting with class I Limited Shares).
5.7. In the event of a redemption of Alphabet Shares (in the order provided for in article 5.6), such class of Alphabet
Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class or to such proportion and amount as otherwise
determined in these Articles or in any shareholders agreement relating to the Company to be entered into from time to time
(if any) to the Available Amount (with the limitation however to the Total Redemption Amount as determined by the
general meeting of shareholders) and the holders of Alphabet Shares of the repurchased class of Alphabet Shares shall
receive from the Company an amount equal to the Redemption Value Per Share for each Alphabet Share of the relevant
class held by them in accordance with the economic rights of the sub-category of Shares they hold as determined in the
Articles or any shareholders' agreement relating to the Company to be entered into from time to time (if any).
5.7.1 The Redemption Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Redemption Amount (determined in
accordance with clause 5.7 above and these Articles or any shareholders' agreement relating to the Company to be entered
into from time to time (if any)) by the number of shares in issue in the class of shares to be redeemed.
5.7.2. The Total Redemption Amount shall be an amount determined by the board of directors and approved by the
general meeting on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Redemption Amount for each of the Classes I,
H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant class of shares at the time of the Redemption of
the relevant class of Alphabet Shares unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner
provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Redemption Amount shall never be higher than
such Available Amount.
5.7.3 Upon the redemption of the Alphabet Shares of the relevant class of Alphabet Shares, the Redemption Value Per
Share will become due and payable by the Company.
5.7.4. In the event Alphabet Shares have been redeemed in accordance with the above provisions, such Alphabet Shares
shall be cancelled no later than the end of the financial year during which they have been so redeemed.
5.8. The Company may not issue fractional Shares. The General Partner shall be authorised at its discretion to provide
for the payment of cash or the issuance of scrip in lieu of any fraction of a Share.
5.9. The Company or its subsidiaries may proceed to the purchase or repurchase of its own Shares and may hold Shares
in treasury, each time within the limits laid down by law.
73070
L
U X E M B O U R G
5.10. In addition to the issued capital, there may be set up a share premium account and/or special equity reserve account
(account 115 “compte des apports des associés non rémunérés par des titres” of the Luxembourg Standard Chart of Ac-
counts) (the “Account 115”) to which any premium paid on the shares of the Company in addition to their nominal value
is transferred. The amount of the share premium account and/or the Account 115 shall be freely distributable in accordance
with the provisions of these Articles.
Art. 16. Allocation of Profits, Distributions.
16.1. Out of the net profits of each year, an amount equal to five percent (5%) shall be allocated to the legal reserve
account. This allocation ceases to be compulsory when such reserve is equal to ten percent (10%) of the issued share capital
of the Company.
16.2. In case of distributions either by way of distribution of dividends, repayment of share premium or any other
distributable reserves as well as in case of reduction of the share capital with payment to the shareholders or a distribution
of liquidation proceeds, the General Partner shall receive an amount of such distribution or payment pro rata to its share-
holding in the Company.
16.3. In the event of a dividend declaration and subject to the provisions of any shareholders' agreement relating to the
Company (if any), such dividend shall be allocated and paid as follows:
(i) the holders of Ordinary Limited Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year
in an amount of 0.20% of the nominal value of the Ordinary Limited Shares held by them;
(ii) the holders of Class A Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of 0.65% of the nominal value of the Class A Shares held by them; the holders of Class B Shares shall be entitled to receive
dividend distributions with respect to such year in an amount of 0.60% of the nominal value of the Class B Shares held by
them; the holders of Class C Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of 0.55% of the nominal value of the Class C Shares held by them; the holders of Class D Shares shall be entitled to receive
dividend distributions with respect to such year in an amount of 0.50% of the nominal value of the Class D Shares held by
them; Class E Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of 0.45% of
the nominal value of the Class E Shares held by them; Class F Shares shall be entitled to receive dividend distributions
with respect to such year in an amount of 0.40% of the nominal value of the Class F Shares held by them the holders of
Class G Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of 0.35% of the
nominal value of the Class G Shares held by them; the holders of Class H Shares shall be entitled to receive dividend
distributions with respect to such year in an amount of 0.30% of the nominal value of the Class H Shares held by them;
(iii) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the shareholders starting with the last
class of Alphabet Shares in the reverse alphabetical order (i.e. first Class I Shares, then if no Class I Shares are in existence,
Class H Shares and in such continuation until only the ordinary shares are in existence).
16.4. Interim distributions may be declared and paid (including by way of staggered payments) by the General Partner
subject to observing the terms and conditions provided by law.
Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1. In the event of the dissolution of the Company, the liquidation will be performed by liquidators or by the General
Partner then in office who will be endowed with the powers provided by Articles 144 et seq. of the Luxembourg Law of
10 August 1915 on commercial companies, as amended.
17.2. Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting shall be paid to the Share-
holders. Article 16.2 shall apply mutatis mutandis to any such payments.
Art. 19. Definitions.
Available Amount
means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)
increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable
reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and
legal reserve reduction relating to the class of Alphabet Shares to be redeemed and
cancelled and in any case in accordance with article 72-1 (1) of the law on commercial
companies dated 10 August 1915, as amended but reduced by (i) any losses (included
carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the
requirements of law or of the Articles each time as set out in the relevant Interim
Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) – (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable share premium and other freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to
the class of shares to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
73071
L
U X E M B O U R G
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the
articles of association.
Class A
means class A Limited Shares in the Company including the sub-categories A1, A2, B,
C1 and C2.
Class B
means class B Limited Shares in the Company including the sub-categories A1, A2, B,
C1 and C2.
Class C
means class C Limited Shares in the Company including the sub-categories A1, A2, B,
C1 and C2.
Class D
means class D Limited Shares in the Company including the sub-categories A1, A2, B,
C1 and C2.
Class E
means class E Limited Shares in the Company including the sub-categories A1, A2, B,
C1 and C2.
Class F
means class F Limited Shares in the Company including the sub-categories A1, A2, B,
C1 and C2.
Class G
means class G Limited Shares in the Company including the sub-categories A1, A2, B,
C1 and C2.
Class H
means class H Limited Shares in the Company including the sub-categories A1, A2, B,
C1 and C2.
Class I
means class I Limited Shares in the Company including the sub-categories A1, A2, B,
C1 and C2
Interim Accounts
means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date
means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase of the
relevant class of shares.
Redemption Value Per Share means the amount resulting from the division of the relevant Total Redemption Amount
by the number of Alphabet Shares in issue in the class(es) to be repurchased.
Total Redemption Amount
means the amount determined by the general meeting of shareholders of the Company
as total redemption amount at the time of a repurchase of one or more classes of shares
within the limits of the Available Amount.
After having considered the above, the meeting unanimously resolved as follows:
<i>First resolutioni>
A. The meeting resolved to change the nominal value of the existing shares from one euro (EUR 1) to 10 cents of euro
(EUR 0.10) and to reclassify the fifty-two thousand five hundred (52,500) existing shares of the Company in ten (10)
unlimited shares and five hundred twenty-four thousand nine hundred ninety (524,990) limited shares of a nominal value
of 10 cents of euro (EUR 0.10) each.
B. The meeting resolved to authorise the creation and issuance by the Company of redeemable shares in accordance
with article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies.
C. The meeting resolved to create (10) different classes of limited shares, namely (i) ordinary limited shares (the “Or-
dinary Limited Shares”) and (ii) class A redeemable limited shares, class B redeemable limited shares, class C redeemable
limited shares, class D redeemable limited shares, class E redeemable limited shares, class F redeemable limited shares,
class G redeemable limited shares, and class I redeemable limited shares (the class A to I redeemable shares being referred
together as the “Alphabet Shares”),, the Alphabet Share being redeemable shares in accordance with article 49-8 of the
Company Law, divided into five sub-categories of limited shares each, namely sub-category A1 limited shares, sub-category
A2 limited shares, sub-category B limited shares, sub-category C1 limited shares, and sub-category C2 limited shares; and
to determine the rights and obligations thereof by amending the articles of association as set forth in item F of the agenda.
D. The meeting then resolved to reclassify all the five hundred twenty-four thousand nine hundred ninety (524,990)
existing limited shares of a nominal value of 10 cents of euro (EUR 0.10) into five hundred twenty-four thousand nine
hundred ninety (524,990) Ordinary Limited Shares of a nominal value of 10 cents of euro (EUR 0.10)
E. The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company from fifty-two thousand five hundred euros
(EUR 52,500) to two hundred fifty-three thousand four hundred seventy-nine Euros and thirty cents (EUR 253,479.30) by
the issue of two hundred twenty-three thousand three hundred thirteen (223,313) class A redeemable limited shares, being
one hundred and eleven thousand six hundred fifty-six (111,656) class A-A1 redeemable limited shares and one hundred
and eleven thousand six hundred fifty-seven (111,657) class A-A2 redeemable limited shares, two hundred twenty-three
thousand three hundred ten (223,310) class B redeemable limited shares, being one hundred and eleven thousand six hundred
fifty-five (111,655) class B-A1 redeemable limited shares and one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five
(111,655) class B-A2 redeemable limited share, two hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310) class C
redeemable limited shares, being one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class C-A1 redeemable
limited shares and one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class C-A2 redeemable limited shares,
two hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310) class D redeemable limited shares, being one hundred and
73072
L
U X E M B O U R G
eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class D-A1 redeemable limited shares and one hundred and eleven thou-
sand six hundred fifty-five (111,655) class D-A2 redeemable limited shares, two hundred twenty-three thousand three
hundred ten (223,310) class E redeemable limited shares, being one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five
(111,655) class E-A1 redeemable limited shares and one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655)
class E-A2 redeemable limited shares, two hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310) class F redeemable
limited shares, being one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class F-A1 redeemable limited
shares and one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class F-A2 redeemable limited shares, two
hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310) class G limited shares, being one hundred and eleven thousand
six hundred fifty-five (111,655) class G-A1 redeemable limited shares and one hundred and eleven thousand six hundred
fifty-five (111,655) class G-A2 redeemable limited shares, two hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310)
class H redeemable limited shares, being one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class H-A1
redeemable limited shares and one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class H-A2 redeemable
limited shares, and two hundred twenty-three thousand three hundred ten (223,310) class I redeemable limited shares, being
one hundred and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class I-A1 redeemable limited shares and one hundred
and eleven thousand six hundred fifty-five (111,655) class I-A2 redeemable limited shares, of a nominal value of ten cents
of Euro (EUR 0.10) each and to accept the subscription to such new shares by Avocado Topco Luxembourg S.à r.l. for a
total subscription price of two million nine thousand seven hundred ninety-three euros (EUR 2,009,793).
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Avocado Topco Luxembourg S.à r.l. represented by Me Vianney de Bagneaux, prenamed, by virtue of a
proxy, subscribed to, and fully paid-up, the new shares by way of a contribution in cash to the Company so that the total
subscription price for the new shares of an amount of two million nine thousand seven hundred ninety-three euros (EUR
2,009,793) is available to the Company.
Evidence of the full payment of the total subscription price of the new shares was shown to the undersigned notary.
The meeting resolved to allocate the nominal value of the new shares of an amount of two hundred thousand nine hundred
seventy-nine Euros and thirty cents (EUR 200,979.30) so issued to the share capital and an aggregate amount of one million
eight hundred eight thousand eight hundred thirteen Euros and seventy cents (EUR 1,808,813.70) to the freely distributable
share premium account.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to amend article 5, 16 and 17 of the articles of association of the Company and to insert a new
article 19 of the articles of association of the Company in the form set forth in item F of the agenda.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated
at EUR 3,800.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing parties
hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties
in case of divergences between the English and French versions, the English version will be prevailing.
Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary
signed together the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille seize, le vingt-sixième jour du mois de février.
Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale des associés de Avocado Partnership Luxembourg S.C.A., une société en commandite par actions
de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés (le «RCS») à Luxembourg sous le numéro B 202138, constituée le 20
novembre 2015 par acte de Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 524 du 23 février 2016 (le «Mémorial») agissant par le biais
de son associé commandité Avocado General Partner Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, dont le siège social se situe au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, ayant un capital social de
douze mille cinq cents euros (12.5000 EUR), immatriculée auprès du RCS à Luxembourg sous le numéro B 203916 (la
«Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière par acte du notaire instrumentant, de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 10 février 2016, non encore publié au Mémorial.
L'assemblée a été présidée par Maître Vianney de Bagneaux, avocat, demeurant à Luxembourg.
Maître Justine Peduzzi, avocate, résidant professionnellement au Luxembourg, a été nommée comme secrétaire et scru-
tateur. Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
73073
L
U X E M B O U R G
1. Les associés représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, figurent sur une liste de présence signée par
le(s) mandataire(s), le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste restera annexée à ce document
afin d'être soumise aux formalités de l'enregistrement.
Tel qu'il ressort de ladite liste de présence, toutes les actions émises dans la Société étaient représentées à la présente
assemblée générale. Cette même assemblée a renoncé aux avis de convocation, les associés représentés se considérant
comme ayant parfaitement connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
2. En raison de ce qui précède, la présente assemblée était régulièrement constituée et pouvait valablement délibérer sur
tous les points portés à l'ordre du jour.
3. L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
A. Restructuration du capital social émis de la Société en changeant la valeur nominale des actions existantes de un euro
(1 EUR) à dix cents d'euro (0,10 EUR) et reclassification des toutes les cinquante-deux mille cinq cents (52.500) actions
existantes de la Société en dix (10) actions commandités et cinq cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix (524.990)
actions commanditaires d'une valeur nominale de dix cents d'euro (0,10 EUR) chacune;
B. Autorisation pour la création et l'émission par la Société d'actions rachetables conformément à l'article 49-8 de la loi
du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales (la «Loi des Sociétés»)
C. Création de dix (10) différentes classes d'actions parmi les actions commanditaires de la Société, à savoir (i) les
actions commanditaires ordinaires (les «Actions Commanditaires Ordinaires») et (ii) les actions commanditaires racheta-
bles de classe A, les actions commanditaires rachetables de classe B, les actions commanditaires rachetables de classe C,
les actions commanditaires rachetables de classe D, les actions commanditaires rachetables de classe E, les actions com-
manditaires rachetables de classe F, les actions commanditaires rachetables de classe G, les actions commanditaires
rachetables de classe H, et les actions commanditaires rachetables de classe I (les actions rachetables de classe A à I étant
décrites ensembles comme les «Actions Alphabétiques»), les Actions Alphabétiques étant des actions rachetables confor-
mément à l'article 49-8 de la Loi des Sociétés. Les Actions Alphabétiques seront subdivisées en cinq sous-catégories
d'actions commanditaires rachetables chacune, à savoir les actions commanditaires de sous-catégorie A1, les actions com-
manditaires de sous-catégorie A2, les actions commanditaires de sous-catégorie B, les actions commanditaires de sous-
catégorie C1, et les actions commanditaires de sous-catégorie C2, et détermination de leurs droits et obligations par la
modification des statuts tels qu'énoncé ci-dessous;
D. Reclassification de toutes les cinq cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix (524.990) actions commandi-
taires existantes d'une valeur nominale de dix cents d'euro (0,10 EUR) en cinq cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-
vingt-dix (524.990) Actions Commanditaires Ordinaires d'une valeur nominale de dix cents d'euro (0,10 EUR);
E. Augmentation du capital social émis de la Société afin de le porter de son montant actuel de cinquante-deux mille
cinq cents euros (52.500 EUR) à deux cent cinquante-trois mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et trente centimes
(253.479,30 EUR) par l'émission de deux cent vingt-trois mille trois cent treize (223.313) actions commanditaires rache-
tables de classe A, étant cent onze mille six cent cinquante-six (111.656) actions commanditaires rachetables de classe A-
A1 et cent onze mille six cent cinquante-sept (111.657) actions commanditaires rachetables de classe A-A2, deux cent
vingt-trois mille trois cent dix (223.310) actions commanditaires rachetables de classe B, étant cent onze mille six cent
cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe B-A1 et cent onze mille six cent cinquante-cinq
(111.655) actions commanditaires rachetables de classe B-A2, deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310) actions
commanditaires rachetables de classe C, étant cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires
rachetables de classe C-A1 et cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de
classe C-A2, deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310) actions commanditaires rachetables de classe D, étant cent
onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe D-A1 et cent onze mille six cent
cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe D-A2, deux cent vingt-trois mille trois cent dix
(223.310) actions commanditaires rachetables de classe E, étant cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) actions
commanditaires rachetables de classe E-A1 et cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires
rachetables de classe E-A2, deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310) actions commanditaires rachetables de
classe F, étant cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe F-A1 et cent
onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe F-A2, deux cent vingt-trois
mille trois cent dix (223.310) actions commanditaires rachetables de classe G, étant cent onze mille six cent cinquante-
cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe G-A1 et cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655)
actions commanditaires rachetables de classe G-A2, deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310) actions comman-
ditaires rachetables de classe H, étant cent onze mille six cent cinquante-cinq ( 111.655) actions commanditaires rachetables
de classe H-A1 et cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe H-A2,
et deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310) actions commanditaires rachetables de classe I, étant cent onze mille
six cent cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe I-A1 et cent onze mille six cent cinquante-
cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe I-A2, d'une valeur nominale de dix cents d'euro (0,10 EUR)
chacune pour un prix de souscription total de deux millions neuf mille sept cent quatre-vingt-treize euros (2.009.793 EUR)
(le «Prix de Souscription»); souscription des nouvelles actions par Avocado Topco Luxembourg S.à r.l.; paiement du Prix
de Souscription par Avocado Topco Luxembourg S.à r.l. au moyen d'un apport en numéraire; attribution de la valeur
73074
L
U X E M B O U R G
nominale des nouvelles actions d'un montant de deux cent mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et trente centimes
(200.979,30 EUR) alors émises au capital social et un montant total de un million huit cent huit mille huit cent treize euros
soixante-dix centimes (1.808.813,70 EUR) au compte de prime d'émission librement distribuable;
F. Modification des articles 5, 16, 17 des statuts de la Société et insertzion d'un nouvel article 19 des statuts de la Société
tel qu'énoncé ci-dessous:
Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social émis de la Société sera représenté par deux classes d'actions, à savoir (i) une/des action(s) de
commandité («Actions de Commandité») détenue(s) par l'Actionnaire Commandité-Gérant en sa qualité d'Actionnaire
commandité et (ii) des actions de commanditaire («Actions de Commanditaire») détenues par les Actionnaires comman-
ditaires de la Société. Les Actions de Commanditaire seront divisées en dix (10) classes différentes d'Actions de
Commanditaire, à savoir les Actions de Commanditaire ordinaires (les «Actions de Commanditaire Ordinaires») et les
Actions de Commanditaire Rachetables de classe A, les Actions de Commanditaire Rachetables de classe B, les Actions
de Commanditaire Rachetables de classe C, les Actions de Commanditaire Rachetables de classe D, les Actions de Com-
manditaire Rachetables de classe E, les Actions de Commanditaire Rachetables de classe F, les Actions de Commanditaire
Rachetables de classe G, les Actions de Commanditaire Rachetables de classe H et les Actions de Commanditaire Rache-
tables de classe I (les Actions de Commanditaire de classe A aux Actions de Commanditaire de classe I étant collectivement
dénommées les «Actions Alphabet»). Chaque classe d'Actions Alphabet est elle-même sous-divisée en cinq (5) sous-
catégories, à savoir les sous-catégories A1, A2, B, C1 et C2 de sorte que le capital social de la Société est représenté comme
indiqué à l'article 5.2 ci-dessous.
Les Actions de Commanditaire (y compris les Actions de Commanditaire Ordinaires et les Actions Alphabet) et les
Actions de Commandité seront désignées en tant qu'«Action» et collectivement en tant qu'«Actions», chaque fois que la
référence à une classe particulière n'est pas justifiée ni requise.
5.2. Le capital social émis de la Société est fixé à deux cent cinquante-trois mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et
trente centimes (EUR 253.479,30) représenté par:
- dix (10) Actions de Commandité intégralement libérées;
- cinq cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix (524.990) Actions de Commanditaire Ordinaires;
- deux cent vingt-trois mille trois cent treize (223.313) Actions de Commanditaire Rachetables de classe A divisées en:
* cent onze mille six cent cinquante-six (111.656) Actions de Commanditaire de classe A-A1;
* cent onze mille six cent cinquante-sept (111.657) Actions de Commanditaire de classe A-A2;
- deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310) Actions de Commanditaire Rachetables de classe B divisées en:
* cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) Actions de Commanditaire de classe B-A1;
* cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) Actions de Commanditaire de classe B-A2;
- deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310) Actions de Commanditaire Rachetables de classe C divisées en:
* cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) Actions de Commanditaire de classe C-A1;
* cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) Actions de Commanditaire de classe C-A2;
- deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310) Actions de Commanditaire Rachetables de classe D divisées en:
* cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) Actions de Commanditaire de classe D-A1;
* cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) Actions de Commanditaire de classe D-A2;
- deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310) Actions de Commanditaire Rachetables de classe E divisées en:
* cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) Actions de Commanditaire de classe E-A1;
* cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) Actions de Commanditaire de classe E-A2;
- deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310) Actions de Commanditaire Rachetables de classe F divisées en:
* cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) Actions de Commanditaire de classe F-A1;
* cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) Actions de Commanditaire de classe F-A2;
- deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310) Actions de Commanditaire Rachetables de classe G divisées en:
* cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) Actions de Commanditaire de classe G-A1;
* cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) Actions de Commanditaire de classe G-A2;
- deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310) Actions de Commanditaire Rachetables de classe H divisées en:
* cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) Actions de Commanditaire de classe H-A1;
* cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) Actions de Commanditaire de classe H-A2;
- deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310) Actions de Commanditaire Rachetables de classe I divisées en:
* cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) Actions de Commanditaire de classe I-A1;
* cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) Actions de Commanditaire de classe I-A2;
d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 EUR) chacune.
73075
L
U X E M B O U R G
5.3. Les Actions de Commandité seront détenues par Avocado General Partner Luxembourg S.à r.l., une société à
responsabilité limitée, constituée en vertu de la loi luxembourgeoise par acte passé devant notaire Me Cosita Delvaux en
date du 10 février 2015, dont le siège social est situé au 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, en qualité d'Actionnaire com-
mandité.
5.4. Le capital social émis de la Société peut être augmenté ou réduit une ou plusieurs fois sur décision de l'assemblée
générale des Actionnaires (l'«Assemblée Générale») adoptée conformément aux règles de quorum et de majorité fixées par
les présents Statuts ou, le cas échéant, par la loi en ce qui concerne la modification des présents Statuts ou de tout pacte
d'actionnaires relatif à la Société devant être conclu de temps à autre (le cas échéant).
5.5. Chaque Action, de quelque classe et sous-catégorie que ce soit, aura les mêmes droits et obligations qui y sont
attachés, sauf disposition contraire dans les Statuts ou dans tout pacte d'actionnaires relatif à la Société devant être conclu
de temps à autre entre les actionnaires (le cas échéant).
5.6. La Société peut racheter les Actions Alphabet, sous réserve des dispositions des Statuts et de l'article 49-8 de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et conformément à ces dispositions, par le rachat d'une ou
de plusieurs classes entières de classes d'Actions Alphabet par le rachat de toutes les Actions Alphabet émises dans cette
(ces) classe(s), y compris, afin d'éviter tout doute, toutes les Actions de Commanditaire dans chaque sous-catégorie de cette
classe d'Actions Alphabet faisant partie de la classe d'Actions de Commanditaire. En cas de rachat de classes d'actions, les
rachats d'actions se feront dans le sens inverse de l'ordre alphabétique (en commençant par les Actions de Commanditaire
de classe I).
5.7. Dans le cas d'un rachat d'Actions Alphabet (dans l'ordre prévu à l'article 5.6), cette classe d'Actions Alphabet donne
droit à ses détenteurs, au prorata de leur participation dans cette classe ou à la proportion et au nombre autrement déterminés
dans les présents Statuts ou dans tout pacte d'actionnaires relatif à la Société devant être conclu de temps à autre (le cas
échéant) au Montant Disponible (sans toutefois dépasser le Montant Total de Rachat tel que déterminé par l'assemblée
générale des actionnaires) et les porteurs d'Actions Alphabet de la classe rachetée d'Actions Alphabet recevront de la part
de la Société un montant égal à la Valeur de Rachat par Action pour chaque Action Alphabet de la classe concernée détenue
par eux conformément aux droits économiques de la sous-catégorie d'Actions qu'ils détiennent tel que déterminé dans les
Statuts ou tout pacte d'actionnaires relatif à la Société devant être conclu de temps à autre (le cas échéant).
5.7.1 La Valeur de Rachat par Action sera calculée en divisant le Montant Total de Rachat (déterminé conformément à
la clause 5.7 ci-dessus et aux présents Statuts ou tout pacte d'actionnaires relatif à la Société devant être conclu de temps
à autre (le cas échéant)) par le nombre d'actions émises dans la classe d'actions devant être rachetée.
5.7.2. Le Montant Total de Rachat devra être un montant déterminé par le conseil d'administration et approuvé par
l'assemblée générale sur la base des Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total de Rachat pour chacune des Classes
I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible de la classe d'actions concernée au moment du Rachat de ladite classe
d'Actions Alphabet, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par l'assemblée générale des actionnaires selon les modalités
prévues pour la modification des Statuts, à condition toutefois que le Montant Total de Rachat ne soit jamais supérieur à
ce Montant Disponible.
5.7.3 Au moment du rachat des Actions Alphabet de la classe d'Actions Alphabet concernée, la Valeur de Rachat par
Action deviendra due et payable par la Société.
5.7.4. Dans le cas où les Actions Alphabet auraient été rachetées conformément aux dispositions ci-dessus, ces Actions
Alphabet seront annulées au plus tard à la fin de l'exercice social au cours duquel elles ont ainsi été rachetées.
5.8. La Société ne peut pas émettre de fractions d'Actions. L'Actionnaire Commandité-Gérant est autorisé, à sa discrétion,
à prévoir le paiement en numéraire ou l'émission de certificats en remplacement d'une fraction d'Action.
5.9. La Société ou ses filiales peuvent procéder à l'acquisition ou au rachat de ses propres Actions et peuvent détenir
des Actions en trésorerie, à chaque fois dans les limites prescrites par la loi.
5.10. En plus du capital émis peuvent être créés un compte de prime d'émission et/ou un compte de réserve de titres
spéciale (le compte 115 «compte des apports des associés non rémunérés par des titres» du plan comptable normalisé
luxembourgeois) (le «Compte 115») sur lesquels tout prime versée sur les actions de la Société en sus de leur valeur
nominale est transférée. Le montant du compte de prime d'émission et/ou le Compte seront librement distribuables con-
formément aux dispositions des présents Statuts.
Art. 16. Affectation des bénéfices, distributions.
16.1. Il sera prélevé sur les bénéfices nets annuels un montant égal à cinq pour cent (5%) qui sera affecté à la réserve
prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital
émis de la Société.
16.2. In case of distributions either by way of distribution of dividends, repayment of share premium or any other
distributable reserves as well as in case of reduction of the share capital with payment to the shareholders or a distribution
of liquidation proceeds, the Actionnaire Commandité shall receive an amount of such distribution or payment pro rata to
its shareholding in the Société.
16.3. In the event of a dividend declaration and subject to the provisions of tout pacte d'actionnaires relatif à la Société
(if any), such dividend shall be allocated and paid as follows:
73076
L
U X E M B O U R G
(i) the holders of Actions de Commanditaire Ordinaires shall be entitled to receive dividend distributions with respect
to such year in an amount of 0.20% of the nominal value of the Actions de Commanditaire Ordinaires held by them;
(ii) the holders of Class A Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of 0.65% of the nominal value of the Class A Shares held by them; the holders of Class B Shares shall be entitled to receive
dividend distributions with respect to such year in an amount of 0.60% of the nominal value of the Class B Shares held by
them; the holders of Class C Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of 0.55% of the nominal value of the Class C Shares held by them; the holders of Class D Shares shall be entitled to receive
dividend distributions with respect to such year in an amount of 0.50% of the nominal value of the Class D Shares held by
them; Class E Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of 0.45% of
the nominal value of the Class E Shares held by them; Class F Shares shall be entitled to receive dividend distributions
with respect to such year in an amount of 0.40% of the nominal value of the Class F Shares held by them the holders of
Class G Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of 0.35% of the
nominal value of the Class G Shares held by them; the holders of Class H Shares shall be entitled to receive dividend
distributions with respect to such year in an amount of 0.30% of the nominal value of the Class H Shares held by them;
(iii) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the shareholders starting with the last
class of Actions Alphabet in the reverse alphabetical order (i.e. first Class I Shares, then if no Class I Shares are in existence,
Class H Shares and in such continuation until only the ordinary shares are in existence).
16.4. Des acomptes sur dividendes peuvent être déclarés et payés (y compris par paiements échelonnées) par l'Action-
naire Commandité-Gérant sous réserve que soient respectées les conditions prévues par la loi.
Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par les soins de liquidateurs ou de l'Actionnaire
Commandité-Gérant alors en fonction qui auront les pouvoirs conférés par les articles 144 et suivants de la loi luxembour-
geoise modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
17.2. Une fois toutes les dettes, charges et dépenses de liquidation réglées, tout solde en résultant sera payé aux Ac-
tionnaires. L'article 16.2 s'appliquera mutatis mutandis à ces paiements.
Art. 19. Définitions.
Montant Disponible
désigne le montant total de bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés)
augmenté (i) de toute prime d'émission librement distribuable et d'autres réserves
librement distribuables et (ii) le cas échéant, du montant de la réduction du capital social
ou le montant de réduction de la réserve légale en rapport avec la classe d'Actions Al-
phabet devant être rachetée et annulée et dans tous les cas conformément à l'article 72-1
(1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, mais
diminué de (i) toute perte (y compris les pertes reportées) et (ii) toute somme devant être
placée en réserve(s) conformément aux conditions de la loi ou aux dispositions des
Statuts, chaque fois tel que ces éléments apparaissent dans les Comptes Intérimaires
concernés (sans, afin d'éviter tout doute, double comptage) de telle sorte que:
MD= (BN + PE+ RC) – (P + OL)
Où:
MD= Montant Disponible
BN= bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés)
PE= toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement
distribuables
RC= le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale
en rapport avec la classe d'actions devant être annulée
P= pertes (y compris les pertes reportées)
OL= toute somme à porter en réserve(s) en vertu des obligations de la loi ou des Statuts.
Classe A
désigne les Actions de Commanditaire Rachetables de classe A dans la Société, y
compris les sous-catégories A1, A2, B, C1 et C2.
Classe B
désigne les Actions de Commanditaire Rachetables de classe B dans la Société, y compris
les sous-catégories A1, A2, B, C1 et C2.
Classe C
désigne les Actions de Commanditaire Rachetables de classe C dans la Société, y compris
les sous-catégories A1, A2, B, C1 et C2.
Classe D
désigne les Actions de Commanditaire Rachetables de classe D dans la Société, y
compris les sous-catégories A1, A2, B, C1 et C2.
Classe E
désigne les Actions de Commanditaire Rachetables de classe E dans la Société, y compris
les sous-catégories A1, A2, B, C1 et C2.
Classe F
désigne les Actions de Commanditaire Rachetables de classe F dans la Société, y compris
les sous-catégories A1, A2, B, C1 et C2.
Classe G
désigne les Actions de Commanditaire Rachetables de classe G dans la Société, y
73077
L
U X E M B O U R G
compris les sous-catégories A1, A2, B, C1 et C2.
Classe H
désigne les Actions de Commanditaire Rachetables de classe H dans la Société, y
compris les sous-catégories A1, A2, B, C1 et C2.
Classe I
désigne les Actions de Commanditaire Rachetables de classe I dans la Société, y compris
les sous-catégories A1, A2, B, C1 et C2.
Comptes Intérimaires
désigne les comptes intermédiaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires
concernée.
Date des Comptes Intérimaires désigne la date intervenant au plus tôt huit (8) jours avant la date du rachat de la classe
d'actions concernée.
Valeur de Rachat par Action désigne le résultat de la division du Montant Total de Rachat en question par le nombre
d'Actions Alphabet émises dans la (les) classe(s) devant être rachetée(s).
Montant Total de Rachat
désigne le montant défini par l'assemblée générale des actionnaires de la Société comme
étant le montant total de rachat à l'occasion du rachat d'une ou de plusieurs classes
d'actions dans les limites du Montant Disponible.
Après avoir examiné ce qui précède, l'assemblée a décidé à l'unanimité ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
A. L'assemblée a décidé de changer la valeur nominale des actions existantes de un euro (1 EUR) à dix cents d'euro
(0,10 EUR) et de reclassifier toutes les cinquante-deux mille cinq cents (52.500) actions existantes de la Société en dix
(10) actions commandités et cinq cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix (524.990) actions commanditaires d'une
valeur nominale de dix cents d'euro (0,10 EUR) chacune
B. L'assemblée a décidé d'autoriser la création et l'émission par la Société d'actions rachetables conformément à l'article
49-8 de la Loi des Sociétés.
C. L'assemblée a décidé de créer dix (10) différentes classes d'actions commanditaires, à savoir (i) les actions com-
manditaires ordinaires (les «Actions Commanditaires Ordinaires») et (ii) les actions commanditaires rachetables de classe
A, les actions commanditaires rachetables de classe B, les actions commanditaires rachetables de classe C, les actions
commanditaires rachetables de classe D, les actions commanditaires rachetables de classe E, les actions commanditaires
rachetables de classe F, les actions commanditaires rachetables de classe G, les actions commanditaires rachetables de
classe H, et les actions commanditaires rachetables de classe I (les actions rachetables de classe A à I étant décrites ensembles
comme les «Actions Alphabétiques»), les Actions Alphabétiques étant des actions rachetables conformément à l'article
49-8 de la Loi des Sociétés, divisées en cinq sous-catégories d'actions commanditaires rachetables chacune, à savoir les
actions commanditaires de sous-catégorie A1, les actions commanditaires de sous-catégorie A2, les actions commanditaires
de sous-catégorie B, les actions commanditaires de sous-catégorie C1, et les actions commanditaires de sous-catégorie C2,
et de déterminer leurs droits et obligations par la modification des statuts tels qu'énoncé dans le point F de l'ordre du jour.
D. L'assemblée a ensuite décidé de reclassifier toutes les cinq cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix (524.990)
actions commanditaires existantes d'une valeur nominale de dix cents d'euro (0,10 EUR) en cinq cent vingt-quatre mille
neuf cent quatre-vingt-dix (524.990) Actions Commanditaires Ordinaires d'une valeur nominale de dix cents d'euro (0,10
EUR).
E. L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société afin de le porter de son montant actuel de
cinquante-deux mille cinq cents euros (52.500 EUR) à deux cent cinquante-trois mille quatre cent soixante-dix-neuf euros
et trente centimes (253.479,30 EUR) par l'émission de deux cent vingt-trois mille trois cent treize (223.313) actions com-
manditaires rachetables de classe A, étant cent onze mille six cent cinquante-six (111.656) actions commanditaires
rachetables de classe A-A1 et cent onze mille six cent cinquante-sept (111.657) actions commanditaires rachetables de
classe A-A2, deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310) actions commanditaires rachetables de classe B, étant cent
onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe B-A1 et cent onze mille six cent
cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe B-A2, deux cent vingt-trois mille trois cent dix
(223.310) actions commanditaires rachetables de classe C, étant cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) actions
commanditaires rachetables de classe C-A1 et cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires
rachetables de classe C-A2, deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310) actions commanditaires rachetables de
classe D, étant cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe D-A1 et
cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe D-A2, deux cent vingt-
trois mille trois cent dix (223.310) actions commanditaires rachetables de classe E, étant cent onze mille six cent cinquante-
cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe E-A1 et cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655)
actions commanditaires rachetables de classe E-A2, deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310) actions comman-
ditaires rachetables de classe F, étant cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires rachetables
de classe F-A1 et cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe F-A2,
deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310) actions commanditaires rachetables de classe G, étant cent onze mille
six cent cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe G-A1 et cent onze mille six cent cinquante-
cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe G-A2, deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310)
actions commanditaires rachetables de classe H, étant cent onze mille six cent cinquante-cinq ( 111.655) actions comman-
73078
L
U X E M B O U R G
ditaires rachetables de classe H-A1 et cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires rachetables
de classe H-A2, et deux cent vingt-trois mille trois cent dix (223.310) actions commanditaires rachetables de classe I, étant
cent onze mille six cent cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe I-A1 et cent onze mille six
cent cinquante-cinq (111.655) actions commanditaires rachetables de classe I-A2,, d'une valeur nominale de dix cents
d'euro (0,10 EUR) chacune et d'accepter la souscription de ces nouvelles actions par Avocado topco Luxembourg S.à r.l.
pour un prix total de souscription de deux millions neuf mille sept cent quatre-vingt-treize euros (2.009.793 EUR).
<i>Souscription - Paiementi>
À la suite de quoi, Avocado Topco Luxembourg S.à r.l. représenté par Me Vianney de Bagneaux, précité, en vertu d'une
procuration, a souscrit, et intégralement libéré, les nouvelles actions par un apport en numéraire à la Société de sorte que
le prix total de souscription pour les nouvelles actions d'un montant de deux millions neuf mille sept cent quatre-vingt-
treize euros (2.009.793 EUR) est à la disposition de la Société.
Preuve du paiement intégral du prix total de souscription des nouvelles actions s a été montrée au notaire soussigné.
L'assemblée a décidé d'affecter la valeur nominale des nouvelles actions d'un montant de deux cent mille neuf cent
soixante-dix-neuf euros et trente centimes (200.979,30 EUR) alors émises au capital social et un montant total de un million
huit cent huit mille huit cent treize euros soixante-dix centimes (1.808.813,70 EUR) au compte de prime d'émission libre-
ment distribuable.
<i>Seconde résolutioni>
L'assemblée a décidé de modifier les articles 5, 16 et 17 des statuts de la Société et d'insérer un nouvel article 19 des
statuts de la Société tels qu'énoncés au point F de l'agenda.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incomberont à la Société sont estimés
à EUR 3.800,-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes,
le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction en langue française; à la demande des mêmes parties
comparantes, cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en-tête des présentes.
Après lecture du présent procès-verbal, le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné ont
signé le présent acte.
Signé: V. DE BAGNEAUX, J. PEDUZZI, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 février 2016. Relation: 1LAC/2016/6651. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 mars 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016074504/673.
(160039447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Digital Services LIII (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 204.300.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fifth of February,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Digital Services LIII S.à r.l., a limited liability corporation (société à responsabilité limitée) existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg with its statutory seat in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés), having its business address
at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg;
here represented by Magdalena Staniczek, private employee, professionally residing in Senningerberg, by virtue of a
proxy.
73079
L
U X E M B O U R G
Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company
(société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Digital Services LIII (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any
Luxembourg or foreign entity.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
73080
L
U X E M B O U R G
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such
approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse
or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second
time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are
validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share
capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management.
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
73081
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.
14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if
any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
73082
L
U X E M B O U R G
(namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and
class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
73083
L
U X E M B O U R G
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2016.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Digital Services LIII S.à r.l., afore-
mentioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited duration:
- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
3. Any one manager of the Company, regardless of his category, and Magdalena Staniczek, is authorized to sign solely,
on behalf of the sole shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the
Company.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechszehn, am fünfundzwanzigsten Februar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Digital Services LIII S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, noch nicht eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des
Sociétés), mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg,
hier vertreten durch Magdalena Staniczek, Angestellte, geschäftsansässig in Senningerberg, gemäß einer Vollmacht.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert wurde,
wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:
73084
L
U X E M B O U R G
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit
dem Namen Digital Services LIII (GP) S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen
und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-
tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
73085
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zustim-
mung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in übertragen
werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jähr-
lich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in
Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntma-
chung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit
statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in
einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die
Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,
bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten schrift-
lichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
73086
L
U X E M B O U R G
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-
punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abge-
geben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.
Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-
führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer ein anderes Mitglied des Rates der
Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore
ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen
Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
73087
L
U X E M B O U R G
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Ka-
tegorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie
B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der Kategorie
B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder
von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Katego-
rien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B),
werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens
eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii)
durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschrifts-
befugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-
klang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-
falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
73088
L
U X E M B O U R G
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise
vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von
1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung
der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an
die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2016.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Digital Services LIII S.à r.l., vorbenannt,
zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesell-
schaftskapital zugeführt.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.500,-geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle
Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
Die folgende Person weird für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
73089
L
U X E M B O U R G
3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, und Magdalena Staniczek, ist er-
mächtigt, das Anteilinhaberregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für
Rechnung des alleinigen Gesellschafters zu unterzeichnen.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen Partei,
dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Namen,
Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: M. STANICZEK, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 février 2016. Relation: 1LAC/2016/6424. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 02. März 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016074641/576.
(160038927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Honos Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 204.315.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the fifth day of the month of February.
Before us, Maître Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Rhône Partners V L.P., a limited partnership organized and incorporated under the laws of the Cayman Islands, having
its registered office at C/o Maples Corporate Services Limited P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, Grand
Cayman KY1-1104, Cayman Islands, registered under registration number MC-81311 (Rhône);
here represented by Mr. Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal; and
Rhône Offshore Partners V L.P., a limited partnership organized and incorporated under the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at C/o Maples Corporate Services Limited P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street,
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands, registered under registration number MC-81298 (Rhône Offshore);
here represented by Mr. Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;
Such powers of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing parties, represented as described above, have requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “Honos Luxembourg Holdings S.à r.l.” (the Company). The Company is a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of
incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred within the municipality
by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for
the amendment of the Articles.
73090
L
U X E M B O U R G
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains
a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by one million two
hundred fifty thousand (1,250,000) shares in registered form, having a par value of one eurocent (EUR 0.01.-) each, all
subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share. Proof of ownership of shares
are established through the recording of a shareholder in the register of shareholders. Certificates of the recordings in the
register of shareholders may be issued and signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members
or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the
prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-quarters
of the rights owned by the survivors.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that
purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
6.5. A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection
by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence
or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the date of notification
73091
L
U X E M B O U R G
to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as any security rights
granted on shares.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more class A managers and one or more class B managers appointed by a
resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which is in Lu-
xembourg. Only in case of duly justified, exceptional circumstances, the Board may meet outside Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of
the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented including the vote of at least
one class A manager and one class B manager. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman
of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.
(vi) In case of duly justified, exceptional circumstances, any manager may participate in any meeting of the Board by
telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting
to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person
at a meeting duly convened and held. Notwithstanding the preceding sentence, at least half of the attending board members
must be physically present at the Board meeting.
(vii) The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the Board,
which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.”
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of one (1) class A manager and one
(1) class B manager or the signature of the sole manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been
delegated.
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be
read as a reference to such sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made
by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders which takes place in Luxembourg
(the General Meeting). Only in case of duly justified, exceptional circumstances, the General Meeting may take place
outside of Luxembourg.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
73092
L
U X E M B O U R G
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be
represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings are passed by shareholders owning more than one-half of the share
capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened
by registered letter to a second General Meeting and the resolutions are adopted at the General Meeting by a majority of
the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters
of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the
Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting is to be read as a reference to such sole
shareholder, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting within six (6) months
from the closing of the financial year.
Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by law.
14.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the
term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.
15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the date
of the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
73093
L
U X E M B O U R G
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by the majority of the
shareholders holding three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not
be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise
decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the
Company.
16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in
proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications are made or waived in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of
electronic communication.
17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board
meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures.
17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to any
non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2016.
<i>Subscription and paymenti>
Rhône represented as stated above, subscribes to seven hundred seventy-five thousand six hundred forty-three (775,643)
shares in registered form, with a par value of one eurocent (EUR 0.01) each, and agrees to pay them in full by a contribution
in cash in the amount of seven thousand seven hundred fifty-six euros and forty-three eurocents (EUR 7,756.43).
Rhône Offshore represented as stated above, subscribes to four hundred seventy-four thousand three hundred fifty-seven
(474,357) shares in registered form, with a par value of one eurocent (EUR 0.01) each, and agrees to pay them in full by
a contribution in cash in the amount of four thousand seven hundred forty-three euros and fifty-seven eurocents (EUR
4,743.57).
The amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire subscribed
capital, have passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an indefinite period of time:
- Mr. Frans Petter David Johnsson, born on 19 November 1973, in Taby, Sweden and having his professional address
at 40 Bruton St., London, W1J6QZ United Kingdom; and
- Ms. M. Allison Steiner, born on 6 May 1972, in Texas, U.S.A. and having her professional address at c/o Rhône Group
L.L.C., 630 Fifth Ave., New York, NY 10111, U.S.A.
2. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period of time:
- Mr. Carl Anders Peter Lundin, born on September 10, 1976 in Kalmar, Sweden and having his professional address
at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg; and
- Mrs. Virginia Strelen, born on 30 May 1977 in Bergisch-Gladbach, Germany and having her professional address at
15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
3. The registered office of the Company is set at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representatives of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned
notary.
73094
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le cinquième jour du mois de février,
Pardevant Maître Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
Rhône Partners V L.P., une société en commandite (limited partnership) organisée et constituée selon les lois des îles
Caïmans, ayant son siège social à C/o Maples Corporate Services Limited P.O. Box 309, Ugland House, South Church
Street, Grand Cayman KY1-1104, les îles Caïmans, immatriculée sous le numéro MC-81311 (Rhône);
ici représenté par Mr. Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et
Rhône Offshore Partners V L.P., une société en commandite (limited partnership) organisée et constituée selon les lois
des îles Caïmans, ayant son siège social à C/o Maples Corporate Services Limited P.O. Box 309, Ugland House, South
Church Street, Grand Cayman KY1-1104, les îles Caïmans, immatriculée sous le numéro MC-81298 (Rhône Offshore);
ici représenté par Mr. Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le
notaire instrumentant, annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est «Honos Luxembourg Holdings S.à r.l.» (la Société). La Société est
une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la
commune par décision du conseil de gérance (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique
ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature compromettre
les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège
social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provi-
soires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une
société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de
toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres
droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation
requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investisse-
ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres
risques.
3.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
73095
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par un million deux cent cinquante
mille (1.250.000,-) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale. La preuve
de la propriété des parts sociales est rapportée par l'inscription d'un associé dans le registre des associés. Des certificats
d'inscription au registre des associés seront émis et signés par le président du conseil de gérance, par deux de ces membres
ou par le gérant unique, le cas échéant, à la demande et à la charge de l'associé concerné.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable
des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-quarts
des droits détenus par les survivants.
Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes
à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
6.5. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société, où il sera disponible à la consultation par tout associé.
Ce registre des associés contiendra en particulier le nom de chaque associé, sa résidence ou son siège enregistré ou principal,
le nombre de parts détenues par chaque associé, tout transfert de parts sociales, la date de notification ou d'acceptation par
la Société d'un tel transfert selon les dispositions de ces statuts ainsi que toute sûreté consentie sur ces parts sociales.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B nommés par une
résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas être associés
7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui est au Luxembourg.
Uniquement en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le Conseil peut se réunir hors du Luxembourg.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures
à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir
parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une
réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions
se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés incluant au moins
73096
L
U X E M B O U R G
le vote d'un gérant de classe A et un gérant de classe B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux
signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par
téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant
à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par ces moyens équivaut à une participation en
personne à une réunion valablement convoquée et tenue. Nonobstant la phrase qui précède, au moins la moitié des membres
qui assistent à la réunion doivent être physiquement présents à la réunion du Conseil.
(vii) Le secrétaire, ou dans l'hypothèse où aucun secrétaire n'a été nommé, le président, rédigera des procès-verbaux de
chaque réunion du Conseil, qui seront signés par le président et par le secrétaire, le cas échéant.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un (1) gérant de classe
A et d'un (1) gérant de classe B ou par la signature du gérant unique.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés qui a lieu à Luxembourg (l'Assemblée
Générale). Uniquement en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, l'Assemblée Générale peut être tenue
hors du Luxembourg.
(ii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédures de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans
la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure indiqués dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés
de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut être tenue sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter en Assemblées Générales sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital
social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés
sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée
Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-
quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la
Loi à l'Assemblée Générale.
12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale doit être considérée, le cas échéant, comme
une référence à cet associé unique.
73097
L
U X E M B O U R G
12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle dans les six (6) mois
de la clôture de l'exercice social.
Art. 14. Réviseurs d'entreprises agrée.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agrée, dans les cas prévus
par la loi.
14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agrée, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises agrée peuvent être renommés.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants
sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,
les associés doivent reverser l'excès à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié des associés
détenant les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être
associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des
associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et sont établies par
écrit, télégramme, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire à l'ensemble des
conditions légales pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libérationi>
Rhône, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à sept cent soixante-quinze mille six cent quarante-trois
(775.643.-) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et de
73098
L
U X E M B O U R G
les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de sept mille sept cent cinquante-six euros et quarante-
trois centimes d'euro (EUR 7.756,43.-).
Rhône Offshore, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à quatre cent soixante-quatorze mille trois cent
cinquante-sept (474.357.-) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 1) cha-
cune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de quatre mille sept cent quarante-trois euros
et cinquante-sept centimes d'euro (EUR 4.743,57.-).
Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au
notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent
approximativement à mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social
souscrit, ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Frans Petter David Johnsson, né le 19 novembre 1973 à Taby, Suède et ayant son adresse professionnelle au 40
Bruton St., Londres, W1J6QZ Royaume Uni; et
- Mme Allison Steiner, née le 6 mai 1972 au Texas, Etats-Unis et ayant son adresse professionnelle chez Rhône Group
L.L.C., 630 Cinquième Avenue, New York, NY 01111, Etats-Unis.
Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
- Mr. Carl Anders Peter Lundin né le 10 septembre 1976 à Kalmar, Suède et ayant son adresse professionnelle au 15,
rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg; et
- Mme Virginia Strelen, gérante, né le 30 mai 1977 à Bergish-Gladbach, Allemagne, et ayant son adresse professionnelle
au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 15, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux mandataires de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 8 février 2016. Relation: 1LAC/2016/4412. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 mars 2016.
Référence de publication: 2016074748/507.
(160039331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Advent Therapy (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 158.711.
In the year two thousand and sixteen, on the seventeenth of February.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED
AI Global Investments & Cy S.C.A., a société en commandite par actions, governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 140.619,
here represented by Mrs Linda HARROCH, lawyer, with professional address in Howald, by virtue of a proxy given in
Luxembourg on February 2016.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
73099
L
U X E M B O U R G
Such appearing party is the sole shareholder of "Advent Therapy (Luxembourg) S.à r.l." (hereinafter the “Company”),
a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
2-4, rue Beck L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 158.711, incorporated pursuant to a notarial deed received by the undersigned notary dated 1
st
February 2011, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") dated 7 May
2011, number 934, page 44801. The articles of association have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary
dated 2 March 2011, published in the Memorial C dated 20 June 2011, number 1333, page 63970.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to dissolve and to put the Company into liquidation as of the date of the present deed.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to appoint, as liquidator of the Company, Florida Liquidator Ltd, a Limited Company
incorporated in the British Virgin Islands with registered office at PO Box 3175 Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder decides that the liquidator shall receive the powers and compensations as determined hereafter.
The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended (the "1915 Law").
The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the 1915 Law, without requesting the autho-
rization of the general meeting in the cases in which it is requested.
The liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all in
rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of all
the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part
of its powers it determines and for the period it will fix.
The liquidator may distribute the Company’s assets to the sole shareholder in cash or in kind to its willingness.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person,
the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person, and in
case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant;
Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and
residence, said appearing person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille seize, le dix-sept février.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU
«AI Global Investments & Cy S.C.A.» une société en commandite par actions régie selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 140.619,
ici représentée par Madame Linda HARROCH, avocat, demeurant professionnellement à Howald, en vertu d'une pro-
curation donnée à Luxembourg en date du février 2016.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l’associé unique de «Advent Therapy (Luxembourg) S.à r.l.» (ci-après la «Société»),
une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue
Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 158.711, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 1
er
février 2011, dont les statuts ont
été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 7 mai 2011, numéro 934,
page 44801. Les statuts de la Société ont été amendés suivant un acte notarié du 2 mars 2011, publié au Mémorial C du 20
juin 2011, numéro 1333, page 63970.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les ré-
solutions suivantes:
73100
L
U X E M B O U R G
<i>Première Résolutioni>
L’associé unique décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation en date du présent acte.
<i>Deuxième Résolutioni>
L’associé unique décide de nommer en tant que liquidateur, Florida Liquidator Ltd, une société à responsabilité limitée
constituée et régie selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à PO Box 3175, Road Town, Tortola,
Iles Vierges Britanniques, immatriculée au registre des Iles Vierges Britanniques.
<i>Troisième Résolutioni>
L’associé unique décide que le liquidateur recevra les pouvoirs et rémunérations comme déterminés ci-après.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).
Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l’article 145 de la Loi de 1915, sans demander l’autorisation de
l’assemblée générale dans les cas où cette autorisation serait requise.
Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les droits
réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les
inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur n’a pas à faire l’inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs
mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.
Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société à l'associé unique en numéraire ou en nature selon sa volonté.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne prenant la parole, l’assemblée est close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande de la comparante le présent acte est dressé
en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête.
Le document ayant été lu à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, les comparants
ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 février 2016. Relation: EAC/2016/4314. Reçu douze Euros (12.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2016078297/99.
(160043837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Advent Therapy (Luxembourg) Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 158.865.
In the year two thousand and sixteen, on the seventeenth of February.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED
“Advent Therapy (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 158.711,
here represented by Mrs Linda HARROCH, lawyer, with professional address in Howald, by virtue of a proxy given in
Luxembourg on February 2016.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of "Advent Therapy (Luxembourg) Finance S.à r.l." (hereinafter the “Com-
pany”), a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 2-4, rue Beck L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 158.865, incorporated pursuant to a notarial deed received by the undersigned notary
dated 4 February 2011, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C")
dated 4 May 2011, number 887, page 42552. The articles of association have not been amended.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
73101
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to dissolve and to put the Company into liquidation as of the date of the present deed.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to appoint, as liquidator of the Company, Florida Liquidator Ltd, a Limited Company
incorporated in the British Virgin Islands with registered office at PO Box 3175 Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder decides that the liquidator shall receive the powers and compensations as determined hereafter.
The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended (the "1915 Law").
The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the 1915 Law, without requesting the autho-
rization of the general meeting in the cases in which it is requested.
The liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all in
rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of all
the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part
of its powers it determines and for the period it will fix.
The liquidator may distribute the Company’s assets to the sole shareholder in cash or in kind to its willingness.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person,
the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person, and in
case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant;
Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and
residence, said appearing person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille seize, le dix-sept février.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU
«Advent Therapy (Luxembourg) S.à r.l.» une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 158.711,
ici représentée par Madame Linda HARROCH, avocat, demeurant professionnellement à Howald, en vertu d'une pro-
curation donnée à Luxembourg en date du février 2016.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l’associé unique de «Advent Therapy (Luxembourg) Finance S.à r.l.» (ci-après la «So-
ciété»), une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 158.865, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 4 février 2011, dont les
statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 4 mai 2011,
numéro 887, page 42552. Les statuts de la Société n’ont pas été amendés.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les ré-
solutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
L’associé unique décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation en date du présent acte.
<i>Deuxième Résolutioni>
L’associé unique décide de nommer en tant que liquidateur, Florida Liquidator Ltd, une société à responsabilité limitée
constituée et régie selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à PO Box 3175, Road Town, Tortola,
Iles Vierges Britanniques, immatriculée au registre des Iles Vierges Britanniques.
<i>Troisième Résolutioni>
L’associé unique décide que le liquidateur recevra les pouvoirs et rémunérations comme déterminés ci-après.
73102
L
U X E M B O U R G
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).
Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l’article 145 de la Loi de 1915, sans demander l’autorisation de
l’assemblée générale dans les cas où cette autorisation serait requise.
Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les droits
réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les
inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur n’a pas à faire l’inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs
mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.
Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société à l'associé unique en numéraire ou en nature selon sa volonté.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne prenant la parole, l’assemblée est close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande de la comparante le présent acte est dressé
en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête.
Le document ayant été lu à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, les comparants
ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 février 2016. Relation: EAC/2016/4305. Reçu douze Euros (12.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2016078296/97.
(160043772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Silvertower 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35F, Avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 191.347.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions des associés prises en date du 7 Mars 2016i>
Les associés de Silvertower 3 S.à r.l. (la «Société») ont décidé comme suit:
- D'accepter la démission de:
* Monsieur Bumhee Han en tant que gérant de catégorie A de la Société à partir du 7 Mars 2016;
- De nommer:
* Monsieur Young Kyu Kim, née en Corée du Sud, le 20 février 1987, demeurant professionnellement à 19f, Samsung
Life Insurance Bldg #55. Sejong St. Jung Gu, Seoul, Corée 100-716, en tant que gérant de catégorie A de la Société à partir
du 7 Mars 2016, pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078149/17.
(160043275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.
PHR Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 115.557.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Lors de l’«Assemblée Générale Extraordinaire» de la société à responsabilité limitée PHR INVESTMENTS Sàrl, établie
et ayant son siège social au 13, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, inscrite sous le numéro B 115.557 auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 674 du 20 mars 2013,
73103
L
U X E M B O U R G
acte enregistré à Luxembourg Actes Civiles, le 21 décembre 2012, LAC/2012/61950, aux droits de soixante-quinze
euros (75.- EUR) déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 31 janvier 2013 avec la relation
L130019301,
il a été omis de modifier correctement l’article 8 des statuts de la Société dans la version française.
En conséquence l’article 8 des statuts de la Société aurait dû se lire comme suit dans la version française dans son
entièreté:
“ Art. 8. Représentation. La Société sera engagée par la signature du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants par
la signature conjointe de deux gérants. Néanmoins, pour tout montant inférieur à EUR 500.000,-, la Société sera engagée
par la signature du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la
signature conjointe de deux personnes à qui le conseil de gérance aura délégué le pouvoir de signature.
Aucun contrat ou engagement liant la Société supérieur à EUR 500.000,- ne pourra être conclu ou pris sans l'accord du
conseil de gérance à travers des résolutions.
Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/
leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).”
Signé: Notaire Martine SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 4 mars 2016. Relation: 2LAC/2016/4926. Reçu douze euros Eur 12.-
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Yvette THILL.
POUR EXTRAIT CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 10 mars 2016.
Référence de publication: 2016078111/35.
(160042982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.
Berlys Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 55.431.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2016i>
Le siège social est transféré au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.
Acceptation de la démission de Madame Tazia BENAMEUR en tant que Gérant B.
Acceptation de la nomination comme nouveau Gérant B, à partir de ce jour, de:
- Madame Nathalie PRIEUR, née le 08/04/1967 à Trèves (Allemagne), demeurant professionnellement au 45-47, route
d'Arlon, L-1140 Luxembourg.
Acceptation de la démission de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS en tant que Commissaire aux Comptes.
<i>Pour la société
i>BERLYS MANAGEMENT S.à.r.l.
Référence de publication: 2016077753/16.
(160043399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.
RREEF EuCoReF 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 82.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 161.436.
Il est à noter que la nouvelle adresse, à compter du 1
er
juillet 2015, des gérants Stefan Hohgraefe et Johann Erich
Clemens Schäfer est la suivante:
- Taunusanlage 12, 60327 Frankfurt am Main, Allemagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
RREEF EuCoReF 1 S.à.r.l.
TMF Corporate Services S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016079725/16.
(160044822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
73104
Advent Therapy (Luxembourg) Finance S.à r.l.
Advent Therapy (Luxembourg) S.à r.l.
Avocado Partnership Luxembourg S.C.A.
Berlys Management S.à r.l.
Cauren S.A.
CMS Management Services S.A.
CNR International (Luxembourg) S.A.
Davmar S.à r.l.
De Gier & Co
Delta International Holding S.à r.l.
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Devon Holdings S.à r.l.
DH Blythe Valley S.à r.l.
Digital Services LIII (GP) S.à r.l.
Domain Tools Holdings
DROPINVEST S.A.
Dune Lux
Eren Grece
Eridanus Investments S.à r.l.
Financière Vasco de Gama
H3 Group s. à r.l.
Honos Luxembourg Holdings S.à r.l.
Inreca S.A.
IQS Avantiq Luxembourg S.à r.l.
Jandvi Investments S.A.
KOR Holdings Sàrl
KOR Holdings Sàrl
LKS 1
Luxbauhaus Promotions
MBERP II (Luxembourg) 27 S.à r.l.
Melpa International S.A.
Memba S.à r.l.
Montreux Regard Holdings S.à r.l.
MPC International S.A.
NEXT AM Fund
PBG Soda Can Holdings S. à r.l.
Pearl Luxury Information Technology
PepsiCo Global Investments S.à r.l.
PepsiCo Group Spotswood Holdings S.C.S.
PepsiCo Investments Luxembourg S.à r.l.
PHR Investments Sàrl
PRB Luxembourg International S. à r.l.
RREEF EuCoReF 1 S.à.r.l.
Silvertower 3 S.à r.l.
Sistema Finance S.A.
SL2AC S.A.
VHPE S.à r.l.
Wellness House S.A.