logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1511

26 mai 2016

SOMMAIRE

1492i Investments & Co S.C.A.  . . . . . . . . . . . .

72485

9900 Finance Lux Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . .

72484

9900 Finance Lux Co S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

72485

Aforcomlux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72491

Ageney S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72485

Andreas Management Services S.à r.l.  . . . . . .

72486

Argos Investment Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72486

Atlantico Investment Corporation S.à r.l. . . . .

72487

Auryn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72487

Batiau S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72493

Batiau S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72492

Bati Expansion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72493

Bâti-rêve S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72486

Belle Isle Investissements S.A., société de ges-

tion de patrimoine familial S.A., SPF  . . . . . .

72493

Bowline S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72488

City Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72492

Compact Music, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72489

CRH Canada Finance Luxembourg Sàrl  . . . .

72494

Elderflower Infrastructure VIII S.à r.l.  . . . . .

72525

Elderflower Infrastructure VII S.à r.l.  . . . . . .

72523

E-TPA S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72516

European Real Estate Senior Debt 3 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72489

Fernbach Financial Software S.A.  . . . . . . . . . .

72522

Fidelio 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72487

Fondation Pauline de Faillonnet  . . . . . . . . . . .

72488

HERIP Master I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72502

H.I.P.E. S.à r.l. (Holographic International

Productions Entertainment) . . . . . . . . . . . . . .

72528

Hosco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72490

Immo.Pacha S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72519

International Railroad Holding S.à r.l.  . . . . . .

72491

Intertrust Topholding (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72490

Invesco Munich Hotel Investment S.à r.l.  . . . .

72490

KPI Retail Property 24 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

72489

Lamandier Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

72491

PBD Investissements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72528

Thea Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72483

Universal WM Solutions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

72483

Uno Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72483

Vakraly S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72483

Vanbreda & Lang S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72482

Vesalius Biocapital I S.A. SICAR  . . . . . . . . . .

72484

Viper Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72484

Winnebago Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

72484

WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l.  . . .

72482

WPP Luxembourg Holdings Two S.à r.l.  . . . .

72482

WPP Union Square S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

72482

72481

L

U X E M B O U R G

WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 141.425,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 112.018.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2016.

Référence de publication: 2016078242/10.
(160043056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

WPP Luxembourg Holdings Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 610.810,85.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 99.124.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2016.

Référence de publication: 2016078250/10.
(160043442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

WPP Union Square S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.196,20.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 123.911.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2016.

Référence de publication: 2016078253/10.
(160043465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

Vanbreda & Lang S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, 2-4, rue du Château d'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 34.547.

<i>Extrait de l'assemblée du 6 mars 2015

L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra

en 2018:

- Pedro Matthynssens, Président du conseil d'administration, demeurant à B-2520 Ranst, 6 Haegenbroekseweg, Belgique
- Raymond Lang, demeurant à L-1870 Luxembourg, 199 Kohlenberg
- Pascal Joosten, demeurant à B-3960 Bree, 27A Kipdorpstraat, Belgique

<i>Extrait de l'assemblée du 4 mars 2016

L'assemblée décide de nommer à partir de ce jour comme nouveau administrateur Monsieur Koen AUSLOOS, avec

domicile à Volmolenheide 22, 2400 Mol (Belgique) jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2018.

Est nommé commissaire, en remplacement de BDO Tax &amp; Accounting, la société anonyme AUDIEX S.A., inscrite au

RCS sous le n° B 65 469, ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg. Son mandat prendra fin
lors de l'assemblée devant approuver les comptes au 31 décembre 2017.

Pedro Matthynssens
<i>Président / Administrateur

Référence de publication: 2016082388/21.
(160048563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72482

L

U X E M B O U R G

Thea Invest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 148.534.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 10 mars 2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6 

ème

 chambre, siégeant

en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société THEA INVEST
SA, dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 29 mars 2011 et a mis les
frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2016081663/13.
(160047654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.

Universal WM Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 161.001.

EXTRAIT

La société UNIVERSAL WM SOLUTIONS S.à r.l a pris acte du changement d'adresse de l'associée unique VERTEX

HOLDING LTD, numéro d'immatriculation N° 92395, ayant désormais son siège social à Suite 508, Marina Towers,
Newtown Barracks Road, Belize City, Belize

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2016081673/13.
(160047542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.

Uno Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 163.449.

L'adresse de Monsieur Ryan Prince, gérant de la société susmentionnée, né le 31 janvier 1977 à Toronto (Canada), est

désormais la suivante: 1 

st

 Floor, 7a Howick Place, London, SW1P 1DZ, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016081674/13.
(160047609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.

Vakraly S.à r.l., Société Anonyme Soparfi.

Capital social: EUR 26.042.028,57.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 15, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 35.849.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de cession de parts sociales du 16 mars 2016, que Monsieur Frédéric GASTALDO-NIGRA a cédé

la part sociale ordinaire qu'il détenait dans la Société à:

- F.G. Investissements, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 15, rue des Bains, L-1212 Luxembourg

et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B173887.

Luxembourg, le 17 mars 2016.

<i>Pour VAKRALY S.A.R.L.

Référence de publication: 2016081687/15.
(160047581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.

72483

L

U X E M B O U R G

Vesalius Biocapital I S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à

Risque.

Siège social: L-1445 Strassen, 1B, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 132.300.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle du 15 mars 2016

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Réviseur d'entreprises agréé de la société ERNST &amp; YOUNG, ayant

son siège social au L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, et inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous
le numéro B 47771.

Le mandat du Réviseur d'entreprises agréé ainsi renouvelé viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle

qui se tiendra en l'année 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS FAS

Référence de publication: 2016081681/16.
(160047843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.

Viper Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 163.447.

L'adresse de Monsieur Ryan Prince, gérant de la société susmentionnée, né le 31 janvier 1977 à Toronto (Canada), est

désormais la suivante: 1 

st

 Floor, 7a Howick Place, London, SW1P 1DZ, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016081684/13.
(160047608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.

Winnebago Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.010.000,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 167.395.

L'adresse de Monsieur Ryan Prince, gérant de la société susmentionnée, né le 31 janvier 1977 à Toronto (Canada), est

désormais la suivante: 1 

st

 Floor, 7a Howick Place, London, SW1P 1DZ, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016081701/13.
(160047607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.

9900 Finance Lux Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 167.212.

Il résulte d'une décision du conseil de gérance tenu en date du 11 mars 2016 que:
Madame Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, née le 30 août 1969 à Villerupt (F), a changé de résidence profes-

sionnelle, avec effet au 1 

er

 février 2016, résidant dorénavant au L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016081715/12.
(160047924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.

72484

L

U X E M B O U R G

1492i Investments &amp; Co S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 164.398.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 8 février 2016 que

les mandats des membres du conseil de surveillance ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant
sur les comptes annuels au 31.12.2016 qui se tiendra en 2017:

- Jaime NAVARRO ESTEVA, ayant son adresse professionnelle au 96, C/ Josep Umbert, E-08402 Granollers (Barce-

lone), Espagne;

- Gerardo ROCA PUJOL, ayant son adresse professionnelle au 5, Plaza de la Corona, E-08401 Granollers (Barcelone),

Espagne.

Il résulte également que Monsieur Nicolás López Correa né le 7 mars 1980 à Medellín (Colombie) et résident au Calle

5G No. 32 - 103 Apto 903, Edificio Loft 5G, Medellín, (Colombie) a été nommé membre du conseil de surveillance avec
effet au 1 

er

 janvier 2016 et ce jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2016 qui se tiendra en 2017, en remplacement de Monsieur Dimitri Peignois, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2016.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2016081714/23.
(160048058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.

9900 Finance Lux Co S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 8.027.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 167.302.

Il résulte d'une décision du conseil de gérance tenu en date du 11 mars 2016 que;
Madame Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, née le 30 août 1969 à Villerupt (F), a changé de résidence profes-

sionnelle, avec effet au 1 

er

 février 2016, résidant dorénavant au L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016081716/13.
(160047925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.

Ageney S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 300.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 36.682.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 février 2016

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Jean LAMBERT, administrateur avec effet au 31 décembre

2015.

L'Assemblée Générale décide de nommer un nouvel administrateur au lieu et place de l'administrateur sortant, à savoir:
Monsieur Nicolas SCHREURS, né le 3 décembre 1970 à Knokke (Belgique), demeurant professionnellement au 19,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec au 1 

er

 janvier 2016.

Son mandat d'Administrateur expirera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2017.

Extrait sincère et conforme
AGENEY S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016081774/18.
(160048297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72485

L

U X E M B O U R G

Andreas Management Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 179.712.

EXTRAIT

Il résulte des contrats de transferts de parts sociales signés en date du 15 mars 2016 que les parts sociales de la société

de EUR 1,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'Associé

Nombre

de parts

GREAT SKY GROUP HOLDINGS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Luxembourg, le 21 mars 2016.

Référence de publication: 2016081782/16.
(160048947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Argos Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 86.102.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'actionnaire unique a approuvé en date du 15 mars 2016 la clôture de la liquidation de la Société d'investissement à

capital variable «ARGOS INVESTMENT FUND» ayant son siège social au 20, Boulevard Emmanuel Servais, à L-2535
Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, alors notaire de résidence à Sanem, en date du
25 février 2002, publié au Mémorial C numéro 432 du 18 mars 2002.

La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire Maître Henri Hellinckx, en date du 17 décembre

2015, publication au Mémorial C non disponible à ce jour.

Les livres et documents sociaux de la Société resteront déposés pendant la durée de cinq ans à l'ancien siège social de

la Société au 20, boulevard Emmanuel Servais, à L-2535 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016081784/17.
(160048519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Bâti-rêve S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4392 Pontpierre, 8, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 181.677.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 février 2016

<i>Résolution n° 1

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle à L-4390

Pontpierre, 1, rue de Schifflange vers L-4392 Pontpierre, 8, rue d'Esch.

<i>Résolution n° 2

L'Assemblée Générale Extraordinaire constate le changement d'adresse de résidence du gérant-associé, Monsieur Ziya

BAYINDIR, actuellement en fonction, qui est dorénavant à F-57290 Fameck, 4A, rue du Maize.

<i>Résolution n° 3

L'Assemblée Générale Extraordinaire constate le changement d'adresse de résidence du gérant-associé, Monsieur Adem

TORUN, actuellement en fonction, qui est dorénavant à F-57270 Uckange, 7, lotissement Le Nid.

Esch-sur-Alzette, le 25 février 2016.

Pour extrait sincère et conforme à l'original
Fiduciaire C.G.S.
Signature

Référence de publication: 2016081795/21.
(160048449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72486

L

U X E M B O U R G

Atlantico Investment Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 158.699.

Par résolutions prises en date du 20 juillet 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Tiago Alberto Frois Simaria Da Silva, avec adresse professionnelle au 60-62, Rua

Manuel Almeida Vasconcelos, Luanda, Angola, de son mandat de gérant A, avec effet immédiat;

2. Acceptation de la démission d'Antonio João Assis de Almeida, avec adresse professionnelle au 62, Rua Manuel

Almeida &amp; Vasconcelos, Luanda, Angola, de son mandat de gérant A, avec effet immédiat;

3. Acceptation de la démission de José Pedro Carvalho Reis Soeiro, avec adresse professionnelle au 60-62, Rua Manuel

Almeida Vasconcelos, Luanda, Angola, de son mandat de gérant A, avec effet immédiat;

4. Acceptation de la démission d'Antonio Carlos de Oliveira, avec adresse professionnelle au 60, Rua Manuel Almeida

&amp; Vasconcelos, Luanda, Angola, de son mandat de gérant A, avec effet immédiat;

5. Acceptation de la démission de João De Ayala Botto Mariz Fernandes, avec adresse professionnelle au 62, Rua Manuel

Almeida &amp; Vasconcelos, Luanda, Angola, de son mandat de gérant A, avec effet immédiat;

6. Nomination de Manuel Eduardo Carneiro de Brito de Queiroz Aguiar, avec adresse professionnelle au 60-62, Rua

Manuel Almeida Vasconcelos, Luanda, Angola, au mandat de gérant A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2016.

Référence de publication: 2016081790/23.
(160048425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Auryn, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 175.582.

<i>Extrait des Résolutions Circulaires du Conseil d'Administration adoptées en date du 18 mars 2016

1. Le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Madame Martine Vermeersch de sa fonction d'adminis-

trateur avec effet au 31 décembre 2015.

2.  Le  Conseil  d'Administration  a  décidé  de  coopter  Monsieur  Luis  Gomez  Gonzalez  né  le  16  août  1979  à  Madrid

(Espagne), avec adresse professionnelle au 7A rue Robert Stümper, L-2557 à Luxembourg en tant que nouvel administrateur
pour un terme prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2016.

<i>Pour AURYN
ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
<i>Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2016081794/18.
(160048460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Fidelio 2, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, Avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 195.945.

EXTRAIT

Par résolutions prises en date du 20 octobre 2015, le conseil de gérance de Fidelio 2 S.A. a transféré le siège social de

la société au 2-8, rue Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet au 20 octobre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 18 mars 2016.

Référence de publication: 2016081959/13.
(160048250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72487

L

U X E M B O U R G

Fondation Pauline de Faillonnet, Fondation.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 21, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg G 96.

<i>Bilan au 31 décembre 2015

ACTIF

PASSIF

Immeubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 506 455,51

Fonds social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 273 919,35

Prêt à AGEDOC ASBL . . . . . . . . . . . . 5 543 363,05

Subventions d'investissements . . . . . . . . .

1 543 448,85

Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . 19 972 638,59

Dettes diverses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 046 009,51

Disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 089 856,80

Dettes financières  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

850 341,42

Excédent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

398 594,82

30 112 313,95

30 112 313,95

<i>Compte de résultat 2015

CHARGES

PRODUITS

Frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . .

27,00

Loyer immobilier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98 084,64

Frais sur titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 992,72

Loyer mobilier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 700,00

Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,60

Gains de change  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 485,64

Frais sur logement . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 527,54

PV sur cession valeurs mobilières  . . . . . . . .

321 365,82

Intérêts débiteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 076,90

Intérêts créditeurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 014,10

Pertes de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 863,47

Revenus sur valeurs mobilières  . . . . . . . . . .

177 333,25

MV sur cession valeurs mobilières . . . . . .

48 815,65

CV sur subventions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 078,38

CV sur immeubles . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56 950,24

Reprise CV sur valeurs mobilières . . . . . . . .

139 277,91

CV sur valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . 185 969,80

Libéralités reçues  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 500,00

Excédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 594,82

845 839,74

845 839,74

<i>Budget 2016

CHARGES

PRODUITS

Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 000,00

Loyer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147 000,00

CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000,00

Revenus financiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

453 000,00

Excédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 000,00

600 000,00

600 000,00

<i>Conseil d'Administration:

Madame Danièle FALTZ, Supérieure Provinciale des Soeurs de la Doctrine Chrétienne, Luxembourg, Présidente
Madame Philomène HOFFMANN, Administrateur AGEDOC ASBL, Luxembourg
Monsieur Robert BIEVER, docteur en droit, Luxembourg
Madame Elisabeth BLANCHE, Econome Provinciale des Soeurs de la Doctrine Chrétienne, Luxembourg
Référence de publication: 2016081967/39.
(160048854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Bowline S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 198.219.

Concerning the company Bowline S.a rl (hereinafter the "Company"), registered at the trade register of Luxembourg

with the number B-198219, registered office at 412F, route d'Esch, L- 1471 Luxembourg, the seat of the company was
terminated with effect of 23 February 2016 and the domiciliation agreement between the Company and SGG S.A. was also
terminated with effect of 23 February 2016.

Concernant la société Bowline S.à rl (ci-après la «Société»), n° de Registre de Commerce Luxembourg B-198219, avec

siège social au 412F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, le siège de la Société a été dénoncé avec effet au 23 février 2016
et la convention de domiciliation conclue entre la Société et SGG S.A. a également été dénoncée avec effet au 23 février
2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016081833/15.
(160048472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72488

L

U X E M B O U R G

Compact Music, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social:

R.C.S. Luxembourg B 28.122.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 26 novembre 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère
Public en leurs conclusions, a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société à responsabilité
limitée

- COMPACT MUSIC GMBH Sàrl, ayant eu son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I 

er

 , de

fait inconnue à cette adresse

et mis les frais à charge de la masse.

Pour extrait conforme
Me Arnaldina FERREIRA DA SILVA
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2016081892/18.
(160049038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

European Real Estate Senior Debt 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 197.338.

EXTRAIT

1) Il résulte d'une décision prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 11 mars 2016 que:
- Monsieur Kevin Hughes, née le 28 septembre 1981 en Belfast, demeurant au 13, Maximinstrasse, D-54292, Trier,

Allemande, a été nommée aux fonctions de gérant de la Société, à compter du 11 mars 2016 pour une période indéterminée.

2) Le conseil de Gérance de la Société est dorénavant compose par:
- Alexandra Fantuz, gérant
- Rolf Caspers, gérant
- Peter Dickinson, gérant
- Kevin Hughes, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2016.

Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) SA

Référence de publication: 2016081936/21.
(160048836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

KPI Retail Property 24 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 114.514.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 14 mars 2016:

- Acceptation de la démission, avec effet au 31 décembre 2015, de Monsieur Jean LAMBERT, gérant B de la société.
- Acceptation de la nomination avec effet au 14 mars 2016 de la société Regere Mgt. Services S.A., dont le siège social

est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 125133, nouveau gérant B de la société pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2016082101/15.
(160048410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72489

L

U X E M B O U R G

Invesco Munich Hotel Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.480.977,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 151.590.

En date du 17 mars 2016, l'associé unique de la société, INVESCO EUROPEAN HOTEL REAL ESTATE V S.à r.l., a

décidé comme suit:

1/ De prendre acte et d'accepter la démission avec effet au 17 mars 2016 des gérants suivants:
- Madame Marion Geniaux,
- Madame Simone Schmitz,
- Monsieur Marc Socker.
2/ De nommer Monsieur Jean-Paul Vaeyens, né le 25 août 1954 à Ninove, Belgique, ayant son adresse au Anderenbroek

54, 9450 Haaltert, Belgique, en tant que Gérant de la société, avec effet au 18 mars 2016 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2016.

Référence de publication: 2016082046/18.
(160048470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Intertrust Topholding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.135.487,30.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 173.039.

<i>Extrait du contrat d'apport de parts de la Société daté du 17 mars 2016

En vertu du contrat d'apport de parts, daté du 17 mars 2016, Intertrust N.V., a transféré la totalité de ses parts détenues

dans la Société de la manière suivante:

- 113,548,730 parts sociales d'une valeur d'EUR 0,01 chacune, à la société Intertrust Group B.V., une Besloten ven-

nootschap, existant sous le droit néerlandais, avec siège social à Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, Pays-bas,
et enregistrée au Kamer van Koophandel sous le numéro 56528582.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2016.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016082045/17.
(160048175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Hosco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 132.907.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 16 mars 2016, Maxime TANNOURI, domicilié profes-

sionnellement  au  42,  Rue  de  la  Vallée,  L-2661  Luxembourg,  a  été  nommé  administrateur  en  remplacement  de  Tanja
BERNAT, démissionnaire, avec date effective au 29 février 2016.

Le mandat de l'administrateur nouvellement élu s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.
Par cette même assemblée, les mandats des administrateurs Pii KETVEL et Magali MICHELETTI, ainsi que celui du

commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ont été renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
annuelle de 2016.

Luxembourg.

<i>Pour: HOSCO S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2016082036/19.
(160048353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72490

L

U X E M B O U R G

Lamandier Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 161.819.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue de manière extraordinaire

<i>le 18 mars 2016 à 12 heures au 370 route de Longwy, L-1940 Luxembourg

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide de révoquer Monsieur Dominique Fontaine de son poste d'administrateur de la Société

avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Didier McGaw, avec adresse professionnelle à L-1940 Luxembourg,

370 route de Longwy, en qualité d'administrateur unique de la Société, avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de révoquer avec effet immédiat le commissaire actuel de la Société, la société STRA-

TEGO INTERNATIONAL, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au
370, route de Longwy, immatriculée au registre de commercer et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45.163.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer commissaire, la société à responsabilité CERTIFICA Luxembourg S.à R.L.,

société à responsabilité limitée inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 86.770,
avec siège social au 1, Rue des Glacis, L-1628 LUXEMBOURG avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme
<i>L'Administrateur unique

Référence de publication: 2016082134/29.
(160048242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

International Railroad Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 186.709.

Der neue Teilhaber von 100 Anteilen der Gesellschaft ist die International IP Entreprises S. à r.l., L-2146 Luxembourg,

63-65, Rue de Merl, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxembourg unter der Nummer B 188.223.

Luxembourg, den 21. März 2016.

Référence de publication: 2016082837/10.
(160049369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

Aforcomlux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5752 Frisange, 8C, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 154.607.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 21 Décembre 2015 que:
- l'assemblée prend note du fait que le commissaire aux comptes actuel a changé sa dénomination de Euro-Green S.à

r.l.. en Setac S.à r.l.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2016081773/12.
(160048749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72491

L

U X E M B O U R G

City Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 98, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 202.970.

<i>Extrait des Résolutions de l'actionnaire unique prises en date du 10 février 2016 à Luxembourg

Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique de la Société prises en date du 10 février 2016 que:
- Monsieur Claude Schmitz et Monsieur Pierre Lentz, ont démissionné de leur fonction d'administrateurs de catégorie

B de la Société, avec effet immédiat.

- La société Audiex S.A. a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes de la Société, avec effet immédiat.
- Madame Bénédicte Mayolle, née le 29.12.1959 à Nogen-Sur-Seine (France), demeurant 3 rue du Colombier, F-78490

Mère (France) a été nommée administrateur de catégorie A de la Société avec effet immédiat, et jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire appelée à statuer sur les comptes au 31.12.2020.

- Madame Bouchra Akhertous, née le 08.10.1974 à Mont Saint-Martin, ayant son adresse professionnelle 98 rue de

Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, a été nommée administrateur de catégorie B de la Société avec effet immédiat, et jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes au 31.12.2020.

- Monsieur Fernando Sousa, né le 26.11.1978 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle 98 rue de Bonnevoie,

L-1260 Luxembourg, a été nommé administrateur de catégorie B de la Société avec effet immédiat, et jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes au 31.12.2020.

- La société S-Gestion S.à r.l, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2522

Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B. 162813; a été nommée de commissaire aux comptes de la Société, avec effet immédiat, et jusqu'à l' assemblée
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes au 31.12.2020

- Le siège social de la société a été transféré au 98 rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2016.

Bouchra AKHERTOUS.

Référence de publication: 2016081885/28.
(160048469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Batiau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5942 Itzig, 1, rue Désiré Zahlen.

R.C.S. Luxembourg B 135.977.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mars 2016

L'Associé unique de la société BATIAU S.à.r.l. en date du 18 mars, a décidé de prendre les résolutions suivantes:
L'associé unique décide d'accepter la démission de:
- Monsieur Peter WEBER, Commerçant, né le 9 avril 1951 à Trèves (Allemagne), demeurant professionnellement à

L-5942 Itzig, 1, rue Désiré Zahlen

- Monsieur Manfred MÜLLER, Diplômé en Gestion, né le 2 juillet 1951 à Saarbrücken (Allemagne), demeurant pro-

fessionnellement à L-5942 Itzig, 1, rue Désiré Zahlen

de son mandat de gérant avec effet immédiat.
Par conséquent, l'associé unique décide de nommer pour une durée indéterminée:
- Monsieur Marc FELTES, gérant de sociétés, né le 27 juillet 1974 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

demeurant à L-2551 Luxembourg, 23, rue Charlemagne,

- Monsieur Joachim LEGROSCOLLARD, ingénieur, né le 22 décembre 1975 à Liège (Belgique), demeurant à B-6600

Bastogne, 3, rue des Arbalétriers,

- Madame Nadine FELTES, épouse THEIS, gérante de sociétés, née à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le

2 juillet 1966, demeurant à B-6781 Sélange, 29, rue du Kirchberg,

au poste de gérants de la société.
La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature conjointe des trois gérants.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 18 mars 2016.

Référence de publication: 2016081817/26.
(160048350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72492

L

U X E M B O U R G

Batiau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5942 Itzig, 1, rue Désiré Zahlen.

R.C.S. Luxembourg B 135.977.

<i>Constatation de cession de parts sociales

Suite à une convention de cession de parts sociales sous-seing privé, il résulte que le capital social de la société à

responsabilité limitée BATIAU S.à.r.l. est désormais réparti comme suit:

La société F &amp; A Prom S.à.r.l, ayant son siège social à 2551 Luxembourg, 135, avenue du dix septembre,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 185863:
sept cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
Total: sept cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750

Luxembourg, le 18/03/2016.

Pour extrait conforme
<i>L'associé unique / Les gérants

Référence de publication: 2016081818/17.
(160048350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Belle Isle Investissements S.A., société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF, Société Anonyme - Société de

Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 36.421.

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social à Luxembourg, le 10 mars 2016

Nomination en qualité d'administrateur-délégué à la gestion journalière, de Monsieur Daniel RUCHONNET né le 13

septembre 1956 à Les Thioleyres- Puidoux (Suisse), domicilié au 2, rue Charles Bonnet CH-1206 GENEVE, pour une
durée 6 ans.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016081820/16.
(160048726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Bati Expansion, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 104.023.

EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire du 10 mars 2016 que:
L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs suivants pour une nouvelle période de 6 ans prenant fin à l'issue

de l'assemblée générale qui se tiendra en 2022:

- Monsieur Luc Hilger, né le 16/11/1974 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36,

avenue Marie-Thérèse

- Madame Martine Bonnefond, née le 12/05/1951 à Martimprey du Kiss (Maroc) demeurant à F-38240 Meylan, 2,

avenue de la Plaine Fleurie

- Monsieur Frédéric Bonnefond, né le 25/04/1952 à La Tronche (France) demeurant à F-38240 Meylan, 2, avenue de

la Plaine Fleurie

L'assemblée décide de reconduire le mandat du commissaire aux comptes à savoir Fidu-Concept Sàrl, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés sous le numéro B38136, avec siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2022.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2016081816/21.
(160048299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72493

L

U X E M B O U R G

CRH Canada Finance Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 198.316.

In the year two thousand and fifteen, on the second day of July.
Before us Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

THERE APPEARED:

CRH Cities Luxembourg Sàrl, a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg having its registered office at 18, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B198.290.

represented by Maître Brigitte CZOSKE, avocat, professionally residing at L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-

Thérèse, by virtue of a proxy given under private seal on June 29 

th

 , 2015.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the here above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

private limited liability company (société à responsabilité limitée), which it intends to organize as unitholder or with any
person who may become unitholder of this company in the future.

Title I. Name - Duration - Registered office - Object

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée), under the name of

“CRH Canada Finance Luxembourg Sàrl”, governed by the present articles of association and the laws of Luxembourg
pertaining to such an entity (hereinafter the “Corporation”), and in particular the law dated 10 

th

 of August, 1915, on

commercial companies, as amended (hereafter the “Law”).

Art. 2. Object.
2.1 The object of the Corporation is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of participations,

in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever. The Corporation may also pursue marketing and selling activities
directly or through branches established abroad and/or offices located abroad. The Corporation may in particular acquire
by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever.

2.2 The Corporation may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Corporation may also contract loans
and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.
It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Corporation may further pledge, transfer, encumber or other-
wise create security over some of its assets. The Corporation may hold interests in partnerships. It may also acquire, enhance
and dispose of patents, licences and sub-licences, and all other intangible property, as well as rights deriving there from or
supplementing them. In addition, the Corporation may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in
Luxembourg or abroad, and may lease or dispose of moveable property.

2.3 The Corporation may also carry on a treasury group activity including the procurement of short medium or long-

term finance or finance of unlimited duration and the provision of financial and investment services and facilities, financial
and investment management, advice, assistance, information and agency services in any currency whatsoever and to carry
out financing and lending of every description to companies in which it has a direct or indirect participation.

2.4 In general, the Corporation may carry out all commercial and financial operations, whether in the area of securities

or of real estate, likely to enhance or to supplement the abovementioned purpose.

Art. 3. Duration.
3.1 The Corporation is established for an unlimited duration.
3.2 The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of members adopted in the

manner required for the amendment of these articles.

3.3 The life of the Corporation does not come to an end by the incapacity, bankruptcy, insolvency of or any other similar

event affecting, one or several unitholders.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office is established in the city of Luxembourg. The registered office may be transferred within the

municipality of Luxembourg by decision of the board of managers. It may further be transferred to any other place within
the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members adopted in the manner
required for the amendment of these articles of association.

72494

L

U X E M B O U R G

4.2 The Corporation may establish offices and branches, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision

of the board of managers.

4.3 In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent, that would interfere

with the normal activities of the Corporation at its registered office or with the ease of communications with such office,
the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures will have no effect on the nationality of the Corporation, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg Corporation.

Title II. Capital - Units

Art. 5. Capital - Units.
5.1 The Corporation's corporate capital is set at CAD 30,000.- (thirty thousand Canadian Dollars), represented by 30,000

(thirty thousand) units each with a nominal value of CAD 1.- (one Canadian Dollars) and with such rights and obligations
as set out in the present articles of incorporation and all fully paid up.

5.2 Capital contribution made by a holder of units without issuance of new units shall be booked in the special account

(identified as the “Account 115”).

Art. 6. Increase and reduction of capital. The corporate capital of the Corporation may be increased or reduced in one

or several times, by a resolution of the general meeting of the members, adopted in the manner required for the amendment
of these articles.

Art. 7. Transfer of units.
7.1 Units are freely transferable among members.
7.2 In case of a sole unitholder, the units are freely transferable to non-members. In case of plurality of members, units

may be transferred to non-members provided such transfer complies with the requirements set forth in article 189 of the
Law, namely has been authorized by the general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the capital
of the Corporation.

7.3  The  transfer  of  units  will  only  be  binding  upon  the  Corporation  or  third  parties  following  a  notification  to,  or

acceptance by the Corporation as provided in article 1690 of the civil code.

7.4 The Corporation may purchase its own units.

Art. 8. Form of units - Members' register.
8.1 Units are in registered form.
8.2 A members' register will be kept at the registered office of the Corporation in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each member who so requires.

8.3 The ownership of the registered units will result from the inscription in the members' register.

Title III. Administration - Management - Representation

Art. 9. Board of managers.
9.1 The Corporation shall be managed by a board of managers composed, at least, of three managers, who do not need

to be members and who will be appointed pursuant to a resolution of the general meeting of members.

9.2 The managers are appointed and removed ad nutum pursuant to a decision of the general meeting of members, which

determines  their  powers,  compensation  and  duration  of  their  mandates  reserved  the  faculty  attributed  to  the  board  of
managers to proceed by way of cooptation in order to replace resigning or deceased board members. The managers shall
hold office until their successors are appointed.

Art. 10. Power of the board of managers.
10.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present articles of association to the general meeting of members

fall within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Corporation's object.

10.2 To the extent permitted by the Law, the board of managers may sub-delegate powers for specific tasks to one or

several ad hoc agents. The board of managers will determine the agent's responsibilities and remunerations (if any), the
duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

10.3 The agent so appointed shall in any case be revocable ad nutum.

Art. 11. Procedure.
11.1 The board of managers shall meet in Luxembourg as often as the Corporation's interest so requires or upon call of

any manager. The board of managers shall meet at least annually in Luxembourg. The board of managers may choose from
among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

11.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least two (2) working

days in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such

72495

L

U X E M B O U R G

circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by
cable, telegram, telex or telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers. No such notice
is required if all the managers of the Corporation are present or represented at the meeting and if they state to have been
duly informed, and to have full knowledge of the agenda of the meeting.

11.3 The board of managers' meeting may exceptionally be held by means of telephone conference or videoconference.

The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

11.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or telefax, or by email another manager as his proxy. In case there is only one manager present at the board meeting, this
manager is allowed to appoint a secretary, who needs not to be manager, in order to assist him by holding the board meeting.
Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email.

11.5 The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of the managers are present or represented.

Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting.

11.6 Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the

managers' meetings. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter or telefax.

11.7 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

chairman pro tempore who presided at such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial
proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 12. Representation. The Corporation shall be bound by the joint signature of two managers in any case or by the

sole or joint signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of
managers.

Art. 13. Liability of the managers. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible

for the obligations of the Corporation. As agents of the Corporation, they are responsible for the correct performance of
their duties.

Title IV. General meetings of members

Art. 14. Powers and voting rights.
14.1 Any regularly constituted meeting of members of the Corporation shall represent the entire body of members of

the Corporation. It shall have the power to ratify all acts relating to the operations of the Corporation.

14.2 Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a

simple majority of those present and voting.

14.3 The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by a majority of

members representing at least three quarters (3/4) of the capital of the Corporation. The members may change the nationality
of the Corporation by a unanimous decision. If all of the members are present or represented at a meeting of members, and
if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or
publication.

14.4 Each unit entitles its holder to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
14.5 The Corporation will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the

Corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as
the sole owner in relation to the Corporation.

14.6 Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to its relationship

with the number of units in existence. If the Corporation has only one member, this sole member exercises all the powers
of the general meeting.

14.7 The decisions of the sole member are recorded in minutes or drawn-up in writing.
14.8 Also, contracts entered into between the sole member and the Corporation represented by him are recorded on

minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under
normal conditions.

Art. 15. Annual general meeting. An annual general meeting of members approving the annual accounts shall be held

annually within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Corporation or at such other
place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and

shall terminate on the thirty-first of December, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the
date of the formation of the Corporation and shall terminate on the thirty-first of December, of the year two thousand and
fifteen.

72496

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Annual accounts and allocation of profits.
17.1 The annual accounts are drawn up in CAD (Canadian Dollars) which is the functional currency of the Corporation

by the board of managers as at the end of each accounting year and will be at the disposal of the shareholders at the registered
office of the Corporation.

17.2 Out of the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be placed into the legal reserve account.

This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital of the
Corporation.

Interim dividends may be distributed, at any time and in any currency selected by the board of managers, under the

following conditions:

1. Interim accounts are established by the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the unitholders or by the board of managers,
4. The payment is made once the Corporation has obtained the assurance that the rights of the significant creditors of

the Corporation are not threatened.

Title V. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation.
18.1 In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the sole unitholder or the meeting of unitholders, as the case may
be, in charge of such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

18.2 The power to amend the articles of association, if so justified by the needs of the liquidation, remains with the sole

unitholder or the general meeting of unitholders, as the case may be.

18.3 The power of the board of managers will end upon the appointment of the liquidator(s). After the payment of all

debts and liabilities of the Corporation or deposit of any funds to that effect, the remaining amount will be distributed to
the unitholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution
rules set for dividend distributions.

Art. 19. General provision. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Subscription - Payment

The articles of incorporation of the Corporation having thus been drawn up by the appearing party, the said party,

represented as stated here above, declares to subscribe 30,000 (thirty thousand) units of the Corporation having a par value
of CAD 1,- (one Canadian Dollar) each and to have fully paid up these units for an amount of CAD 30,000.-(thirty thousand
Canadian Dollars) through a contribution in cash (the “Contribution”).

<i>Statement

Evidence of the payment of the Contribution has been given by means of a blocking certificate confirming the availability

of the amount of the Contribution on the Corporation's bank account.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).

For the purpose of the registration taxes, the appearing party declares that the amount of CAD 30,000.- (thirty thousand

Canadian Dollars) is valued at EUR 21,884.88 (twenty-one thousand eight hundred eighty-four euro eighty-eight cents).

<i>Resolution of the sole member

The prenamed member, representing the entire subscribed capital, has immediately taken the following resolutions:
1. The registered office of the Corporation is fixed at L-2132 Luxembourg, 18 Avenue Marie-Thérèse.
2. The number of managers is fixed at 4 (four):
3. The following persons are appointed managers:
- Mr. Aylwyn BRYAN, born on February 17, 1979 in Cork (Ireland), residing at 1 Newbridge Avenue, Donabate, Co.

Dublin, Ireland;

- Mr. Rudolf COHEN, born on November 7, 1957 in Rotterdam (Netherlands), residing at 26 Einsteinlaan, 2289 CC

Rijswijk, The Netherlands;

- Mr. Emmanuel RÉVEILLAUD, born on October 10, 19671 in La Rochelle (France), residing at 20 Avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mrs. Christine LOUIS-HABERER, born on July 23, 1967 in Vitré (France), residing at 20 Avenue Marie-Thérèse,

L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

72497

L

U X E M B O U R G

4. The term of office of the managers shall be unlimited.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le deux juillet,
Pardevant nous Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la

présente minute,

A comparu:

CRH Cities Luxembourg Sàrl, société à responsabilité limitée, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social au 18, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B198.290.

ici représentée par Maître Brigitte CZOSKE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg,

20 avenue Marie-Thérèse, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 29 juin 2015.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant ès-qualités, a arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée que la

partie prémentionnée va constituer en tant qu'associé ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de la société par
la suite.

Titre I 

er

 . Nom - Durée - Siège social - Objet

Art. 1 

er

 . Nom.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination “CRH Canada Finance Luxembourg

Sàrl”, qui sera régie par les présents statuts et les lois luxembourgeoises relatives à une telle entité (ci-après la “Société”),
et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»).

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, le développement et la cession de prise de participations dans toute

entreprise luxembourgeoise ou étrangère sous quelque forme que ce soit. La Société pourra également poursuivre des
activités de marketing et de vente directement ou par l'intermédiaire de succursales situées à l'étranger et/ou de bureaux
situés à l'étranger. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute manière toutes
sortes d'actions cotées, actions simples et d'autres titres participatifs, bonds, obligations, certificats de dépôt ou d'autres
instruments de crédit et plus généralement tous titres et instruments financiers émis par des entités privées ou publiques.

2.2 La Société pourra emprunter sous toutes les formes, sauf par voie d'émission publique. Elle pourra émettre par voie

d'émission privée seulement, effets, obligations et titres de créances et tout autre type de dette et/ou de titre de participation.
La Société pourra aussi faire des prêts et accorder toutes sortes de support, prêts, avances et garanties à d'autres sociétés
dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect. Elle pourra aussi donner des garanties et accorder des garanties à l'égard
de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou toutes autres sociétés. La
Société pourra de plus gager, transférer, grever ou créer d'autres types de garanties sur des parties de ses actifs. La Société
pourra détenir des participations dans des associations. Elle pourra également acquérir, développer et céder des brevets,
licences ou tout autre bien matériel, ainsi que les droits en dérivant ou les complétant. De plus, la Société pourra acquérir,
gérer, développer et céder des propriétés immobilières situées au Luxembourg ou à l'étranger, et elle pourra louer ou disposer
de biens meubles.

2.3 La Société pourra également poursuivre une activité de trésorerie intragroupe incluant l'obtention de financement à

court,  moyen  et  long  terme  ainsi  que  l'obtention  de  financement  sans  limitation  de  durée,  la  fourniture  de  services  et
d'instruments financiers et d'investissement, la gestion financière et d'investissement, le conseil, l'assistance, des services
d'intermédiaires quelque soit la monnaie choisie ainsi et finalement de procéder à des financements ou à des prêts de toute
nature envers les sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement une participation.

2.4 De manière générale, la Société pourra procéder à toutes opérations commerciales et financières dans les domaines

de l'acquisition de titres ou de biens immobiliers, qui sont de nature à développer et compléter l'objet social ci-dessus.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée des associés adoptée dans les conditions

requises pour modifier les présents statuts.

72498

L

U X E M B O U R G

3.3 L'existence de la Société ne prend pas fin par l'incapacité, la banqueroute, l'insolvabilité ou tout autre événement

similaire affectant un ou plusieurs associés.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la ville de Luxem-

bourg par décision du conseil de gérance. Il pourra également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de
Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des
statuts.

4.2 La Société pourra établir des bureaux et des succursales tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par

décision du conseil de gérance.

4.3 Dans l'hypothèse d'événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se
sont produits ou sont imminents, il pourra être procédé au transfert provisoire du siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales, ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle nonobstant ce transfert du siège social statutaire, restera luxembourgeoise.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à CAD 30.000,- (trente mille dollars canadiens) représenté par 30.000 (trente

mille) parts sociales ayant toutes une valeur nominale de CAD 1,- (un dollar canadiens) chacune, et avec les droit et
obligations attachés tels que déterminés dans les présents statuts et toutes ayant été entièrement libérées.

5.2 L'apport en capitaux propres par un détenteur de parts sociales sans émission de parts sociales devra être comptabilisé

dans un compte spécial (le «Compte 115»).

Art. 6. Augmentation et réduction du capital. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une ou

plusieurs fois par décision des associés prise dans les conditions prévues pour la modification des présents statuts.

Art. 7. Transfert des parts.
7.1 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.2 En cas d'associé unique les parts sociales sont librement cessibles à des non-associés. En cas de pluralité d'associés

le transfert de parts sociales peut-être effectué envers des non-associés à condition que ce transfert respecte les règles de
l'article 189 de la Loi, c'est à dire qu'il a été autorisé au préalable par l'assemblée générale des associés représentant au
moins trois quarts (3/4) du capital social.

7.3 Le transfert de parts sociales ne sera opposable à la Société ou aux tiers que suite à sa notification à la Société ou

son acceptation par la Société telles que prévue par l'article 1690 du code civil.

7.4 La Société pourra acquérir ses propres parts sociales.

Art. 8. Forme des parts sociales - Registre des associés.
8.1 Les parts sociales sont nominatives.
8.2 Un registre des associés sera détenu au siège social de la Société conformément à la Loi et pourra être examiné par

tout associé qui le demande.

8.3 La propriété des parts nominatives résultera de l'inscription dans le registre des associés.

Titre III. Administration - Gérance - Représentation

Art. 9. Conseil de gérance.
9.1 La Société est gérée par un conseil de gérance, composé, au moins, de trois gérants, qui n'ont pas besoin d'être des

associés et qui seront nommés par résolution de l'assemblée générale des associés.

9.2 Les gérants sont nommés et révoqués ad nutum par une décision de l'assemblée générale des associés, qui détermine

également leurs pouvoirs, rémunération ainsi que la durée de leur mandat, sous réserve du pouvoir accordé au conseil de
gérance de procéder au remplacement des gérants démissionnaires ou décédés par voie de cooptation. Les gérants sont
maintenus en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance.
10.1 Tous les pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à la décision des associés, relèvent

de la compétence du conseil de gérance, qui est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes et effectuer les
opérations conformément à l'objet social de la Société.

10.2 Dans les limites permises par la Loi, le conseil de gérance est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour des tâches

spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération (si
c'est le cas), la durée de la représentation et toute autre condition appropriée de la fonction d'agent.

10.3 L'agent nommé sera dans tous les cas révocable ad nutum.

72499

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Procédure.
11.1 Le conseil de gérance se réunira à Luxembourg aussi souvent que l'intérêt de la Société le requière ou sur convo-

cation par un gérant. Le conseil de gérance se réunira au moins une fois par an à Luxembourg. Le conseil de gérance pourra
choisir en son sein un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en
charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des associés.

11.2 Tout gérant doit être convoqué par une convocation écrite au moins deux (2) jours avant la tenue du conseil de

gérance, à moins qu'un délai de convocation plus bref ne soit imposé par le caractère d'urgence des affaires en cause, lequel
sera dans ce cas décrit dans la convocation. Il peut être passé outre cette convocation avec l'accord écrit, par télécopieur,
par câble, par télégramme, par télex ou par e-mail de chaque gérant. Aucune convocation spéciale n'est requise pour les
réunions se tenant à une date, à une heure et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement prise par le conseil
de gérance. Une telle convocation n'est pas requise si tous les gérants sont présents ou représentés lors de la réunion et
qu'ils constatent qu'ils ont été bien informés et qu'ils ont pleine connaissance de l'ordre du jour de la réunion.

11.3 Le conseil de gérance pourra se tenir exceptionnellement par voie de téléconférence ou vidéoconférence. La par-

ticipation à une réunion par ces moyens sera équivalente à une participation en personne.

11.4 Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax

ou par e-mail un autre gérant. Pour le cas où un seul gérant serait présent à une réunion du conseil de gérance, ce gérant
est autorisé à nommer un secrétaire, qui peut ne pas être un gérant, pour l'assister dans la tenue de la réunion du conseil de
gérance. Les votes peuvent également être exprimés par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou par email.

11.5 Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à une telle réunion.

11.6 Les résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants ont les mêmes effets que les résolutions votées

lors d'une réunion du conseil de gérance. De telles signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs
copies de la même résolution et peuvent être prouvées par des lettres ou des téléfax.

11.7 Les minutes de chacune des réunions du conseil de gérance doivent être signées par le président ou en son absence

par le président intérimaire qui préside une telle réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en
justice ou ailleurs seront signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

Art. 12. Représentation. La Société est engagée par la signature conjointe de deux gérants dans tous les cas ou par la

signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de
gérance.

Art. 13. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont respon-
sables que de l'exécution de leur mandat.

Titre IV. Assemblée générale des associés

Art. 14. Pouvoirs et droits de votes.
14.1 Toute assemblée d'associés de la Société valablement constituée représentera l'ensemble des associés de la Société.

Elle aura le pouvoir de ratifier tous les actes en relation avec les opérations de la Société.

14.2 Sauf exception légale, les décisions des assemblées des associés valablement convoquées seront prises à la majorité

simple des associés présents et votants.

14.3 Le capital social et les autres dispositions de ces statuts pourront être modifiés à tout moment par l'associé unique

ou par une majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité
de la société requiert l'unanimité des voix des associés. Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée
des associés et s'ils précisent qu'ils ont tous été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans
convocation ou publication préalable.

14.4 Chaque part sociale donne droit à une voix au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
14.5 La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par part sociale; dans l'hypothèse où une part sociale est détenue par

plusieurs personnes, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne
ait été désignée comme le seul propriétaire de cette part sociale vis-à-vis de la Société.

14.6 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et des bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre de parts sociales en circulation. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs
de l'assemblée générale des associés.

14.7 Les décisions de l'associé unique sont établies sous la forme de minutes ou dressées par écrit.
14.8 De plus, les contrats passés entre l'associé unique et la société représentée par l'associé unique, seront établis sous

la forme de minutes ou dressées par écrit. Cependant, cette dernière hypothèse n'est pas applicable aux opérations courantes
passées à des conditions normales.

Art. 15. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour

l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra dans les six mois de la clôture de l'exercice social au siège de la Société
ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

72500

L

U X E M B O U R G

Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre

de la même année, à l'exception du premier exercice social qui débutera à la date de création de la Société et se terminera
le trente et un décembre deux mille quinze.

Art. 17. Comptes annuels et allocation des bénéfices.
17.1 Les comptes annuels sont établis en CAD (dollars canadiens), qui est la monnaie fonctionnelle de la Société, par

le conseil de gérance de la Société à la fin de chaque exercice et seront mis à la disposition des associés au siège social de
la Société.

17.2 Cinq pourcent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve légale. Cette affectation

cessera d'être requise dès que le montant de la réserve légale s'élèvera à dix pourcent (10%) du capital social émis de la
Société.

17.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment et dans toute devise décidée par le conseil de

gérance, sous les conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires seront établis par le conseil de gérance de la Société,
2. Ces comptes montrent un bénéfice incluant les bénéfices reportés suffisant pour payer le dividende intérimaire en-

visagé,

3. La décision de payer un dividende intérimaire est prise par les associés ou le conseil de gérance,
4. Le paiement sera effectué après que la Société aura obtenu la garantie que les droits des créanciers importants de la

Société ne sont pas menacés.

Titre V. - Dissolution et liquidation

Art. 18. Dissolution et liquidation.
18.1 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront

être des personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée des associés qui déterminera leurs pouvoirs et rému-
nérations.

18.2 Le pouvoir de modifier les statuts, si nécessaire pour les besoins de la liquidation, reste une prérogative de l'as-

semblée générale des associés.

18.3 Les pouvoirs des gérants cesseront par la nomination du(es) liquidateur(s). Après le paiement de toutes les dettes

et tout le passif de la Société ou du dépôt des fonds nécessaires à cela, le surplus sera versé à l'associé unique ou en cas de
pluralité d'associé le surplus sera versé à chaque associé en proportion du nombre de ses parts.

Art. 19. Dispositions générales. Tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents statuts sera régi

par la Loi.

<i>Souscription et libération

La partie comparante, ici représentée comme indiqué ci-dessus, ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a déclaré

souscrire à 30.000 (trente mille) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de CAD 1,- (un dollar canadien)
chacune et a déclaré les avoir entièrement libérées pour un montant de CAD 30.000,- (trente mille dollars canadiens) par
un apport en numéraire (l'«Apport»).

<i>Constatation

Le paiement en vertu de l'Apport a été certifié au moyen d'un certificat de blocage qui confirme la disponibilité du

montant de souscription payé en vertu de l'Apport sur le compte bancaire de la Société.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ mille euros (EUR 1.000,-).
Pour les besoins de l'enregistrement, le comparant déclare que le montant de CAD 30.000,- (trente mille dollars cana-

diens) est évalué à la somme de EUR 21.884,88 (vingt et un mille huit cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-huit
cents).

<i>Résolutions de l'associé unique

Et aussitôt, l'associé unique représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 18 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg;
2. Le nombre de gérants est fixé à 4 (quatre).
3. Sont nommés gérants de la Société:
- Monsieur Aylwyn BRYAN, né le 17 février 1979, à Cork (Irlande), demeurant à 1 Newbridge Avenue, Donabate, Co.

Dublin, Irland;

- Monsieur Rudolf COHEN, né le 7 novembre 1957 à Rotterdam (Pays-Bas), demeurant à 26 Einsteinlaan, 2289 CC

Rijswijk, Pays-Bas;

72501

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Emmanuel REVEILLAUD, né le 10 novembre 1971, à La Rochelle (France), demeurant au 20 Avenue

Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Madame Christine LOUIS-HABERER, née le 23 juillet 1967 à Vitré (France), demeurant au 20 Avenue Marie-Thérèse,

L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4. Les mandats des gérants ont une durée illimitée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: CZOSKE, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 3 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/20775. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Référence de publication: 2016076400/453.
(160041221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

HERIP Master I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 203.807.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the second day of the month of February.
Before Us Maitre Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Heitman European Residential Investment Partners I SCSp, a special limited partnership (société en commandite spé-

ciale) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26,
Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies'  Register  (Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés)  under  number  B  202976,  acting  through  its  general  partner,
Heitman European Residential Investment GP, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-
porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26B Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 202800,

here represented by Mrs Caroline BOCKLANDT, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal dated 29 January 2016.
Said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached

to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):

1. "Corporate form and name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of HERIP Master

I S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time
to time (the "1915 Law").

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:
(a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
(b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or

72502

L

U X E M B O U R G

2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution

of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles -including
Article 12.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg
Law").

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which

would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such  time  as  the  situation  becomes  normalised;  such  temporary  measures  will  not  have  any  effect  on  the  Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board
of Managers as appropriate.

2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the

Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and
other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments,
and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the

business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as

appropriate) thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as

appropriate) thinks fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other secu-
rities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's
property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the

sharing  of  profits,  union  of  interests,  co-operation,  joint  venture,  reciprocal  concession  or  otherwise  with  any  person,
including any employees of the Company;

3.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security for the performance of

the obligations of and/or the payment of any money by any person (including anybody corporate in which the Company
has a direct or indirect interest or any person (a "Holding Entity") which is for the time being a member of or otherwise
has a direct or indirect interest in the Company or anybody corporate in which a Holding Entity has a direct or indirect
interest and any person who is associated with the Company in any business or venture), with or without the Company
receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage,
charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property or assets (present and future) or by other means; for
the purposes of this Article-3.6 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for
the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or
otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations of any other person;

3.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or

privilege over or in respect of it;

3.8 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the

undertaking of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks
fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having
objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so
acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and
otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,

agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or
with another person or persons;

3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements

with or in favour of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate)
incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity

of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.

4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

5. Share capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into:

72503

L

U X E M B O U R G

- One thousand two hundred and fifty (1,250) class A shares (the "Class A Shares"),
- One thousand two hundred and fifty (1,250) class B shares (the "Class B Shares"),
- One thousand two hundred and fifty (1,250) class C shares (the "Class C Shares"),
- One thousand two hundred and fifty (1,250) class D shares (the "Class D Shares"),
- One thousand two hundred and fifty (1,250) class E shares (the "Class E Shares"),
- One thousand two hundred and fifty (1,250) class F shares (the "Class F Shares"),
- One thousand two hundred and fifty (1,250) class G shares (the "Class G Shares"),
- One thousand two hundred and fifty (1,250) class H shares (the "Class H Shares"),
- One thousand two hundred and fifty (1,250) class I shares (the "Class I Shares"), and
- One thousand two hundred and fifty (1,250) class J shares (the "Class J Shares"),
each a "Share" and together referred to as the "Shares", having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and the

rights and obligations set out in these Articles and each class of Shares shall be referred to as a "Class". The holders of the
Shares are together referred to as the "Shareholders" and individually a "Shareholder".

Each Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium

paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Manager
(s) subject to the 1915 Law and these Articles.

5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities

in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of
any such accounts are to be taken by the Manager(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of doubt,
any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.

5.4 The share capital of the Company may be reduced exclusively through the repurchase and subsequent cancellation

of all the issued Shares of one Class (a "Share Redemption") as may be determined from time to time by the Sole Manager
or, as the case may be, the Board of Managers and approved by the Sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders
provided however that the Company may not at any time purchase and cancel the Class A Shares. A reduction of share
capital through the repurchase and cancellation of a Class shall be made in the following order:

(a) Class J Shares;
(b) Class I Shares;
(c) Class H Shares;
(d) Class G Shares;
(e) Class F Shares;
(f) Class E Shares;
(g) Class D Shares;
(h) Class C Shares; and
(i) Class B Shares.
Upon the repurchase and cancellation of an entire Class, the Cancellation Amount as determined by the Sole Manager

or, in case of plurality of managers, the Board of Managers in its reasonable discretion and within the best corporate interest
of the Company, and as approved by the Shareholder(s) will become due and payable by the Company to the Shareholder
(s) pro-rata to their holding in such Class. For the avoidance of doubt the Company may discharge its payment obligation
in cash, in kind or by way of set-off.

6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the

Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that repre-
sentative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other
payment rights.

7. Transfer of shares.
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders

holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;

7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding

at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged by
article 189 of the 1915 Law;

7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.

72504

L

U X E M B O U R G

8. Management.
8.1 The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders'

Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles. The Managers may be appointed but are not
necessarily appointed as class A Managers (each a "Class A Manager") or class B Managers (each a "Class B Manager").

8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he/she is referred to in these Articles as a "Sole Manager".
8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil

de gérance (the "Board of Managers").

8.4 A Manager may be removed at any time for any reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with

Luxembourg Law and these Articles.

9. Powers of the managers. The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the

Board of Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company,
with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.

10. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the Company is validly bound or

represented towards third parties by:

10.1 if the Company has a Sole Manager, the sole signature of the Sole Manager;
10.2 if the Company has more than one (1) Manager, the joint signature of any two (2) Managers, or in case of several

classes of Managers, the joint signature of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.

11. Board meetings.
11.1 In case of plurality of Managers, the Board of Managers may choose from among its members a chairman, and

may choose from among its members one or more vice-chairmen.

11.2 The Manager or in case of plurality of Managers, the Board of Managers may also choose a secretary, who need

not be a Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of
the Shareholders.

11.3 The Manager or in case of plurality of Managers, the Board of Managers may from time to time appoint officers

of the Company, including a managing director, a general manager and any assistant managers or other officers considered
necessary  for  the  operation  and  management  of  the  Company.  Officers  need  not  be  Managers  or  Shareholders  of  the
Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated herein, shall have the powers and duties given to them by
the Manager or in case of plurality of Managers, the Board of Managers.

11.4 The Board of Managers shall meet upon call by the chairman, or any two Managers, at the place indicated in the

notice of meeting.

11.5 Notice of any meeting of the Board of Managers shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, telefax or

by other electronic means of transmission to all Manager at least twenty four hours in advance of the day set for the meeting.
The notice shall specify the purposes of and each item of business to be transacted at the meeting, and no business other
than that referred to in such notice may be conducted at any such meeting nor shall any action taken by the Board of
Managers not referred to in such notice be valid. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram
or telex or telefax or by other electronic means of transmission of each Manager and shall be deemed to be waived by any
Manager who is present in person or represented by proxy at the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

11.6 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by cable or telegram,

telex or telefax another Manager as his proxy. Any Manager may attend a meeting of the Board of Managers using tele-
conference, video means or any other audible or visual means of communication. A member of the Board of Managers
attending a meeting of the Board of Managers by using such means of communication is deemed to be present in person
at this meeting.

11.7 A meeting of the Board of Managers held by teleconference or videoconference or any other audible or visual

means of communication, in which a quorum of Managers participate shall be as valid and effectual as if physically held,
provided that a minute of the meeting is made and signed by the chairman of the meeting.

11.8 The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the Managers is present or

represented at a meeting of the Board of Managers. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Managers
present or represented at such meeting. Managers who are not present in person or represented by proxy may vote in writing
or by cable or telegram or telex or telefax or by other electronic means of communication.

11.9 In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall

have a casting vote.

11.10 Circular resolutions signed by all Managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened

and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be
evidenced by letters or telefaxes. Such resolutions shall enter into force on the date of the circular resolution as mentioned
therein. In case no specific date is mentioned, the circular resolution shall become effective on the day on which the last
signature of a member of the Board of Managers is affixed.

72505

L

U X E M B O U R G

11.11 Resolutions taken by any other electronic means of communication e.g. e-mail, cables, telegrams or telexes shall

be formalized by subsequent circular resolution. The date of effectiveness of the then taken circular resolution shall be the
one of the latest approval received by the Company via electronic means of communication. Such approvals received from
all members of the Board of Managers shall remain attached to and form an integral part of the circular resolution endorsing
the decisions formerly approved by electronic means of communication.

11.12 Any circular resolutions may only be taken by unanimous consent of all members of the Board of Managers.
11.13 The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman of the meeting.
11.14 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the chairman of the Board of Managers or chairman pro tempore of that meeting, or by two Managers.

12. Shareholders' resolutions.
12.1 Each Shareholder shall have one (1) vote for each Share of which he/she/it is the holder.
12.2 Subject as provided in Articles 12.3, 12.4 and 12.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by

Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first
written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the resolution
may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

12.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their

participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.

12.4 Subject as provided in Article 12.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered

Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders representing
three quarters of the Shares.

12.5 A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint

the liquidators needs to be passed in accordance with Luxembourg Law.

12.6 A meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") may validly debate and take decisions without complying

with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening
requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised
representative.

12.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders’ Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.

12.8
12.8.1 If at the time the Company has no more than twenty-five (25) Shareholders, Shareholders' Resolutions may be

passed by written vote of Shareholders rather than at a Shareholders' Meeting provided that each Shareholder receives the
precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted.

12.8.2 The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting apply mutatis

mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders. Except where required by Luxembourg Law, there shall be
no quorum requirements for the passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of Shareholders shall
be validly passed immediately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission
or as e-mail attachments) of Shareholders' votes subject to the requirements as provided in Article 12.8.1 and the above
provisions of Article 12.8.2, irrespective of whether all shareholders have voted or not.

13. Business year. The Company’s financial year starts on 1 

st

 January and ends on the 31 

st

 December of each year (all

dates inclusive).

14. Distributions on shares.
14.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent (5%) shall be

deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

14.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholder

(s) declare dividends. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be
taken by the Shareholders and such dividend shall be allocated and paid in the following sequential order:

- first to the holder(s) of the Class A Shares who shall be entitled to a preferential dividend equal to 10 % of the nominal

value of the Class A Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class B Shares who shall be entitled to a preferential dividend equal to 9 % of the nominal value

of the Class B Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class C Shares who shall be entitled to a preferential dividend equal to 8 % of the nominal value

of the Class C Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class D Shares who shall be entitled to a preferential dividend equal to 7 % of the nominal value

of the Class D Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class E Shares who shall be entitled to a preferential dividend equal to 6 % of the nominal value

of the Class E Shares held by them, then,

72506

L

U X E M B O U R G

- to the holder(s) of the Class F Shares who shall be entitled to a preferential dividend equal to 5 % of the nominal value

of the Class F Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class G Shares who shall be entitled to a preferential dividend equal to 4 % of the nominal value

of the Class G Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class H Shares who shall be entitled to a preferential dividend equal to 3 % of the nominal value

of the Class H Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class I Shares who shall be entitled to a preferential dividend equal to 2 % of the nominal value

of the Class I Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class J Shares who shall be entitled to a preferential dividend equal to 1 % of the nominal value

of the Class J Shares held by them.

14.3 If the Company resolves to make a distribution to the Shareholders out of (i) the annual net profits, (ii) the profits

carried forward and/or (iii) any available reserve, the amount to be distributed must be distributed first to the holders of
the relevant Class of Shares with respect to the preferential dividend. Thereafter, any remaining amounts shall be distributed
to the holders of the Class J Shares or, if all of the Class J Shares have been redeemed and cancelled, to the preceding Class
of Shares (in reverse alphabetical order). If at the time of any distribution a Class of Shares has been redeemed and cancelled
in accordance with Article 5, the distribution to which the holders of such Class of Shares would have been entitled shall
be allocated to the preceding Class of Shares (in reverse alphabetical order).

14.4 The Sole Manager or, as the case may be, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the

Shareholder(s) before the end of the financial year in accordance with the distribution provisions described in the Article
14.2 of these Articles on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it
being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of
the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward
losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles and that (ii) any
such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant Shareholder
(s).

15. Dissolution and liquidation. The dissolution and liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders'

meeting in accordance with Luxembourg Law and Article 12. If at the time the Company has only one (1) Shareholder,
that Shareholder may, at its option, resolve to dissolve and liquidate the Company by assuming personally all the assets
and liabilities, known or unknown, of the Company. However, after settling all outstanding debts and liabilities, including
tax and liquidation costs, the remaining net assets of the Company shall be distributed to the Shareholder(s) so as to achieve
on an aggregate basis the same economic result as per the distribution rules set forth for dividend distributions in Article
14.2 of these Articles.

16. Interpretation and Luxembourg law.
16.1 Unless otherwise defined herein, capitalised terms used herein shall have the following meaning:

"Available Amount"

shall mean for each Class the total amount of net profits of the Company (including carried
forward profits), increased by (i) any freely distributable reserves and/or share premium
attributable to the Shares, and (ii) as the case may be, by the amount of the share capital
reduction and legal reserve reduction relating to the Class to be repurchased and cancelled
but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) expressed as a positive, (ii)
any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the 1915 Law or the
Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of
doubt, any double counting), (iii) any dividends to which is entitled the holder(s) of the
Shares pursuant to the Articles (eg. any Profit Entitlement) so that:
AA = (NP + P+ CR) – (L + LR+PE)
Whereby:
AA = Available Amount;
NP = net profits (including carried forward profits);
P = any freely distributable reserves (including the share premium reserves) as determined
by the Sole Manager or, as the case may be, the Board of Managers whereby, for the
avoidance of doubt, the Sole Manager or, as the case may be, the Board of Managers, may
include or exclude in whole or in part such freely distributable reserves at his/her/its sole
discretion;
CR = the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class
of Shares to be cancelled;
L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive; and
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the 1915 Law
or the Articles.
PE = Profit Entitlement (the annual fixed dividends to which the holder(s) of the Shares is
entitled pursuant to the Articles).

72507

L

U X E M B O U R G

"Cancellation Amount"

shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class in
accordance with the 1915 Law and these Articles.

"Interim Accounts"

shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

"Interim Account Date"

shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before
the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class.

"Profit Entitlement"

means the annual fixed dividends to which the holder(s) of the Shares not being redeemed
are entitled to pursuant to the Articles.

16.2 In these Articles:
16.2.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,

state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body
(whether or not having a separate legal personality);

(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications)

thereof.

16.2.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general

words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a particular
class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;

16.2.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
16.3 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law."

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 December

2016.

<i>Subscription - Payment

The share capital has been subscribed as follows:

Subscriber

Shares

Heitman European Residential Investment Partners I SCSp, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,250 Class A Shares

1,250 Class B Shares
1,250 Class C Shares

1,250 Class D Shares

1,250 Class E Shares

1,250 Class F Shares

1,250 Class G Shares
1,250 Class H Shares

1,250 Class I Shares

1,250 Class J Shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500 Shares

All the Shares have been fully paid up in cash at one Euro (EUR 1.-) each for a total issue price of twelve thousand five

hundred Euro (EUR 12,500.-). Proof that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) in respect of
this cash contribution, corresponding to a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), is at the
disposal of the Company has been given to the Notary, who expressly acknowledged receipt of the proof of payment.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result

of the present deed and/or in connection with its incorporation are estimated at approximately thousand three hundred euro
(EUR 1,300.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, represented as stated above, representing

the  entirety  of  the  subscribed  capital  of  the  Company  and  exercising  the  powers  devolved  to  the  meeting,  passed  the
following resolutions:

1. Each of the following is appointed as a manager of the Company for an undetermined duration:
- Mr. Gordon BLACK, manager, born on 23 April 1965 in Royal Oak, Michigan, United States of America, having its

professional address at 8 Hanover Street, third floor, W1S 1YQ London, United Kingdom; and

- Mr Piotr ANDRZEJEWSKI, manager, born on 31 August 1978 in Sokolka, Poland, having its professional address at

26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

72508

L

U X E M B O U R G

2. The registered office of the Company is at 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary, by her surname, Christian

name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with us, the notary, the present deed.

Es folgt die Deutsche Übersetzung des Vorangehenden Englischen Textes

Im Jahre zweitausendsechszehn, am zweiten Tag des Monats Februar.
Vor Uns Maître Léonie GRETHEN, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

Heitman European Residential Investment Partners I SCSp, eine spezielle Kommanditgesellschaft (société en com-

mandite spéciale) gegründet und bestehend unter Luxemburger Recht, mit Sitz in 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des
Sociétés) unter der Nummer B 202976, agierend durch ihren Komplementär, Heitman European Residential Investment
GP, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend unter Luxem-
burger Recht, mit Sitz in 26B Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 202800,

hier vertreten durch Frau Caroline BOCKLANDT, Anwältin, berufsansässig in Luxemburg,
gemäß einer am 29. Januar 2016 ausgestellten privatschriftlicher Vollmacht.
Die besagte Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigte und den unterzeichnenden

Notar der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Die vorstehend erschienene Partei, wie oben dargelegt vertreten, beauftragte den unterzeichnenden Notar wie folgt die

Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") zu beurkunden:

1. Rechtsform und Firma. Dieses Dokument ist die Satzung ("Satzung") der HERIP Master I S.à r.l. (die "Gesellschaft"),

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die nach Luxemburger Recht, insbesondere
dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 1915"), ge-
gründet wurde.

2. Gesellschaftssitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft ("Gesellschaftssitz") ist in LuxemburgStadt, Großherzogtum Luxemburg.
2.2 Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft kann:
2.2.1 an einen anderen Ort innerhalb derselben Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden,
(a) wenn der alleinige Geschäftsführer (im Sinne von Artikel 8.2) dies entscheidet, sofern die Gesellschaft zum gege-

benen Zeitpunkt einen alleinigen Geschäftsführer hat; oder

(b) wenn die Geschäftsführung (im Sinne von Artikel 8.3) dies entscheidet, sofern die Gesellschaft zum gegebenen

Zeitpunkt eine Geschäftsführung hat;

2.2.2  an  einen  anderen  Ort  im  Großherzogtum  Luxemburg  (innerhalb  oder  außerhalb  derselben  Gemeinde)  verlegt

werden, wenn die Gesellschafter der Gesellschaft dies durch Beschluss ("Gesellschafterbeschluss") gemäß dieser Satzung
- insbesondere gemäß Artikel 12.4 - und dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz von 1915,
in der jeweils geltenden Fassung ("Luxemburger Recht") entscheiden.

2.3 Sofern eine militärische, politische, wirtschaftliche, soziale oder sonstige Lage eintritt oder als unmittelbar bevor-

stehend anzunehmen ist und sofern dadurch eine normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz verhindert wird, kann
der Gesellschaftssitz bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse vorübergehend ins Ausland verlegt werden;
diese vorübergehende Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet der
vorübergehenden Sitzverlegung stets eine Luxemburger Gesellschaft bleibt. Der Beschluss über die vorübergehende Sitz-
verlegung der Gesellschaft ins Ausland wird durch den alleinigen Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführung getroffen.

2.4 Die Gesellschaft kann Büros und Niederlassungen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland unterhalten.

3. Gesellschaftszweck. Der Gesellschaftszweck besteht darin,
3.1 als Anlageholdinggesellschaft (investment holding company) zu fungieren und die Geschäfte der juristischen Per-

sonen  zu  koordinieren,  an  denen  die  Gesellschaft  jeweils  unmittelbare  oder  mittelbare  Beteiligungen  hält,  und  (durch
Zeichnung, öffentliches Gebot, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise) Aktien, Anteile, Schuldverschreibungen, Obligati-
onen, Anleihen und andere ausgegebene oder garantierte Wertpapiere oder Vermögensgegenstände zu erwerben, diese als
Anlage zu halten, und sie zu verkaufen, zu tauschen bzw. auf sonstige Weise darüber zu verfügen;

72509

L

U X E M B O U R G

3.2 Handelsgeschäfte und sonstige Geschäfte zu betreiben, sowie Geschäfte, Vermögen oder Verbindlichkeiten von

Personen, die Handelsgeschäfte und sonstige Geschäfte betreiben, vollständig oder teilweise zu erwerben, zu übernehmen
oder fortzuführen;

3.3 zu Konditionen, die der alleinige Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführung für angemessen erachtet, Gelder und

Mittel der Gesellschaft anzulegen oder mit diesen zu handeln, und beliebigen Personen Kredite und Darlehen mit oder
ohne Sicherheitsleistung zu gewähren;

3.4  zu  Konditionen,  die  der  alleinige  Geschäftsführer  bzw.  die  Geschäftsführung  für  angemessen  erachtet,  Kredite

aufzunehmen, Kapital zu beschaffen und Zahlungen sicherzustellen, was (soweit nach Luxemburger Recht zulässig) durch
Ausgabe von Obligationen und anderen Wertpapieren oder Finanzierungsinstrumenten erfolgen kann, unabhängig davon,
ob diese befristet oder unbefristet, wandelbar oder nicht wandelbar sind, oder ob dadurch (gegenwärtiges oder zukünftiges)
Vermögen der Gesellschaft oder noch nicht abgerufenes Kapital ganz oder teilweise belastet wird, und solche Wertpapiere
zu kaufen, zurückzukaufen, umzuwandeln und abzubezahlen;

3.5 Beteiligungen an Personengesellschaften zu erwerben, mit beliebigen Personen, auch Mitarbeitern der Gesellschaft,

oder Personengesellschaften zu verschmelzen, zu fusionieren, oder sich zusammenzuschließen oder eine sonstige Verein-
barung zum Zwecke der Beteiligung an Gewinnen, der Bündelung von Interessen, der Zusammenarbeit, der Gründung
eines Gemeinschaftsunternehmens (Joint Venture) o.ä. zu treffen;

3.6 Garantien, Garantieverträge oder Bürgschaften zu vereinbaren, sowie Sicherheiten für die Erfüllung der sich hieraus

ergebenen Verpflichtungen oder für die Zahlung von Geldleistungen (auch solchen von juristische Personen, an denen die
Gesellschaft eine direkte oder indirekte Beteiligung in beliebiger Höhe hält, oder Personen ("Holdinggesellschaft" (Holding
Entity)), die Inhaber einer direkten oder indirekten Beteiligung an der Gesellschaft sind oder der gleichen Unternehmens-
gruppe  angehören  oder  auf  sonstige  Weise  mit  der  Gesellschaft  geschäftlich  oder  unternehmerisch  verbunden  sind)
bereitzustellen, dies gilt unabhängig davon, ob die Gesellschaft dadurch (mittelbar oder unmittelbar) eine Gegenleistung
oder einen Vorteil erhält und unabhängig davon, ob eine persönliche Zusage oder ein Pfandrecht, eine Belastung oder ein
dingliches Sicherungsrecht an einem Teil oder der Gesamtheit der Verpflichtungen, des Eigentums oder des (gegenwärtigen
oder zukünftigen) Vermögens der Gesellschaft oder eine sonstige Sicherheit existiert; wobei der Begriff der "Garantie" im
Sinne dieses Artikels 3.6 unabhängig von der genauen Bezeichnung jede Verpflichtung zur Zahlung, Erfüllung bzw. Be-
reitstellung von Geldern zur Zahlung oder Erfüllung von Schulden Dritter oder zur Sicherstellung von Zahlungen im Falle
eines Zahlungsausfalls und jede anderweitige Haftung für die Verbindlichkeiten oder finanzielle Verpflichtungen anderer
Personen umfasst;

3.7  bewegliches  oder  unbewegliches  Vermögen  sowie  diesbezügliche  Rechte  oder  Vorteile  zu  kaufen,  zu  pachten,

auszutauschen, zu mieten oder anderweitig zu erwerben;

3.8 gegen ein Entgelt, das der alleinige Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführung für angemessen erachtet, bewegliches

oder unbewegliches Vermögen sowie Teile oder die Gesamtheit der Verpflichtungen oder des Unternehmens der Gesell-
schaft zu verkaufen, zu verpachten, auszutauschen, zu vermieten oder darüber zu verfügen, insbesondere auch gegen - voll
oder teilweise eingezahlte - Aktien, Schuldverschreibungen und andere Wertpapiere beliebiger Personen, unabhängig da-
von,  ob  diese  Personen  Zwecke  verfolgen,  die  denen  der  Gesellschaft  (gänzlich  oder  teilweise)  vergleichbar  sind;
solchermaßen erworbene Anteile, Schuldverschreibungen und Wertpapiere zu halten, sowie Vermögen und Rechte der
Gesellschaft in Teilen oder als Ganzes zu optimieren, zu verwalten, zu entwickeln, zu verkaufen, auszutauschen, zu ver-
pachten, zu belasten, darüber zu verfügen, zum Gegenstand von Optionsrechten zu machen, zu verwerten oder anderweitig
damit zu verfahren;

3.9 Handlungen gemäß diesem Artikel 3 (a) weltweit, (b) als Geschäftsherr, Bevollmächtigter, Vertragspartner, Treu-

händer  oder  sonstiges,  (c)  von  oder  über  einen  Treuhänder,  Bevollmächtigten,  Subunternehmer  oder  sonstigen  (d)
eigenständig oder zusammen mit einer oder mehreren anderen Personen vorzunehmen;

3.10 sämtliche Handlungen vorzunehmen, welche der alleinige Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführung für die Er-

füllung der Geschäftszwecke oder die Ausübung seiner Kompetenzen als förderlich oder zielführend erachtet (dies umfasst
den Abschluss, die Erfüllung und Durchführung von Verträgen, Urkunden, Abkommen und Vereinbarungen mit oder
zugunsten einer beliebigen Person);

WOBEI die Gesellschaft STETS solche Geschäfte unterlassen wird, die der Finanzaufsicht unterliegen oder für die nach

Luxemburger Recht eine Gewerbegenehmigung erforderlich wäre, die die Gesellschaft aber nicht besitzt.

4. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

5. Stammkapital.
5.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in:
eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse A (die "Klasse A Anteile"),
eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse B (die "Klasse B Anteile"),
eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse C (die "Klasse C Anteile"),
eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse D (die "Klasse D Anteile"),
eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse E (die "Klasse E Anteile"),
eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse F (die "Klasse F Anteile"),

72510

L

U X E M B O U R G

eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse G (die "Klasse G Anteile"),
eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse H (die "Klasse H Anteile"),
eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse I (die "Klasse I Anteile"), und
eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse J (die "Klasse J Anteile"),
jeweils ein "Anteil", und gemeinsam die "Anteile", mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) und den Rechten

und Pflichten, die in dieser Satzung festgelegt sind, und jede Klasse von Anteilen eine "Klasse". Die Inhaber der Anteile
werden in dieser Satzung als "Gesellschafter" bezeichnet und der Begriff "Gesellschafter" im Singular ist entsprechend
auszulegen.

Jeder Anteil verleiht das Recht zu einer Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafterversammlungen.
5.2 Die Gesellschaft kann ein Aufgeldkonto ("Aufgeldkonto") eröffnen, auf welches Aufgelder einzuzahlen sind, die

auf Anteile gezahlt werden. Über die Verwendung dieses Aufgeldkontos entscheidet/entscheiden der alleinige Geschäfts-
führer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, die Geschäftsführung im Einklang mit dem Gesetz von 1915
und der vorliegenden Satzung.

5.3 Die Gesellschaft kann Kapitalbeteiligungen oder sonstige Einlagen unbeschränkt annehmen, ohne Anteile oder

andere Wertpapiere als Gegenleistung dafür auszugeben, und sie kann diese Einlagen auf einem oder mehreren Konten
verbuchen. Entscheidungen darüber, wie diese Konten zu verwenden sind, sind von dem alleinigen Geschäftsführer, oder,
sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Geschäftsführung gemäß dem Gesetz von 1915 und dieser Satzung zu
treffen. Um Missverständnisse auszuschließen: Im Rahmen einer solchen Entscheidung kann die Einlage der Person zu-
geordnet werden, die die Einlage geleistet hat, dies ist aber nicht zwingend erforderlich.

5.4 Das Stammkapital der Gesellschaft kann ausschließlich durch einen Rückkauf mit darauffolgender Annullierung

aller Anteile einer bestimmten Klasse erfolgen (ein "Anteilsrückkauf") wie dies von dem alleinigen Geschäftsführer, oder,
sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Geschäftsführung von Zeit zu Zeit entschieden werden kann, vorausgesetzt
dass die Gesellschaft zu keinem Zeitpunkt die Klasse A Anteile zurückkaufen und annullieren soll. Eine Kapitalherabset-
zung durch den Rückkauf und die Annullierung einer Klasse soll nach der folgenden Reihenfolge erfolgen:

(a) Klasse J Anteile;
(b) Klasse I Anteile;
(c) Klasse H Anteile;
(d) Klasse G Anteile;
(e) Klasse F Anteile;
(f) Klasse E Anteile;
(g) Klasse D Anteile;
(h) Klasse C Anteile; und
(i) Klasse B Anteile;
Bei dem Rückkauf und der Annullierung einer vollständigen Klasse, wird der Annullierungsbetrag von dem alleinigen

Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Geschäftsführung im angemessenen Ermessen und
im besten Interesse der Gesellschaft bestimmt, und wie von dem/den Gesellschafter(n) genehmigt, von der Gesellschaft an
den/die Gesellschafter jeweils in Höhe ihrer Beteiligung in der jeweiligen Klasse fällig und zahlbar. Zur Vermeidung von
Missverständnissen sei erwähnt dass die Gesellschaft ihren Zahlverpflichtungen durch Bezahlung, Sachleistungen oder
Aufrechnung gerecht werden kann.

6. Unteilbarkeit der Anteile.
6.1 Die Anteile sind unteilbar.
6.2 Mehrere Personen können als Inhaber desselben Anteils eingetragen werden, sofern alle Inhaber eines Anteils die

Gesellschaft schriftlich darüber in Kenntnis setzen, welcher Inhaber als Vertreter fungieren soll und die Gesellschaft wird
den Vertreter so behandeln, als ob er der einzige Gesellschafter wäre; dies gilt auch in Bezug auf Abstimmungsrechte und
Dividenden- oder sonstige Zahlungsansprüche.

7. Übertragung von Anteilen.
7.1 Solange die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, sind die Anteile frei übertragbar.
7.2 Solange die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat,
7.2.1 dürfen mit Ausnahme eines Todesfalls eines Gesellschafters Anteile nicht an Personen übertragen werden, die

keine Gesellschafter sind, es sei denn, die Übertragung wurde bei einer Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit
von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel der Anteile halten, genehmigt;

7.2.2 dürfen Anteile im Falle des Todes eines Gesellschafters nicht an Personen übertragen werden, die keine Gesell-

schafter sind, es sei denn, die Übertragung wurde bei einer Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit der überlebenden
Gesellschafter, die mindestens drei Viertel der Anteile halten, genehmigt, oder die Voraussetzungen von Artikel 189 des
Gesetzes von 1915 liegen vor;

7.2.3 erfolgt die Übertragung von Anteilen vorbehaltlich der Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes von

1915.

72511

L

U X E M B O U R G

8. Geschäftsführung.
8.1  Die  Gesellschaft  wird  von  einem  oder  mehreren  Geschäftsführern  ("Geschäftsführer")  geführt,  die  durch  einen

Gesellschafterbeschluss bestellt werden, der gemäß Luxemburger Recht und dieser Satzung gefasst wird. Die Geschäfts-
führer können, müssen jedoch nicht unbedingt, als Klasse A Geschäftsführer ("Klasse A Geschäftsführer") oder als Klasse
B Geschäftsführer ("Klasse B Geschäftsführer") ernannt werden.

8.2 Wenn die Gesellschaft zum maßgeblichen Zeitpunkt nur einen Geschäftsführer hat, wird dieser in der vorliegenden

Satzung als "alleiniger Geschäftsführer" bezeichnet.

8.3 Wenn die Gesellschaft gegebenenfalls mehr als einen Geschäftsführer hat, bilden diese eine Geschäftsführung (con-

seil de gérance) ("Geschäftsführung").

8.4 Ein Geschäftsführer kann durch Gesellschafterbeschluss, der gemäß Luxemburger Recht und dieser Satzung gefasst

wird, jederzeit aus einem jedweden Grund seines Amtes enthoben werden.

9. Befugnisse der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung - bzw. der alleinige Geschäftsführer, wenn die Gesellschaft

nur einen Geschäftsführer hat, - ist befugt, sämtliche Handlungen vorzunehmen, die notwendig oder zweckmäßig sind, um
den Gesellschaftszweck zu erfüllen, sofern diese Handlungen nicht gemäß Luxemburger Recht oder diese Satzung aus-
drücklich den Gesellschaftern vorbehalten sind.

10. Vertretung. Gemäß Luxemburger Recht und der vorliegenden Satzung wird die Gesellschaft gegenüber Dritten

folgendermaßen vertreten oder wirksam verpflichtet:

10.1 Sofern die Gesellschaft einen alleinigen Geschäftsführer hat, durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Ge-

schäftsführers;

10.2 sofern die Gesellschaft mehr als einen (1) Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zweier (2)

Geschäftsführer, oder im Falle von verschiedenen Klassen von Geschäftsführern, der gemeinsamen Unterschrift von jeweils
einem (1) Klasse A Geschäftsführer und einem (1) Klasse B Geschäftsführer.

11. Sitzungen der Geschäftsführung.
11.1 Im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, ernennt die Geschäftsführung aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden

und kann einen oder mehrere stellvertretende Vize-Vorsitzende ernennen.

11.2 Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, die Geschäftsführung kann einen Sekretär

ernennen, der kein Geschäftsführer sein muss und für die Führung des Protokolls von Versammlungen der Geschäftsfüh-
rung und von Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.

11.3 Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, die Geschäftsführung kann jeweils Be-

vollmächtigte ("Officers") der Gesellschaft ernennen, einschließlich eines Managing Directors, eines General Managers,
eines Assistant Managers oder sonstiger Bevollmächtigte, die im Hinblick auf den Betrieb und die Verwaltung der Ge-
sellschaft  für  erforderlich  gehalten  werden.  Bevollmächtigte  müssen  keine  Geschäftsführer  oder  Gesellschafter  der
Gesellschaft sein. Die ernannten Bevollmächtigten haben die ihnen von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Ge-
schäftsführer bestellt sind, von der Geschäftsführung zugewiesenen Befugnisse und Pflichten.

11.4 Die Geschäftsführung versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern an dem

in der jeweiligen Einladung genannten Ort.

11.5 Die Einladung zu einer Versammlung der Geschäftsführung erfolgt schriftlich bzw. per Kabel, Telegramm, Telex,

Fax oder auf elektronischem Wege und soll mindestens vierundzwanzig Stunden vor der Versammlung zugestellt werden.
Die Einladung beinhaltet die Tagesordnung der Versammlung. Ein nicht in der Tagesordnung enthaltener Agenda-Punkt
kann nicht rechtsgültig in der Versammlung beraten werden. Auf die Einberufung zur Versammlung der Geschäftsführer
kann verzichtet werden mittels schriftlicher Einwilligung bzw. mittels einer Zustellung der Mitteilung per Kabel, Tele-
gramm,  Telex,  Fax  oder  elektronischer  Mittel.  Das  Erfordernis  der  Einberufung  gilt  als  verzichtet  für  alle  in  der
Versammlung anwesenden oder durch Vollmacht vertretenen Geschäftsführer. Für die Versammlungen, die gemäß einem
durch Beschluss der Geschäftsführer festgesetzten Zeitplan abgehalten werden, ist keine zusätzliche Einladung zur Ver-
sammlung erforderlich.

11.6 Jeder Geschäftsführer kann sich in der Versammlung der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer

vertreten lassen, in dem er schriftlich bzw. per Kabel, Telefax, Telegramm, Telex, einen anderen Geschäftsführer als seinen
Bevollmächtigten ernennt.

11.7 Eine Versammlung der Geschäftsführer per Telefon oder VideoKonferenzschaltung oder jeder anderen Art von

Audio- oder Videokommunikation, an der ein Quorum von Geschäftsführern teilnimmt, ist genauso bindend als ob alle
Geschäftsführer persönlich anwesend gewesen wären, vorausgesetzt, ein Protokoll wurde erstellt und vom Vorsitzenden
der Geschäftsführungssitzung unterzeichnet.

11.8 Die Geschäftsführung kann rechtsgültig Beschlüsse fassen, wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder anwesend

oder vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Geschäftsführer gefasst, welche
bei der Sitzung anwesend oder vertreten sind. Nicht persönlich anwesende oder nicht vertretene Geschäftsführer können
schriftlich bzw. durch Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder durch Einsatz anderer elektronischer Mittel an der Abstimmung
teilnehmen.

11.9 Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden auschlaggebend.

72512

L

U X E M B O U R G

11.10 Umlaufbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurden, sind genauso rechtswirksam und bin-

dend, als ob die Sitzung ordnungsgemäß einberufen und abgehalten worden wäre. Die Unterschrift der Geschäftsführer
kann auf einer einzelnen Ausfertigung bzw. auf mehreren Ausfertigungen eines jeden Beschlusses vermerkt sein, und auch
per Brief, Telefax oder Telex bestätigt werden. Diese Beschlüsse treten in Kraft am Tage des im Umlaufbeschluss ver-
merkten Datums. Sollte dort kein spezielles Datum vermerkt sein, wird der Umlaufbeschluss gültig an dem Tag, an dem
die letzte Unterschrift getätigt wird.

11.11 Beschlüsse, die durch elektronische Mittel wie z.B. per E-Mail, ein Telegramm oder ein Telex gefasst werden,

müssen anschließend durch einen Zirkularbeschluss formalisiert werden. Das Inkrafttreten des Zirkularbeschlusses erfolgt
am Tage der letzten Zustimmungserklärung, welche die Gesellschaft in elektronischer Form erhielt. Die Zustimmungen
von allen Mitgliedern der Geschäftsführung werden dem Umlaufbeschluss beigefügt und bilden dabei einen integralen
Bestandteil derselben, wobei der Umlaufbeschluss die zuvor in elektronischer Form gefassten Beschlüsse bestätigt.

11.12 Umlaufbeschlüsse können nur durch einstimmigen Beschluss aller Geschäftsführer gefasst werden.
11.13 Die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung müssen durch den Vorsitzenden der Sitzung unterzeichnet

werden.

11.14 Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, welche für die Zwecke von juristischen Verfahren oder andersweitig

erstellt werden, sind vom Vorsitzenden der Geschäftsführung oder seinem zeitweisen Vertreter in dieser Sitzung oder von
zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

12. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.
12.1 Jedem Gesellschafter steht für jeden Anteil, dessen Inhaber er ist, eine (1) Stimme zu.
12.2 Vorbehaltlich der Artikel 12.3, 12.4 und 12.5 sind Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur wirksam, wenn

sie von einer Mehrheit von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte der Anteile halten, gefasst wurden; sofern diese Zahl
bei der ersten Sitzung oder der ersten schriftlichen Befragung nicht erreicht wird, werden die Gesellschafter durch Ein-
schreiben ein zweites Mal einberufen bzw. befragt, wobei der Beschluss mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen,
unabhängig von der Anzahl der vertretenen Anteile gefasst wird.

12.3 Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft sowie die Erhöhung der Verpflichtungen der Gesellschafter ge-

genüber der Gesellschaft kann die Gesellschafterversammlung nur einstimmig beschließen.

12.4 Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 12.3 bedarf ein Beschluss zur Änderung dieser Satzung (inklusive

einer Verlegung vom Gesellschaftssitz) vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen einer zahlenmäßigen Mehrheit von
Gesellschaftern, die mehr als drei Viertel der Anteile halten.

12.5 Ein Beschluss zur Auflösung der Gesellschaft oder zur Festlegung der Art und Weise der Abwicklung der Gesell-

schaft und/oder zur Ernennung der Liquidatoren ist gemäß Luxemburger Recht zu fassen.

12.6 Eine Gesellschafterversammlung ("Gesellschafterversammlung") kann auch bei Nichtbefolgung sämtlicher oder

einzelner formaler Anforderungen an die Einberufung einer Gesellschafterversammlung wirksam beraten und Beschlüsse
fassen,  falls  alle  Gesellschafter  auf  die  Einhaltung  dieser  formalen  Erfordernisse  schriftlich  oder  bei  der  betreffenden
Gesellschafterversammlung persönlich oder durch einen bevollmächtigten Vertreter verzichtet haben.

12.7 Ein Gesellschafter kann auf einer Gesellschafterversammlung vertreten werden, indem er schriftlich (auch per Fax,

E-Mail oder auf vergleichbarem Weg) einen Stellvertreter oder Bevollmächtigten bestellt, der kein Gesellschafter zu sein
braucht.

12.8
12.8.1 Sofern die Gesellschaft zum gegebenen Zeitpunkt nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, können

Gesellschafterbeschlüsse durch eine Abstimmung der Gesellschafter außerhalb einer Gesellschafterversammlung im Um-
laufverfahren  gefasst  werden,  sofern  jeder  Gesellschafter  den  genauen  Wortlaut  der  zu  treffenden  Beschlüsse  oder
Entscheidungen erhält.

12.8.2 Die Mehrheitserfordernisse für Beschlussfassungen der Gesellschafterversammlung gelten für schriftliche Be-

schlussfassungen im Umlaufverfahren der Gesellschafter entsprechend sinngemäß. Außer sofern nach Luxemburger Recht
erforderlich, existieren für schriftliche Beschlussfassungen der Gesellschafter keine Anforderungen an die Beschlussfä-
higkeit. Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter werden vorbehaltlich der Anforderungen der Artikel 12.8.1 und 12.8.2
unverzüglich mit Eingang der Originale (oder der per Fax oder als E-Mail-Anlagen übermittelter Kopien) bei der Gesell-
schaft wirksam, unabhängig davon, ob alle Gesellschafter abgestimmt haben oder nicht.

13. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. De-

zember desselben Jahres, (alle Daten jeweils einschließlich).

14. Ausschüttungen.
14.1 Vom Nettogewinn der Gesellschaft, der in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Recht ermittelt wird, werden

fünf Prozent (5%) in eine gesetzliche Rücklage eingestellt. Diese Verpflichtung zur Bildung der Rücklage verliert ihren
zwingenden Charakter, sobald die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht.

14.2 Vorbehaltlich der Bestimmungen des Luxemburger Rechts und der vorliegenden Satzung kann die Gesellschaft

durch  Beschluss  des  Gesellschafters/der  Gesellschafter  Dividenden  beschließen  und  festsetzen.  Die  Entscheidung  zur

72513

L

U X E M B O U R G

Ausschüttung und die Bestimmung des Betrags dieser Ausschüttung werden von den Gesellschaftern getroffen und diese
Dividende soll in der folgenden Reihenfolge ausgeschüttet werden:

- zuerst an den/die Inhaber der Klasse A Anteile, der/die einen Anspruch auf eine Vorzugsdividende die einem Betrag

von 10% des Nennwertes aller der von diesem/n Inhaber gehaltenen Klasse A Anteile entspricht haben soll/en, dann,

- an den/die Inhaber der Klasse B Anteile, der/die einen Anspruch auf eine Vorzugsdividende die einem Betrag von 9%

des Nennwertes aller der von diesem/n Inhaber gehaltenen Klasse B Anteile entspricht haben soll/en, dann,

- an den/die Inhaber der Klasse C Anteile, der/die einen Anspruch auf eine Vorzugsdividende die einem Betrag von 8%

des Nennwertes aller der von diesem/n Inhaber gehaltenen Klasse C Anteile entspricht haben soll/en, dann,

- an den/die Inhaber der Klasse D Anteile, der/die einen Anspruch auf eine Vorzugsdividende die einem Betrag von 7%

des Nennwertes aller der von diesem/n Inhaber gehaltenen Klasse D Anteile entspricht haben soll/en, dann,

- an den/die Inhaber der Klasse E Anteile, der/die einen Anspruch auf eine Vorzugsdividende die einem Betrag von 6%

des Nennwertes aller der von diesem/n Inhaber gehaltenen Klasse E Anteile entspricht haben soll/en, dann,

- an den/die Inhaber der Klasse F Anteile, der/die einen Anspruch auf eine Vorzugsdividende die einem Betrag von 5%

des Nennwertes aller der von diesem/n Inhaber gehaltenen Klasse F Anteile entspricht haben soll/en, dann,

- an den/die Inhaber der Klasse G Anteile, der/die einen Anspruch auf eine Vorzugsdividende die einem Betrag von 4%

des Nennwertes aller der von diesem/n Inhaber gehaltenen Klasse G Anteile entspricht haben soll/en, dann,

- an den/die Inhaber der Klasse H Anteile, der/die einen Anspruch auf eine Vorzugsdividende die einem Betrag von 3%

des Nennwertes aller der von diesem/n Inhaber gehaltenen Klasse H Anteile entspricht haben soll/en, dann,

- an den/die Inhaber der Klasse I Anteile, der/die einen Anspruch auf eine Vorzugsdividende die einem Betrag von 2%

des Nennwertes aller der von diesem/n Inhaber gehaltenen Klasse I Anteile entspricht haben soll/en, dann,

- an den/die Inhaber der Klasse J Anteile, der/die einen Anspruch auf eine Vorzugsdividende die einem Betrag von 1%

des Nennwertes aller der von diesem/n Inhaber gehaltenen Klasse J Anteile entspricht haben soll/en.

14.3 Wenn die Gesellschaft entscheidet, eine Ausschüttung aus (i) den Jahresüberschüssen, (ii) Gewinnvorträgen und/

oder (ii) verfügbaren Reserven, an die Gesellschafter vorzunehmen, ist der entsprechende Ausschüttungsbetrag zuerst den
Inhabern der entsprechenden Klasse von Anteilen als Vorzugsdividende auszuschütten. Danach sollen alle verbleibende
Beträge an die Gesellschafter der Anteile der Klasse J ausgeschüttet werden oder, wenn alle Anteile der Klasse J zurück-
gekauft und annulliert wurden, der vorangehenden Klasse von Anteilen (in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge). Wenn
zu der Zeit der Ausschüttung eine Klasse von Anteilen gemäß Artikel 5 zurückgekauft und annulliert wurde, dann soll die
Ausschüttung, zu welcher die Inhaber dieser Klasse von Anteilen berechtigt gewesen wären, der vorangehenden Klasse
von Anteilen (in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge) zugeteilt werden.

14.4 Der alleinige Geschäftsführer oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, die Geschäftsführung kann be-

schließen, vor Ende des Geschäftsjahres Zwischendividenden an den oder die Gesellschafter im Einklang mit in Artikel
14.2 der vorliegenden Satzung genannten Vorschriften auszuzahlen, wenn aus dem Abschluss hervorgeht, dass ausrei-
chende Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei (i) die auszuschüttenden Beträge die seit dem Ende des letzten
Geschäftsjahres realisierten Gewinne, zuzüglich vorgetragener Gewinne und ausschüttungsfähiger Rücklagen, aber ab-
züglich vorgetragener Verluste und solcher Beträge, die in Rücklagen einzustellen sind, die gemäß dem Gesetz von 1915
oder dieser Satzung zu bilden sind - nicht übersteigen dürfen, und (ii) ausgeschüttete Summen, die nicht durch tatsächliche
Gewinne gedeckt sind, von dem oder den jeweiligen Gesellschafter(n) zurückgefordert werden können.

15. Auflösung und Liquidation. Über die Liquidation der Gesellschaft wird durch die Gesellschafterversammlung gemäß

Luxemburger Recht und Artikel 12 entschieden. Wenn die Gesellschaft zum maßgeblichen Zeitpunkt nur einen (1) Ge-
sellschafter hat, kann dieser Gesellschafter beschließen, die Gesellschaft abzuwickeln, indem er persönlich alle bekannten
oder unbekannten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft übernimmt. Nachdem alle ausstehenden Schul-
den und Verbindlichkeiten, einschließlich Steuer- und Abwicklungskosten, beglichen worden sind, sind die verbleibenden
Nettovermögenswerte der Gesellschaft an den/die Gesellschafter so auszuschütten, dass insgesamt das gleiche wirtschaft-
liche Ergebnis wie das im Sinne der Ausschüttungsregeln für Dividenden in Artikel 14.2 dieser Satzung erreicht wird.

16. Auslegung und Luxemburger recht.
16.1 Sofern in dieser Satzung nicht anders definiert, haben die hierin benutzen großgeschriebenen Begriffe die folgende

Bedeutung:

"Verfügbarer Betrag"

bedeutet für jede Klasse den vollständigen Betrag des Nettogewinns der
Gesellschaft (inklusive Gewinnvorträge) erhöht durch (i) die jeweiligen frei
ausschüttbaren Reserven und/oder den Anteilen zugeteiltem Aufgeld, und (ii),
gegebenenfalls, durch den Betrag der Kapitalherabsetzung und der Reduzierung
der gesetzlichen Rücklage bezüglich der zurückzukaufenden und zu annullierenden
Klasse von Anteilen, jedoch reduziert durch (i) jegliche positiv bilanzierte Verluste
(einschließlich Verlustvorträge), (ii) jegliche von Gesetzes wegen (im Sinne des
Gesetzes von 1915) oder kraft dieser Satzung in Rücklagen einzuzahlenden
Summen, jeweils so wie in den entsprechenden Zwischenabschlüssen
wiedergegebenen Maße (zu Vermeidung von Missverständnissen, ohne

72514

L

U X E M B O U R G

Doppelzählung), (iii) jegliche Dividenden zu denen der/die Inhaber der Anteile
gemäβ dieser Satzung berechtigt ist/sind (z.B. jegliche Gewinnberechtigung), so
dass:
AA = (NP + P+ CR) – (L + LR+ PE),
wobei:
AA = Verfügbarer Betrag;
NP = Nettogewinn (einschließlich Gewinnvorträge);
P = jegliche frei verfügbaren Rücklagen (einschließlich Aufgeld), wie durch den
Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, die
Geschäftsführung bestimmt, wobei, um Missverständnisse auszuschließen, der
Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, die
Geschäftsführung nach seinem/ihrem Ermessen entscheidet, den Gesamtbetrag
oder einen Teilbetrag solcher frei verfügbaren Rücklagen einzubeziehen oder
auszuschließen;
CR = der Betrag der Kapitalherabsetzung und der Reduzierung der gesetzlichen
Rücklage bezüglich der zu annullierenden Klasse von Anteilen;
L = als positiv bilanzierte Verluste (einschließlich Verlustvorträge);
LR = jegliche, nach den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 oder dieser Satzung,
den Rücklagen zu zuordnende Summen.
PE = Gewinnberechtigung (feste jährliche Ausschüttungen zu denen der/die
Inhaber der Anteile gemäβ dieser Satzung berechtigt ist/sind).

"Annullierungsbetrag"

bedeutet ein Betrag, der den Verfügbaren Betrag, bezüglich der jeweiligen Klasse
von Anteilen, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 oder
dieser Satzung nicht übersteigt.

"Zwischenabschlüsse"

bedeutet die Zwischenabschüsse der Gesellschaft zu dem entsprechenden Datum
der Zwischenabschlüsse.

"Datum der Zwischenabschlüsse" bedeutet das Datum, das nicht mehr als dreißig (30) Tage und nicht weniger als

zehn (10) Tage vor dem Datum des Rückkaufs und der Annullierung der jeweiligen
Klasse liegt.

"Gewinnberechtigung"

bedeutet die festen jährlichen Ausschüttungen zu denen der/die Inhaber der Anteile,
die nicht zurückgekauft werden, gemäβ dieser Satzung berechtigt ist/sind).

16.2 In der vorliegenden Satzung

16.2.1 gilt jeweils Folgendes:

(a) Bei Verwendung eines grammatikalischen Geschlechts zur Bezeichnung von Personen sind Personen des anderen

Geschlechts ebenfalls gemeint;

(b) Begriffsverwendungen in Einzahl und Mehrzahl sind jeweils austauschbar, sofern sich aus dem Zusammenhang

nichts anderes ergibt;

(c) vom Begriff der "Person" sind natürliche Personen, Unternehmen, Gesellschaften und sonstige juristische Personen,

Regierungen, Staaten oder staatliche Behörden oder Joint Ventures, Vereine, Personengesellschaften, Betriebsräte oder
Arbeitnehmervertretungen (mit oder ohne eigene Rechtspersönlichkeit) umfasst;

(d) beim Verweis auf gesetzliche Bestimmungen oder Gesetze sind diesbezügliche Änderungen und geänderte oder

unveränderte Neufassungen der Bestimmungen oder Gesetze ebenfalls umfasst;

16.2.2 sollen Formulierungen wie "sind ebenfalls gemeint" oder "sind umfasst" oder "einschließlich" so verstanden

werden, als würden Worte wie "...aber nicht ausschließlich..." oder "...aber nicht begrenzt auf..." oder "...aber nicht einge-
schränkt auf..." diesen Formulierungen nachstehen; allgemeine Begriffe sind nicht deshalb einschränkend auszulegen, weil
davor oder danach konkretere Handlungen, Begriffe oder Beispiele stehen;

16.2.3 lassen die Überschriften die Auslegung dieser Satzung unberührt.

16.3 Ergänzend zu dieser Satzung gelten für die Gesellschaft alle anwendbaren Bestimmungen Luxemburger Rechts."

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2016.

<i>Zeichnung - Zahlung

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:

72515

L

U X E M B O U R G

Zeichner

Anteile

Heitman European Residential Investment Partners I SCSp, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 Klasse B Anteile

1.250 Klasse C Anteile

1.250 Klasse D Anteile

1.250 Klasse E Anteile

1.250 Klasse F Anteile

1.250 Klasse G Anteile
1.250 Klasse H Anteile

1.250 Klasse I Anteile

1.250 Klasse J Anteile

Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500 Anteile

Alle Anteile wurden vollständig durch eine Bareinlage von jeweils einem Euro (EUR 1.-) und einen Zeichnungspreis

von insgesamt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-) eingezahlt. Der Nachweis dieser Zahlung und dass ein Betrag
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurde, ist dem Notar vorgelegt
worden, der die Entgegennahme dieses Zahlungsnachweises ausdrücklich feststellte.

<i>Kosten

Die von der Gesellschaft infolge dieser Urkunde und/oder der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten einer

jedweden Form, belaufen sich auf tausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-).

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat die oben genannte Person, wie vorstehend vertreten, die das gesamte

gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertritt und die der Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse
ausübt, die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Jede der folgenden Personen wird als Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Zeit ernannt:
- Herr Gordon BLACK, Geschäftsführer, geboren am 23. April 1965 in Royal Oak, Michigan, Vereinigte Staaten, mit

beruflicher Anschrift in 8, Hanover Street, third floor, W1S 1YQ London, Vereinigtes Königreich; und

- Herr Piotr ANDRZEJEWSKI, Geschäftsführer, geboren am 31. August 1978 in Sokolka, Polen, mit beruflicher An-

schrift in 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

2. Der Gesellschaftssitz ist in 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der vorstehend

genannten Person die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung.
Auf Wunsch der vorstehend genannten Person ist bei Widersprüchen zwischen der englischen und der deutschen Fassung
die englische Fassung maßgeblich.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Bocklandt, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 février 2016. Relation: 1LAC/2016/3821. Reçu soixante-quinze (75.-)

euros.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Luxemburg, den Februar. 09 2016.

Référence de publication: 2016065270/814.
(160027225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

E-TPA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 22, rue de Macher.

R.C.S. Luxembourg B 204.419.

L'an deux mille seize, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

a comparu:

Monsieur Jabir CHAKIB, chef de projet, demeurant à L-5421 Erpeldange, 3b, Schmattegaass.

72516

L

U X E M B O U R G

Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité

limitée qu’elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois y

relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société pourra
en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de
participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou ins-
truments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la
gestion  et  le  contrôle  de  toute  société  ou  entreprise.  Elle  pourra  en  outre  investir  dans  l'acquisition  et  la  gestion  d'un
portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra procéder au développement, l'acquisition, l'exploitation, la vente et la distribution de droits intellectuels

relatifs à des logiciels au sens de la Loi du 22 mai 2009. Elle réalisera son objet directement ou par le biais de participations
dans d'autres sociétés ou des accords de coopération. La Société pourra réaliser son objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Elle pourra développer toute autre activité industrielle, commerciale, ou immobilière susceptible de contribuer à la réali-
sation de son objet principal et dans ce cadre, elle pourra s'intéresser à la constitution, gestion et financement, sous quelque
forme que ce soit, d'autres entreprises. Tout ceci pour autant que la société qualifiera comme une société de participations
financières.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, unique-

ment par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des
émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra aussi
donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur toutes ou partie
de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société,
et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

La Société peut apporter toutes prestations de services aux entreprises dans le domaine de secrétariat de sociétés, de

gestion de projet, études de marché, analyse et optimisation des structures de groupe de sociétés et mise à disposition des
consultants.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de «E-TPA S.à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Remich. Il pourra être déplacé dans la même commune par simple

décision de la gérance de la société.

Il peut être transféré en dehors de cette commune en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une

décision de l'assemblée générale des associés.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500.- EUR) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125.- EUR) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés

qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent pas

fin à la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son
objet social.

72517

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital

social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assemblée

générale sont exercés par celui-ci. Les dispositions des articles 200-1 et 200-2 de la loi sur les sociétés commerciales sont
alors applicables.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Du bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal

jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale
des associés.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l’indication

des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les dispositions légales s’appliqueront.

<i>Souscription et libération

Toutes les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Jabir CHAKIB, prénommé, et ont été

libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500.- EUR) se trouve dès
à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à mille cent euros (1.100.- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi à L-5550 Remich, 22, rue de Macher.
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Jabir CHAKIB, prénommé.
Vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et

l’engager valablement par sa seule signature.

<i>Déclaration

Le comparant déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre

le financement du terrorisme, et du règlement grand-ducal du 1 

er

 février 2010, être le bénéficiaire réel et final de la société

ci-dessus et certifie que les fonds/biens/droits ne proviennent d’aucune infraction pénale.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention sur la nécessité d’obtenir des autorités com-

pétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l’article deux
des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Remich, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante, connue du notaire

par nom, prénom, état et demeure, a signé avec Nous notaire le présent acte.

72518

L

U X E M B O U R G

Signé: J. CHAKIB, Patrick SERRES.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 26 février 2016. Relation: GAC/2016/1484. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): N. DIEDERICH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 08 mars 2016.

Référence de publication: 2016076433/120.
(160041334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

Immo.Pacha S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 7, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 204.441.

STATUTS

L'an deux mille seize,
Le vingt-trois février,
Par-devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange,

Ont comparu:

1) Monsieur Michel MALUNGU N'KIAMBI, employé privé, né à Kinshasa (Congo) le 22 janvier 1978, demeurant à

L-5447 Schwebsingen, 2, rue du Port,

2) Monsieur Ndanda NZEYIMO, employé privé, né à Kinshasa (Congo) le 7 juillet 1957, demeurant à L-2349 Luxem-

bourg, 48, rue des Prés.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée qu'ils vont constituer par les présentes:

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les lois y relatives
ainsi que par les présents statuts.

La Société comporte initialement plusieurs associés; elle peut, à toute époque, devenir société unipersonnelle par la

réunion de toutes les parts sociales en une seule main, puis redevenir une société à plusieurs associés par suite de cession
ou de transmission totale ou partielle des parts sociales ou de création de parts nouvelles.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet social, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre

ou pour compte de tiers, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l'achat, la vente, la location de toutes
propriétés immobilières avec ou sans promesse de vente, la gérance et l'administration ou l'exploitation de tous immeubles,
la promotion immobilière ainsi que la gestion d'un syndic de copropriété et l'administration de biens et toutes opérations
auxquelles les immeubles peuvent donner lieu, qu'elles soient commerciales, financières, mobilières ou immobilières, et
l'exploitation d'une agence immobilière.

La Société a également pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec restauration

et d'un établissement d'hébergement.

D'une façon générale, la Société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières

et  financières,  pouvant  se  rapporter  directement  ou  indirectement  aux  activités  ci-dessus  décrites  ou  susceptibles  d'en
faciliter l'accomplissement.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société prend la dénomination de «Immo.Pacha S.à r.l.».

Art. 5. Siège social. Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé ou des associés,

selon le cas. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant ou conseil de gérance.

Des succursales ou bureaux pourront être établis partout, au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- €) représenté par cent (100) parts

sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- €) chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues

par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans

les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social.

72519

L

U X E M B O U R G

L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés; en cas

de pluralité d'associés toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou

de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants-droits ou héritiers de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte

que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire
judiciaire des valeurs sociales; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Au cas où une part est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par

l'usufruitier.

Art. 10. Cession et transmission des parts.
1. Cessions et transmissions en cas d'associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
2. Cessions et transmissions en cas de pluralité d'associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l'agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des descendants

soit au conjoint survivant.

Dans les cas où la cession ou transmission de parts est soumise à l'agrément des associés restants, ces derniers ont un

droit de préférence pour le rachat des parts à céder, en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent au moment de la
cession. En cas de l'exercice de leur droit de préférence par les associés restants et en cas de désaccord sur le prix de rachat,
le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte
pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Art. 11. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture de l'associé ou de l'un des associés. Le décès, l'incapacité, la mise en

tutelle ou en curatelle, la faillite, la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés, n'entraîne pas la dissolution de
la Société.

Art. 12. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non-associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition

intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet de
la Société. Le ou les gérants représentent, de même, la Société en justice soit en demandant, soit en défendant.

Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique ou par

l'assemblée générale des associés.

Dans ce dernier cas, l'associé unique ou l'assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur nombre,

la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu'il

soit besoin d'une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes,
mais encore pour toutes raisons, quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine de l'associé unique ou des
associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L'associé unique ou les associés décideront de la ré-
munération du gérant.

Art. 13. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent

pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 14. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société. Simple mandataire il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 15. Décisions de l'associé ou des associés.
1. Lorsque la Société ne compte qu'un associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés.

Les décisions de l'associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

72520

L

U X E M B O U R G

2. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été

adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, à moins que la loi ou les présents statuts n'en
disposent autrement.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il possède.

Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Art. 17. Inventaire - Bilan. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. Tout associé peut prendre au siège social communication
de l'inventaire et des comptes annuels.

Art. 18. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux,

amortissements et provisions, résultant des comptes annuels constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou l'assemblée générale des associés.

Art. 19. Dissolution - Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce

soit, la liquidation sera faite pour un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts l'associé unique ou les associés,

selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Disposition transitoire.

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente-et-un décembre 2016.

<i>Souscription et paiement

Les cent parts sociales (100) ont été souscrites comme suit par:

1. Monsieur Michel MALUNGU N'KIAMBI prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 parts

2. Monsieur Ndanda NZEYIMO prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Les cents parts sociales (100) ont été entièrement souscrites et intégralement libérées par les associés, comme suit:
- Cinquante-deux (52) parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en nature d'un montant de six mille

cinq cents euros (6.500.- €) consistant en du matériel informatique, qui, suivant la facture présentée, est évaluée à la valeur
de six mille cinq cents euros (6.500.- €), de sorte que la valeur de six mille cinq cents euros (6.500.- €) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la Société.

L'évaluation de l'apport en nature a été faite par les futurs associés sous leur unique responsabilité et ils déchargent

expressément le notaire instrumentaire de toute responsabilité quant à la réalité et la valeur de cet apport. La prédite facture,
après avoir été signée «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec
lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

- Quarante-huit (48) parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en numéraire de sorte que la somme de

six mille euros (6.000.- €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales se trouvent remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à mille cent euros (1.100.- €).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les associés prénommés, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, ont pris à l'unanimité les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

Est appelé aux fonctions de gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Michel MALUNGU N'KIAMBI, prénommé.
La Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant unique.

72521

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la Société est fixé à L-2611 Luxembourg, 7, route de Thionville.

DONT ACTE, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instru-

mentaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. MALUNGU N'KIAMBI, N. NZEYIMO, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 février 2016. Relation: EAC/2016/4859. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): A. SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins

de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 29 février 2016.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2016076561/162.
(160041813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

Fernbach Financial Software S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 1A, op der Ahlkerrech.

R.C.S. Luxembourg B 70.830.

Im Jahre zweitausendsechzehn, den sechsundzwanzigsten Tag im Monat Februar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz zu Niederanven.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,

der  Aktiengesellschaft  FERNBACH  FINANCIAL  SOFTWARE  S.A.,  mit  Sitz  in  L-5365  Munsbach,  1A,  rue  Gabriel
Lippmann, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 70.830, aufgenommen durch Notar Notar
Emile SCHLESSER, mit den Amtswohnsitze in Luxemburg, am 20. Juli 1999, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations Nummer 754 vom 12. Oktober 1999, letztmalig abgeändert durch den Notar Henri BECK, Notar
mit dem Amtssitze in Echternach. am 16. September 2011, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2725 vom 9. November
2011.

Die  Versammlung  wird  eröffnet  unter  dem  Vorsitz  von  Herr  Günther  Fernbach,  Datenverarbeitungskaufmann,  ge-

schäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, 1a, op der Ahlkerrech.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Danielle Schmuck-Fernbach, Diplom Kauffrau, geschäftsansässig in

L-6776 Grevenmacher, 1a, op der Ahlkerrech.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herr Günther Fernbach, vorbenannt.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf

einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
beschliessen.

Etwaige Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem ins-

trumentierenden  Notar  “ne  varietur“  unterzeichnet,  bleiben  gegenwärtigem  Protokolle,  mit  welchem  sie  einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.

3.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-6776 Grevenmacher, 1a, op der Ahlkerrech.
2.- Abänderung von Artikel 2 der Satzungen.
3.- Abänderung des beruflichen Wohnsitzes von Herrn Günter Fernbach als alleiniger Verwaltungsratsmitglied der

Gesellschaft den nunmehr wie folgt lautet: L-6776 Grevenmacher, 1a, op der Ahlkerrech.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-5365 Munsbach, 1A, rue Gabriel Lippmann nach

L-6776 Grevenmacher, 1a, op der Ahlkerrech, zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

In Folge dessen, beschliesst die Generalversammlung Artikel 2 der Satzungen der Gesellschaft abzuändern wie folgt:

72522

L

U X E M B O U R G

„ Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Grevenmacher.“

<i>Dritter und letzter Beschluss

Die  Generalversammlung  beschliesst  den  beruflichen  Wohnsitz  von  Herrn  Günter  Fernbach  als  alleiniger  Verwal-

tungsratsmitglied der Gesellschaft abzuändern den nunmehr wie folgt lautet: L-6776 Grevenmacher, 1a, op der Ahlkerrech.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

<i>Bevollmächtigung

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten

Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

<i>Kosten

Die  Kosten  welche  der  Gesellschaft  wegen  der  gegenwärtigen  Urkunde  obliegen,  werden  auf  EINTAUSENEIND-

HUNDERT EURO (EUR 1.100,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Danielle Schmuck-Fernbach, Günther Fernbach, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 01 mars 2016. 1LAC/2016/6927. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 8. März 2016.

Référence de publication: 2016076476/61.
(160041927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

Elderflower Infrastructure VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.501,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 191.902.

In the year two thousand and sixteen, on the eighth of January,
Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange,

THERE APPEARED:

Charleston Infrastructure III S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

under the laws of Luxembourg, having its registered office at 23 Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg and registered with
the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B184131,

represented by Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, residing professionally in Pétange, by virtue of a power of

attorney given under private seal on 8 January 2016.

Which power of attorney shall be signed ne varietur by the proxyholder of the above named party and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Who declared and requested the notary to state:
1) That Charleston Infrastructure III S.à r.l., prenamed, is the sole shareholder of Elderflower Infrastructure VII S.à r.l.,

a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 23, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B191902 and incorporated by a deed of the Francis KESSELER on 23 October 2014 published in the Mémorial C, Receuil
des Sociétés et Associations on 9 December 2014 number 3791(the “Company”).

2) That the corporate capital of the Company is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500) represented

by twelve thousand and five hundred (12,500) ordinary shares each having a nominal value of one Euro (EUR 1).

3)  After  this  had  been  set  forth,  the  above  named  sole  shareholder  representing  the  entire  corporate  capital  of  the

Company, has decided to hold an extraordinary general meeting and to take the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company with effect as of 31 December 2015 by an

amount of one Euro (EUR 1), so as to raise it from its present amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR
12,500) to twelve thousand five hundred and one Euro (EUR 12,501) by the creation and the issue of one (1) new ordinary
share with a nominal value of one Euro (EUR 1).

72523

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and paying up

The one (1) new ordinary share together with a total issue premium of one million one hundred fifty-five thousand nine

hundred ninety Euro and eighteen Cents (EUR 1,155,990.18) have been subscribed as follows:

Charleston Infrastructure III S.à r.l., prenamed, has subscribed to one (1) new ordinary share.
Such new ordinary share is paid up by way of
- a contribution in kind in the aggregate amount of one million one hundred fifty-five thousand nine hundred ninety-

one Euro and eighteen Cents (EUR 1,155,991.18) consisting in a liquid payable that “Charleston Infrastructure III S.à r.l.”,
holds against the Company (the “Contribution in Kind”).

Evidence of the value of the aforementioned Contribution in Kind has been given to the undersigned notary by a de-

claration of contribution value of the board of managers of the Company dated 31 December 2015, which declaration of
contribution value will be signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary and shall remain annexed
to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Contribution in Kind for a total amount one million one hundred fifty-five thousand nine hundred ninety-one Euro

and eighteen Cents (EUR 1,155,991.18) out of which:

- one Euro (EUR 1) shall be allocated to the corporate capital of the Company; and
- one million one hundred fifty-five thousand nine hundred ninety Euro and eighteen Cents (EUR 1,155,990.18) shall

be allocated to the share premium account of the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the sole shareholder resolves to amend the entire article 6 of the Articles

of the Company, which shall now read as follows:

“ Art. 6. Capital.
6.1. The corporate capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred and one Euro (EUR 12,501) repre-

sented by twelve thousand five hundred and one (12,501) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the
“Shares”).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party

the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party, in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing party, known to the undersigned notary, by name,

last name, civil status and residence, the said representative of the appearing party signed together with us, the notary, the
present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille seize, le huit janvier,
Par devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange,

A COMPARU:

Charleston Infrastructure III S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois de Lu-

xembourg,  ayant  son  siège  social  à  23,  Rue  Aldringen,  L-1118  Luxembourg  et  immatriculée  auprès  du  registre  de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B184131

représentée par Sofia Afonso-da Chao Conde, clerc de notaire, résidant professionnellement à Pétange, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé le 8 janvier 2016.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Qui a déclaré et demandé au notaire d'acter:
1) Que «Charleston Infrastructure III S.à r.l.», prénommée est l'associé unique de Elderflower Infrastructure VII S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 191902 et constituée
suivant acte reçu par le notaire Francis KESSELER en date du 23 octobre 2014 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations en date du 9 décembre 2014 numéro 3791 (la «Société»).

2) Que le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par douze mille

cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune.

3) Ceci ayant été exposé, l'associé unique prénommé représentant l'intégralité du capital social de la Société a décidé

de tenir une assemblée générale extraordinaire et de prendre les résolutions suivantes:

72524

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant d'un euro (1 EUR), afin de le porter

de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) à douze mille cinq cent et un euros (12.501 EUR) par
une (1) nouvelle part sociale ordinaire avec une valeur nominale d'un euro (1 EUR).

<i>Souscription et libération

La (1) nouvelle part sociale ordinaire d'une valeur nominale d'un euro (1 EUR) avec une prime d'émission totale d'un

million cent cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et dix-huit centimes (1.155.990,18 EUR) ont été sou-
scrites comme suit:

Charleston Infrastructure III S.à r.l., prénommée, a souscrit à une (1) nouvelle part sociale ordinaire.
Cette nouvelle part sociale ordinaire est libérée par:
- un apport en nature d'un montant total d'un million cent cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et dix-

huit centimes (1.155.991,18 EUR) consistant en une position liquide que «Charleston Infrastructure III S.à r.l.» détient à
l'encontre de la Société (l'«Apport en Nature»).

La preuve de la valeur de l'Apport en Nature susmentionné a été apportée au notaire instrumentaire par une déclaration

de valeur du conseil de gérance de la Société datée du 31 décembre 2015, cette déclaration de valeur sera signée “ne varietur”
par la partie comparante et le notaire instrumentaire et restera annexée au présent acte, pour être enregistrée avec lui.

L'Apport en Nature d'un montant total d'un million cent cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et dix-

huit centimes (1.155.991,18 EUR) duquel:

- un euro (1 EUR) sera alloué au capital social de la Société; et
- un million cent cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et dix-huit centimes (1.155.990,18 EUR) seront

alloués au compte de prime d'émission de la Société.

<i>Deuxième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'associé unique décide de modifier l'entièreté de l'article 6 des Statuts de

la Société, pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 6. Capital.
6.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent et un euros (12.501 EUR) représenté par douze mille

cinq cent et un (12.501) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, en cas de divergence entre
le texte français et anglais, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, qui est connu du notaire instru-

mentaire par son nom, prénom, état civil et résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec nous, le notaire,
le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 janvier 2016. Relation: EAC/2016/1998. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016077846/126.
(160043702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

Elderflower Infrastructure VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.501,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 191.889.

In the year two thousand and sixteen, on the eighth of January,
Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange,

THERE APPEARED:

Charleston Infrastructure III S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

under the laws of Luxembourg, having its registered office at 23 Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg and registered with
the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B184131,

72525

L

U X E M B O U R G

represented by Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, residing professionally in Pétange by virtue of a power of

attorney given under private seal on 8 January 2016.

Which power of attorney shall be signed ne varietur by the proxyholder of the above named party and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Who declared and requested the notary to state:
1) That Charleston Infrastructure III S.à r.l., prenamed, is the sole shareholder of Elderflower Infrastructure VIII S.à r.l.,

a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 23, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B191889 and incorporated by a deed of the Francis KESSELER on 23 October 2014 published in the Mémorial C, Receuil
des Sociétés et Associations on 8 December 2014 number 3764(the “Company”).

2) That the corporate capital of the Company is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500) represented

by twelve thousand and five hundred (12,500) ordinary shares each having a nominal value of one Euro (EUR 1).

3)  After  this  had  been  set  forth,  the  above  named  sole  shareholder  representing  the  entire  corporate  capital  of  the

Company, has decided to hold an extraordinary general meeting and to take the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company with effect as of 31 December 2015 by an

amount of one Euro (EUR 1), so as to raise it from its present amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR
12,500) to twelve thousand five hundred and one Euro (EUR 12,501) by the creation and the issue of one (1) new ordinary
share with a nominal value of one Euro (EUR 1).

<i>Subscription and paying up

The one (1) new ordinary share together with a total issue premium of six hundred seventy-four thousand two hundred

nineteen Euro and sixty Cents (EUR 674,219.60) have been subscribed as follows:

Charleston Infrastructure III S.à r.l., prenamed, has subscribed to one (1) new ordinary share.
Such new ordinary share is paid up by way of
- a contribution in kind in the aggregate amount of six hundred seventy-four thousand two hundred twenty Euro and

sixty Cents (EUR 674,220.60) consisting in a liquid payable that “Charleston Infrastructure III S.à r.l.”, holds against the
Company (the “Contribution in Kind”).

Evidence of the value of the aforementioned Contribution in Kind has been given to the undersigned notary by a de-

claration of contribution value of the board of managers of the Company dated 31 December 2015, which declaration of
contribution value will be signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary and shall remain annexed
to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Contribution in Kind for a total amount six hundred seventy-four thousand two hundred twenty Euro and sixty

Cents (EUR 674,220.60) out of which:

- one Euro (EUR 1) shall be allocated to the corporate capital of the Company; and
- six hundred seventy-four thousand two hundred nineteen Euro and sixty Cents (EUR 674,219.60) shall be allocated

to the share premium account of the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the sole shareholder resolves to amend the entire article 6 of the Articles

of the Company, which shall now read as follows:

“ Art. 6. Capital.
6.1. The corporate capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred and one Euro (EUR 12,501) repre-

sented by twelve thousand five hundred and one (12,501) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the
“Shares”).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party

the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party, in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing party, known to the undersigned notary, by name,

last name, civil status and residence, the said representative of the appearing party signed together with us, the notary, the
present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille seize, le huit janvier,

72526

L

U X E M B O U R G

Par devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange,

A COMPARU:

Charleston Infrastructure III S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois de Lu-

xembourg,  ayant  son  siège  social  à  23,  Rue  Aldringen,  L-1118  Luxembourg  et  immatriculée  auprès  du  registre  de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B184131

représentée par Sofia Afonso-da Chao Conde, clerc de notaire, résidant professionnellement à Pétange, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé le 8 janvier 2016.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Qui a déclaré et demandé au notaire d'acter:
1) Que «Charleston Infrastructure III S.à r.l.», prénommée est l'associé unique de Elderflower Infrastructure VIII S.à

r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 191889 et
constituée suivant acte reçu par le notaire Francis KESSELER en date du 23 octobre 2014 publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations en date du 8 décembre 2014 numéro 3764 (la «Société»).

2) Que le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par douze mille

cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune.

3) Ceci ayant été exposé, l'associé unique prénommé représentant l'intégralité du capital social de la Société a décidé

de tenir une assemblée générale extraordinaire et de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant d' un euro (1 EUR), afin de le porter

de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) à douze mille cinq cent et un euros (12.501 EUR) par
une (1) nouvelle part sociale ordinaire avec une valeur nominale d'un euro (1 EUR).

<i>Souscription et libération

La (1) nouvelle part sociale ordinaire d'une valeur nominale d'un euro (1 EUR) avec une prime d'émission totale de six

cent soixante-quatorze mille deux cent dix-neuf euros et soixante centimes (674.219,60 EUR) ont été souscrites comme
suit:

Charleston Infrastructure III S.à r.l., prénommée, a souscrit à une (1) nouvelle part sociale ordinaire.
Cette nouvelle part sociale ordinaire est libérée par:
- un apport en nature d'un montant total de six cent soixante-quatorze mille deux cent vingt euros et soixante centimes

(674.220,60 EUR) consistant en une position liquide que «Charleston Infrastructure III S.à r.l.» détient à l'encontre de la
Société (l'«Apport en Nature»).

La preuve de la valeur de l'Apport en Nature susmentionné a été apportée au notaire instrumentaire par une déclaration

de valeur du conseil de gérance de la Société datée du 31 décembre 2015, cette déclaration de valeur sera signée “ne varietur”
par la partie comparante et le notaire instrumentaire et restera annexée au présent acte, pour être enregistrée avec lui.

L'Apport en Nature d'un montant total de six cent soixante-quatorze mille deux cent vingt euros et soixante centimes

(674.220,60 EUR) duquel:

- un euro (1 EUR) sera alloué au capital social de la Société; et
- six cent soixante-quatorze mille deux cent dix-neuf euros et soixante centimes (674.219,60 EUR) seront alloués au

compte de prime d'émission de la Société.

<i>Deuxième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'associé unique décide de modifier l'entièreté de l'article 6 des Statuts de

la Société, pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 6. Capital.
6.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent et un euros (12.501 EUR) représenté par douze mille

cinq cent et un (12.501) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, en cas de divergence entre
le texte français et anglais, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, qui est connu du notaire instru-

mentaire par son nom, prénom, état civil et résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec nous, le notaire,
le présent acte.

72527

L

U X E M B O U R G

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 janvier 2016. Relation: EAC/2016/1581. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016077847/126.
(160043704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

H.I.P.E. S.à r.l. (Holographic International Productions Entertainment), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.230,00.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 194.136.

<i>Extrait de conventions de cession de parts sociales

Il résulte de plusieurs conventions de cession de parts sociales que les parts sociales de la Société sont désormais détenues

comme suit:

Monsieur David MICHEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
né le 23 juin 1970 à Metz, France,
demeurant à F-57855 Saint-Privat-la-Montagne
31, rue de la Petite-Flammée

- 8653 actions

Monsieur Patrick CAMUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
né le 31 août 1961 à Algrange, France
demeurant à F-57310 Betrange
3, impasse du Forgeron

- 962 actions

PCLEASE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18, rue Robert Stümper
L-2557 Luxembourg
R.C.S: Luxembourg B 72.509

- 7692 actions

LAZURINVEST SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55-57, rue de Merl
L-2146 Luxembourg
R.C.S: Luxembourg B 146.280

- 1923 actions

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2016.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016077919/32.
(160043390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

PBD Investissements, Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: eDéclaration Investissements.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 21, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 175.579.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 08 mars 2016, que les associés

décident de transférer le siège social de la société du 49 boulevard Royal, L-1741 Luxembourg au 21, rue de Hollerich,
L-1741 Luxembourg à compter du 1 

er

 mars 2016.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016083083/13.
(160049600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

72528


Document Outline

1492i Investments &amp; Co S.C.A.

9900 Finance Lux Branch

9900 Finance Lux Co S.à.r.l.

Aforcomlux SA

Ageney S.A.

Andreas Management Services S.à r.l.

Argos Investment Fund

Atlantico Investment Corporation S.à r.l.

Auryn

Batiau S.à r.l.

Batiau S.à r.l.

Bati Expansion

Bâti-rêve S.à r.l.

Belle Isle Investissements S.A., société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF

Bowline S.à r.l.

City Investments S.A.

Compact Music, S.à r.l.

CRH Canada Finance Luxembourg Sàrl

Elderflower Infrastructure VIII S.à r.l.

Elderflower Infrastructure VII S.à r.l.

E-TPA S.à r.l.

European Real Estate Senior Debt 3 S.à r.l.

Fernbach Financial Software S.A.

Fidelio 2

Fondation Pauline de Faillonnet

HERIP Master I S.à r.l.

H.I.P.E. S.à r.l. (Holographic International Productions Entertainment)

Hosco S.A.

Immo.Pacha S.à.r.l.

International Railroad Holding S.à r.l.

Intertrust Topholding (Luxembourg) S.à r.l.

Invesco Munich Hotel Investment S.à r.l.

KPI Retail Property 24 S.à r.l.

Lamandier Investments S.A.

PBD Investissements

Thea Invest S.A.

Universal WM Solutions S.à r.l.

Uno Holdings S.à r.l.

Vakraly S.à r.l.

Vanbreda &amp; Lang S.A.

Vesalius Biocapital I S.A. SICAR

Viper Holdings S.à r.l.

Winnebago Holdings S.à r.l.

WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l.

WPP Luxembourg Holdings Two S.à r.l.

WPP Union Square S.à r.l.