This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1477
23 mai 2016
SOMMAIRE
Bazar International de Luxembourg . . . . . . . .
70896
Bermuda Holdco Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
70894
Borgo Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
70896
Bornbet GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70896
CADMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70892
Cadmos Fund Management . . . . . . . . . . . . . . .
70892
Carbolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70893
CCL FINANCES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70895
COPEL S.A. Société de gestion de patrimoine
familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70853
DBIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70852
De Jonge S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70852
De Roude Leif S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70853
Development Portisco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
70850
Digital Services LIII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
70869
Digital Services LIV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
70859
Donald SPV D S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70852
Donald SPV E S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70852
Ebrand Services SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70850
EEM World S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70850
EFR Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70851
EFR Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70853
EMI Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70857
Engineered Packaging Center S.A. . . . . . . . . .
70850
Enumdns S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70851
European Capital Private Debt S.à r.l. . . . . . .
70851
European Capital UK Sme Debt S.à r.l. . . . . .
70851
Faber Digital Solutions S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
70853
Facs SV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70854
Fell-Systemhaus-Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
70854
Financial Development S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
70854
FM Transac SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70855
Foreveryoung Parent S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
70855
Henderson Property Management Company
(Luxembourg) No. 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
70855
Hifi Tech Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70856
Hod Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70856
Hong Da Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70856
Horses Trucks Import S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
70857
HPL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70857
I Like Events S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70858
I Want Car Lease S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70858
Lezam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70858
Lilux International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70880
N P C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70895
Quattrex GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70869
WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l. . . .
70888
70849
L
U X E M B O U R G
Ebrand Services SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 21, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 135.335.
Le siège social de la société est désormais établi au 21 rue Léon Laval L-3372 Leudelange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2015.
Référence de publication: 2016079316/10.
(160044809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
EEM World S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 45, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 166.088.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires convoqués de façon extraordinaire au siègei>
<i>social en date du 1 i>
<i>eri>
<i> mars 2016 à 13hi>
<i>Résolutionsi>
L'Assemblée accepte la démission du Commissaire en fonction soit:
La société VAN CAUTER-SNAUWAERT & Co Sàrl.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'Assemblée décide de nommer un nouveau Commissaire à savoir:
Monsieur Reiner VAN TILBORG, né le 14.02.1958 à Wilrijk et ayant son adresse privée au 4d, rue Pletzer L-8080
BERTRANGE.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2016.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EEM WORLD SA
Référence de publication: 2016079320/20.
(160045532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Engineered Packaging Center S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4902 Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.
R.C.S. Luxembourg B 142.520.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 18 novembre 2015 que Michèle Lutgen a
été réélue aux fonctions de comme commissaire aux comptes pour un terme expirant lors de l'assemblée générale ordinaire
de 2016.
Luxembourg, le 15 mars 2016.
Référence de publication: 2016079302/12.
(160045608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Development Portisco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 110.558.
<i>Extrait des résolutions du conseil d'administration du 8 mars 2016i>
Le siège social est transféré au 127, Rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg à la date du 22 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 8 mars 2016.
Référence de publication: 2016079288/12.
(160045406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
70850
L
U X E M B O U R G
European Capital Private Debt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 937.521,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 191.694.
Lors du conseil de gérance tenu en date du 16 février 2016, les gérants ont pris connaissance de la décision de la ville
de Luxembourg de modifier le nom et le code postal de la rue Robert Stümper.
En conséquence, le siège social de la Société est au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2016.
Référence de publication: 2016079310/13.
(160045522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
European Capital UK Sme Debt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 130.500,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 188.383.
Lors du conseil de gérance tenu en date du 16 février 2016, les gérants ont pris connaissance de la décision de la ville
de Luxembourg de modifier le nom et le code postal de la rue Robert Stümper.
En conséquence, le siège social de la Société est au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2016.
Référence de publication: 2016079311/13.
(160045521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
EFR Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1141 Luxembourg, 103, Bei der Härewiss.
R.C.S. Luxembourg B 4.427.
<i>Extrait d'une résolution par écrit prise le 23 février 2016i>
Il résulte desdites décisions que:
- Monsieur Paul Siemelink a démissionné de ses fonctions de gérant de la société avec effet au 18 février 2016.
- Monsieur Alexandre Page-Relo, né le 21 août 1978 à Avignon, France, domicilié à John F. Kennedylaan 14-D6 à 4811
ET Breda, et monsieur George Roberts, né le 23 octobre 1978 à Sao Paulo, Brésil, domicilié à 129 Storm van 's Grave-
sandeweg à 2242 JE Wassenaar, ont été nommés gérants de la société avec effet au 1
er
mars 2016 et ce pour une durée
indéterminée.
Luxembourg, le 23 février 2016.
Pour extrait conforme
Rika Camilla Alice Coppens
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016079321/18.
(160044862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Enumdns S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 21, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 120.519.
Le siège social de la société est désormais établi au 21, rue Léon Laval L-3372 Leudelange
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 2016.
Référence de publication: 2016079337/10.
(160044810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
70851
L
U X E M B O U R G
Donald SPV D S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 164.764.
Mit Datum 1. Januar 2016 ändert sich die Anschrift von Stuart Hanbury, Gérant de classe B, auf 55 St. James's Street,
SW1A 1LA London, Grossbritanien.
Im Februar 2016 hat die Stadt Luxembourg beschlossen, die Addresse von 7a, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
in 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg zu ändern.
Luxembourg, den 14. März 2016.
Référence de publication: 2016079275/13.
(160044913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Donald SPV E S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 164.765.
Mit Datum 1. Januar 2016 ändert sich die Anschrift von Stuart Hanbury, Gérant de classe B, auf 55 St. James's Street,
SW1A 1LA London, Grossbritanien.
Im Februar 2016 hat die Stadt Luxembourg beschlossen, die Addresse von 7a, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
in 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg zu ändern.
Luxembourg, den 14. März 2016.
Référence de publication: 2016079276/13.
(160044912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
DBIT, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 46.585.
<i>Assemblée générale extraordinaire tenue en date du 11 mai 2015i>
Révocation de Madame Joëlle LERUTH en qualité d’administrateur.
Nomination de la SPRL LOPAKICK ayant son siège social à B-1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, avenue des Cy-
clistes, 39, représentée par M. Jean-Patrick RAEMDONCK VAN MEGRODE demeurant à B-1150 WOLUWE-SAINT-
PIERRE, Avenue des Cyclistes, 39 avec effet au 16 mars 2015. Son mandat expirera après l’Assemblée générale ordinaire
tenue en l’an 2020.
Référence de publication: 2016079283/13.
(160044779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
De Jonge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9632 Alscheid, 20, Um Bëchel.
R.C.S. Luxembourg B 100.318.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafter der Firma «De Jonge S.à r.l.» Abgehalten am 15. Dezember 2015 um 10.00i>
<i>Uhr in Alscheidi>
Die Anwesenden nehmen die Rücktritterklärung des Geschäftsführers Reinald DE JONGE an.
Frau Jacqueline HORSMANS geboren am 26. Oktober 1964 in Gilze en Rijen (NL) und wohnhaft in L-9632 Alscheid,
20 um Bëchel wird zur neuen technische Geschäftsführerin für unbestimmte Dauer genannt. Sie kann die Gesellschaft
durch ihre alleinige Unterschrift verpflichten.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Die Gesellschafteri>
Référence de publication: 2016079285/15.
(160045040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
70852
L
U X E M B O U R G
De Roude Leif S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 51, rue de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 141.196.
Suite à une assemblée générale extraordinaire, signée par les détenteurs des parts sociales en date du 30 novembre 2015
il résulte les changements comme suit:
1. Changement de gérant:
Monsieur Sergio Manuel PINTO NOGUEIRA, serveur, né le 2 février 1973 à Peso da Regua (Portugal), demeurant à
L-2222 Luxembourg, 40, rue de Neudorf, démissionne de son poste de gérant technique de la société.
Bertrange, le 30 novembre 2015.
Référence de publication: 2016079286/13.
(160044897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
EFR Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1141 Luxembourg, 103, Bei der Härewiss.
R.C.S. Luxembourg B 4.427.
<i>Extrait d'une résolution par écrit prise le 23 février 2016i>
Il résulte desdites décisions que:
- L'associé unique décide à l'unanimité de nommer comme commissaire Ernst & Young, Reviseurs d'entreprises, dont
le siège social est situé 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, représenté par monsieur Yves Even, reviseur d'en-
treprises pour l'exercice 2015. La durée du mandat est d'un an et prend fin à l'assemblée générale annuelle de 2016.
Luxembourg, le 23 février 2016.
Pour extrait conforme
Rika Camilla Alice Coppens
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016079322/16.
(160044862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
COPEL S.A. Société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 138.184.
Par la présente, je me permets de vous informer que je démissionne en tant que administrateur de la société de droit
luxembourgeois Copel SA Société de gestion de patrimoine familial sise à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, avec
effet à ce jour.
Luxembourg, le 16 février 2016.
Gary DENNIS.
Référence de publication: 2016079255/11.
(160045080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Faber Digital Solutions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7561 Mersch, 7, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 71.705.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 24 février 2016i>
En application des dispositions de la nouvelle loi du 28 juillet 2014 et à la demande de l'actionnaire, le Conseil d'Ad-
ministration décide de convertir les actions au porteur en actions nominatives.
Le mandat de la société FIRELUX S.A. en tant que dépositaire, avec siège social à L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F.
Kennedy, a été annulé avec effet à la même date.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2016079365/14.
(160045371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
70853
L
U X E M B O U R G
Facs SV, Société Anonyme de Titrisation.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, Place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 179.027.
<i>Extrait des résolutions du conseil d'administration prises en date du 4 Mars 2016i>
Ont démissionné du conseil d'administration avec date d'effet au 29 Février 2016:
- Monsieur Victor Decrion, Administrateur A, né le 04/05/1976 à Paris (France), résidant professionnellement au 23 bis
Avenue de Messine, F-75008 Paris
- Monsieur Christophe Blanche, Administrateur B, né le 27/04/1974 à Pantin (France), résidant professionnellement au
1 Place d'Armes, L-1136 Luxembourg
A été nommé Administrateur B à compter du 29 Février 2016 et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année
2019 Monsieur Marc-Antoine Levallois, né le 22 Août 1983 à Arras (France), résidant professionnellement au 1 Place
d'Armes, L-1136 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
FACS SV
Référence de publication: 2016079368/19.
(160045730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Fell-Systemhaus-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5447 Schwebsange, 111, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 124.214.
<i>Gesellschafterbeschluss der Fell-Systemhaus-Lux S.à r.l.i>
Der unterzeichnende Axel Fell ist alleiniger Gesellschafter der Fell-Systemhaus-Lux S.à r.l., eingetragen im Handels-
register Luxemburg (RCS) unter der Handelsregisternummer B124214.
Unter Verzicht auf alle Fristen und Formen für die Einberufung und die Abhaltung einer Gesellschafterversammlung
halte ich hiermit eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab und beschließe mit sofortiger Wirkung:
Die Bestellung von Herrn André Märker, geboren am 23.02.1973, wohnhaft: Auf der Oberen Liss 7 in 66636 Tholey,
zum zweiten Geschäftsführer. Als solcher ist er alleine zur Vertretung der Gesellschaft befugt.
Schwebsange, den 16.02.2016 / Den 1.3.2016.
Fell-Systemhaus-Lux S. àr.l.
111 route du vin L-5447 SCHWEBSANGE
Référence de publication: 2016079371/17.
(160045653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Financial Development S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 59.518.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale a
déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme FINANCIAL DEVELOPMENT
S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59518, dont le siège social à
L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, a été dénoncé en date du 12 novembre 2008.
Ce même jugement a ordonné la publication du dispositif par extrait au Mémorial. Il a également mis les frais à charge
du Trésor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Maître Hanan GANA-MOUDACHE
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016079373/18.
(160045710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
70854
L
U X E M B O U R G
FM Transac SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 61-63, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 117.748.
Dépôt à rectifier: numéro de dépôt L1500144262 du 10/03/2015
<i>Extrait du procès-verbal du 05/03/2015 à 10hi>
Selon le procès-verbal des résolutions prises par le conseil d'administration de la société F.M. TRANSAC S.A. en date
du 05/03/2015, il a été décidé le point suivant:
1. Décision de nommer comme dépositaire en vertu de l'article premier de la loi du 28 Juillet 2014, relative à l'immo-
bilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur
et portant modification, la Fiduciaire GL SARL, inscrite au registre de Commerce Luxembourg sous le numéro B 123 133 ,
avec siège social au 10 Rue de la Libération L-3510 DUDELANGE.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et demeure,
les comparants ont tous signé la présente minute
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 05/03/2015.
MUNSCH Pascal Thierry / MUNSCH Fabienne / MUNSCH Marine Sophie
<i>Administrateur délégué / Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2016079380/21.
(160044980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Foreveryoung Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 15.092,50.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 144.726.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 14 mars 2016 lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société FORE-i>
<i>VERYOUNG PARENT S.À R.L.i>
- Monsieur Alexandre TASKIRAN a démissionné de son mandant de gérant de la Société avec effet au 23 décembre
2015.
- Monsieur Vishal SOOKLOLL, né le 14 juin 1975 à Goodlands (Ile Maurice), demeurant au 127, rue de Mühlenbach,
L-2168 Luxembourg, a été nommé Gérant pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 2016.
FOREVERYOUNG PARENT S.À R.L.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016079383/18.
(160045195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Henderson Property Management Company (Luxembourg) No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 96.114.
<i>Extrait d'une décision prise par les Associés de la Société en date du 11 août 2015i>
Les Associés de la Société décident de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, ayant
son siège social au 2 rue Gerhard Mercator, L-1014 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B65 477, en qualité de Réviseur
d'entreprises agréé jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des Associés appelée à statuer sur les comptes annuels
de la Société au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 Mars 2016.
Référence de publication: 2016079420/15.
(160045316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
70855
L
U X E M B O U R G
Hifi Tech Holding S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 62.359.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière
commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société:
La société anonyme HIFI TECH HOLDING S.A., ayant eu son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la
Faïencerie, dénoncé en date du 19 novembre 2010, RCS n° B 62359,
Pour extrait conforme
Me Céline HENRY-CITTON
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016079430/14.
(160045433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Hod Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 165.645.
EXTRAIT
En date du 24 février 2016, le Conseil d'administration a élu à l'unanimité Monsieur Marc Koeune comme Président du
Conseil d'administration.
Signature.
Référence de publication: 2016079432/11.
(160044895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Hong Da Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4742 Pétange, 59, rue des Jardins.
R.C.S. Luxembourg B 194.851.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2016i>
Les associés adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes:
1. L'assemblée générale prend acte de la cession de parts en date du 7 mars 2016, que Monsieur Wenfei WU cède sa
totalité des 10 parts sociales aux autres associés de la société, dont 3 parts sociales à Monsieur Jinbiao WU, 3 parts sociales
à Monsieur Xiaoming WU et 4 parts sociales à Monsieur Yilang WANG, de fait que la nouvelle répartition des parts sociales
s'établit comme suit:
- Monsieur Jinbiao WU, trente-trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
- Monsieur Xiaoming WU, trente-trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
- Monsieur Yilang WANG, dix-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
- Madame Jingxia WU, quinze parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Total: Cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2. L'acceptation de la démission de Monsieur Wenfei WU, demeurant à L-6447 Echternach, 23, rue Hoovelek, de sa
fonction de gérant technique;
3. La nomination de Monsieur Yilang WANG, né le 24 mars 1991, demeurant à L-4742 Pétange, 59, rue des Jardins,
comme nouveau gérant technique pour une durée indéterminée;
4. L'assemblée générale demande de faire modifier les adresses domiciles des associés ou gérants comme suit: que
Monsieur Jinbiao WU, Monsieur Xiaoming WU, Monsieur Yilang WANG et Madame Jingxia WU, demeurant ensemble
à L-4742 Pétange, 59, rue des Jardins.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 7 mars 2016.
<i>Pour la société
i>Hong Da S.à r.l.
Référence de publication: 2016079433/29.
(160045214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
70856
L
U X E M B O U R G
Horses Trucks Import S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 122.478.
Dépôt à rectifier: numéro de dépôt L 150035985 du 10/02/2015
<i>Extrait du procès-verbal du 10/02/2015 à 10hi>
Selon le procès-verbal des résolutions prises par l'administrateur unique de la société HORSES TRUCKS IMPORT S.A.
en date du 10/02/2015, il a été décidé le point suivant:
1. Décision de nommer comme dépositaire en vertu de l'article premier de la loi du 28 Juillet 2014, relative à l'immo-
bilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur
et portant modification, la Fiduciaire GL SARL, inscrite au registre de Commerce Luxembourg sous le numéro B 123 133,
avec siège social au 10 Rue de la Libération L-3510 DUDELANGE.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et demeure,
les comparants ont tous signé la présente minute
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 10/02/2015.
Mr Jacques GRANDMONTAGNE
<i>Administrateur Uniquei>
Référence de publication: 2016079435/21.
(160044979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
HPL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 155.537.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique du 14 mars 2016 que:
- la nomination de Monsieur Stéphane Allart, expert-comptable, né le 19 février 1981 à B -Uccle, demeurant profes-
sionnellement au 45 Avenue de la Liberté, L - 1931 Luxembourg, et de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, né le
21 novembre 1961 à B - Etterbeek, demeurant professionnellement au 45 Avenue de la Liberté, L - 1931 Luxembourg en
tant qu'Administrateurs supplémentaires de la société est approuvée avec effet immédiat. Leur mandat viendra à échéance
lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.
- conformément à l'article 13.1 des statuts, la société sera engagée en toutes circonstances à l'égard des tiers seulement
par la signature conjointe de deux Administrateurs de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg.
Référence de publication: 2016079437/19.
(160045162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
EMI Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 195.234.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires en date du 26 février 2016 que la société
FIN-CONTRÔLE S.A., société anonyme, ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enre-
gistrée auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, numéro 42230 a démissionnée de son
mandat de commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2016.
Référence de publication: 2016079329/14.
(160045495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
70857
L
U X E M B O U R G
I Like Events S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 133, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 145.983.
EXTRAIT
Suite à une cession de parts sociales dûment approuvée par les associés et dûment signifiée à la société, le capital social
fixé à 12.500 EUR, représenté par 500 parts sociales, entièrement souscrites et libérées, se repartit comme suit:
Madame Mireille Rahme Bley
cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Monsieur Christopher Rahme
cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
RAC Group S.à r.l.
cent soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
MORGANA S.A.
cent-vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
IKM S.A.
cent-vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Total: cinq cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2016.
I LIKE EVENTS SARL
Fiduciaire des P.M.E.
Société anonyme
Signature
Référence de publication: 2016079449/27.
(160045419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
I Want Car Lease S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 105, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 167.503.
<i>Extrait des décisions de l'actionnaire unique en date du 29 janvier 2016i>
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire unique accepte la démission de Monsieur WANT Jean-Marc comme administrateur unique avec effet au
1
er
mars 2016.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Actionnaire unique décide de nommer comme administrateur unique de la société, Monsieur Ahmed Zaïm, né le
02/07/1977 à Charleville-Mézières (France) demeurant professionnellement au 105, route d'Arlon à L-8009 Strassen à
partir du 1
er
mars 2016 pour une durée de 6 ans.
Pour extrait
La société
Référence de publication: 2016079450/17.
(160045004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Lezam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 132.649.
Par la présente, je me permets de vous informer que je démissionne en tant que administrateur de la société de droit
luxembourgeois Lezam S.A. sise à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, avec effet à ce jour.
Luxembourg, le 15 février 2016.
Barry O’Dwyer.
Référence de publication: 2016079538/10.
(160045081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
70858
L
U X E M B O U R G
Digital Services LIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 204.282.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fifth of February,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Rocket Internet SE, a European Company (Societas Europaea) with its statutory seat in Berlin, Germany, registered
with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany,
under no. HRB 165662 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany;
here represented by Magdalena Staniczek, private employee, professionally residing in Senningerberg, by virtue of a
proxy.
Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company
(société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Digital Services LIV S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at fifteen thousand euro (EUR 15,000), represented by fifteen thousand (15,000)
shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
70859
L
U X E M B O U R G
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such
approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse
or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second
time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are
validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share
capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
70860
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.
14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
70861
L
U X E M B O U R G
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if
any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and
class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
70862
L
U X E M B O U R G
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2016.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The fifteen thousand (15,000) shares issued have been subscribed by Rocket Internet SE, aforementioned, for the price
of fifteen thousand euro (EUR 15,000).
The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of fifteen thousand euro (EUR
15,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) is entirely allocated to the share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited duration:
- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
3. Any one manager of the Company, regardless of his category, and Magdalena Staniczek, is authorized to sign solely,
on behalf of the sole shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the
Company.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
70863
L
U X E M B O U R G
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechszehn, am fünfundzwanzigsten Februar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Rocket Internet SE, eine Societas Europaea bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland unter der Nummer HRB 165662 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Deutschland.
hier vertreten durch Magdalena Staniczek, Angestellte, geschäftsansässig in Senningerberg, gemäß einer Vollmacht.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert wurde,
wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit
dem Namen Digital Services LIV S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschafts Kapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) aufgeteilt in fünfzehntausend
(15.000) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
70864
L
U X E M B O U R G
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zustim-
mung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in übertragen
werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jähr-
lich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in
Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntma-
chung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit
statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in
einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die
Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,
bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten schrift-
lichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
70865
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-
punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abge-
geben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.
Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-
führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer ein anderes Mitglied des Rates der
Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore
ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen
Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
70866
L
U X E M B O U R G
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Ka-
tegorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie
B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der Kategorie
B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder
von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Katego-
rien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B),
werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens
eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii)
durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschrifts-
befugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
70867
L
U X E M B O U R G
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-
klang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-
falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise
vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von
1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung
der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an
die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2016.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die fünfzehntausend (15.000) ausgegebenen Anteile wurden durch Rocket Internet SE, vorbenannt, zum Preis von
fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) gezeichnet.
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.
Die gesamte Einlage von in Höhe von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.500,-geschätzt.
70868
L
U X E M B O U R G
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle
Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
Die folgende Person weird für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, und Magdalena Staniczek, ist er-
mächtigt, das Anteilinhaberregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für
Rechnung des alleinigen Gesellschafters zu unterzeichnen.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen Partei,
dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Namen,
Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: M. STANICZEK, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 février 2016 Relation: 1LAC/2016/6422. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 02. März 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016073977/569.
(160038187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Quattrex GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.
R.C.S. Luxembourg B 204.104.
Les statuts coordonnés au 19 février 2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 mars 2016.
Référence de publication: 2016076750/10.
(160041861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Digital Services LIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 204.280.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fifth of February,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Rocket Internet SE, a European Company (Societas Europaea) with its statutory seat in Berlin, Germany, registered
with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany,
under no. HRB 165662 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany;
here represented by Magdalena Staniczek, private employee, professionally residing in Senningerberg, by virtue of a
proxy.
70869
L
U X E M B O U R G
Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company
(société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Digital Services LIII S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at fifteen thousand euro (EUR 15,000), represented by fifteen thousand (15,000)
shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
70870
L
U X E M B O U R G
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such
approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse
or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second
time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are
validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share
capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
70871
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.
14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if
any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
70872
L
U X E M B O U R G
(namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and
class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
70873
L
U X E M B O U R G
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2016.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The fifteen thousand (15,000) shares issued have been subscribed by Rocket Internet SE, aforementioned, for the price
of fifteen thousand euro (EUR 15,000).
The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of fifteen thousand euro (EUR
15,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) is entirely allocated to the share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited duration:
- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
3. Any one manager of the Company, regardless of his category, and Magdalena Staniczek, is authorized to sign solely,
on behalf of the sole shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the
Company.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechszehn, am fünfundzwanzigsten Februar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Rocket Internet SE, eine Societas Europaea bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland unter der Nummer HRB 165662 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Deutschland.
hier vertreten durch Magdalena Staniczek, Angestellte, geschäftsansässig in Senningerberg, gemäß einer Vollmacht.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert wurde,
wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:
70874
L
U X E M B O U R G
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit
dem Namen Digital Services LIII S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschafts Kapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) aufgeteilt in fünfzehntausend
(15.000) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
70875
L
U X E M B O U R G
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zustim-
mung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in übertragen
werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jähr-
lich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in
Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntma-
chung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit
statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in
einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die
Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,
bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten schrift-
lichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
70876
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-
punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abge-
geben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.
Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-
führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer ein anderes Mitglied des Rates der
Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore
ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen
Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
70877
L
U X E M B O U R G
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Ka-
tegorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie
B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der Kategorie
B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder
von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Katego-
rien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B),
werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens
eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii)
durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschrifts-
befugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-
klang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-
falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
70878
L
U X E M B O U R G
22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise
vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von
1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung
der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an
die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2016.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die fünfzehntausend (15.000) ausgegebenen Anteile wurden durch Rocket Internet SE, vorbenannt, zum Preis von
fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) gezeichnet.
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.
Die gesamte Einlage von in Höhe von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.500,-geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle
Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
Die folgende Person weird für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, und Magdalena Staniczek, ist er-
mächtigt, das Anteilinhaberregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für
Rechnung des alleinigen Gesellschafters zu unterzeichnen.
70879
L
U X E M B O U R G
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen Partei,
dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Namen,
Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: M. STANICZEK, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 février 2016. Relation: 1LAC/2016/6421. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 02. März 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016073976/568.
(160038160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Lilux International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 1, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 109.538.
L'an deux mille seize,
le vingt-neuf février.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
s’est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblée») de la société «LILUX INTERNATIONAL
S.A.» (la «Société»), une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 11, Avenue
de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous le
numéro 109 538.
La Société fut constituée originairement sous le droit italien suivant acte reçu par Maître Francesco CANDIANI, notaire
de résidence à Mestre (Italie), le 16 septembre 1999.
Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 12 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (le «Mémorial»), numéro 1243 du 21 novembre 2005, la Société a transféré son siège social statutaire et
administratif de Padova (Italie) à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg) avec refonte complète des statuts pour
les adapter à la législation luxembourgeoise sur les sociétés à responsabilité limitée.
Les statuts de la Société furent modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié dressé en date
du 12 février 2016, en voie de publication au Mémorial.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO, juriste, avec adresse
professionnelle au 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg (le «Président»).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Angelina SCARCELLI, employée privée, avec adresse professionnelle
au 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.
L’Assemblée élit comme scrutatrice Madame Carine AGOSTINI, employée privée, avec adresse professionnelle au 11,
Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.
Le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exact par les membres du bureau de l’Assemblée, que toutes
les quatorze mille sept cents (14'700) actions ordinaires ayant une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune,
représentant l’intégralité du capital social d’UN MILLION QUATRE CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS
(1'470'000.- EUR) sont présentes ou représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée
et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurants à l’ordre du jour, ci-après reproduit, les actionnaires
représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.
Ladite liste de présence, après avoir été signée “ne varietur” par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau de l’Assemblée et par le notaire soussigné, sera annexée au présent acte pour être soumise simultanément à
l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires éventuellement représentés, signées «ne varietur» par les personnes présentes et le
notaire instrumentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l'enregistrement.
II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
70880
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des états financiers de la Société au 28 février 2016 de la Société qui sert aussi de bilan de clôture de la
Société au Luxembourg et de bilan d’ouverture en Italie.
Le premier exercice social en Italie se clôturera au 28 février 2017.
2. Transfert du siège social du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie, et adoption de la forme juridique d’une société
par actions (S.p.A.) selon le droit italien;
3. Fixation du siège social à Padova [Italie];
4. Modification de la dénomination sociale en «Lilux International S.p.A.»;
5. Démission des administrateurs actuellement en fonction et décharge à leur donner pour l’exécution de leurs mandats
jusqu’à ce jour;
6. Démission du Commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à lui donner pour l’exécution de son
mandat jusqu’à ce jour;
7. Nomination de Monsieur Dott. Alex Inti Ligabue, né à Venise (Italie), le 17 avril 1981, demeurant à Sestriere San
Marco, I-3319 Venezia (Italie), en sa qualité d’administrateur unique.
8. Nomination d’un collège de commissaires («Collegio Sindacale») composé de cinq (5) membres, dont trois perma-
nents et deux suppléants;
9. Pouvoirs à conférer à Monsieur Dott. Alex Inti Ligabue, prénommé, pour représenter la Société vis-à-vis des instances
administratives et fiscales en Italie à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant;
10. Adoption des statuts et refonte de ces mêmes statuts pour les adapter au droit italien;
11. Pouvoirs à conférer à tout employé de la société «LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.», en
abrégé «INTERCONSULT» établie et ayant son siège social au 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, pour
représenter la Société vis-à-vis des instances administratives et fiscales à Luxembourg à la suite du transfert de siège et du
changement de nationalité comme dit ci-avant et en vue d’accomplir toutes les formalités requises;
12. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé du Président et après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé
l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’approuver les états financiers de la Société arrêtée au 28 février 2016, qui sert ainsi de bilan de
clôture de la Société au Luxembourg et de bilan d’ouverture en Italie. Il est encore décidé que le premier exercice social
de la Société qui sera transférée en Italie et par conséquent soumise aux lois italiennes, se clôturera au 28 février 2017.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide à l’unanimité et en conformité avec l’article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales telle qu’amendé par la suite, de transférer le siège social de la Société en Italie, sans dissolution
préalable de la Société, laquelle continuera l’activité avec tous les actifs et passifs existants de la Société, et continuera son
existence sous la nationalité italienne.
L’Assemblée décide d’établir le siège social de la Société en Italie, à Padova. Aux seules fins de l’inscription au Registre
de Commerce de Padova, le siège social est fixé à Via Ugo Foscolo n. 8, I-35131 Padova (Italie). La Société ne maintiendra
pas de succursale ou d’autre entité juridique au Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide d’adopter les statuts d’une société par actions (S.p.A.) de droit italien et de changer ainsi la déno-
mination sociale en «Lilux International S.p.A.».
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société sous la forme juridique d’une société
par actions (S.p.A.) pour les mettre en concordance avec la législation italienne et de les arrêter en langue italienne comme
ci-après:
STATUTO SOCIALE DELLA
“Liliux International S.p.A.”
“Titolo I. Denominazione - Comune della sede attività dell’oggetto sociale - Durata
Art. 1. Denominazione.
1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione:
"Lilux International S.p.A."
70881
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Comune della sede.
2.1 La sede della Società è posta nel Comune di Padova.
2.2 È attribuita alla competenza dell’organo amministrativo, ai sensi dell’art. 2365, secondo comma, c.c., la facoltà di
trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e di istituire o sopprimere sedi secondarie.
Art. 3. Attività dell’oggetto sociale.
3.1 La Società ha il seguente oggetto sociale:
a. lo svolgimento in via principale dell’attività di assunzione e gestione di partecipazioni in altre società, consorzi, joint
ventures, GEIE, associazioni e persone giuridiche in genere ed enti, sia in Italia che all’estero, non nei confronti del pubblico
e non al fine della collocazione presso terzi, ma a titolo di stabile investimento. E’ espressamente escluso dall’attività
statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell’interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non
abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale. E’ altresì
esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata ad iscritti in albi professionali previsti dal d.lgs. 58/1998;
b. la fornitura, a livello centralizzato, di servizi in favore delle società controllate, collegate e/o partecipate, aventi ad
oggetto qualsiasi prestazione che possa risultare necessaria, utile e/o opportuna al perseguimento dell’oggetto sociale, fatte
salve le riserve di legge.
3.2 Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, la Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale,
può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile,
contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali,
personali, pegni, privilegi speciali e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore
di terzi, anche non soci, purché non risulti vietata dalle leggi vigenti e comunque non nei confronti del pubblico.
Art. 4. Durata.
4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea
straordinaria dei soci.
Titolo II. Capitale sociale - Azioni - Altri apporti
Art. 5 Capitale.
5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.470.000,00 (unmilionequattrocentosettantamila/00) suddiviso in numero 1.470.000
(unmilionequattrocentosettantamila) azioni ciascuna di valore nominale di Euro 1,00 (uno/00).
5.2 Possono essere conferiti, oltre al danaro, anche beni in natura o crediti.
5.5 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l’emissione di speciali categorie di azioni da assegnare indivi-
dualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di eventuali società controllate, per un ammontare corris-
pondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro; alla stessa compete stabilire la forma, il modo di trasferimento e i diritti
spettanti ai possessori di tali azioni.
Art. 6. Aumento e riduzione del capitale sociale.
6.1 Il capitale sociale è aumentato a pagamento, con conferimenti in denaro o di beni in natura o di crediti, o gratuitamente
ed è ridotto, nei casi e con le modalità previsti dalla legge.
Art. 7. Altri apporti dei soci.
7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta degli amministratori, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero
finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.
Titolo III. Obbligazioni
Art. 8. Emissione.
8.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti c.c., es-
clusivamente con deliberazione dell’assemblea straordinaria della Società.
Titolo IV. Partecipazioni sociali e loro circolazione recesso e riscatto
Art. 9. Comproprietà - Diritti reali e vincoli.
9.1 Nel caso di comproprietà di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante
comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c..
9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle azioni si applica l’articolo 2352 c.c..
Art. 10. Trasferimento per atto tra vivi.
10.1 In caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:
- per “trasferimento” si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito concernente o la piena proprietà o la nuda
proprietà o l’usufrutto di dette azioni (ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, la compravendita, la donazione,
70882
L
U X E M B O U R G
la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione “in blocco”, “forzata”
o “coattiva”, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d’azienda, fusione e scis-
sione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di tali partecipazioni;
- fermo restando il diritto di prelazione, in caso di costituzione di diritti reali di godimento sulla partecipazione, il diritto
di voto deve permanere in capo al socio che concede il diritto reale, a meno che tutti gli altri soci unanimi non consentano
che il voto spetti al titolare del diritto reale.
10.2 Il diritto di prelazione è escluso:
- nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci nonché del coniuge, dei parenti dell’alienante entro il terzo grado
e dei suoi affini entro il secondo grado;
- nel caso di trasferimenti a favore di società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette
al controllo della stessa società che controlla la società socia;
- nei trasferimenti finalizzati all’instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra
fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle
intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie
in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società
fiduciaria;
- nel caso di cessazione del trust, laddove la devoluzione delle azioni avvenga a favore del beneficiario designato.
10.3 Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni deve preventivamente offrirle a tutti gli altri soci,
i quali hanno il diritto di acquistarle, nei seguenti termini:
a) il socio, intenzionato al trasferimento, dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo e ad ogni socio
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto
ricevimento;
b) l’offerta deve indicare specificamente le azioni oggetto del trasferimento, la tipologia dell’atto o del negozio attraverso
il quale si intende realizzare il trasferimento medesimo, il nominativo del soggetto interessato all’acquisto e, se si tratti di
società di capitali, il nominativo dell’azionista o quotista di riferimento, il prezzo pattuito o - nelle ipotesi di trasferimento
diverso dalla cessione a titolo oneroso - il controvalore in danaro che intenderebbe ricevere in alternativa al corrispettivo
o comunque al risultato derivante dal tipo di trasferimento comunicato (ad esempio, in alternativa al bene oggetto di permuta,
alle partecipazioni conseguite con il conferimento, alla liberalità connessa alla donazione etc.), le condizioni, i tempi del
trasferimento ed ogni altro elemento significativo;
c) nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera b) ogni socio
interessato all'acquisto deve a sua volta comunicare al socio trasferente ed all’organo amministrativo, con lettera racco-
mandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, la
propria volontà incondizionata di esercitare la prelazione per le azioni offerte, precisando altresì se e quante azioni in più
intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci;
d) in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, in mancanza di diverso accordo tra questi ultimi, le
azioni offerte saranno attribuite ai medesimi, in proporzione alle rispettive partecipazioni all’intero capitale sociale;
e) qualora, pur comunicando di voler esercitare il diritto di prelazione, nel rispetto del termine di cui alla precedente
lettera c), taluno dei soci dichiari di non essere d’accordo sul prezzo o sul controvalore in denaro indicato nell’offerta, il
prezzo, in mancanza di diverso accordo tra le parti, sarà determinato da un arbitratore nominato dal presidente del Tribunale
di Venezia su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della
situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti,
della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione
ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. Gli oneri per l'arbitraggio saranno a carico del socio che
intende trasferire la partecipazione, se il prezzo/controvalore stabilito dall’arbitratore risulterà inferiore a quello proposto
nell'offerta; in caso diverso saranno a carico degli acquirenti, in proporzione all'entità delle partecipazioni acquistate;
f) l'arbitratore dovrà comunicare la propria decisione al socio trasferente, al/i socio/i interessati ed all’organo amminis-
trativo della Società entro 30 (trenta) giorni dall’accettazione dell’incarico;
g) le azioni dovranno essere trasferite entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla
precedente lettera c) ovvero f), in caso di nomina dell’arbitratore;
h) qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il
socio cedente sarà libero di trasferire tutte le azioni offerte in vendita all’acquirente indicato nella comunicazione di cui
alla precedente lettera b) entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è scaduto il termine per la comunicazione dell’esercizio
della prelazione; in mancanza di trasferimento nel termine predetto la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;
i) nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente
non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi
e non potrà alienare le azioni con effetto verso la Società. Gli amministratori della Società saranno tenuti al rispetto delle
predette regole.
10.4 La cessione delle azioni sarà possibile, senza l’osservanza della procedura di cui al precedente articolo 10.3 qualora
il socio cedente abbia ottenuto il consenso, per lo specifico trasferimento, da parte di tutti gli altri soci.
70883
L
U X E M B O U R G
10.5 La disciplina sul trasferimento delle azioni prevista dai commi che precedono si applica altresì al trasferimento di
obbligazioni convertibili, warrants e diritti di opzione in genere.
Art. 11. Recesso.
11.1 Quando il presente statuto o la legge riconosce al socio il diritto di recesso, lo stesso, salvo diversa disposizione di
legge, può essere esercitato per tutte le azioni possedute.
11.2 Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
- la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della So-
cietà;
- la trasformazione della Società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede all’estero;
- l’eliminazione o l’introduzione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto.
11.3 Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e ss. c.c., spetterà
ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall’articolo 2497-quater c.c..
11.4 Il diritto di recesso compete ai soci in tutti gli altri casi previsti inderogabilmente dalla legge.
Art. 12. Disciplina del recesso.
12.1 Per i termini e le modalità di esercizio del recesso, per la determinazione del valore delle azioni e per il procedimento
di liquidazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater c.c., salvo il maggior termine
previsto dall’art. 34, sesto comma, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
Titolo V. Assemblee
Art. 13. Convocazione.
13.1 L'assemblea è convocata dall’organo amministrativo, dal presidente o dall’amministratore delegato, ovvero anche
da un consigliere di amministrazione, nel comune dove ha sede la Società o altrove, purché negli Stati membri dell’Unione
Europea, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.
13.2 L’avviso deve essere comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, con mezzi che garantiscano la prova
dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
13.3 In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero
capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Art. 14. Assemblea ordinaria e straordinaria.
14.1 L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
14.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale. Quando ricorrono le ipotesi di cui all’art. 2364, secondo comma, c.c., l'organo di amministrazione
può convocare l'assemblea annuale entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
14.3 L'assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l’organo amministrativo, il presidente o
l'amministratore delegato lo ritengano opportuno.
Art. 15. Intervento e rappresentanza.
15.1 Il diritto di intervenire all'assemblea e la facoltà di farsi rappresentare da altri soci o da terzi sono regolati dalle
norme di legge.
Art. 16. Presidenza e svolgimento dell’assemblea.
16.1 L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona eletta con il voto
della maggioranza dei presenti.
16.2 Il presidente è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea, o da un notaio nei casi previsti dalla legge.
16.3 E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,
mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di
parità di trattamento dei soci ed in particolare:
a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e
sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riu-
nione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-
zione;
70884
L
U X E M B O U R G
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno.
Art. 17. Quorum costitutivi e deliberativi.
17.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera sia in prima che nelle successive convocazioni con
l’intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 50,1% (cinquanta virgola uno per cento) del
capitale sociale.
17.2 L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rap-
presentino, in proprio o per delega, almeno il 50,1% (cinquanta virgola uno per cento) del capitale sociale.
Art. 18. Delibere assembleari.
18.1 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché
non intervenuti o dissenzienti.
Titolo VI. Amministrazione e rappresentanza
Art. 19. Nomina e cessazione degli amministratori.
19.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di amministratori variabile
da un minimo di tre ad un massimo di nove, ovvero da un amministratore unico, a scelta dell’assemblea.
19.2 La nomina degli amministratori spetta all'assemblea.
19.3 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e possono essere
scelti anche fra i non soci.
19.4 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare anche un solo consigliere, l'intero consiglio di amministrazione si
considera dimissionario; in tale caso gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea affinché
provveda all'integrale sostituzione dello stesso, essendo fatto loro divieto di compiere atti eccedenti la quotidiana condu-
zione della società.
19.5 Fino a deliberazione contraria dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390
c.c..
Art. 20. Compensi degli amministratori.
20.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, può essere riconos-
ciuto un compenso annuo complessivo, anche sotto forma di partecipazione agli utili, stabilito all’atto della nomina o
dall’assemblea. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da partecipazione agli utili o dall’attribuzione del
diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
20.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere
del collegio sindacale.
L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi
quelli investiti di particolari cariche.
20.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto,
da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.
Art. 21. Presidente - Vice Presidente - Segretario Delega attribuzioni.
21.1 Il consiglio di amministrazione sceglie fra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea,
e può anche eleggere ove lo ritenga opportuno un vice presidente. Il presidente ed il vice presidente sono rieleggibili.
21.2 Il consiglio può nominare un segretario il quale può essere scelto al di fuori dai suoi membri.
21.3 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad uno o più
dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
21.4 Gli organi delegati devono fornire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale le informazioni previste
dall’art. 2381, quinto comma, c.c., almeno ogni 6 (sei) mesi.
21.5 Il consiglio di amministrazione potrà nominare direttori generali, direttori e procuratori determinandone i poteri e
gli emolumenti.
Art. 22. Convocazione del consiglio di amministrazione.
22.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione nel comune dove ha sede la Società o altrove, purché in uno
degli Stati membri dell’Unione Europea, anche su richiesta del collegio sindacale ovvero anche di un solo consigliere di
amministrazione. La convocazione potrà altresì essere effettuata dall’amministratore delegato.
22.2 Le convocazioni sono effettuate con avviso da inviarsi a ciascun amministratore e a ciascun sindaco almeno 5
(cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, nei casi urgenti, almeno 1 (un) giorno prima. L’avviso può essere
redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi
il telefax e la posta elettronica.
22.3 Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza ed il voto della maggioranza degli amministratori presenti.
70885
L
U X E M B O U R G
22.4 Il consiglio è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli
amministratori ed i sindaci effettivi.
22.5 E' ammessa la possibilità che la riunione del consiglio di amministrazione si svolga con partecipanti dislocati in
più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione. All’uopo si applicano le disposizioni del presente
statuto relative all’assemblea in quanto compatibili.
Art. 23. Poteri di amministrazione - Azione di responsabilità.
23.1 La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per
l’attuazione dell’oggetto sociale.
23.2 L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis c.c., può essere
esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Per l’opposizione alla rinuncia e alla
transazione dell’azione di responsabilità di cui all’art. 2393, ultimo comma, c.c. è necessario il voto di almeno un terzo del
capitale sociale.
Art. 24. Rappresentanza.
24.1 Il potere di rappresentanza generale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all’amministratore unico
o al presidente del consiglio di amministrazione o all’amministratore delegato cui sia stata attribuita delega generale.
24.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al
precedente art. 21.5 nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina; la rappresentanza spetta
altresì ai componenti del consiglio di amministrazione forniti di specifiche deleghe, nei limiti della rispettiva delega.
Titolo VIII. Controllo
Art. 25. Collegio sindacale e revisione legale dei conti.
25.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti.
25.2 Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amminis-
trazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo.
25.3 I sindaci scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
25.4 Il compenso del collegio sindacale è stabilito dall’assemblea all’atto della nomina e per tutta la durata del mandato.
25.5 E' ammessa la possibilità che la riunione del collegio sindacale si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi,
contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione. All’uopo si applicano le disposizioni del presente statuto relative
all’assemblea in quanto compatibili.
25.6 L’attività di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale scelti
dall’assemblea tra gli iscritti nell’apposito registro, salvo che, in presenza dei requisiti stabiliti dall’art. 2409 bis c.c., la
stessa assemblea deliberi di attribuire l’incarico ai membri del collegio sindacale.
Titolo IX. Bilancio e utili
Art. 26. Esercizio sociale.
26.1 L'esercizio sociale si chiude al 28 febbraio di ogni anno.
26.2 L’organo amministrativo provvede a redigere l’inventario e il bilancio d’esercizio e convoca l’assemblea per
l’approvazione del bilancio nei modi e nei termini di legge, o in quelli maggiori che fossero ritenuti necessari ai sensi
dell'art. 14.2 del presente statuto.
Art. 27. Utili.
27.1 Gli utili risultanti dal bilancio saranno destinati secondo le delibere dell'assemblea ordinaria, dedotti, nell'ordine,
gli accantonamenti di legge e le partecipazioni agli utili spettanti agli amministratori, eventualmente stabilite dall'assemblea
medesima.
27.2 I dividendi non esatti andranno prescritti a favore della Società, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero
esigibili.
Titolo X. Scioglimento e liquidazione
Art. 28. Scioglimento e liquidazione.
28.1 In caso di scioglimento volontario o al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. o
da altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per
le deliberazioni dell’assemblea straordinaria, stabilisce:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.
In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'art. 2489 c.c..
70886
L
U X E M B O U R G
28.2 Il riparto di liquidazione potrà essere effettuato in tutto o in parte anche mediante assegnazione ai soci di quote in
natura dell’attività sociale.
28.3 La Società, con deliberazione presa con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria,
può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Ai soci
che non abbiano consentito alla revoca spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo
comma, c.c..
28.4 Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili,
anche durante la liquidazione.
Titolo XI. Disposizioni generali
Art. 29. Disposizioni Generali.
29.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se ed in
quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge
in tema di società unipersonale.
29.2 Per tutto quanto previsto non espressamente dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizione di legge
in materia.”
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs de la Société actuellement en fonction et de leur donner
décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes de la Société actuellement en fonction et de
lui donner décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer la personne suivante en sa qualité d’administrateur unique («Amministratore Unico»)
de la société soumise désormais à la loi italienne:
Dott. Alex Inti Ligabue, entrepreneur, né à Venise (Italie), le 17 avril 1981, demeurant à Sestriere San Marco, I-3319
Venezia (Italie).
L’administrateur unique restera en fonction jusqu’à l'approbation des états financiers au 28 février 2019.
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer un Collège des Commissaires («Collegio Sindacale») de la Société composé des cinq
(5) membres suivants:
(i) Monsieur Aldo TRAVAIN, né à Trento (Italie), le 15 janvier 1971, demeurant à Via Martiri della Libertà, 1, 35137
Padova (Italie), Codice Fiscale: TRV LDA 71A15 L378G, Président de Collège des Commissaires;
(ii) Monsieur Massimo Giovanni PELLANDA, né à Camposampiero (Italie), le 13 janvier 1972, demeurant à Via
Ungaretti G, 1, 35030 Selvazzano Dentro (PD) (Italie), Codice Fiscale: PLL MSM 72A13 B563F, Commissaires permanent;
(iii) Madame Marella CHIAPETTI, née à Padova (Italie), le 04 octobre 1977, demeurant à Via Tirana, 44, 35138 Padova
(Italie), Codice Fiscale: CHP MLL 77R44 G224F Commissaires permanent;
(iv) Madame Inge BISINELLA, née à Marostica (Italie), le 10 août 1973, demeurant à Via Rea, 38, 36020 Pove de
Grappa (Italie), Codice Fiscale: BSN NGI 73M50 E970V commissaires suppléants et
(v) Monsieur Emanuele ARTUSO, né à Camposampiero (Italie), le 22 janvier 1981, demeurant à Via Fabris, 52, 35012
Camposampiero (PD), (Italie), commissaires suppléants.
Les membres du Collège des Commissaires resteront en fonction jusqu'à l'approbation des états financiers au 28 février
2019.
<i>Neuvième résolutioni>
L’Assemblée confère à Monsieur Emanuele ARTUSO, prénommé, tous pouvoirs en vue de l’exécution matérielle de
ce qui a été délibèrent supra. En particulier ils lui donnent mandat de procéder au dépôt auprès d’un notaire italien, de
l’ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l’apostille de la Haye le cas échéant, ainsi que
la faculté d’y apporter toute modification requise par le autorités compétentes en vue de l’inscription de la présente au
registre des firmes Italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée confère tous pouvoirs à tout employé de la société «LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING
S.A.», en abrégé «INTERCONSULT» établie et ayant son siège social au 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxem-
bourg, pour représenter la Société vis a vis des instances administratives et fiscales à Luxembourg à la suite du transfert
70887
L
U X E M B O U R G
de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant et en vue d’accomplir toutes les formalités requises, notamment
pour faire constater par-devant notaire la réalisation de la condition suspensive ci-après.
<i>Condition suspensivei>
Les résolutions ci-dessus deux (2) à dix (10) incluses sont prises sous la condition suspensive de l’inscription de la
Société auprès du Registre du Commerce de Padova en Italie auprès de toutes autorités compétentes.
<i>Confirmationi>
Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l’état patrimonial susvisé que le capital social d’UN MILLION QUATRE
CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (1'470'000.- EUR) était intégralement souscrit et entièrement libéré lors du
transfert de la Société vers l’Italie.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. CANNIZZARO di BELMONTINO, A. SCARCELLI, C. AGOSTINI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1
er
mars 2016. Relation: EAC/2016/5341. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016074190/437.
(160038674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 141.425,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 112.018.
In the year two thousand and sixteen, on the third day of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l., a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 112018 and having a share capital of
141,425 USD (the Company), incorporated on 2 November 2005 pursuant to a deed of notary Hellinckx, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations - N° 379 of 21 February 2006 and whose articles of association (the Articles) have been amended several
times and for the last time on 13
th
December 2012 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, then notary residing in
Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C -number
1206 of 23 May 2013.
THERE APPEARED:
1. WPP Luxembourg Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 90.028 and having a share capital of USD 4,914,733,590,
2. WPP Luxembourg Holdings Six S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-
porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in
L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
the number B 112.002 and having a share capital of GBP 498,950.38,
3. WPP Luxembourg Holdings Two S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-
porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in
L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
the number B 99.124 and having a share capital of USD 610,810.85,
4. WPP Luxembourg Holdings Three S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse
in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under the number B 106.206 and having a share capital of USD 10,794,458,
70888
L
U X E M B O U R G
5. WPP Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 68.213
and having a share capital of EUR 212,761,323,
6. WPP Luxembourg Beta Three S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorpo-
rated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 106.207 and having a share capital of USD 3,214,575,100,
7. WPP Luxembourg Beta Two S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 98.276 and having a share capital of USD 3,649,208,050,
8. WPP Luxembourg Holdings Seven S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse
in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under the number B 112.003 and having a share capital of GBP 2,041,243,516.45,
9. WPP Luxembourg Gamma S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 79.018 and having a share capital of USD 5,140,008,810,
10. Luxembourg Finance Holdings Six C.V., a Dutch limited partnership ("commanditaire vennootschap") with regis-
tered office at 167, Laan op Zuid, 3072 DE Rotterdam, the Netherlands, registered with the Commerical Chambre of
Rotterdam under the number 24392012,
11. WPP Luxembourg US Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-
porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in
L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
the number B 106.208 and having a share capital of USD 2,496,371,300,
12. WPP Luxembourg Gamma Five S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-
porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in
L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
the number B 108.490 and having a share capital of USD 27,134.25, and
13. WPP Luxembourg Gamma Four S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-
porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in
L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
the number B 108.491 and having a share capital of USD 25,000,
(the parties listed under items 1. to 13. above are referred to hereunder each as a Shareholder and collectively as the
Shareholders),
all hereby represented by Aisling Murphy, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of powers of
attorney given under private seal.
The powers of attorney from the Shareholders, after having been initialled ne varietur by the proxyholder acting on his
name and on his behalf and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed
with the registration authorities.
The Shareholders, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Shareholders hold all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at USD 141,425
(one hundred forty-one thousand four hundred and twenty-five Dollars of the United States of America) represented by
141,425 ordinary shares having a nominal value of USD 1 (one Dollar of the United States of America) per share each;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment to the dates of the financial year of the Company; and
3. Amendment to article 14 of the Articles in order to reflect the amendment under item (2) above.
III. that the Meeting takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the Shareholders considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which
has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:
70889
L
U X E M B O U R G
1) the financial year of the Company shall begin on the 1
st
of January rather than the 1
st
of December, and
2) the financial year of the Company shall close on the 31
st
of December of each year.
As a result thereof, the Meeting resolves that the financial year of the Company that started on the 1
st
of December
2015 has closed on the 31
st
of December 2015 rather than on the 30
th
of November 2016 as previously expected. A new
financial year has therefore started on the 1
st
of January 2016 and shall close on the 31
st
December 2016.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend and hereby amend article 14 of the Articles in order to reflect the second resolution
above, so that it shall henceforth read as follows:
" Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on 1 January and ends on 31 December of each year."
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,300.-
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is stated
that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Grand Duchy of Luxembourg on the day named at the beginning of
this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le trois février.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l., une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 112018 et ayant un capital social de 141.425 USD (la Société), constituée le 2 novembre 2005 selon un
acte de Maître Henri Hellinckx, notaire alors résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N° 379 du 21 février 2006 et dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés pour la
dernière fois le 13 décembre 2012 selon un acte de Maître Francis Kesseler, alors notaire de résidence à Esch/Alzette,
Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations- N° 1206 du 23 mai 2013.
ONT COMPARU:
1. WPP Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège
social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.028 et ayant un capital social de 4.914.733.590
USD,
2. WPP Luxembourg Holdings Six S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège
social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.002 et ayant un capital social de 498.950,38
GBP,
3. WPP Luxembourg Holdings Two S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège
social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.124 et ayant un capital social de 610.810,85
USD,
4. WPP Luxembourg Holdings Three S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son
siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.206 et ayant un capital social de 10.794.458
USD,
5. WPP Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au124,
Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.213 et ayant un capital social de 212.761.323 EUR,
6. WPP Luxembourg Beta Three S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège
social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
70890
L
U X E M B O U R G
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.207 et ayant un capital social de 3.214.575.100
USD,
7. WPP Luxembourg Beta Two S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège
social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.276 et ayant un capital social de 3.649.208.050
USD,
8. WPP Luxembourg Holdings Seven S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son
siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.003 et ayant un capital social de
2.041.243.516,45 GBP,
9. WPP Luxembourg Gamma S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social
au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.018 et ayant un capital social de 5.140.008.810 USD,
10. Luxembourg Finance Holdings Six CV, une commanditaire vennootschap ayant son siège social au 167, Laan op
Zuid, 3072 DE Rotterdam, Pays-Bas, immatriculée auprès du Registre du chambre de commerce de Rotterdam sous le
numéro de 24392012,
11. WPP Luxembourg US Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège
social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.208 et ayant un capital social de 2.496.371.300
USD,
12. WPP Luxembourg Gamma Five S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège
social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.490 et ayant un capital social de 27.134,25
USD, et
13. WPP Luxembourg Gamma Four S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège
social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108491 et ayant un capital social de 25.000 USD,
(les parties mentionnées des points 1. à 13. étant individuellement désignées comme un Associé et collectivement comme
les Associés),
toutes ci-après représentées par Mlle Aisling Murphy, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
de procurations données sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire agissant en son nom et pour son compte
et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec ledit acte auprès des autorités
compétentes.
Les Associés, représentés tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que les Associés détiennent la totalité du capital social de la Société s'élevant à 141.245 USD (cent quarante-et-un
mille deux cent quarante-cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique) représenté par 141.245 (cent quarante-et-un mille deux
cent quarante-cinq) parts sociales ordinaires de la Société, ayant une valeur nominale de 1 USD (un dollar des Etats-Unis
d’Amérique) chacune;
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société; et
3. Modification de l'article 14 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus.
III. qu'après délibération l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l’Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de
convocation, l'Associé Unique se considère comme dûment convoqué et déclare avoir parfaite connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:
1) l'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier, au lieu du 1
er
décembre, et
2) l'année sociale de la Société se termine le 31 décembre de la même année.
Par conséquent, l'Assemblée décide que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1
er
décembre 2015 s’est terminé
le 31 décembre 2015 au lieu du 30 novembre 2016 comme initialement prévu. L’année sociale de la Société qui a commencé
le 1
er
janvier 2016 se terminera dès lors le 31 décembre 2016.
70891
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessus, de sorte qu’il
aura la teneur suivante:
" Art. 14. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la
même année."
<i>Estimation des coûtsi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour
lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300.-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a
été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé en date des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: A. MURPHY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 8 février 2016. Relation: 1LAC/2016/4384. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 mars 2016.
Référence de publication: 2016074459/222.
(160038062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
CADMOS, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. Cadmos Fund Management).
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 119.883.
L'an deux mille seize, le quinze février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
l'assemblée générale (Assemblée) des actionnaires (les Actionnaires) de CADMOS FUND MANAGEMENT (la So-
ciété), une société d'investissement à capital variable organisée sous la forme d'une société anonyme, ayant son siège social
au 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, constituée par acte notarié de Maître
Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg le 2 octobre 2006, publié au Mémorial C du Recueil des Sociétés et
Associations le 18 octobre 2006. La Société est immatriculée au Registre de commerce et des Sociétés sous le numéro B
119.883. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 5
novembre 200, publié le 5 décembre 2007 au Mémorial.
L'Assemblée est ouverte à 15h15 sous la présidence de Mike Kara (le Président), résidant à Luxembourg. Le Président
désigne Arnaud Pierre, résidant à Luxembourg comme secrétaire et scrutateur de l'Assemblée (le Secrétaire et Scrutateur).
Le Président et le Secrétaire et Scrutateur sont ci-après collectivement désignés les Membres du Bureau ou le Bureau.
Le Bureau étant ainsi constitué, le Président prie le notaire d'acter que:
1. un avis de convocation a été envoyé à tous les actionnaires enregistrés dans le registre des actionnaires de la Société
par lettre recommandée le 3 février 2016;
2. les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux ressortent
d'une liste de présence, qui sera signée par les actionnaires et/ou les mandataires qui représentent les actionnaires n'étant
pas présents et les Membres du Bureau. Cette liste de présence ainsi que les procurations, après avoir été signées ne varietur
par les mandataires des actionnaires qui ne sont pas présents et par le notaire soussigné, resteront annexées aux présentes
minutes;
3. il résulte de cette liste de présence que 1'486'463 actions sans valeur nominale représentant 78,60 % du capital social
souscrit de la Société sont présentes ou dûment représentées à l'Assemblée. Les actionnaires présents ou représentés dé-
clarent avoir été dûment convoqués à, et dûment informés de l'ordre du jour de l'Assemblée. L'Assemblée est dès lors
régulièrement constituée et peut délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, indiqués ci-après; et
4. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
(a) Changement de la dénomination de la Société de «Cadmos Fund Management» à «Cadmos».
70892
L
U X E M B O U R G
(b) Modification de l'article 1 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter le changement de dénomination de
la Société de la manière suivante:
« Art. 1
er
. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d'une
société anonyme sous le régime d'une société d'investissement à capital variable sous la dénomination de CADMOS.».
(c) Pouvoir au conseil d'administration de la Société d'adapter les documents nécessaire de la Société.
Après délibération, l'Assemblée décide d'adopter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier la dénomination de la Société de «CADMOS FUND MANAGEMENT» en «CAD-
MOS».
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 1 des Statuts de la manière suivante:
« Art. 1
er
. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d'une
société anonyme sous le régime d'une société d'investissement à capital variable sous la dénomination de CADMOS.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de donner pouvoir au conseil d'administration de la Société d'adapter en conséquence le prospectus
de la Société ainsi que tous les autres documents relatifs à la Société qui requièrent d'être modifiés suite à ces résolutions.
<i>Estimation des coûtsi>
Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et frais de quelque nature que ce soit qui seront supportés par la Société
en conséquence du présent acte est estimé à environ EUR 1.200.-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête de la présente.
Et après lecture faite aux parties comparantes, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. KARA, A. PIERRE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 22 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5639. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 8 mars 2016.
Référence de publication: 2016076364/61.
(160041483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Carbolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 82.947.
L'an deux mille seize, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «CARBOLUX S.A.», une société anonyme, établie et ayant son
siège social au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 82947, suivant acte notarié en date du 11 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 28 du 7 janvier 2002 (ci-après: «la Société»). Les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 15 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 479 du 20 février 2015.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Steve GOUVEIA, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Andreia Alves, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.
70893
L
U X E M B O U R G
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution et mise en liquidation de la société;
2. Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise
en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur:
«Mayfair Trust S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège
social au, 2, Millewee, L-7257 Walferdange, R.C.S. Luxembourg numéro B 112769.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés
Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale
dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges,
hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypo-
thécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle
partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. GOUVEIA, A. ALVES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 25 février 2016. Relation: EAC/2016/4895. Reçu douze Euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016076367/60.
(160041876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Bermuda Holdco Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 34.578.752,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 161.000.
Bei der Einreichung des Antrages mit der Nr. L160010755 vom 19.01.2016 wurde ein Fehler bei der Zahl der Anteile
der Aktien der Klasse A von Vision Capital Partners VII L.P. gemacht. Die korrekte Anzahl ist 11.845.430 und nicht
11.845.530.
Zwischenzeitlich wurde am 26.01.2016 eine Kapitalerhöhung von Herrn Notar Jean Seckler durchgeführt u. das ein-
gezahlte Kapital der Aktien der Klasse A von Vision Capital Partners VII L.P. wurde um 8.213 Aktien auf 11.853.643
erhöht. Der publizierte Betrag von 11.853.743 muss daher auf 11.853.643 geändert werden.
Im Februar 2016 hat die Stadt Luxembourg beschlossen, die Addresse von 7a, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
in 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg zu ändern.
Luxembourg, den 07. März 2016.
Référence de publication: 2016076286/17.
(160041304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
70894
L
U X E M B O U R G
CCL FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 17, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 137.098.
Les statuts coordonnés au 17 février 2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 mars 2016.
Référence de publication: 2016076377/10.
(160041620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
N P C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8151 Bridel, 41, rue de Schoenfels.
R.C.S. Luxembourg B 191.359.
L'an deux mille seize, le vingt-neuf février;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
A COMPARU:
Monsieur Christophe PETRA, maître cuisinier, né à Hyères (France), le 1
er
novembre 1971, demeurant à L-8151 Bridel,
41, rue de Schoenfels.
Lequel comparant a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société à responsabilité limitée régie par lois du Grand-Duché de Luxembourg “N P C S.à r.l.”, établie et ayant
son siège social à L-8151 Bridel, 41, rue de Schoenfels, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, section B, sous le numéro 191359 (ci-après la “Société”), a été constituée le 20 octobre 2014 suivant acte reçu
par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3589 du 27 novembre
2014, et que les statuts (les “Statuts”) n’ont pas été modifiés depuis lors;
- Que le comparant est le seul associé actuel (l’“Associé unique”) de la Société et qu'il a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé unique constate et accepte la cession par Monsieur Nicolas COLL, comptable, né à Toulon (France), le 11
janvier 1988, demeurant à L-8151 Bridel, 41, rue de Schoenfels, de toutes les cent vingt-six (126) parts sociales détenues
dans la Société et représentant cent pour cent (100%) du capital social, à Monsieur Christophe PETRA, prénommé.
<i>Significationi>
Conformément à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, la Société,
dûment représentée par son gérant unique, Monsieur Nicolas COLL, prénommé, a accepté cette cession de parts sociales
et la considère comme dûment signifiée à la Société, conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois, tel que
modifié.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé unique prend acte de et accepte la démission de Monsieur Nicolas COLL de ses fonctions de gérant unique
de la Société et décide de lui accorder décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date des présentes.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé unique décide de nommer, pour une durée indéterminée, Monsieur Christophe PETRA, maître cuisinier, né
à Hyères (France), le 1
er
novembre 1971, demeurant à L-8151 Bridel, 41, rue de Schoenfels, comme nouveau gérant unique
de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé unique décide de modifier l’article 2 des Statuts, relatif à l’objet social, afin de lui donner dorénavant la teneur
suivante:
“ Art. 2. La Société a pour objet la location de matériel de cuisine et de réception, l'organisation d'événements ainsi que
l'exploitation d’un restaurant et d'un débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées. Elle pourra également fournir tous
services de consultant en restauration et tous services de traiteur et pourra procéder à l’organisation de cours de cuisine.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société peut s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise.
70895
L
U X E M B O U R G
La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.”
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit comparant
a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: C. PETRA, N. COLL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 3 mars 2016. 2LAC/2016/4740. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 7 mars 2016.
Référence de publication: 2016076705/59.
(160041633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Bornbet GmbH, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.250.000,00.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 102.241.
<i>Auszug aus dem Aufhebungsvertrag vom 16. März 2016i>
Aufgrund der Aufhebung des abgeänderten Treuhandvertrags vom 28. Juli 2015 wurden die 100 Gründeranteile der
Gesellschaft an Herr Rolf Mathias ALTER zurückübertragen.
Herr Rolf Mathias ALTER, wohnhaft in L-6419 Echternach, 36, rue de la Chapelle, geboren am 14. Februar 1939 in
Koblenz (Deutschland), hält demgemäß alle 100 Gründeranteile und 900 ordentliche Anteile der Gesellschaft.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, den 16. März 2016.
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschriften
Référence de publication: 2016079951/17.
(160046636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Borgo Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 185.141.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2016.
Référence de publication: 2016077009/10.
(160042846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Bazar International de Luxembourg, Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg F 6.024.
Les modifications des statuts coordonnés ont été déposées au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016077013/10.
(160042947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
70896
Bazar International de Luxembourg
Bermuda Holdco Lux 1 S.à r.l.
Borgo Luxembourg S.à r.l.
Bornbet GmbH
CADMOS
Cadmos Fund Management
Carbolux S.A.
CCL FINANCES S.A.
COPEL S.A. Société de gestion de patrimoine familial
DBIT
De Jonge S.à r.l.
De Roude Leif S.àr.l.
Development Portisco S.A.
Digital Services LIII S.à r.l.
Digital Services LIV S.à r.l.
Donald SPV D S.à r.l.
Donald SPV E S.à r.l.
Ebrand Services SA
EEM World S.A.
EFR Luxembourg S.à r.l.
EFR Luxembourg S.à r.l.
EMI Investments S.A.
Engineered Packaging Center S.A.
Enumdns S.A.
European Capital Private Debt S.à r.l.
European Capital UK Sme Debt S.à r.l.
Faber Digital Solutions S.A.
Facs SV
Fell-Systemhaus-Lux S.à r.l.
Financial Development S.A.
FM Transac SA
Foreveryoung Parent S.à r.l.
Henderson Property Management Company (Luxembourg) No. 1 S.à r.l.
Hifi Tech Holding S.A.
Hod Group S.A.
Hong Da Sàrl
Horses Trucks Import S.A.
HPL S.A.
I Like Events S. à r.l.
I Want Car Lease S.A.
Lezam S.A.
Lilux International S.A.
N P C S.à r.l.
Quattrex GP S.à r.l.
WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l.