logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1472

23 mai 2016

SOMMAIRE

Antargaz Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

70615

Aurexia Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

70614

Besti's S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70621

Besti's S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70621

EuroSerLux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70620

Fidelity International Real Estate Fund Euro-

zone Company 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70621

Fidelity International Real Estate Fund UK

Company 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70621

Five Rings Commodities  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70654

GCC Lux S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70620

Immobal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70620

Kaderma S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70611

Kustermann Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

70618

Kustermann (Rosenheimer) S.à r.l.  . . . . . . . . .

70615

Kustermann (TastyCo) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

70616

Kyrielle Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

70610

Länsförsäkringar Secondary PE Investments

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70611

Lanvi S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70619

Lux-Avantage Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70656

Lux-World Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70655

Maps Cologne One . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70622

Master Liffey S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70612

MGE Giunchetto Wind Park S.A.  . . . . . . . . . .

70611

Nevio S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70612

Ntree-Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70610

Oaktree (Lux.) Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70610

Oakvest Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70610

Opus (Public) Chartered Issuance S.A. . . . . . .

70612

ORESC 11 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70647

Pineapple Aarhus Residential Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70613

Pineapple Commercial 1 Holdings S.à r.l.  . . .

70613

PLVJ Partners Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

70614

Porphyrion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70614

Redevco Asian Investments S.A.  . . . . . . . . . . .

70613

Red Theatre Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

70639

Reinet Fund S.C.A., F.I.S. . . . . . . . . . . . . . . . . .

70617

Représentations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70618

SECOND INVEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70616

Sirenis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70616

SM Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70619

Sodintec Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70619

'SOMALUX' Société de Matériel Luxembour-

geoise S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70617

Spring Petroleum Investments Luxco 2 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70618

SPUERKEESS Ré S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70617

Uno S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70611

70609

L

U X E M B O U R G

Ntree-Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 4, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 145.893.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 22 février 2016

Il a été décidé:
De transférer le siège social du 23, Boulevard Charles Marx L-2130 Luxembourg au 4, Place de Paris L-2314 Luxem-

bourg, à compter du 1 

er

 mars 2016.

Ces décisions n'emportent pas de modification statutaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 Février 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016078817/14.
(160044716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Oaktree (Lux.) Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 172.546.

Suite à l'assemblée générale qui s'est tenue le 7 mars 2016, PricewaterhouseCoopers, a été réélu comme réviseur d'en-

treprises, et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2016078819/11.
(160044413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Oakvest Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 102.500,00.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 147.534.

EXTRAIT

La société a été informée du changement d'adresse des managers de la société:
- Monsieur Mark Holyoake demeurant Casa Campanilla, Apartado de correos 20280, 07816 Puig d'en valls Ibiza, Spain
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078820/12.
(160044328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Kyrielle Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 99.843.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 4 mars 2016 que:
1. La démission de Madame Sandrine Bisaro, avec effet au 12 février 2016, de son poste d'administrateur de la Société,

a été acceptée.

2. Madame Caroline Goergen, née le 9 juin 1979 à Verviers, Belgique, demeurant professionnellement au 9 allée Schef-

fer, L-2520 Luxembourg, a été nommée en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 12 février 2016 et ce jusqu'à
l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 11 mars 2016.

Référence de publication: 2016078722/17.
(160044199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

70610

L

U X E M B O U R G

Kaderma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9bis, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 169.004.

<i>Extrait de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 10 mars 2016

Démissions de Monsieur Mickaël ANTOLINOS, Grégory ANTOLINOS et Madame Johane BOUIX et de leurs postes

d'Administrateurs de la société, avec effet immédiat.

Nomination de Monsieur Alan BOUIX, né le 7 octobre 1972 à Josselin (France), demeurant au 8D, Chemin Edouard-

Tavan, 1206 Genève, Suisse. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée générale annuelle de 2019. Il pourra
engager la société par la signature conjointe de 2 administrateurs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
KADERMA S.A.

Référence de publication: 2016078716/16.
(160044321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Länsförsäkringar Secondary PE Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 187.873.

<i>Extrait des résolutions des actionnaires de la société Länsförsäkringar Secondary PE Investments S.A. du 9 mars 2016

1. Acceptation de la démission de Monsieur James Bermingham, né le 19 décembre 1972, à Sheffield, Royaume-Uni,

résidant au 7, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que Administrateur de
la Société avec effet au 11 janvier 2016,

2. Acceptation de la nomination de Madame Monica Morsch, née le 3 juin 1987 à Craiova, Roumanie, résidante au 7,

rue Lou Hemmer, 1748 Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que Administrateur de la Société avec effet au 11
janvier 2016 jusqu'au 11 janvier 2021.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2016.

Référence de publication: 2016078723/16.
(160044430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

MGE Giunchetto Wind Park S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 117.207.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 19 novembre 2015:

Monsieur Marc Koeune, administrateur, est nommé Président du Conseil d'Administration.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2016078792/11.
(160044223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Uno S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 50.477.

EXTRAIT

En date du 9 mars 2016, le Conseil d'administration a élu à l'unanimité Monsieur Marc Koeune comme Président du

Conseil d'administration.

Signature.

Référence de publication: 2016079037/11.
(160044694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

70611

L

U X E M B O U R G

Nevio S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9155 Grosbous, 31, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 30.600.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 09.03.2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale a dissous

et déclaré en état de liquidation la société à responsabilité limitée NEVIO Sàrl, établie et ayant son siège social à L-9155
Grosbous, 31 rue d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 30600

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles PETRY et liquidateur Me Claude Speicher, avocat à

la Cour, à Diekirch.

Les déclarations de créance sont à déposer au greffe du Tribunal de commerce de Diekirch endéans les 3 semaines de

la présente publication.

Pour extrait conforme
Me Claude SPEICHER
<i>Le liquidateur / Avocat à la Cour

Référence de publication: 2016078813/18.
(160044249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Opus (Public) Chartered Issuance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 199.463.

<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil d'administration de la société en date du 4 mars 2016

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société du 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724

Luxembourg, au 287-289 Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg avec effet au 29 février 2016.

À Luxembourg, le 11 mars 2016.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2016078825/14.
(160043987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Master Liffey S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 202.137.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 4 mars 2016

L'associé unique de la Société a décidé en date du 4 mars 2016:
- d'accepter la démission de Monsieur Ian Gear de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat; et
- de nommer Monsieur Mark Hatcher gérant de la Société, demeurant professionnellement au 10 New Burlington Street

W1S 3BE, Londres, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

Depuis le 4 mars 2016, le conseil de gérance de la Société se compose donc comme suit:
- Madame Damien Schuind, gérant;
- Michael Thomas, gérant;
- Monsieur Fabrice Huberty, gérant; et
- Monsieur Mark Hatcher, gérant.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Master Liffey S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016078766/22.
(160044086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

70612

L

U X E M B O U R G

Pineapple Aarhus Residential Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: DKK 93.270,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 200.654.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 4 mars 2016

L'associé unique de la Société a décidé en date du 4 mars 2016:
- d'accepter la démission de Monsieur Ian Richard Gear de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat; et
- de nommer Monsieur Mark Hatcher gérant de la S Société, demeurant professionnellement au 10 New Burlington

Street W1S 3BE, Londres, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Depuis le 4 mars 2016, le conseil de gérance de la Société se compose donc comme suit:
- Monsieur Petr Klimo, gérant;
- Monsieur Peter Dickinson, gérant; et
- Monsieur Mark Hatcher, gérant.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Pineapple Aarhus Residential Holdings S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016078837/21.
(160044084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Pineapple Commercial 1 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: DKK 93.270,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 200.656.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 4 mars 2016

L'associé unique de la Société a décidé en date du 4 mars 2016:
- d'accepter la démission de Monsieur Ian Richard Gear de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat; et
- de nommer Monsieur Mark Hatcher gérant de la Société, demeurant professionnellement au 10 New Burlington Street

W1S 3BE, Londres, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Depuis le 4 mars 2016, le conseil de gérance de la Société se compose donc comme suit:
- Monsieur Petr Klimo, gérant;
- Monsieur Peter Dickinson, gérant; et
- Monsieur Mark Hatcher, gérant.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Pineapple Commercial 1 Holdings S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016078838/21.
(160044280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Redevco Asian Investments S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-8009 Strassen, 19/21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 101.727.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé de la Société qui s'est tenue en date

du 10 Mars 2016 au siège social que:

- L'Actionnaire unique a pris acte de la démission de Monsieur Johny Seré de sa fonction d'administrateur en date du

23 Février 2016.

Référence de publication: 2016078897/12.
(160044455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

70613

L

U X E M B O U R G

PLVJ Partners Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 165.664.

EXTRAIT

Il  résulte  du  contrat  de  cession  de  parts  sociales  du  29  janvier  2016,  que  Messieurs  Paul  ARENT,  Lucien-Florent

CIPOLLONE, Jean-François JOACHIM et John Viktor BERGSTRÖM ont cédé toutes les parts sociales qu'ils détenaient
dans la Société à:

- HABIO HOLDINGS, société anonyme, dont le siège social se situe au 92, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg

et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B174308.

Il résulte des contrats de cession de parts sociales du 30 janvier 2016, que HABIO HOLDINGS, associé unique, a cédé

6,200 parts sociales qu'il détenaient dans la Société comme suit:

- 5,828 parts sociales à Monsieur Jonathan BASSE demeurant au 138, route d'Arlon, B-6780 Messancy, Belgique;
- 372 parts sociales à Madame Noémie RIEFOLO demeurant au 138, route d'Arlon, B-6780 Messancy, Belgique.
L'assemblée générale extraordinaire des associés du 2 février 2016 a pris note de la démission de Monsieur Paul ARENT

de ses fonctions de gérant de la Société, avec effet au 12 février 2016, et a nommé comme nouveau gérant, avec effet au
12 février 2016 et pour une durée indéterminée:

- Madame Noémie RIEFOLO demeurant au 138, route d'Arlon, B-6780 Messancy, Belgique.

Luxembourg, le 10 mars 2016.

<i>Pour PLVJ PARTNERS LUXEMBOURG
Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2016078862/25.
(160044553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Porphyrion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 169.131.

Suite à l'Assemblée Générale du 07 mars 2016, M. Frode Aschim, entrepreneur né le 10 janvier 1974 à Oslo (Norvège)

et demeurant 10 Cedar Parks Gardens à Londres SW19 4TE (Royaume-Uni) et M. John Richard Shaw né le 13 septembre
1949 à Beckenham (Royaume-Uni) et demeurant Garden Flat, 4 Camden Terrace à Londres NW1 9BP ont été nommés en
qualité d'administrateurs de la société pour un terme expirant à la date de l'assemblée générale ordinaire de 2022.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 mars 2016.

<i>Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2016078864/14.
(160044174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Aurexia Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 4, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 197.317.

<i>Extrait de la résolution des associés de la société adoptée le 22 septembre 2015

<i>Résolution unique

Le mandat de gérant de catégorie B exercé par Monsieur François Baratte prend fin le 31 mai 2015. Il est remplacé à

partir du 1 

er

 Juin 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016, par la société FBA Conseil S.à.r.l. une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 4 rue de Bragance, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 193.714, représentée par Monsieur François Baratte, en sa qualité de gérant
unique, demeurant 4 rue de Bragance L-1255 Luxembourg.

Référence de publication: 2016079130/15.
(160045703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

70614

L

U X E M B O U R G

Antargaz Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 7, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 66.186.

Il résulte du PV de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires en date du 11 février 2016 ainsi que des résolutions

des actionnaires et des résolutions du conseil d'administration en date du 1 

er

 mars 2016 de Antargaz Luxembourg S.A.,

que:

1. Monsieur Georges Sciberras a démissionné de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 1 

er

 mars 2016;

2. Monsieur Mathieu Baquet, né le 10 janvier 1979 à Anderlecht (Belgique), résidant à Dr J. Appelmanslaan 59, 1700

Dilbeek, Belgique, est nommé administrateur de la Société à partir du 1 

er

 mars 2016 jusqu'à l'assemblée générale qui se

tiendra en 2022;

3. Monsieur Kristof Laenen, né le 9 avril 1971 à Mechelen (Belgique), résidant à Isabellalei 149, 2018 Anvers (Belgique)

est nommé administrateur de la Société à partir du 1 

er

 mars 2016 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2022;

4. Monsieur Lieven Busschaert, né le 24 août 1954 à Kortrijk (Belgique), résidant à Oudburgweg 69, 9830 Laethem-

Saint-Martin (Belgique) est nommé délégué à la gestion journalière de la Société à partir du 1 

er

 mars 2016;

5. Monsieur Guy Van Cauwenbergh a demissionné de son poste de délégué à la gestion journalière de la Société avec

effet à partir du 1 

er

 mars 2016 mais reste administrateur de la Société;

6. A partir du 1 

er

 mars 2016, le conseil d'administration de la Société est composé de:

Monsieur Eric Naddéo;
Monsieur Guy Van Cauwenbergh;
Monsieur Lieven Busschaert;
Monsieur Mathieu Baquet;
Monsieur Kristof Laenen;
7. La société Ernst &amp; Young S.A., ayant son siège social à 7 rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach (Luxembourg), est

nommé commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de la Société qui statuera sur l'exercice social se
clôturant le 30 septembre 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2016.

Rutsaert Legal
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016079125/33.
(160044759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

Kustermann (Rosenheimer) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 275.701,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 199.891.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 4 mars 2016

L'associé unique de la Société a décidé en date du 4 mars 2016:
- d'accepter la démission de Monsieur Ian Gear de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat; et
- de nommer Monsieur Mark Hatcher gérant de la Société, demeurant professionnellement au 10 New Burlington Street

W1S 3BE, Londres, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Depuis le 4 mars 2016, le conseil de gérance de la Société se compose donc comme suit:
- Madame Damien Schuind, gérant;
- Monsieur Fabrice Huberty, gérant; et
- Monsieur Mark Hatcher, gérant.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Kustermann (Rosenheimer) S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016078713/21.
(160044282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

70615

L

U X E M B O U R G

Kustermann (TastyCo) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.690,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 199.894.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 4 mars 2016

L'associé unique de la Société a décidé en date du 4 mars 2016:
- d'accepter la démission de Monsieur Ian Gear de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat; et
- de nommer Monsieur Mark Hatcher gérant de la Société, demeurant professionnellement au 10 New Burlington Street

W1S 3BE, Londres, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

Depuis le 4 mars 2016, le conseil de gérance de la Société se compose donc comme suit:
- Madame Damien Schuind, gérant;
- Monsieur Fabrice Huberty, gérant; et
- Monsieur Mark Hatcher, gérant.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Kustermann (TastyCo) S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016078714/21.
(160044191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

SECOND INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11b, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 188.081.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société anonyme SECOND INVEST qui s'est tenue

<i>en date du 15 février 2016

Il a été décidé ce qui suit:
- après délibération, le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Nicolas Hamel en sa qualité

d'Administrateur de la Société et décide de coopter en remplacement Madame Marie-Aleth Hendessi, Avocat à la Cour,
demeurant professionnellement au 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

Le mandat du nouvel Administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2019.
Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:
Madame Alexandra Corre, IKKS INVEST, société par actions simplifiée, ayant pour représentant permanent Monsieur

Pierre-André Cauche et Madame Marie-Aleth Hendessi.

Extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2016078959/20.
(160044024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Sirenis S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 197.001,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 114.234.

- L'adresse de l'administrateur Jacques Abelac est désormais sise au 129, rue Laurent Ménager, L-2143 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 March 2016.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016078965/13.
(160044378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

70616

L

U X E M B O U R G

'SOMALUX' Société de Matériel Luxembourgeoise S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine

Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 4.523.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 10 mars 2016

- FIN-CONTROLE S.A., Commissaire aux comptes, avec siège social au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

est élu en qualité de Commissaire aux comptes pour une durée d'un an, son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée
Générale Statutaire de l'an 2017.

Fait à Luxembourg, le 10 mars 2016.

Certifié sincère et conforme
«SOMALUX» SOCIETE DE MATERIEL LUXEMBOURGEOISE S.A., SPF
Société Anonyme

Référence de publication: 2016078978/16.
(160043797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

SPUERKEESS Ré S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2954 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 164.465.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mars 2016 tenue au siège administratif de la société

<i>74, rue de Merl L-2146 Luxembourg

- L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants:
M. Michel BIREL, Administrateur,
M. Jean-Claude FINCK, Administrateur
M. Gilbert ERNST, Administratrice
M. Guy ROSSELJONG, Administratrice
Mme Françoise THOMA, Administrateur
Mme Michèle FOHL, Administrateur
Leurs mandats expireront à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2017 qui aura à statuer sur les comptes de

l'exercice social de 2016.

- L'Assemblée nomme PricewaterhouseCoopers Sàr.l. 2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg comme réviseur

d'entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2017 et qui aura à
statuer sur les comptes de l'exercice de 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016078980/25.
(160044241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Reinet Fund S.C.A., F.I.S., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 141.613.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Collège des Commissaires du 8 mars 2016

Le Collège des Commissaires a pris note du décès de Monsieur Peter KAUL en date du 22 février 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2016.

Certifié conforme à l'original

Référence de publication: 2016078900/13.
(160043930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

70617

L

U X E M B O U R G

Représentations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 57.784.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 31/12/2015

Renouvellement des mandats des administrateurs, de l'administrateur - délégué et du commissaire aux comptes jusqu'à

l'assemblée générale de l'an 2019.

<i>Conseil d'Administration / Gérance

- Monsieur Christian MAROLDT, administrateur-délégué, demeurant à L-5828 Fentange, 17, rue Gewaennchen
- Monsieur Marc F. DECKER, demeurant à L-4243 Esch/Alzette, 115, rue Jean-Pierre Michels.
- Monsieur Laurent DECKER demeurant à L-4024 Esch/Alzette, rue de Belval

<i>Commissaire aux comptes

- LUX-FIDUCIAIRE Consulting SARL, avec siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste. Zithe.
Référence de publication: 2016078905/16.
(160044570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Spring Petroleum Investments Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 154.476.

<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 10 mars 2016

1. M. Sami HAJJEM a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B avec effet au 29 janvier 2016.
2. Ms. Séverine BARROIS, administratrice de sociétés, née à Metz (France), le 28 avril 1977, demeurant profession-

nellement au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg a été nommée comme gérante de catégorie B, avec effet immédiat
et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 11 mars 2016.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Spring Petroleum Investments Luxco 2 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2016078944/17.
(160043754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Kustermann Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 199.885.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 4 mars 2016

L'associé unique de la Société a décidé en date du 4 mars 2016:
- d'accepter la démission de Monsieur Ian Gear de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat; et
- de nommer Monsieur Mark Hatcher gérant de la Société, demeurant professionnellement au 10 New Burlington Street

W1S 3BE, Londres, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

Depuis le 4 mars 2016, le conseil de gérance de la Société se compose donc comme suit:
- Madame Damien Schuind, gérant;
- Monsieur Fabrice Huberty, gérant; et
- Monsieur Mark Hatcher, gérant.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Kustermann Holdings S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016078715/21.
(160044192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

70618

L

U X E M B O U R G

SM Lux S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 104.568.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugements du 16 juin 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a

ordonné en vertu des articles 203 et 203-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution
et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme SM LUX S.A., dont le siège social à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, a été dénoncé en date

du 18 juillet 2008, RC no B 104568;

Ledit jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, et liquidateur Maître Nadia JANAKOVIC, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 07 juillet 2011 au greffe de la 6 

ème

 chambre

du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Pour extrait conforme
Maître Nadia JANAKOVIC
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2016078967/19.
(160044501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Sodintec Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 38.152.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 21 mai 2015.

Madame Nadine LAMBALLAIS, née le 1 

er

 janvier 1972 à Thionville (France), adresse professionnelle au 3, avenue

Pasteur, L-2311 Luxembourg, est nommée représentant permanent pour la société FMS SERVICES S.A.

<i>Pour la société
SODINTEC FINANCES S.A.

Référence de publication: 2016078971/12.
(160043884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Lanvi S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 83.037.537,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 117.157.

<i>Extrait de l'assemblée générale des associés de la Société tenue à Luxembourg le 23 décembre 2015

L'Assemblée a décidé d'approuver et de ratifier la cession (i) de 808.129 parts sociales A1 et 1.799.793 parts sociales

B1 par l'associé unique de la Société à Travis Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
dont le siège social se situe au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152281 et (ii) de 808.129 parts sociales A1 et 1.799.793 parts sociales
B1 par Travis Investment S.à r.l. à Lhold S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège
social se situe au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 203.656 toutes deux intervenues le 15 décembre 2015.

L'Assemblée a pris acte qu'en conséquence des cessions ci-dessus, les parts sociales sont détenues comme suit:
- Lhold S.à r.l.: 808.129 parts sociales A1 et 1.799.793 parts sociales B1; et
- ABN Amro Bank (Luxembourg) S.A.: 526.735 parts sociales A2, 526.735 parts sociales A3, 526.735 parts sociales

A4, 1.896 parts sociales B2, 1.896 parts sociales B3 et 1.896 parts sociales B4.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Lanvi S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2016078728/23.
(160044609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

70619

L

U X E M B O U R G

GCC Lux S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.400,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 136.843.

EXTRAIT

En date du 9 mars 2016, lors d'une assemblée générale ordinaire, les résolutions suivantes ont été prises:
- Acceptation de la démission de Mario Curcio comme gérant de classe A de la société avec effet au 15 décembre 2015;
- Nomination au poste de gérant de classe A de Benoit Caillaud, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen,

L-2540 Luxembourg, avec effet au 15 décembre 2015 pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 11 mars 2016.

Référence de publication: 2016079398/15.
(160045196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

Immobal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 101.331.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg,

<i>le 1 

<i>er

<i> mars 2016

Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur REGGIORI Robert et Monsieur VEGAS-PIERONI Louis sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur DE BErNARDI Alexis est renommé Président du Conseil
d'administration. Monsieur DONATI Régis est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats
viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2019.

Pour extrait sincère et conforme
IMMOBAL S.A.

Référence de publication: 2016079462/15.
(160044885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

E.S.L., EuroSerLux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 106.950.

EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire tenue le lundi 15 juin 2015 à Rodange que:
- Les mandats des administrateurs ont été reconduits. Occupent les fonctions d'administrateurs à l'issue de cette assemblée

générale:

* Madame Catherine Van Roey, née à Bruxelles (Belgique) le 25/09/1960, demeurant à B-1180 Uccle, chaussée Saint-

Job, 695,

* Monsieur Eric Crochelet, né à Ixelles (Belgique) le 19/09/1960, demeurant à B-1180 Uccle, chaussée Saint-Job, 695,
* Monsieur Gilles Léonard, né à Charleroi (Belgique) le 12/06/1978, demeurant à B-6530 Thuin, chemin de Walcourt,

4.

- La société EMAXAME-EUROPEAN MANAGEMENT AGENCY S.A., société anonyme ayant son siège social à

L-4831 Rodange, route de Longwy, 146, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 64.393, a été reconduite à la fonction de
commissaire aux comptes.

- Monsieur Eric CROCHELET a été nommé président du conseil d'administration et administrateur-délégué.
Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire 2021.

Rodange, le 15 juin 2015.

Eric Crochelet
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2016079315/24.
(160045223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

70620

L

U X E M B O U R G

Fidelity International Real Estate Fund Eurozone Company 2, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 129.344.

Il est à noter que:
a) M. Timothy Fenwick réside désormais professionnellement au 32-A, rue de Saeul, L-8189 Kopstal;
b) le mandat en tant que gérant de Mme Nicola Morse a expiré à la fin de l'assemblée générale de la Société pour l'année

2015 qui s'est tenue le 18 décembre 2015 et n'a pas été renouvelé;

c) le code postal du siège social de la Société est le L-1246, de sorte que l'adresse de son siège social est:
2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2016079353/16.
(160045019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

Fidelity International Real Estate Fund UK Company 2, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 164.030.

Il est à noter que:
a) M. Timothy Fenwick réside désormais professionnellement au 32-A, rue de Saeul, L-8189 Kopstal;
b) le mandat en tant que gérant de Mme Nicola Morse a expiré à la fin de l'assemblée générale de la Société pour l'année

2015 qui s'est tenue le 18 décembre 2015 et n'a pas été renouvelé;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2016079354/14.
(160045028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

Besti's S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 185.197.

Par la présente, nous vous informons de notre démission du poste d'Administrateur de la Société.
Ma démission prendra effet le 10 mars 2016

Luxembourg, le 10 mars 2016.

CL Management S.A.
Signatures

Référence de publication: 2016079203/12.
(160045526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

Besti's S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 185.197.

Par la présente, nous vous informons de notre démission du poste de Commissaire aux comptes de la Société.
Notre démission prendra effet le 10 mars 2016.

Luxembourg, le 10 mars 2016.

C.A.S. SERVICES S.A.
Signatures

Référence de publication: 2016079204/12.
(160045526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

70621

L

U X E M B O U R G

Maps Cologne One, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 200.872.

In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth day of February.
Before the undersigned, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (hereinafter the “Meeting”) of Maps Cologne One (hereinafter the

“Company”), a société anonyme existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 200.872, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Marc Loesch, notary residing in
Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, on 16 October 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n° 3371 on 17 December 2015. The articles of association were amended for the last time pursuant to a
deed of the undersigned notary, on 16 November 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n° 329 on 5 February 2016.

The meeting begins at 10.45 a.m. with Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Mondorf-les-Bains, Grand-

Duchy of Luxembourg, being in the chair (the “Chairman”).

The Chairman appoints as secretary of the Meeting Mrs Brigitte Wahl, with professional address in Mondorf-les-Bains,

Grand-Duchy of Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Karola Böhm, with professional address in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of

Luxembourg.

The shareholder(s) present or represented, the proxies of the represented shareholder(s) and the number of their shares

are shown on an attendance list which, signed by the shareholder(s) present, the proxyholder of the represented shareholder
(s), the board of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with
the registration authorities.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

The Chairman then states that the shareholder(s) of the Company, representing the total share capital and having waived

any notice requirement, being duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may validly
deliberate, hereby requires the notary to enact the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to create mandatory redeemable preferred shares (the “MRPS”) in the share capital of the Company

which shall have the rights and obligations set out in the amended articles of association of the Company.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase the Company’s share capital by an amount of sixteen million nine hundred twenty

thousand one hundred seventy-six euro (EUR 16,920,176.-) from its current amount of four hundred seventy-nine thousand
euro (EUR 479,000,-) represented by hundred seventy-nine thousand (479,000) shares with a nominal value of one euro
(EUR  1,-)  each,  up  to  seventeen  million  three  hundred  ninety-nine  thousand  one  hundred  seventy-six  euro  (EUR
17,399,176.-) through the issue of eight million two hundred twenty thousand five hundred eighty-eight (8,220,588) ordi-
nary shares and eight million six hundred ninety-nine thousand five hundred eighty-eight (8,699,588) MRPS, each with a
nominal value of one euro (EUR 1,-).

The eight million two hundred twenty thousand five hundred eighty-eight (8,220,588) new ordinary shares and eight

million six hundred ninety-nine thousand five hundred eighty-eight (8,699,588) new MRPS issued have been entirely
subscribed by the sole shareholder of the Company, represented as stated above, for the price of one hundred sixty-nine
million four hundred eighty thousand seven hundred fifty euro (EUR 169,480,750.-).

The ordinary shares and MRPS so subscribed have been fully paid-up by the sole shareholder of the Company afore-

mentioned, through a contribution in cash consisting of one hundred sixty-nine million four hundred eighty thousand seven
hundred fifty euro (EUR 169,480,750.-) so that the amount of one hundred sixty-nine million four hundred eighty thousand
seven  hundred  fifty  euro  (EUR  169,480,750.-)  is  as  of  now  available  to  the  Company,  as  it  has  been  justified  to  the
undersigned notary.

The total cash contribution in the amount of one hundred sixty-nine million four hundred eighty thousand seven hundred

fifty euro (EUR 169,480,750.-) shall be allocated as follows:

- eight million two hundred twenty thousand five hundred eighty-eight euro (EUR 8,220,588.-) shall be allocated to the

ordinary shares of the Company;

- thirteen million three hundred sixty-seven thousand one hundred seventy-five euro (EUR 13,367,175.-) shall be allo-

cated to the share premium attached to the ordinary shares of the Company;

70622

L

U X E M B O U R G

- eight million six hundred ninety-nine thousand five hundred eighty-eight euro (EUR 8,699,588.-) shall be allocated to

the MRPS; and

- one thirty-nine million one hundred ninety-three thousand three hundred ninety-nine euro (EUR 139,193,399.-) shall

be allocated to the share premium attached to the MRPS.

<i>Third resolution

The Meeting further resolves that the aggregate amount of one million seven hundred thirty-nine thousand nine hundred

eighteen euro (EUR 1,739,918.-) shall be entirely allocated to the legal reserves, out of (i) for a portion of eight hundred
sixty-nine thousand nine hundred fifty-nine euro (EUR 869,959), the share premium attached to the ordinary shares of the
Company and (ii) for a portion of eight hundred sixty-nine thousand nine hundred fifty-nine euro (EUR 869,959), the share
premium attached to the MRPS.

The legal reserve account of the Company shall thus be credited with an amount of one million three hundred eighty-

nine thousand nine hundred eighteen euro (EUR 1,739,918.-).

<i>Fourth resolution

As a consequence of the precedent resolutions, the Meeting resolves to entirely restate the articles of association of the

Company, which shall henceforth read as follows:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a public limited company (société anonyme) under the name Maps Cologne

One (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies,
as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1. The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2. The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds

a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3. The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities

or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4. An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies,
the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate
properties.

2.5. The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2. It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of Shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of directors.

It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of Shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of directors.

4.4 In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The Company's share capital is set at seventeen million three hundred ninety-nine thousand one hundred seventy-

six euro (EUR 17,399,176.-), represented by (i) eight million six hundred ninety-nine thousand five hundred eighty-eight

70623

L

U X E M B O U R G

(8,699,588) ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the “Ordinary Shares”), and (ii) eight million
six hundred ninety-nine thousand five hundred eighty-eight (8,699,588) non-voting mandatory redeemable preferred shares
with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the “MRPS” and the “Ordinary Shares”, hereinafter collectively referred
to as the “Shares”). Each holder of Ordinary Shares is hereinafter referred to as an “Ordinary Shareholder”, each holder of
“MRPS” is hereinafter referred to as a “MRPS Holder”, and MRPS Holders and Ordinary Shareholders are hereinafter
collectively referred to as “Shareholders”.

5.2 Any share premium paid in relation with MRPS shall be booked in a MRPS share premium account (the “MRPS

Premium Account”), and the Company shall book in such account, in the currency in which they are effectively paid, the
amount or value of any additional capital surplus contributed by the MRPS Holders to the Company and of any amount
allocated to such MRPS Premium Account in accordance with these articles of association.

5.3 Any share premium paid in relation with Ordinary Shares shall be booked in an Ordinary Share premium account

(the “Ordinary Shares Premium Account”), and the Company shall book in such account, in the currency in which they
are effectively paid, the amount or value of any additional capital surplus contributed by the Ordinary Shareholders to the
Company and of any amount allocated to such Ordinary Shares Premium Account in accordance with these articles of
association.

5.4 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of Shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.5 Any new Shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing Shareholder(s). In case of plurality

of Shareholders, such Shares shall be offered to the Shareholders in proportion to the number of Shares held by them in
the Company’s share capital. The board of directors shall determine the period of time during which such preferential
subscription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered
letter sent to the Shareholder(s) announcing the opening of the subscription period. The general meeting of Shareholders
may  limit  or  suppress  the  preferential  subscription  right  of  the  existing  Shareholder(s)  in  the  manner  required  for  an
amendment of these articles of association.

5.6 The Company may redeem its own Shares subject to the provisions of the Law.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into Shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The Shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several Shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the Shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 No security interest (including, but not limited to, mortgages, charges (whether fixed, floating, legal or equitable),

pledges, liens or assignments by way of security) may be created by any person (including the MRPS Holders) over the
MRPS without the prior written consent of the board of directors.

Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of Shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any Shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of Shares is established
by registration in said Share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of
the relevant Shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that Share until such representative has been appointed.

7.3 The Shares are freely transferable in accordance with the provisions of the Law.
7.4 Any transfer of registered Shares shall become effective (opposable) towards the Company and third parties either

(i) through a declaration of transfer recorded in the register of Shares, signed and dated by the transferor and the transferee
or their representatives, or (ii) upon notification of a transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company.

Art. 8. Art. 9. Redemption of Shares.
8.1 The Company may redeem its own Shares to the extent permitted by these articles of association on the basis of

amounts available for distribution, in accordance with the Law and the present articles.

8.2 The Company may issue redeemable Shares in accordance with the provisions of article 49-8 of the Law.
8.3 Subject to article 8.6, all subscribed and fully paid-up MRPS shall be in whole or in part redeemable for the Re-

demption Consideration upon request of the Company in accordance with the provisions of article 49-8 of the Law and on
a pro rata basis among the Shareholders, and shall, in any case, be redeemed on the date which is ten years from the issue
date of the MRPS. The redemption shall take place pursuant to a decision of the board of directors.

8.4 Upon redemption of the MRPS, each holder of redeemed MRPS shall receive a payment in cash in an aggregate

amount equal to the nominal value of the redeemed MRPS plus the MRPS Premium Account amount related to such
redeemed MRPS and any accrued but unpaid dividends with respect to such MRPS (the Redemption Consideration).

70624

L

U X E M B O U R G

8.5 The Company may redeem its Ordinary Shares within the limits set forth by the Law. However, the redemption of

Ordinary Shares is subject to prior redemption of all the MRPS.

8.6 The redemption of the MRPS can only be made by using sums available for distribution in accordance with article

72-1 of the Law or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption.

8.7 Redeemed MRPS shall be cancelled immediately upon their redemption by the Company.
8.8 An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value, of all the Shares redeemed

must be included in a reserve which cannot be distributed to the Shareholders except in the event of a capital reduction of
the subscribed Share capital. The reserve may only be used to increase the subscribed Share capital by capitalization of
reserves. This reserve is not required in case of a redemption using the proceeds of a new issue made with a view to carry
out such redemption.

C. General meetings of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of Shareholders.
9.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of Shareholders. Any regularly constituted

general meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Company. The
general meeting of Shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of
association.

9.2 If the Company has only one Shareholder, any reference made herein to the “general meeting of Shareholders” shall

be construed as a reference to the “sole shareholder”, depending on the context and as applicable and powers conferred
upon the general meeting of Shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

Art. 10. Convening of general meetings of Shareholders.
10.1. The general meeting of Shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or,

as the case may be, by the statutory auditor(s).

10.2. It must be convened by the board of directors or the statutory auditor(s) upon written request of one or several

Shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting of
Shareholders shall be held within a period of one (1) month from the receipt of such request.

10.3. The convening notice for every general meeting of Shareholders shall contain the date, time, place and agenda of

the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and
eight (8) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper.
Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to the registered Shareholders, but no proof that this formality
has been complied with need be given. Where all the Shares are in registered form, the convening notices may be made by
registered letter only and shall be dispatched to each Shareholder by registered mail at least eight (8) days before the date
scheduled for the meeting.

10.4. If all of the Shareholders are present or represented at a general meeting of Shareholders and have waived any

convening requirements, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 11. Conduct of general meetings of Shareholders.
11.1 The annual general meeting of Shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on 10 June at 10:00 am
CET. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other
meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices.

11.2 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of Shareholders, composed of a chairman, a secretary

and a scrutineer who need neither be Shareholders, nor members of the board of directors. If all the Shareholders present
at the general meeting decide that they can control the regularity of the votes, the Shareholders may unanimously decide
to only appoint (i) a chairman and a secretary or (ii) a single person who will assume the role of the board and in such case
there is no need to appoint a scrutineer. Any reference made herein to the “board of the meeting” shall in such case be
construed as a reference to the “chairman and secretary” or, as the case may be, to the “single person who assumes the role
of the board”, depending on the context and as applicable. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of Shareholders.

11.3 An attendance list must be kept at all general meetings of Shareholders.
11.4 A Shareholder may act at any general meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing

or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even
all Shareholders.

11.5 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of

communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for
the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of
the meeting.

70625

L

U X E M B O U R G

11.6 Each Shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile

or any other means of communication to the Company’s registered office or to the address specified in the convening notice.
The Shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of
the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the Shareholders, as well as for each proposal three
boxes allowing the Shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate box.

11.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the

proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account
voting forms received prior to the general meeting to which they relate.

11.8 The board of directors may determine further conditions that must be fulfilled by the Shareholders for them to take

part in any general meeting of Shareholders.

Art. 12. Quorum and vote.
12.1 Each Ordinary Share entitles to one vote in general meetings of Shareholders.
12.2 The MRPS are non-voting Shares in accordance with articles 44 to 47 of the Law. Each MRPS entitles the holder

thereof to one vote on all specific matters upon which holders of non-voting preferred Shares have the right to vote in
accordance with article 46 of the Law.

12.3 Resolutions of the Shareholders are adopted at general meetings of the Shareholders in accordance with the Law

and for the avoidance of doubt, the MRPS Holders will only be authorized to vote, and the general meeting of the Share-
holders will then be composed of the Ordinary Shareholders and the MRPS Holders, in respect of the resolutions contained
in article 46 of the Law. The general meeting of the Shareholders has the broadest powers to adopt and ratify all acts and
operations consistent with the corporate object.

12.4 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of Sha-

reholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes
validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

Art. 13. Amendments of the articles of association. Except as otherwise provided herein, these articles of association

may be amended by a majority of at least two thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of
more than half of the Company’s Share capital is present or represented. If no quorum is reached in a meeting, a second
meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of association which may deliberate regardless of
the quorum and at which resolutions are taken at a majority of at least two thirds of the votes validly cast. Abstentions and
nil votes shall not be taken into account.

Art. 14. Change of nationality. The Shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 15. Adjournment of general meeting of Shareholders. Subject to the provisions of the Law, the board of directors

may adjourn any general meeting of Shareholders being in progress for four (4) weeks. The board of directors shall do so
at the request of Shareholders representing at least twenty percent (20%) of the share capital of the Company. In the event
of an adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of Shareholders shall be cancelled.

Art. 16. Minutes of general meetings of Shareholders.
16.1 The board of any general meeting of Shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by

the members of the board of the meeting as well as by any Shareholder upon its request.

16.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case
the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors or by any two
of its members.

D. Management

Art. 17. Composition and powers of the board of directors.
17.1 The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members, which shall at

least include one (1) class A director and two (2) class B directors. However, where the Company has been incorporated
by a single Shareholder or where it appears at a Shareholders’ meeting that all the Shares issued by the Company are held
by a sole shareholder, the Company may be managed by a sole director until the next general meeting of Shareholders
following the increase of the number of Shareholders. In such case, to the extent applicable and where the term “sole
director” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of directors” used in these
articles of association is to be construed as a reference to the “sole director”.

17.2 The board of directors is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfill the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or
by these articles of association to the general meeting of Shareholders.

Art. 18. Daily management.
18.1 The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with such daily

management may, in accordance with article 60 of the Law, be delegated to one or more directors, officers or other agents,

70626

L

U X E M B O U R G

acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the board of
directors.

18.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 19. Appointment, removal and term of office of directors.
19.1 The directors shall be appointed by the general meeting of Shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

19.2 The term of office of a director may not exceed six (6) years and each director shall hold office until a successor

is appointed. Directors may be reappointed for successive terms.

19.3 Each director is appointed by the general meeting of Shareholders at a simple majority of the votes validly cast.
19.4 Any director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of Shareholders

at a simple majority of the votes validly cast.

19.5 If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a physical person as

permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity
may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a
permanent representative of one (1) director of the Company and may not be a director of the Company at the same time.

Art. 20. Vacancy in the office of a director.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a director because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced director by the remaining directors until the next meeting of Shareholders which shall resolve on the permanent
appointment in compliance with the applicable legal provisions.

20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole director, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of Shareholders.

Art. 21. Convening meetings of the board of directors.
21.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman, or by any director. Meetings of the board of directors

shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

21.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four (24) hours at least

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient
proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of directors which has been communicated to all directors.

21.3 No prior notice shall be required in case all the members of the board of directors are present or represented at a

board meeting and waive any convening requirements or in the case of resolutions in writing approved and signed by all
members of the board of directors.

Art. 22. Conduct of meetings of the board of directors.
22.1 The board of directors shall elect among its members a chairman. It may also choose a secretary who does not need

to be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.

22.2 The chairman shall chair all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may

appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority of directors present at any such meeting.

22.3 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing,

or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient
proof thereof. A director may represent one or more, but not all of the other directors.

22.4 Meetings of the board of directors may also be held by conference call or video conference or by any other means

of communication allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

22.5 The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors, with at least one (1)

class A director and one (1) class B director, are present or represented at a meeting of the board of directors.

22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors, including at least one (1) class A director and one (1)

class B director, present or represented at such meeting. In the case of a tie, the chairman shall not have a casting vote.

22.7 Save as otherwise provided by the Law, any director who has, directly or indirectly, an interest in a transaction

submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company’s interest, must inform the board of
directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant
director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest
must be reported to the next general meeting of Shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item.

22.8 Where the Company comprises a single director, transactions made between the Company and the director having

an interest conflicting with that of the Company is only mentioned in the resolution of the sole director.

70627

L

U X E M B O U R G

22.9 The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of directors or the sole director relates

to current operations entered into under normal conditions.

22.10 The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each director may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.

Art. 23. Minutes of the meeting of the board of directors - Minutes of the decisions of the sole director.
23.1 The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

chairman pro tempore, or by one (1) class A director and one (1) class B director jointly. Copies or excerpts of such minutes
which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by one (1) class A director
and one (1) class B director jointly.

23.2 Decisions of the sole director shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole director. Copies or

excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the sole director.

Art. 24. Dealing with third parties.
24.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the signature of the sole director, or,

if the Company has several directors, by the joint signature of any one class A director together with any one class B director
or by (ii) the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such power may have been delegated by the
board of directors within the limits of such delegation.

24.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of

any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits
of such delegation.

E. Audit and supervision

Art. 25. Auditor(s).
25.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s)). The

general meeting of Shareholders shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine their term of office, which may
not exceed six (6) years.

25.2 An statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of Shareholders.

25.3 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Com-

pany.

25.4 If the general meeting of Shareholders of the Company appoints one or more independent auditor(s) (réviseur(s)

d’entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies
register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of statutory auditor(s) is
suppressed.

25.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of Shareholders with cause or with his

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 26. Financial year.
26.1 The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first

of December of the same year.

26.2 When preparing the balance sheet and the profit and loss accounts at the end of the financial year, the board of

directors shall book a provision equal to the amount of the MRPS Dividend due to the MRPS Holders for the relevant
financial year as determined in these articles of association. Such provision will be at the disposal of the annual general
meeting of the Shareholders.

Art. 27. Annual accounts and allocation of profits.
27.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors draws up an inventory of the

Company’s assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

27.2 For each financial year, the credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs,

amortizations, charges and provisions, such as approved by the general meeting of the Shareholders, represents the annual
net profits of the Company.

27.3 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.

27.4 The remaining profits after allocation to the legal reserve, calculated in accordance with Luxembourg GAAP,

represent the Available Profits and may be distributed as set forth under the present article below, as applicable.

70628

L

U X E M B O U R G

27.5 Sums contributed to a reserve of the Company by a Shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing Shareholder agrees to such allocation.

27.6 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

27.7 Each financial year, out of the Available Profits, each MRPS Holder is entitled to a dividend per MRPS (the MRPS

Dividend) of five point three six nine one per cent (5.3691%) of (a) the nominal value or par value of each MRPS plus (b)
any amount that may be allocated from time to time on a voluntary basis from the MRPS Premium Account to the legal
reserve divided by the number of MRPS in issue plus (c) the amount of the MRPS Premium Account divided by the number
of MRPS in issue plus (d) any unpaid MRPS Dividend of previous years.

27.8 As applicable and should the Available Profits be sufficient to distribute the MRPS Dividend, in whole or in part,

and the general meeting of the Shareholders makes no distribution resolution with respect to the MRPS Dividend, then the
aggregate amount of the MRPS Dividends that should have been distributed to the MRPS Holders as provisioned by the
board of directors pursuant to article 26.2, shall be automatically allocated to a distributable reserve booked in a MRPS
reserve account (the MRPS Reserve Account).

27.9  The  MRPS  Dividend  is  cumulative  and  recoverable,  which  means  that  MRPS  Holders  shall,  during  posterior

financial years, recover the MRPS Dividend that they could not receive during the foregoing financial years during which
there was no realized nor distributed Available Profits.

27.10 Therefore, should the result of a financial year not allow to fully pay the MRPS Dividend or should the general

meeting of the Shareholders not decide to pay a dividend despite the existence of Available Profits, the unpaid fraction of
the privileged dividend of a certain year shall be paid during subsequent years, without prejudice to other rights reserved
to the MRPS in such hypothesis. The recovery of the MRPS Dividend is not limited in time. However, the MRPS do not
give right to an additional payment of an ordinary dividend.

27.11 Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of Shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association. In particular,
after distribution or allocation of the MRPS Dividends, as applicable, the remainder of the Available Profits (that is, the
Available Profits less the aggregate MRPS Dividends) may be distributed to the holders of the Ordinary Shares.

Art. 28. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
28.1 The board of directors may proceed to the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law.
28.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the Shareholders

subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation.
29.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of Shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators  shall  have  the  most  extensive  powers  for  the  realisation  of  the  assets  and  payment  of  the  liabilities  of  the
Company.

29.2 After payment of all third party debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, each

MRPS Holder will have a preferential right to payment and be entitled to the payment in cash of the fair market value of
the Redemption Consideration.

29.3 If the Company cannot pay such amounts in full to all the MRPS Holders, payment will be made on a pro rata basis

to each MRPS Holder.

29.4 The MRPS Holders being granted the full payment of any amount due to them shall not participate to the sharing

out of the liquidation proceeds eventually existing thereafter, these liquidation proceeds being reserved to the Ordinary
Shareholders.

H. Final clause - Governing law

Art. 30. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the Law.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result

of the present deed, are estimated at approximately six thousand eight hundred euros (EUR 6,800.-).

There being no further business, the meeting is closed at 11.00 a.m..
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German translation; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English text shall prevail.

70629

L

U X E M B O U R G

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the

day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed the present deed together with the notary.

Follows the German Translation of the Foregoing deed

Im Jahre zweitausendundsechzehn, am neunzehnten Tag des Monats Februar.
Vor uns, Maître Marc Loesch, Notar mit Amtswohnsitz in Mondorf-les-Bains, Großherzogtum Luxemburg,
Wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter (im Folgenden die „Versammlung“) von Maps

Cologne One (im Folgenden die „Gesellschaft“), eine société anonyme, bestehend nach dem Recht vom Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 200.872, mit Ge-
sellschaftssitz  in  19,  rue  de  Bitbourg,  L-1273  Luxemburg,  Großherzogtum  Luxemburg,  gegründet  durch  notarielle
Urkunde, ausgestellt von Maître Marc Loesch, Notar wohnhaft in Mondorf-les-Bains, Großherzogtum Luxemburg, am 16.
Oktober 2015, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3371 am 17 December 2015. Die
Satzung wurde zuletzt geändert gemäß Urkunde vom unterzeichnendem Notar, am 16 November 2015, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 329 am 5. Februar 2016.

Die Versammlung beginnt um 10.45 Uhr mit Herrn Frank Stolz-Page, geschäftsansässig in Bad-Mondorf, Luxemburg,

als Vorsitzender (der „Vorsitzender“).

Der Vorsitzender ernennt Frau Brigtte Wahl geschäftsansässig in Bad-Mondorf, Luxemburg, als Schriftführer der Ver-

sammlung.

Die Versammlung beruft zum Stimmzähler Frau Karola Böhm, geschäftsansässig in Bad-Mondorf, Luxemburg.
Der/Die anwesende(n) oder vertretende(n) Gesellschafter, die Vollmachten des/der vertretenden Gesellschafter(s) und

die Anzahl ihrer Aktien sind auf der Anwesenheitsliste aufgeführt, die von dem/n anwesenden Gesellschafter(n), dem/n
Bevollmächtigten des/der vertretenden Gesellschafter(s), dem Vorstand der Versammlung und dem unterzeichnendem
Notar unterzeichnet ist. Die Anwesenheitsliste wird der vorliegenden Urkunde beigefügt um mit ihr zusammen den Re-
gistrierungsbehörden hinterlegt zu werden.

Besagte Vollmachten, welche von den erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert

wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen den Registrierungsbehörden hinterlegt zu
werden.

Der Vorsitzende erklärt, dass der/die Gesellschafter der Gesellschaft, der/die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt/

vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet hat/haben, ordnungsgemäß in dieser Versammlung zusammen-
gesetzt und beschlussfähig ist/sind und ersucht hiermit den Notar die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt verpflichtend rückzahlbare Vorzugsaktien (die „VRVA“) im Gesellschaftskapital der Ge-

sellschaft zu schaffen, mit den in der abgeänderten Satzung der Gesellschaft festgelegten Rechten und Pflichten.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag von sechszehn Millionen neun-

hundertzwanzigtausendeinhundertsechsundsiebzig Euro (EUR 16.920.176,-) von seinem aktuellen Betrag von vierhun-
dertneunundsiebzigtausend Euro (EUR 479.000,-) aufgeteilt in vierhundertneunundsiebzigtausend (479.000) Aktien mit
einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Aktie, auf einen Betrag von siebzehn Millionen dreihundertneunund-
neunzigtausendeinhundertsechsundsiebzig Euro (EUR 17.399.176,-), durch die Ausgabe von acht Millionen zweihundert-
zwanzigtausendfünfhundertachtundachtzig (8.220.588) neuen Aktien und acht Millionen sechshundertneunundneunzig-
tausendfünfhundertachtundachtzig (8.699.588) neuen VRVA mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-), zu
erhöhen.

Die acht Millionen zweihundertzwanzigtausendfünfhundertachtundachtzig (8.220.588) neuen Aktien und die acht Mil-

lionen sechshundertneunundneunzigtausendfünfhundertachtundachtzig (8.699.588) neuen VRVA wurden vollständig vom
Alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft, wie vorbenannt, zum Gesamtpreis von einhundertneunundsechzig Millionen
vierhundertachtzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 169.480.750) gezeichnet.

Die Einlage über einen Gesamtbetrag von einhundertneunundsechzig Millionen vierhundertachtzigtausendsiebenhun-

dertfünfzig Euro (EUR 169.480.750) für die so gezeichneten Aktien und VRVA wurde vollständig in bar erbracht, so dass
der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von einhundertneunundsechzig Millionen vierhundertachtzigtausendsiebenhundert-
fünfzig Euro (EUR 169.480.750) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

Die gesamte Einlage in Höhe von einhundertneunundsechzig Millionen vierhundertachtzigtausendsiebenhundertfünfzig

Euro (EUR 169.480.750) besteht aus:

- acht Millionen zweihundertzwanzigtausendfünfhundertachtundachtzig (8.220.588) für die ordinären Aktien der Ge-

sellschaft;

-  dreizehn  Millionen  dreihundertsiebenundsechzigtausendeinhundertfünfundsiebzig  Euro  (EUR  13.367.175)  für  das

Agio der ordinären Aktien der Gesellschaft;

70630

L

U X E M B O U R G

- acht Millionen sechshundertneunundneunzigtausendfünfhundertachtundachtzig (8.699.588) für die VRVA der Ge-

sellschaft; und

-  einhundertneununddreißig  Millionen  einhundertdreiundneunzigtausenddreihundertneunundneunzig  Euro  (EUR

139.193.399,-) für das Agio der VRVA der Gesellschaft.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt den Gesamtbetrag von einer Millionen siebenhundertneunundachtzigtausendneunhun-

dertachtzehn Euro (EUR 1.789.918,-) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zuzuteilen, wovon der Betrag von (i)
achthundert neunundsechzigtausendneunhundertneunundfünfzig Euro (EUR 869.959,-) aus dem Agio der ordinären Aktien
der  Gesellschaft  und  der  Betrag  von  (ii)  achthundert  neunundsechzigtausendneunhundertneunundfünfzig  Euro  (EUR
869.959,-) aus der VRVA der Gesellschaft entspricht.

Die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft soll daher mit dem Betrag von einer Millionen siebenhundertneununddrei-

ßigtausendneunhundertachtzehn Euro (EUR 1.739.918,-) kreditiert werden.

<i>Vierter Beschluss

In Folge der vorstehenden Beschlüsse, beschließt die Versammlung die ganze Satzung der Gesellschaft umzuformieren,

welche ab nun wie folgt lauten soll:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit dem Namen Maps Cologne One

(die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner
aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1  Zweck  der  Gesellschaft  ist  das  Halten  von  Beteiligungen  jeglicher  Art  an  luxemburgischen  und  ausländischen

Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher

Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen
und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Ein weiterer Gesellschaftszweck ist der Erwerb und Verkauf von Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder

im Ausland, einschließlich der direkten oder indirekten Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften,
deren Hauptzweck der Erwerb, die Entwicklung, Förderung, Verkauf oder Verwaltung von Immobilien ist.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie

solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke för-
derlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst

werden, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt wer-

den. Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforder-
lichen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Verwaltungsrates im Großher-

zogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Verwaltungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklun-

gen  aufgetreten  sind  oder  unmittelbar  bevorstehen,  welche  die  gewöhnlichen  Aktivitäten  der  Gesellschaft  an  ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen  Umstände  vorübergehend  ins  Ausland  verlegt  werden;  solche  vorübergehenden  Maßnahmen  haben  keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

70631

L

U X E M B O U R G

B. Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt siebzehn Millionen dreihundertneunundneunzigtausendeinhun-

dertsechsundsiebzig  Euro  (EUR  17.399.176,-),  bestehend  aus  (i)  acht  Millionen  sechshundertneunundneunzigtausend-
fünfhundertachtundachtzig (8.699.588) ordinären Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Aktie (die
„Ordinären Aktien“) und (ii) acht Millionen sechshundertneunundneunzigtausendfünfhundertachtundachtzig (8.699.588)
nicht stimmberechtigt verpflichtend rückzahlbare Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-) (die
„VRVA“ und zusammen mit den Ordinären Aktien die „Aktien“.). Jeder Inhaber von Ordinären Aktien wird hierfolgend
als „Ordinärer Gesellschafter“ bezeichnet, jeder Inhaber von VRVA wird hierfolgend als „VRVA Inhaber“ bezeichnet,
und Ordinäre Gesellschafter und VRVA Inhaber werden gemeinsam als „Gesellschafter“ bezeichnet.

5.2 Jedes Emissionsagio in Bezug zu VRVA soll in einem VRVA Emissionsagiokonto verbucht werden (das „VRVA

Emissionsagiokonto“), und die Gesellschaft soll in solchem Konto, in der Währung in welcher effektiv bezahlt wird, den
Betrag oder Wert von jedem weiteren Kapitalzuschuss zugeführt von VRVA Inhaber an die Gesellschaft und jeden Betrag
zugeteilt zum VRVA Emissionsagiokonto im Einklang mit dieser Satzung, verbuchen.

5.3 Jedes Emissionsagio in Bezug zu Ordinären Aktien soll in einem Ordinäre Aktien Emissionsagiokonto verbucht

werden  (das  „Ordinäre  Aktien  Emissionsagiokonto“),  und  die  Gesellschaft  soll  in  solchem  Konto,  in  der  Währung  in
welcher effektiv bezahlt wird, den Betrag oder Wert von jedem weiteren Kapitalzuschuss zugeführt von Ordinären Ge-
sellschaftern an die Gesellschaft und jeden Betrag zugeteilt zum Ordinären Aktien Emissionsagiokonto im Einklang mit
dieser Satzung, verbuchen.

5.4 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in und mit der

für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.5 Alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen einzuzahlen sind, werden bevorzugt dem bestehenden Aktionär/den be-

stehenden  Aktionären  angeboten.  Im  Falle  einer  Mehrheit  von  Aktionären  werden  diese  Aktien  den  Aktionären  im
Verhältnis zur Anzahl der von ihnen am Gesellschaftskapital jeweils gehaltenen Aktien angeboten. Der Verwaltungsrat
bestimmt den Zeitraum in dem dieses Vorzugsrecht ausgeübt werden kann und welcher nicht weniger als dreißig (30) Tage
vom Datum der Absendung eines an den Aktionär/die Aktionäre gesendeten Einschreibens, welches die Eröffnung der
Zeichnungsfrist ankündigt, beträgt. Die Hauptversammlung der Aktionäre kann das Vorzugsrecht des bestehenden Akti-
onärs/der bestehenden Aktionäre durch einen Beschluss, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Form und Mehrheit gefasst wird, begrenzen oder aufheben.

5.6 Im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 kann die Gesellschaft ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 6. Aktien.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Aktien mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Aktionär betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Verwaltungsrats, können keinerlei Sicherungsrechte bezüglich

VRVA (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Hypotheken, Belastungen (ob fest, schwebend, rechtliche oder gerechte),
Verpfändungen, Pfandrechte oder Sicherungsabtretungen) von jeder beliebigen Person (einschließlich der VRVA Inhaber)
erstellt werden.

Art. 7. Aktienregister - Übertragung von Aktien.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches von den Aktionären eingesehen werden kann.

Dieses Aktienregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Der Nachweis über das Eigentum
an Aktien kann durch die Eintragung eines Aktionärs im Aktienregister erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten
des betreffenden Aktionärs werden Zertifikate über die Eintragung ausgegeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Sofern eine Aktie von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt,  die  Ausübung  aller  Rechte  im  Zusammenhang  mit  einer  derartigen  Aktie  auszusetzen,  bis  eine  Person  als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Aktien sind im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 frei übertragbar.
7.4 Jede Übertragung von Namensaktien wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten wirksam (i) durch Eintragung

einer vom Zedenten und vom Zessionar oder deren Vertretern datierten und unterschriebenen Übertragungserklärung im
Aktienregister, oder (ii) nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder dieser zugestimmt
hat.

Art. 8. Rückkauf von Aktien.
8.1 Die Gesellschaft kann, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes und dieser Satzung, ihre eigenen Aktien,

sofern von dieser Satzung auf Basis des zur Verfügung stehenden ausschüttbaren Betrags erlaubt, rückkaufen.

70632

L

U X E M B O U R G

8.2 Die Gesellschaft kann, im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 49-8 des Gesetzes, rückzahlbare Aktien

ausgeben.

8.3 Vorbehaltlich Artikel 8.6, alle gezeichneten und voll einbezahlten VRVA sollen, im Einklang mit den Bestimmungen

von Artikel 49-8 des Gesetzes und auf einer pro rata Basis zwischen Gesellschafter, bei Anfrage der Gesellschaft zum
Rückkaufspreis im Ganzen oder zum Teil rückzahlbar sein, und sollen, in jedem Fall, am zehnten Jahrestag der Ausgabe
der VRVA rückgezahlt werden. Die Rückzahlung soll Gegenstand einer Entscheidung des Verwaltungsrats sein.

8.4 Bei Rückzahlung der VRVA soll jeder Inhaber der zurückgekauften VRVA einen in Bar ausgestellten Gesamtbetrag

in Höhe des Nominalwerts des zurückgekauften VRVA Betrags zusätzlich des VRVA Emissionsagiokonto Betrags in
Bezug zu solch zurückgekauften VRVA und alle aufgelaufenen jedoch nicht ausbezahlten Dividenden in Bezug zu solchen
VRVA (der „Rückkaufspreis“) erhalten.

8.5 Im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes kann die Gesellschaft ihre eigenen Ordinären Aktien zurückkaufen.

Die Rückzahlung der Ordinären Aktien ist jedoch nur nach Rückzahlung aller VRVA möglich.

8.6 Die Rückzahlung aller VRVA kann nur dann erfolgen wenn zur Verfügung stehende ausschüttbare Beträge, im

Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 72-1 des Gesetzes, benutzt werden oder im Falle einer neuen Ausgabe mit
dem Zweck einer solchen Rückzahlung.

8.7 Zurückgekaufte VRVA sollen unmittelbar nach ihrem Rückkauf annulliert werden.
8.8 Ein Betrag in Höhe des Nominalwerts, oder, in der Abwesenheit von solchem, des Buchwerts, von jeder rückge-

zahlten Aktie soll in einer nicht an die Gesellschafter ausschüttbaren Reserve zurückgehalten werden, außer im Falle einer
Kapitalreduktion der gezeichneten Aktien. Die Reserve kann nur benutzt werden um, bei Kapitalisierung der Reserven,
das gezeichnete Aktienkapital zu erhöhen. Diese Reserve ist nicht notwendig im Falle einer neuen Ausgabe mit dem Zweck
eines solchen Rückkaufs.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 9. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.
9.1 Die Aktionäre üben ihre gemeinsamen Rechte in der Hauptversammlung der Aktionäre aus. Jede regelmäßig ein-

berufene Hauptversammlung der Aktionäre repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Die Hauptver-
sammlung der Aktionäre hat die ihr durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen Befugnisse.

9.2 Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär, so ist jeder Bezug auf die „Hauptversammlung der Aktionäre“ in der

vorliegenden Satzung je nach Zusammenhang und soweit anwendbar als Bezug auf den „alleinigen Aktionär“ zu verstehen
und alle Befugnisse der Hauptversammlung werden vom alleinigen Aktionär ausgeübt.

Art. 10. Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre.
10.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit durch den Verwaltungsrat oder, soweit vorhanden, durch

den/die Rechnungsprüfer einberufen werden.

10.2 Sie muss auf schriftliche Aufforderung von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens 10 Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals halten, vom Verwaltungsrat oder vom Rechnungsprüfer/den Rechnungsprüfern einberufen
werden. In einem derartigen Fall muss die Hauptversammlung der Aktionäre innerhalb eines (1) Monats ab Zugang des
Ersuchens abgehalten werden.

10.3 Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung der Aktionäre muss das Datum, die Uhrzeit, den Ort und die Tages-

ordnung der Versammlung enthalten und zweimal in Form einer Einberufung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations und in einer Luxemburger Tageszeitung mit einem Zeitabstand von mindestens acht (8) Tagen und acht (8)
Tage vor dem für die Hauptversammlung anberaumten Datum erfolgen. Einberufungen per Post sind acht (8) Tage vor
dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Inhaber von Namensaktien zu versenden, wobei kein Beweis der
Einhaltung dieser Formvorschrift erbracht werden muss. Handelt es sich bei allen Aktien um Namensaktien, so kann die
Einberufung ausschließlich durch Einschreiben erfolgen, die mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung
anberaumten Datum an jeden Aktionär zu versenden sind.

10.4 Falls alle Aktionäre in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf Ladungsformalitäten verzichtet

haben, kann die Hauptversammlung auch ohne vorherige Einladung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 11. Durchführung der Hauptversammlung der Aktionäre.
11.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird in der Gemeinde, in der sich der Gesellschaftssitz befindet, oder

an  einem  anderen  in  der  Einberufung  bestimmten  Ort  am  10.  Juni  um  10:00  Uhr  CET  abgehalten.  Ist  dieser  Tag  ein
gesetzlicher Feiertag, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am darauf folgenden Werktag abzuhalten. Weitere
Hauptversammlungen der Aktionäre können an dem in der Einberufung bestimmten Ort zu der darin angegebenen Zeit
abgehalten werden.

11.2 In jeder Hauptversammlung der Aktionäre wird ein Rat der Versammlung bestimmt, der aus einem Vorsitzenden,

einem Schriftführer und einem Stimmzähler besteht, die weder Aktionäre, noch Mitglieder des Verwaltungsrats sein müs-
sen. Wenn alle bei der Hauptversammlung anwesenden Aktionäre entscheiden, dass eine ordnungsgemäße Abstimmung
derart  gewährleisten  werden  kann,  so  können  sie  einstimmig  beschließen,  lediglich  (i)  einen  Vorsitzenden  und  einen
Schriftführer oder (ii) eine Person zu ernennen, die die Rolle des Rates der Versammlung übernimmt und in einem solchen

70633

L

U X E M B O U R G

Fall ist die Ernennung eines Stimmzählers nicht erforderlich. Soweit anwendbar und je nach Zusammenhang ist jeder Bezug
auf den „Rat der Versammlung“ in dieser Satzung als Verweis auf den „Vorsitzenden und Schriftführer“ oder gegebenen-
falls als Verweis auf die „Einzelperson, die die Rolle des Rates übernommen hat“, zu verstehen. Der Rat der Versammlung
soll sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und vor allem im Einklang mit den Regeln
betreffend die Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Aktionären abgehalten wird.

11.3 In jeder Hauptversammlung wird eine Anwesenheitsliste geführt.
11.4 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person durch ein

unterzeichnetes Dokument, das per Post, Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt
wird, schriftlich bevollmächtigt. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Aktionäre vertreten.

11.5 Aktionäre, die an einer Hauptversammlung der Aktionäre durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel teilnehmen, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und
tatsächlich an der Versammlung teilzunehmen, gelten als anwesend für die Bestimmung des Quorums und des Stimmrechts,
insofern diese Kommunikationsmittel am Ort der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt werden.

11.6 Jeder Aktionär kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Aktionäre durch eine unterzeichnete Stimmkarte

abgeben, welche per Post, EMail, Fax oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den Sitz der Gesellschaft oder
an die in der Einberufung genannte Adresse gesendet wird. Die Aktionäre können nur solche Stimmkarten verwenden, die
von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung,
die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Aktionären
ermöglichen, seine Stimme für oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das
entsprechende Kästchen ankreuzt.

11.7 Stimmkarten, die für einen vorgeschlagenen Beschluss nicht nur (i) eine Stimme für oder (ii) eine Stimme gegen

den vorgeschlagenen Beschluss oder (iii) eine Enthaltung beinhalten, sind in Bezug auf diesen Beschluss ungültig. Die
Gesellschaft wird nur Stimmkarten berücksichtigen, die sie vor der entsprechenden Hauptversammlung der Aktionäre
erhalten hat.

11.8 Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen bestimmen, die von den Aktionären eingehalten werden müssen,

um an einer Hauptversammlung teilzunehmen.

Art. 12. Quorum und Stimmrecht.
12.1 Jede Ordinäre Aktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlungen der Aktionäre.
12.2 Die VRVA sind nicht stimmberechtigte Aktien im Einklang mit den Artikeln 44 bis 47 des Gesetzes. Jede VRVA

berechtigt  seinen  Inhaber  zu  einer  Stimmberechtigung  bezüglich  jeder  Angelegenheit  zur  welcher  Inhaber  von  nicht
stimmberechtigten Vorzugsaktien gemäß Artikel 46 des Gesetzes stimmberechtigt sind.

12.3 Beschlüsse der Gesellschafter werden bei Gesellschafterversammlungen im Einklang mit dem Gesetz beschlossen.

Für Klarstellung, die VRVA sind nur stimmberechtigt in Bezug zu Bestimmungen beinhaltet in Artikel 46 des Gesetzes,
wobei die Gesellschafterversammlung dann aus Ordinären Gesellschafter und VRVA Inhaber besteht.

12.4 Sofern sich nicht aus dem Gesetz von 1915 oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in

einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre ohne Erfordernis eines Anwesenheitsquorums mit
einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst unabhängig von dem dabei vertretenen Anteil am Gesell-
schaftskapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Art. 13. Änderungen der Satzung. Vorbehaltlich anderer Regelungen in dieser Satzung erfordert die Änderung der

Satzung einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3) der
abgegebenen gültigen Stimmen, in der mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist. Falls
die zweite Bedingung nicht erfüllt ist, kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung
eine zweite Hauptversammlung der Aktionäre einberufen werden, die unabhängig von einem Anwesenheitsquorum be-
schlussfähig ist und in welcher Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen gültigen
Stimmen gefasst werden. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Aktionäre können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 15. Vertagung von Hauptversammlungen der Aktionäre. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 1915

kann der Verwaltungsrat jede sich im Gange befindliche Hauptversammlung der Aktionäre um vier (4) Wochen vertagen.
Der Verwaltungsrat muss eine Hauptversammlung der Aktionäre vertagen, wenn dies von einem oder mehreren Aktionären,
die mindestens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftskapitals halten, gefordert wird. Durch derartige Vertagung wird
jeder bereits gefasste Beschluss in dieser Versammlung annulliert.

Art. 16. Protokoll von Hauptversammlungen der Aktionäre.
16.1 Der Rat der Versammlung nimmt ein Protokoll jeder Versammlung auf, welches vom Rat der Versammlung sowie

von jedem Aktionär, der darum ersucht, unterzeichnet wird.

16.2 Kopien und Auszüge dieser Protokolle, die in Gerichtsverfahren verwendet oder Dritten zugänglich gemacht wer-

den sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die

70634

L

U X E M B O U R G

Originalurkunde verwahrt, beglaubigt werden, oder ansonsten vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei beliebigen
Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 17. Zusammensetzung und Befugnisse des Verwaltungsrates.
17.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet, der sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusam-

mensetzt, mit zumindest einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und zwei (2) Geschäftsführern der Kategorie B. Sollte
die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionären gegründet worden sein oder wird in einer Hauptversammlung der Akti-
onäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionären hat, so kann die Gesellschaft bis zu der Hauptver-
sammlung der Aktionäre durch ein einziges Verwaltungsratsmitglied geleitet werden, die auf die Feststellung folgt, dass
es wieder mehr als einen Aktionär gibt. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff „einziges Verwal-
tungsratsmitglied“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Verwaltungsrat“ als
Verweis auf das „einzige Verwaltungsratsmitglied“ auszulegen.

17.2 Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle

Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der
durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 18. Tägliche Geschäftsführung.
18.1 Gemäß Artikel 60 des Gesetzes von 1915 können die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung

der Gesellschaft einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten oder anderen Personen, mit
gemeinsamer oder Einzelvertretungsbefugnis übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden
durch einen Verwaltungsratsbeschluss bestimmt.

18.2 Die Gesellschaft kann durch notarielle Urkunden oder privatschriftlich Spezialvollmachten erteilen.

Art. 19. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern.
19.1 Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

19.2 Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten und jedes Verwaltungsrats-

mitglied übt sein Amt aus, bis sein Nachfolger ernannt ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann wiederernannt werden.

19.3  Jedes  Verwaltungsratsmitglied  wird  durch  einfache  Mehrheit  der  rechtsgültig  abgegebenen  Stimmen  in  einer

Hauptversammlung ernannt.

19.4 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit und ohne Grund mit einfacher Mehrheit der in einer Hauptversamm-

lung der Aktionäre abgegebenen Stimmen abberufen werden.

19.5 Wird eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt, so muss diese eine natürliche Person als ihren

ständigen Vertreter benennen, die ihr Mandat in ihrem Namen und für ihre Rechnung ausübt. Die betreffende juristische
Person kann nur dann ihren ständigen Vertreter abberufen, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernennt. Eine natürliche
Person kann nur ständiger Vertreter eines (1) Verwaltungsratsmitglieds und nicht gleichzeitig persönlich Verwaltungs-
ratsmitglied sein.

Art. 20. Vakanz des Amtes eines Verwaltungsratsmitglieds.
20.1 Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen

Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten Haupt-
versammlung der Aktionäre vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit des zu ersetzenden Verwaltungsrats-
mitglieds nicht übersteigenden Zeitraum bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre ausgefüllt werden, welche im
Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

20.2 Für den Fall, dass das einzige Verwaltungsratsmitglied aus seinem Amt scheidet, muss die frei gewordene Stelle

unverzüglich durch die Hauptversammlung der Aktionäre neu besetzt werden.

Art. 21. Einladung zu Verwaltungsratssitzungen.
21.1 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung des Vorsitzenden, oder eines beliebigen Verwaltungsrats-

mitglieds. Die Verwaltungsratssitzungen finden, soweit in der Einladung nicht anders bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft
statt.

21.2 Die Verwaltungsratsmitglieder werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anbe-

raumten Datum zu jeder Sitzung des Verwaltungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, wenn alle Verwaltungs-
ratsmitglieder schriftlich, per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung
abgegeben  haben,  wobei  eine  Kopie  einer  solchen  unterzeichneten  Zustimmung  ein  hinreichender  Nachweis  ist.  Eine
Einladung zu Sitzungen des Verwaltungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Verwaltungsrats bestimmt worden sind, welcher allen Verwaltungsratsmitgliedern übermittelt wurde.

21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und diese

alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des
Verwaltungsrats diesen zugestimmt und sie unterzeichnet haben.

70635

L

U X E M B O U R G

Art. 22. Durchführung von Verwaltungsratssitzungen.
22.1 Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden aus. Der Verwaltungsrat kann auch einen

Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Verwaltungsrats sein muss und der für die Protokollfüh-
rung der Verwaltungsratssitzungen verantwortlich ist.

22.2 Verwaltungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats geleitet. In dessen Abwesenheit

kann der Verwaltungsrat ein anderes Mitglied des Verwaltungsrats durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder
vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

22.3 Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an einer Verwaltungsratssitzung teilnehmen, indem es ein anderes Mit-

glied  des  Verwaltungsrats  schriftlich,  per  Fax,  E-Mail  oder  ein  anderes  vergleichbares  Kommunikationsmittel  bevoll-
mächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied des Verwaltungsrats
kann ein oder mehrere, aber nicht alle anderen Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

22.4 Eine Verwaltungsratssitzung kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kom-

munikationsmittel  abgehalten  werden,  welches  es  allen  Teilnehmern  ermöglicht,  einander  durchgängig  zu  hören  und
tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleich-
bedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft
abgehalten erachtet.

22.5 Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mit-

glieder, mit zumindest einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B, in der
Sitzung anwesend oder vertreten ist.

22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Verwaltungsratssitzung teilnehmenden

oder  vertretenen  Verwaltungsratsmitglieder,  mit  zumindest  einem  (1)  Geschäftsführer  der  Kategorie  A  und  einem  (1)
Geschäftsführer der Kategorie B, gefasst. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die
entscheidende Stimme.

22.7 Soweit nicht gesetzlich anders bestimmt muss jedes Verwaltungsratsmitglied, welches an einem Geschäft, das dem

Verwaltungsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein Interesse hat, welches den Interessen der Gesellschaft
entgegensteht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenskonflikt informieren; die Erklärung wird im Protokoll der be-
treffenden Sitzung aufgenommen. Das betreffende Verwaltungsratsmitglied darf weder an der Beratung über das in Frage
stehende Geschäft teilnehmen, noch darüber abstimmen. Die nächste Hauptversammlung der Aktionäre muss von derar-
tigen Interessenkonflikten informiert werden, bevor Beschlüsse zu anderen Tagesordnungspunkten gefasst werden.

22.8 Hat die Gesellschaft nur ein einziges Verwaltungsratsmitglied, so werden Geschäfte zwischen der Gesellschaft und

dem Verwaltungsratsmitglied, welches daran ein der Gesellschaft entgegenstehendes Interesse hat, nur im Beschluss des
einzigen Verwaltungsratsmitglieds erwähnt.

22.9 Regeln zum Interessenkonflikt finden keine Anwendung, sofern sich die Entscheidung des Verwaltungsrats oder

des einzigen Verwaltungsratsmitglieds auf gängige Geschäfte bezieht, die unter normalen Bedingungen eingegangen wur-
den.

22.10 Der Verwaltungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Fax,

E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Zustim-
mung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 23. Protokoll von Verwaltungsratssitzungen - Protokoll der Entscheidungen des einzigen Verwaltungsratsmitglieds.
23.1 Das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder, im Falle seiner

Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore, oder gemeinsam von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem
(1) Geschäftsführer der Kategorie B unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren
oder anderweitig vorzulegen sind, werden vom Vorsitzenden oder von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und
einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B gemeinsam unterzeichnet.

23.2 Die Entscheidungen des einzigen Verwaltungsratsmitglieds werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom

einzigen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom einzigen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.

Art. 24. Geschäfte mit Dritten.
24.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift des einzigen Verwal-

tungsratsmitglieds oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Verwaltungsratsmitglieder hat, durch die gemeinsame
Unterschrift von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B, oder durch
(ii) die gemeinsame oder Einzelunterschrift jedweder Person(en), der/denen eine solche Befugnis durch den Verwaltungsrat
übertragen worden ist, im Rahmen dieser Befugnis verpflichtet.

24.2 Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder

Einzelunterschrift der Person(en) verpflichtet, der/denen diese Vollmacht übertragen wurde.

70636

L

U X E M B O U R G

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 25. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
25.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)).

Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest, die sechs (6) Jahre nicht
überschreiten darf.

25.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.
25.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Prüfung und Kontrolle aller Geschäfte der

Gesellschaft.

25.4 Wenn die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom

19. Dezember 2002 betreffend das Handels- und Gesellschaftsregister sowie zur Buchhaltung und zum Jahresabschluss
von Unternehmen in seiner geänderten Fassung einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises
agréé(s)) ernennt, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.

25.5  Ein  unabhängiger  Wirtschaftsprüfer  darf  nur  aus  berechtigtem  Grund  oder  mit  seiner  Zustimmung  durch  die

Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 26. Geschäftsjahr.
26.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

26.2. Bei der Bilanzaufstellung und der Gewinn- und Verlustrechnung am Ende des Geschäftsjahres soll der Verwal-

tungsrat eine Provision in Höhe der VRVA Dividende welche den VRVA Inhaber für das jeweilige Geschäftsjahr schuldig
ist, so wie in dieser Satzung vorgesehen, verbuchen.

Art. 27. Jahresabschluss und Gewinne.
27.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Verwaltungsrat erstellt im Einklang mit

den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

27.2 Für jedes Geschäftsjahr, soll das Guthaben der Gewinn- und Verlustrechnung, nach Abzug von Ausgaben, Kosten,

Tilgungen, Gebühren und Provisionen, so wie von der ordinären jährlichen Hauptversammlung der Gesellschafter geneh-
migt, den Nettojahresgewinn der Gesellschaft aufweisen.

27.3 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

27.4 Die verbleibenden Gewinne nach Zuführung in die gesetzliche Rücklage, gerechnet im Einklang mit Luxemburg

GAAP, repräsentieren die Zur Verfügung Stehenden Gewinne und können ausgezahlt werden so wie tiefer in diesem Artikel
beschrieben, je nach Anwendbarkeit.

27.5 Durch einen Aktionär erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Aktionärs ebenfalls der

gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

27.6 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

27.7 Jedes Geschäftsjahr ist jeder VRVA Inhaber, aus dem Zur Verfügung Stehenden Gewinn, zu einer Dividende je

VRVA (die VRVA Dividende) in Höhen von fünf Komma drei sechs neun eins Prozent (5,3691%) (a) des Nominalwerts
oder des Nennwerts des Wertes einer jeden VRVA zusätzlich (b) dem Betrag welcher freiwillig aus dem VRVA Emissi-
onsagiokonto der gesetzlichen Rücklage zugeteilt wurde, geteilt durch die Anzahl der VRVA in Ausgabe zusätzlich (c)
dem Betrag des VRVA Emissionsagiokonto geteilt durch die Anzahl der VRVA in Ausgabe und (d) jeder unbezahlten
MRPS Dividende vorheriger Jahre, berechtigt.

27.8 Je nach Anwendbarkeit und sollten die Zur Verfügung Stehenden Gewinne ausreichend sein um VRVA Dividende

auszuschütten, im Ganzen oder zum Teil, und die Hauptversammlung der Gesellschafter keine Ausschüttungsbeschlüsse
in Bezug zu VRVA Dividende nimmt, dann soll der Gesamtbetrag der VRVA Dividende die an die VRVA Inhaber aus-
geschüttet hätte werden sollen, so wie vorgesehen vom Verwaltungsrat in Bezug auf Artikel 26.2, automatisch in einer
ausschüttbaren Rücklage in einem VRVA Rücklagekonto verbucht werden (das VRVA Rücklagekonto).

27.9 Die VRVA Dividende sind kumulierbar und erstattungsfähig, was bedeutet das die VRVA Inhaber, während spä-

teren Geschäftsjahren, die VRVA Dividende welche sie nicht in vorherigen Geschäftsjahren in Abwesenheit von erzielten
und ausschüttbaren Gewinnen erhalten konnten, rückgewinnen können.

27.10 Deswegen, sollten die Resultate eines Geschäftsjahres die vollständige Ausschüttung von VRVA Dividende nicht

erlauben oder sollte die Hauptversammlung der Gesellschafter eine solche Ausschüttung nicht beschließen trotz der Exis-
tenz von Zur Verfügung Stehenden Gewinne, so soll der ausstehende nicht ausgeschüttete Anteil der Vorteilsdividende
eines Jahres während des nächsten Jahres ausgeschüttet werden, ohne Beeinträchtigung anderer vorgesehenen Rechte in
solcher Hinsicht. Die Rückgewinnung der VRVA Dividende ist zeitlich nicht limitiert. Jedoch geben die VRVA keine
Rechte zur weiteren Auszahlung von ordinären Dividenden.

70637

L

U X E M B O U R G

27.11 Auf Vorschlag des Verwaltungsrates bestimmt die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit dem Gesetz

von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden
soll. Insbesondere nach Verteilung und Zuteilung der VRVA Dividende, je nach Anwendbarkeit, kann der Restbetrag der
Zur Verfügung Stehenden Gewinne (welcher das Resultat der Zur Verfügung Stehenden Gewinne weniger der VRVA
Dividende ist) an die Ordinären Gesellschafter verteilt werden.

Art. 28. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.

28.1 Der Verwaltungsrat kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 Abschlagsdividenden aus-

zahlen.

28.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation.

29.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die über
die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts
anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte
und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

29.2 Nach Zahlung aller Drittparteischulden und Haftungen der Gesellschaft oder Hinterlegung jeglicher Anlagefonds

in solcher Hinsicht, erhält jeder VRVA Inhaber ein Vorzugsrecht zur Auszahlung und wird zu einer in Bar bestehenden
Geldauszahlung zum fairen Marktpreis des Rückkaufspreises berechtigt.

29.3 Wenn die Gesellschaft solch eine Betrag nicht vollständig an alle VRVA Inhaber auszahlen kann, werden Aus-

zahlung auf eine pro rata Basis an jedem VRVA Inhaber vorgenommen.

29.4 Die VRVA Inhaber welche eine volle Auszahlung der ihnen zustehenden Beträge erhalten, sollen nicht an eine

Verteilung während eventuellen weiteren Liquidationsverfahren teilnehmen. Diese Liquidationsverfahren sind den Ordi-
nären Gesellschaftern vorbehalten.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 30. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, welche der Ge-

sellschaft aus Anlass des vorliegenden Aktes entstehen, beläuft sich auf ungefähr sechtausendachthundert Euro (EUR
6.800,-).

Da nichts mehr au der Tagesordnung steht, wird die Sitzung um 11.00 Uhr aufgehoben.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht stellt hiermit fest, dass die vorliegende Urkunde

auf Anfrage der erschienenen Partei in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage
derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die
englische Fassung maßgeblich.

Worüber Urkunde Aufgenommen in Mondorf-les-Bains, in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Nach Verlesung des Vorstehenden gegenüber den erschienenen Parteien, dem Notar nach Namen, Vornamen sowie

Familienstand und Wohnort bekannt, haben die erschienenen Parteien mit uns, dem Notar, die vorliegende Urkunde un-
terzeichnet.

Signé: F. Stolz-Page, B. Wahl, K. Böhm, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 25 février 2016. GAC/2016/1436. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 3 mars 2016.

Référence de publication: 2016074834/947.

(160039054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

70638

L

U X E M B O U R G

Red Theatre Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: JPY 13.000.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 204.301.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth day of February,
Before the undersigned Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

CVC Capital Partners Asia IV Limited, a limited company governed by the laws of Jersey and having its registered

office at Lime Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST, Channel Islands, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 112867;

hereby represented by Mrs Stella Le Cras, employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal established on 18 February 2016.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) which

will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated 10 

th

August,  1915,  on  commercial  companies,  as  amended  (hereafter  the  “Law”),  as  well  as  by  the  articles  of  association
(hereafter the “Articles”), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member
company.

Art. 2. Corporate object.
2.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, deve-
lopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

2.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

2.3 The Company may also enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any

contracts or obligations of the Company or of group companies.

2.4 In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures

and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

2.5 The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

on real estate or on movable property.

2.6 The Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be

considered as a regulated activity of the financial sector.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination “Red Theatre Holdings S.à r.l.”.

Art. 5. Registered office.
5.1 The registered office is established in Luxembourg-City.
5.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

5.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the sole director

(gérant) or in case of plurality of directors (gérants), by a decision of the board of directors (conseil de gérance).

5.4 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 - Subscribed Share Capital
6.1.1 The Company's corporate capital is fixed at JPY 13,000,000 (thirteen million Japanese Yens) represented by

13,000,000 (thirteen million) shares (parts sociales) of JPY 1 (one Japanese Yen) each, all fully subscribed and entirely
paid up.

70639

L

U X E M B O U R G

6.1.2 At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In such case Articles 200-1 and 200-2 of the Law,
among others, will apply, entailing that each decision of the single shareholder and each contract concluded between him
and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of Share Capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders’

meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.

6.3 - Profit Participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

6.4 - Indivisibility of Shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of Shares
6.5.1 In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
6.5.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters

of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of
Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in accordance

with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management.
7.1 - Appointment and Removal
7.1.1 The Company is managed by a sole director (gérant) or more directors (gérants). If several directors (gérants) have

been appointed, they will constitute a board of directors (conseil de gérance). The director(s) (gérant(s)) need not to be
shareholder(s).

7.1.2 The director(s) (gérant(s)) is/are appointed by the general meeting of shareholders.
7.1.3 A director (gérant) may be dismissed ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted

by the shareholders.

7.1.4 The sole director (gérant) and each of the members of the board of directors (conseil de gérance) shall not be

compensated for his/their services as director (gérant), unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders.
The Company shall reimburse any director (gérant) for reasonable expenses incurred in the carrying out of his office,
including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board, in case of plurality of directors
(gérants).

7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), of the board of directors (conseil de
gérance).

7.3 - Representation and Signatory Power
7.3.1 In dealing with third parties as well as in justice, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors

(gérants), the board of directors (conseil de gérance) will have all powers to act in the name of the Company in all cir-
cumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this Article

7.3 shall have been complied with.
7.3.2 The Company shall be bound by the sole signature of its sole director (gérant), and, in case of plurality of directors

(gérants), by the joint signature of any two member of the board of directors (conseil de gérance).

7.3.3 The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance)

may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents and determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Procedures
7.4.1 The board of directors (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It

may also choose a secretary, who need not be a director (gérant) and who shall be responsible for keeping the minutes of
the meeting of the board of directors and of the shareholders.

70640

L

U X E M B O U R G

7.4.2 The resolutions of the board of directors (conseil de gérance) shall be recorded in the minutes, to be signed by the

chairman and the secretary (if any), and recorded in the corporate book of the Company. Copies or extracts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary or by any
director (gérant).

7.4.3 Decisions of the sole director (gérant) shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole director

(gérant). Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed
by the sole director (gérant).

7.4.4 The board of directors (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the directors

(gérants) is present or represented at the meeting of the board of directors (conseil de gérance).

7.4.5 In case of plurality of directors (gérants), resolutions shall be taken by a majority of the votes of the directors

(gérants) present or represented at such meeting.

7.4.6 Any director (gérant) may act at any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by appointing in writing

another director (gérant) as his proxy. A director (gérant) may also appoint another director (gérant) to represent him by
phone to be confirmed at a later stage.

7.4.7 Resolutions in writing approved and signed by all directors (gérants) shall have the same effect as resolutions

passed at the directors’ (gérants) meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents. The date
of such resolutions shall be the date of the last signature.

7.4.8 Any and all directors (gérants) may participate in any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by

telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the directors (gérants) taking
part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting.

7.5 - Liability of Directors (gérants)
Any director (gérant) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders’ meeting.
8.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
8.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him.
Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

8.3 However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous

vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.

8.4 The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed

twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to
be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders’ meeting.
9.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), an annual general meeting of shareholders shall be

held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the 16 

th

 day of the month of August, at 11.30.a.m..

9.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole director
(gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance), exceptional circumstances
so require.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be

supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder.
If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.
11.1 - Fiscal Year
The Company’s fiscal year starts on the first of March and ends on the last day of February of each year.
11.2 - Annual Accounts
11.2.1 At the end of each fiscal year, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board

of directors (conseil de gérance) prepare an inventory, including an indication of the value of the Company’s assets and
liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be
made.

70641

L

U X E M B O U R G

11.2.2 Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered

office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory
auditor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits.
12.1 The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit.

12.2 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

12.3 The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 13. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
13.1 The board of directors (conseil de gérance) may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial

statements prepared by the board of directors (conseil de gérance) showing that sufficient funds are available for distribution.
The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits
carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve
which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

13.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

subject to the provisions of the Law and these articles of association.

Art. 14. Dissolution - Liquidation.
14.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

14.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to

a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to
the Articles.

14.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 15. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

Art. 16. Modification of articles. The Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders,

by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

<i>Transitional dispositions

The first fiscal year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the last day of

February 2017.

The first annual general meeting of the shareholders shall be held in 2017.

<i>Subscription - Payment

The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe the entire share capital as follows:

Subscriber

Number

of shares

Subscribed

amount

in JPY

%

CVC Capital Partners Asia IV Limited, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,000,000 13,000,000

100%

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,000,000 13,000,000

100%

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the amount

of JPY 13,000,000.- (thirteen million Japanese Yens) is now available to the Company, evidence thereof having been given
to the notary.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1.500,-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1. The Company will be administered by the following directors (gérants) appointed for an unlimited period:

70642

L

U X E M B O U R G

a. Mrs. Emanuela Brero, private employee, born on 25 May 1970 in Bra (Italy), having her professional address at 20,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

b. Mr. Thomas Morana, private employee, born 14 June 1982 in Huy (Belgium), having his professional address at 20,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

c. Mr. Marc Rachman, private employee, born on 4 April 1958 in Glasgow (United Kingdom), having his professional

address at 111 Strand, London WC2R 0AG, United Kingdom

2. The registered office of the Company shall be established at 33 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois de février.
Par devant Maître Marc LOESCH notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-duché de Luxembourg;

A COMPARU:

CVC Capital Partners Asia IV Limited, une limited company ayant son siège social au 1 Waverley Place, Union Street,

St. Helier, Jersey JE1 1SG, Iles Anglo-Normandes, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro
112867,

ici représentée par Madame Stella Le Cras, employée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 février 2016.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme sociale.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après

la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
«Loi»”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8
et 11.2, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social.
2.1 L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises

et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange
ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la
propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre des parti-
cipations dans des sociétés de personnes.

2.2 La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être convertibles

(à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.

2.3 La Société peut aussi contracter toute garantie, gage ou toute autre forme de sûreté pour l’exécution de tous contrats

ou obligations de la Société ou d’une société du groupe.

2.4 D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

2.5 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-

action sur des biens mobiliers ou immobiliers.

2.6 La Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait con-

sidérée comme une activité réglementée du secteur financier.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: «Red Theatre Holdings S.à r.l.».

Art. 5. Siège social.
5.1 Le siège social est établi à Luxembourg - Ville.
5.2 Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

70643

L

U X E M B O U R G

5.3 L’adresse du siège social peut-être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant unique ou

en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

5.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 - Capital Souscrit et Libéré
6.1.1 Le capital social est fixé à 13.000.000 JPY (treize millions de Yen Japonais) représenté par 13.000.000 (treize

millions) parts sociales d’une valeur nominale de 1 JPY (un Yen Japonais) toutes entièrement souscrites et libérées.

6.1.2 A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par
lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du Capital Social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de

l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article 199
de la Loi.

6.3 - Participation aux Profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre

des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire est admis par part sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de Parts Sociales
6.5.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
6.5.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect

des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non -associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Les transferts de parts sociales doivent s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts ne

peuvent être opposables à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de leur notification à la Société ou de
leur acceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement des Parts Sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés

conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Management.
7.1 - Nomination et Révocation
7.1.1 La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils consti-

tueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).

7.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés.
7.1.3 Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par

les associés.

7.1.4 Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance n’est ou ne seront pas rémunéré(s) pour ses/leurs

services en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des associés. La Société pourra
rembourser tout gérant des dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de son mandat, y compris les dépenses
raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de
pluralité de gérants.

7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et Signature Autorisée
7.3.1 Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de

gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l’objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.

7.3.2 La Société est engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la signature

conjointe de deux des membres du conseil de gérance.

7.3.3 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour

des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc et déterminera les responsabilités du mandataire et sa

70644

L

U X E M B O U R G

rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes
de ce mandat.

7.4 - Président, Vice-Président, Secrétaire, Procédures
7.4.1 Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.

7.4.2 Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui, signés par le président et le

secrétaire (le cas échéant), seront déposées dans les livres de la Société. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui
pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président, le secrétaire ou par un quelconque gérant.

7.4.3 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés
par le gérant unique.

7.4.4 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

7.4.5 En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

7.4.6 Tout gérant pourra agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son

représentant. Un gérant pourra également désigner un autre gérant pour le représenter par téléphone, cela sera confirmé
par écrit par la suite.

7.4.7 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise lors d’une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents distincts.
La date de ces décisions sera la date de la dernière signature.

7.4.8 Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par “conference call” via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en
personne à la réunion.

7.5 - Responsabilité des Gérants
Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés.
8.1 L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
8.2 En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre

de parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital.

8.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

8.4 La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra
son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.
9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), une assemblée générale des associés doit être tenue,

conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé
dans la convocation de l'assemblée, le 16 

ème

 jour du mois d’aout, à 11.30 heures.

9.2 Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable

suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif du gérant unique ou en cas de
pluralité du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société

sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1 - Exercice Social
L’année sociale commence le premier mars de chaque année et se termine le dernier jour de février de l’année suivante.
11.2 - Comptes Annuels

70645

L

U X E M B O U R G

11.2.1 A la fin de chaque exercice social, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse

un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et
profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

11.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social

de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des
commissaire(s) établi conformément à l’article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits.
12.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

12.2 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi

longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

12.3 Le solde des bénéfices nets peut être distribué au(x) associé(s) en proportion de leur participation dans le capital

de la Société.

Art. 13. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
13.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d’un état comptable

intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées
à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

13.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-

formément à la Loi et aux présents statuts.

Art. 14. Dissolution - Liquidation.
14.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

14.2 Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.

14.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 15. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux

dispositions de la Loi.

Art. 16. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être à tout moment modifiés par l'assemblée des associés

selon le quorum et conditions de vote requis par les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social débutera à la date de constitution et se terminera le dernier jour de Février 2017.
La première assemblée générale des associés se tiendra en 2017.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts ainsi établis, la partie comparante déclare souscrire l’intégralité du capital comme suit:

Souscripteur

Nombre

de parts
sociales

Montant

souscrit

JPY

% du

capital

social

CVC Capital Partners Asia IV Limited, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000.000 13.000.000,-

100%

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000.000 13.000.000,- 100%

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de 13.000.000

JPY (treize millions de Yens Japonais) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

70646

L

U X E M B O U R G

<i>Résolutions de l’associé unique

1. La Société est administrée par les gérants suivants nommés pour une période illimitée:
a. Madame Emanuela Brero, employée privée, née le 25 mai 1970 en Bra (Italie), ayant son adresse professionnelle au

20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg;

b. Monsieur Thomas Morana, employé privé, né le 14 juin 1982 à Huy (Belgique), ayant son adresse professionnelle

au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

c. Monsieur Marc Rachman, employé privé, né le 4 avril 1958 à Glasgow (Royaume-Uni), ayant son adresse profes-

sionnelle au 111 Strand, Londres WC2R 0AG, Royaume-Uni.

2. Le siège social de la Société est établi au 33, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la partie comparante a requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la prédite partie comparante, en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le prédit mandataire a signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: S. Le Cras, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 25 février 2016. GAC/2016/1440. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 2 mars 2016.

Référence de publication: 2016074931/454.
(160038982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

ORESC 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bartringen, 37, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 204.322.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-sixth day of the month of February;
Before the undersigned notary Danielle KOLBACH, residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg

“Orpea  Real  Estate  Luxembourg  S.à  r.l.”,  having  its  registered  office  in  L-8070  Bertrange,  37,  rue  du  Puits  Romain,
registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 196576,

here represented by Mr. Christian DOSTERT, employee, residing professionally in L-8510 Redange/Attert, 66, Grand-

Rue (Grand Duchy of Luxembourg), (the “Proxy-holder”), by virtue of a proxy given under private seal; which proxy, after
having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed
in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, requests the officiating notary to enact the articles of association of a

private limited liability company, (“Gesellschaft mit beschränkter Haftung”), to establish as follows:

Chapter A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. There is hereby formed a private limited liability company (“Gesellschaft mit beschränkter Haftung”) under the

name of “ORESC 11 S.à r.l.”, (the “Company”), which will be governed by the present articles of association (the “Articles”)
as well as by the respective laws and particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial companies (the
“Law of 1915”).

Art. 2. The Company may proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,

whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer
in real estate.

The Company’s purpose is furthermore the participation in businesses and companies of any kind and the establishment,

development, administration and supervision of businesses and companies. The Company may acquire its participations
by subscription, contribution in kind, exercise of option rights and in any other way, manage and exploit them and dispose
of them by sale, assignment, exchange or in any other way.

70647

L

U X E M B O U R G

The Company may use its means to create, administer, develop and exploit a portfolio consisting of securities and patents

of any kind and origin. For this it may acquire all kinds of securities by purchase, subscription or in any other way and
alienate them by sale, assignment, exchange or in any other way.

The Company may give loans and grant advance payments and sureties to and for the benefit of its subsidiaries, affiliated

companies or any other company in which it has an economic interest, as well as to companies belonging to the same group
of companies, and support them in any way, under reserve and allowing for the respective legal provisions and without
carrying on a bank business or of the financial sector. Moreover, it may borrow in any form with or without guaranty and
mortgage, issue debt securities, loan notes or other debt instruments, pledge or otherwise hypothecate for the benefit of its
own creditors or for the benefit of creditors of companies of the aforementioned kind.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security

for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.

The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which are

in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its
purposes.

Art. 3. The duration of the Company is unlimited.

Art. 4. The Company’s registered office is established in the municipality of Bertrange (Grand Duchy of Luxembourg).
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or the board

of managers.

The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a collective

decision of the corporate unit holders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as abroad by a simple decision of the board of managers.

Chapter B. Corporate capital - Corporate units

Art. 5. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) corporate units with a nominal value of one Euro (1.- EUR) each.

Each corporate unit is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the Law of 1915.

Art. 6. The Company will recognize only one holder per corporate unit.
The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 7. The Company's corporate units are freely transferable among corporate unit holders. Inter vivos, they may only

be transferred to new corporate unit holders subject to the approval of such transfer given by the other corporate unit holders
in a general meeting, at a majority of three quarters of the corporate capital.

In the event of death, the corporate units of the deceased corporate unit holder may only be transferred to new corporate

unit holders subject to the approval of such transfer given by the other corporate unit holders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the remaining corporate capital. Such approval is, however, not required in case the corporate
units are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 8. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the corporate unit holders will not cause

the dissolution of the Company.

Art. 9. The creditors, the assignees and the heirs of the corporate unit holders may not for whatever reason affix seals

to the property and the documents of the Company nor may they interfere in any manner in the management of the Company.
They have to refer to the Company’s inventories.

Chapter C. Management - Representation

Art. 10. The Company is managed by one or several managers, appointed by a resolution of the sole partner or the

general meeting of partners, which sets the term of their office.

The manager(s) need not to be partner(s). If several managers have been appointed, they will constitute a board of

managers.

The managers may be dismissed “ad nutum”.

Art. 11. All powers not expressly reserved by the Law of 1915 or the present Articles to the general meeting of partners

fall within the competence of the sole manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not, by

the sole manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.

70648

L

U X E M B O U R G

Art. 12. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of the chairman

or any two managers at the place indicated in the convening notice.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or

represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy.
The board of managers can only deliberate and act legally, if the majority of the managers are present or represented.

The resolutions of the board of managers are valid with the majority of the votes of the present or represented managers.
Minutes of meetings of the board of managers will be signed by all managers present or represented at the meeting.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other.
The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 13. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly

made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law of 1915.

Chapter D. Decisions of the sole corporate unit holder - Collective decisions of the corporate unit holders

Art. 14. Each corporate unit holder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of corporate

units which he owns. Each corporate unit holder is entitled to as many votes as he holds or represents corporate units.

Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by corporate unit holders owning more

than half of the corporate capital.

The amendment of these Articles requires the approval of a majority of corporate unit holders representing at least three

quarters of the corporate capital.

Art. 16. The sole corporate unit holder exercises the powers granted to the general meeting of corporate unit holders

under the provisions of section XII of the Law of 1915 concerning commercial companies, as amended.

Chapter E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 17. The Company's accounting year begins on the 1 

st

 of January and ends on the 31 

st

 of December of each year.

Art. 18. Each year, with reference to December 31, the Company's accounts are established and the Managers prepare

an annual account in the form of a financial statement including profits and losses.

Each corporate unit holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortizations,

expenses and other burdens is allocated as follows:

- five percent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten

per cent (10%) of the Company's nominal corporate capital;

- the remaining amount is at the disposal of the corporate unit holders.

Art. 19. The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these
Articles.

Chapter F. Dissolution - Liquidation

Art. 20. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which

do not need to be corporate unit holders, and which are appointed by the general meeting of corporate unit holders which
will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

corporate unit holders proportionally to the corporate units of the Company held by them.

70649

L

U X E M B O U R G

Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the Company, either between the corporate unit holders

themselves or between the manager(s) and the Company, will be settled insofar as the Company’s business is concerned
by arbitration in compliance with the civil procedure.

Art. 22. For all points not regulated by these bylaws, reference is made to the provisions of the modified Law of 1915

on commercial companies.

<i>Transitory disposition

The first accounting year starts with the present day and ends on the 31 

st

 December 2016.

<i>Subscription and payment of the corporate units

The Articles having thus been established, the twelve thousand five hundred (12,500) corporate units have been sub-

scribed  by  the  sole  corporate  unit  holder,  the  company  “Orpea  Real  Estate  Luxembourg  S.à  r.l.”,  pre-designated  and
represented as said before, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of twelve
thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has
been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

<i>Decisions taken by the sole corporate unit holder

Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of the

subscribed corporate capital, has adopted the following resolutions as sole corporate unit holder:

1. The registered office of the Company is established in L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain.
2. The following persons are appointed, for an undetermined period, as the managers of the Company:
- Mr. Marc VERBRUGGEN, company director, born in Schaerbeek (Belgium) on June 24, 1955, residing professionally

in B-1620 Drogenbos, Langestraat 366 (Belgium);

- Mr. Sébastien MESNARD, directeur financier &amp; administratif, born in Versailles (France) on April 13, 1970, residing

professionally in F-10032 (CS), Puteaux, 12, rue Jean Jaurès (France);

- Mr. Tom FABER, economist, born in Munich (Federal Republic of Germany), on November 5, 1979, residing pro-

fessionally in L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain (Grand Duchy of Luxembourg).

3. The Company is validly bound in any circumstances and without restrictions by the sole signature of any manager.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-

pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand one hundred Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Redange/Attert, on the day stated at the beginning.
The deed having been read to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by

first and last name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsechszehn, am sechsundzwanzigsten Tag des Monats Februar;
Vor der unterzeichneten Notarin Danielle KOLBACH, mit Amtssitz in Redingen/Attert (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung

„Orpea Real Estate Luxembourg S.à r.l.“, mit Sitz in L-8070 Bartringen, 37, rue du Puits Romain, eingetragen im Handels-
und Firmenregister Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 196576,

hier vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-8510 Redingen/Attert, 66, Grand-

Rue (Großherzogtum Luxemburg), (der „Bevollmächtigte“), auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift;
welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und die amtierende Notarin „ne varietur“ unterschrieben, bleibt der gegenwär-
tigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Statuten einer zu gründ-

enden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Kapitel A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung „ORESC 11 S.à r.l.“ (die

„Gesellschaft“) gegründet, welche durch gegenwärtige Satzungen (die „Statuten“), sowie durch die anwendbaren Gesetze

70650

L

U X E M B O U R G

und besonders durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das „Gesetz von 1915“)
geregelt wird.

Art. 2. Die Gesellschaft kann möblierte oder nicht möblierte Immobilien erwerben, verwalten, bewirtschaften, verkaufen

oder diesbezüglich Mietverträge abschließen, und ganz allgemein Immobiliengeschäfte jeglicher Art tätigen mit der Aus-
nahme derer welche den Immobilienhändlern vorbehalten sind.

Der Gesellschaftszweck ist weiterhin die Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art und die Grün-

dung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann ihre Beteili-
gungen durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder in sonstiger Art und Weise erwerben
und durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise verwerten.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios verwenden,

welches sich aus Wertpapieren und Patenten jedweder Art und Herkunft zusammensetzen kann. Sie kann dabei alle Arten
von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder in sonstiger Art und Weise erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung
oder Tausch oder in sonstiger Weise veräußern.

Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, wie auch Unter-

nehmen,  die  zu  der  gleichen  Gruppe  gehören,  unter  Vorbehalt  und  Beachtung  der  diesbezüglich  zur  Anwendung
gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des
Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese in jedweder Art und Weise zu unterstützen.
Sie kann darüber hinaus Darlehen mit oder ohne Garantie aufnehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige Sicher-
heiten aller Art zugunsten ihrer eigenen Gläubiger oder zugunsten von Gläubigern von Unternehmen der vorbezeichneten
Art bestellen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit

oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Bartringen (Großherzogtum Luxemburg).
Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann Innerhalb der Gemeinde durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder des

Geschäftsführerrates verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen,

die für eine Änderungen der Statuten maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Lu-
xemburg verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen, Filialen, Agenturen, Büros oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großher-

zogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Kapitel B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in zwölftausendfünf-

hundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR).

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesetzes von 1915

festgelegt ist.

Art. 6. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an.
Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 7. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des restlichen

Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendenten, Deszendenten
oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 8. Der Tod, der Verlust der Bürgerrechte, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters wird

nicht die Auflösung der Gesellschaft herbeiführen.

Art. 9. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Dokumente

der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungshandlungen
einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.

70651

L

U X E M B O U R G

Kapitel C. Verwaltung - Vertretung

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, ernannt durch einen Beschluss des

Einzelgesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, welche die Dauer ihrer Mandate festlegt.

Der (die) Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein. Im Fall der Ernennung mehrerer Geschäftsführer bilden

diese die Geschäftsführung.

Die Geschäftsführer sind „ad nutum“ abrufbar.

Art. 11. Sämtliche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die vorliegenden Statuten der Gesellschafter-

versammlung vorbehaltenen Befugnisse fallen in die Zuständigkeit des Geschäftsführers bzw. bei mehreren Geschäfts-
führern in die Zuständigkeit der Geschäftsführung, der/die mit sämtlichen Befugnissen ausgestattet ist, um alle mit dem
Gesellschaftszweck zu vereinbarenden Handlungen und Geschäfte vorzunehmen und zu genehmigen.

Jeder Geschäftsführer kann beschränkte Sondervollmachten für besondere Aufgaben an einen oder mehrere Bevoll-

mächtigte erteilen, der/die kein(e) Gesellschafter zu sein braucht/brauchen.

Art. 12. Die Geschäftsführung versammelt sich so oft, wie es die Interessen der Gesellschaft erfordern sowie auf Ein-

berufung eines der Geschäftsführer an dem in der Einberufung angegebenen Versammlungsort.

Jeder Geschäftsführer erhält für jede Versammlung der Geschäftsführung mindestens 24 (vierundzwanzig) Stunden vor

dem  für  die  Versammlung  vorgesehenen  Zeitpunkt  eine  mündliche  oder  schriftliche  Mitteilung,  außer  im  Falle  einer
Dringlichkeit; in einem solchen Fall wird die Art dieser Dringlichkeit (und ihre Gründe) in der Einberufung der Versamm-
lung der Geschäftsführung kurz angegeben.

Die Versammlung kann ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer der

Gesellschaft bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Ver-
sammlung und ihre Tagesordnung informiert worden sind. Auf die Einberufung kann auch verzichtet werden, wenn das
schriftliche Einverständnis jedes Geschäftsführers der Gesellschaft entweder in Urschrift oder als Telegramm, Fax, Telex
oder E-Mail vorliegt.

Jeder Geschäftsführer kann sich durch schriftliche Ernennung eines anderen Geschäftsführers zu seinem Vertreter bei

den Versammlungen der Geschäftsführung vertreten lassen.

Die Geschäftsführung kann nur rechtsgültig beraten und handeln, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend

oder vertreten ist. Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden rechtsgültig mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden
oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Die Protokolle der Versammlungen der Geschäftsführung werden von allen bei
der Versammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet.

Jeder Geschäftsführer kann an der Versammlung der Geschäftsführung mittels Telefon-oder Videokonferenz oder ähn-

licher  Kommunikationsmittel  teilnehmen,  bei  denen  sämtliche  Versammlungsteilnehmer  sich  hören  und  miteinander
sprechen können. Die Teilnahme an der Versammlung durch eines dieser Mittel gilt als der persönlichen Teilnahme an der
Versammlung gleichwertig.

Die von allen Geschäftsführern unterzeichneten Umlaufbeschlüsse gelten als rechtsgültig gefasst, als wären sie in einer

ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung der Geschäftsführung gefasst worden. Die Unterschriften
der Geschäftsführer können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren, per Brief oder Telefax verschickten Kopien
eines identischen Beschlusses angebracht werden.

Art. 13. Die Geschäftsführer übernehmen auf der Grundlage ihres Amtes keine persönliche Haftung für Verpflichtungen,

die sie im Namen der Gesellschaft eingegangen sind, soweit diese Verpflichtungen in Übereinstimmung mit den Statuten
und den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 eingegangen wurden.

Kapitel D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 15. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Statuten benötigt die Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens

drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 16. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes von 1915 zustehen.

Kapitel E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 18. Jedes Jahr, am 31. Dezember, werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahres-

abschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

70652

L

U X E M B O U R G

Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen, Rückstellungen und sonstigen Lasten verbleibende Nettogewinn wird

wie folgt verteilt:

- fünf Prozent (5%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen,

bis diese 10% des gezeichneten Kapitals erreicht;

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 19. Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines

von den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur Ver-
fügung  stehen,  wobei  der  auszuschüttende  Betrag  selbstverständlich  nicht  die  seit  dem  Ende  des  letztes  Steuerjahres
erzielten Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich
der  übertragenen  Verluste  und  der  Summen,  die  einer  gesetzlich  oder  durch  diese  Statuten  vorgeschriebenen  Reserve
zugewiesen werden.

Kapitel F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 21. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern

selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in den Statuten festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes

von 1915 über die Handelsgesellschaften, verwiesen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2016.

<i>Zeichnung und Zahlung der Anteile

Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile durch die

alleinige Gesellschafterin, die Gesellschaft „Orpea Real Estate Luxembourg S.à r.l.“, vorgenannt und vertreten wie hiervor
erwähnt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt worden, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-
EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies
ausdrücklich bestätigt.

<i>Beschlussfassung der Alleinigen Gesellschafterin

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die erschienene Partei, welche das gesamte gezeichnete Gesell-

schaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8070 Bartringen, 37, rue du Puits Romain.
2. Folgende Personen werden, für eine unbestimmte Dauer, zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
- Herr Marc VERBRUGGEN, Geschäftsführer, geboren in Schaerbeek (Belgien), am 24. Juni 1955, beruflich wohnhaft

in B-1620 Drogenbos, Langestraat 366 (Belgien);

- Herr Sébastien MESNARD, directeur financier &amp; administratif, geboren in Versailles (Frankreich), am 13. April 1970,

beruflich wohnhaft in F-10032 (CS), Puteaux, 12, rue Jean Jaurès (Frankreich);

- Herr Tom FABER, Economist, geboren in München (Bundesrepublik Deutschland), am 5. November 1979, beruflich

wohnhaft in L-8070 Bartringen, 37, rue du Puits Romain (Großherzogtum Luxemburg).

3. Die Gesellschaft wird rechtmäßig vertreten in allen Umständen und ohne Einschränkungen durch die Einzelunter-

schrift eines Geschäftsführers.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, wird auf ungefähr tausendeinhundert Euro abge-
schätzt.

<i>Erklärung

Die unterzeichnete Notarin, welche Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der

erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen

70653

L

U X E M B O U R G

derselben erschienenen Partei, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die
englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Redingen/Attert, an dem anfangs oben angegebenen Tag, erstellt

wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, handelnd wie hiervor er-

wähnt,  der  instrumentierenden  Notarin  nach  Vor-  und  Zunamen,  Personenstand  und  Wohnort  bekannt,  hat  besagter
Bevollmächtigter mit Uns, der Notarin, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. DOSTERT - D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch-Actes Civils, le 29 février 2016. Relation: DAC/2016/3117. Reçu: 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): J. THOLL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt;

Redingen/Attert, am 03. März 2016.

Référence de publication: 2016074888/359.
(160039545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

Five Rings Commodities, Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 187.452.

L'an deux mille seize, le deux mars,
Pardevant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, sous-

signée.

Se réunit

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIVE RING COMMODITIES, ayant son

siège social au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous la section B numéro 187452, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster,
Grand-Duché de Luxembourg en date du 15 mai 2014, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations
numéro 2066 du 6 août 2014; et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Barbara Schmitt, employée privée,

demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires, présents ou représentés, et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les quatre-vingts (80) actions de catégorie A et les vingt (20) actions B d'une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune représentant l'intégralité de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

Décision sur le caractère exclusivement nominatif des actions et modification subséquente du 2 

ème

 alinéa de l'Article

5 des Statuts.

IV.- L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, il a été décidé de renoncer aux formalités

de convocation.

Les actionnaires acceptent dès lors de délibérer et de voter les points portés à l'ordre du jour. Ils confirment que toute

la  documentation  présentée  lors  de  l'assemblée  a  été  mise  à  leur  disposition  endéans  une  période  suffisante  pour  leur
permettre d'examiner attentivement chaque document.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide qu'à compter de la date du présent acte les actions sont et resteront nominatives et décide de procéder

à la modification subséquente du deuxième alinéa de l'Article 5 des Statuts qui se lira désormais comme suit:

« Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions, divisés

en quatre-vingts (80) actions A et vingt (20) actions B, ayant chacune une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR
310,-) chacune.

70654

L

U X E M B O U R G

Les actions de la société sont et resteront nominatives.
[...]»
Le reste de l'article 5 demeure inchangé.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Redange-sur-Attert, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: S. LECOMTE, B. SCHMITT, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 3 mars 2016. Relation: DAC/2016/3291. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 8 mars 2016.

Référence de publication: 2016076488/56.
(160041540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

Lux-World Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 48.864.

Faute de quorum de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 mai 2016, il y a lieu de convoquer une seconde Assemblée

Générale Extraordinaire.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Ste Zithe,

le mercredi <i>8 juin 2016 à 11.30 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du projet commun de fusion daté du 9 mars 2016 entre les sociétés LUX-AVANTAGE, LUX-EQUITY,

LUX-EURO-STOCKS,  LUX-INDEX  US,  LUX-PROTECT  FUND,  LUX-SECTORS,  LUX-TOP  50  et  LUX-
WORLD FUND.

2. Approbation de la fusion par absorption du compartiment LUX-WORLD FUND GROWTH par le compartiment

LUX-EQUITY 1 (dont la dénomination deviendra LUX-EQUITY GLOBAL) conformément aux dispositions du
projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en conséquence, transfert de l'ensemble du patrimoine
(passif et actif) de LUX-WORLD FUND GROWTH dans le compartiment LUX-EQUITY 1 (dont la dénomination
deviendra LUX-EQUITY GLOBAL) avec date d'effet au 17 juin 2016, après avoir entendu:
- le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet commun de fusion, et
- le rapport du réviseur prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparé par
Ernst &amp; Young S.A., ayant son siège social à Luxembourg et agissant en tant qu'expert indépendant; décision réservée
aux actionnaires du compartiment LUX-WORLD FUND GROWTH.

3. Approbation de la fusion par apport du compartiment LUX-WORLD FUND EMERGING MARKETS à un nouveau

compartiment de la Sicav LUX-EQUITY, qui portera la dénomination LUX-EQUITY EMERGING MARKETS,
conformément aux dispositions du projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en conséquence, transfert
de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) de LUX-WORLD FUND EMERGING MARKETS dans le comparti-
ment LUX-EQUITY EMERGING MARKETS, avec date d'effet au 17 juin 2016, après avoir entendu:
- le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet commun de fusion, et
- le rapport du réviseur prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparé par
Ernst &amp; Young S.A., ayant son siège social à Luxembourg et agissant en tant qu'expert indépendant; décision réservée
aux actionnaires du compartiment LUX-WORLD FUND EMERGING MARKETS.

4. Dissolution sans liquidation de la Société suite à la fusion.
5. Décharge aux administrateurs.
6. Divers.

Le projet commun de fusion est disponible sur simple demande et sans frais au siège social de la Société.

Les propriétaires d'actions à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils

désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

70655

L

U X E M B O U R G

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée pourra délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour sans quorum

de présence. Les résolutions pour être valables, devront réunir la moitié au moins des voix des actionnaires présents ou
représentés.

Le point (2) de l'ordre du jour sera soumis à la délibération exclusive des actionnaires du compartiment LUX-WORLD

FUND GROWTH, qui pourront valablement décider à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés
du compartiment.

Le point (3) de l'ordre du jour sera soumis à la délibération exclusive des actionnaires du compartiment LUX-WORLD

FUND EMERGING MARKETS, qui pourront valablement décider à la majorité simple des voix des actionnaires présents
ou représentés du compartiment.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016103828/755/50.

Lux-Avantage Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 46.041.

Faute de quorum de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 mai 2016, il y a lieu de convoquer une seconde Assemblée

Générale Extraordinaire.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Ste Zithe,

le mercredi <i>8 juin 2016 à 10.45 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'article 4 des statuts concernant l'objet social, qui prendra la teneur suivante : " La société a pour

objet exclusif de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées dans le but de répartir les risques
d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.
Dans le cadre de la réalisation de son objet social, la société peut notamment, sans que cette énumération soit limi-
tative, mais sous réserve du respect de la politique d'investissement conformément à l'article 20 des présents statuts,
acquérir par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi qu'aliéner par vente, échange ou de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces, gérer ou mettre en valeur le portefeuille qu'elle détiendra et, d'une façon
générale, prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet dans le sens le plus large de la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement
collectif. "

2. Modification des articles 5, 21, 25, 33 et 35 des statuts.
3. Refonte complète des statuts.
4. Approbation du projet commun de fusion daté du 9 mars 2016 entre les sociétés LUX-AVANTAGE, LUX-EQUITY,

LUX-EURO-STOCKS,  LUX-INDEX  US,  LUX-PROTECT  FUND,  LUX-SECTORS,  LUX-TOP  50  et  LUX-
WORLD FUND.

5. Approbation de la fusion par absorption du compartiment LUX-AVANTAGE I par le compartiment LUX-EQUITY

EUROPE conformément aux dispositions du projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en consé-
quence, transfert de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) de LUX-AVANTAGE I dans le compartiment LUX-
EQUITY EUROPE avec date d'effet au 17 juin 2016, après avoir entendu:
- le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet commun de fusion, et
- le rapport du réviseur prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparé par
PricewaterhouseCoopers S.C., ayant son siège social à Luxembourg et agissant en tant qu'expert indépendant.

6. Dissolution sans liquidation de la Société suite à la fusion.
7. Décharge aux administrateurs.
8. Divers.

Le projet complet des modifications statutaires ainsi que le projet commun de fusion sont disponibles sur simple demande

et sans frais au siège social de la Société.

Les propriétaires d'actions à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils

désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée pourra délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour sans quorum

de présence. Les résolutions pour être valables, devront réunir la moitié au moins des voix des actionnaires présents ou
représentés.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016103839/755/46.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

70656


Document Outline

Antargaz Luxembourg S.A.

Aurexia Luxembourg S.à r.l.

Besti's S.A.

Besti's S.A.

EuroSerLux S.A.

Fidelity International Real Estate Fund Eurozone Company 2

Fidelity International Real Estate Fund UK Company 2

Five Rings Commodities

GCC Lux S. à r.l.

Immobal S.A.

Kaderma S.A.

Kustermann Holdings S.à r.l.

Kustermann (Rosenheimer) S.à r.l.

Kustermann (TastyCo) S.à r.l.

Kyrielle Participations S.A.

Länsförsäkringar Secondary PE Investments S.A.

Lanvi S.à.r.l.

Lux-Avantage Sicav

Lux-World Fund

Maps Cologne One

Master Liffey S.à r.l.

MGE Giunchetto Wind Park S.A.

Nevio S.à.r.l.

Ntree-Lux S.A.

Oaktree (Lux.) Funds

Oakvest Holdings S.à r.l.

Opus (Public) Chartered Issuance S.A.

ORESC 11 S.à r.l.

Pineapple Aarhus Residential Holdings S.à r.l.

Pineapple Commercial 1 Holdings S.à r.l.

PLVJ Partners Luxembourg

Porphyrion S.A.

Redevco Asian Investments S.A.

Red Theatre Holdings S.à r.l.

Reinet Fund S.C.A., F.I.S.

Représentations S.A.

SECOND INVEST

Sirenis S.A.

SM Lux S.A.

Sodintec Finances S.A.

'SOMALUX' Société de Matériel Luxembourgeoise S.A., SPF

Spring Petroleum Investments Luxco 2 S.à r.l.

SPUERKEESS Ré S.A.

Uno S.A.