This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1462
20 mai 2016
SOMMAIRE
Auren International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70136
Beard Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70131
Blicon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70132
Braas Monier Building Group Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70132
Calypso International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
70162
Cathay Impex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70138
Certeco Technologies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
70139
Cidron Panel 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70136
Cocktail And Co S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70175
Code Bar S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70138
COMOI Fund S.C.A., SIF-SICAV . . . . . . . . .
70138
Contender S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70137
Cottbus Property Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70140
Dauzac Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
70136
De Boeck Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70137
Den RE Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70140
Dewey Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70140
Digital Services Holding XXII (GP) S.à r.l. . .
70137
Digital Services LV (GP) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
70151
Domus-SP SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70139
DRC European Real Estate Debt III S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70139
Elan International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70166
ICE Global Credit Funds . . . . . . . . . . . . . . . . .
70134
Ilco Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70134
Infinitas Bidco GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70141
Jade Portfolio 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70136
Kamina Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70135
Keytrade Bank Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .
70131
Lord Nominee S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70135
Lucoma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70176
Luky S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70176
Maghera S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70130
Mortgage Opportunities I Lux S.à r.l. . . . . . . .
70131
Najuma Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70130
Noper Investment S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . .
70130
Real Estate Development S.A. . . . . . . . . . . . . .
70151
SAJA Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70134
Service d'Incendie de la commune de Bour-
scheid a.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70170
Société Civile Immobilière Charline . . . . . . . .
70135
Société d'Exploitation «Bonshanz Holding
S.A.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70176
Urban Capital Holdings (Lux) S.à r.l. . . . . . . .
70132
VCP VII Luxco 6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70133
Venezia Finance S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . .
70133
Wehobi S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70133
70129
L
U X E M B O U R G
Najuma Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 130.633.
<i>Extrait des décisions de l'associé unique du 2 octobre 2012i>
<i>Troisième décisioni>
L'associé unique, nomme en remplacement de la société BS CONSULTING S.A., commissaire aux comptes, la société
SOCOGESCO INTERNATIONAL S.A. (immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 44 906) ayant son
siège social au 11, Boulevard Docteur Charles Marx, L- 2130 Luxembourg pour une durée de six années qui prendre fin
lors de l'Assemblée Générale tenue dans l'année 2018.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016077366/16.
(160042641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Noper Investment S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 195.503.
Par décision du conseil d'administration tenu en date du 29 février 2016:
LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63130, ayant son siège social au 42, Rue de la Vallée, L-2661
Luxembourg, a désigné Madame Hélène SCHORR, domiciliée professionnellement au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Lu-
xembourg, comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société NOPER INVESTMENT S.A. SPF en remplacement de Madame Tanja BERNAT, démis-
sionnaire.
Luxembourg, le 09 mars 2016.
<i>Pour: NOPER INVESTMENT S.A. SPF
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2016077369/18.
(160042423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Maghera S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 190.501.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée le 25 février 2016i>
1. L'Assemblée prend note des rapports du liquidateur et du commissaire vérificateur sur la liquidation de la Société, et
approuve les comptes de liquidation arrêtés au 31 décembre 2015.
2. L'Assemblée décide de donner décharge au liquidateur, C.G. Consulting, ayant son siège social au 40, avenue Mon-
terey à L-2163 Luxembourg, ainsi qu'au commissaire vérificateur, Co-Ventures S.A., ayant son siège social au 40, avenue
Monterey à L-2163 Luxembourg, relativement à l'exécution de leur mandat.
3. L'Assemblée décide de clôturer la liquidation.
4. L'Assemblée décide que les documents et registres de la société seront conservés pendant une période de cinq ans
suivant la publication de la présente résolution au Journal officiel au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 25 février 2016.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016077330/20.
(160042957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
70130
L
U X E M B O U R G
Mortgage Opportunities I Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 41.050,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 138.961.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Suite à une résolution circulaire prise par les associés de la Société en date du 23 décembre 2015, il a été prononcé la
clôture de la liquidation de la société Mortgage Opportunities I Lux S.à r.l., qui cessera d'exister.
Les associés ont décidé que les livres et documents de la Société resteront déposés pendant 5 années à 534, rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2016.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016077326/17.
(160043138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Keytrade Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 69.935.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de Mr Ternier en sa qualité d'administrateur
et président:
Mr Thierry Ternier: 13/02 rue Leopold II, B-8660 De Panne
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de Mr de Barsy en sa qualité d'adminis-
trateur et d'administrateur-délégué:
Mr Thibault de Barsy: 10-12 rue van der Meulen, L-2152-Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 mars 2016.
<i>Pour la Société
i>Stephane Jodin
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016077269/18.
(160042218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Beard Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 189.855.
EXTRAIT
Par résolution écrite de l'associé unique en date du 08 mars 2016, l'associé unique a décidé d'adopter les résolutions
suivantes:
1. La démission de Madame Melissa Leader de son mandat de gérant de catégorie A avec effet au 10 mars 2016.
2. La nomination de Madame Aleksandra Kaleta, née le 20 mai 1982 à Kielce, Pologne, avec adresse professionnelle
au 36-38 Wigmore Street, W1U 2LJ London, Royaume-Uni, en tant que gérant de catégorie A pour la période du 10 mars
2016 au 31 mars 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2016077002/19.
(160042798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
70131
L
U X E M B O U R G
Braas Monier Building Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.400.000,00.
Siège social: L-1748 Senningerberg, 4, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 122.155.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 2 mars 2016i>
En date du 2 mars 2016, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- de révoquer Monsieur Gerhard MUEHLBEYER de son mandat de gérant de classe A de la Société avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2016.
Braas Monier Building Group Holding S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016077010/15.
(160042295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Blicon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 53.207.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale du 22 Février 2016, accepte, à compter du 31 août 2015, la démission d'un administrateur, à
savoir:
- Monsieur Rob SONNENSCHEIN, administrateur, né le 30 août 1955 à Eindhoven (Pays-Bas), domicilié profession-
nellement au 50 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg
L'Assemblée Générale accepte, à compter du 22 Février 2016, de nommer un administrateur, à savoir:
- Madame Emilie GALLAIS, administrateur, née le 03 mai 1978 à Coutances (France), domiciliée professionnellement
au 50 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg
Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
Conformément à la circulaire RCSL 15/2 du 13 février 2015, le représentant permanent de la société Luxglobal Mana-
gement S.à r.l. est le suivant:
- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 50,
rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016077025/22.
(160042457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Urban Capital Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 77.300,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 167.088.
<i>Extrait du contrat de cession de parts socialesi>
En vertu de l'acte de transfert de parts sociales, daté du 7 mars 2016, Sparrowhawk Properties 304 PCC., a transféré la
totalité de ses parts sociales détenues dans la société de la manière suivante:
- 50 parts sociales de Catégorie A d'une valeur nominale de GBP 125.- à Urban Capital Holdings. (Jersey) PCC, une
société existant sous les lois de Jersey, ayant son siège social au Templar House, Don Road, St. Helier, JE1 2TR Jersey,
enregistrée auprès du Registre des Sociétés de Jersey sous le numéro 108452.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016076877/17.
(160041713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
70132
L
U X E M B O U R G
Venezia Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 42.290.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 février 2016.i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance.
Les sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période
de 6 ans avec effet rétroactif au 9 novembre 2015.
Ratification de la nomination de Madame Tazia BENAMEUR, en tant qu'Administrateur pour une période de 5 ans.
Monsieur Eric HERREMANS est réélu Commissaire aux Comptes avec effet rétroactif au 9 novembre 2015 à ce jour.
Monsieur Gilles PERRANG né le 13 avril 1967 à Metz, adresse professionnelle 3, avenue Pasteur L-2311 Luxembourg,
est élu Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur Eric HERREMANS à compter de ce jour jusqu'à l'as-
semblée Générale ordinaire de 2021.
<i>Pour la société
i>VENEZIA FINANCE S.A., SPF
Référence de publication: 2016076892/18.
(160041155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Wehobi S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5670 Altwies, 46, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 96.294.
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de dissolution de société, reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date
du 29 février 2016, numéro 2016/0377 de son répertoire, enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 3 mars 2016, relation:
1LAC/2016/7235 de la société à responsabilité limitée "WEHOBI S.à r.l.", avec siège social à L-5670 Altwies, 46, route
de Mondorf, inscrite au RCS à Luxembourg sous le numéro B 96 294, constituée suivant acte reçu par Maître Paul BET-
TINGEN, de résidence à Niederanven, en date du 29 septembre 2003, publié au Mémorial C, numéro 1182 du 11 novembre
2003,
- Madame Viviane HOLLERICH, seule associée, a déclaré procéder à la dissolution et à la liquidation de la société
prédite, avec effet au 29 février 2016,
- la société dissoute n'a plus d'activités.
- l'associée a déclaré en outre que la liquidation de la prédite société a été achevée et qu'elle assume tous les éléments
actifs et passifs éventuels de la société dissoute.
- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années à l'adresse suivante:
L-5630 Mondorf-les-Bains, 16, avenue Dr. Klein.
Bascharage, le 8 mars 2016.
Pour extrait conforme
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2016076905/25.
(160041828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
VCP VII Luxco 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 149.764.048,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 156.876.
Im Februar 2016 hat die Stadt Luxembourg beschlossen, die Addresse von 7a, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
in 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg zu ändern.
Luxembourg, den 07. März 2016.
Référence de publication: 2016076888/11.
(160041306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
70133
L
U X E M B O U R G
ICE Global Credit Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47-49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 155.039.
Faisant suite au conseil d'administration de la société qui s'est tenu le 27 janvier 2016, et la résolution circulaire signée
par les administrateurs le 27 janvier 2016, il a été décidé et ratifié:
- d'accepter la démission de Laya Khadjavi en tant qu'administrateur du conseil d'administration, en date du 31 janvier
2016
- d'accepter, en date du 31 janvier 2016, la co-optation de Jonathan Kaplan, né le 7 décembre 1971, à Duarte, Californie,
États-Unis et résidant professionnellement au 2000, Avenue of the Stars, 11
th
floor, Los Angeles, CA 90067, USA
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2016.
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Référence de publication: 2016077250/16.
(160042594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Ilco Lux, Société Anonyme.
Siège social: L-8057 Bertrange, 17, rue du Chemin de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 147.078.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 22 juillet 2015i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2020:
- Madame RUGO Martina, demeurant professionnellement au 17, rue du Chemin de Fer à L-8057 Bertrange, Président
- Monsieur KIEFFER Jean-Louis, demeurant professionnellement au 17, rue du Chemin de Fer à L-8057 Bertrange;
- Monsieur RUGO Marco, demeurant professionnellement au 17, rue du Chemin de Fer à L-8057 Bertrange.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2020:
- Madame Josée MAQUET, demeurant 73, rue Mameranus, L-8249 Mamer
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 9 mars 2016.
Référence de publication: 2016077253/18.
(160042367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
SAJA Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 153.560.
EXTRAIT
Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société SAJA Investments S.A., qui s'est tenue
au siège social de la société le 31 décembre 2015 que:
1. Sont révoquées de leurs postes d'administrateurs les sociétés SAJA Limited et Commercial Consulting Europe Ltd
avec effet immédiat.
2. Est révoquée de son poste d'administrateur-délégué Madame Brigitte GENTIL avec effet immédiat.
3. Est nommée en tant qu'administrateur unique Madame Brigitte GENTIL, née le 27 octobre 1951 à Charleville (France),
demeurant professionnellement au 20, rue Glesener, L-1630 Luxembourg, pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée
générale à tenir en 2022.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 mars 2016.
<i>Pour SAJA Investments S.A.
i>LPL Expert-Comptable Sàrl
Référence de publication: 2016076798/20.
(160041705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
70134
L
U X E M B O U R G
Kamina Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 152.805.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale du 22 Février 2016, accepte, à compter du 31 août 2015, la démission d'un administrateur, à
savoir:
- Monsieur Rob SONNENSCHEIN, administrateur, né le 30 août 1955 à Eindhoven (Pays-Bas), domicilié profession-
nellement au 50 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg
L'Assemblée Générale accepte, à compter du 22 Février 2016, de nommer un administrateur, à savoir:
- Madame Emilie GALLAIS, administrateur, née le 03 mai 1978 à Coutances (France), domiciliée professionnellement
au 50 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg
Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
Conformément à la circulaire RCSL 15/2 du 13 février 2015, le représentant permanent de la société Luxglobal Mana-
gement S.à r.l. est le suivant:
- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 50,
rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016077276/22.
(160042456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Lord Nominee S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 177.793.
EXTRAIT
Par résolution écrite de l'associé unique en date du 08 mars 2016, l'associé unique a décidé d'adopter les résolutions
suivantes;
1. La démission de Madame Melissa Leader de son mandat de gérant de catégorie A avec effet au 10 mars 2016.
2. La nomination de Madame Aleksandra Kaleta, née le 20 mai 1982 à Kielce, Pologne, avec adresse professionnelle
au 36-38 Wigmore Street, W1U 2LJ London, Royaume-Uni, en tant que gérant de catégorie A pour la période du 10 mars
2016 au 31 mars 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2016077288/19.
(160042840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Société Civile Immobilière Charline, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-5640 Mondorf-les-Bains, 1, Montée Belle-Vue.
R.C.S. Luxembourg E 2.469.
<i>Extrait des décisions prises par les associés en date du 4 mars 2016i>
Les associés décident d'établir le siège social à 1, Montée Belle-Vue, L-5640 Mondorf-les-Bains.
Les statuts sont modifiés comme suit:
«Le siège de la société est établi à Mondorf-les-Bains.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 mars 2016.
Référence de publication: 2016077076/13.
(160042678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
70135
L
U X E M B O U R G
Cidron Panel 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 190.970.
La dénomination de l'associé unique a changé du Nordic Capital VII Alpha Limited à Cidron Avon Limited le 9 janvier
2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2016.
Cidorn Panel 2 S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016077046/14.
(160042873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Jade Portfolio 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.100,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 131.441.
EXTRAIT
Il résulte du contrat de cession de parts sociales du 1
er
mars 2016, que l'un des associés, à savoir, BGP INVESTMENT
S.à r.l., a cédé les 18,018 parts sociales de classe A qu'il détenait dans la Société, à l'autre associé, à savoir:
- JADE MANAGEMENT HOLDING S.à r.l., société à responsabilité limitée, dont le siège social se situe au 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg et immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 116859.
Luxembourg, le 9 mars 2016.
<i>Pour JADE PORTFOLIO 2 S.à r.l.
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2016077264/17.
(160042260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Auren International S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 147.915.
Le siège de la société AUREN INTERNATIONAL S.A. inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 147915 est dénoncé avec effet au 26 février 2016 par son agent domiciliataire CAREY S.A. ayant son siège social au
19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 122743
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2016.
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2016076999/12.
(160042324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Dauzac Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 189.380.
EXTRAIT
En date du 10 mars 2016, l'actionnaire unique de la Société a résolu d'accepter la démission de Monsieur Johny Seré en
tant que Gérant de la Société.
Référence de publication: 2016078488/11.
(160043973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
70136
L
U X E M B O U R G
Digital Services Holding XXII (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.619.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 9 mars 2016i>
En date du 9 mars 2016, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de nommer Monsieur Florian FÄRBER, né le 10 mai 1982 à Bobingen, Allemagne, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 11, Ritterstrasse, 10969 Berlin, Allemagne, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société avec
effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Monsieur Lorenzo FRANZI, né le 20 mai 1983 à Etterbeek, Belgique, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 76, Oxford Street, W1D 1BS Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la
Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
En conséquence, le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Monsieur Christian SENITZ, gérant de catégorie A
- Monsieur Florian FÄRBER, gérant de catégorie A
- Monsieur Lorenzo FRANZI, gérant de catégorie A
- Monsieur Ulrich BINNINGER, gérant de catégorie B
- Monsieur Julien DE MAYER, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2016.
Digital Services Holding XXII (GP) S.à r.l.
Référence de publication: 2016078495/25.
(160043901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
De Boeck Digital, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 177.008.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2016i>
L'assemblée générale accepte la démission de la KENLOO SARL de son poste d'administrateur de la société.
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale décide de nommer nouvel administrateur Monsieur Kevin SCOUPPE, né
le 17/12/1984 à Ixelles (Belgique) et demeurant à B-1430 BRAINE L'ALLEUD, Clos Bourdon, 11. Le mandat expirera à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2019.
Référence de publication: 2016078507/12.
(160044575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Contender S.A.H., Société Anonyme Holding.
R.C.S. Luxembourg B 32.253.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 6
ème
chambre, a prononcé la dissolution
et ordonné la liquidation de la société anonyme CONTENDER S.A.H, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 32 253, dont le siège social à L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison, a été dénoncé en date
du 20 décembre 2010.
Luxembourg, le 11/03/16.
Pour extrait conforme
Me Alexandre DILLMANN
<i>Le liquidateur / Avocat à la Cour
i>9a, boulevard du Prince Henri
BP 846 L-2018 Luxembourg
Référence de publication: 2016078475/17.
(160044599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
70137
L
U X E M B O U R G
Code Bar S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9168 Mertzig, 13, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 106.182.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement du 09.03.2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale a dissous
et déclaré en état de liquidation la société à responsabilité limitée CODE BAR Sàrl, établie et ayant son siège social à
L-9168 Mertzig, 13 rue Principale, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 106182.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles PETRY et liquidateur Me Claude Speicher, avocat à
la Cour, à Diekirch.
Les déclarations de créance sont à déposer au greffe du Tribunal de commerce de Diekirch endéans les 3 semaines de
la présente publication.
Pour extrait conforme
Me Claude SPEICHER
<i>Le liquidateur / Avocat à la Couri>
Référence de publication: 2016078468/18.
(160044250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
COMOI Fund S.C.A., SIF-SICAV, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-
vestissement Spécialisé.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 170.811.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance des tiers que l'adresse de COMOI Fund Management S.A., associé gérant commandité de
la Société se trouve être désormais la suivante:
- 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, grand-Duché de Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2016.
Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Représenté par Julien François
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2016078473/18.
(160044332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Cathay Impex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9420 Vianden, 35, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 141.680.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement du 09.03.2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale a dissous
et déclaré en état de liquidation la société à responsabilité limitée CATHAY IMPEX Sàrl, établie et ayant son siège social
à L-9420 Vianden, 35 rue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 141680.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles PETRY et liquidateur Me Claude Speicher, avocat à
la Cour, à Diekirch.
Les déclarations de créance sont à déposer au greffe du Tribunal de commerce de Diekirch endéans les 3 semaines de
la présente publication.
Pour extrait conforme
Me Claude SPEICHER
<i>Le liquidateur / Avocat à la Couri>
Référence de publication: 2016078455/18.
(160044251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
70138
L
U X E M B O U R G
DRC European Real Estate Debt III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.400,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 202.115.
EXTRAIT
1) Il résulte d'une décision prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 08 mars 2016 que:
- Monsieur Kevin Hughes, née le 28 septembre 1981 à Belfast, demeurant professionnellement au 42-44, Avenue de la
Gare, L-1610 Luxembourg, a été nommée aux fonctions de gérant de la Société, à compter du 08 mars 2016 pour une durée
indéterminée.
2) Le conseil de Gérance de la Société est dorénavant composé par:
- Alexandra Fantuz
- Rolf Caspers
- Peter Dickinson
- Kevin Hughes
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2016078514/22.
(160044310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Domus-SP SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1453 Luxembourg, 33, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 84.624.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29/01/2016i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 29 janvier 2016 que:
Le conseil d'administration a nommé Maître Tessa STOCKLAUSEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1724 Luxem-
bourg, 11, bld. Prince Henri, aux fonctions de dépositaire des actions au porteur de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05.02.2016.
Jacques BOES
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2016078511/15.
(160044449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Certeco Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 176.966.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 7 mars 2016 lors de la réunion du conseil d'administration de la sociétéi>
<i>CERTECO TECHNOLOGIES S.A.i>
- M. Alexandre TASKIRAN a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 23 décembre
2015.
- Mme Joanna DROZD, employée privée, née à Opole (Pologne), le 16 juin 1980, résidant professionnellement au 127,
rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, a été cooptée administrateur de la Société avec effet au 23 décembre 2015 et
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CERTECO TECHNOLOGIES S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016078440/17.
(160043977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
70139
L
U X E M B O U R G
Dewey Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 146.337.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions des actionnaires prises en date du 9 juillet 2015 que les mandats
- des administrateurs suivants:
* Johansson Friôrik, ayant pour adresse le 9, rue Audeju, LVA - LV- 1050 Riga, administrateur;
* Vitols Daumants, ayant pour adresse le 9, rue Audeju, LVA - LV- 1050 Riga, administrateur et Président du conseil
* Hjaltason Jon Thor, ayant pour adresse le 9, rue Audeju, LVA - LV- 1012 Riga, administrateur;
* Gunnarsson Bjarni, ayant pour adresse le 9, rue Audeju, LVA - LV- 1012 Riga, administrateur;
- Du commissaire aux comptes:
* Grant Thornton Lux Audit, ayant pour adresse le 89A, Pafebruch, L-8308 Capellen, numéro B 183652;
Ont été reconduits jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2016.
<i>Pour Dewey Holding S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016078493/21.
(160043994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Den RE Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 154.825.
EXTRAIT
Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 22 février 2016 que:
La société DATA GRAPHIC SA a été révoquée de sa fonction de commissaire aux comptes
Monsieur Nicolas GODFREY, né le 27 janvier 1984 à Kortrijk (Belgique) et domicilié au 4c, Fleeschgaass L-6665
Herborn a été nommé à la fonction de commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2022.
Les mandats d'administrateurs de Monsieur Alain NOULLET, Monsieur Clive GODFREY et Monsieur Jean-Pierre
HIGUET ont été prolongés jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en 2022.
Monsieur Alain NOULLET, administrateur est désormais domicilié professionnellement au 7, rue Guillaume J. Kroll
L-1882 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016078492/18.
(160043854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Cottbus Property Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 500.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 118.811.
L'adresse de l'actionnaire, THE COTTBUS PROPERTY (GP) LIMITED, est dorénavant la suivante:
c/o Thompson Taraz LLP 4
th
Floor, Stanhope House
47 Park Lane
Londres W1K 1PR
Royaume-Uni
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2016.
Référence de publication: 2016078480/15.
(160044607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
70140
L
U X E M B O U R G
Infinitas Bidco GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 204.323.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty second day of January,
Before Us Maître Jacques Kesseler, notary residing at Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED
INFINITAS FUND L.P., a limited partnership existing under the laws of Jersey, having its registered office at Ordnance
House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey JE4 8PW and registered with the Jersey Financial Services Commission under
registration number 2109, acting by its general partner, Compass Partners Investments Master GP Limited, a limited com-
pany existing and incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at Ordnance House, 31 Pier Road, St.
Helier, Jersey JE4 8PW and registered with the Jersey Financial Services Commission under number 119909,
here represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange, by virtue of
a power of attorney, given under private seal.
The said power of attorney, initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing person and the notary, will
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated above, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation
of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:
1. Corporate form and name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of Infinitas Bidco
GP S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from
time to time (the "1915 Law").
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:
(a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
(b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or
2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution
of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles -including
Article 13.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg
Law").
2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which
would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to transfer abroad the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board of
Managers as appropriate.
2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 to act as a general partner (associé gérant commandité) of Luxembourg société(s) en commandite par actions and,
in that capacity, the Company may administer and manage such entities and their assets and decide on their investment
objectives, policies and restrictions and its course of conduct of management and business affairs and more generally, to
carry out all the objectives and purposes of such entities;
3.2 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the
Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and
other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments,
and to sell, exchange and dispose of the same;
3.3 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the
business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;
70141
L
U X E M B O U R G
3.4 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as
appropriate) thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;
3.5 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as
appropriate) thinks fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other secu-
rities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's
property (present and future), and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;
3.6 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the
sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;
3.7 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security for the performance of
the obligations of and/or the payment of any money by any person (including any body corporate in which the Company
has a direct or indirect interest or any person (a "Holding Entity") which is for the time being a member of or otherwise
has a direct or indirect interest in the Company or any body corporate in which a Holding Entity has a direct or indirect
interest and any person who is associated with the Company in any business or venture), with or without the Company
receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage,
charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property or assets (present and future) or by other means; for
the purposes of this Article 3.7 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for
the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or
otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations of any other person;
3.8 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or
privilege over or in respect of it;
3.9 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the
undertaking of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks
fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having
objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so
acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and
otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;
3.10 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,
agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or
with another person or persons;
3.11 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements
with or in favour of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate)
incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;
PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity
of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.
4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
5. Share capital.
5.1 The share capital of the Company is twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500.-) divided into twelve
thousand and five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Shares"). In these Articles,
"Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.
5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium
paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Manager
(s) subject to the 1915 Law and these Articles.
5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities
in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of
any such accounts are to be taken by the Manager(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of doubt,
any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.
5.4 All Shares have equal rights.
5.5 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.
6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the
Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative, the Company will deal with that repre-
sentative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other
payment rights.
70142
L
U X E M B O U R G
7. Transfer of shares.
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
7.2.1 shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders
holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;
7.2.2 shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding
at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged by
article 189 of the 1915 Law;
7.2.3 the transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.
8. Management.
8.1 The Company will be managed by one (1) or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders'
Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles. At all times, a majority of Managers shall be
Luxembourg residents.
8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".
The Sole Managers will at all times be tax resident in Luxembourg.
8.3 If the Company has from time to time more than one (1) Manager, they will be divided into class A managers ("Class
A Managers") and class B managers ("Class B Managers"), whereby the Class B Managers shall be at all times tax resident
in Luxembourg. The Class A Managers and the Class B Managers will collectively constitute a board of managers or conseil
de gérance (the "Board of Managers").
8.4 A Manager may be removed at any time for any reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with
Luxembourg Law and these Articles.
9. Powers of the managers. The Sole Manager, when the Company has only one (1) Manager, and at all other times the
Board of Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company,
with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.
10. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the Company is validly bound or
represented towards third parties by:
10.1 if the Company has a Sole Manager, the sole signature of the Sole Manager;
10.2 if the Company has more than one Manager, the joint signature of one (1) Class A Manager and one (1) Class B
Manager;
10.3 the sole signature of any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.
11. Agent of the managers. The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, the Board of Managers
may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent's powers
and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of its agency.
12. Board meetings.
12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers
shall appoint a chairman. The Board of Managers shall meet at least once a year in Luxembourg.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or
any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.
12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's
Representative") at a Board Meeting, for the avoidance of doubt a Class A Manager shall only represent a Class A Manager
and a Class B Manager shall only represent a Class B Manager, to attend, deliberate, vote and perform all his functions on
his behalf at that Board Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting
provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager
are physically present at a Board Meeting held in person or participate in person in a Board Meeting held under Article
12.5.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or
represented, and at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager. Decisions of the Board of Managers shall
be adopted by a simple majority, with at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager voting in favour.
12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of
conference telephone, video conference or similar form of communications equipment provided that all persons partici-
pating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this way
is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject to
Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be deemed
to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of Managers (or
70143
L
U X E M B O U R G
their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place. A meeting held in this way
is deemed to be held at the registered office. For this purpose, such a meeting shall always be initiated from the registered
office of the Company in Luxembourg.
12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative)
shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or
several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.
12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified
by any Manager present at the Meeting.
13. Shareholders' resolutions.
13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.
13.2 Subject as provided in Articles13.3, 13.4 and 13.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by
Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first
written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the resolution
may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.
13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their
participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.
13.4 Subject as provided in Article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered
Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders representing
three quarters (3/4) of the Shares.
13.5 A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint
the liquidators needs to be passed in accordance with Luxembourg Law.
13.6 A meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") may validly debate and take decisions without complying
with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening
requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised
representative.
13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders' Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.
13.8
13.8.1 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed
by written vote of Shareholders rather than at a Shareholders' Meeting provided that each Shareholder receives the precise
wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted.
13.8.2 The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting apply mutatis
mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders. Except where required by Luxembourg Law, there shall be
no quorum requirements for the passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of Shareholders shall
be validly passed immediately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission
or as e-mail attachments) of Shareholders' votes subject to the requirements as provided in Article 13.8.1 and the above
provisions of Article 13.8.2, irrespective of whether all shareholders have voted or not.
14. Business year. The Company's financial year starts on 1
st
January and end on the 31
st
December of each year
provided that, as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and
ends on the following 31 December (all dates inclusive).
14.1 If at the time the Company has more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be
held each year pursuant to article 196 of the 1915 Law on commercial companies.
15. Distributions on shares.
15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be
deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.
15.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders
declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.
15.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder
(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits
since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by
carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles
and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant
Shareholder(s).
16. Dissolution and liquidation. The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in
accordance with Luxembourg Law and Article 13. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder
70144
L
U X E M B O U R G
may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown,
of the Company.
17. Interpretation and Luxembourg law.
17.1 In these Articles:
17.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include plural and vice versa;
(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,
state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body
(whether or not having a separate legal personality);
(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications)
thereof.
17.1.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitations" and
general words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating
a particular class of acts, matters or things or by examples failing within the general words;
17.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles thus having been established, the twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been subscribed
for by INFINITAS FUND LP., prenamed and represented as said before.
All these shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500) is
forthwith at the free disposal of the Company.
<i>Transitional dispositioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31
st
December
2016.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately 1,500.- euros.
<i>General meeting of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, INFINITAS FUND L.P., representing the entirety of the subscribed
capital has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
2. The following persons are appointed as Class A Managers of the Company, for an indefinite duration:
a. Mr. Alister Wormsley, born in London, United Kingdom, on 14 November 1967 with professional address at 1
Grosvenor Place, London SW1X 7JH, United Kingdom; and
b. Mr. Franklin Rudd, born in New York, United States of America, on 24 December 1960 with professional address at
111 West Hill Road, Stamford, CT. 06902, United States of America.
3. The following person are appointed Class B Managers of the Company, for an indefinite duration:
a. Mr. Christophe Gammal, born in Uccle, Belgium, on 9 August 1967 with address at 35 rue des Merisiers, L-8253
Mamer, Grand Duchy of Luxembourg;
b. Mr. Nicolas Poncelet, born in Arlon, Belgium, on 16 June 1979 with professional address at 174 route de Longwy,
L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
c. Ms. Jana Oleksy, born in Levice, Slovakia, on 10 October 1964 with professional address at 2 avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxyholder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with Us, the notary, the present deed.
70145
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour de janvier,
Par-devant Nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
INFINITAS FUND L.P., une limited partnership, constituée et existant selon les lois de Jersey, ayant son siège social
au Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey JE4 8PW et immatriculée au Jersey Financial Services Commission,
sous le numéro d'enregistrement 2109, agissant par le biais de son associé gérant commandité, Compass Partners Invest-
ments Master GP Limited, une limited company, existant et constituée selon les lois de Jersey, ayant son siège social au
Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey JE4 8PW et immatriculée au Jersey Financial Services Commission, sous
le numéro d'enregistrement 119909.
ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement à
Pétange, en vertu d'une procuration, donnée sous seing privé.
Ladite procuration restera, signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire, restera annexée
au présent acte pour être enregistrée au même moment avec l'enregistrement.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de consti-
tution d'une société à responsabilité limitée qui est présumé devant être constituée et les statuts seront comme suit:
1. Forme juridique et dénomination sociale. Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") d'Infinitas Bidco
GP S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg y
compris la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, comme modifiée de temps à autre (la "Loi de 1915").
2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 en tout autre lieu de la même municipalité du Grand-Duché de Luxembourg par:
(a) le Gérant Unique (comme défini à l'Article 8.2) si la Société est gérée par un Gérant unique au moment du transfert;
ou
(b) le Conseil de Gérance (comme défini à l'Article 8.3) si la Société est gérée par un Conseil de gérance au moment du
transfert; ou
2.2.2 en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg (dans la même municipalité ou non) par une résolution des
associés de la Société (une "Résolution des Associés") prise en accord avec les présents Statuts - y compris l'Article 13.4
-et les lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg comme modifiées de temps à autre, y compris la Loi de 1915 (la
"Loi Luxembourgeoise").
2.3 Au cas où des événements d'ordre militaire, politique, économique, social ou de tout autre ordre de nature à com-
promettre l'activité normale au Siège Social se produiraient, ou seraient considérés comme imminents, le Siège Social
pourrait être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à un retour à la normale de la situation; de telles mesures tempo-
raires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, malgré ce transfert temporaire du Siège Social,
restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique
ou le Conseil de Gérance de la Société le cas échéant.
2.4 La Société peut avoir des bureaux et succursales, à la fois au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.
3. Objet social. La Société a pour objets:
3.1 d'agir en tant qu'associé gérant commandité de société(s) en commandite par actions luxembourgeoise(s) et, en vertu
de cette capacité, la Société peut administrer et gérer ces entités et leurs actifs et décider de leurs objectifs d'investissement,
politiques et restrictions et sa ligne de conduite de gérance et d'affaires commerciales et plus généralement, de réaliser tous
les objectifs et les buts de ces entités;
3.2 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes les entités sociales dans
lesquelles la Société détient à cet instant un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (que ce soit par souscription initiale,
appel d'offres, achat, échange ou tout autre procédé) la totalité ou partie des titres, actions ou parts, obligations, emprunts
obligataires, et tout autre titre émis ou garanti par toute personne, et tout autre actif de quelque nature qu'il soit, et de détenir
ces titres en tant qu'investissements, ainsi que de les vendre, les échanger et en disposer au même titre;
3.3 d'entreprendre toute activité ou commerce qui soit, et d'acquérir, entreprendre ou reprendre la totalité ou partie de
l'activité, des biens et/ou des dettes de toute personne exerçant une activité quelconque;
3.4 d'investir et de gérer l'argent et les fonds de la Société de la façon que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance
(le cas échéant) juge appropriée, et de prêter des sommes d'argent et d'accorder à toute personne des crédits assortis ou non
de sûretés en fonction des cas;
3.5 de conclure des emprunts, lever des fonds et sécuriser le paiement de sommes d'argent de la façon que le Gérant
Unique ou le Conseil de Gérance (le cas échéant) juge appropriée, y compris par l'émission (dans la mesure où la Loi
Luxembourgeoise l'autorise) d'obligations et de tout autre titre ou instrument, perpétuel ou non, convertible ou non, en
70146
L
U X E M B O U R G
relation ou non avec la totalité ou partie des biens de la Société (présents et futurs) ou son capital non encore levé, et
d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;
3.6 d'acquérir une participation, fusionner, se regrouper, entreprendre une consolidation ou encore de conclure un par-
tenariat ou un arrangement en vue d'un partage des profits, une communauté d'intérêts, une coopération, une société
commune (joint venture), une concession réciproque ou autre avec toute personne, y compris tout employé de la Société;
3.7 de conclure un accord de garantie ou un contrat d'indemnités ou de sûretés, et d'accorder une sûreté en vue de
l'exécution des obligations et/ou du paiement de toute somme d'argent par toute personne (y compris toute entité sociale
dans laquelle la société a un intérêt direct ou indirect (une "Entité Holding") ou toute personne qui est à cet instant un
membre ou a, de quelque façon que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la Société ou toute entité sociale dans laquelle
une Entité Holding a un intérêt direct ou indirect, et toute personne associée avec la Société dans certaines activités ou
entreprises), avec ou sans que la Société y reçoive une quelconque contrepartie ou un quelconque avantage (direct ou
indirect), et que ce soit par convention personnelle ou hypothèque, débit ou nantissement pesant sur tout ou partie des
engagements, biens, actifs (présents et futurs) de la Société, ou par tout autre moyen; pour les besoins de cet Article 3.77,
"garantie" inclut toute obligation, sous quelque forme que ce soit, de payer, de satisfaire, de fournir des fonds pour le
paiement ou la satisfaction de, d'indemniser ou d'assurer l'indemnisation contre les conséquences d'un défaut de paiement
d'une dette ou d'être plus généralement responsable de toute obligation financière ou dette à laquelle une autre personne
est tenue;
3.8 d'acheter, prendre à bail, échanger, louer ou acquérir de quelque façon que ce soit toute propriété mobilière ou
immobilière et tout droit ou privilège qui s'y rattache;
3.9 de vendre, louer, échanger ou disposer de toute propriété mobilière ou immobilière et/ou la totalité ou partie des
entreprises de la Société, en échange d'une contrepartie déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (le cas
échéant), y compris des actions, obligations ou tout autre titre, entièrement ou partiellement libérés, de toute personne, que
cette personne ait ou non les même objet social (en tout ou en partie) que la Société; détenir des actions, obligations ou
tout autre titre ainsi acquis; améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, céder ou accorder des
options, tirer profit ou encore disposer de tout ou partie des biens et des droits de la Société;
3.10 de réaliser toutes les actions envisagées en vertu de tous les paragraphes de cet Article 3 (a) où que ce soit dans le
monde; (b) en tant que partie principale, agent/représentant, prestataire, trustee, administrateur ou autre; (c) par l'intermé-
diaire de trustees, agents/représentants, sous-traitants, ou autre; et (d) seul ou avec une ou plusieurs autres personnes;
3.11 de prendre toutes les mesures nécessaires (y compris conclure et exécuter des contrats, actes, accords et arrange-
ments avec ou en faveur de toute personne) que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (le cas échéant) estime
accessoires ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, ou à l'exercice de la totalité ou partie de ses pouvoirs;
ETANT TOUJOURS ENTENDU que la Société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité
réglementée du secteur financier ou qui nécessiterait l'obtention d'une autorisation de faire le commerce en vertu de la Loi
Luxembourgeoise sans avoir obtenu préalablement l'autorisation requise conformément à la Loi Luxembourgeoise.
4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents] euros (EUR 12.500,-) divisé en douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents
Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associé" doit être interprété en
conséquence.
5.2 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel la prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera transférée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission
doivent être prises par le(s) Gérant(s) sous réserve des dispositions de la Loi de 1915 et des présents Statuts.
5.3 La Société peut, sans limite, accepter du capital ou d'autres apports sans émettre de Parts Sociales ou d'autres titres
en contrepartie de l'apport en question et peut créditer les apports sur un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à
l'utilisation de tels comptes seront prises le(s) Gérant(s), sous réserve des dispositions de la Loi de 1915 et des présents
Statuts. Afin d'éviter tout doute, il est entendu qu'il peut ainsi être décidé, sans que cela soit cependant nécessaire, d'allouer
le montant de l'apport en question à son apporteur.
5.4 Toutes les Parts Sociales confèrent les mêmes droits.
5.5 La Société peut racheter, rembourser et/ou annuler ses propres Parts Sociales sous réserve des dispositions de la Loi
de 1915.
6. Indivisibilité des parts sociales.
6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.
6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs d'une Part
Sociale notifient à la Société par écrit qui parmi eux doit être considéré comme leur représentant; la Société traitera ce
représentant comme s'il était l'unique Associé détenteur de la Part Sociale en question, y compris en matière de vote,
dividende et autres droits au paiement.
70147
L
U X E M B O U R G
7. Cession de parts sociales.
7.1 Tant que la Société n'aura qu'un Associé, les Parts Sociales seront librement cessibles.
7.2 Lorsque la Société a plus d'un Associé:
7.2.1 les parts sociales ne peuvent être cédées autrement qu'en raison de décès à des personnes autres que des Associés,
à moins que les Associés détenant au moins trois quarts des Parts Sociales aient accepté la cession lors d'une assemblée
générale;
7.2.2 les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de décès à des personnes autres que des Associés, à moins
que les Associés détenant au moins trois quarts des Parts Sociales détenues par les survivantes aient accepté la cession ou
dans les circonstances envisagées à l'article 189 de la Loi de 1915;
7.2.3 la cession de Parts Sociales est sujette aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.
8. Gérance.
8.1 La Société sera gérée par un (1) ou plusieurs gérants ("Gérants") qui seront nommés par une Résolution des Associés
adoptée conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts. A tout moment, une majorité de Gérants doivent
être des résidents luxembourgeois.
8.2 Si la Société n'a qu'un seul Gérant à un instant donné, ce Gérant sera désigné dans les présents Statuts comme le
"Gérant Unique". Le Gérant Unique sera à tout moment résident fiscal au Luxembourg.
8.3 Si la Société a plus d'un (1) Gérant à un instant donné, ces Gérants seront divisés en gérants de catégorie A ("Gérants
de Catégorie A") et gérants de catégorie B ("Gérants de Catégorie B"), selon lesquels les Gérants de Catégorie B devront
à tout moment être résidents fiscaux au Luxembourg. Les Gérants de Catégorie A et les Gérants de Catégorie B constitueront
ensemble un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").
8.4 Un Gérant peut être révoqué à tout moment pour toute cause par une Résolution des Associés adoptée conformément
à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.
9. Pouvoirs des gérants. Le Gérant Unique, quand la Société n'a qu'un (1) Gérant, et sinon le Conseil de Gérance, peut
entreprendre toute action nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception des actions réservées
aux Associés par la Loi Luxembourgeoise ou les présents Statuts.
10. Représentation. Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société est
valablement engagée ou représentée envers des tiers de la manière suivante:
10.1 si la Société a un Gérant Unique, la signature unique du Gérant Unique;
10.2 si la Société a plus d'un Gérant, la signature conjointe d'un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie
B;
10.3 la signature unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir a été délégué en vertu de l'Article 11.
11. Délégation de pouvoirs. Le Gérant Unique ou, si la Société a plus d'un Gérant, le Conseil de Gérance peut déléguer
ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs représentants ad hoc et déterminera les pouvoirs, les responsa-
bilités et la rémunération (le cas échéant) de ces représentants, la durée de leur période de représentation ainsi que toute
autre condition pertinente de sa mission.
12. Réunions du conseil de gérance.
12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil") peuvent être convoquées par tout Gérant. Le
Conseil de Gérance doit désigner un président. Le Conseil de Gérance devra se rencontrer au moins une fois par an au
Luxembourg.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans se
plier à la totalité ou partie des conditions et formalités de convocation si tous les Gérants ont renoncé à ces mêmes conditions
et formalités de convocation soit par écrit, lors de la Réunion du Conseil en question, en personne ou par l'intermédiaire
d'un représentant autorisé.
12.3 Un Gérant peut nommer un autre Gérant (mais pas une personne autre qu'un Gérant) pour le représenter (le "Re-
présentant du Gérant") lors d'une Réunion du Conseil, pour écarter tout doute un Gérant de Catégorie A pourra uniquement
représenter un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B pourra uniquement représenter un Gérant de Catégorie
B, afin d'y assister, de délibérer, de voter, et d'accomplir toutes les fonctions du Gérant en son nom pendant cette Réunion
du Conseil. Un Gérant peut représenter plusieurs autres Gérants à une Réunion du Conseil à condition (et sans préjudice
des quorums requis) qu'au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B soient physiquement présents
à une Réunion du Conseil en personne ou participent en personne à une Réunion du Conseil tenue en vertu de l'Article
12.5.
12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de Gérants est
présente ou représenté, et au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B. Les décisions du Conseil
de Gérance sont adoptées à la majorité simple, avec au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie
B votant en faveur.
70148
L
U X E M B O U R G
12.5 Un Gérant ou son Représentant du Gérant peut valablement participer à une Réunion du Conseil par conférence
téléphonique, une vidéoconférence ou par un moyen de communication similaire à condition que toutes les personnes
participant à la réunion soient capables de s'entendre et de parler entre eux tout au long de la réunion. Une personne
participant de cette façon est réputée être présente en personne à la réunion, doit être prise en compte dans le quorum et
être autorisée à voter. Sous réserve de la Loi Luxembourgeoise, toute activité traitée de cette façon par les Gérants sera,
pour les besoins des présents Statuts, réputée valablement et effectivement traitée durant une Réunion du Conseil, en dépit
d'un nombre d'Associés (ou leurs représentants) physiquement présents au même endroit inférieur au nombre requis pour
constituer un quorum. Une assemblée tenue de cette manière est considérée comme s'étant tenue au siège social. Pour cela,
cette assemblée sera toujours initiée depuis le siège social de la Société à Luxembourg.
12.6 Une résolution écrite signée par tous les Gérants (ou pour tout Gérant, par un Représentant du Gérant en question)
est aussi valable et effective que si elle avait été adoptée lors d'une Réunion du Conseil dûment convoquée et tenue, et peut
consister en un ou plusieurs documents sous la même forme, chacun signé par ou au nom d'un ou plusieurs des Gérants
concernés.
12.7 Les procès-verbaux d'une Réunion du Conseil devront être signés et les extraits de ces procès verbaux pourront
être certifiés par tout Gérant présent à la Réunion.
13. Résolutions des associés.
13.1 Chaque Associé dispose d'une voix pour chaque Part Sociale qu'il détient.
13.2 Sous réserve des stipulations des Articles 13.3, 13.4 et 13.5, les Résolutions des Associés sont valides uniquement
si elles sont adoptées par des Associés détenant plus de la moitié des Parts Sociales, étant entendu que si ce taux n'est pas
atteint lors de la première assemblée ou lors de la première consultation écrite, les Associés devront être convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et la résolution pourra être adoptée à la majorité des votes, sans
préjudice du nombre de Parts Sociales représentées.
13.3 Les Associés ne peuvent pas changer la nationalité de la Société ou obliger un Associé quelconque à augmenter sa
participation dans la Société autrement que par un vote unanime des Associés.
13.4 Sous réserve des stipulations de l'Article 13.3, toute résolution visant à modifier les présents Statuts (incluant un
changement du Siège Social), doit être adoptée à la majorité des Associés représentant les trois quarts (3/4) du capital
social, sous réserve de toute stipulation contraire.
13.5 Une résolution visant à la dissolution de la Société ou à déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou à
nommer les liquidateurs doit être adoptée selon les dispositions de la Loi Luxembourgeoise.
13.6 Une assemblée des Associés (une "Assemblée Générale") peut valablement débattre et prendre des décisions sans
se conformer complètement ou en partie aux conditions et formalités de convocation si tous les Associés ont renoncé à ces
conditions et formalités de convocation soit par écrit, soit lors de l'Assemblée Générale en question, en personne ou encore
par l'intermédiaire d'un représentant dûment autorisé.
13.7 Un Associé peut être représenté à une Assemblée Générale en nommant par écrit (ou par fax, courriel ou tout autre
moyen similaire) un mandataire qui n'a pas besoin d'être un Associé.
13.8
13.8.1 Si à un instant donné il y a moins de vingt-cinq Associés au sein de la Société, des Résolutions des Associés
peuvent être adoptées par vote écrit des Associés plutôt que durant une Assemblée Générale, à condition que chaque Associé
reçoive le libellé exact du texte des résolutions ou décisions à adopter.
13.8.2 La condition de majorité applicable à l'adoption de résolutions par l'Assemblée Générale s'applique mutatis
mutandis à l'adoption de résolutions écrites des Associés. Sauf dispositions contraires de la Loi Luxembourgeoise, aucune
condition de quorum ne doit être remplie pour l'adoption de résolutions écrites par les Associés. Les résolutions écrites des
Associés sont réputées valablement adoptées immédiatement après la réception par la Société des copies originales (ou de
copies envoyées par télécopieur ou en pièces-jointes de courriel) des votes des Associés sous réserve des conditions requises
à l'article 13.8.1, et ce que tous les associés aient voté ou non.
14. Exercice social.
14.1 L'exercice social de la Société débute le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, étant entendu
que, à titre transitoire, le premier exercice social de la Société débute le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre
suivant (toutes dates incluses).
14.2 Si à un instant donné la Société a plus de vingt-cinq Associés, au moins une assemblée générale annuelle doit être
tenue chaque année conformément à l'article 196 de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales.
15. Distributions.
15.1 Sur les bénéfices nets de la Société déterminés en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent sont
prélevés et affectés à la constitution d'une réserve légale conformément à la Loi de 1915. Ce prélèvement cessera d'être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social de la Société.
15.2 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société peut par une résolution
des Associés déclarer des dividendes dans le respect des droits respectifs des Associés.
70149
L
U X E M B O U R G
15.3 Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (le cas échéant) peut décider de payer des acomptes sur dividendes à/
aux Associé(s) avant la fin de l'exercice social si l'état comptable fait apparaître que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne dépassera pas, si applicable, les bénéfices réalisés depuis
la fin de l'exercice social précédent, auxquels sont additionnés les bénéfices reportés et les réserves distribuables, et auxquels
sont soustraites les pertes reportées et les sommes allouées à une réserve devant être constituée selon les dispositions de la
Loi de 1915 ou des présents Statuts, et que (ii) de telles sommes ainsi distribuées ne correspondant pas aux bénéfices
actuellement réalisés pourront être recouvrées auprès des Associés concernés.
16. Dissolution et Liquidation. La liquidation de la Société sera décidée par l'Assemblée Générale en conformité avec
les dispositions de la Loi Luxembourgeoise et l'Article 13 des présents Statuts. Si à cet instant la Société n'a qu'un Associé,
cet Associé peut, selon son bon vouloir, décider de liquider la Société en assumant personnellement tous les actifs et passifs
de la Société, connus ou inconnus.
17. Interprétation et loi luxembourgeoise.
17.1 Dans les présents Statuts:
17.1.1 une référence à:
(a) un genre inclut chaque genre;
(b) (à moins que le contexte ne l'exige autrement) le singulier inclut le pluriel et vice versa;
(c) une "personne" inclut une référence à tout individu, société, compagnie ("corporation") ou toute autre personne
morale, gouvernement, Etat ou agence d'Etat ou joint venture, association ou partenariat, comité d'entreprise ou organe de
représentation des employés (ayant ou non une personnalité juridique séparée);
(d) une disposition législative inclut toutes les modifications ultérieures et toute les entrées en vigueur ultérieures (avec
ou sans modifications).
17.1.2 les conjugaisons du verbe "inclure" et l'expression "y compris" sont réputées suivis des mots "sans limitation" et
on ne saura attribuer à des mots au sens général une signification restrictive en invoquant leur proximité dans le texte avec
des mots se rapportant à une classe particulière d'actions, sujets ou choses, ou par des exemples tombant dans le sens mots
généraux.
17.1.3 Les titres des Articles de ces Statuts n'affectent pas leur interprétation et leur construction.
17.2 En complément des présents Statuts, la Société est également régie par toutes les dispositions applicables de la Loi
Luxembourgeoise.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts ont été ainsi établis, les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par INFINITAS
FUND L.P., prénommé et représenté comme décrit avant.
Toutes ces parts sociales ont été entièrement libérées, et la somme de douze mille cinq cents (12.500 EUR) est immé-
diatement à la libre disposition de la Société.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera à la date de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2016.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
en raison de sa constitution, s'élève à environ 1.500,- euros.
<i>Assemblée générale de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, INFINITAS FUND L.P., représentant la totalité du capital souscrit
a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées Gérant de Catégorie A de la Société pour une durée indéterminée:
a) M. Alister Wormsley, né à Londres, Royaume-Uni, le 14 novembre 1967 ayant son adresse professionnelle au 1
Grosvenor Place, London SW1X 7JH, Royaume-Uni; et
b) M. Franck Rudd, né à New York, Etats-Unis d'Amérique, le 24 décembre 1960 et ayant son adresse professionnelle
au 111 West Hill Road, Stamford, CT. 06902, Etats-Unis d'Amérique.
3. Les personnes suivantes sont nommées Gérant de Catégorie B de la Société pour une durée indéterminée:
a) M. Christophe Gammal, né à Uccle, Belgique, le 9 août 1967 ayant son adresse au 35 rue des Merisiers, L-8253
Mamer, Grand-Duché de Luxembourg;
b) M. Nicolas Poncelet, né à Arlon, Belgique, le 16 juin 1979 ayant son adresse professionnelle au 74 route de Longwy,
L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
70150
L
U X E M B O U R G
c) Mme Jana Oleksy, née à Levice, Slovénie, le 10 octobre 1964 ayant son adresse professionnelle au 2 avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Pétange, à la date indiquée au début de ce document.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit précédemment, connu du notaire
par son nom, prénom, statuts civil et résidence, le dit mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 janvier 2016. Relation: EAC/2016/2399. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016074757/571.
(160039549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Real Estate Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 29.211.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A. tenue le 15i>
<i>février 2016 au siège de la sociétéi>
Il a été décidé ce qui suit:
- d'accepter la démission de Monsieur Nicolas Hamel, Administrateur démissionnaire;
- de nommer en qualité de nouvel Administrateur:
* Madame Marie-Aleth Hendessi, Avocat à la Cour, née le 12 septembre 1985 à Paris, 13
ème
arrondissement (France),
demeurant professionnellement au 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg;
Le mandat du nouvel Administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2018.
Le Conseil d'Administration est désormais composé comme suit: Mesdames Véronique Wauthier et Marie-Aleth Hen-
dessi et Monsieur Didier Schönberger.
Pour extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016075516/20.
(160040117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Digital Services LV (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 204.305.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fifth of February,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Digital Services LV S.à r.l., a limited liability corporation (société à responsabilité limitée) existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg with its statutory seat in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés), having its business address
at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg;
here represented by Magdalena Staniczek, private employee, professionally residing in Senningerberg, by virtue of a
proxy.
Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
70151
L
U X E M B O U R G
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company
(société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Digital Services LV (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any
Luxembourg or foreign entity.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
70152
L
U X E M B O U R G
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such
approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse
or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second
time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are
validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share
capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
70153
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.
14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if
any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
70154
L
U X E M B O U R G
(namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and
class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
70155
L
U X E M B O U R G
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2016.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Digital Services LV S.à r.l., afore-
mentioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited duration:
- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
3. Any one manager of the Company, regardless of his category, and Magdalena Staniczek, is authorized to sign solely,
on behalf of the sole shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the
Company.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechszehn, am fünfundzwanzigsten Februar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Digital Services LV S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, noch nicht eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des
Sociétés), mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg,
hier vertreten durch Magdalena Staniczek, Angestellte, geschäftsansässig in Senningerberg, gemäß einer Vollmacht.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert wurde,
wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:
70156
L
U X E M B O U R G
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit
dem Namen Digital Services LV (GP) S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen
und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-
tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
70157
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zustim-
mung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in übertragen
werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jähr-
lich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in
Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntma-
chung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit
statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in
einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die
Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,
bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten schrift-
lichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
70158
L
U X E M B O U R G
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-
punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abge-
geben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.
Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-
führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer ein anderes Mitglied des Rates der
Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore
ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen
Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
70159
L
U X E M B O U R G
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Ka-
tegorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie
B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der Kategorie
B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder
von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Katego-
rien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B),
werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens
eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii)
durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschrifts-
befugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-
klang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-
falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
70160
L
U X E M B O U R G
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise
vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von
1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung
der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an
die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2016.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Digital Services LV S.à r.l., vorbenannt,
zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesell-
schaftskapital zugeführt.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.500,-geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle
Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
Die folgende Person weird für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
70161
L
U X E M B O U R G
3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, und Magdalena Staniczek, ist er-
mächtigt, das Anteilinhaberregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für
Rechnung des alleinigen Gesellschafters zu unterzeichnen.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen Partei,
dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Namen,
Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: M. STANICZEK, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 février 2016. Relation: 1LAC/2016/6426. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 03. März 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016074643/576.
(160039025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Calypso International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg B 197.180.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue en date du 24 février 2016 que:
1. l’associé IK VII N°1 Limited Partnership a décidé de transférer à:
Pantheon International PLC, ayant son siège social à Beaufort House, 51 New North Road, Exeter, EX4 4EP, Royaume-
Uni:
- 487 parts sociales ordinaires
- 18.998 parts sociales privilégiées de classe A
- 18.998 parts sociales privilégiées de classe B
- 18.998 parts sociales privilégiées de classe C
- 18.998 parts sociales privilégiées de classe D
- 18.998 parts sociales privilégiées de classe E
Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund III, L.P., ayant son siège social à Transamerica Center, 23
rd
Floor,
600 Montgomery Street, San Francisco, CA 94111, USA:
- 372 parts sociales ordinaires
- 14.483 parts sociales privilégiées de classe A
- 14.483 parts sociales privilégiées de classe B
- 14.483 parts sociales privilégiées de classe C
- 14.483 parts sociales privilégiées de classe D
- 14.483 parts sociales privilégiées de classe E
Pantheon Multi-Strategy Co-Investment Program 2014, L.P. ?? Global Series, ayant son siège social à Transamerica
Center, 23
rd
Floor, 600 Montgomery Street, San Francisco, CA 94111, USA:
- 90 parts sociales ordinaires
- 3.528 parts sociales privilégiées de classe A
- 3.528 parts sociales privilégiées de classe B
- 3.528 parts sociales privilégiées de classe C
- 3.528 parts sociales privilégiées de classe D
- 3.528 parts sociales privilégiées de classe E
Hermes GPE PEC II LP, ayant son siège social au 1 Portsoken St, London E1 8HZ, United Kingdom:
- 210 parts sociales ordinaires
- 7.968 parts sociales privilégiées de classe A
- 7.968 parts sociales privilégiées de classe B
70162
L
U X E M B O U R G
- 7.968 parts sociales privilégiées de classe C
- 7.968 parts sociales privilégiées de classe D
- 7.968 parts sociales privilégiées de classe E
2. l’associé IK VII N°2 Limited Partnership a décidé de transférer à:
Hermes GPE PEC II LP, ayant son siège social au 1 Portsoken St, London E1 8HZ, United Kingdom:
- 132 parts sociales ordinaires
- 5.355 parts sociales privilégiées de classe A
- 5.355 parts sociales privilégiées de classe B
- 5.355 parts sociales privilégiées de classe C
- 5.355 parts sociales privilégiées de classe D
- 5.355 parts sociales privilégiées de classe E
Hermes GPE Horizon Co-investment LP, ayant son siège social au 1 Portsoken St, London E1 8HZ, United Kingdom:
- 607 parts sociales ordinaires
- 23.686 parts sociales privilégiées de classe A
- 23.686 parts sociales privilégiées de classe B
- 23.686 parts sociales privilégiées de classe C
- 23.686 parts sociales privilégiées de classe D
- 23.686 parts sociales privilégiées de classe E
HarbourVest 2015 Global Fund L.P., ayant son siège social au One Financial Center, 44
th
Floor, Boston, MA 02111,
USA:
- 84 parts sociales ordinaires
- 3.257 parts sociales privilégiées de classe A
- 3.257 parts sociales privilégiées de classe B
- 3.257 parts sociales privilégiées de classe C
- 3.257 parts sociales privilégiées de classe D
- 3.257 parts sociales privilégiées de classe E
NPS Co-Investment (A) Fund L.P., ayant son siège social au One Financial Center, 44
th
Floor, Boston, MA 02111,
USA:
- 18 parts sociales ordinaires
- 558 parts sociales privilégiées de classe A
- 558 parts sociales privilégiées de classe B
- 558 parts sociales privilégiées de classe C
- 558 parts sociales privilégiées de classe D
- 558 parts sociales privilégiées de classe E
3. l’associé IK VII N°3 Limited Partnership a décidé de transférer à:
NPS Co-Investment (A) Fund L.P., ayant son siège social au One Financial Center, 44
th
Floor, Boston, MA 02111,
USA:
- 619 parts sociales ordinaires
- 24.312 parts sociales privilégiées de classe A
- 24.312 parts sociales privilégiées de classe B
- 24.312 parts sociales privilégiées de classe C
- 24.312 parts sociales privilégiées de classe D
- 24.312 parts sociales privilégiées de classe E
HarbourVest Summit Hill Fund L.P., ayant son siège social au One Financial Center, 44
th
Floor, Boston, MA 02111,
USA:
- 228 parts sociales ordinaires
- 8.882 parts sociales privilégiées de classe A
- 8.882 parts sociales privilégiées de classe B
- 8.882 parts sociales privilégiées de classe C
- 8.882 parts sociales privilégiées de classe D
- 8.882 parts sociales privilégiées de classe E
Varma Mutual Pension Insurance Company, ayant son siège social au Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki, Finland:
- 112 parts sociales ordinaires
70163
L
U X E M B O U R G
- 4.289 parts sociales privilégiées de classe A
- 4.289 parts sociales privilégiées de classe B
- 4.289 parts sociales privilégiées de classe C
- 4.289 parts sociales privilégiées de classe D
- 4.289 parts sociales privilégiées de classe E
4. l’associé IK VII N°4 Limited Partnership a décidé de transférer à:
Varma Mutual Pension Insurance Company, ayant son siège social au Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki, Finland:
- 837 parts sociales ordinaires
- 32.720 parts sociales privilégiées de classe A
- 32.720 parts sociales privilégiées de classe B
- 32.720 parts sociales privilégiées de classe C
- 32.720 parts sociales privilégiées de classe D
- 32.720 parts sociales privilégiées de classe E
Monsieur HANS KARL ERIK PETERSSON, né le 9 septembre 1951 à Lund (Suède), domicilié à Dockgatan 27,
SE-1112 Malmo, Suède:
- 5 parts sociales ordinaires
- 180 parts sociales privilégiées de classe A
- 180 parts sociales privilégiées de classe B
- 180 parts sociales privilégiées de classe C
- 180 parts sociales privilégiées de classe D
- 180 parts sociales privilégiées de classe E
Monsieur JOHN R. NOTMAN-WATT, né le 23 juin 1963 à Guilford (Royaume-Uni), domicilié à Wychwood Close 1,
Oxshott, Surrey KT22 0JA (Royaume-Uni);
- 5 parts sociales ordinaires
- 180 parts sociales privilégiées de classe A
- 180 parts sociales privilégiées de classe B
- 180 parts sociales privilégiées de classe C
- 180 parts sociales privilégiées de classe D
- 180 parts sociales privilégiées de classe E
En conséquence, les associés détiennent les parts sociales et les parts sociales privilégiées suivantes:
IK VII N°1 Limited Partnership:
- 2.630 parts sociales
- 103.042 parts sociales privilégiées de classe A
- 103.042 parts sociales privilégiées de classe B
- 103.042 parts sociales privilégiées de classe C
- 103.042 parts sociales privilégiées de classe D
- 103.042 parts sociales privilégiées de classe E
IK VII N°2 Limited Partnership:
- 1.927 parts sociales
- 75.267 parts sociales privilégiées de classe A
- 75.267 parts sociales privilégiées de classe B
- 75.267 parts sociales privilégiées de classe C
- 75.267 parts sociales privilégiées de classe D
- 75.267 parts sociales privilégiées de classe E
IK VII N°3 Limited Partnership:
- 2.198 parts sociales
- 85.866 parts sociales privilégiées de classe A
- 85.866 parts sociales privilégiées de classe B
- 85.866 parts sociales privilégiées de classe C
- 85.866 parts sociales privilégiées de classe D
- 85.866 parts sociales privilégiées de classe E
IK VII N°4 Limited Partnership:
- 1.939 parts sociales
70164
L
U X E M B O U R G
- 75.779 parts sociales privilégiées de classe A
- 75.779 parts sociales privilégiées de classe B
- 75.779 parts sociales privilégiées de classe C
- 75.779 parts sociales privilégiées de classe D
- 75.779 parts sociales privilégiées de classe E
Pantheon International PLC
- 487 parts sociales
- 18.998 parts sociales privilégiées de classe A
- 18.998 parts sociales privilégiées de classe B
- 18.998 parts sociales privilégiées de classe C
- 18.998 parts sociales privilégiées de classe D
- 18.998 parts sociales privilégiées de classe E
Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund III, L.P.
- 372 parts sociales
- 14.483 parts sociales privilégiées de classe A
- 14.483 parts sociales privilégiées de classe B
- 14.483 parts sociales privilégiées de classe C
- 14.483 parts sociales privilégiées de classe D
- 14.483 parts sociales privilégiées de classe E
Pantheon Multi-Strategy Co-Investment Program 2014, L.P. - Global Series
- 90 parts sociales
- 3.528 parts sociales privilégiées de classe A
- 3.528 parts sociales privilégiées de classe B
- 3.528 parts sociales privilégiées de classe C
- 3.528 3 parts sociales privilégiées de classe D
- 3.528 parts sociales privilégiées de classe E
Hermes GPE PEC II LP
- 342 parts sociales
- 13.323 parts sociales privilégiées de classe A
- 13.323 parts sociales privilégiées de classe B
- 13.323 parts sociales privilégiées de classe C
- 13.323 parts sociales privilégiées de classe D
- 13.323 parts sociales privilégiées de classe E
Hermes GPE Horizon Co-investment LP
- 607 parts sociales
- 23.686 parts sociales privilégiées de classe A
- 23.686 parts sociales privilégiées de classe B
- 23.686 parts sociales privilégiées de classe C
- 23.686 parts sociales privilégiées de classe D
- 23.686 parts sociales privilégiées de classe E
HarbourVest 2015 Global Fund L.P.
- 84 parts sociales
- 3.257 parts sociales privilégiées de classe A
- 3.257 parts sociales privilégiées de classe B
- 3.257 parts sociales privilégiées de classe C
- 3.257 parts sociales privilégiées de classe D
- 3.257 parts sociales privilégiées de classe E
NPS Co-Investment (A) Fund L.P.
- 637 parts sociales
- 24.870 parts sociales privilégiées de classe A
- 24.870 parts sociales privilégiées de classe B
- 24.870 parts sociales privilégiées de classe C
- 24.870 parts sociales privilégiées de classe D
70165
L
U X E M B O U R G
- 24.870 parts sociales privilégiées de classe E
HarbourVest Summit Hill Fund L.P.
- 228 parts sociales
- 8.882 parts sociales privilégiées de classe A
- 8.882 parts sociales privilégiées de classe B
- 8.882 parts sociales privilégiées de classe C
- 8.882 parts sociales privilégiées de classe D
- 8.882 parts sociales privilégiées de classe E
Varma Mutual Pension Insurance Company
- 949 parts sociales
- 37.009 parts sociales privilégiées de classe A
- 37.009 parts sociales privilégiées de classe B
- 37.009 parts sociales privilégiées de classe C
- 37.009 parts sociales privilégiées de classe D
- 37.009 parts sociales privilégiées de classe E
Monsieur HANS KARL ERIK PETERSSON:
- 5 parts sociales
- 180 parts sociales privilégiées de classe A
- 180 parts sociales privilégiées de classe B
- 180 parts sociales privilégiées de classe C
- 180 parts sociales privilégiées de classe D
- 180 parts sociales privilégiées de classe E
Monsieur JOHN R. NOTMAN-WATT:
- 5 parts sociales
- 180 parts sociales privilégiées de classe A
- 180 parts sociales privilégiées de classe B
- 180 parts sociales privilégiées de classe C
- 180 parts sociales privilégiées de classe D
- 180 parts sociales privilégiées de classe E
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Leudelange, le 29 février 2016.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016073291/229.
(160037288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Elan International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 197.557.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of the month of February;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders (the Shareholders) of Elan International SA, a limited
liability company (société anonyme), organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38, Boulevard
Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 197.557 (the Company). The Company has been incorporated on the 5 June 2015 pursuant
to a deed of the officiating notary, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 2002 on 7 August, 2015,
and whose articles of association (the “Articles”) have not been amended since then.
The Meeting was opened at 11 am and chaired by Mrs. Angela PAZ, jurist, with professional address in Luxembourg
(the Chairman).
The Chairman appointed as Secretary Mr. Jürgen FISCHER, private employee, with professional address in Luxembourg
(the Secretary).
70166
L
U X E M B O U R G
The Meeting elects as scrutineer Mr. Klaus KRUMNAU, private employee, residing professionally in Luxembourg (the
Scrutineer).
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state that:
I. The names of the Shareholders and the number of shares they hold are shown on an attendance list (the Attendance
List). The Attendance List signed by the Shareholders, the Bureau and the undersigned notary, after having been signed
ne varietur, will remain annexed to the present deed for the purposes of registration.
II. The Company's capital is presently set at thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by three hundred ten
(310) fully paid-up shares, each with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-).
III. It appears from the Attendance List established and certified by the members of the Bureau that all the Shareholders
are present at the Meeting, so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda which have previously
been communicated to the Shareholders.
IV. The agenda of the Meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the Company's share capital by an amount of four million four hundred sixty-four thousand Euro (EUR
4,464,000.-), in order to bring it from its present amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by three
hundred ten (310) fully paid-up shares, each having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-), to four million four
hundred ninety-five thousand Euro (EUR 4,495,000.-) by the creation and issuance of forty-four thousand six hundred forty
(44,640) shares each having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) (the New Shares), in the share capital of
the Company;
2. Subscription for and payment of the New Shares as specified under item 1. by means of contributions in cash in the
aggregate amount of four million four hundred sixty-four thousand Euro (EUR 4,464,000.-);
3. Subsequent amendment of article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order
to reflect the share capital increase adopted in items 1. and 2. above;
4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given
to any director of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the New Shares in the share
register of the Company;
5. Issuance of share certificates to the subscribers of New Shares, in accordance with the Articles;
6. Modification of the name of the Company, from “Elan International S.A.” to “Eurelan S.A.”; and.
7. Miscellaneous.
V. The Meeting hereby takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting hereby resolves to increase the Company's share capital by an amount of four million four hundred sixty-
four thousand Euro (EUR 4,464,000.-), in order to bring it from its present amount of thirty one thousand Euro (EUR
31,000.-) represented by three hundred ten fully paid-up shares, having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-)
each, to four million four hundred ninety-five thousand Euro (EUR 4,495,000.-) by the creation and issuance of forty-four
thousand six hundred forty (44,640) New Shares, in the share capital of the Company.
<i>Second resolutioni>
The Meeting hereby resolves to accept and record the following subscriptions for and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription and paymenti>
1) Shareholder 1 (as identified in the Attendance List) subscribes for twenty-two thousand seven hundred fifty-two
(22,752) New Shares, each having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) and fully pays them up by way of a
contribution in cash of two million two hundred seventy-five thousand two hundred Euro (EUR 2,275,200.-).
This contribution in cash is fully allocated to the share capital account of the Company.
2) Shareholder 2 (as identified in the Attendance List) subscribes for twenty-one thousand eight hundred eighty-eight
(21,888) New Shares each having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) and fully pays them up by way of a
contribution in cash of two million one hundred eighty-eight thousand eight hundred Euro (EUR 2,188,800.-).
This contribution in cash is fully allocated to the share capital account of the Company.
The aggregate amount of four million four hundred sixty-four thousand Euro (EUR 4,464,000.-) is at the disposal of the
Company and evidence thereof has been given to the undersigned notary by a bank certificate, who expressly attests thereto.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Meeting hereby resolves to amend the first paragraph of article 5 of the
Company's articles of association, which will henceforth have the following wording:
70167
L
U X E M B O U R G
“ Art. 5.1. The share capital is set at FOUR MILLION FOUR HUNDRED NINETY-FIVE THOUSAND Euro (EUR
4,495,000.-), divided into FORTY-FOUR THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY (44,950) shares, each having a nominal
value of ONE HUNDRED Euro (EUR 100,-) and having equal rights in all respects.”
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the shareholders register of the Company in order to reflect the above changes and
empowers and authorizes any director of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the
registration of the newly issued shares.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting hereby resolves to issue share certificates to Shareholder 1 and Shareholder 2 in accordance with the
Articles, recording their registration as holders of the New Shares for which they have subscribed.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting hereby resolves to change the name of the Company from “Elan International S.A.” to “Eurelan S.A.”.
As a consequence, the Meeting resolves to amend article 1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:
“ 1. There is hereby established, by the subscriber and by all those who will become owners of the shares thereafter
created, a public limited liability company (société anonyme) under the name “Eurelan S.A.” which shall be governed by
the present articles (the “Articles”), as well as by the respective laws, especially by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies (the “Law”).”
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at three thousand four hundred
Euros (EUR 3,400.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by an French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the French version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède
L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de février;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires (les Actionnaires) de Elan International SA, une
société anonyme régie par les lois de Luxembourg, dont le siège social se situe au 38 Boulevard Napoléon I
er
, L-2210
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 197.557 (la Société). La Société a été constituée le 5 juin 2015 suivant un acte reçu par le notaire instrumentant,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2002 du 7 août 2015, et dont les statuts (les “Statuts”)
n'ont pas été modifiés depuis lors.
L'Assemblée est ouverte à onze heures et présidée par Madame Angela PAZ, juriste, demeurant professionnellement à
Luxembourg (le Président).
Le Président nomme comme secrétaire Monsieur Jürgen FISCHER, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg (le Secrétaire).
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Klaus KRUMNAU, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg (le Scrutateur).
Le Bureau constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Les noms des Actionnaires et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence (la Liste de
présence). Cette liste de présence, signée par les Actionnaires, le Bureau et le notaire instrumentant, après signature ne
varietur, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
II. Le capital de la Société est actuellement fixé à trente et un mille euros (31,000.-EUR) représenté trois cent dix (310)
actions entièrement libérées d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR).
70168
L
U X E M B O U R G
III. Il ressort de la liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que tous les Actionnaires sont présents
ou représentés à l'Assemblée de sorte que l'Assemblée peut valablement statuer sur tous les points à l'ordre du jour dont
les actionnaires présents ou représentés ont été préalablement informés.
IV. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Agenda:i>
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre millions quatre cent soixante-quatre mille euros
(4.464.000.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000.- EUR) représenté par trois
cent dix (310) actions entièrement libérées, ayant chacune une valeur nominale de cent euros (100.- EUR), à quatre millions
quatre cent quatre-vingt-quinze mille euros (4.495.000.-EUR) par la création et l'émission de quarante-quatre mille six cent
quarante (44.640) nouvelles actions ayant chacune une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) (les Nouvelles Actions),
dans le capital social de la Société;
2. Souscription et libération des Nouvelles Actions tel que précisé au point 1. par apports en numéraire d'un montant de
quatre millions quatre cent soixante-quatre mille euros (4.464.000.- EUR);
3. Modification subséquente de l'article 5 alinéa 1
er
des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y refléter l'augmentation
du capital social adoptées aux points 1. et 2. ci-dessus;
4. Modification du registre des actions de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout administrateur de la Société pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des Nouvelles Actions
dans le registre des actions de la Société;
5. Délivrance de certificats d'actions pour les Nouvelles Actions, conformément aux Statuts;
6. Changement de la dénomination sociale de la Société de «Elan International S.A.» en «Eurelan S.A.»; et.
7. Divers.
V. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre millions quatre cent soixante-
quatre mille euros (4.464.000.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000.- EUR)
représenté par trois cent dix actions, entièrement libérées, toutes ayant une valeur nominale de cent euros (100.- EUR)
chacune, à quatre millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (4.495.000.- EUR) par la création et l'émission de quarante-
quatre mille six cent quarante (44.640) Nouvelles Actions ayant une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune,
dans le capital social de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes et la libération intégrale de l'augmentation de
capital social comme suit:
<i>Souscription et libérationi>
1) Actionnaire 1 (identifié sur la Liste de présence) souscrit à vingt-deux mille sept cent cinquante-deux (22.752) Nou-
velles Actions, ayant chacune une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) et les libère intégralement par un apport en
numéraire d'un montant de deux millions deux cent soixante-quinze mille deux cent euros (2.275.200.- EUR).
Cet apport en numéraire est affecté intégralement au compte capital social de la Société.
2) Actionnaire 2 (identifié sur la Liste de présence) souscrit à vingt-et-un mille huit cent quatre-vingt-huit (21.888)
Nouvelles Actions, ayant chacune une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) et les libère intégralement par un apport
en numéraire d'un montant de deux millions cent quatre-vingt-huit mille huit cent euros (2.188.800.- EUR).
L'apport en numéraire est affecté intégralement au compte capital social de la Société.
Le montant de quatre millions quatre cent soixante-quatre mille euros (4.464.000.-EUR) est à la disposition de la Société,
dont la preuve a été donnée au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des Statuts de
la Société, lequel se lira dorénavant comme suit:
“ Art. 5.1. Le capital social est fixé à QUATRE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE
euros (4.495.000.-EUR), représenté par QUARANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE (44.950) actions
d'une valeur nominale de CENT euros (100,- EUR) chacune et ouvrent les mêmes droits à tout égard.”
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des actions de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout administrateur de la Société pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des
Nouvelles Actions ci-dessus dans le registre des actions de la Société.
70169
L
U X E M B O U R G
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de délivrer des certificats d'actions à l'Actionnaire 1 et à l'Actionnaire 2, qui prennent note de leur
enregistrement en tant que porteurs des Nouvelles Actions dans le registre des actions de la Société, conformément aux
Statuts.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société de «Elan International S.A.» en «Eurelan S.A.».
L'Assemblée décide en conséquence de modifier l'article 1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
“ Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-
après créées, une société anonyme sous la dénomination de «Eurelan S.A.» (la «Société»), laquelle sera régie par les présents
statuts (les «Statuts») ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales (la «Loi»).”
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à trois mille quatre cents euros
(3.400.-EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version française prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, lesdits com-
parants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. FISCHER, K. KRUMNAU, A. PAZ, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 25 février 2016. 2LAC/2016/4136. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Référence de publication: 2016073375/206.
(160037573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Service d'Incendie de la commune de Bourscheid a.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-9140 Bourscheid, 15, Groussgaass.
R.C.S. Luxembourg F 10.730.
STATUTEN
Am 26. Februar 2016 wird zwischen den Unterzeichneten eine Vereinigung ohne Gewinnzweck gegründet, welche dem
diesbezüglichen Gesetz vom 21. April 1928 sowie den gegenwärtigen Statuten unterliegt:
Kapitel 1. - Name / Sitz / Aufgabe und Ziel
Art. 1.1. Die Vereinigung trägt den Namen „Service d'Incendie de la commune de Bourscheid a.s.b.l.“, beziehungsweise
«Pompjeeë Gemeng Buurschent a.s.b.l.».
Art. 1.2. Sie übernimmt alle Besitztümer, Rechte und Verpflichtungen, sowie die Mitglieder des nicht rechtsfähigen
Vereins „Service d'Incendie de la commune de Bourscheid“, welcher infolge der Vereinigung der 4 lokalen Feuerwehren
(Bourscheid gegründet 1923, Kehmen gegründet 1933, Schiindermanderscheid gegründet 1953, Welscheid gegründet
1948) gegründet wurde. Dieser ist ab dem in Kraft treten der vorliegenden Statuten aufgelöst.
Im Feuerlöschwesen oder „Service d'Incendie“ werden die fusionierten früheren Wehren weiterhin als Sektionen ge-
führt.
Art. 1.3. Die Vereinigung hat ihren Sitz im Feuerwehrlokal der Gemeinde Bourscheid in L-9140 Bourscheid, 15,Grouss-
gaass. Die Adresse des Korpschefs gilt als Anschrift, falls nicht ausdrücklich eine andere Adresse angegeben ist.
Art. 1.4. Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt.
70170
L
U X E M B O U R G
Art. 1.5. Der „Service d'Incendie de la commune de Bourscheid“ ist der freiwillige Zusammenschluss von Männern und
Frauen um bei Bränden, Notständen und sonstigen Erfordernissen organisierte Hilfe zu leisten. Dies geschieht gemäß dem
Gemeindegesetz vom 13.12.1988, Artikel 100 und 101, sowie der spezifisch gültigen Gesetzgebung.
Er gehört über den Regionalverband Norden dem luxemburgischen Landesfeuerwehrverband an und steht freiwillig,
ehrenamtlich und autonom im Dienst der Gemeinde Bourscheid.
Art. 1.6. Eine weitere Aufgabe besteht darin, die Mitglieder zur Hilfsbereitschaft anzuregen, sowie die Kameradschaft
unter ihnen zu fördern und zu pflegen.
Art. 1.7. Bei der Bildung einer Jugendfeuerwehr ist sich nach den Bestimmungen des Nationalen Feuerwehrjugend-
Ausschusses zu richten.
Kapitel 2. - Leitung
Art. 2.1. Die Leitung der Wehr geschieht durch den Vorstand, an dessen Spitze der Korpschef (Chef de corps) steht.
Art. 2.2. Der Vorstand setzt sich aus einer ungeraden Anzahl an Mitgliedern zusammen. Minimal sind folgende Posi-
tionen zu besetzen :
a) 1 Korpschef
b) 1 oder 2 stellvertretende(r) Korpschef(s)
c) 1 Sekretär
d) 1 Kassierer
e) 1 Jugendleiter
f) 1 stellvertretender Jugendleiter
g) 1 Gerätewart
Die Anzahl der Mannschaftsvertreter wird vom Vorstand festgelegt.
Hierbei sind die Bestimmungen des luxemburgischen Feuerwehrverbandes und die bestehenden gesetzlichen Bestim-
mungen einzuhalten.
Kapitel 3. - Wahlen
Art. 3.1. Die Kandidaten für den Posten des Korpschefs, der stellvertretenden Korpschefs, dem Jugendleiter und dem
stellvertretenden Jugendleiter müssen die Bedingungen, die durch die Gesetze und Réglemente festgelegt sind, erfüllen.
Sie werden auf 5 Jahre mit absoluter Stimmenmehrheit (die Hälfte + 1 Stimme der abgegebenen gültigen Stimmzettel) von
der Generalversammlung in geheimer Wahl bestimmt. Die Kandidaturen müssen dementsprechend formuliert werden
Art. 3.2. Sekretär, Kassierer und Gerätewart werden in abwechselnder Reihenfolge auf die Dauer von 4 Jahren ebenfalls
von der Generalversammlung in geheimer Wahl mit einfacher Stimmenmehrheit ermittelt. Für die verschiedenen Posten
werden gesonderte Wahlgänge eingelegt. Die Kandidaturen müssen dementsprechend formuliert mindestens 8 Tage vor
der Generalversammlung schriftlich beim Korpschef eingereicht werden. Austretende Mitglieder sind wiederwählbar.
Art. 3.3. Die neugewählten Vorstandsmitglieder treten sofort nach erfolgter Wahl ihr Amt an. Sie beenden gegebenen-
falls die Amtsperiode ihrer Vorgänger.
Art. 3.4. Die Besetzung von neuen Posten im Vorstand ist dem Regionalvorstand (beim Jugendleiter und seinem Stell-
vertreter ebenfalls dem Regionaljugendleiter) schriftlich mitzuteilen. Die Wahl des Korpschefs ist umgehend dem
Zentralvorstand des luxemburgischen Feuerwehrverbandes über den zuständigen Kantonalvorstand schriftlich zu melden.
Der gewählte Kandidat ist ebenfalls dem Gemeinderat zwecks Ernennung vorzuschlagen.
Art. 3.5. Der Korpschef kann jedoch auch, falls er seine Pflichten nicht erfüllt und seinen Aufgaben nicht nachkommt,
mit einer 2/3 Stimmenmehrheit der Generalversammlung dem Gemeinderat für die Enthebung seines Amtes vorgeschlagen
werden. Die restlichen Vorstandsmitglieder können ebenfalls bei Nichterfüllung ihrer Pflichten mit einer 2/3 Stimmen-
mehrheit der Generalversammlung ihres Amtes enthoben werden.
Art. 3.6. Die Mitgliedschaft im Vorstand endet durch Tod, freiwilligen Austritt, Abberufung oder Ausschluss. Die
ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder können durch einfachen Mehrheitsbeschluss des Vorstandes bis zur nächsten or-
dentlichen Generalversammlung ersetzt werden.
Kapitel 4. - Aufgaben des Vorstandes sowie dessen Mitglieder
Art. 4.1. Die Aufgaben des Vorstandes sind:
a) die Geschäftsführung der Wehr
b) die Aufnahme bzw. der Ausschluss von Mitgliedern
c) die Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung und die Festsetzung der Tagesordnung
d) den Fortbestand der Feuerwehr mittels einer Jugendfeuerwehr zu fördern
70171
L
U X E M B O U R G
e) jede Tätigkeit, die nicht ausdrücklich durch die Statuten, die Satzung des luxemburgischen Feuerwehrverbandes oder
das Gesetz, der Generalversammlung vorbehalten ist
f) die Ausarbeitung des Ausbildungsprogramms
Die Sitzungen des Vorstandes werden vom Korpschef je nach Bedarf einberufen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn
wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.
Sind in einer Sitzung nicht genügend Mitglieder zur Beschlussfähigkeit anwesend, so wird eine neue Sitzung mit der-
selben Tagesordnung einberufen, welche dann ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig ist.
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des Korpschefs.
Art. 4.2. Der Korpschef hat unteranderem folgende Aufgaben:
a) die Leitung des Ausbildungs-, Übungs-, Brandschutz-, und Rettungsdienstes
b) die Leitung der Versammlungen, der Vorstandssitzungen sowie der Generalversammlung
c) die Beurkundung der Sitzungsberichte, der Korrespondenz und aller wichtigen Schriftstücke zusammen mit dem
Sekretär
d) bei Auftritten der Feuerwehr für Disziplin und vorschriftsmäßige Bekleidung zu sorgen
e) die Beratung der Gemeinde in allen Angelegenheiten des Brandschutzes, der Anschaffung von Feuerlösch- und
Rettungsgeräten sowie die Anregung von Verbesserungsmaßnahmen
f) die Überwachung einer ordnungsgemäßen Führung von Inventar und Dienstbuch, sowie von Anwesenheits- und
Mitgliederlisten
g) die Koordination unter den einzelnen Sektionen
Art. 4.3. Der Gerätewart hat folgende Aufgaben:
a) Führung eines Inventarbuches mit Zustandsbeschreibung der Feuerwehrgebäude
b) Führung eines Inventarbuches mit Zustandsbeschreibung des gesamten Feuerwehrmaterials
c) Koordination des Materials unter den einzelnen Sektionen
d) Vorschläge an den Korpschef betreffend Arbeiten an den Feuerwehrlokalen sowie Ankauf von Feuerwehrmaterial
Art. 4.4. Die stellvertretenden Korpschefs unterstützen den Korpschef bei der Ausübung seiner Mission und ersetzen
ihn im Abwesenheits- und Verhinderungsfall.
Art. 4.5. Der Jugendleiter betreut die Jugendfeuerwehr unter der Aufsicht des Korpschefs und gemäß den Reglementen
und Vorschriften des Feuerwehrjugend-Ausschusses. Er legt dem Korpschef Rechenschaft ab. Der Jugendleiter wird durch
einen stellvertretenden Jugendleiter unterstützt.
Art. 4.6. Der Sekretär hat folgende Aufgaben:
a) das Erstellen einer Mitgliederdatei, das Verfassen von Berichten über die Sitzungen und Versammlungen, sowie das
Führen einer Präsenzliste und des Dienstbuches
b) auf Anweisung des Korpschefs hin kümmert er sich um die Einberufung von Sitzungen, Versammlungen und anderen
Veranstaltungen
c) er erledigt sämtliche schriftliche Arbeiten, welche vom Vorstand festgelegt werden
Die Sekretariatskosten werden gegen Einreichen von Rechnungsbelegen von der Wehrkasse beglichen.
Art. 4.7. Der Kassierer:
a) hat für eine ordnungsgemäße Buchführung über die Finanzsituation der Wehr sowie über die Konten bei den Finan-
zinstituten zu sorgen
b) hält das Kassen- und Kontenbuch dem Vorstand zu jeder Zeit zur Einsicht zur Verfügung
c) begleicht Rechnungen und leistet Zahlungen, wenn sie vom Korpschef genehmigt wurden
d) er schließt am Ende des Geschäftsjahres die Kassen und Buchführung ab und lässt sie von 2 Kassenrevisoren auf ihre
Richtigkeit überprüfen sowie abzeichnen. Nach erfolgter Prüfung berichten die Kassenrevisoren dem Vorstand und der
Generalversammlung. Der Kassierer enthält Entlastung durch die Generalversammlung.
Das Rechnungsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Die 2 Kassenrevisoren werden in der vorhergehenden Generalversammlung bestimmt. Sie dürfen nicht Vorstandsmit-
glieder sein.
Kapitel 5. - Mitgliedschaft
Art. 5.1. Der „Service d'Incendie“ der Gemeinde Bourscheid besteht aus:
a) aktiven Mitgliedern,
b) inaktiven Mitgliedern,
c) Jugendmitgliedern,
70172
L
U X E M B O U R G
d) Ehrenmitgliedern,
wobei nur die aktiven Mitglieder (a) als „associés“ im Sinne des Artikels 7 des Gesetzes vom 21. April 1928 über die
Vereinigungen ohne Gewinnzweck gelten.
Art. 5.2. Die Anzahl der Mitglieder ist unbegrenzt, mit einem Minimum von 7 Aktiven.
Art. 5.3. Aktives Mitglied kann jeder Bürger, männlich oder weiblich, vom vollendeten 16. bis zum vollendeten 65.
Lebensjahr werden. Ab dem 50. Lebensjahr erfolgt die Aufnahme ohne Anrecht auf Sterbegeld und „allocation de vété-
rance".
Art. 5.4. Ein diesbezügliches Aufnahmegesuch ist an den Vorstand zu richten, der über die provisorische Aufnahme
entscheidet. Eine eventuelle Ablehnung ist zu begründen und dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen.
Der (die) Kandidat(in) muss sich einem ärztlichen Fähigkeitstest unterziehen und einen aktuellen (max. 2 Monate alt)
Auszug aus dem Strafregister vorlegen. Nach einer Probezeit von 1 Jahr entscheidet der Vorstand über die definitive
Aufnahme. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der Eltern resp. des Erziehungsberechtigten erfordert.
Jugendliche, die sich in der Jugendfeuerwehr bewährt haben, werden ab 16 Jahre mit der Zustimmung der Eltern bzw.
des Erziehungsberechtigten in die Abteilung der Aktiven übernommen.
Art. 5.5. Das neu aufgenommene Mitglied verpflichtet sich:
a) die Statuten zu achten
b) regelmäßig und pünktlich an allen Übungen, Ausbildungskursen, Versammlungen und festlichen Angelegenheiten
teilzunehmen
c) bei Bränden oder sonstigen Hilfeleistungen schnellstens und diszipliniert anzutreten und sich aktiv zu beteiligen
d) die Kameradschaft innerhalb der Mannschaft zu pflegen und zu fördern
e) den Dienstanweisungen, die von den Vorgesetzten angeordnet werden, auf freiwilliger Basis ohne Forderung auf
irgendeine Entschädigung, Folge zu leisten
Art. 5.6. Der Beitritt zur Sterbekasse der luxemburgischen Feuerwehr ist obligatorisch.
Art. 5.7. Jedes aktive Mitglied hat das Recht:
a) bei der Gestaltung des Vereinsgeschehens aktiv mitzuwirken
b) in eigener Sache gehört zu werden
c) an den Wahlen teilzunehmen
Art. 5.8. Mit dem Alter von 65 Jahren erlischt die aktive Dienstzeit und das Mitglied tritt in die Abteilung der Inaktiven
über.
Art. 5.9. Aktive Mitglieder, welche ihre Funktion als Feuerwehrmann nicht mehr ausüben können, können ebenfalls
inaktives Mitglied werden. Der Vorstand befindet über die Annahme eines diesbezüglichen Gesuches.
Aktive Mitglieder, welche 1 Jahre nicht mehr am aktiven Dienst (Übungen, Ausbildungen, Einsätzen usw.) teilgenom-
men haben, können vom Vorstand als inaktive Mitglieder beim luxemburgischen Feuerwehrverband gemeldet werden.
Art. 5.10. Inaktive Mitglieder sind von sämtlichen Verpflichtungen entbunden, können aber weiterhin an den Bege-
benheiten der Feuerwehr teilnehmen.
Erworbene Rechte auf Ehrenabzeichen, Veteranenzulage und Sterbegeld bleiben jedoch gewährt.
Art. 5.11. Jugendmitglied können männliche und weibliche Jugendliche gemäß den Regeln der luxemburgischen Feuer-
wehrjugend werden, wenn die schriftliche Zustimmung der Eltern oder des Erziehungsberechtigten vorliegt. Ein schrift-
licher Aufnahmeantrag ist an den Vorstand zu richten, welcher über die Aufnahme entscheidet.
Art. 5.12. Jedes Mitglied der Jugendfeuerwehr verpflichtet sich:
a) die Statuten zu achten
b) regelmäßig, pünktlich und aktiv an den Übungen und Veranstaltungen teilzunehmen
c) die Kameradschaft innerhalb der Feuerwehrjugend zu pflegen und zu fördern
Art. 5.13. Jedes Jugendfeuerwehrmitglied hat das Recht, aktiv bei der Gestaltung der Jugendarbeit mitzuwirken und in
eigener Sache gehört zu werden.
Art. 5.14. Die Mitgliedschaft geht verloren durch:
a) den Tod
b) freiwilligen Austritt
c) Ausschluss gemäß Art. 6.1. dieser Statuten
Art. 5.15. Beim Austritt oder Ausschluss eines Mitgliedes, sowie bei der Auflösung der Wehr, besteht kein Anrecht auf
jedwede Aus- und Rückzahlung.
70173
L
U X E M B O U R G
Das austretende Mitglied ist verpflichtet, das zu seiner Verfügung gestellte Eigentum der Wehr unvermittelt dem Vors-
tand auszuhändigen. Für etwaigen böswillig verursachten Schaden muss es aufkommen.
Art. 5.16. Wird ein Gradierter bei Wohnungswechsel aus einer anderen Wehr in die Feuerwehr der Gemeinde Bourscheid
aufgenommen, behält er seinen Grad.
Art. 5.17. Ehrenmitglied kann jeder werden, der zur Förderung und Unterstützung der Wehr den hierzu vorgeschriebenen
Jahresbeitrag leistet. Ehrenmitglieder sind nicht stimmberechtigt. Sie können entsprechend den Statuten der Mutuelle des
Sapeurs-Pompiers du Grand-Duché de Luxembourg teilhabende Mitglieder der Sterbekasse werden.
Art. 5.18. Der Mitgliederbeitrag wird von der Generalversammlung festgelegt und kann die Summe von 10 Euro (In-
dexziffer 100) nicht übersteigen.
Kapitel 6. - Ordnungsmaßnahmen
Art. 6.1. Hat ein Mitglied gegen die Statuten verstoßen, oder ist seinen Verpflichtungen nicht genügend nachgekommen,
so können folgende Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden:
a) Verweis unter 4 Augen durch den Korpschef
b) Verweis vor und durch den Vorstand
c) Ausschluss aus der Wehr durch den Vorstand
Art. 6.2. Gegen mündlich verhängte Ordnungsmaßnahmen steht jedem Mitglied das Recht auf Beschwerde zu. Diese
muss spätestens 7 Tage nach Ausspruch der Ordnungsmaßnahme schriftlich beim Vorstand eingereicht werden, der dem
Mitglied seine Entscheidung schriftlich mitteilt.
Kapitel 7. - Versammlungen
Art. 7.1. Die ordentliche Generalversammlung muss mindestens einmal jährlich innerhalb der 3 ersten Monate des Jahres
stattfinden. Die Einberufung erfolgt schriftlich durch den Vorstand wenigstens 2 Wochen vor dem festgesetzten Datum,
unter Angabe der Tagesordnung.
Eine außerordentliche Generalversammlung kann vom Vorstand einberufen werden, wenn die Umstände dies verlangen.
Bei schriftlicher Anfrage von 1/5 der Mitglieder muss eine außergewöhnliche Generalversammlung innerhalb von 30 Tagen
einberufen werden.
Art. 7.2. Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder
anwesend ist. Jedes stimmberechtigte Mitglied verfügt über nur eine Stimme. Abstimmungen erfolgen mit einfacher Stim-
menmehrheit, sofern die Statuten nichts anderes vorsehen. Bei Wahlen entscheidet bei Stimmengleichheit das Dienstalter
der Kandidaten. Ansonsten bedeutet Stimmengleichheit Ablehnung.
Art. 7.3. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden in einem Register festgehalten, in welches jedes aktive Mit-
glied und die Vertreter der Gemeindeverwaltung auf Wunsch Einsicht erhalten.
Art. 7.4. Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben:
a) die Wahl der Vorstandsmitglieder
b) die geheime Abberufung von Vorstandsmitgliedern, hierzu ist jedoch eine 2/3 Stimmenmehrheit erforderlich
c) die Genehmigung der Tätigkeits-, Kassen- und Kassenprüfberichte
d) die Entlastung des Kassierers
e) die Beratung und Beschlussfassung über eingebrachte Anträge
f) die Abänderung der Statuten, mit einer 2/3 Stimmenmehrheit, wenn 2/3 der Stimmberechtigten anwesend sind. Die
Statutenabänderung muss in dem Einberufungsschreiben ausdrücklich angegeben werden
g) sind nicht 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend, so kann eine außerordentliche Generalversammlung ein-
berufen werden. In dieser kann dann mit einer 2/3 Stimmenmehrheit über die Statutenabänderung abgestimmt werden,
unabhängig von der Zahl der Anwesenden
h) die Beratung und Entscheidung über sonstige wichtige Angelegenheiten innerhalb der Wehr, die der Vorstand nicht
verabschieden kann
i) die Auflösung der Wehr, gemäß Kapitel 8 dieser Statuten.
Art. 7.5. Zwecks Erledigung von wichtigen Angelegenheiten können weitere Mitgliederversammlungen einberufen
werden.
Kapitel 8. - Auflösung der Wehr
Art. 8.1. Die Vereinigung ist aufgelöst, wenn in einer ordentlichen Generalversammlung oder in einer eigens zu diesem
Zweck einberufenen außerordentlichen Generalversammlung zu der 2/3 der Gesamtzahl der Stimmberechtigten anwesend
sein müssen, mit 2/3 Stimmenmehrheit der Beschluss zur Auflösung gefasst wird.
70174
L
U X E M B O U R G
Sind nicht 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend, so kann eine weitere außerordentliche Generalversammlung
wie in Art. 7.1. beschrieben einberufen werden. In dieser kann dann unabhängig von der Zahl der Anwesenden mit einer
2/3 Stimmenmehrheit abgestimmt werden.
Des Weiteren erfolgt die Auflösung, wenn die Zahl der aktiven Mitglieder soweit abgesunken ist, dass die Wehr außers-
tande ist, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen.
Im Falle einer Auflösung wird das Vermögen der Wehr der Gemeinde überwiesen, mit dem Auftrag, dasselbe einer
neuen Vereinigung, die dieselben Ziele verfolgt, zu übergeben.
Kapitel 9. - Allgemeine Verfügungen
Art. 9.1. Für alle in den gegenwärtigen Statuten nicht ausdrücklich vorgesehenen Fälle gelten die Bestimmungen des
Gesetzes vom 21. April 1928 über die
Vereinigungen ohne Gewinnzweck, die Satzungen und Richtlinien des Landesfeuerwehrverbandes, die großherzogli-
chen und ministeriellen Reglemente betreffend das Feuerlösch- und Rettungswesen, sowie die Reglemente der Gemeinde
Bourscheid.
So geschrieben in Bourscheid, den 26. Februar 2016.
Référence de publication: 2016073669/242.
(160037921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
Cocktail And Co S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1261 Luxembourg, 123, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 145.654.
DISSOLUTION
L'an deux mille seize, le premier mars.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Dominique SEURIN, liquoriste, né à Sées (France) le 6 mai 1958, demeurant à L-1261 Luxembourg, 123,
rue de Bonnevoie;
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les déclarations et constatations sui-
vantes:
I.- Que la société à responsabilité limitée "Cocktail And Co S.à.r.l.", établie et ayant son siège social à L-1261 Luxem-
bourg, 123, rue de Bonnevoie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 145.654
a été constituée suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, préqualifiée en date du 7 avril 2009, publié au Mémorial
C, numéro 879 du 24 avril 2009.
II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "Cocktail And Co S.à.r.l.", préqualifiée, s'élève actuellement
à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-), représenté par CENT (100) parts sociales d'une valeur nominale
de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.
III.- Que le comparant présent ou dûment représenté déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation
financière de la susdite société "Cocktail And Co S.à.r.l.".
IV.- Que le comparant est propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associés ils
déclarent expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V.- Que le comparant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs,
passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée
sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société dissoute pour l'exécution de son mandat jusqu'à
ce jour.
VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation des parts sociales, le tout en présence du notaire instrumentant.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1261 Luxembourg, 123,
rue de Bonnevoie;
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison de présentes, sont évalués approximativement à ONZE CENTS EUROS (1.100 EUR).
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante agissant en ses dites qualités, connue du notaire par ses
nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
signé avec Nous notaire le présent acte.
70175
L
U X E M B O U R G
Signé: Dominique Seurin, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 mars 2016. Relation: EAC/2016/5399. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 03 mars 2016.
Référence de publication: 2016073958/47.
(160038994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Société d'Exploitation «Bonshanz Holding S.A.», Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 172.257.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société Société d'Exploitation «Bonshanz Holdingi>
<i>S.A.» qui s'est tenue en date du 15 février 2016i>
Il a été décidé ce qui suit:
- après délibération, le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Nicolas Hamel en sa qualité
d'Administrateur de la Société et décide de coopter en remplacement Madame Marie-Aleth Hendessi, Avocat à la Cour,
demeurant professionnellement au 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.
Le mandat du nouvel Administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2018.
Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:
Mesdames Véronique Wauthier et Marie-Aleth Hendessi et Monsieur Didier Schönberger.
Extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016075528/19.
(160040138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Luky S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 187.074.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1 i>
<i>eri>
<i> Février 2016i>
L'Assemblée prend note de la nouvelle adresse de l'Administrateur
Monsieur Predrag SAVIC, gérant de société, né à 20 janvier 1957 à Padez (Serbie), demeurant professionnellement à
2163 Luxembourg 29 avenue Monterey
Pour extrait Conforme
Référence de publication: 2016077309/12.
(160042767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Lucoma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9538 Wiltz, 1, Gruberbeerig.
R.C.S. Luxembourg B 98.985.
Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration du 1
er
février 2016, que le siège social de la société a été transféré
de son adresse actuelle
L - 9519 Wiltz 2, Route d'Ettelbruck
à l'adresse suivante:
L - 9538 WILTZ 1, Gruberbeerig
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2016078004/13.
(160043104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
70176
Auren International S.A.
Beard Investment S.à r.l.
Blicon S.A.
Braas Monier Building Group Holding S.à r.l.
Calypso International S.à r.l.
Cathay Impex S.à r.l.
Certeco Technologies S.A.
Cidron Panel 2 S.à r.l.
Cocktail And Co S.àr.l.
Code Bar S. à r.l.
COMOI Fund S.C.A., SIF-SICAV
Contender S.A.H.
Cottbus Property Sàrl
Dauzac Investments S.à r.l.
De Boeck Digital
Den RE Invest S.A.
Dewey Holding S.A.
Digital Services Holding XXII (GP) S.à r.l.
Digital Services LV (GP) S.à r.l.
Domus-SP SA
DRC European Real Estate Debt III S.à r.l.
Elan International S.A.
ICE Global Credit Funds
Ilco Lux
Infinitas Bidco GP S.à r.l.
Jade Portfolio 2 S.à r.l.
Kamina Corporation S.A.
Keytrade Bank Luxembourg S.A.
Lord Nominee S.à r.l.
Lucoma S.A.
Luky S.A., SPF
Maghera S.A., SPF
Mortgage Opportunities I Lux S.à r.l.
Najuma Immo S.A.
Noper Investment S.A. SPF
Real Estate Development S.A.
SAJA Investments S.A.
Service d'Incendie de la commune de Bourscheid a.s.b.l.
Société Civile Immobilière Charline
Société d'Exploitation «Bonshanz Holding S.A.»
Urban Capital Holdings (Lux) S.à r.l.
VCP VII Luxco 6 S.à r.l.
Venezia Finance S.A., SPF
Wehobi S.à.r.l.