logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1243

27 avril 2016

SOMMAIRE

AIM Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59622

Airfly Motorsport S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59619

Cale Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59618

CapAssurances S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59619

Carpini S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59618

Cavallo Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59619

Ceca Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59622

COM-Invest Management Distriland S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59622

Ed Business & Cie S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

59623

Energering Consult S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

59622

Exul Investissements Immobiliers S.A.  . . . . . .

59620

Fiduciaire Comptable et Fiscale de Martelange

SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59620

Gaj Invest SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59623

Garage Intini S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59623

GEORGES BOISSENET, Société à responsa-

bilité limitée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59618

Heirens Constructions S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

59623

HPS Cactus Direct Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

59624

Inerit S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59620

IRE Asia Lux HoldCo 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

59618

JC Trading S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59618

Josy Welter Bertrange S.à.r.l  . . . . . . . . . . . . . .

59622

Landa Bay Mediainvest  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59655

La Rose Blanche Immobilière S.A.  . . . . . . . . .

59618

Lazada Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59637

Les Jardins d'Altlinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59620

Lion Property  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59657

Loisirs Ré S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59620

Magewo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59661

Malasi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59621

Malasi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59621

Malasi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59621

Mar Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59633

M.A.V.I. Coaching S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

59620

Mercedes-Benz Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . .

59621

Micro Focus Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

59659

Milestone Investisseurs 2014 GP S.à r.l.  . . . . .

59621

Milestone Investisseurs GP S.à r.l. . . . . . . . . . .

59621

NGS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59619

PFCE Czech I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59664

Rigatte SA, SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59619

Stratton II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59623

Tataski Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59622

Torno Global Contracting S.A.  . . . . . . . . . . . .

59664

59617

L

U X E M B O U R G

Cale Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 99.373.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079981/9.
(160045791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.

Carpini S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 75, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 44.710.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079988/9.
(160046661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.

GEORGES BOISSENET, Société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 88, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 37.470.

Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016080129/9.
(160046587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.

IRE Asia Lux HoldCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 185.296.

Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016080213/9.
(160046559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.

JC Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3841 Schifflange, Dumontshaff.

R.C.S. Luxembourg B 192.333.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016080223/9.
(160045873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.

La Rose Blanche Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 106.290.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016080245/9.
(160046317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.

59618

L

U X E M B O U R G

Airfly Motorsport S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3313 Bergem, 76, Grand Rue.

R.C.S. Luxembourg B 176.084.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079150/9.
(160045565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

CapAssurances S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8393 Olm, 15, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 171.563.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079224/9.
(160045137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

Cavallo Lux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 160.647.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079226/9.
(160045704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

Rigatte SA, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emilie Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 130.851.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RIGATTE SA, SPF
Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial

Référence de publication: 2016080420/11.
(160046230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.

NGS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 175.762.

Le bilan au 30.09.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 15 mars 2016.

<i>Pour la société
COFICOM Trust S.à r.l.
B. P. 126
50, Esplanade
L-9227 DIEKIRCH
Signature

Référence de publication: 2016080316/16.
(160045912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.

59619

L

U X E M B O U R G

Exul Investissements Immobiliers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 108.564.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078565/9.
(160044535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Fiduciaire Comptable et Fiscale de Martelange SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 6, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 91.760.

Les comptes annuels au 31-12-15 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078569/9.
(160044244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Inerit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 102.618.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078686/9.
(160044730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Les Jardins d'Altlinster, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 180.243.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078732/9.
(160044496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Loisirs Ré, Loisirs Ré S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 163.885.

Les comptes annuels au 30/09/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078756/9.
(160043584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

M.A.V.I. Coaching S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 193.408.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078762/9.
(160044058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

59620

L

U X E M B O U R G

Milestone Investisseurs GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 184.048.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078769/9.
(160043622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Milestone Investisseurs 2014 GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 192.246.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078770/9.
(160043611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Malasi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 665, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 81.143.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078775/9.
(160043757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Malasi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 665, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 81.143.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078776/9.
(160043945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Malasi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 665, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 81.143.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078777/9.
(160044073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Mercedes-Benz Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1248 Luxembourg, 45, rue de Bouillon.

R.C.S. Luxembourg B 57.028.

Der Jahresabschluss vom 01.01. -31.12.2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078787/9.
(160044466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

59621

L

U X E M B O U R G

Ceca Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 146.022.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CECA INVEST S.A.

Référence de publication: 2016078459/10.
(160043690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

COM-Invest Management Distriland S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 141.243.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AGIF S.A.

Référence de publication: 2016078469/10.
(160044260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Energering Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Tataski Holdings S.à r.l.).

Siège social: L-9772 Troine, Maison 32.

R.C.S. Luxembourg B 144.050.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078548/9.
(160044624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

AIM Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 74.676.

La Société a été constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, en date du 25 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n° 449 du 26 juin 2000.

Les comptes annuels de la Société au 31 août 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AIM Services S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2016079147/15.
(160045659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

Josy Welter Bertrange S.à.r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 28.511.

Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

JOSY WELTER BERTRANGE S.à r.l.

Référence de publication: 2016080225/10.
(160046490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.

59622

L

U X E M B O U R G

Gaj Invest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 137.269.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016079395/10.
(160044976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

Garage Intini S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 8B, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 62.077.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079396/9.
(160045431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

Heirens Constructions S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7738 Colmar, 17, rue Colmar-Pont.

R.C.S. Luxembourg B 102.858.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Le gérant

Référence de publication: 2016079428/11.
(160045099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

Ed Business &amp; Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 172.680.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2016.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2016079319/12.
(160045205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

Stratton II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 273.600,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 100.033.

Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
STRATTON II S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2016080495/12.
(160046194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.

59623

L

U X E M B O U R G

HPS Cactus Direct Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 203.614.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of December.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Highbridge Principal Strategies - Cactus Direct Lending Fund, L.P., a limited partnership incorporated under the laws

of the Cayman Islands, having its registered office at The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, City of Wil-
mington, County of New Castle, Delaware 19801, registered with the Secretary of State of Delaware,

here represented by Mrs Stefanie Kreuzer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company

(société à responsabilité limitée) which the appearing party wishes to incorporate with the following articles of association:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “HPS Cactus Direct Lux Sàrl” (the “Company”). The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), and these articles of incorporation
(the “Articles”).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises

in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription,  purchase  and  exchange  or  in  any  other  manner,  any  stock,  shares  and  other  participation  securities,  bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and

protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to

real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.

59624

L

U X E M B O U R G

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance

with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the “Board”).

The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or
several class B managers.

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of one manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle

shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except

in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have

full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the
meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if half of its members are present or represented, provided that if the

shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A
manager and one (1) class B manager shall be present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a
majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have appointed one or several
class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager votes
in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if
no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (“Managers' Circular Resolutions”) shall be valid and binding as

if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the sole manager or, in case of

plurality of managers by the joint signature of any two managers. If the shareholders have appointed one or several class

59625

L

U X E M B O U R G

A managers and one or several class B managers, the Company shall be bound towards third parties in all matters by the
joint signature of any class A manager and any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers

have been delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the

managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any

commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at

a general meeting of shareholders (each a “General Meeting”).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may

be adopted in writing (“Written Shareholders' Resolutions”).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting

following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders.

The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each
manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda

of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to

be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the

share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the
votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least

three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company

shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall

bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is

to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
owed by its managers and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:

59626

L

U X E M B O U R G

(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the

end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders'
Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.

Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors

(réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their
number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be su-

pervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more approved
external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual General
Meeting. They may or may not be shareholders.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the “Legal

Reserve”). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;

and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the

distribution of an interim dividend.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Com-
pany's assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-

holders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders

Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one
original  or  several  counterparts  of  the  same  document,  all  of  which  taken  together  shall  constitute  one  and  the  same
document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law

and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on the thirty-first (31)

of December 2016.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

59627

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and payment

The twelve thousand and five hundred (12,500) shares issued have been entirely subscribed by Highbridge Principal

Strategies - Cactus Direct Lending Fund, L.P., aforementioned, for the price of one euro (EUR 1) each.

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five

hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500 is entirely allocated to the

share capital.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne

by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder of the Company, representing the entire share capital of the Company and having waived any

convening requirements, has passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 46A, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as A managers of the Company for an unlimited term:
- Ms. Faith Rosenfeld, director, born on 22 December 1951 in Massachusetts, U.S.A., with professional address at 40

West, 57 

th

 Street, 33 

rd

 Floor, New York 10019, U.S.A.;

- Mr. Marcus Colwell, director, born on 23 May 1962 in Michigan, U.S.A., with professional address at 40 West, 57

th

 Street, 33 

rd

 Floor, New York 10019, U.S.A.; and

- Mr. Emmanuel Bresson, director, born on 22 January 1968 in Clermont-Ferrand, France, with professional address at

Highbridge Principal Strategies (UK) LLP, 2 

nd

 floor, 25 St. James's Street, London, SW1A 1HA, United Kingdom.

3. The following persons are appointed as B managers of the Company for an unlimited term:
- Mr. Robert Jan Schol, private employee, born on 1 August 1959 in Delft, Netherlands, with professional address at

46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Jan Lubawinski, private employee, born on 11 February 1976 in Berlin-Friedrichshain, Germany, with professional

address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Armando José Brochado Soares Correia, private employee, born on 7 April 1984 in Lisbon, Portugal, with pro-

fessional address at 2A rue de l'Ouest L-2273, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this

deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and

residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le onze décembre.
Par devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Highbridge Principal Strategies - Cactus Direct Lending Fund, L.P., a limited partnership incorporated under the laws

of the Cayman Islands, having its registered office at The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, City of Wil-
mington, County of New Castle, Delaware 19801, registered with the Secretary of State of Delaware,

ici représentée par Stefanie Kreuzer, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Laquelle comparante a requis le notaire officiant à adopter l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée -

private limited company- que la comparante souhaite intégrer avec les statuts suivants:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est «HPS Cactus Direct Lux Sàrl» (la «Société»). La Société est une

société à responsabilité limitée régie sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

59628

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par

décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires
d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments
financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets
ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever
de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation
requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investisse-

ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres
risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cent (12.500)

parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la

Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés

59629

L

U X E M B O U R G

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les

associés peuvent décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et un
ou plusieurs gérants de classe B.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,

qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au

Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures

à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la
convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux

déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés,

pourvu qu'au cas où les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au
moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B soient présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont
valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, pourvu qu'au cas où les associés ont nommé
un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un (1) gérant de classe A et un (1)
gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés
par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des «Résolutions Circulaires des Gérants») sont valables

et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, en cas de

pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants. Si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe
A et un ou plusieurs gérants de classe B, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures
conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs

spéciaux ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux

gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont adoptées

en assemblée générale des associés (chacune une «Assemblée Générale»).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être

adoptées par écrit (des «Résolutions Ecrites des Associés»).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

59630

L

U X E M B O U R G

(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer

une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la

date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les

associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés

de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute

Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées,
sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au

moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec les quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.

Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés

doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérant[s] et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice

social en question soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites des
Associés; ou

(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.

Art. 14. Commissaires/Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus

par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur mandat.

14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires

à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires sont sujet
à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve

Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2.  Les  associés  décident  de  l'affectation  du  solde  des  bénéfices  nets  annuels.  Ils  peuvent  allouer  ce  bénéfice  au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

59631

L

U X E M B O U R G

(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime

d'émission) sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à
la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires; et

(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés

proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail ou
tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions

du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales

pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice financier devra commencer à la date de constitution de la Société et se terminer le trente-et-un

(31) décembre 2016.

2. Les dividendes intérimaires pourront être distribués pendant le premier exercice de la Société.

<i>Souscription et paiement

Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été entièrement souscrites par Highbridge Principal Stra-

tegies - Cactus Direct Lending Fund, L.P., susmentionnée, pour le prix d'un euro (1 EUR) chacune.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en numéraire de sorte que le montant de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès à présent disponible à la Société, comme il a été justifié au notaire
soussigné.

La contribution totale d'un montant de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) est entièrement allouée au capital

social.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit encourus par la Société ou qui seront

supportés par la Société dans le cadre de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.500,-.

<i>Résolutions de l'associé unique

L'associé unique de la Société, représentant la totalité du capital de la Société et ayant renoncé à toute de convocation,

a pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est fixée à 46A, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

2. Les personnes suivantes sont nommées gérants A de la Société pour une durée illimitée:
- Madame Faith Rosenfeld, directeur, née le 22 décembre 1951 dans l'Etat du Massachusetts, Etats-Unis, ayant pour

adresse professionnelle le 40 West, 57 

th

 Street, 33 

rd

 Floor, New York 10019, Etats-Unis;

- Monsieur Marcus Colwell, directeur, né le 23 mai 1962 dans l'Etat du Michigan, ayant pour adresse professionnelle

le 40 West, 57 

th

 Street, 33 

rd

 Floor, New York 10019, Etats-Unis; et

59632

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Emmanuel Bresson, directeur, né le 22 janvier 1968 à Clermont-Ferrand, France, ayant pour adresse pro-

fessionnelle le Highbridge Principal Strategies (UK) LLP, 2 

nd

 floor, 25 St. James's Street, Londres, SW1A 1HA, Royaume-

Uni.

3. Les personnes suivantes sont nommées gérants B de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Robert Jan Schol, employé privé, né le 1 août 1959 à Delft, Pays-Bas, ayant pour adresse professionnelle le

46A, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Jan Lubawinski, employé privé, né le 11 février 1976 à Berlin-Friedrichshain, Allemange, ayant pour adresse

professionnelle le 46A, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et

- Monsieur Armando José Brochado Soares Correia, employé privé, né le 7 avril 1984 à Lisbonne, Portugal, ayant pour

adresse professionnelle le 2A rue de l'Ouest L-2273, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, le jour indiqué au début de ce document.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que sur la demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi par une traduction française; à la demande du même comparant et en cas de divergence entre le
texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom et domicile, ledit

mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. KREUZER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 21 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40868. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 3 février 2016.

Référence de publication: 2016062267/512.
(160023314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.

Mar Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 203.792.

STATUTS

L'an deux mille seize, le trois février.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1) Monsieur Mantovani Franco, né le 11.07.1938 à Rio Saliceto (RE), Italie, domicilié au 9 via G. Di Vittorio, Rio

Saliceto (RE), Italie;

ici représenté par Monsieur Denis BREVER, employé privé, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449

Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Rio Saliceto, le 26 novembre 2015.

2) Monsieur Mantovani Stefano, né le 20.11.1973 à Carpi (MO), Italie domicilié au 13 via G. Di Vittorio, Rio Saliceto

(RE), Italie;

ici représenté par Monsieur Denis BREVER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Rio Saliceto, le 26 no-

vembre 2015.

3) Madame Mantovani Cristina, née le 21.05.1980 à Carpio (MO), Italie, domiciliée au 16 via G. Di Vittorio, Rio Saliceto

(RE), Italie;

ici représenté par Monsieur Denis BREVER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Rio Saliceto, le 26 no-

vembre 2015.

4) Monsieur Giuliano Ascari, né le 27.05.1941 à Rio Saliceto (RE), domicilié au 7, via dei Martiri, Rio Saliceto (RE),

Italie;

ici représenté par Monsieur Denis BREVER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Rio Saliceto, le 26 no-

vembre 2015.

5) Monsieur Marco Ascari, né le 25.04.1972 à Correggio (RE), domicilié au 20, via Elsa Morante, Rio Saliceto (RE),

Italie;

ici représenté par Monsieur Denis BREVER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Rio Saliceto, le 26 no-

vembre 2015.

6) Madame Rita Ascari, née le 22.08.1969 à Correggio (RE), domiciliée au 18, via Elsa Morante, Rio Saliceto (RE),

Italie;

59633

L

U X E M B O U R G

ici représenté par Monsieur Denis BREVER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Rio Saliceto, le 26 no-

vembre 2015.

Lesdites procurations paraphées “ne varietur” par le comparant et par le notaire soussigné seront annexées au présent

acte pour être déposées auprès des autorités d'enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer

entre eux:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "MAR EUROPE S.A.".

Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale

des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale

des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, indus-

trielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création,
la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité,
sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille
créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme "Société de Partici-
pations Financières".

La société peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet iden-

tique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter, ainsi
que procéder à l'acquisition, la détention, l'exploitation, le développement et la mise en valeur de tous biens immobiliers,
terrains à bâtir y compris.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en cinq mille (5.000) actions d'une valeur

nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Art. 4. La titularité de chaque action représentative du capital social pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en

usufruit ou encore en nue-propriété.

Les droits attachés à la titularité de l'usufruit et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu'il suit:
1) le droit aux dividendes;
2) le droit de vote relatif à l'affectation des résultats lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires;
3) le droit au boni de liquidation.
Les droit attachés à la titularité de la nue-propriété et conférés par chaque action sont tous ceux non affectés à l'usufruitier

tel qu'à l'alinéa précédent, et notamment:

1) le droit de vote lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires;
2) le droit au remboursement de l'apport;
3) le droit de souscription préférentiel en cas d'émission d'actions nouvelles ou d'obligations convertibles;
4) le droit de disposition des actions.
L'usufruit attaché aux actions de la Société prend fin conformément aux dispositions légales.
Le changement du titulaire de la nue-propriété des actions dont la propriété est démembrée ne produit aucun changement

dans les droits de l'usufruitier.

Le transfert de l'usufruit ne requiert pas le consentement préalable du nu-propriétaire. Une telle opération n'affecte pas

la durée de l'usufruit.

Le démembrement de la propriété des actions de la Société est effectué par la Société sur demande écrite et selon les

instructions du propriétaire des actions.

La reprise de la propriété des actions de la Société dans les mains d'une même personne est effectuée soit sur demande

écrite conjointe du nu-propriétaire et de l'usufruitier, soit sur demande écrite du nu-propriétaire à compter de la cessation
de l'usufruit.

La titularité de l'usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée par une référence directe au démembrement

de la propriété et aux droits y attachés sur les titres ou certificats représentatifs des actions, ainsi que dans le registre des
actions nominatives.

Les actions au porteur dont la propriété fait l'objet d'un démembrement seront immédiatement converties en actions

nominatives en même temps qu'elles seront démembrées, et ne pourront être converties en titres au porteur pendant toute
la durée du démembrement.

59634

L

U X E M B O U R G

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Tous les certificats au porteur émis devront être immobilisés auprès d'un dépositaire établi au Luxembourg et nommé

par le conseil d'administration. Le conseil d'administration informera les actionnaires de toute nomination de dépositaire
ou de tout changement le concernant dans le délai de 15 jours ouvrables. Les actes de nomination ou changement concernant
les dépositaires devront être déposés et publiés conformément à l'article 11bis §1 

er

 , 3), d) de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

Un registre des actions au porteur sera ouvert, lequel se trouvera auprès du dépositaire et renseignera la désignation

précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre des actions au porteur ou coupures détenues, la date du dépôt, les
transferts, l'annulation ou la conversion des actions en titres nominatifs avec leur date.

La propriété de l'action au porteur s'établit par l'inscription sur le registre des actions au porteur. À la demande écrite de

l'actionnaire au porteur, un certificat peut lui être délivré par le dépositaire constatant toutes les inscriptions le concernant
qui lui sera remis endéans 8 jours calendrier.

Toute cession entre vifs est rendue opposable vis-à-vis des tiers et de la Société par un constat de transfert inscrit par le

dépositaire sur le registre des actions au porteur sur base de tout document ou notification constatant le transfert de propriété
entre cédant et cessionnaire. La notification de transfert pour cause de mort est valablement faite à l'égard du dépositaire,
s'il n'y a opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété reçu par le juge
de paix ou par un notaire.

Les actions au porteur ne se trouvant pas en dépôt ou n'étant pas valablement inscrites dans le registre des actions au

porteur, verront leurs droits suspendus.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions

de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée

générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront de la catégorie A ou de la catégorie B. Lors de la nomination d'un administrateur, l'assemblée

générale lui donnera pouvoir de signature “A” ou pouvoir de signature “B”.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur

ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement

et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d'administration élit en son sein son président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence.

En toute circonstance, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions
par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des
réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en

cas de partage des voix.

La société se trouve engagée par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie A et d'un administrateur

de la catégorie B.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non, nommés

pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 24 mai à 18.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

59635

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles  ne  sont  pas  nécessaires  lorsque  tous  les  actionnaires  sont  présents  ou  représentés  et  qu'ils  déclarent  avoir  eu

préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit

en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sur les bénéfices nets annuels de la société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale.

Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra
dix pour cent (10%) du capital social de la société.

Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le conseil

d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2016.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2017.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) Monsieur Stefano Mantovani, préqualifié,
* Six cent vingt-cinq actions en pleine propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

* Six cent vingt-cinq actions en nue-propriété numérotées 1 à 625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

2) Madame Cristina Mantovani, préqualifiée,
* Six cent vingt-cinq actions en pleine propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

* Six cent vingt-cinq actions en nue-propriété numérotées 626 à 1.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

3) Monsieur Franco Mantovani, préqualifié,
* Mille deux cents cinquante en usufruit numérotées 1 à 1.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
4) Monsieur Marco Ascari, préqualifié,
* Six cent vingt-cinq actions en pleine propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

* Six cent vingt-cinq actions en nue-propriété numérotées 1.251 à 1.875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

5) Madame Rita Ascari, préqualifiée,
* Six cent vingt-cinq actions en pleine propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

* Six cent vingt-cinq actions en nue-propriété numérotées 1.876 à 2.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

6) Monsieur Giuliano Ascari préqualifié
* Mille deux cents cinquante en usufruit numérotées 1.251 à 2.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cinquante mille euros (EUR 50.000.-)

est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Résolutions des actionnaires

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constatés que celle-ci était régu-
lièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à six (6) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs de la catégorie A:
a) Monsieur Stefano Mantovani, préqualifié;
b) Monsieur Marco Ascari, préqualifié;

59636

L

U X E M B O U R G

3) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs de la catégorie B:
a) Monsieur Denis BREVER, employé privé, né le 2 janvier 1983 à Malmedy - Belgique et domicilié professionnellement

au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

d) Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au

18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

4) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société CeDerLux-Services S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au

Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79327.

5) Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

qui se tiendra en l'an 2020.

6) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé: D. Brever et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 04 février 2016. 2LAC/2016/2662. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2016.

Référence de publication: 2016064638/221.
(160027076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Lazada Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 195.318.

In the year two thousand and sixteen, on the twelfth day of the month of April.
Before Us, Me Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned;

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of Lazada Group S.A., a public limited liability

company (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number
B.195318, incorporated following a deed of the undersigned notary on 6 March 2015, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the “Luxembourg Official Gazette”) on 28 April 2015 n° 1107 (the “Company”), and whose
articles have last been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated 1 July 2015 published in the Luxembourg
Official Gazette of 22 September 2015 n° 2583.

The Meeting opened at 6 p.m. with David DE PASQUALE, attorney-at-law, in the chair.
The chairman designated Benoît TASSIGNY, notarial clerc, as secretary.
The Meeting elected François BERNARD, attorney-at-law, as scrutineer.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to

record the following:

I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares

are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxyholders of the represented shareholders,
the board of the Meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with
the registration authorities.

The said proxies, initialed ne varietur by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

II. Pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders present or

represented declare that they have received notice and knowledge of the agenda prior to this Meeting and thus waive any
convening formalities.

III. The present Meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the following agenda.

59637

L

U X E M B O U R G

IV. The agenda of the present Meeting is the following:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred fifty-three thousand three hundred sixty

euro (EUR 153,360.-) so as to raise it from its current amount of eighteen million four hundred seventeen thousand nine
hundred ninety-six euro (EUR 18,417,996.-) to an amount of eighteen million five hundred seventy-one thousand three
hundred fifty six euro (EUR 18,571,356.-) through the issuance of one hundred fifty-three thousand three hundred sixty
(153,360) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, to be fully paid up by a contribution in cash.

2. Decrease of the share capital of the Company by an amount of thirteen thousand four hundred sixty euro (EUR

13,460.-) so as to decrease it from its current amount of eighteen million five hundred seventy-one thousand three hundred
fifty-six euro (EUR 18,571,356.-) to an amount of eighteen million five hundred fifty-seven thousand eight hundred ninety-
six euro (EUR 18,557,896.-), by the cancellation of thirteen thousand four hundred sixty (13,460) shares with a nominal
value of one euro (EUR 1.-) each and reimbursement of the relevant amounts to the relevant shareholders.

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of six million seven hundred thirty-two thousand one

hundred ninety-four euro (EUR 6,732,194.-) so as to raise it from its current amount of eighteen million five hundred fifty-
seven thousand eight hundred ninety-six euro (EUR 18,557,896.-) to an amount of twenty-five million two hundred ninety
thousand  ninety  euro  (EUR  25,290,090.-)  through  the  issuance  of  six  million  seven  hundred  thirty-two  thousand  one
hundred ninety-four (6.732.194) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all to be fully paid up by a
contribution in cash.

4.  Acknowledgement  and  confirmation  that  the  issuance  of  the  six  million  seven  hundred  thirty-two  thousand  one

hundred ninety-four (6.732.194) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each as subscribed by a new
shareholder of the Company shall bear the right to participate in the profits of the Company for the financial year beginning
on 1 January 2016 and ending on 31 December 2016.

5. Amendment of article 5.1 of the articles of association (the “Articles”) of the Company.
6. Increase of the amount of the authorized share capital of the Company by an amount of one million two hundred

eleven thousand eight hundred nineteen euro (EUR 1,211,819.-) so as to raise it from its current amount of one million six
hundred thirty-nine thousand ninety-two euro (EUR 1,639,092.-) (excluding the issued share capital) to two million eight
hundred fifty thousand nine hundred eleven euro (EUR 2,850,911.-) (excluding the issued share capital) and subsequent
amendment of article 6.1 of the Articles.

7. Restatement in full of the Articles.
8. Changes to the composition of the board of directors of the Company.
9. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the Meeting after deliberation unanimously took, and required the

undersigned notary to enact, the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase the Company’s share capital by an amount of one hundred fifty-three thousand three

hundred sixty euro (EUR 153,360.-) so as to raise it from its current amount of eighteen million four hundred seventeen
thousand nine hundred ninety-six euro (EUR 18,417,996) to an amount of eighteen million five hundred seventy one
thousand three hundred fifty-six euro (EUR 18,571,356.-) through the issuance of one hundred fifty-three thousand three
hundred sixty (153,360) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each for an aggregate subscription price in an
amount of one hundred fifty-three thousand three hundred sixty euro (EUR 153,360.-).

The one hundred fifty-three thousand three hundred sixty (153,360) new shares issued were subscribed as per the list

annexed to this deed and were fully paid-up by an aggregate contribution in cash equal to one hundred fifty-three thousand
three hundred sixty euro (EUR 153,360.-).

The amount of one hundred fifty-three thousand three hundred sixty euro (EUR 153,360.-) is at the free disposal of the

Company and proof thereof was given to the undersigned notary who expressly acknowledged it.

The existing shareholders have, inter alia, waived their preferential rights as well as any transfer restrictions, pre-emptive

rights, rights of first refusal, tag-along rights, drag-along rights and or any other rights provided by law, by the Articles,
or, as the case may be, contained in any shareholders’ agreement with respect to the Company to which the appearing
shareholders are a party from time to time.

<i>Second resolution

Subsequently, the Meeting resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of thirteen thousand

four hundred sixty euro (EUR 13,460) in order to reduce its current amount of eighteen million five hundred seventy-one
thousand three hundred fifty-six euro (EUR 18,571,356.-) to an amount of eighteen million five hundred fifty-seven thou-
sand eight hundred ninety-six euro (EUR 18,557,896.-), by the cancellation of thirteen thousand four hundred sixty (13,460)
shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each by way of reimbursement of an amount of thirteen thousand four
hundred sixty euro (EUR 13,460) to the relevant shareholders as per the list annexed to this deed.

59638

L

U X E M B O U R G

All powers are conferred to any director of the Company, each acting individually with full power of substitution, in

order to (i) implement the necessary bookkeeping amendments, (ii) proceed with all accounting entries to the cancellation
of thirteen thousand four hundred sixty (13,460) shares and (iii) reimburse the shareholders, it being understood that the
reimbursement can only take place as from thirty (30) days after publication of the present deed in the Luxembourg Official
Gazette. The reimbursement shall be made under observance of the provisions of Article 69(2) of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended (the “1915 Law”).

<i>Third resolution

The Meeting resolves to increase the Company’s share capital by an amount of six million seven hundred thirty-two

thousand one hundred ninety-four euro (EUR 6,732,194.-) so as to raise it from its current amount of eighteen million five
hundred fifty-seven thousand eight hundred ninety-six euro (EUR 18,557,896.-) to twenty-five million two hundred ninety
thousand ninety euro (EUR 25,290,090) through the issuance of six million seven hundred thirty-two thousand one hundred
ninety-four (6,732,194) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each for an aggregate subscription price
in an amount of six million seven hundred thirty-two thousand one hundred ninety-four euro (EUR 6,732,194.-).

The six million seven hundred thirty-two thousand one hundred ninety-four (6,732,194) new shares issued were sub-

scribed as per the list annexed to this deed by a new shareholder (the “New Shareholder”) and were fully paid up by an
aggregate contribution in cash in an amount in United States Dollars corresponding to six million seven hundred thirty-
two thousand one hundred ninety-four euro (EUR 6,732,194.-) at the exchange rate published by the European Central
Bank on April 8, 2016.

The amount in United States Dollar corresponding to six million seven hundred thirty-two thousand one hundred ninety-

four euro (EUR 6,732,194.-) at the exchange rate published by the European Central Bank on April 8, 2016 is at the free
disposal of the Company and proof thereof was given to the undersigned notary who expressly acknowledged it.

The existing shareholders have, inter alia, waived their preferential subscription rights as well as any transfer restrictions,

pre-emptive rights, rights of first refusal, tag-along rights, drag-along rights and or any other rights provided by law or by
the Articles or, as the case may be, contained in any shareholders’ agreement with respect to the Company to which the
appearing shareholders are a party from time to time in connection with this Meeting.

Then, the New Shareholder joins the existing shareholders and the Meeting resolves on the subsequent items of the

agenda. The proxy of the New Shareholder, initialed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary will remain
annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to acknowledge and confirm that the issuance of the six million seven hundred thirty-two thousand

one hundred ninety-four (6,732,194) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each as subscribed by the
New Shareholder shall bear the right to participate in the profits of the Company for the financial year beginning on 1
January 2016 and ending on 31 December 2016.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The Company has an issued share capital of twenty-five million two hundred ninety thousand ninety euro (EUR

25,290,090), represented by twenty-five million two hundred ninety thousand ninety (25,290,090) shares with a nominal
value of one euro (EUR 1) each.”

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to increase the amount of the authorized share capital of the Co mpany by one million two hundred

eleven thousand eight hundred nineteen euro (EUR 1,211,819.-) thereby raising it from its current amount of one million
six hundred thirty-nine thousand ninety-two euro (EUR 1,639,092.-) (excluding the issued share capital) to an amount of
two million eight hundred fifty thousand nine hundred eleven euro (EUR 2,850,911.-) (excluding the issued share capital)
on the basis of a report of the board of directors to the Meeting in conformity with Article 32-3 (5) of the 1915 Law, which
after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the members of the board will remain attached to the
present deed in order to be filed at the same time with the registration authorities.

The Meeting further resolves to amend article 6.1 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

“ 6.1. The Company’s authorized capital, excluding the issued share capital, is set at two million eight hundred fifty

thousand nine hundred eleven euro (EUR 2,850,911.-), consisting of two million eight hundred fifty thousand nine hundred
eleven (2,850,911) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-).”

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to restate the Articles in full so that they shall henceforth read as follows:

59639

L

U X E M B O U R G

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a public limited company (société anonyme) under the name Lazada Group

S.A. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies,
as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of

any entity in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which forms part of the same group of
entities as the Company and lend funds, render services or otherwise assist any such entity in any other manner.

2.3 The Company may further provide any and all financial management services, including, but not limited to treasury

management services, currencies management services, interest rate and foreign exchange risk management to any entity
in which it holds a direct or indirect controlling interest.

2.4 The Company may raise funds, especially through borrowing in any form, and may issue any kind of notes, securities

or debt instruments, bonds and debentures and generally issue any securities options to subscribe for securities of any type.

2.5 A further purpose of the Company is the (i) acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such
intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property
rights.

2.6 The Company shall not act as an alternative investment fund as defined in the law of 12 July 2013 on Alternative

Investment Fund Managers and shall not carry out any other activity which would be subject to supervision by the Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier.

2.7 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate, technical, intellectual property or

other activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The Company’s registered office is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. The Company’s

registered office may be transferred within the same municipality by a resolution of the board of directors. It may be
transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting
of shareholders.

4.2 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of directors.

B. Share capital - Shares - Register of shares - Ownership and transfer of shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The Company has an issued share capital of twenty-five million two hundred ninety thousand ninety euro (EUR

25,290,090.-), represented by twenty-five million two hundred ninety thousand ninety (25,290,090) shares with a nominal
value of one Euro (EUR 1) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association in accordance with the Law or as set out
in article 6 hereof.

5.3 Subject to article 6.2 of these articles of association, any new shares to be paid for in cash will be offered by preference

to the existing shareholder(s) in proportion to the number of shares held by them in the Company’s issued share capital.
The board of directors shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be exercised.
This period may not be less than thirty (30) days from the date of the opening of the subscription as published in the official
gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Memorial”) and two
(2) Luxembourg newspapers in accordance with the Law or, in case all the shares are in registered form, from the date of
notification of the shareholders by registered letter. However, subject to the provisions of the Law, the general meeting of
shareholders called (i) to resolve upon an increase of the Company’s issued share capital or (ii) on the occasion of an
authorization granted to the board of directors to increase the Company’s issued share capital, may limit or suppress the
preferential subscription right of the existing shareholder(s) or authorize the board of directors to do so. Such resolution
shall be adopted in the manner required for an amendment to these articles of association.

59640

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Authorized Capital.
6.1 The Company’s authorized capital, excluding the issued share capital, is set at two million eight hundred fifty

thousand nine hundred eleven Euro (EUR 2,850,911.-), consisting of two million eight hundred fifty thousand nine hundred
eleven (2,850,911) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1).

6.2 The board of directors is hereby authorized to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any

other instruments convertible into shares for the purpose of delivery of shares upon exercise or conversion, as applicable,
of the Company’s stock options or other equity-based awards granted under any management incentive plan of the Company
or issues of shares to certain managers or other employees of the group of companies of which the Company is the parent
company, within the limit of the authorized capital, to such persons and on such terms as it shall see fit, and specifically
to proceed to such issue without reserving a preferential subscription right for the existing shareholders during a period of
time of five (5) years from the date of publication of the relevant resolution of the general meeting of shareholders in the
Mémorial. This authorization may be renewed once or several times by a resolution of the general meeting of shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time for a period not exceeding five
(5) years.

6.3 The authorized capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders adopted in the manner required for amendments of these articles of association.

Art. 7. Shares.
7.1 Notwithstanding article 22.2. the Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same

nominal value. The shares of the Company are in registered form. No fractional shares shall be issued.

7.2 The shares are freely transferable, subject to the provisions of the Law and these articles of association. The Company

may repurchase its shares and hold them in treasury subject to the conditions of the Law.

7.3 The Company will recognize only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

7.5 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law and ownership of shares is established
by registration in said share register, without prejudice to the conditions for transfer by book-entries provided for in article
7.6 of these articles of association. Certificates of such registration shall be issued by the Company upon request and at the
expense of the relevant shareholder and, in the situation described by article 7.6 of these articles of association, to the
Depositary (as defined below). All communications and notices to be given to a registered shareholder shall be deemed
validly made to the latest address communicated by the shareholder to the Company. The board of directors may decide
that no entry shall be made in the share register and no notice of a transfer shall be recognized by the Company during the
period starting on the Record Date (as defined below) and ending on the closing of the relevant general meeting.

7.6 Where shares are in registered form and are recorded in the Company’s register of shares in the name of or on behalf

of a securities settlement system or the operator of such system and recorded as book-entry interests in the accounts of a
financial institution or a professional depositary or sub-depositary (any such institution, depositary and sub-depositary
being referred to hereinafter as a “Depositary”), the Company, subject to having received from the Depositary a proper
certification of such record position, will permit the Depositary of such book-entry interests to exercise the rights attached
to the shares corresponding to the book-entry interests of the relevant shareholder, including receiving notices of general
meetings, admission to and voting at general meetings (the “Certificates”). The board of directors may determine formal
requirements with which such Certificates must comply.

Art. 8. Transfer Restrictions. Any transfer of the shares in the Company or parts thereof requires a majority of no less

than sixty-six and two-thirds per cent (66 2/3%) of the votes validly cast in a meeting of shareholders provided that a
quorum of no less than fifty per cent (50%) of the share capital is represented at the meeting of shareholders. Abstentions
and nil votes shall not be taken into account.

C. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders. The shareholders exercise their collective rights in the general

meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the
entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly
reserved to it by the Law and by these articles of association.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on the last Thursday
of May of each year at 10.00 a.m. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be
held on the next following business day. Other general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened
by the board of directors, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meetings.

59641

L

U X E M B O U R G

10.2 General meetings of shareholders shall be convened in accordance with the provisions of the Law and these articles

of association and in the event the shares of the Company are listed on a foreign stock exchange, in accordance with the
publicity requirements of such foreign stock exchange applicable to the Company. If all shareholders are present or repre-
sented, the meeting may be held without prior notice or publication.

10.3 In the event the shares of the Company are not listed on any foreign stock exchange, all shareholders recorded in

the register of shareholders on the date of the general meeting of the shareholders are entitled to be admitted to the general
meeting of shareholders. If the shares of the Company are listed on a foreign stock exchange, the board of directors may
determine a date and time preceding the general meeting of shareholders as the record date for admission to the general
meeting of shareholders (the “Record Date”). In such case, any shareholder who wishes to attend the general meeting must
inform the Company thereof at the latest on the Record Date, in a manner to be determined by the board of directors in the
convening notice. In case of shares held through a Depositary, a shareholder wishing to attend a general meeting of sha-
reholders should receive from such Depositary one or more Certificates regarding the number of shares recorded in his
name on the Record Date. No entry shall be made in the share register and no notice of transfer shall be recognized by the
Company or a registrar acting for the Company in the period between the Record Date and the date of a general meeting
ending at the closing of such general meeting if so decided by the board of directors. In the event of a transfer of shares
held in book-entry form in the period between the Record Date and the date of the general meeting, the transferor is
authorized and empowered by the transferee to participate in such general meeting and, in particular, exercise the voting
rights attached to such shares. The Certificates should be submitted to the Company (or its agent appointed in the convening
notice) no later than five (5) business days prior to the date of the relevant general meeting. Proxies and voting forms
relating to such general meeting must be remitted at the same time. The board of directors may set a shorter period for the
submission of the Certificate, proxies or voting forms.

10.4 A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy.

10.5 Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company or its agent specified

in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and the board of directors
shall determine their content.

10.6 The board of directors may determine other terms or set conditions that must be respected by a shareholder to

participate in any meeting of shareholders in the convening notice (including, but not limited to, longer notice periods).

Art. 11. Quorum and vote.

11.1 Each share entitles the holder to one vote in general meetings of shareholders.

11.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of sha-

reholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes
validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

11.3 The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

11.4 Resolutions by the general meeting on the following matters require the consent of shareholders holding at least

two-thirds of the aggregate number of shares issued in the Company:

(i) any amendment of these articles of association;

(ii) the winding-up, liquidation, or dissolution of the Company;

(iii) any change in the share capital or the creation, allotment or issue of any shares (other than realized through the

authorized capital in accordance with article 6 of these articles of association); and

(iv) any reduction of the share capital or any redemption or repurchase by the Company of any shares.

In respect of variation of the rights attaching to any class of shares, the consent of shareholders holding at least two-

thirds of the shares of the relevant class at a general meeting is required in addition to the requirements of the preceding
sentence. The creation, allotment or issue of securities in the Company other than shares, or the grant of any option or rights
to subscribe for or to convert any instrument into shares or other securities in the Company (other than realized through
the authorized capital in accordance with article 6 of these articles of association) shall require the consent of the share-
holders with majority set out in the first sentence of this article 10.4.

Resolutions by the general meeting on the following matters require the consent of shareholders holding more than fifty

per cent (50%) of the aggregate number of shares issued in the Company:

(i) the adoption of statutory accounts of the Company and any consolidated group accounts;

(ii) the payment or declaration of any dividend or other distribution by the Company; and

(iii) the appointment or change of the Company’s auditor.

The conclusion, termination or amendment of (a) silent partnerships and sub- participations in the Company or (b)

enterprise agreements of the Company within the meaning of sections 291 et seq. of the German Stock Corporation Act
shall require the consent of the shareholders with majority set out in the fourth sentence of this article 10.4.

59642

L

U X E M B O U R G

D. Management

Art. 12. Board of directors.
12.1 The Company shall be managed by a board of directors. The board of directors is vested with the broadest powers

to take any actions necessary or useful to fulfill the Company’s corporate purpose, with the exception of the actions reserved
by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

12.2 Subject to the rules of procedure of the board of directors, the board of directors can deliberate or act validly only

if at least a majority of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

12.3 In accordance with article 60 of the Law, the Company’s daily management and the Company’s representation in

connection with such daily management may be delegated to one or several members of the board of directors or to any
other person(s) appointed by the board of directors, acting alone or jointly. Their appointment, revocation and powers shall
be determined by a resolution of the board of directors.

12.4 The board of directors may also grant special powers by notarized proxy or private instrument.
12.5 The board of directors is composed of at least three (3) directors. The board of directors must choose from among

its members a chairman of the board of directors. It may also choose a vice-chairman and it may choose a secretary, who
does not need to be a shareholder or a member of the board of directors.

12.6 Resolutions at a board of directors meeting are adopted with the approval of a majority of the members present or

represented at board of directors meeting, subject to the rules of procedure of the board of directors. In case of a tie, the
chairman of the board shall have a casting vote.

Art. 13. Election and removal of directors and term of the office.
13.1 Directors may be re-elected for successive terms. The directors are elected by a simple majority vote of the shares

represented in a general meeting. Any director may be removed at any time without cause and prior notice by the general
meeting of shareholders at a simple majority vote of the shares represented.

13.2 If a vacancy in the office of a member of the board of directors because of death, legal incapacity, bankruptcy,

retirement, dismissal or otherwise occurs, such vacancy may be filled on a temporary basis by a person designated by such
person or group of persons that has nominated the board member that is causing the vacancy until the next general meeting
of shareholders, which shall resolve on a permanent appointment.

Art. 14. Rules of procedure of the board of directors and Board committees.
14.1 The board of directors determines its rules of conduct in a resolution and establishes such rules in writing.
14.2 The board may (but shall not be obliged to unless required by law) establish one or more committees. The board

shall determine the purpose, powers and authorities as well as the procedures and such other rules as may be applicable for
all committees which are established.

14.3 The Board may in particular pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile,

electronic mail or any other similar means of communication, provided that each of the directors participates in such
resolution by circular means. The directors may express their consent separately on one or several documents. The date of
such resolutions shall be the date of the last signature.

Art. 15. Dealing with third parties.
15.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the joint signature of any two (2) directors

or by the joint or single signature(s) of any person(s) to whom such power may have been delegated by the board of directors.

15.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signatures of

any person to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly and within the limits of such
delegation.

Art. 16. Indemnification.
16.1 The members of the board of directors are not held personally liable for the indebtedness or other obligations of

the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties. Subject to mandatory
provisions of law, every person who is, or has been, a member of the board of directors or officer of the Company shall be
indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably
incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding in which he becomes involved as a party
or otherwise by virtue of his being or having been such a director or officer and against amounts paid or incurred by him
in the settlement thereof. The words “claim”, “action”, “suit” or “proceeding” shall apply to all claims, actions, suits or
proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words “liability” and “expenses”
shall include without limitation attorneys’ fees, costs, judgments, amounts paid in settlement and other liabilities.

16.2 No indemnification shall be provided to any director or officer (i) against any liability to the Company or its

shareholders by reason of willful misconduct, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in
the conduct of his office, (ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in
bad faith and not in the interest of the Company or (iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved
by a court of competent jurisdiction or by the board of directors.

59643

L

U X E M B O U R G

16.3 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any

director or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such director or
officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein
shall affect or limit any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be
entitled by contract or otherwise under law. The Company shall specifically be entitled to provide contractual indemnifi-
cation to any corporate personnel, including directors and officers of the Company, as the Company may decide upon from
time to time.

16.4 Expenses in connection with the preparation and representation of a defense of any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this Article 16 shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is
not entitled to indemnification under this article.

Art. 17. Conflicts of interest.
17.1 To the extent required by law, any director who has, directly or indirectly, a personal interest in a transaction

submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company’s interests, such director must inform
the board of directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting.
The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Such conflict
of interest shall be reported to the next general meeting.

17.2 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that a director has a personal interest in, or is a director, associate, officer, agent, adviser or employee of
such other company or firm.

E. Auditors

Art. 18. Independent auditor(s).
18.1 The Company’s annual accounts shall be audited by one or more approved independent auditors (réviseurs d’en-

treprises agréés), appointed by the general meeting of shareholders at the board of directors’ recommendation (itself acting
upon recommendation of the Audit Committee). The general meeting of shareholders shall determine the number of auditor
(s) and the term of their office.

18.2 An approved independent auditor may be dismissed at any time with cause (or with his approval) by the general

meeting of shareholders. An approved independent auditor (réviseur d’entreprises agréé) may be reappointed.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 19. Financial year. The Company’s financial year shall begin on the first of January of each year and shall end on

the thirty-first of December of the same year.

Art. 20. Profits.
20.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors shall draw up or shall cause to

be drawn up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the
Law.

20.2 From the Company’s annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company’s legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company’s reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company’s issued share capital.

20.3 The annual general meeting of shareholders determines upon recommendation of the board of directors how the

remainder of the annual net profits will be allocated. Each share shall be entitled to receive the same amount.

20.4 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation. In the case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced
in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the issued share capital.

20.5 If the shares are held through a Depositary, the Company will make dividend payments and any other payments in

cash, shares or other securities only to the Depositary recorded in the register or in accordance with its instructions, and
such payment will fully discharge of the Company’s obligations in this respect.

20.6 Dividends which have not been claimed within five (5) years after the date on which they became due and payable

revert back to the Company.

Art. 21. Interim dividends - Share premium and additional premiums.
21.1 The board of directors may pay interim dividends in accordance with the provisions of the Law.
21.2 Any share premium, additional premiums or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

subject to the provisions of the Law and these articles of association.

59644

L

U X E M B O U R G

G. Liquidation

Art. 22. Liquidation.
22.1 In the event of the Company’s dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, indi-

viduals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company’s dissolution which
shall determine the liquidators’ powers and remuneration. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most
extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

22.2 Unless otherwise provided in these articles of association, the surplus resulting from the realization of assets and

the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in accordance and in compliance with any mutual
shareholders’ agreements existing at the time of the liquidation.

H. Governing law

Art. 23. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the Law.

<i>Eighth resolution

The Meeting resolves to accept the resignations of the following persons in their capacity as directors of the Company

with immediate effect:

- Ulrich Ludwig BINNINGER,
- Chee Meng YAP,
- Christoph BARCHEWITZ,
- Lorenzo GRABAU,
- Robin TERRELL,
- Julia ATWOOD,
- Scott COLLINS,
- Nicholas CATOR, and
- Daniel SHINAR,
and to confirm the appointment of the following directors, each originally appointed on 1 April 2015:
- Oliver SAMWER,
- Peng Huat ANG, and
- Maximilian BITTNER,
and to appoint with immediate effect the following persons as new directors of the Company such mandates for the

maximum duration permitted by law (i.e. a period of six years running from the date of the present deed):

- John Michael EVANS,
- Wu QIAN, and
- Kumara Guru GOWRAPPAN.
There being no further business, the Meeting is closed at 6.30 p.m.

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at EUR 5,900.-.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing parties, known to the notary by name, first name and residence, the

said appearing parties signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausendsechzehn, am zwölften Tag des Monats April.
Vor uns, Me Cosita DELVAUX, unterzeichnete Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
Wird eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre (die "Versammlung") der Lazada Group S.A. abgehalten,

einer  Aktiengesellschaft  (société  anonyme),  die  dem  Recht  des  Großherzogtums  Luxemburg  unterliegt,  mit  Sitz  in  5,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer
B.195318, gegründet am 6. März 2015 gemäß einer Urkunde der unterzeichneten Notarin, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (das “Luxemburger Amtsblatt”) vom 28. April 2015 Nr. 1107 (die "Gesellschaft"),
und deren Satzung zuletzt geändert wurde gemäß einer Urkunde der unterzeichneten Notarin, vom 1. Juli 2015, veröffent-
licht in dem Luxemburger Amtsblatt vom 22. September 2015 Nr. 2583.

59645

L

U X E M B O U R G

Die Versammlung wird um 18 Uhrzeit unter dem Vorsitz von David DE PASQUALE, Anwalt, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft Benoît TASSIGNY, Notargehilfe, zum Schriftführer.
Die Versammlung beruft François BERNARD, Anwalt, zum Stimmzähler.
Nach  der  ebenso  erfolgten  Zusammensetzung  des  Rates  der  Versammlung  erklärt  und  ersucht  der  Vorsitzende  die

unterzeichnete Notarin, Folgendes festzuhalten:

I. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien

erscheinen auf einer Anwesenheitsliste, die von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Akti-
onäre,  vom  Rat  der  Versammlung  und  von  der  unterzeichneten  Notarin  unterzeichnet  und  der  vorliegenden  Urkunde
beigefügt werden, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Besagte Vollmachten, welche von den erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur paraphiert wurden, werden

der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und alle

anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, eine Ladung erhalten zu haben und vor dieser Versammlung über die
Tagesordnung in Kenntnis gesetzt worden zu sein und verzichten somit auf jegliche Ladungsformalitäten.

III. Diese Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über alle Punkte der fol-

genden Tagesordnung beraten.

IV. Die Tagesordnung dieser Versammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von achtzehn Millionen vier-

hundertsiebzehntausendneunhundertsechsundneunzig Euro (EUR 18.417.996,-) um einen Betrag von einhundertdreiund-
fünfzigtausenddreihundertsechzig Euro (EUR 153.360,-) auf einen Betrag von achtzehn Millionen fünfhunderteinund-
siebzigtausenddreihundertsechsundfünfzig Euro (EUR 18.571.356,-) durch die Ausgabe von einhundertdreiundfünfzig-
tausenddreihundertsechzig (153.360) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-), vollständig
einzuzahlen durch eine Bareinlage.

2. Herabsetzung des Gesellschaftskapitals von seinem derzeitigen Betrag von achtzehn Millionen fünfhunderteinund-

siebzigtausenddreihundertsechsundfünfzig Euro (EUR 18.571.356,-) um einen Betrag von dreizehntausendvierhundert-
sechzig Euro (EUR 13.460,-) auf einen Betrag von achtzehn Millionen fünfhundertsiebenundfünfzigtausendachthundert-
sechsundneunzig Euro (EUR 18.557.896,-), durch die Einziehung von dreizehntausendvierhundertsechzig (13.460) Aktien
mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-) und Zurückerstattung der entsprechenden Beträge an die jeweiligen
Aktionäre.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von achtzehn Millionen fünf-

hundertsiebenundfünfzigtausendachthundertsechsundneunzig Euro (EUR 18.557.896,-) um einen Betrag von sechs Mil-
lionen  siebenhundertzweiunddreißigtausendeinhundertvierundneunzig  Euro  (EUR  6.732.194,-)  auf  einen  Betrag  von
fünfundzwanzig Millionen zweihundertneunzigtausendneunzig Euro (EUR 25.290.090,-) durch die Ausgabe von sechs
Millionen siebenhundertzweiunddreißigtausendeinhundertvierundneunzig (6.732.194) neuer Aktien mit einem Nominal-
wert von je einem Euro (EUR 1,-) vollständig einzuzahlen durch eine Bareinlage.

4. Anerkennung und Bestätigung, dass die Ausgabe der sechs Millionen siebenhundertzweiunddreißigtausendeinhun-

dertvierundneunzig (6.732.194) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-), jeweils gezeichnet
durch einen neuen Aktionär der Gesellschaft, das Recht der Gewinnbeteiligung an der Gesellschaft für das Geschäftsjahr,
beginnend am 1. Januar 2016 und endend am 31. Dezember 2016, umfasst.

5. Änderung des Artikels 5.1 der Satzung (die "Satzung") der Gesellschaft.
6. Erhöhung des Betrages des genehmigten Kapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von einer Million

sechshundertneununddreißigtausendzweiundneunzig Euro (EUR 1.639.092,-) (ausgenommen des ausgegebenen Aktien-
kapitals) um einen Betrag von einer Million zweihundertelftausendachthundertneunzehn Euro (EUR 1.211.819,-) auf einen
Betrag von zwei Millionen achthundertfünfzigtausendneunhundertelf Euro (EUR 2.850.911,-) (ausgenommen des ausge-
gebenen Aktienkapitals) und anschließende Änderung des Artikel 6.1 der Satzung.

7. Vollumfängliche Neufassung der Satzung.
8. Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Gesellschaft.
9. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunktes fasst die Versammlung nach Beratung einstimmig die

folgenden Beschlüsse und ersucht die Notarin, diese zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von achtzehn

Millionen vierhundertsiebzehntausendneunhundertsechsundneunzig Euro (EUR 18.417.996,-) um einen Betrag von ein-
hundertdreiundfünfzigtausenddreihundertsechzig Euro (EUR 153.360,-) auf einen Betrag von achtzehn Millionen fünf-
hunderteinundsiebzigtausenddreihundertsechsundfünfzig Euro (EUR 18.571.356,-) durch die Ausgabe von einhundertd-

59646

L

U X E M B O U R G

reiundfünfzigtausenddreihundertsechzig (153.360) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-), zu einem
Bezugspreis von insgesamt einhundertdreiundfünfzigtausenddreihundertsechzig Euro (EUR 153.360,-), zu erhöhen.

Die einhundertdreiundfünfzigtausenddreihundertsechzig (153.360) neu ausgegebenen Aktien wurden wie in der dieser

Urkunde beigefügten Liste aufgeführt gezeichnet und die Bareinlage von insgesamt einhundertdreiundfünfzigtausendd-
reihundertsechzig Euro (EUR 153.360,-) wurde vollständig einbezahlt.

Der Betrag von einhundertdreiundfünfzigtausenddreihundertsechzig Euro (EUR 153.360,-) steht zur freien Verfügung

der Gesellschaft und ein Nachweis hierüber wurde gegenüber der Unterzeichneten Notarin erbracht, die dies ausdrücklich
zur Kenntnis genommen hat.

Die vorhandenen Aktionäre haben, unter anderem sowohl auf ihre Bezugsrechte als auch auf etwaige Übertragungsbe-

schränkungen,  Vorkaufsrechte,  Rechte  der  ersten  Ablehnung,  Tag-along  Rechte,  Drag-along  Rechte  sowie  auf  andere
Rechte, die vom Gesetz, der Satzung oder, gegebenenfalls, von Gesellschaftervereinbarungen, an denen die erschienenen
Aktionäre gelegentlich beteiligt sind, im Hinblick auf die Gesellschaft garantiert werden, verzichtet.

<i>Zweiter Beschluss

Nachfolgend beschließt die Versammlung, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von

achtzehn Millionen fünfhunderteinundsiebzigtausenddreihundertsechsundfünfzig Euro (EUR 18.571.356,-) um einen Be-
trag von dreizehntausendvierhundertsechzig Euro (EUR 13.460,-) auf achtzehn Millionen fünfhundertsiebenundfünfzig-
tausendachthundertsechsundneunzig Euro (EUR 18.557.896,-), durch die Einziehung von dreizehntausendvierhundert-
sechzig (13.460) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-) durch Rückerstattung des Betrages von
dreizehntausendvierhundertsechzig Euro (EUR 13.460,-) an die entsprechenden Aktionäre, wie in der beigefügten Liste
ausgewiesen, herabzusetzen.

Alle Befugnisse werden auf eines der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft übertragen, die jeweils einzeln mit

Substitutionsvollmacht ausgestattet sind um (i) die notwendigen Änderungen der Buchführung umzusetzen, (ii) alle Bu-
chungssätze für die Einziehung von dreizehntausendvierhundertsechzig (13.460) Aktien fortzuführen und (iii) die Rück-
erstattung  an  die  Aktionäre  durchzuführen,  wobei  die  Rückerstattung  frühestens  nach  dreißig  (30)  Tagen  nach  der
Veröffentlichung der vorliegenden Urkunde im Luxemburger Amtsblatt erfolgen kann. Die Rückerstattung ist unter Be-
achtung der Vorschrift des Artikel 69(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in der jeweils
gültigen Fassung, (das”1915 Gesetz”) durchzuführen.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von achtzehn

Millionen fünfhundertsiebenundfünfzigtausendachthundertsechsundneunzig Euro (EUR 18.557.896,-) um einen Betrag
von sechs Millionen siebenhundertzweiunddreißigtausendeinhundertvierundneunzig Euro (EUR 6.732.194,-) auf einen
Betrag von fünfundzwanzig Millionen zweihundertneunzigtausendneunzig Euro (EUR 25.290.090,-) durch die Ausgabe
von sechs Millionen siebenhundertzweiunddreißigtausendeinhundertvierundneunzig (6.732.194) neuer Aktien mit einem
Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-), zu einem Bezugspreis von insgesamt sechs Millionen siebenhundertzwei-
unddreißigtausendeinhundertvierundneunzig Euro (EUR 6.732.194,-) zu erhöhen.

Die  sechs  Millionen  siebenhundertzweiunddreißigtausendeinhundertvierundneunzig  (6.732.194)  neu  ausgegebenen

Aktien wurden wie in der dieser Urkunde beigefügten Liste aufgeführt durch einen neuen Aktionär gezeichnet (der "Neue
Aktionär")  und  die  Bareinlage  von  insgesamt  sechs  Millionen  siebenhundertzweiunddreißigtausendeinhundertvierund-
neunzig  Euro  (EUR  6.732.194,-)  wurde  vollständig  in  einem  entsprechenden  Betrag  in  United  States  Dollars  zu  dem
Wechselkurs, der von der Europäischen Zentralbank am 8. April 2016 veröffentlicht wurde, einbezahlt.

Der in United States Dollars zu dem Wechselkurs, der von der Europäischen Zentralbank am 8. April 2016 veröffentlicht

wurde, entsprechende Betrag von sechs Millionen siebenhundertzweiunddreißigtausendeinhundertvierundneunzig Euro
(EUR 6.732.194,-) steht zur freien Verfügung der Gesellschaft und ein Nachweis hierüber wurde gegenüber der unter-
zeichneten Notarin erbracht, die dies ausdrücklich zur Kenntnis genommen hat.

Die vorhandenen Aktionäre haben im Zusammenhang mit dieser Versammlung, unter anderem sowohl auf ihre Be-

zugsrechte als auch auf etwaige Übertragungsbeschränkungen, Vorkaufsrechte, Rechte der ersten Ablehnung, Tag-along
Rechte, Drag-along Rechte sowie auf andere Rechte, die vom Gesetz, der Satzung oder, gegebenenfalls, von Gesellschaf-
tervereinbarungen,  an  denen  die  erschienenen  Aktionäre  gelegentlich  beteiligt  sind,  im  Hinblick  auf  die  Gesellschaft
garantiert werden, verzichtet.

Daraufhin tritt der Neue Aktionär den vorhandenen Aktionären bei und die Versammlung beschließt die nachfolgenden

Punkte der Tagesordnung. Die Vollmacht des Neuen Aktionärs, welche von dem Bevollmächtigten und der Unterzeichneten
Notarin ne varietur paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt, anzuerkennen und zu bestätigen, dass die Ausgabe der sechs Millionen siebenhundert-

zweiunddreißigtausendeinhundertvierundneunzig (6.732.194) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,-), jeweils gezeichnet durch den Neuen Aktionär, das Recht der Gewinnbeteiligung an der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr beginnend am 1. Januar 2016 und endend am 31. Dezember 2016, umfasst.

59647

L

U X E M B O U R G

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt, Artikel 5.1. der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:

"  5.1.  Das  ausgegebene  Gesellschaftskapital  beträgt  fünfundzwanzig  Millionen  zweihundertneunzigtausendneunzig

Euro  (EUR  25.290.090,-),  bestehend  aus  fünfundzwanzig  Millionen  zweihundertneunzigtausendneunzig  (25.290.090)
Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-)."

<i>Sechster Beschluss

Die Versammlung beschließt auf Grundlage eines in Übereinstimmung mit Artikel 32-3 (5) des 1915 Gesetzes erstellten

Berichts des Verwaltungsrates an die Gesellschaft, welcher, nachdem er ne varietur von der unterzeichneten Notarin und
den Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet wurde, der vorliegenden Urkunde beigefügt wurde, um mit ihr zu-
sammen hinterlegt zu werden, das genehmigte Kapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von einer Million
sechshundertneununddreißigtausendzweiundneunzig Euro (EUR 1.639.092,-) (ausgenommen des ausgegebenen Aktien-
kapitals) um einen Betrag von einer Million zweihundertelftausendachthundertneunzehn Euro (EUR 1.211.819,-) auf einen
Betrag von zwei Millionen achthundertfünfzigtausendneunhundertelf Euro (EUR 2.850.911,-) (ausgenommen des ausge-
gebenen Aktienkapitals) zu erhöhen.

Die Versammlung beschließt weiter, Artikel 6.1. der Satzung zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:

6.1. Das genehmigte Kapital, ausgenommen des ausgegebenen Aktienkapitals, wird auf zwei Millionen achthundert-

fünfzigtausendneunhundertelf Euro (EUR 2.850.911,-), bestehend aus zwei Millionen achthundertfünfzigtausendneun-
hundertelf Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-), festgesetzt."

<i>Siebter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Satzung vollumfänglich neu zu fassen, welche nunmehr wie folgt lautet:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit dem Namen Lazada Group S.A.

(die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner
aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1  Zweck  der  Gesellschaft  ist  das  Halten  von  Beteiligungen  jeglicher  Art  an  luxemburgischen  und  ausländischen

Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren jegliche Art von Sicherheiten für die Erfüllung von Verpflichtungen der Ge-

sellschaft sowie für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält,
oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, einräumen und Kredite gewähren, Leistungen
erbringen oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann des Weiteren für jede Gesellschaft, an welcher sie eine direkte oder indirekte Kontrollmehrheit

hält, Leistungen im Bereich der Finanzverwaltung erbringen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Vermögensverwal-
tung (treasury management), Währungsmanagement (currencies management Services), Zins- (interest rate) und Devi-
senkursrisikomanagement (foreign exchange risk management).

2.4 Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher

Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen
und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.5 Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist (i) der Erwerb von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten

durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art,
(ii) die Erteilung von Lizenzen bezüglich dieses geistigen Eigentums und dieser gewerblichen Schutzrechte, und (iii) das
Halten und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.6 Die Gesellschaft wird nicht als alternativer Investmentfonds im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die

Verwalter alternativer Investmentfonds handeln und wird keine anderen Tätigkeit durchführen, die der Aufsicht der Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier unterliegen würde.

2.7 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller, finanzieller und technischer

Natur, sowie solche, welches geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser
Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft ist für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst

werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

59648

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. Innerhalb derselben Gemeinde kann

der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden. Durch Beschluss der Hauptversammlung
der Aktionäre, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere
Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.2 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Verwaltungsrates im Großher-

zogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

B. Gesellschaftskapital - Aktien - Aktienregister - Eigentum und Übertragung von Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1  Das  ausgegebene  Gesellschaftskapital  beträgt  fünfundzwanzig  Millionen  zweihundertneunundzwanzigtausend-

neunzig Euro (EUR 25.290.090), bestehend aus fünfundzwanzig Millionen zweihundertneunundzwanzigtausendneunzig
(25.290.090) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für eine

Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird und im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 oder im Einklang mit Artikel 6 dieser Satzung erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Vorbehaltlich des Artikels 6.2 dieser Satzung werden alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen zu zahlen sind,

bevorzugt den bestehenden Aktionären im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen am ausgegebenen Gesellschaftskapital
jeweils gehaltenen Aktien angeboten. Der Verwaltungsrat bestimmt den Zeitraum, in dem dieses Vorzugsrecht ausgeübt
werden kann. Dieser Zeitraum beträgt nicht weniger als dreißig (30) Tage ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Zeich-
nungszeitraums,  welcher  im  Amtsblatt  des  Großherzogtums  Luxemburg,  dem  Memorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations  (das  „Memorial“)  und  in  zwei  (2)  Luxemburger  Tageszeitungen  im  Einklang  mit  dem  Gesetz  von  1915
veröffentlicht wird, oder, falls alle Aktien Namensaktien sind, ab dem Zeitpunkt der Benachrichtigung der Aktionäre durch
Einschreiben. Jedoch kann, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915, die Hauptversammlung der Aktionäre (i)
im Rahmen eines Beschlusses über die Erhöhung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals oder (ii) anlässlich einer dem
Verwaltungsrat eingeräumten Berechtigung zur Erhöhung des von der Gesellschaft ausgegebenen Gesellschaftskapitals
das Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre durch einen Beschluss begrenzen oder aufheben, oder den Verwaltungsrat
hierzu ermächtigen. Ein solcher Beschluss ist im Einklang mit den Bestimmungen zur Änderung dieser Satzung zu fassen.

Art. 6. Genehmigtes Kapital.
6.1 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt, ausschließlich des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, zwei Mil-

lionen achthundertfünfzigtausendneunhundertelf Euro (EUR 2.850.911), aufgeteilt in zwei Millionen achthundertfünfzig-
tausendneunhundertelf (2.850.911) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

6.2 Der Verwaltungsrat ist hiermit während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung

des betreffenden Gesellschafterbeschlusses im Memorial im Rahmen des genehmigten Kapitals ermächtigt, Aktien aus-
zugeben, Aktienbezugsoptionen für Aktien zu gewähren, und jedes andere in Aktien umwandelbare Wertpapier auszuge-
ben,  um  die  Zuteilung  von  Aktien,  folgend  auf  die  Ausübung  oder  Umwandlung  der  Aktienoptionen  oder  anderer
aktienbasierter Zuteilungen im Rahmen eines Management-Beteiligungsprogramms (management incentive plan) der Ge-
sellschaft vorzunehmen, oder Aktien an bestimmte Führungskräfte oder andere Mitarbeiter der Unternehmensgruppe, von
welcher die Gesellschaft das Mutterunternehmen ist, auszugeben, wobei die Ausgabe an solche Personen und unter solchen
Bedingungen erfolgt, die der Verwaltungsrat für sinnvoll hält und insbesondere ohne den bestehenden Aktionären ein
Vorzugsrecht zur Zeichnung der neu auszugebenden Aktien zu gewähren. Diese Ermächtigung kann einmal oder mehrmals
durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden, welcher in der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Art und Weise gefasst wird, und zwar jeweils für einen Zeitraum, der nicht mehr als fünf (5) Jahre beträgt.

6.3 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher

in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 7. Aktien.
7.1 Unbeschadet des Artikel 22.2 ist das Gesellschaftskapital der Gesellschaft in Aktien aufgeteilt, die alle den gleichen

Nominalwert haben. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien. Es werden keine Bruchteilsaktien ausgegeben.

7.2 Die Aktien sind im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung frei übertragbar.

Die Gesellschaft kann entsprechend den Bedingungen des Gesetzes von 1915 ihre Aktien zurückerwerben und als eigene
Aktien halten.

7.3 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Sofern eine Stammaktie von mehreren Personen

gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Ge-
sellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einer derartigen Aktie solange auszusetzen, bis
eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz,

noch ein vergleichbares, einen Aktionär betreffendes Ereignis, aufgelöst.

7.5 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches von den Aktionären eingesehen werden kann.

Dieses Register enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Der Nachweis über das Eigentum an

59649

L

U X E M B O U R G

Aktien kann durch die Eintragung eines Aktionärs im Aktien register erbracht werden, unbeschadet der Bedingungen für
Übertragungen im Wege der Umbuchung von Bucheffekten, wie in Artikel 7.6 dieser Satzung vorgesehen. Zertifikate über
die Eintragung werden auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Aktionärs an diesen und, in dem in Artikel 7.6 dieser
Satzung vorgesehenen Fall, an die Verwahrstelle (wie unten definiert) ausgegeben. Alle einem eingetragenen Aktionär
zuzustellenden Mitteilungen und Bescheide gelten als ordnungsgemäß zugestellt, wenn sie an die letzte von diesem Akti-
onär an die Gesellschaft kommunizierte Adresse geschickt wurden. Der Verwaltungsrat kann beschließen, weder einen
Eintrag im Aktienregister vorzunehmen, noch eine Übertragungsmitteilung während eines Zeitraums ab dem Stichtag (wie
unten definiert) bis zum Ablauf der betreffenden Hauptversammlung von der Gesellschaft anzuerkennen.

7.6 Handelt es sich bei den Aktien um Namensaktien und sind diese im Aktienregister der Gesellschaft im Namen oder

für Rechnung eines Wertpapierabwicklungssystems oder des Betreibers eines solchen Systems eingetragen und als Buch-
effekte in den Geschäftsbüchern eines Kreditinstituts oder einer professionellen Verwahrstelle oder Unterverwahrstelle
verzeichnet (wobei solche Kreditinstitute, Verwahrstellen und Unterverwahrstellen im Folgenden als „Verwahrstelle“ be-
zeichnet  werden),  räumt  die  Gesellschaft  der  betreffenden  Verwahrstelle,  nach  Vorlage  eines  Nachweises  durch  die
Verwahrstelle über die Eintragung der Bucheffekte, die Ausübung der mit den Aktien verbundenen Rechte entsprechend
der Bucheffekte des betreffenden Aktionärs, einschließlich des Erhalts von Einberufungen zu Hauptversammlungen, die
Zulassung zu Hauptversammlungen und ein Stimmrecht bei Hauptversammlungen ein (die „Zertifikate“). Der Verwal-
tungsrat kann Formvorschriften festlegen, denen diese Zertifikate entsprechen müssen.

Art. 8. Übertragungsbeschränkung. Jede Übertragung von Aktien der Gesellschaft oder Teilen hiervon erfordert eine

Mehrheit von mindestens sechsundsechzig und zwei Drittel Prozent (66 2/3%) der in der Gesellschafterversammlung gültig
abgegebenen Stimmen vorausgesetzt, dass mindestens fünfzig Prozent des Gesellschaftskapitals bei der Gesellschafter-
versammlung vertreten ist. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmabgaben werden nicht berücksichtigt.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 9. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre. Die Aktionäre üben ihre gemeinsamen Rechte in der Haupt-

versammlung der Aktionäre aus. Jede regelmäßig einberufene Hauptversammlung der Aktionäre repräsentiert die Ge-
samtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die ihr durch das Gesetz von 1915 oder
durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen Befugnisse.

Art. 10. Einberufung der Hauptversammlung.
10.1 Die Jahreshauptversammlung wird am Gesellschaftssitz in Luxemburg, oder an einem anderen in der Einberufung

bestimmten Ort in Luxemburg am letzten Donnerstag des Monats Mai eines jeden Jahres um 10:00 Uhr abgehalten. Ist
dieser Tag kein Werktag in Luxemburg, so ist die Jahreshauptversammlung am darauf folgenden Werktag abzuhalten.
Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre können zu jeder Zeit durch den Verwaltungsrat einberufen werden und an
dem in der Einberufung bestimmten Ort zu der darin angegebenen Zeit abgehalten werden.

10.2 Hauptversammlungen der Aktionäre müssen im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser

Satzung und, falls die Aktien an einer ausländischen Börse notiert sind, in Übereinstimmung mit den die Gesellschaft
betreffenden Publizitätspflichten dieser ausländischen Börse, einberufen werden. Falls alle Aktionäre anwesend sind, ist
keine Einberufung oder vorherige Mitteilung notwendig.

10.3 Falls die Aktien der Gesellschaft nicht an einer ausländischen Börse zum Handel zugelassen sind, sind alle am Tag

der Hauptversammlung der Aktionäre im Aktienregister geführten Aktionäre dazu berechtigt, zur Hauptversammlung der
Aktionäre zugelassen zu werden. Sind die Aktien der Gesellschaft an einer ausländischen Börse notiert, so kann der Ver-
waltungsrat  ein/e  dem  der  Hauptversammlung  vorangehende/s  Datum  und  Uhrzeit  als  Stichtag  zur  Zulassung  zur
Hauptversammlung der Aktionäre bestimmen (der „Stichtag“). In einem solchen Fall muss jeder Aktionär, der an der
Hauptversammlung teilnehmen möchte, die Gesellschaft spätestens am Stichtag auf die vom Verwaltungsrat im Einberu-
fungsbescheid festgelegte Weise darüber in Kenntnis setzen. Werden Aktien durch eine Verwahrstelle gehalten, muss ein
Aktionär, der an der Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen möchte, von dieser Verwahrstelle ein oder mehrere
Zertifikate erhalten, welche(s) die Anzahl der auf seinen Namen registrierten Aktien am Stichtag ausweist. In der Zeit
zwischen dem Stichtag und dem Ablauf der Hauptversammlung darf weder ein Eintrag im Aktienregister vorgenommen
werden, noch darf eine Mitteilung einer Aktienübertragung von der Gesellschaft oder einem im Auftrag der Gesellschaft
handelnden Registerführer anerkannt werden, wenn dies vom Verwaltungsrat entschieden wird. Bei einer Übertragung von
Aktien  in  Form  von  Bucheffekten  in  der  Zeit  zwischen  dem  Stichtag  und  dem  Datum  der  Hauptversammlung  ist  der
Veräußerer vom Erwerber ermächtigt, an einer solchen Hauptversammlung teilzunehmen und insbesondere die mit den
Aktien verbundenen Stimmrechte auszuüben. Die Zertifikate sollten bei der Gesellschaft (oder dem in der Einberufung
ernannten  Vertreter)  nicht  später  als  fünf  (5)  Werktage  vor  dem  Tag  der  betreffenden  Hauptversammlung  eingereicht
werden. Vollmachten und Stimmzettel bezüglich solcher Hauptversammlungen müssen zur gleichen Zeit übermittelt wer-
den. Der Verwaltungsrat kann einen kürzeren Zeitraum für die Übermittlung der Zertifikate sowie der Vollmachten oder
Stimmzetteln festlegen.

10.4 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person bevoll-

mächtigt.

10.5 Jeder Aktionär kann seine Stimme durch eine Stimmkarte abgeben, welche per Post oder Fax an den Sitz der

Gesellschaft oder an den in der Einberufung genannten Vertreter gesendet wird. Die Aktionäre können nur solche Stimm-

59650

L

U X E M B O U R G

karten verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurden und deren Inhalt durch den Verwaltungsrat
bestimmt wird.

10.6 Der Verwaltungsrat kann in der Einberufung weitere Bedingungen festlegen, die ein Aktionär zur Teilnahme an

einer Versammlung der Aktionäre einhalten muss (einschließlich, aber nicht begrenzt auf längere Mitteilungsfristen).

Art. 11. Quorum und Stimmrecht.
11.1 Jede Aktie gewährt eine Stimme in Hauptversammlungen der Aktionäre.
11.2 Sofern sich nicht aus dem Gesetz von 1915 oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in

einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre ohne Erfordernis eines Anwesenheitsquorums mit
einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst unabhängig von dem dabei vertretenen Anteil am Gesell-
schaftskapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

11.3 Die Aktionäre können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
11.4 Beschlüsse der Hauptversammlung in folgenden Angelegenheiten bedürfen der Zustimmung von Aktionären, die

mindestens zwei Drittel (2/3) aller von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien halten:

(i) eine Änderung dieser Satzung;
(ii) die Abwicklung, Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft;
(iii) eine Änderung des Gesellschaftskapitals oder die Einführung, Zuteilung oder Ausgabe von Aktien (sofern nicht

über das genehmigte Kapital in Übereinstimmung mit Artikel 6 dieser Satzung vorgenommen); und

(iv) eine Herabsetzung des Gesellschaftskapitals oder die Einziehung oder der Rückkauf von Aktien durch die Gesell-

schaft.

Für die Änderung von Rechten einer Aktienklasse bedarf es zusätzlich zu den Voraussetzungen des vorhergehenden

Satzes der Zustimmung von Aktionären, die mindestens zwei Drittel (2/3) aller Aktien der betreffenden Klasse halten. Die
Einführung, Zuteilung oder Ausgabe von anderen Wertpapieren als Aktien in der Gesellschaft oder die Bewilligung von
Optionen oder Bezugsrechten oder die Umwandlung jeglicher Instrumente in Aktien oder andere Sicherheiten der Gesell-
schaft (sofern nicht über das genehmigte Kapital in Übereinstimmung mit Artikel 6 dieser Satzung vorgenommen), erfordert
die Zustimmung der Aktionäre mit der im ersten Satz dieses Artikels 10.4 festgelegten Mehrheit.

Beschlüsse der Hauptversammlung hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten bedürfen der Zustimmung von Aktio-

nären, die mehr als fünfzig Prozent (50%) aller von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien halten:

(i) die Genehmigung von gesetzlich vorgeschriebenen Abschlüssen der Gesellschaft und konsolidierten Konzernab-

schlüssen;

(ii) die Auszahlung oder die Festsetzung von Dividenden oder anderen Ausschüttungen durch die Gesellschaft; und
(iii) die Ernennung oder die Neubesetzung des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft.
Der Abschluss, die Beendigung oder die Änderung von (a) stillen Beteiligungen und Unterbeteiligungen an der Ge-

sellschaft oder (b) Unternehmensverträgen der Gesellschaft im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG)
erfordert die Zustimmung der Aktionäre mit der im ersten Satz des Artikels 10.4 dieser Satzung festgelegten Mehrheit.

D. Geschäftsführung

Art. 12. Verwaltungsrat.
12.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet. Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden

Befugnisse  im  Namen  der  Gesellschaft  zu  handeln  und  alle  Handlungen  vorzunehmen,  die  zur  Erfüllung  des  Gesell-
schaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diese Satzung der Hauptver-
sammlung der Aktionäre vorbehaltenen Befugnisse.

12.2 Vorbehaltlich der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates, kann der Verwaltungsrat nur Beschlüsse fassen oder

wirksam handeln, wenn mindestens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung des Verwaltungsrats
anwesend oder vertreten ist.

12.3 Gemäß Artikel 60 des Gesetzes von 1915 können die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung

der Gesellschaft einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, oder einer oder mehreren durch den Verwaltungsrat
dazu berufenen Personen, mit gemeinsamer oder Einzelvertretungsbefugnis übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberu-
fung und ihre Befugnisse werden durch einen Verwaltungsratsbeschluss bestimmt.

12.4 Der Verwaltungsrat kann durch notarielle Urkunden oder privatschriftlich Spezialvollmachten erteilen.
12.5 Der Verwaltungsrat setzt sich aus mindestens drei (3) Verwaltungsratsmitgliedern zusammen. Der Verwaltungsrat

wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden aus. Der Verwaltungsrat kann auch einen stellvertretenden Vorsitzenden
und einen Schriftführer ernennen, der weder Aktionär, noch Mitglied des Verwaltungsrats sein muss.

12.6 Vorbehaltlich der Bestimmungen der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates, werden in Versammlungen des

Verwaltungsrates Beschlüsse mit der Zustimmung der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-
glieder gefasst. Im Fall der Stimmgleichheit, hat der Vorsitzende des Rates die entscheidende Stimme.

59651

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern.
13.1 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann wiederernannt werden. Jedes Verwaltungsratsmitglied wird durch einfache

Mehrheit der abgegebenen Stimmen der in einer Hauptversammlung vertretenen Aktien ernannt. Ein Verwaltungsratsmit-
glied kann jederzeit und ohne Grund und vorherige Mitteilung von der Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher
Mehrheit der vertretenen Aktien abberufen werden.

13.2 Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen

Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die Person oder die Gruppe von Personen, die das Verwal-
tungsratsmitglied, welches ausgeschieden ist, nominiert hat, bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, welche
über die endgültige Neubesetzung entscheidet, vorübergehend besetzt werden.

Art. 14. Geschäftsordnung des Verwaltungsrats und der Ausschüsse.
14.1 Der Verwaltungsrat beschließt seine Geschäftsordnung in einem Beschluss und stellt diese in schriftlicher Form

auf.

14.2 Der Verwaltungsrat kann einen oder mehrere Ausschüsse einrichten (ist aber nicht dazu verpflichtet, es sei denn,

dies ist gesetzlich vorgeschrieben). Der Verwaltungsrat bestimmt den Zweck, die Befugnisse und die Zuständigkeiten sowie
die Verfahrensweisen und die anderen Regeln, soweit anwendbar, die für alle eingerichteten Ausschüsse gelten.

14.3 Der Verwaltungsrat kann insbesondere Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Fax,

E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen, vorausgesetzt, dass alle Verwaltungsratsmitglieder
an diesem Beschluss teilnehmen. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Zustimmung auf einem oder mehreren Do-
kumenten getrennt erteilen. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 15. Geschäfte mit Dritten.
15.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2)

beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die gemeinsame oder Einzelunterschrift jedweder Person(en) vertreten,
der(denen) eine solche Befugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist.

15.2 Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder

Einzelunterschrift der Person(en) verpflichtet, der(denen) diese Vollmacht übertragen wurde.

Art. 16. Entschädigung.
16.1 Die Mitglieder des Verwaltungsrats haften nicht persönlich für die Schulden oder sonstigen Verpflichtungen der

Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie für die Erfüllung ihrer Pflichten verantwortlich. Vorbehaltlich zwing-
ender  gesetzlicher  Vorschriften  soll  jede  Person,  die  Mitglied  des  Verwaltungsrats  oder  sonstiger  Mandatsträger  der
Gesellschaft ist oder war, im größtmöglichen, gesetzlich zulässigen Maße durch die Gesellschaft von jeglicher Haftung
oder von angemessenen Kosten freigestellt werden, die im Zusammenhang mit Ansprüchen, Rechtsmitteln, Klagen oder
sonstigen Verfahren, in die die betreffende Person als Partei oder in sonstiger Weise aufgrund ihres bestehenden oder
ehemaligen Mandatsverhältnisses mit der Gesellschaft involviert ist oder war, oder im Zusammenhang mit der Begleichung
oder Beseitigung derselben, eintreten. Die Begriffe „Anspruch“, „Rechtsmittel“, „Klage“ oder sonstigen „Verfahren“ er-
fassen sämtliche bestehenden oder drohende Ansprüche, Rechtsmittel, Klagen oder sonstige Verfahren (ob zivilrechtlicher,
strafrechtlicher oder sonstiger Natur, einschließlich in weiteren Instanzen), und die Worte „Haftung“ und „Kosten“ sollen
ohne Einschränkung Anwaltskosten, Unkosten, Urteile, zu Begleichungs- oder Vergleichszwecken gezahlte Beträge und
sonstige Verbindlichkeiten umfassen.

16.2 Ein Verwaltungsratsmitglied soll nicht entschädigt werden, wenn (i) die Haftung des Verwaltungsratsmitglieds

gegenüber der Gesellschaft oder den Aktionären aus vorsätzlicher, arglistiger, grob fahrlässiger oder rücksichtsloser Ver-
letzung der Mandatspflichten entstand, (ii) wenn es sich um eine Angelegenheit handelt, bezüglich welcher das betreffende
Verwaltungsratsmitglied wegen arglistigem und nicht im Interesse der Gesellschaft liegenden Handeln rechtskräftig ver-
urteilt wurde, oder (iii) es sich um Zahlungen aus einem Vergleich handelt, sofern nicht durch ein zuständiges Gericht oder
durch den Verwaltungsrat bestätigt.

16.3 Das Recht auf Entschädigung ist individuell, es berührt in keiner Weise sonstige gegenwärtige oder zukünftige

Rechte eines Verwaltungsratsmitglieds und besteht einmal entstanden fort, auch wenn die betreffende Person in der Folge
nicht länger Verwaltungsratsmitglied ist, und kommt seinen Erben, dem Testamentsvollstrecker und dem Verwalter zugute.
Keine der hierin enthaltenen Bestimmungen soll etwaige vertragliche oder sonstige gesetzlich vorgesehene Entschädi-
gungsrechte von Angestellten, Verwaltungsratsmitgliedern oder Mandatsträgern beschränken oder berühren. Die Gesell-
schaft ist ausdrücklich befugt, vertragliche Entschädigungen an Angestellte, einschließlich Verwaltungsratsmitglieder oder
Mandatsträger der Gesellschaft nach eigenem Ermessen zu gewähren.

16.4 Ausgaben in Verbindung mit der Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung von Ansprüchen, Rechtsmitteln,

Klagen oder sonstigen Verfahren im Sinne dieses Artikels 16 sollen, vor der endgültigen Entscheidung über ihre Erstat-
tungsfähigkeit,  von  der  Gesellschaft  vorgestreckt  werden,  sofern  sich  der  betreffende  leitende  Angestellte  oder  das
Verwaltungsratsmitglied gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, diese an die Gesellschaft zurück zu erstatten, sollte sich
im Nachhinein herausstellen, dass dem betreffenden Mandatsträger oder dem Verwaltungsratsmitglied kein Entschädi-
gungsanspruch gemäß dieses Artikels zusteht.

59652

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Interessenkonflikt.
17.1 Soweit gesetzlich erforderlich hat jedes Verwaltungsratsmitglied, welches an einer Transaktion, die dem Verwal-

tungsrat  zur  Entscheidung  vorliegt,  direkt  oder  indirekt  ein  persönliches  Interesse  hat,  welches  den  Interessen  der
Gesellschaft entgegensteht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenkonflikt zu informieren und dafür zu sorgen, dass
die Erklärung im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen wird. Das betroffene Verwaltungsratsmitglied darf
weder an der Beratung über die in Frage stehend Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Über einen solchen
Interessenkonflikt ist auf der nächsten Hauptversammlung Bericht zu erstatten.

17.2 Kein Vertrag oder andere Transaktion zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wird

durch die Tatsache, dass ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches Interesse an einer solchen Gesellschaft oder Firma
hat oder durch die Tatsache, dass er Verwaltungsratsmitglied, Partner, leitender Angestellter, Vertreter, Berater oder An-
gestellter einer solchen Gesellschaft oder Firma ist, beeinflusst oder ungültig.

E. Wirtschaftsprüfer

Art. 18. Unabhängige Wirtschaftsprüfer.
18.1 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft sind von einem oder mehreren zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprü-

fern (réviseurs d’entreprises agréés), die von der Hauptversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrats (welcher selbst
auf Vorschlag des Prüfungsausschusses handelt) ernannt werden, zu prüfen. Die Hauptversammlung der Aktionäre be-
stimmt die Anzahl des/der Wirtschaftsprüfer/s und ihre Amtszeit.

18.2 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer kann jederzeit mit Grund (oder mit seiner Zustimmung) durch die Hauptver-

sammlung  der  Aktionäre  abberufen  werden.  Ein  zugelassener  unabhängiger  Wirtschaftsprüfer  (réviseur  d’entreprises
agréé) kann wiederernannt werden.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 19. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 20. Gewinne.
20.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Verwaltungsrat erstellt im Einklang mit

den Anforderungen des Gesetzes von 1915 ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Ver-
lustrechnung.

20.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals beträgt.

20.3 Auf Vorschlag des Verwaltungsrates bestimmt die Jahreshauptversammlung der Aktionäre, wie der verbleibende

jährliche Nettogewinn der Gesellschaft verwendet werden soll. Jede Aktie erhält den gleichen Betrag.

20.4 Durch einen Aktionär erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Aktionärs ebenfalls der

gesetzlichen  Rücklage  zugeführt  werden.  Im  Falle  einer  Herabsetzung  des  Gesellschaftskapitals  kann  die  gesetzliche
Rücklage entsprechend herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals
nicht übersteigt.

20.5 Werden Aktien von einer Verwahrstelle gehalten, so tätigt die Gesellschaft Dividendenzahlungen oder andere

Barzahlungen, durch Aktien oder andere Wertpapiere nur an die im Aktienregister benannte Verwahrstelle im Einklang
mit ihren Anweisungen, und eine solche Zahlung befreit die Gesellschaft von jeglichen Verpflichtungen in dieser Ange-
legenheit.

20.6 Dividenden, die nicht innerhalb von fünf (5) Jahren nach Fälligkeit geltend gemacht wurden, fallen an die Gesell-

schaft zurück.

Art. 21. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
21.1 Der Verwaltungsrat kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 Abschlagsdividenden aus-

zahlen.

21.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-

mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 22. Liquidation.
22.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt,

welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und
die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren
die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft.

59653

L

U X E M B O U R G

22.2 Sofern nicht anders in dieser Satzung festgelegt, wird der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung

der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss an die Aktionäre im Einklang und in Übereinstimmung mit einer etwaig zum
Zeitpunkt der Auflösung bestehenden gegenseitigen Gesellschaftervereinbarung verteilt.

H. Anwendbares Recht

Art. 23. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Achter Beschluss

Die Versammlung beschließt, die Niederlegung ihrer Ämter als Verwaltungsratsmitglieder durch die folgenden Perso-

nen mit sofortiger Wirkung anzunehmen:

- Ulrich Ludwig BINNINGER,
- Chee Meng YAP,
- Christoph BARCHEWITZ,
- Lorenzo GRABAU,
- Robin TERRELL,
- Julia ATWOOD,
- Scott COLLINS,
- Nicholas CATOR, and
- Daniel SHINAR,
und die Bestellung der folgenden Verwaltungsratsmitglieder zu bestätigen, wovon jeder ursprünglich am 1. April 2015

bestellt wurde:

- Oliver SAMWER,
- Peng Huat ANG, und
- Maximilian BITTNER,
und mit sofortiger Wirkung die folgenden Personen als neue Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft für die ge-

setzlich zulässige Höchstdauer (d.h. einer Dauer von sechs Jahren ab dem Datum dieser Urkunde) zu ernennen:

- John Michael EVANS,
- Wu QIAN, und
- Kumara Guru GOWRAPPAN.
Da die Tagesordnung erledigt ist, wird die Versammlung geschlossen um 18.30 Uhrzeit.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde zu

tragen sind, werden auf ungefähr EUR 5.900,- geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum, aufgenommen.
Die  unterzeichnete  Notarin,  die  die  englische  Sprache  beherrscht  und  spricht,  erklärt  hiermit,  dass  die  vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung ist die englische Fassung maßgebend.

Die  vorstehende  Urkunde  ist  den  erschienenen  Parteien,  welche  der  Notarin  mit  Namen,  Vornamen  und  Wohnsitz

bekannt sind, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesen erschienenen Parteien unterzeichnet worden.

Gezeichnet: D. DE PASQUALE, B. TASSIGNY, F. BERNARD, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 14 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/12264. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 21. April 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016096920/964.
(160066876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.

59654

L

U X E M B O U R G

Landa Bay Mediainvest, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 129.940.

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth of January.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of “LANDA BAY MEDIAINVEST”, a private

limited liability company ("société à responsabilité limitée") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg,
established and having its registered office in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, inscribed in the Trade and Companies'
Registry of Luxembourg, section B, under the number 129.940, (the”Company”), incorporated pursuant to a deed dated
July 4 

th

 , 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1848 of August 31 

st

 , 2007.

The Meeting is presided by Mrs Catherine BEERENS, employee, with professional address in Howald.
The Chairman appoints as secretary Mrs Géraldine YERNAUX, employee, with professional address in Howald.
The Meeting elects as scrutineer Mrs Vanessa TIMMERMANS, employee, with professional address in Howald.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary

to state:

A) That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Transfer, with retroactive effect on January 1 

st

 , 2016, of the registered office of the Company from L-1449 Luxem-

bourg, 18, rue de l’Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

2. Subsequent amendment of the statutes.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an

attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members
of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting

and  the  officiating  notary,  will  remain  annexed  to  the  present  deed  to  be  filed  at  the  same  time  with  the  registration
authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,

present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>Sole resolution

The Meeting resolves, with retroactive effect on January 1 

st

 , 2016, to transfer the registered office of the Company

from L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen and to amend consequently article 5,
first sentence of the statutes, as follows:

“ Art. 5. First sentence. The registered office is established in the Municipality of Hesperange (Grand-Duchy of Lu-

xembourg).

No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak,

the Chairman then adjourned the Meeting.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-

pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at seven hundred fifty Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and

residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

59655

L

U X E M B O U R G

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-neuf janvier.
Pardevant  Nous  Maître  Carlo  WERSANDT,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  (Grand-Duché  de  Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie

l'assemblée  générale  extraordinaire  (l'"Assemblée")  des  associés  de  LANDA  BAY  MEDIAINVEST,  une  société  à

responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1449 Lu-
xembourg, 18, rue de l’Eau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
129.940, (la "Société"), constituée suivant acte reçu en date du 4 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1848 du 31 août 2007.

L'Assemblée est présidée par Madame Catherine BEERENS, employée, demeurant professionnellement à Howald.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Géraldine YERNAUX, employée, demeurant professionnellement à

Howald.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, demeurant professionnellement

à Howald.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert, avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2016, du siège social de la Société de L-1449 Luxembourg, 18, rue de

l’Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

2. Modification afférente des statuts.
B) Que les associés, présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les associés présents, les mandataires de ceux repré-
sentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des associés représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le

notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les associés, présents ou représentés, déclarent

avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux
formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Assemblée décide, avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2016, de transférer le siège social de la Société de L-1449

Luxembourg, 18, rue de l’Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen et de modifier en conséquence l’article 5, première
phrase des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Première phrase. Le siège social est établi dans la commune de Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des associés présents ou représentés ne de-

mandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à sept cent cinquante euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdites

comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. BEERENS, G. YERNAUX, V. TIMMERMANS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 2 février 2016. 2LAC/2016/2339. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

59656

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 4 février 2016.

Référence de publication: 2016064593/109.
(160025929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Lion Property, Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 148.255.

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth of January.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of LION PROPERTY, a public limited company

("société anonyme") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its registered office
in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under
the number 148.255, (the”Company”), incorporated pursuant to a deed dated September 18 

th

 , 2009, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1932 of October 5 

th

 , 2009.

The Meeting is presided by Mrs Catherine BEERENS, employee, with professional address in Howald.
The Chairman appoints as secretary Mrs Géraldine YERNAUX, employee, with professional address in Howald.
The Meeting elects as scrutineer Mrs Vanessa TIMMERMANS, employee, with professional address in Howald.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary

to state:

A) That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Transfer, with retroactive effect on January 1 

st

 , 2016, of the registered office of the Company from L-1449 Luxem-

bourg, 18, rue de l’Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

2. Subsequent amendment of the statutes.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an

attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members
of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting

and  the  officiating  notary,  will  remain  annexed  to  the  present  deed  to  be  filed  at  the  same  time  with  the  registration
authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,

present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>Sole resolution

The Meeting resolves to transfer, with retroactive effect on January 1 

st

 , 2016, the registered office of the Company

from L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen and to amend consequently article 2,
first paragraph of the statutes, as follows:

“ Art. 2. First paragraph. The registered office is established in the Municipality of Hesperange (Grand-Duchy of Lu-

xembourg).

No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak,

the Chairman then adjourned the Meeting.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-

pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at seven hundred fifty Euros.

59657

L

U X E M B O U R G

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and

residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-neuf janvier.
Pardevant  Nous  Maître  Carlo  WERSANDT,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  (Grand-Duché  de  Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de LION PROPERTY, une société anonyme régie

par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 148.255, (la "Société"),
constituée suivant acte reçu en date du 18 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1932 du 5 octobre 2009.

L'Assemblée est présidée par Madame Catherine BEERENS, employée, demeurant professionnellement à Howald.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Géraldine YERNAUX, employée, demeurant professionnellement à

Howald.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, demeurant professionnellement

à Howald.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert, avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2016, du siège social de la Société de L-1449 Luxembourg, 18, rue de

l’Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

2. Modification afférente des statuts.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés

sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

D)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  et  que  les  actionnaires,  présents  ou  représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Assemblée décide, avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2016, de transférer le siège social de la Société de L-1449

Luxembourg, 18, rue de l’Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen et de modifier en conséquence l’article 2, alinéa 1
des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. Alinéa 1. Le siège social est établi dans la commune de Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne

demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à sept cent cinquante euros.

59658

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdites

comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. BEERENS, G. YERNAUX, V. TIMMERMANS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 2 février 2016. 2LAC/2016/2341. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 4 février 2016.

Référence de publication: 2016064601/109.
(160025950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Micro Focus Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 275.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 203.440.

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-eight of January.
Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Minerva Finance S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) having its registered

address at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 190.756,

here represented by Peggy Simon, private employee, with professional address at 9 Rabatt, L-6475 Echternach, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on January 26, 2016.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the entity appearing and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing entity is the sole shareholder of the private limited liability company (“société à responsabilité limitée”)

established in Luxembourg under the name of “Micro Focus Finance S.à r.l.”, having its registered office at 16, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, under registration process with the Luxembourg Trade and
Companies Register (the “Company”), incorporated pursuant to a deed by the notary Jean SECKLER, residing in Jun-
glinster, in replacement if the undersigned notary on January 20, 2016, not yet published in the Mémorial C - Recueil des
Sociétés et Associations.

II. The Company’s share capital is set at twenty-five thousand U.S. Dollars (USD 25,000.-) represented by twenty-five

thousand (25,000) shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.

III. The appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following

resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by two hundred and fifty thousand U.S.

Dollars (USD 250,000.-) in order to raise it from its present amount of twenty-five thousand U.S. Dollars (USD 25,000.-)
to two hundred and seventy-five thousand U.S. Dollars (USD 275,000.-) by the creation and issue of two hundred and fifty
thousand (250,000) new shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each (the “New Shares”).

<i>Subscription - Payment

Thereupon, Minerva Finance S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to the New Shares and

to have them fully paid up in the amount of two hundred and fifty thousand U.S. Dollars (USD 250,000.-), along with the
payment of a share premium in the amount of two million, two hundred and fifty thousand U.S. Dollars (USD 2,250,000.-),
by a contribution in cash in the amount of two million, five hundred thousand U.S. Dollars (USD 2,500,000.-) so that from
now on the Company has at its free and entire disposal this amount, as has been certified to the undersigned notary.

59659

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

As a consequence of the capital increase, the shareholder resolved to amend and fully restate article 6 of the Company’s

articles of association as follows:

“ Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at two hundred and seventy-five thousand U.S. Dollars (USD

275,000.-) represented by two hundred and seventy-five thousand (275,000) shares with a nominal value of one U.S. Dollar
(USD 1.-) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions
to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve”.

<i>Third resolution

The sole shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

hereby empowered and authorized any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration
of the New Shares in the share register of the Company.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, the English

version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the entity appearing, who is known to the notary by his Surname,

Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L’an deux mille seize, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Minerva Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 16,

Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxemburg sous le numéro B 190.756,

ici représentée par Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-

Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 26 janvier 2016.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de «Micro Focus Finance S.à r.l.», ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg Grand-Duché de
Luxembourg, en cours d’enregistrement auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la «Société»),
constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en remplacement du notaire instru-
mentant, en date du 20 janvier 2016, en cours de publication au Mémorial C -Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille dollars U.S. (USD 25.000,-) représenté par vingt-cinq mille

(25.000) parts sociales d’une valeur nominale d’un dollar U.S. (USD 1,-) chacune.

III. La comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique a décidé d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante mille dollars U.S. (USD

250.000,-) pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille dollars U.S. (USD 25.000,-) à deux cent soixante-quinze
mille dollars U.S. (USD 275.000,-) par la création et l’émission de deux cent cinquante mille (250.000) nouvelles parts
sociales d’une valeur nominale d’un dollar U.S. (USD 1,-) (les «Nouvelles Parts Sociales»).

<i>Souscription - Libération

Sur ce, Minerva Finance S.à r.l., prénommée, par son mandataire, a déclaré souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et

les libérer intégralement pour un montant de deux cent cinquante mille dollars U.S. (USD 1,-), avec le paiement d’une
prime d’émission d’un montant de deux millions, deux cent cinquante mille dollars U.S. (USD 2.250.000,-), par un apport
en numéraire d’un montant de deux millions, cinq cent mille dollars U.S. (USD 2.500.000,-) de sorte que la Société a dès
maintenant à sa libre et entière disposition cette somme ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

59660

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

En conséquence de l’augmentation de capital de la Société, l’associé unique a décidé de modifier et reformuler l’article

6 des statuts de la Société comme suit:

« Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à la somme de deux cent soixante-quinze mille dollars U.S. (USD

275.000,-) représenté par deux cent soixante-quinze mille (275,000) parts sociales d’une valeur nominale d’un dollar U.S.
(USD 1.-) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le
remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale».

<i>Troisième résolution

L’associé unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter les modifications qui

précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à l’inscription
des Nouvelles Parts Sociales dans le registre des parts sociales de la Société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le présent

acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état

et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 01 février 2016. Relation: GAC/2016/855. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 11 février 2016.

Référence de publication: 2016064622/121.
(160026564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Magewo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 29, rue Notre Dame.

R.C.S. Luxembourg B 203.762.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsechzehn, am ersten Februar.
Vor der unterzeichneten Notarin Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Gerhard HENZE, Bankkaufmann, geboren in Berlin (Deutschland) am 13. Januar 1943, wohnhaft in CH-8126

Zumikon, Weberacher 10,

hier vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thomas WEIMER, auf Grund einer Vollmacht gegeben in Frankfurt am Main

(Deutschland) am 21. Januar 2016.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung „ne varietur“ durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar ge-

genwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Dieser Komparent ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihm zu gründenden Aktiengesellschaft wie

folgt zu beurkunden.

Art. 1. Unter der Bezeichnung "MAGEWO S.A." wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort der Gemeinde Lu-

xembourg und durch Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung zu den Bedingungen, welche für die
Abänderung der Satzungen erforderlich sind an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl

im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

59661

L

U X E M B O U R G

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche

geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederhers-
tellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden; die Gesellschaft bleibt jedoch der luxemburgischen Gesetzge-
bung unterworfen.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 2. Die Gesellschaft hat zum Zweck jedwelche Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften,

der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere
Art, von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die
Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen

Gesellschaft beteiligen und an verbundene Gesellschaften alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien oder auf
andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung an verbundene Gesellschaften geben.

Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, kommerziellen und

industriellen Operationen tätigen, beweglicher oder unbeweglicher Natur, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und
Durchführung ihres Zweckes.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000.- EUR), und ist eingeteilt auf einunddreißig-

tausend (31.000) Aktien zu je ein Euro (1.- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Alle ausgegebenen Inhaberaktien müssen bei einem Verwahrer hinterlegt werden welcher durch einen Beschluss des

Verwaltungsrats bestellt wird.

Der Verwaltungsrat informiert die Gesellschafter über diese Bestellung und über jedwede Änderung betreffend den

Verwahrer innerhalb 15 (fünfzehn) Werktagen.

Beschlüsse über die Ernennung oder die Kenntnisnahme von Änderungen betreffend den Verwahrer müssen, gemäß

Artikel 11bis (1§, 3) des Gesetzes vom 10. August 1915 über handelsrechtliche Gesellschaften, registriert und veröffentlicht
werden

Ein Inhaberaktienregister wird vom Verwahrer gehalten.
Dieses Register weist die Identität eines jeden Gesellschafters, die Anzahlt oder Einheiten von Inhaberaktien welche

von diesen gehalten wird, den Zeitpunkt der Verwahrung, sowie Übertragungen, Einziehung oder Umtausch von Inhabe-
raktien, auf.

Der Anteilsbesitz der Inhaberaktien wird gemäß Eintragung im Inhaberaktienregister geltend gemacht.
Nach schriftlicher Aufforderung des Eigentümers von Inhaberaktien, wird diesem innerhalb 8 (acht) Kalendertage eine

Bescheinigung ausgestellt welche die Eintragungen seiner Inhaberaktien zusammenfasst.

Übertragungen von Inhaberaktien inter vivos werden gegenüber Dritten und Gesellschaft wirksam durch die Eintragung

dieser Übertragung im Inhaberaktienregister durch den Verwahrer, auf Basis und durch Erhalt eines jeden Dokuments
welches deren Eigentumsübertragung zwischen Übertragendem und Empfänger nachweist.

Die Anzeige einer Übertragung von Todes wegen beim Verwahrer ist gültig, wenn kein Widerspruch vorhanden ist,

durch die Hinterlegung eines Todesscheins welcher durch den zuständigen Richter oder Notar ausgestellt wurde.

Rechte von ausgegebenen Inhaberaktien welche weder verwahrt noch ordnungsgemäß registriert sind, gelten als aus-

gesetzt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden

Aktien.

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen.

Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär kann der Verwaltungsrat, in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 25. August

2006, aus nur einem Mitglied bestehen, welcher nicht Aktionär zu sein braucht.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können jederzeit abberufen werden.
Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit  aus,  so  können  die  auf  gleiche  Art  ernannten  verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einen  vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirkli-

chung  des  Gesellschaftszweckes  notwendig  sind  oder  diesen  fördern.  Alles,  was  nicht  durch  das  Gesetz  oder  die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

59662

L

U X E M B O U R G

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Delegierten bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem

anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Delegierte des Verwaltungsrates wird zum ersten Mal durch die erste Hauptversammlung ernannt.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich
erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Ferns-
chreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; jeder einzelne der nachfolgend aufgeführten

Verwaltungsratmitglieder hat ein Vetorecht.

Vetorecht bedeutet, dass gegen die Stimme der o.g. Verwaltungsratmitglieder keine Beschlussfassung möglich ist.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung  der  Gesellschaft  an  einen  oder  mehrere  Verwaltungsratsmitglieder,  Direktoren,  Geschäftsführer  oder  andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritte durch (1) Einzelunterschrift ihres alleinigen Verwaltungsratsmitglieds, im Falle

von mehreren Verwaltungsmitgliedern durch (2) die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch
(3) die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrats oder eines Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechts-
gültig verpflichtet.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brau-

chen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 15. des Monats Mai, um 11.00 Uhr, am Gesellschaftssitz

oder an einem andern, in der Einberufung angebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 9. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-

dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt
der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu billigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividende auszuzahlen.

Art. 11.  Die  Bestimmungen  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften  einschliesslich  der

Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2016
2. Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2017 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt der Erschienene, Herr Gerhard HENZE, vorgenannt, alle einunddreißig-

tausend (31.000) Aktien für einem Betrag von einem Euro (1.- EUR) zu zeichnen und einzuzahlen.

Die einunddreißigtausend (31.000) Aktien wurden zu hundert Prozent (100 %) in bar eingezahlt; demgemäss verfügt

die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), wie dies
dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften

vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro (1.500.- EUR).

59663

L

U X E M B O U R G

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann treten die eingangs erwähnten Parteien die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich für wirksam einberufen erklären und fassen, nachdem sie die ordnungsge-
mässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf eins (1) und die der Abschlusskommissare auf eins (1) fest-

gesetzt.

2) Zum Mitglied des Verwaltungsrates wird ernannt:
Herr  Gerhard  Henze,  Bankkaufmann,  geboren  in  Berlin  (Deutschland)  am  13.  Januar  1943,  wohnhaft  in  CH-8126

Zumikon, Weberacher 10.

3) Zum Kommissar wird ernannt:
Die  Gesellschaft  ANKIN  Rechtsanwaltsgesellschaft  mbH,  eine  deutsche  GmbH  mit  Sitz  in  Bonameser  Strasse  9a,

D-60433 Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 98136.

4)  Die  Mandate  des  Verwaltungsratsmitgliedes  und  des  Kommissars  enden  mit  Schluss  der  ordentlichen  Hauptve-

rammlung des Jahres 2021.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2240 Luxemburg, 29, rue Notre Dame.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: T. Weimer et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 04 février 2016. 2LAC/2016/2652. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2016.

Référence de publication: 2016064636/159.
(160026424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Torno Global Contracting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 133.381.

Le Bilan arrêté au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2016080508/10.
(160046123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.

PFCE Czech I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 615.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 95.697.

Les comptes consolidés de CBRE Property Fund Central and Eastern Europe au 31 décembre 2014 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2016.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016080380/13.
(160045853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

59664


Document Outline

AIM Services S.à r.l.

Airfly Motorsport S.A.

Cale Finance S.A.

CapAssurances S.à r.l.

Carpini S.à r.l.

Cavallo Lux

Ceca Invest S.A.

COM-Invest Management Distriland S.C.A.

Ed Business &amp; Cie S.C.A.

Energering Consult S.à r.l.

Exul Investissements Immobiliers S.A.

Fiduciaire Comptable et Fiscale de Martelange SA

Gaj Invest SA

Garage Intini S.A.

GEORGES BOISSENET, Société à responsabilité limitée

Heirens Constructions S.àr.l.

HPS Cactus Direct Lux S.à r.l.

Inerit S.à r.l.

IRE Asia Lux HoldCo 1 S.à r.l.

JC Trading S.A.

Josy Welter Bertrange S.à.r.l

Landa Bay Mediainvest

La Rose Blanche Immobilière S.A.

Lazada Group S.A.

Les Jardins d'Altlinster

Lion Property

Loisirs Ré S.A.

Magewo S.A.

Malasi S.A.

Malasi S.A.

Malasi S.A.

Mar Europe S.A.

M.A.V.I. Coaching S.à.r.l.

Mercedes-Benz Luxembourg S.A.

Micro Focus Finance S.à r.l.

Milestone Investisseurs 2014 GP S.à r.l.

Milestone Investisseurs GP S.à r.l.

NGS

PFCE Czech I S.à r.l.

Rigatte SA, SPF

Stratton II S.à r.l.

Tataski Holdings S.à r.l.

Torno Global Contracting S.A.