This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1149
18 avril 2016
SOMMAIRE
Betvest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55109
Blue Colibri Capital Partners Fund II SCA, SI-
CAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55125
Bluehouse Accession Property Holdings III S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55137
Borletti Group Management S.A. . . . . . . . . . .
55109
Cegyco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55106
Cienega Holding S.à.r.l./B.V. . . . . . . . . . . . . . .
55109
Dakar Holdings S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55108
DCIT Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55142
Dirbach Plage Immobilier S.à r.l. . . . . . . . . . .
55144
Douglas Private S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . .
55146
Duke Investments & Participations S.A. . . . . .
55140
Eiffel Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55147
Energy T.I. Industrial S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
55112
Ensemble environnement / patrimoine écologi-
que, culturel et artistique . . . . . . . . . . . . . . . .
55117
Equifax Luxembourg (No. 7) S.à r.l. . . . . . . . .
55107
Eudial Nature S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55106
European Healthcare Partners S.C.S. . . . . . . .
55106
Falcon Investment A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55106
GPB Credit Risk Management S.A. . . . . . . . .
55110
Grace Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
55116
Granada S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55110
Griffon Capital S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . .
55111
HCP Health Care Products S.A. . . . . . . . . . . .
55111
Heirens Constructions S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
55152
Hong Kong Garden Capellen Sàrl . . . . . . . . . .
55150
Horizont Immobilien S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
55152
IB Management Services S.A. . . . . . . . . . . . . .
55107
Interdean Daleiden S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55151
ITSmart S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55112
Javi Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55113
J. & M. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55107
John Deere Cash Management S.A. . . . . . . . .
55112
Lakeside Corporation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
55114
La Maison S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55113
Les Résidences d'Howald S.A. . . . . . . . . . . . . .
55114
Louriçal S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55108
Mastignac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55106
Mastu Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55116
Midnight Investments Partners SCSp . . . . . . .
55107
MOF III Investments S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
55116
Mohawk International Holdings S.à r.l. . . . . .
55108
Murci Group SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55108
Negentropy SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55115
Novilog s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55117
Ricano S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55118
Santa Fe Relocation Services SA . . . . . . . . . . .
55151
Tellus Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55152
Thot SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55109
55105
L
U X E M B O U R G
Falcon Investment A.G., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 72.306.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement du 04/02/2016, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale a déclaré
dissoute et ordonné la liquidation de la société FALCON INVESTMENT A.G., Société Anonyme, avec siège social à
L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen, de fait inconnue à cette adresse. Ce même jugement a nommé juge-commissaire
Monsieur Thierry SCHILTZ, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et désigné comme liquidateur Maître Radia
DOUKHI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Me Radia DOUKHI.
Référence de publication: 2016062199/16.
(160022988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Eudial Nature S.A., Société Anonyme,
(anc. Mastignac S.A.).
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 85.186.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 5 février 2016.
<i>Pour la société
i>Joëlle SCHWACHTGEN
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2016062178/13.
(160023352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
European Healthcare Partners S.C.S., Société en Commandite simple.
Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 200.381.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2016.
Référence de publication: 2016062159/10.
(160023130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Cegyco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7740 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.
R.C.S. Luxembourg B 58.432.
Il résulte de la résolution circulaire du Conseil d’Administration du 17 décembre 2015 que:
Suite à la démission avec effet immédiat de Monsieur Pascal PIXIUS de ses fonctions d’administrateur et de délégué à
la gestion journalière de la société CEGYCO S.A., les administrateurs restant en fonction se sont réunis pour coopter un
nouvel administrateur.
Il est décidé de coopter comme nouvel administrateur et délégué à la gestion journalière - avec effet immédiat - Monsieur
Jean-Claude Backendorf, née le 2 décembre 1966 à Pétange (Luxembourg) et ayant son adresse professionnelle 2, avenue
Gordon Smith L-7750 Colmar-Berg et ce jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui procédera à l'élection définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016062076/15.
(160023408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
55106
L
U X E M B O U R G
Equifax Luxembourg (No. 7) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 200.390.
Les statuts coordonnés au 5 janvier 2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016062153/11.
(160023479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
IB Management Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 47.699.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire en date du 8 décembre 2015:i>
- Noel McCORMACK, 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg a démissionné de sa fonction d'administrateur de
la société avec effet au 30 novembre 2015.
- Laure PAKLOS, 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, est nommé administrateur de la société avec effet 1
er
Décembre 2015 et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2019.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016063780/15.
(160025261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
J. & M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 152.150.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire tenue à Luxembourg le 20 mai 2015 à 14.30 heures.i>
Les mandats d'administrateur de Messieurs Joeri STEEMAN et Kris GOORTS (demeurant tous les deux profession-
nellement: 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg) sont renouvelés pour une période de six ans.
Les mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration de Monsieur Frederik ROB (demeurant pro-
fessionnellement: 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg) sont renouvelés pour une période de six ans.
Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Régis PIVA (demeurant professionnellement: 24, rue Saint Ma-
thieu L-2138 Luxembourg) est renouvelé pour une période de six ans.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2016063798/15.
(160025296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Midnight Investments Partners SCSp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 185.722.
EXTRAIT
Suite à un acte reçu par le notaire Henri BECK, de résidence à Echternach, en date du 31 décembre 2015, les données
concernant le siège de la société Mareth Capital S.à r.l. (anciennement Mareth S.à r.l.), étant associé et associé gérant
commandité de la société Midnight Investments Partners SCSp, ont été modifiées telles que le nouveau siège se situé à
L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
Echternach, le 28 janvier 2016.
Référence de publication: 2016063879/13.
(160025397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
55107
L
U X E M B O U R G
Mohawk International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.175,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 110.608.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 5 février 2016:i>
Hermanus Roelof Willem Troskie a démissionné de sa fonction de gérant de classe B avec effet immédiat.
Andrew Smith, ayant pour adresse professionnelle le 56 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, est nommé gérant de
classe B avec effet immédiat pour une période illimitée.
Luxembourg, le 10 février 2016.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016063882/16.
(160025863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Murci Group SARL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 203.583.
La société FINEX.LU S.A. SOPARFI, RCSL B144705, siégeant 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, déclare
avoir vendu en date du 26.01.2016:
12,500 parts de la société Murci Group SARL, siégeant 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
à
- Monsieur Jan RABIEGA né le 6/5/1968 à Kepno, Pologne, résidant Leka Mroczenska 102 A, PL-63-604 Leka Mroc-
zenska, Pologne
Certifié exact et sincère
Paddock Fund Administration, Luxembourg
Référence de publication: 2016063886/15.
(160025531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Louriçal S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-2221 Luxembourg, 1, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg E 682.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Les associés réunis en assemblée générale le 8 septembre 2015, ont prononcé à l'unanimité la clôture de la liquidation
de la société civile Louriçal S.C.I. et ont mis fin aux fonctions de Madame Maria Elisabete JORDAO ROSA, demeurant
à L-3961 Ehlange, 11, rue de Roedgen, nommée liquidatrice en date du 10 novembre 2011.
Luxembourg, le 11 février 2016.
Référence de publication: 2016063830/13.
(160025662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Dakar Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 200.897.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2016.
Référence de publication: 2016065879/10.
(160028432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
55108
L
U X E M B O U R G
Betvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 185.906.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique du 2 décembre 2015i>
1. L'Assemblée Générale décide de nommer au poste de gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Joao
Luis Da Fonseca Ferreira, né le 21/05/1980 à C Se Nova Coimbra, Portugal, demeurant professionnellement au 18-20, rue
Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach.
<i>Pour la société
i>Joao Luis Da Fonseca Ferreira
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2016064289/15.
(160025983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Cienega Holding S.à.r.l./B.V., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 197.297.
En date du 03 février 2016, les associés de la Société ont pris la résolution suivante:
Nomination de Madame Muriel Basso, née le 1
er
avril 1978 à Metz, France, ayant son adresse professionnelle au 46A,
Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité de Gérant de la Société à compter du 03 février 2016 pour une durée
illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Muriel Basso
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016064331/15.
(160026039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Borletti Group Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 116.174.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 5 février 2016i>
<i>Résolution:i>
L'assemblée a décidée de nommer, pour une période expirant à l'assemblée ordinaire qui se tiendra en 2021:
<i>Commissaire aux comptes:i>
- Picigiemme S.à r.l., ayant son siège social au 38 Haerebierg, L-6868 Wecker.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 10 février 2016.
Référence de publication: 2016064281/14.
(160026140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Thot SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 130.859.
Le bilan et annexes au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016076155/10.
(160040783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
55109
L
U X E M B O U R G
GPB Credit Risk Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 112.162.
Les décisions suivantes ont été prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du
26 janvier 2016:
- acceptation de la démission de Monsieur Erik van Os en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 15 octobre
2015;
- nomination, en tant que nouvel administrateur de la Société, de Madame Maud Meyer, née le 25 mai 1982 à Amiens
(France), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet rétroactif au 15
octobre 2015. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019;
- confirmation que le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé des administrateurs suivants:
* Monsieur Patrick van Denzen;
* Monsieur Fabrice Rota; et
* Madame Maud Meyer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2016.
<i>Pour la Société
i>Fabrice Rota
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016066017/23.
(160028363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Granada S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 98.258.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 10 février 2016i>
L'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:
L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats de:
- M. Thierry Grosjean, né le 3 août 1975 à Metz (France), ayant son adresse professionnelle au L-3372 Leudelange, 15,
rue Léon Laval;
- Melle. Radia Taddrart, née le 17 novembre 1985 à Epinal (France), ayant son adresse professionnelle au L-3372
Leudelange, 15, rue Léon Laval;
- Mr. Diogo Alves de Oliveira, né le 14 mars 1983 à Macieira de Cambra/Vale de Cambra (Portugal), ayant son adresse
professionnelle au L-3372 Leudelange, 15, me Léon Laval;
aux fonctions d'administrateurs.
- Kohnen & Associés S à.r.l., ayant son siège social 62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, enregistrée au
registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 114.190,
à la fonction de Commissaire aux Comptes.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 Février 2016.
<i>Pour Granada S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016066018/26.
(160028625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
55110
L
U X E M B O U R G
Griffon Capital S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 191.040.
<i>Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 19 novembre 2015i>
<i>à 10.45 heures au siège social de la sociétéi>
<i>Résolutionsi>
Après délibération, les résolutions suivantes sont successivement mises au vote:
<i>Première résolutioni>
La révocation de l'administrateur Monsieur Pierre Goffinet avec effet immédiat. Cette résolution est adoptée à l'unani-
mité.
<i>Deuxième résolutioni>
La démission de l'administrateur Monsieur Claude Schroeder, demeurant au 498, route de Thionville, L-5886 Alzingen,
avec effet immédiat.
<i>Troisième résolutioni>
Madame Sabrina Lepomme demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg est nommée
administrateurs jusqu'à l'assemblée générale qui aura lieu en 2020.
Madame CARDOSO Isabelle, demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg est nom-
mée administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui aura lieu en 2020.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016066020/24.
(160028289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
HCP Health Care Products S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 131.687.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Maître Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg,
en date du 31 décembre 2015, enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 06 janvier 2016, 2LAC/2016/338, aux droits de
soixante-quinze euro (75,- EUR), que la société anonyme HCP Health Care Products S.A. (en liquidation), ayant son siège
social à 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 131.687, constitué sous le régime de la loi suisse suivant acte de Maître Guglielmo PEDRAZZINI, notaire de résidence
à Lugano (Suisse) en date du 14 février 2001 et transféré à Luxembourg suivant acte de Maître Jean SECKLER, notaire
de résidence à Junglinster en date du 13 septembre 2007 publié au Mémorial C, numéro 2328 du 17 octobre 2007.
La société a été mise en liquidation par acte de Maître Martine SCHAEFFER notaire de résidence à Luxembourg en
date du 3 décembre 2015, non encore publié au Mémorial C.
En prenant note des rapports du liquidateur et du commissaire à la liquidation, l'assemblée générale approuve les comptes
de liquidation et donne décharge au liquidateur REVICONSULT S.A., ayant son siège à 24, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxembourg, et au commissaire à la liquidation Neo Consult S.àr.l., ayant son siège à 11, route des 3 Cantons, L-8399
Windhof, pour l'exécution de leurs mandats en rapport avec la procédure de liquidation de la Société.
En conséquence, l'assemblée générale prononce la clôture de la liquidation de la société HCP Health Care Products S.A.
(en liquidation) et décide de conserver les livres et documents sociaux pour une période de cinq ans (5) à l'ancien siège à
6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, et en outre, que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers
ou aux associés, qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social
au profit de qui il appartiendra.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2016.
Référence de publication: 2016066039/29.
(160028046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
55111
L
U X E M B O U R G
ITSmart S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 177.669.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire et décisions de l'associé uniquei>
<i>du 12 février 2016 au siège social de la sociétéi>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire et décisions de l'Associé
Unique du 12 février 2016 que:
<i>«Première décisioni>
L'Associé Unique décide d'accepter, avec effet au 26 janvier 2016, date de la notification, la lettre de démission datée
du 21 janvier 2016 de la société anonyme de droit luxembourgeois, LUX-AUDIT, ayant son siège social au 57, Avenue
de la Faïencerie, L-1510 LUXEMBOURG, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, LUXEM-
BOURG sous le numéro B 25.797 en tant qualité de Commissaire aux comptes de la Société.
<i>Deuxième décisioni>
L'Associé Unique décide de nommer, avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'Associé Unique
qui se tiendra en 2019, G. T. Fiduciaires S.A., ayant son siège social au 19, Rue de Bitbourg, L-1273 LUXEMBOURG,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, LUXEMBOURG sous le numéro B 121.820, en qualité de
Commissaire aux comptes de la Société, en remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2016.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016066093/26.
(160027933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Energy T.I. Industrial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 201.611.
<i>Extrait de la résolution prise par le gérant unique en date du 15 février 2016i>
Le gérant unique décide de transférer le siège social de la Société de son ancienne adresse sise 4, Grand-Rue L-1660
Luxembourg à 21 avenue Monterey L-2163 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016065921/11.
(160028485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
John Deere Cash Management S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 2.000.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 101.957.
Les décisions suivantes ont été approuvées par l'assemblée générale annuelle de l'actionnaire unique de la Société qui
s'est tenue en date du 26 janvier 2016:
- acceptation de la démission en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 15 février 2016 de Monsieur David
Clive Rogers;
- nomination en remplacement de l'administrateur démissionnaire, en tant que nouvel administrateur de la Société avec
effet au 15 février 2016 et dont son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'actionnaire unique
de la Société approuvant les comptes annuels en 2017, Monsieur Jacques Taylor, né le 1
er
août 1974, en Afrique du Sud,
avec adresse professionnelle au 43, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- approbation du renouvellement de la nomination des administrateurs suivants de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale annuelle de l'actionnaire unique de la Société approuvant les comptes annuels en 2017:
* Monsieur James M. McCabe;
* Monsieur Thomas C. Spitzfaden; et
55112
L
U X E M B O U R G
* Monsieur GAETAN VAN WYNSBERGHE;
- confirmation que le conseil d'administration de la Société est désormais composé par les administrateurs suivants:
* Monsieur Jacques Taylor;
* Monsieur James M. McCabe;
* Monsieur Thomas C. Spitzfaden; et
* Monsieur GAETAN VAN WYNSBERGHE;
- approbation du renouvellement de la nomination du réviseur d'entreprises agréé de la Société, Deloitte Audit S.à r.l.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'actionnaire unique de la Société approuvant les
comptes annuels en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2016.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2016066096/35.
(160028665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Javi Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 9, boulevard Dr Charles Marx.
R.C.S. Luxembourg B 123.533.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 2 février 2016 à 10.00hi>
<i>Extrait des résolutions prises:i>
1. Le conseil d'Administration a pris connaissance et accepte les démissions de:
- Monsieur Alexandre Vancheri
- Madame Donatella Lecci
- Monsieur Nico Hoffeld
- Madame Anique Bourkel
de leur charge d'administrateurs de la société avec effet au 01.01.2016;
2. Le conseil d'administration décide de nommer par cooptation et en remplacement des administrateurs démissionnaires
deux nouveaux administrateurs, à savoir:
- Monsieur Bernard Klein, adresse professionnelle 9, boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg;
et
- Monsieur Cédric Goethals, adresse professionnelle 9, boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg;
(...) avec effet au 01.01.2016 et jusqu'à l'assemblée ordinaire à être tenue en 2016.
Référence de publication: 2016066098/21.
(160028505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
La Maison S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 189.615.
RECTIFICATIF
Lors du dépôt numéro L160014391 effectué en date du 25 janvier 2016, une erreur matérielle s'est produite. Cette
nouvelle donnée remplace la précédente.
Les personnes et entités suivantes ont été nommées jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2020, en
qualité de membre du directoire de la Société:
- Monsieur Cheng Li, né le 18 avril 1980 à Liaoning, Chine, ayant son adresse professionnelle au 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Nicolas Cuisset, né le 25 avril 1973 à Aulnoye Aymeries, France, ayant son adresse professionnelle au 1B,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Michel Cicurel Conseil, une société par actions simplifiée (société à associé unique) constituée et existant selon la
législation française, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 752.950.832, ayant son
siège social au 46, rue Pierre Charron, 75008 Paris, France, représentée par Monsieur Michel Cicurel, ayant son adresse
55113
L
U X E M B O U R G
professionnelle au 46, rue Pierre Charron, 75008 Paris, France, en tant que représentant permanent de Michel Cicurel
Conseil.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 15 février 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016066119/29.
(160028298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Lakeside Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 180.845.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Maître Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg,
en date du 30 décembre 2015, enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 04 janvier 2016, 2LAC/2016/133, aux droits de
soixante-quinze euro (75,- EUR), que la société à responsabilité limitée Lakeside Corporation S.à.r.l. (en liquidation), ayant
son siège social à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 180.845, constitué en date du 30 septembre 2013 par acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence
à Luxembourg, publié au Mémorial C, numéro 2925 du 20 novembre 2013.
La société a été mise en liquidation par acte de Maître Martine SCHAEFFER notaire de résidence à Luxembourg en
date du 23 décembre 2015, non encore publié au Mémorial C.
En prenant note des rapports du liquidateur et du commissaire à la liquidation, l'actionnaire unique approuve les comptes
de liquidation et donne décharge au liquidateur Madame Andia Shtepani, demeurant à 24, rue Beaumont, L-1219 Luxem-
bourg et au commissaire à la liquidation Comcolux S.àr.l., ayant son siège à 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
pour l'exécution de leurs mandats en rapport avec la procédure de liquidation de la Société.
En conséquence, l'actionnaire unique prononce la clôture de la liquidation de la société Lakeside Corporation S.à.r.l.
(en liquidation) et décide de conserver les livres et documents sociaux pour une période de cinq ans (5) à l'ancien siège à
L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2016.
Référence de publication: 2016066122/26.
(160028077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Les Résidences d'Howald S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.
R.C.S. Luxembourg B 135.669.
Il résulte des résolutions du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2016 que:
1. la démission de Monsieur Petrus Wilhelmus Franciscus van der HELM de la fonction d'administrateur de catégorie
B a été acceptée;
2. la démission de Monsieur Adrianus VAN ERK de la fonction d'administrateur de catégorie B a été acceptée;
3. un mandat d'administrateur de catégorie B a été confié à Monsieur Bernard PIRON, résidant à, rue de Lonnai, 10,
6852 Our (Belgique), né à Opont le 23 avril 1958;
4. un mandat d'administrateur de catégorie B a été confié à Monsieur François Piron, résidant à Moulin d'Our, 2, 6852
Paliseul (Belgique), né à Libramont-Chevigny, le 18 avril 1980;
Les mandats confiés commencent le 12 février 2016 pour venir à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de
l'année 2020;
Il résulte des résolutions du procès-verbal du conseil d'administration tenu à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire
du 12 février 2016 que:
1. la démission de Monsieur Petrus Wilhelmus Franciscus van der HELM de la fonction d'administrateur délégué de
catégorie B a été acceptée;
55114
L
U X E M B O U R G
2. un mandat d'administrateur délégué de catégorie B a été confié à Monsieur Bernard PIRON, résidant à, rue de Lonnai,
10, 6852 Our (Belgique), né à Opont le 23 avril 1958;
3. le mandat ainsi confié commence le 12 février 201 6 pour venir à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de
l'année 2020;
4. la co-signature de Monsieur Louis-Marie Piron est obligatoire sur tous les documents engageant la société.
Strassen, le 15 février 2016.
<i>Pour la société
i>Jean-Michel Dangis
<i>Comptablei>
Référence de publication: 2016066146/30.
(160028388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Negentropy SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 141.322.
RECTIFICATIF
Le soussigné Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare
par les présentes que dans l'acte reçu par son ministère, en date du 20 janvier 2016, numéro 109/2016 de son répertoire,
enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 26 janvier 2016, relation: 2LAC/2016/1695, déposé au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016, référence L160021874, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, pour compte de la société à anonyme “NEGENTROPY SICAV - SIF”, établie et ayant son siège
social à L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 141.322,
il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:
IL Y A LIEU DE LIRE:
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting RESOLVED to discard the French translation of the Articles in accordance with article 26 (2) of the 2007
Law and only have an English version going forward.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting RESOLVED to restate the articles of incorporation of the Company.
AU LIEU DE:
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting RESOLVED to discard the French translation of the Articles in accordance with article 26 (2) of the 2007
Law respectively article 95 and 26 (2) of the 2010 Law and only have an English version going forward.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting RESOLVED to restate the articles of incorporation of the Company in light of the conversion of the
Company into an undertaking for collective investment in transferable securities ("UCITS") under the provisions of the
Law dated 17 December 2010 relating to undertakings for collective investments (as amended, the "2010 Law"): the
Company being currently subject to the Luxembourg Law dated 13 February 2007 relating to specialized investment funds.
Le notaire soussigné requiert la mention de cette rectification partout où cela s'avère nécessaire
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 9 février 2016. Relation: 2LAC/2016/2976. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Yvette THILL.
Luxembourg, le 04 février 2016.
Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016066235/37.
(160027616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
55115
L
U X E M B O U R G
Mastu Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 190.969.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 30 octobre 2015, que l'actionnaire Monsieur Kadir
Demirci Tutumlu, né à Kulu Turquie le 31 décembre 1969 demeurant au Zincirlikuyu kasabasi Kulu/Konya 42950 Turquie
a cédé ses 300 parts sociales à Monsieur Isaac Tumulu, né à Barcelone, Espagne, le 5 juillet 1985, demeurant à Palace of
Sheikh Mohammed bin Saqr al Qassimi, Ras al Khaima, Emirats Arabes unis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Signatures
<i>L’agent domiciliairei>
Référence de publication: 2016066174/17.
(160027963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
MOF III Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 143.634.
EXTRAIT
En date du 15 janvier 2016, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Wim RITS, en tant que gérant B de la Société, est acceptée avec effet au 1
er
janvier 2016;
- Monsieur Ajit Singh RAI, né à Leeds, Royaume Uni, le 23 février 1978, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, a été élu gérant B de la Société avec effet au 1
er
janvier 2016 et ce pour une période
indéterminée.
Le conseil de gérance ce compose dès lors comme suit:
Monsieur Jérémie d'Esparbès, gérant A;
Monsieur Eric-Jan van de Laar, gérant B; et
Monsieur Ajit Singh Rai, gérant B;
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016066204/19.
(160028016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Grace Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 199.896.598,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 162.209.
EXTRAIT
En date du 2 février 2016, l'associé unique de la Société a décidé:
(i) De prendre connaissance de la démission de (i) Monsieur Alexander Nielsen de son poste de gérant de classe A de
la Société, avec effet au 1
er
février 2016; et de (ii) Monsieur David Michael de son poste de gérant de classe A de la Société
avec effet au 2 février 2016.
(ii) D'approuver la nomination de (i) Monsieur David Hartill, né le 9 février 1960, à Chesterfield, Royaume-Uni, avec
adresse professionnelle sis au 1 In Der Hollerhecke, 67547 Worms, Allemagne, et de (ii) Monsieur Michael W. Conron,
né le 22 avril 1964, au New Jersey, États-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle sis au 7500 Grace Drive, Columbia,
MD 21044, États-Unis d'Amérique, en tant que nouveaux gérants classe A de la Société avec effet au 2 février 2016 et
pour une durée indéterminée.
Il en résulte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
- Madame Elyse Filon, gérant de classe A;
55116
L
U X E M B O U R G
- Monsieur David Hartill, gérant de classe A;
- Monsieur Michael W. Conron, gérant de classe A;
- Monsieur Valery Beuken, gérant de classe B;
- Monsieur René Beltjens, gérant de classe B;
- Madame Claudia Oprea, gérant de classe C.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2016.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016065991/28.
(160028621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Novilog s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14a, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 194.887.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Es erhellt aus einer Urkunde mit Datum vom 23. Dezember 2015 von Notarin Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in
Luxemburg, einregistriert in Luxemburg Actes Civiles 2, den 30. Dezember 2015, 2LAC/2015/30363, mit einem Recht
von EUR 75,- fünfundsiebzig Euro:
dass die Gesellschaft „NOVILOG S.àr.l.“ (in Liquidation), mit Sitz in 14a, rue des Bains, L-1212 Luxemburg, einge-
tragen im Luxemburger Handels- und Firmenregister Registre de Commerce et des Sociétés unter der Nummer B 194.887,
am 30. Dezember 2014 gemäß einer Urkunde durch die Notarin Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg,
gegründet wurde und im Luxemburger Amtsblatt Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations veröffentlicht
wurde unter der Nummer 974 11. April 2015;
dass die Gesellschaft gemäß einer Urkunde vom 2. September 2015 durch unterzeichnete Notarin in freiwillige Liqui-
dation gesetzt wurde, die im Luxemburger Amtsblatt Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer
3126 am 17. November 2015 veröffentlicht wurde.
Nach Kenntnisnahme und Genehmigung der Berichte des Liquidators Herrn Markus Kunz, wohnhaft in D-76275 Ett-
lingen, Finkenweg 6 und des Prüfungskommissars, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TRIBECA CONSULTING
AND MANAGEMENT S.à r.l. mit Sitz in 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg, beschließen die Gesellschafter dem
Liquidator und dem Prüfungskommissar volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate zu geben.
Folglich beschließen die Gesellschafter die Beendigung der Liquidation der Gesellschaft NOVILOG S.àr.l.“ (in Liqui-
dation).
Die Gesellschaftsbücher und -register und -dokumente werden für mindestens 5 (fünf) Jahre am Firmensitz in 14a, rue
des Bains, L-1212 Luxemburg, aufbewahrt.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2016.
Référence de publication: 2016066244/29.
(160028000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Ensemble environnement / patrimoine écologique, culturel et artistique, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-5335 Moutfort, 20, Gappenhiehl.
R.C.S. Luxembourg B 87.779.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 20 janvier 2016i>
<i>Première résolutioni>
Le capital a été souscrit comme suit:
Monsieur Franck Renevier, né à Boulogne-Billancour le 9 septembre 1947,
demeurant à L-5335 Moutfort, 20, Gappenhiehl CENTS PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES
100
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale constate la démission de Monsieur Louis Bachoud, né à Alger le 21 septembre 1935, demeurant
à F-02210 Droizy, 5, place de la Mairie de ses fonctions de gérant unique à compter du 20 janvier 2016.
55117
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
Est nommée gérant unique de la société, Monsieur Franck Renevier, né à Boulogne-Billancour le 9 septembre 1947,
demeurant à L-5335 Moutfort, 20, Gappenhiehl.
<i>Quatrième résolutioni>
La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
Monsieur Bachoud / Monsieur Renevier.
Référence de publication: 2016065911/22.
(160028154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Ricano S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 203.381.
STATUTES
In the year two thousand sixteen, on the twenty-first of January.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Orangefield (Luxembourg) S.A., a corporation existing under Luxembourg law, established and having its registered
office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 28.967),
here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxembourg, by virtue of a power of attorney delivered in Luxembourg on January 20
th
, 2016.
The prenamed power of attorney given, signed "ne varietur" by the appearing persons and the undersigned notary shall
remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of incor-
poration of a limited liability company (société à responsabilité limitée).
Art. 1. Form. There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the “Company”) governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as
amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.
The Company is initially composed of a single shareholder, owner of all the shares. The Company may however at any
time be composed of several shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Name. The Company will exist under the name of Ricano S.à r.l..
Art. 3. Object. The Company's object is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of the
general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the manage-
ment.
The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand-Duchy of Lu-
xembourg or abroad.
55118
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by one hundred (100)
shares of a par value of one hundred twenty-five euro (EUR 125) each.
Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the single shareholder or
pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of
the Company and to one vote at the general meetings of shareholders.
If the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises all powers which are granted by law and the
articles of incorporation to all the shareholders.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions of
the single shareholder or the general meeting of shareholders.
The creditors or successors of the single shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever reason,
request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single shareholder
or the general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
Art. 10. Transfer of shares. When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may transfer
freely its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders
only.
The shares can be transferred by living persons to non-shareholders only with the authorization of the general meeting
of shareholders representing at least three-quarters of the capital.
Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or
accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
Art. 12. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Art. 14. Single manager / board of managers. The Company is managed by one or several managers. If several managers
have been appointed, they will constitute a board of managers. The General Meeting may decide to create two classes of
managers, being class A manager (s) (the Class A Manager (s)) and class B manager(s) (the Class B Manager).
The managers need not to be shareholders.
Each manager will be elected by the single shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their
number and the duration of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the
single shareholder or by a resolution of the shareholders' meeting.
Art. 15. Meetings of the board of managers. The board of managers may choose from among its members a chairman,
and may choose among its members one or more vice-chairmen.
The board of managers may also choose a secretary, who need not be a manager and who may be instructed to keep the
minutes of the meetings of the board of managers and to carry out such administrative and other duties as directed from
time to time by the board of managers. The chairman shall preside over all meetings of the board of managers. In his absence
the members of the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of a majority of the
managers present or represented at any such meeting.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The person(s) convening the meeting shall determine the agenda. Notice in writing, by telegram, by telefax or
e-mail of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least eight (8) calendar days in advance
of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four (24) hours prior notice shall
suffice which shall duly set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospec-
tively, by the consent in writing, by telegram, by telefax or e-mail of each manager. Separate notice shall not be required
for meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manger may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by telegram, telefax or e-mail
another manager as his proxy. A manager may not represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in a meeting of the board of managers by conference call or similar means of communi-
cations equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other; and participating in a meeting by
such means shall constitute presence in person at such meeting.
55119
L
U X E M B O U R G
The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of managers are present or represented
at a meeting of the board of managers. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting the
managers present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given to
the managers by the secretary to the board, if any, failing whom by any manager.
Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. In the event that in
any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have a casting
vote.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed by a circular document and
be the result of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager without any
exception. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 16. Powers of the managers. The single manager or whether the case may be, the board of managers is vested with
the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not ex-
pressly reserved by the law or by these articles of incorporation to the general meeting of the members fall within the
competence of the single manager or the board of managers.
Art. 17. Representation of the Company - Delegation of Powers. Towards third parties, the Company shall be bound by
the signature of its single manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers of the
Company. In case the General Meeting has appointed classes of managers, the Company shall be bound by the joint signature
of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.
The single manager or the board of managers may generally or from time to time delegate the power to conduct the
daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management to an
executive or to one or several committees whether formed from among its own members or not, or to one or more managers
or other agents who may act individually or jointly. The single manager or the board of managers shall determine the scope
of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the
authority to sub-delegate.
The single manager or the board of managers may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of
its choice.
Art. 18. Representation of the Company in Legal Proceedings. In all legal proceedings, be it as plaintiff or as a defendant,
the Company shall be represented by the single manager or its board of managers, who may delegate this function to its
chairman or any other of its members.
Art. 19. Liability of the manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in
relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.
Art. 20. General meeting of shareholders.
20.1. If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general
meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10
th
, 1915, are not applicable to that situation.
20.2. If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general
meeting of shareholders or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the
management to the shareholders by registered mail.
In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of
the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
Art. 21. Decisions. The decisions of the single shareholder or of the general meeting of shareholders are documented in
writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the
shareholders and the power of-attorneys are attached to the minutes.
Art. 22. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December.
Art. 23. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws
up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to the
general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company
within a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of shareholders.
Art. 24. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the
reserve required by the law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have
reached one tenth of the subscribed share capital.
The annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of the members.
Subject to the conditions determined by law, the single manager or in existence of more than one manager, the board
of managers may pay out an advance payment on dividends.
55120
L
U X E M B O U R G
The single manager or the board of managers sets the amount and the date of payment of any such advance payment.
Art. 25. Dissolution, liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation
will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the single shareholder or by the general
meeting of shareholders of the shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator
(s).
Art. 26. Matters not provided. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Luxembourg law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The appearing party Orangefield (Luxembourg) S.A., aforementioned and as represented, declares to subscribe the
whole capital.
All the one hundred (100) shares have been fully paid up to the amount of one hundred twenty-five euro (EUR 125) per
share by a contribution in cash of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
As a result, the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is as of now at the disposal of the Company
as has been certified to the notary executing this deed.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2016.
<i>Expensesi>
The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company
as a result of its formation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named shareholder, has immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
The sole shareholder, acting in place of the general meeting of the shareholders, has taken immediately the following
resolutions:
1. To set at one (1) the number of managers of the Company;
2. To appoint LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée)
existing under Luxembourg law, established and having its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg, section B number 79.709) single manager of the Company for an unlimited duration; and
3. To set the registered office of the Company at L-2163 Luxembourg, 40, Avenue Monterey.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the Notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt et un janvier.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Orangefield (Luxembourg) S.A., une société anonyme, régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, établie et
ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg section B numéro 28.967),
ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par les mandataires du comparant et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à
responsabilité limitée unipersonnelle et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l'article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi
que par les présents statuts.
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute époque,
comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création de parts
nouvelles.
55121
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de Ricano S.à r.l..
Art. 3. Objet. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'ac-
quérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute
autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société
jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux
conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les
acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer
à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou
aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous
concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le
remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant
directement ou indirectement à son objet.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec
les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée
générale des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) représenté par cent (100)
parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) chacune.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de
l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans
les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la
collectivité des associés.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou
de la collectivité des associés.
Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,
requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des
actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé
unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.
Art. 10. Cession de parts. En cas d'un associé unique, les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de
parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés seuls.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément de l'assemblée générale
des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou acceptées
par elle conformément à l'article 1690 du code civil.
Art. 12. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.
Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement
similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 14. Gérant Unique / Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance. L'Assemblée Générale peut décider de créer deux classes de gérants, à
savoir, le(s) gérant(s) de classe A (le(s) Gérant(s) de Classe A) et le(s) gérant(s) de classe B (le(s) Gérant(s) de Classe B).
Les gérants ne doivent pas nécessairement être des associés.
55122
L
U X E M B O U R G
Les gérants seront élus par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur
mandat. Tout gérant pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des associés.
Art. 15. Réunions du Conseil de Gérance. Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et peut
choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un
gérant et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et d'exécuter des tâches
administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le conseil de gérance. Le président préside les réunions
du conseil de gérance. En l'absence du président, les membres du conseil de gérance peuvent désigner un autre gérant pour
assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majorité des gérants présents ou représentés lors de cette réunion.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail
contenant l'ordre du jour sera donné à tous les gérants au moins huit (8) jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il
y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé vingt-quatre (24) heures avant la réunion, devra mentionner la nature
de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur
à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque gérant. Une convocation spéciale n'est pas requise pour
des réunions du conseil de gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre gérant comme
son mandataire. Un gérant ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.
Tout gérant peut prendre part à une réunion du conseil de gérance au moyen d'une conférence téléphonique ou d'un
équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre; la
participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants sont présents ou représentés
à une réunion du conseil de gérance. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion,
les gérants présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées
sont donnés aux membres du conseil de gérance par le secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout gérant.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion. Au cas où, lors
d'une réunion du conseil de gérance, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président de la
réunion aura une voix prépondérante.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire
et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres du conseil de
gérance sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.
Art. 16. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance est investi des
pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous
pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale sont de la compétence du
gérant unique ou du conseil de gérance.
Art. 17. Représentation de la Société, Délégation de pouvoirs. La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes
circonstances par la signature du gérant unique ou en cas de plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux gérants.
Si l'Assemblée Générale a nommé des classes de gérants, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe
d'un (1) Gérant de Classe A et d'un (1) Gérant de Classe B.
Le gérant unique ou le conseil de gérance peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la gestion journalière
de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un directeur ou à un ou plusieurs
comités, qu'ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs gérants ou autres mandataires sus-
ceptibles d'agir seuls ou conjointement. Le gérant unique ou le conseil de gérance détermine l'étendue des pouvoirs, les
conditions du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.
Le gérant unique ou le conseil de gérance pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires
ou représentants de son choix.
Art. 18. Représentation de la Société en Justice. La Société est représentée dans toutes les instances de justice, tant en
demandant qu'en défendant, par le conseil de gérance, qui peut déléguer cette fonction à son président ou à un autre de ses
membres.
Art. 19. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution
de son mandat.
Art. 20. Décisions de l'associé ou des associés.
20.1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée
générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
20.2. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale ou par vote écrit
sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.
55123
L
U X E M B O U R G
Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de
quinze (15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Art. 21. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit et
consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les
procurations leur seront annexées.
Art. 22. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 23. Bilan. Chaque année le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des
biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, de l'assemblée
générale des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes
annuels, au cours d'une période de quinze jours précédant la date de l'assemblée générale.
Art. 24. Répartition des bénéfices. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la
réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un
dixième du capital social souscrit.
L'assemblée générale des associés dispose librement du bénéfice net annuel.
Sous réserve des conditions fixées par la loi et conformément aux dispositions qui précèdent, le gérant unique ou le
conseil de gérance peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Le gérant unique ou le conseil
de gérance détermineront le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.
Art. 25. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce
soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 26. Disposition générale. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents statuts seront
tranchées en application de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
La société comparante Orangefield (Luxembourg) S.A., prénommée et telle que représentée, déclare vouloir souscrire
la totalité du capital social.
Les cent (100) parts ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) par part
par un apport en liquide de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR).
Le montant de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) est par conséquent à la disposition à partir de ce moment
tel qu'il a été certifié au notaire instrumentant.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2016.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société, ou
qui est mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille quatre cents euros (1.400.- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Après que les statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire:
Et à l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale des associés, a pris les résolutions
suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à un (1).
2. Est nommé gérant unique de la Société LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l. pour une durée illimitée, une
société à responsabilité limitée, régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social au 40,
Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg section B numéro 79.709).
3. Le siège social de la société est établi à L-2163 Luxembourg, 40, Avenue Monterey.
Le notaire soussigné, qui comprend l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de constitution
est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite au mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
55124
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 25 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/1568. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058233/376.
(160018460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Blue Colibri Capital Partners Fund II SCA, SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une
SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 186.501.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of January,
before Us, Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
is held
an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders (the “Shareholders”) of Blue Colibri Capital
Partners Fund II SCA, SICAV-SIF, a partnership limited by shares (société en commandite par actions) qualifying as a
Luxembourg investment company with variable share capital-specialised investment fund (société d’investissment à capital
variable - fond d’investissement spécialisé) with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and being
registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 186.501 (the “Company”). The Company
was incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg on 10 April 2014, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations N° 1683, dated 30 June
2014. The articles of association of the Company (the “Articles”) have been not been amended since then.
The Meeting is chaired by Edouard KOSTER, professionally residing in Luxembourg (the “Chairman”).
The Chairman appoints Oana MILLICH, professionally residing in Luxembourg, as secretary (the “Secretary”).
The Meeting appoints Oana MILLICH, professionally residing in Luxembourg, as scrutineer (the “Scrutineer”) (the
Chairman, the Secretary and the Scrutineer constituting the "Bureau” of the Meeting).
The Shareholders of the Company were convened to this Meeting by registered mail sent on 21 December 2015.
Proxies from the Shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present deed to be
filed with such deed with the registration authorities after having been signed ne varietur by the proxyholders acting on
behalf of the appearing parties and the undersigned notary.
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the undersigned notary to record the
following:
I It appears from the attendance list that one (1) management share, 0 (/) A shares, 25,771,224 (/) B shares and 1,912,491
(/) C shares, representing 79,25 % shares/ 99,64 % of total commitment of the Company are represented at the Meeting,
which is consequently duly constituted and may validly debate and take resolutions on the items of the below agenda.
II The agenda of the Meeting is worded as follows:
1 Amendment of the private placement memorandum of the Company so that the private placement memorandum shall
henceforth have the form as attached to the proxy, in appendix A, provided to the shareholders of the Company for the
Meeting;
2 Amendment of the Articles to align the Articles with the private placement memorandum of the Company in order to
reflect amongst other (i) the insertion, of a section regarding the ERISA partner and its respective definitions, (ii) the
amendment the conditions of removal of the general partner of the company without cause, (iii) the amendment the in-
demnification clauses and (iv) the confirmation that in case of conflicts the Articles will prevail over the private placement
memorandum of the Company, so that the Articles shall henceforth have the form as attached to the proxy, in appendix B,
provided to the shareholders of the Company for the Meeting;
3 Miscellaneous.
III The Meeting, after deliberation, unanimously passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to amend the private placement memorandum of the Company so that the private placement
memorandum shall henceforth have the form as attached to the proxy, in appendix A, provided to the Shareholders for the
Meeting.
55125
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend the Articles to align the Articles with the private placement memorandum of the Company
in order to reflect amongst other (i) the insertion, of a section regarding the ERISA partner and its respective definitions,
(ii) the amendment the conditions of removal of the general partner of the company without cause, (iii) the amendment the
indemnification clauses and (iv) the confirmation that in case of conflicts the Articles will prevail over the private placement
memorandum of the Company, so that the Articles shall henceforth have the form as attached to the proxy, in appendix B,
provided to the Shareholders for the Meeting so that it shall henceforth read as follows:
“I. Name - Registered office - Object - Duration
1. Art. 1. Name. There is formed among Blue Colibri Capital S.à r.l., sole general partner (associé commandité) who is
also the manager of the Fund (the “General Partner”) and the holders of ordinary shares, a société en commandite par
actions under the name “Blue Colibri Capital Partners Fund II SCA, SICAV-SIF” (the “Fund”), which shall be governed
by the laws of Luxembourg, in particular by the 1915 Law, as well as by these Articles of Association.
The Fund will, after authorisation by the Luxembourg supervisory authority, the Commission de Surveillance du Secteur
Financier ("CSSF"), and after having been entered on the official list of specialised investment funds maintained by the
CSSF, be submitted to the provisions of the Luxembourg law dated 13 February 2007 on Luxembourg Specialised Invest-
ments Funds (the “SIF Law”). Upon authorisation, the Specialised Investment Fund status may only be abandoned by the
Fund with the prior approval of the CSSF and the unanimous consent of the Shareholders.
2. Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Fund is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within Luxembourg by a resolution of the General Partner.
2.2 Where the General Partner determines that extraordinary political or military developments or events have occurred
or are imminent as determined in its sole discretion and that these developments or events may interfere with the normal
activities of the Fund at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circums-
tances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Fund, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
2.3 Except in the circumstances described in Article 5.2, any transfers of the Fund’s domicile in a jurisdiction other than
Luxembourg and any changes in the Fund's currency require consent by Shareholders holding at least 2/3 of the Total
Commitments.
3. Art. 3. Object.
3.1 To achieve long-term capital appreciation through pursuing opportunistic (direct or indirect) investments in com-
mercial real estate assets located primarily in Germany, France and Austria.
3.2 The Fund may also hold any participation, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form
whatsoever and engage in the administration, management, control and development of such participations.
3.3 The Fund may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to its participations in companies and/or
enterprises, including the administration, management, control, development, optimization and realization of such parti-
cipations as an investor holding such participations.
3.4 The Fund may, subject to the limitations in the PPM, (i) grant to enterprises in which the Fund has an interest or
which forms part of the group of companies to which the Fund belongs and/or any other companies or persons, any
assistance, loans, advances or guarantees (including upstream or cross stream), and (ii) perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose.
3.5 The Fund may, subject to the limitations in the PPM, borrow in any form and issue bonds, preferred equity certificates,
whether convertible or not, warrants, notes and debentures.
3.6 The Fund can generally perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
4. Art. 4. Duration.
4.1 Subject to an earlier termination pursuant to the below, the term of the Fund will be ten (10) years from the First
Closing Date, which may be extended by the General Partner, with the prior approval of Shareholders holding, in aggregate,
more than 50% of the Total Commitments, for up to two additional one-year periods.
4.2 Notwithstanding anything else in these Articles of Association, the Fund shall dissolve upon the occurrence of any
of the following events:
(a) dissolution of the General Partner;
(b) commencement of insolvency proceedings over the assets of the General Partner or rejection of a petition to com-
mence such proceedings for lack of assets; or
(c) removal of the General Partner from the Fund,
55126
L
U X E M B O U R G
provided that the Fund shall not terminate if, within 120 calendar days after such an event, Shareholders holding, in
aggregate, more than 50 per cent of Total Commitments elect to continue the business of the Fund and to appoint a successor
managing general partner (subject always to the approval of the CSSF).
For the avoidance of doubt, the Fund shall at all times have a General Partner.
4.3 The Fund shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting any of the Shareholders. In case of death, incapacity or inability of the General Partner, article
112 of the 1915 Law shall apply.
II. Capital - Shares
5. Art. 5. Capital.
5.1 The Fund's share capital shall be variable and at all times equal to its Net Asset Value, as determined in accordance
with Article 22 hereafter.
5.2 The Fund is incorporated with a subscribed share capital of € 32,000.- divided into one Management Share and
31,000 A Shares of no par value.
5.3 Further Shares may be issued by the General Partner at its free discretion and without the necessity for any resolution
of the general meeting of Shareholders subject to the following provisions:
The share capital of the Fund shall be represented by the following four classes of Shares:
(a) One “Management Share”, which is a single share which has been or shall be issued to the General Partner as unlimited
shareholder (actionnaire gérant commandité) of the Fund. Such share shall entitle the General Partner to such rights as set
out in these Articles of Association and the PPM including, inter alia, the right to receive the Management Fee;
(b) “A Shares”, which are ordinary shares (actions ordinaires) in the Fund and may be issued by the General Partner in
such number as the General Partner determines in its discretion (subject to the maximum size of the Fund as set out in the
PPM) to such persons determined by the General Partner. Such Shares shall entitle the holders to such rights as set out in
these Articles of Association and the PPM including, inter alia, to the distributions set out in Article 21.
(c) “B Shares”, which are ordinary shares (actions ordinaires) in the Fund and may be issued by the General Partner in
such number as the General Partner determines in its discretion (subject to the maximum size of the Fund as set out in the
PPM) to Investors making a Commitment in relation to B Shares to the Fund. Such Shares shall entitle such Investors to
such rights as set out in these Articles of Association and the PPM including, inter alia, to the distributions set out in Article
21; and
(d) “C Shares”, which are ordinary shares (actions ordinaires) in the Fund and may be issued by the General Partner in
such number as the General Partner determines in its discretion (subject to the maximum size of the Fund as set out in the
PPM) to Investors making a Commitment in relation to C Shares to the Fund. Such Shares shall entitle such Investors to
such rights as set out in these Articles of Association and the PPM including, inter alia, to the distributions set out in Article
21.
5.4 The minimum assets of the Fund, which must be achieved within twelve (12) months after the date on which the
Fund was authorised as a Specialised Investment Fund under the SIF Law, shall be EUR 1,250,000.
6. Art. 6. Shares.
6.1 The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.2 A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Fund in accordance with the provisions of the
1915 Law and may be examined by each Shareholder who so requests.
6.3 Shares shall, subject to Art. 11 below, be transferred by a written declaration of transfer registered in the shareholders’
register of the Fund, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding
suitable powers of attorney. The Fund may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to
the Fund.
6.4 Towards the Fund, the Fund’s shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint co-owners
must appoint a sole person as their representative towards the Fund.
6.5 The Fund may redeem its own Shares within the limits set forth by the 1915 Law. Acquired own Shares will be
automatically cancelled. The Fund is a closed-ended investment Fund. Consequently, Shares in the Fund shall not be
redeemable at the initiative of any Shareholder. In the event an Investor ceases to be a Well-Informed Investor under the
SIF Law, the General Partner shall be entitled to compulsorily redeem the Shares of such Investor at a price determined
by the General Partner.
6.6 Shares shall be fully paid-up at the time of issuance. Shares of the Fund will be issued by the General Partner or its
appointed agent on behalf of the Fund as set out in Art. 5, provided that, in relation to A Shares, the General Partner has
drawn down capital commitments to buy such shares and payment for those shares has been received by the Administrative
Agent.
6.7 Shares may only be subscribed for by Well-Informed Investors.
55127
L
U X E M B O U R G
7. Art. 7. Commitments and Default.
7.1 Each prospective Investor shall execute a Subscription Form, containing, inter alia, the Commitment of the pros-
pective Investor (a “Subscription Form”) which upon acceptance will be countersigned by the General Partner.
7.2 If any Shareholder that has made a Commitment to the Fund fails at any time to pay the drawdown amounts due on
the relevant payment date, the General Partner may decide to apply an interest charge on such amounts (the “Default
Interest”), without further notice, at a rate equal to EURIBOR plus 6 per cent per annum, until the date of full payment.
The Default Interest shall be calculated on the basis of the actual number of days elapsed between the relevant payment
date (inclusive) and the actual date the relevant payment is received by the Fund (exclusive).
7.3 If within 30 Business Days following a formal notice served by the General Partner by registered or electronic mail,
the relevant Shareholder has not paid the full amounts due (including the Default Interest due), this Shareholder shall
become a defaulting Shareholder (the “Defaulting Investor”).
7.4 In the meantime, and notwithstanding the preceding sentence, all the Shares registered in the Defaulting Investor’s
name shall become defaulted Shares (the “Defaulted Shares”). Defaulted Shares shall have their voting rights suspended
and shall not carry any right to distributions, as long as the outstanding payment set out above has not been effected.
7.5 All Shares registered in the name of such Defaulting Investor may be subject at the discretion of the General Partner
to the one of the two following alternative procedures:
(a) The Defaulting Investor’s Shares may be subject to a compulsory redemption (the “Defaulted Redeemable Shares”)
in accordance with the following rules and procedures:
(i) the General Partner shall send a notice (hereinafter the “Redemption Notice”) to the relevant Defaulting Investor;
the Redemption Notice shall specify, inter alia, the Defaulted Redeemable Shares to be redeemed and the price to be paid.
The Redemption Notice may be sent to the Defaulting Investor by registered or electronic mail to its last known address.
The Defaulting Investor in question shall be obliged without delay to deliver to the Fund the certificate or certificates, to
the extent applicable, representing the Defaulted Redeemable Shares specified in the Redemption Notice. From the closing
of the offices on the day specified in the Redemption Notice, the Defaulting Investor shall cease to be the owner of the
Defaulted Redeemable Shares specified in the Redemption Notice and the certificates representing these Shares shall be
rendered null and void in the books of the Fund;
(ii) in such compulsory redemption, the redemption price will be equal to 50% of the subscription price paid at the time
by the redeeming Defaulting Investor less Default Interest accrued on the unpaid part of the Commitment as well as
administration and miscellaneous costs and expenses borne by the Fund in respect of such default (the “Default Redemption
Price”). However, if the General Partner determines that the Net Asset Value of the Fund has increased or decreased
materially since subscription by the relevant Defaulting Investor, the General Partner may change the redemption price to
a price based on the Net Asset Value of such Defaulted Redeemable Shares on the relevant redemption date, less Default
Interest accrued on the unpaid part of the Commitment as well as administration and miscellaneous costs and expenses
borne by the Fund in respect of such default. The above-mentioned redemption price will be payable only at the close of
the liquidation of the Fund.
(b) Alternatively, the General Partner may decide:
(i) to procure the sale of the Defaulted Shares to a purchaser determined by the General Partner in its sole discretion
(each person accepting an offer shall be a “Purchaser”), at the Default Redemption Price, after the deduction of all fees and
expenses incurred in relation to such default as determined at the discretion of the General Partner. The Default Redemption
Price shall be payable immediately to the Fund by the Purchaser and to the Defaulting Investor only upon liquidation of
the Fund and after satisfaction of all other holders of Shares and shall not bear interest until such date. The General Partner
shall constitute the agent for the sale of the Defaulting Investor’s Shares (as well as the transfer of the undrawn Commitment
of such Defaulting Investor) and each Shareholder agrees to appoint or procure the appointment of the General Partner as
its true and lawful attorney to execute any documents required in connection with such transfer if it shall become a De-
faulting Investor and shall ratify whatever the General Partner shall lawfully do pursuant to such power of attorney and to
keep the General Partner indemnified against any claims, costs and expenses which the General Partner may suffer as a
result thereof;
(ii) in the event of such sale, the Purchaser shall, on completion of the transfer, be admitted to the Fund as a new
Shareholder and shall assume all rights and obligations of the Defaulting Investor (including, for the avoidance of doubt,
the Commitment of the Defaulting Investor).
7.6 The General Partner may also bring any legal actions it may deem appropriate against the Defaulting Investor based
on breach of its Subscription Form with the Fund. For the avoidance of doubt, the General Partner shall be entitled to
borrow any amount as is necessary to make up any shortfall in available funds for Portfolio Property or any expenses
(including the Management Fee) and other liabilities.
7.7 The sanctions applied against Defaulting Investors described above are not exclusive of any recourse that the General
Partner may adopt in order to recover the unpaid amounts.
7.8 An ERISA Partner shall not be deemed to be a Defaulting Investor to the extent that it fails to pay drawdown amounts
due to the Fund on the relevant payment date by reason of the assets of the Fund being deemed to be “plan assets” subject
to regulation under ERISA.
55128
L
U X E M B O U R G
8. Art. 8. Share transfers.
No sale, assignment, transfer, exchange, pledge, encumbrance or other disposition (including the granting of any par-
ticipation or any swap or derivative transaction or other synthetic instrument replicating the substantial economic
characteristics of such a transfer) (“Transfer”) of all or any part of any Commitments and Shares in the Fund, whether direct
or indirect, voluntary or involuntary (including, without limitation, to an Affiliate or by operation of law), to any person
(such person being a “Substitute Investor”) shall be valid or effective except with the prior written consent of the General
Partner, which consent may be withheld in its free discretion, and where none of the following apply:
(a) such Transfer would result in a violation of applicable law, including United States Federal or State securities laws,
or any term or condition of the PPM or these Articles of Association;
(b) as a result of such Transfer, the Fund would be required to register as an investment company under the Investment
Company Act;
(c) such Transfer would result in material adverse tax consequences to the Shareholders;
(d) such Transfer would require such participation in the Fund to be subdivided for purposes of resale into units smaller
than a unit costing, by reference to its initial offering price, less than the EUR equivalent of US$ 100,000;
(e) such Transfer would constitute a transaction effected through an “established securities market” within the meaning
of the United States Treasury Regulations promulgated under section 7704 of the Code or otherwise would cause the Fund
to be a “publicly traded partnership” within the meaning of section 7704 of the Code, or would cause there to be more than
100 Shareholders (as determined under the Treasury Regulations promulgated under section 7704 of the Code). For pur-
poses of determining the number of Shareholders under this provision, a person (a “beneficial owner”) owning an interest
in a partnership, grantor trust or S corporation for United States Federal income tax purposes (a “flow-through entity”) that
owns directly, or through other flow-through entities, a Share, is treated as a Partner if (X) substantially all of the value of
the beneficial owner’s interest in the flow-through entity is attributable to the flow-through entity’s direct or indirect interest
in the Fund and (Y) a principal purpose in using the tiered arrangement is to permit the Fund to have not more than 100
Shareholders; or
(f) the proposed transferee is not an Well-Informed Investor.
A Shares may not be transferred to any person who is not employed or otherwise engaged by the General Partner, the
Advisors or the Property Managers in relation to the Fund, or a family member or trust established for the benefit of such
persons or their family members without the consent of the Advisory Committee.
III. Management - Representation
9. Art. 9. Management of the Fund.
9.1 The Fund shall be managed by the General Partner.
9.2 All powers not expressly reserved by the law, the PPM or the present Articles of Association to the Shareholders or
to the Advisory Committee fall within the competence of the General Partner, which shall have all powers to carry out and
approve all acts and operations consistent with the Fund’s object.
9.3 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether Shareholders
or not, by the General Partner.
9.4 The General Partner is authorised to delegate the day-to-day management of the Fund and the power to represent
the Fund in respect thereto to one or more officers, or other agents who may but are not required to be shareholders, acting
individually or jointly.
9.5 The Fund shall be bound towards third parties by the signature of the General Partner or by the joint or single signature
of any person to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with Articles 12.3 and 12.4 and
within the limits of such power.
9.6 No contract or other transaction between the Fund and any other company or person shall be affected or invalidated
by the fact that the General Partner or any officers of the Fund is interested in the transaction, or is a director, associate,
officer or employee of such other company or person.
9a. Art 9a. ERISA.
9a.1 The General Partner shall use all reasonable efforts consistent with the other terms of these Articles of Association
to ensure that participation by “benefit plan investors” in the Fund is not “significant” (in each case as defined in the Plan
Assets Regulation).
9a.2 The Shares of a Shareholder may be redeemed by the Fund if, in the reasonable judgement of the General Partner
by virtue of that Shareholder’s participation in the Fund, any assets of the Fund may be characterised as assets of an employee
benefit plan subject to ERISA, whether or not such Shareholder is subject to ERISA.
Redemptions pursuant to these provisions will be effected by the Fund’s purchase of such Shareholder’s Shares at the
purchase price determined in accordance with the procedures and for the consideration set forth in Article 9a.7.
9a.3 If any ERISA Shareholder shall deliver to the General Partner an opinion of counsel (which opinion and counsel
shall be satisfactory to the General Partner) to the effect that, as a result of the manner in which the activities of the Fund
are conducted or the terms upon which any investments are made or continued, the assets of the Fund constitute “plan
55129
L
U X E M B O U R G
assets” under ERISA or the Code (which opinion shall be provided by the General Partner to all other ERISA Partners),
the General Partner shall then as promptly as is practicable use all reasonable endeavours to take such actions as it deems
necessary and appropriate to prevent or cure such result, taking into account the interests of all Shareholders and of the
Fund as a whole. Without limiting the generality of the foregoing, the General Partner may but shall not be obliged to:
(a) renegotiate the terms of any investment or otherwise modify the manner in which the Fund conducts its business;
(b) permit the transfer, in accordance with the provisions of Article 8, of all or a portion of the Shares of any of the
ERISA Partners; or
(c) require, by notice to such ERISA Partners, any or all ERISA Partners completely or partially to redeem from the
Fund in accordance with the provisions of Article 12.4.
If within 28 days after receipt of such opinion, the General Partner has not delivered to the ERISA Partners an opinion
of counsel (which opinion and counsel shall be to the reasonable satisfaction of a majority (by amount of Commitments)
of such ERISA Partners), or such other evidence as shall be to the reasonable satisfaction of a majority (by amount of
Commitments) of the ERISA Partners, that the assets of the Fund do not constitute “plan assets” under ERISA or the Code,
each ERISA Partner will have the option to redeem completely or partially from the Fund, by notice to the General Partner,
in accordance with the provisions of Article 9a.4.
9a.4 A complete or partial redemption pursuant to Article 9a.3 will be effected by the Fund’s purchase of the redeeming
ERISA Partner’s Shares at the purchase price and in accordance with the procedures set out in Article 9a.7. The effective
date of any redemption pursuant to this Article 9a.4 shall be the last day of the month in which notice of such redemption
was given pursuant to Article 9a.3.
9a.5 The costs of any ERISA Partner for obtaining or seeking to obtain an opinion of counsel for the purposes of Article
9a.3 shall be borne by such ERISA Partner.
9a.6 If the assets of the Fund at any time are “plan assets” for the purposes of ERISA or the Code with respect to any
employee benefit plan subject to either such provision, then each Shareholder which is, directly or indirectly, such a plan
or its fiduciary shall, at the request of the General Partner, identify to the General Partner which of the persons or entities
identified on a list furnished by the General Partner of persons or entities with whom the Fund may have had non-exempt
dealings are parties in interest or disqualified persons (as defined in sections 3 of ERISA and 4975 of the Code, respectively)
with respect to such plan.
9a.7 In the event that the Fund purchases the Shares of any Shareholder pursuant to the provisions of Articles 9a.2 or
9a.3, the purchase price therefor shall be the relevant Net Asset Value. Such purchase price shall be paid in cash, except
that the Fund may pay such purchase price in whole or in part through a distribution in specie of assets of the Fund, as soon
as is reasonably practicable after such redemption. The making of any such payment in specie shall be in the form of the
redeeming Shareholder’s pro rata share of each investment of the Fund; provided that the General Partner may (subject to
the limitations of applicable law, including ERISA) require the redeeming Shareholder to give the General Partner its proxy
with respect to any securities distributed to it. Notwithstanding the foregoing, the Fund shall not be required to sell invest-
ments, in order to make such payments, in advance of the time at which the General Partner, in the best interests of the
Fund (in the General Partner’s absolute discretion), would otherwise cause such investments to be sold.
10 Art. 10. Advisory Committee.
10.1 The General Partner will assemble an Advisory Committee as further described in the PPM which shall consist of
nominees of the Investors.
10.2 The Advisory Committee shall have such procedures and such powers as further set out in the PPM.
11 Art. 11. Liability - Indemnification.
11.1 The General Partner is jointly and severally liable for all liabilities of the Fund to the extent that they cannot be
paid out of the assets of the Fund.
11.2 None of the Indemnified Persons shall have any liability for any loss to the Fund or the Shareholders arising in
connection with the services to be performed under or pursuant to the PPM or these Articles of Association, or under or
pursuant to any management agreement or other agreement relating to the Fund or in respect of services as a Nominated
Director (as defined below) or member of the Advisory Committee or which otherwise arise in relation to the operation,
business or activities of the Fund save in respect of any matter resulting from such Indemnified Person’s wilful misconduct,
bad faith, fraud, reckless disregard for such Indemnified Person's obligations and duties in relation to the Fund, material
breach of the Fund’s constituent documents or gross negligence, provided that no liability of any Indemnified Person shall
hereby be excluded or limited that may not, under mandatory Luxembourg law, be excluded or limited.
11.3 Subject to the limitations on advances and obligations to repay pursuant to clause 14.5 below, the Fund shall
indemnify and hold harmless out of the Fund’s assets the Indemnified Persons against any and all liabilities, actions,
proceedings, claims, costs, demands, damages and expenses (including legal fees) incurred or threatened arising out of or
in connection with or relating to or resulting from the Indemnified Person being or having acted as a General Partner,
general partner or manager in respect of the Fund or arising in respect of or in connection with any matter or other cir-
cumstance relating to or resulting from the exercise of its powers as a General Partner, general partner or manager or from
the provision of services to or in respect of the Fund or under or pursuant to any management agreement or other agreement
relating to the Fund or in respect of services as a Nominated Director or member of the Advisory Committee or which
55130
L
U X E M B O U R G
otherwise arise in relation to the operation, business or activities of the Fund provided however that any Indemnified Person
shall not be so indemnified with respect to any matter resulting from such Indemnified Person’s wilful misconduct, bad
faith, fraud, reckless disregard for such Indemnified Person’s obligations and duties in relation to the Fund, material breach
of the Fund’s constituent documents or gross negligence, provided that no Indemnified Person shall be indemnified in
respect of any matter for which such person may not, under mandatory Luxembourg law, be indemnified and provided
further that no Indemnified Person shall be indemnified in relation to any disputes with any other Indemnified Person.
11.4 For the avoidance of doubt, the indemnities set out in this Article 14 shall continue in effect notwithstanding that
the Indemnified Person shall have ceased to act as General Partner, general partner, adviser or manager or otherwise to
provide services to or in respect of the Fund or to act in any of the capacities described above (provided that, for the
avoidance of doubt, indemnities shall only relate to actions or omissions prior to the date the respective person has ceased
to act in any of the capacities described above) and shall continue in effect notwithstanding the termination of the Fund.
11.5 The Fund shall pay the expenses incurred by any Indemnified Person, as such expenses are incurred, in connection
with any proceeding in advance of the final disposition thereof, provided that in connection with an action against any
Indemnified Person brought by Investors holding a majority of the Total Commitments, the Partnership shall not advance
the expenses incurred by the Indemnified Persons. The Indemnified Persons shall repay any amounts received by them as
indemnification to the extent that a subsequent non-appealable judgement states grounds on the basis of which they would
not have been entitled to such indemnification.
11.6 Each of the Shareholders shall indemnify each of the General Partner, any Affiliate of it and the Fund against the
amount of Taxation for which the General Partner, any Affiliate of it and the Fund is liable either on behalf of that Share-
holder or in respect of that Shareholder’s participation in the Fund. The General Partner shall notify such Shareholder of
such amount having been paid.
12. Art 12. Removal of the General Partner without Cause
12.1 Subject to the approval of the general meeting of the Shareholders as set out below, the General Partner may be
removed by Investors holding at least 75 per cent of Total Commitments at any time.
12.2 The General Partner shall, prior to the general meeting of the Shareholders approving the General Partner’s removal
as set out below, have the right to organise and hold a forum within two weeks from the date of receipt of the notice of the
intended removal. In the event that the General Partner shall be removed in accordance with the above, a general meeting
of the Shareholders shall be held to approve the removal. Such general meeting of the Shareholders shall, at first call, meet
a quorum requirement of 50 per cent of the total Shares issued. Should such quorum requirement not have been met at the
first meeting, no quorum will be required at a reconvened meeting having the same agenda as the first meeting. Decisions
at each meeting will require a majority of two thirds of the votes cast and, for the avoidance of doubt, the approval by
Shareholders holding at least 75 per cent of Total Commitments in accordance with the above.
12.3 For the avoidance of doubt, the General Partner shall not hold a veto right on any resolution with respect to its
removal.
12.4 The General Partner shall be entitled to a compensation for such termination on the amount of one and a half times
the Management Fee payable for the year prior to its removal. The Carried Interest entitlement on the A Shares shall be
reduced to any Carried Interest attributable to investments in Portfolio Property made prior to the General Partner’s removal
(calculated on the basis as if such Portfolio Property had been made through a separate fund having the same terms and
conditions as this Fund but which only made the relevant Portfolio Property). The General Partner shall be required to
transfer its Management Share to a new general partner (if any) at a price equal to EUR 1,000.
13. Art 13. Removal of the General Partner for Cause
13.1 Subject to the approval of the general meeting of the Shareholders as set out below, the General Partner may be
removed by Investors holding at least a majority of Total Commitments as a result of”cause” which shall mean (i) with
respect to the General Partner, its Affiliates and the Advisors a breach of their fiduciary duties to the Fund, gross negligence,
fraud, felony, wilful or intentional misconduct or a material breach of the provisions of the PPM or these Articles of
Association that remains uncured for 30 days it being understood, for the avoidance of doubt, that “cause” shall not be
constituted as a result of unsuccessful achievement of the Fund's financial targets or, in general, Fund's results. The General
Partner shall promptly notify the Investors of any event or condition constituting "cause" as defined above.
13.2 The General Partner shall, prior to the general meeting of the Shareholders approving the General Partner’s removal
as set out below, have the right to organise and hold a forum within two weeks from the date of receipt of the notice of the
intended removal for cause to address the issues raised in the notice of such removal with all Investors and/or to send its
statement addressing the issues raised to all Investors. In the event that the General Partner shall be removed in accordance
with the above, a general meeting of the Shareholders shall be held to approve the removal. Such general meeting of the
Shareholders shall, at first call, meet a quorum requirement of 50 per cent of the total Shares issued. Should such quorum
requirement not have been met at the first meeting, no quorum will be required at a reconvened meeting having the same
agenda as the first meeting. Decisions at each meeting will require a majority of two thirds of the votes cast and, for the
avoidance of doubt, the approval by Shareholders holding a majority of Total Commitments in accordance with the above.
13.3 For the avoidance of doubt, the General Partner shall not hold a veto right on any resolution with respect to its
removal.
55131
L
U X E M B O U R G
13.4 The General Partner shall not be entitled to any compensation for such termination and the Carried Interest entit-
lement on the A Shares shall be reduced to any Carried Interest attributable to investments in Portfolio Property made prior
to the General Partner’s removal (calculated on the basis as if such Portfolio Property had been made through a separate
fund having the same terms and conditions as this Fund but which only made the relevant Portfolio Property). The General
Partner shall be required to transfer its Management Share to a new general partner (if any) at a price equal to EUR 1,000.
Upon removal of the General Partner, all contracts with the Advisors relating to the Fund shall terminate with immediate
effect.
IV. General meetings of shareholders
14. Art. 14. Powers and voting rights.
14.1 The general meeting of Shareholders properly constituted represents the entire body of Shareholders of the Fund.
14.2 It cannot order, adopt, carry out or ratify acts relating to the operations of the Fund without the consent of the
General Partner, unless otherwise provided in these Articles of Association and the PPM (including, in particular, any
resolutions initiated by the Shareholders relating to the General Partner’s removal and/or replacement).
14.3 Resolutions of the Shareholders shall be adopted at general meetings.
14.4 Each Shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each share is entitled to one vote.
15. Art. 15. Notices, quorum, majority and voting proceedings.
15.1 The notice periods and proceedings as well as the discussion proceedings provided by law shall govern the notice
for, and conduct of, the meetings of Shareholders of the Fund, unless otherwise provided herein.
15.2 Meetings of Shareholders of the Fund shall be held at such place and time as may be specified in the respective
convening notices of the meetings.
15.3 The General Partner shall convene Shareholders’ meetings at least annually on not less than 30 calendar days’ prior
written notice, offering the opportunity to review and discuss the affairs of the Fund. Any Shareholders whose Commitments
in aggregate represent 10 per cent or more of the Total Commitments may, by notice in writing together with an agenda,
require the General Partner to call a Shareholders’ meeting within 45 calendar days, unless a proposed resolution on such
agenda is the removal of the General Partner as the managing general partner of the Fund, in which case the General Partner
shall convene a Shareholders’ meeting on not less than 10 Business Days, but no more than 15 Business Days, from the
date upon which the General Partner receives the applicable notice. If all the Shareholders of the Fund are present or
represented at a meeting of the Shareholders of the Fund, and consider themselves as being duly convened and informed
of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
15.4 A representative appointed by the General Partner shall preside as non-voting chairman of every meeting of the
Shareholders of the Fund or if such appointee is not present or is unwilling to act Investors holding Commitments which
in aggregate exceed 50% of Total Commitments shall be entitled to appoint (in advance or in the course of the relevant
meeting) any member present or represented to be chairman of the meeting.
15.5 A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders of the Fund by appointing another person (who need
not be a shareholder) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or email.
15.6 Each Shareholder may also participate in any meeting of the Shareholders of the Fund by telephone or video
conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
identify, hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation
in person at such meeting.
15.7 Each Shareholder may also vote by way of voting forms provided by the Fund. These voting forms contain the
date and place of the meeting, the agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each proposed
resolution, three boxes allowing the Shareholders to vote in favour, against or abstain from voting on the proposed reso-
lution. The voting forms must be sent by the Shareholders by mail, telegram, telex, facsimile or e-mail to the registered
office of the Fund. The Fund will only accept the voting forms which are received prior to the time of the meeting specified
in the convening notice. Voting forms which show neither a vote (in favour or against the proposed resolutions) nor an
abstention shall be void.
15.8 Except as otherwise required by law or by these Articles of Association, resolutions at a meeting of the Shareholders
of the Fund duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting, regardless of
the proportion of the share capital represented at such meeting.
Any amendment to these Articles of Association is subject to the prior approval of the CSSF and shall be decided by
the general meeting of the Shareholders which at first call shall meet a quorum of 50 per cent of the total Shares issued.
Should such quorum requirement not have been met at the first meeting, no quorum requirement will be required at a
reconvened meeting having the same agenda as the first meeting. Decisions at either meeting will require (i) a majority of
two thirds of the votes cast, (ii) the consent of Shareholders representing at least two-thirds of Total Commitments and (iii)
the consent of the General Partner. Notwithstanding the above, no amendment may increase any Shareholder’s Commit-
ment, change the Fund’s jurisdiction, modify any right to distribution and/or modify the majority requirements for
amendments without the unanimous consent of the Shareholders and the General Partner.
55132
L
U X E M B O U R G
15.9 No resolution may increase any Shareholder’s Commitment, change the Fund’s jurisdiction, modify any right to
distribution and/or modify the majority requirements for amendments of these Articles of Association without the unani-
mous consent of the Shareholders and the General Partner.
15.10 Notwithstanding any other provision in these Articles, Article 12a and any other article specifically related to
ERISA may be amended only if 2/3 (by Commitments) of ERISA Partners have also consented to such amendment
V. Supervision - Annual accounts - Allocation of profits
16. Art. 16. Auditor. The operations of the Fund and its financial situation including particularly its books shall be
supervised by one authorized auditor (réviseur d’entreprises agréé), who shall satisfy the requirements of Luxembourg law
as to honourableness and professional experience, who shall carry out the duties prescribed by law and these Articles of
Association, and who will be remunerated by the Fund. This shall include, in particular, such auditor reviewing the ac-
counting data related in the annual report of the Fund.
17. Art. 17. Accounting Year and annual general meeting.
17.1 The accounting year of the Fund shall begin on the 1
st
of January and shall end on the 31
st
of December of each
year. The first accounting year of the Fund shall begin on the day of the incorporation of the Fund and shall end on 31
December 2014.
17.2 The annual general meeting of the Shareholders of the Fund shall be held, in accordance with Luxembourg law,
in Luxembourg at the address of the registered office of the Fund or at such other place in the municipality of the registered
office as may be specified in the convening notice of meeting, on the last Monday of June at 11.30 a.m.. If such day is not
a Business Day, the annual general meeting shall be held on the last immediately preceding Business Day.
17.3 The annual general meeting of the Shareholders of the Fund may be held abroad if, in the absolute and final
judgement of the General Partner, exceptional circumstances so require.
18. Art. 18. Appropriation of Proceeds.
18.1 Distributions may, after satisfying any third party expenses and liabilities of the Fund as well as the Management
Fee and establishment of sufficient reserves for future liabilities of the Fund, be made by the General Partner in its discretion,
subject to compliance with the provisions of the PPM (in particular the waterfall rules).
18.2 Cash distributions shall be made in EUR. No distributions shall be made unless there is sufficient cash available,
or if the Net Asset Value of the Fund would as a consequence of the distribution fall below the legal minimum EUR
1,250,000 (as required by the SIF Law) or if the General Partner believes, in good faith, that the distribution would put the
Fund in a position where it is unable to meet any future obligations or contingencies.
19. Art. 19. Valuation.
19.1 The “Net Asset Value” of the Fund is equal to the fair value of the total assets of the Fund less the value of the total
liabilities of the Fund including accounting profits adjusted for items that do not contribute to fair value (such as derivative
accounting, post balance sheet events, or deferred amounts that will not materialize) as well as any other adjustments
necessary to determine the Net Asset Value in accordance with Luxembourg GAAP.
19.2 The assets of the Fund shall include (without limitation):
(a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
(b) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
(c) all shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other securities, financial
instruments and similar assets owned or contracted for by the Fund (provided that the Fund may make adjustments with
regards to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);
(d) all stock dividends, cash dividends and cash distributions received by the Fund to the extent information thereon is
reasonably available to the Fund;
(e) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Fund except to the extent that the same is included
or reflected in the principal amount of such assets;
(f) the liquidation value of all contracts and options the Fund has an open position in;
(g) the preliminary expenses of the Fund insofar as the same have not been written off; and
(h) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
19.3 The liabilities of the Fund shall include (without limitation):
(a) all loans, bills and accounts payable;
(b) all accrued interest on loans of the Fund (including accrued fees for commitment for such loans);
(c) all accrued or payable expenses (including administrative expenses, depositary fees and any other agents’ fees);
(d) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Fund;
55133
L
U X E M B O U R G
(e) an appropriate provision for future taxation based on capital and income on the accounting date, and other reserves
(if any) authorized and approved by the General Partner as well as such amount (if any) as the General Partner may consider
to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Fund; and
(f) all other liabilities of the Fund of whatsoever kind and nature assessed in accordance with Luxembourg GAAP. In
determining the amount of such liabilities the Fund shall take into account all expenses payable by the Fund. The Fund
may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount ratably for
annual or other periods.
19.4 The General Partner will ensure the Net Asset Value is calculated as of 31 December, 31 March, 30 June and 30
September each year and as at any other times as may be appropriate. If following a valuation day events or new information
is brought to the knowledge of the General Partner which imply that a portion or a substantial portion of the Fund’s assets
should be revalued, the General Partner may, in order to safeguard the interests of the Investors and the Fund, cancel the
first valuation and carry out a second valuation.
19.5 The Net Asset Value per Share on any valuation day equals the total Net Asset Value of the Fund divided by the
total number of issued Shares on that valuation day.
19.6 In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value
taken by the General Partner or Administrative Agent shall be final and binding on the Fund and present, past or future
shareholders, subject to the year-end audit by the auditor of the Fund (being a réviseur d’entreprises agréé).
19.7 The General Partner may suspend the calculation of the Net Asset Value for:
(a) any period when, in the reasonable opinion of the General Partner, a fair valuation of the assets of the Fund is not
practicable for reasons beyond the control of the Fund; or
(b) any period when any of the principal stock exchanges on which Portfolio Investments of the Fund are quoted are
closed (otherwise than for ordinary holidays), or during which dealings thereon are restricted or suspended; or
(c) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which valuation of assets owned
by the Fund would be impractical; or
(d) any breakdown in, or restriction in the use of, the means of communication normally employed in determining the
price or value of any of the Portfolio Investments or the currency price or values on any such stock exchange.
All Investors will be promptly informed of such a suspension by the General Partner.
VI. Dissolution - Liquidation
20. Art. 20. Dissolution - Liquidation.
20.1 Upon the dissolution and liquidation of the Fund, the General Partner (or any other liquidator appointed in accor-
dance with these Articles of Association) will use its best efforts to dispose of all of the Fund’s remaining assets.
20.2 The liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities)
named, subject to the approval of the CSSF, by the meeting of Shareholders pursuant to the Fund Law. The Shareholders
will also determine the remuneration and the powers, subject to the SIF Law, of the liquidators.
20.3 At the end of the liquidation and redemption process of the Fund, any amounts that have not been claimed by the
Shareholders will be paid into the Caisse de consignation, which keep them available for the benefit of the relevant Sha-
reholders during the duration provided for by law.
VII. Miscellaneous
21. Art. 21. Confidentiality.
21.1 The Shareholders shall not, and each Shareholder shall use all reasonable endeavours to procure that every person
connected with or associated with such Shareholder shall not, without the prior written consent of the General Partner,
disclose to any person, firm or corporation or use to the detriment of the Fund or any of the Shareholders (other than in
connection with claims against such parties in respect of any breach of their obligations and duties) any confidential
information which may have come to its or their knowledge concerning the affairs of the Fund or Portfolio Property or
proposed investments, provided however that in respect of each Shareholder the foregoing restriction on disclosure shall
not apply to information which:
(a) is possessed by such Shareholder prior to the receipt thereof from the General Partner; or
(b) becomes known to the public other than as a result of a breach of such obligations by such Shareholder; or
(c) the General Partner (acting reasonably) believes it is necessary to disclose to enable the Fund to make any particular
investment.
21.2 Each Shareholder acknowledges that:
(a) unless otherwise stated all information provided to them by the General Partner relating to the affairs of the Fund,
General Partner, Advisors, Property Managers, any Affiliate of either of them or any Investment is confidential and the
release of such information may be detrimental to the affairs or business of the Fund, General Partner, Advisors, Property
Managers, any Affiliate of either of them or Investment; and
55134
L
U X E M B O U R G
(b) unless otherwise stated all information provided to them by the General Partner in relation to any Investment is
commercially sensitive information and the release of such information may be detrimental to the affairs or business of the
Fund, General Partner, Advisors, Property Managers, any Affiliate of either of them or any Investment and may prejudice
the commercial interests of the before mentioned persons.
21.3 Notwithstanding the above, a Shareholder shall be entitled to disclose confidential information received by it
concerning the business or affairs of the Fund, subject to any applicable laws and regulations:
(a) to its Affiliates, employees and directors;
(b) to its bona fide professional advisers, auditors, insurers and ratings agencies;
(c) if the Shareholder is a fund of funds (or equivalent), to such Shareholders’ investors and bona fide prospective
investors;
(d) if specifically required to do so by law (and there is no relevant exemption which is applicable) or by a court of law
or by the regulations of any relevant stock exchange or any regulatory authority to which any of the Shareholders or any
such person connected or associated with a Shareholder is subject;
(e) to any governmental, regulatory or tax authorities to which such Shareholder is required to report and in particular
a Shareholder (and any employee, representative, or other agent of a Shareholder) may disclose to any and all persons,
without limitation of any kind, where disclosure consists of the tax treatment and tax structure of the Fund and all related
materials (including opinions or other tax analyses) that are provided by the General Partner to the Shareholder relating to
such tax treatment and tax structure; or
(f) if otherwise agreed with the General Partner,
provided that in the case of (a), (b) and (c) above such disclosure shall only be allowed if the recipient is bound by an
equivalent obligation of confidentiality in respect of such information and has given an undertaking not to make any further
disclosures of such information, and the Shareholder shall remain liable for the actions of such recipients.
21.4 Each Shareholder which is subject to any obligation to disclose information received by it or any other information
otherwise concerning the business or affairs of the Fund or any Portfolio Property shall immediately notify the General
Partner as soon as it becomes aware of any request from any third party (other than its own shareholders, investors, advisers,
auditors or any governmental, regulatory or tax authorities to which such Shareholder is required to report) for such in-
formation to be provided or disclosed by such Shareholder to such third party (a “Disclosure Request”) and each Shareholder
warrants to the General Partner that it will use all reasonable endeavours to seek to defend against such Disclosure Request
at all times in accordance with the provisions of the relevant public disclosure laws, statutes, statutory instruments, regu-
lations or policies.
21.5 If a Shareholder discloses any information concerning the valuation of such Shareholder’s interest in the Fund or
any performance data regarding the Fund, it will include in such disclosure a statement to the effect that such data does not
necessarily reflect the current or expected future performance of the Fund and should not be used to compare returns of
the Fund against returns of other private equity funds, and that disclosure has not in any way been sanctioned by the General
Partner.
22. Art. 22. References. Reference is made to the provisions of the 1915 Law, the PPM, the Subscription Forms with
the Investors and to any agreement which may be entered into among the Shareholders from time to time (if any) for all
matters for which no specific provision is made in these Articles of Association.
VIII. Definitions
Except as otherwise defined or as the context may otherwise require, capitalised words and expressions shall have the
meanings as set out below or, to the extent not defined below, as set out in the PPM. In the event of any conflicts between
the terms of these Articles and the PPM, the terms of these Articles shall prevail.
1915 Law
the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended
Advisory Committee
the Fund’s advisory committee as described in the PPM
A Shares
the A Shares in the capital of the Fund
Administrative Agent
the administrative agent of the Fund
Advisors
Blue Colibri AG, Munich, and Blue Colibri S.à r.l., Paris
Affiliates
in relation to any undertaking (“U”), a parent undertaking of U, a subsidiary undertaking of
U, a subsidiary undertaking of a parent undertaking of U or a parent undertaking of a
subsidiary undertaking of U provided that the terms “parent” and “subsidiary” shall be
construed in accordance with the 1915 Law and provided further that (i) a company in
relation to or via which the Fund holds any Portfolio Property shall not be deemed to be an
Affiliate of the General Partner by reason only of an investment by the Fund in such Portfolio
Property and (ii) in relation to an Investor any pooled investment vehicle which is primarily
managed by the same manager (or an Affiliate of such manager) shall be deemed an Affiliate
of such Investor
Articles of Association
the articles of association of the Fund as amended from time to time
B Shares
the B Shares in the capital of the Fund
55135
L
U X E M B O U R G
Business Day
a day (not being a Saturday or Sunday or a public holiday) on which banks are generally
open for non-automated business in Luxembourg
Carried Interest
the carried interest payable to the A Shareholders as more specifically set out in the
distribution waterfall provisions of the PPM
Code
the US Internal Revenue Code of 1986, as amended
Commitment
the amount of capital an Investor has agreed to commit to the Fund by way of subscription
for B Shares and / or C Shares pursuant to its Subscription Form
C Shares
the C Shares in the capital of the Fund
CSSF
the Luxembourg financial supervisory authority (commission de surveillance du secteur
financier)
Custodian
the Fund’s custodian
Default Interest
has the meaning given in Article 10.1
Default Redemption Price has the meaning given in Article 10.5(a)(ii)
Defaulted Redeemable
Shares
has the meaning given in Article 10.5(a)
Defaulted Shares
has the meaning given in Article 10.4
Defaulting Investor
has the meaning given in Article 10.3
Disclosure Request
has the meaning given in Article 24.4
ERISA
the United States Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended
ERISA Partner
a Shareholder that is an employee benefit plan subject to Title I of ERISA or an entity whose
underlying assets include “plan assets” within the meaning of Regulation 29 CFR Section
2510.3– 101 by reason of investment in the entity by an employee benefit plan subject to
Title I of ERISA
Final Closing Date
the date on which the Fund ceases to accept Commitments as set out in the PPM
First Closing Date
the date on which the Fund accepts the first Commitments by Investors as set out in the PPM
Fund
Blue Colibri Capital Partners Fund II SCA, SICAV-SIF
General Partner
Blue Colibri Capital S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée or
S.à r.l.) organised and incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
Indemnified Individual
any officer, director, shareholder, agent, member, adviser, consultant, partner or employee
of the General Partner, the Advisors, Property Managers, any Affiliate of either of them, or
a Nominated Director and members of the Advisory Committee as well as the Shareholders
appointing them to such role (to the extent acting in such capacity)
Indemnified Person
any of the General Partner, the Advisors, Property Managers, any Affiliate of either of them
and any Indemnified Individual
Investment Company Act the US Investment Company Act of 1940
Investors
the persons other than the A Shareholders in their capacity as A Shareholders who become
(or, as the context require, consider to become) Shareholders by entering into a Subscription
Form which is accepted by the General Partner and any substitute Investors and “Investor”
shall be construed accordingly
Management Fee
the remuneration to be received by the General Partner for its management services provided
to the Fund, as defined more precisely in the PPM and the Subscription Forms
Management Share
the unlimited Share in the Fund subscribed for by the General Partner
Net Asset Value
has the meaning given in Article 22.1
Nominated Director
any person nominated by the Fund or the General Partner, the Advisors, Property Managers
or any Affiliate of either of them to be a director (or equivalent) of any company in which
the Fund holds a Portfolio Property
Person
any individual, corporation, partnership, limited liability company, joint-stock company,
association, unincorporated organization or other entity
Plan Assets Regulation
the “plan assets” regulation 29 CFR 2510.3-101 under ERISA
Portfolio Property
real estate and real-estate related assets in which the Fund has made an investment, whether
directly or indirectly via one or more holding entities
Property Managers
service providers including Monopteros Immobilienverwaltung GmbH in Germany and
Austria and Blue Colibri SARL in France rendering Asset and property management
services to the Fund
Purchaser
has the meaning given in Article 10.5(b)(i)
PPM
the private placement memorandum relating to the newly-formed Fund as amended from
time to time, setting out details about the Fund and its Investments
55136
L
U X E M B O U R G
Redemption Notice
has the meaning given in Article 10.5(a)(i)
Share(s)
means, as the context requires, any or all of the A Shares, the B Shares and the C Shares
(but not the Management Share)
Shareholders
the holders of the Shares
SIF Law
the Luxembourg law dated 13 February 2007 on Luxembourg Specialised Investments
Funds, as amended
Subscription Form
an agreement as defined in Article 10.1 which includes the relevant Investor’s Commitment
to the Fund as well as the subscription terms and conditions and which operates adherence
to the Fund
Taxation
any form of taxation together with interest or penalties (if any) thereon and any reasonable
costs incurred in resisting claims therefore
Transfer
has the meaning given in Article 11
Total Commitments
the aggregate amount of all Commitments
Well-Informed Investor
an investor as defined in article 2 of the SIF Law, who shall be any institutional investor,
professional investor or any other investor who meets the following conditions:
(a) he has confirmed in writing that he adheres to the status of well-informed investor; and
(b) he either:
(i) invests or commits to invest a minimum of €125,000 (one hundred and twenty-five
thousand euro) in the Fund; or
(ii) has obtained an assessment made by a credit institution within the meaning of Directive
2006/48/EC, an investment firm within the meaning of Directive 2004/39/EC, or by a
management company within the meaning of Directive 2009/65/EC certifying that it has the
appropriate expertise, experience and knowledge to adequately understand and appraise an
investment in the Fund.
This restriction does not apply to the General Partner
<i>Statement and poweri>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that accordingly to the Luxembourg Law
of 2007 on specialized investment fund as amended, and on the special request of the appearing parties, the present deed
is worded in English only and the English version will always prevail whereas the company representatives will deliver on
first request to any public administration or service the required or necessary applicable translation of any statutory or other
dispositions contained herein as the notary is not enabled or in charge of any translation procedures.
Thus, the above appearing parties, as represented, hereby gives power to any agent or employee of the office of the
signing notary, acting individually, to sign all additional recordings, draw, correct and sign any error, lapse or typo contained
herewith.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the said proxyholder signed together with
the notary the present deed.
Signé: E. Koster, O. Millich, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 janvier 2016. Relation: EAC/2016/2178. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Amédé SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2016.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2016058468/717.
(160019620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Bluehouse Accession Property Holdings III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 142.311.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third of December.
Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared
1) Bluehouse Capital Advisors S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company with registered office at 20, rue
de la Poste L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered at the R.C.S. of Luxembourg under the
55137
L
U X E M B O U R G
number B137.666, acting in its capacity as management company of Bluehouse Accession Property III - A, a sub-fund of
Bluehouse Accession Property III, a Luxembourg fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé, gover-
ned by the law of February 13
th
, 2007 relating to specialised investment funds; and
2) Bluehouse Capital Advisors S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company with registered office at 20, rue
de la Poste L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered at the R.C.S. of Luxembourg under the
number B137.666, acting in its capacity as management company of Bluehouse Accession Property III - B, a sub-fund of
Bluehouse Accession Property III, a Luxembourg fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé, gover-
ned by the law of February 13
th
, 2007 relating to specialised investment funds.
Both parties are here duly represented by Mr. Liridon ELSHANI, jurist, residing professionally in Luxembourg, by
virtue of two proxies given under private seal, on December 23
rd
, 2015.
The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties are all the unitholders of the company "Bluehouse Accession Property Holdings III S.à r.l." (the
"Company"), a private limited liability company organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its
registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 142.311, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER,
notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg on October 8
th
, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 2642 on October 29
th
, 2008. The articles of incorporation have last been modified
pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, on December 11
th
, 2013, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 314 on February 4
th
, 2014.
The appearing parties, representing the whole corporate capital, take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders decide to decrease the issued corporate capital of the Company by an amount of by an amount of
twenty-four thousand and one hundred and fifty Euro (EUR 24,150.-) in order to bring it from its current amount of one
hundred thirty-three thousand two hundred Euro (EUR 133,200.-) to one hundred and nine thousand and fifty Euro (EUR
109,050.-), by the cancellation of one million two hundred seven thousand and five hundred (1,207,500) class G shares
and one million two hundred seven thousand and five hundred (1,207,500) class I shares, with a nominal value of one
eurocent (EUR 0,01) each,
with the purpose to reimburse the shareholders at the proportion to their detention in the share capital, under respect of
the condition foreseen by article 69 (2) of the law of the 10
th
August 1915 on commercial companies
The shareholders decide to confer all powers to the board of managers in order to determine the modalities of the
reimbursement and to implement the necessary bookkeeping amendments, to the cancellation of reimbursed shares and the
shareholders' reimbursement.
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolve to amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:
" 5.1. The issued share capital of the Company (the "Share Capital") is set at one hundred and nine thousand and fifty
Euro (EUR 109,050.-) represented by:
One million two hundred forty thousand (1,240,000) ordinary shares (the "Ordinary Shares"),
- One million two hundred and seven thousand five hundred (1,207,500) class "A" shares (the "Class A Shares"),
- One million two hundred and seven thousand five hundred (1,207,500) class "B" shares (the "Class B Shares"),
- One million two hundred and seven thousand five hundred (1,207,500) class "C" shares (the "Class C Shares"),
- One million two hundred and seven thousand five hundred (1,207,500) class "D" shares (the "Class D Shares"),
- One million two hundred and seven thousand five hundred (1,207,500) class "E" shares (the "Class E Shares"),
- One million two hundred and seven thousand five hundred (1,207,500) class "F" shares (the "Class F Shares"),
- One million two hundred and seven thousand five hundred (1,207,500) class "H" shares (the "Class H Shares"),
- One million two hundred and seven thousand five hundred (1,207,500) class "J" shares (the "Class J Shares"),
- Thousand (1,000) class "K" shares (the "Class K Shares"),
- Thousand (1,000) class "L" shares (the "Class L Shares"),
- Thousand (1,000) class "M" shares (the "Class M Shares"),
- Thousand (1,000) class "N" shares (the "Class N Shares"),
- Thousand (1,000) class "O" shares (the "Class O Shares"),
with a nominal value of one Eurocent (EUR 0,01) each.
55138
L
U X E M B O U R G
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are assessed to one thousand two hundred euro (EUR 1.200,-).
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,
followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English and the
French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first names, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) Bluehouse Capital Advisors S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège
social à 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg et immatriculée auprès du R.C.S. de Lu-
xembourg sous le numéro B137.666, agissante en qualité de société de gestion de Bluehouse Accession Property III - A,
un sous-fond de Bluehouse Accession Property III, un fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé
luxembourgeois, soumis à la loi de 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; et
2) Bluehouse Capital Advisors S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège
social à 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg et immatriculée auprès du R.C.S. de Lu-
xembourg sous le numéro BB137.666, agissante en qualité de société de gestion de Bluehouse Accession Property III - B,
un sous-fond de Bluehouse Accession Property III, un fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé
luxembourgeois, soumis à la loi de 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés.
Les deux parties sont ici dûment représentées par Monsieur Liridon ELSHANI, juriste, demeurant professionnellement
à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé, datées du 23 décembre 2015.
Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumen-
tant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants sont tous les associés de la société "Bluehouse Accession Property Holdings III S.à r.l." (la "So-
ciété"), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346
Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 142.311, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-
duché de Luxembourg, en date du 8 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
2642 du 29 octobre 2008. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 314 du 4 février 2014.
Lesquels comparants, représentants l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de diminuer le capital social de la Société à concurrence de vingt-quatre mille cent cinquante euros
(EUR 24,150.-) pour le porter de son montant actuel de cent trente-trois mille deux cents euros (EUR 133,200.-) à cent
neuf mille cinquante euros (EUR 109,050.-),
par l'annulation d'un million deux cent sept mille cinq cents (1.207.500) parts de la catégorie G, un million deux cent
sept mille cinq cents (1.207.500) parts de la catégorie I, d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, en vue de
rembourser les associés au prorata de leur détention dans le capital social, conformément aux conditions prévues à l'article
69 (2) de la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales.
Les associés de conférer tous pouvoir au conseil de gérance afin de déterminer les modalités de remboursement et de
mettre en oeuvre les modifications comptables nécessaires, à l'annulation des parts sociales remboursées et le rembourse-
ment des associés.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés Décident en conséquence de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur
suivante:
" 5.1. Le capital social de la Société (le «Capital Social») est fixé à cent neuf mille cinquante euros (EUR 109,050.-)
divisé en:
- Un million deux cent quarante mille (1.240.000) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»),
- Un million deux cent sept mille cinq cents (1.207.500) parts sociales de catégorie «A» (les «Parts Sociales de Catégorie
A»),
55139
L
U X E M B O U R G
- Un million deux cent sept mille cinq cents (1.207.500) parts sociales de catégorie «B» (les «Parts Sociales de Catégorie
B»),
- Un million deux cent sept mille cinq cents (1.207.500) parts sociales de catégorie «C» (les «Parts Sociales de Catégorie
C»),
- Un million deux cent sept mille cinq cents (1.207.500) parts sociales de catégorie «D» (les «Parts Sociales de Catégorie
D»),
- Un million deux cent sept mille cinq cents (1.207.500) parts sociales de catégorie «E» (les «Parts Sociales de Catégorie
E»),
- Un million deux cent sept mille cinq cents (1.207.500) parts sociales de catégorie «F» (les «Parts Sociales de Catégorie
F»),
- Un million deux cent sept mille cinq cents (1.207.500) parts sociales de catégorie «H» (les «Parts Sociales de Catégorie
H»),
- Un million deux cent sept mille cinq cents (1.207.500) parts sociales de catégorie «J» (les «Parts Sociales de Catégorie
J»),
- Mille (1.000) parts sociales de catégorie «K» (les «Parts Sociales de Catégorie K»),
- Mille (1.000) parts sociales de catégorie «L» (les «Parts Sociales de Catégorie L»),
- Mille (1.000) parts sociales de catégorie «M» (les «Parts Sociales de Catégorie M»),
- Mille (1.000) parts sociales de catégorie «N» (les «Parts Sociales de Catégorie N»),
- Mille (1.000) parts sociales de catégorie «O» (les «Parts Sociales de Catégorie O»),
ayant chacune une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01).
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel,
état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/30384. Reçu soixante-quinze
euros Eur 75.-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058471/155.
(160018520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Duke Investments & Participations S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 177.210.
This twenty-first day of December two thousand fifteen before me, Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand
Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of:
Duke Investments & Participations S.A., a public company under the laws of Luxembourg, having had its registered
office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 177210, incorporated pursuant to a deed executed before Carlo Wersandt, notary in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, on 2 May 2013, published in the Official Journal of the Grand Duchy of Luxembourg,
Mémorial C, No. 1584 of 3 July 2013, the articles of association of which have not been amended since (the "Company").
The meeting was chaired by Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at Pétange, Grand
Duchy of Luxembourg. Marisa GOMES, employee, with professional address at Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
acted as secretary and scrutineer of the meeting. Such persons, acting as scrutiny committee of the meeting, established
that all shareholders of the Company were represented at the meeting and, acting as proxies of the shareholders of the
55140
L
U X E M B O U R G
Company, declared that they have been informed of the agenda of the meeting and that, accordingly, the meeting may be
held without prior notice in accordance with the last sentence of article 10 of the articles of association of the Company.
The members of the scrutiny committee of the meeting are personally known to me, notary. The proxies to such persons,
as well as the attendance list specifying the names of the shareholders represented and the number of shares held by each
of them, are initialled ne varietur by the members of the scrutiny committee and by me, notary, and are annexed hereto.
The members of the scrutiny committee of the meeting declared and requested me, the undersigned notary, to record
the following:
<i>Resolutionsi>
The general meeting resolved by a unanimous vote:
1. to remove the incumbent directors of the Company from office together with any and all internal auditors and other
officers of the Company and to give them full and final discharge for the execution of their office and their management
and supervision of the Company;
2. to dissolve the Company and put it into liquidation;
3. to appoint Thomas Hubertus Gerardus Marie Sikkink, born on 10 April 1974 in Hoensbroek (Netherlands), residing
at Rua Oceano Pacífico 392, Apartment 302, Block Intermares, Cabedelo, Paraíba, 58310-000, Brazil, as liquidator of the
Company;
4. that the liquidator shall determine the method of liquidation; and
5. that the liquidator is authorised, for the purpose of winding up the Company, to exercise all powers not reserved by
law or the articles to the general meeting of the Company, including the powers referred to in articles 145 and 148 of the
Act concerning commercial companies of 10 August 1915, as amended, and that the liquidator shall have the power to
represent and bind the Company towards third parties and at law.
I, the undersigned notary, having knowledge of the English language, declare that this deed is drawn up in English
followed by a version in French at the request of the persons appearing, who, acting as stated above, stipulated that in case
of any discrepancy between the English version and the French version, the English version shall prevail.
In witness whereof, this deed was drawn up and passed in Pétange on the date first above stated. After the deed was
read to the persons appearing, the persons appearing declared to understand the scope and the consequences and subse-
quently signed the original together with me, notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt et un décembre par-devant moi, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange,
Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
l'assemblée générale extraordinaire de:
Duke Investments & Participations S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant déjà eu son siège social
au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg sous le
numéro B 177210, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Wersandt, notaire à Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, le 2 mai 2013, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des sociétés
et associations, n° 1584 du 3 juillet 2013, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis (la «Société»).
L'assemblée a été présidée par Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à
Pétange, Grand-Duché de Luxembourg. Marisa GOMES, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Pétange,
Grand-Duché de Luxembourg, a été désignée secrétaire et scrutateur de l'assemblée. Ces personnes, agissant comme bureau
de l'assemblée, ont constaté que tous les actionnaires de la Société ont été représentés à l'assemblée et, agissant en tant que
fondés de pouvoir des actionnaires de la Société, ont déclaré qu'elles ont été informées de l'ordre du jour de l'assemblée et
que, par conséquent, l'assemblée a pu être tenue sans convocation préalable en conformité avec la dernière phrase de l'article
10 des statuts de la Société. Les membres du bureau de l'assemblée sont connus personnellement de moi, notaire. Les
procurations données aux membres du bureau de l'assemblée ainsi que la liste de présence mentionnant les actionnaires
représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont paraphées ne varietur par les membres du bureau et par moi, notaire,
et sont annexées aux présentes.
Les membres du bureau de l'assemblée ont déclaré et m'ont requis, le notaire soussigné, d'acter ce qui suit:
<i>Résolutionsi>
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité:
1. de révoquer les mandats des administrateurs de la Société en fonction ainsi que les mandats de tous les commissaires
aux comptes et de tous autres dirigeants de la Société et de leur donner décharge de l'exécution de leur mandat et quitus
entier et définitif de leur gestion ou surveillance de la Société;
2. de dissoudre la Société et de mettre celle-ci en liquidation;
55141
L
U X E M B O U R G
3. de nommer Thomas Hubertus Gerardus Marie Sikkink, né le 10 avril 1974 à Hoensbroek (Pays-Bas), demeurant à la
Rua Oceano Pacífico 392, appartement 302, lotissement Intermares, Cabedelo, Paraíba, 58310-000, Brésil, en tant que
liquidateur de la Société;
4. que le liquidateur détermine le mode de liquidation; et
5. que le liquidateur est autorisé, aux fins de la liquidation de la Société, à exercer tous les pouvoirs non dévolus par la
loi ou les statuts à l'assemblée générale de la Société, y compris les pouvoirs visés aux articles 145 et 148 de la Loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et que le liquidateur a le pouvoir de représenter et
engager la Société à l'égard des tiers et en justice.
Moi, notaire soussigné ayant connaissance de la langue anglaise, je déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi
d'une version française à la demande des comparantes, celles-ci, agissant comme indiqué ci-avant, ont stipulé qu'en cas de
divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera seule foi.
Dont acte, fait et passé à Pétange à la date qu'en tête des présentes. Et après lecture de l'acte faite aux comparantes,
celles-ci ont déclaré qu'elles comprennent la portée et les conséquences et ont ensuite signé la présente minute avec moi,
notaire.
Signé: Conde, Gomes, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31528. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016058604/91.
(160019303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
DCIT Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 181.351.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of December.
Before us Maître Martine DECKER, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
- Daniels Capital Investment GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), incorporated
and existing under the laws of Switzerland, having its registered office at Bahnhofstrasse 42, CH-6160 Entlebuch, Swi-
tzerland, registered with the “registre de commerce du canton de Lucerne" under the number CHE-150.966.336,
here represented by Mrs. Géraldine Nucera, employee, professionally residing in Hesperange, by virtue of a power of
attorney under private seal issued on December 23
rd
, 2015,
Such power, initialed “ne varietur” by the proxyholder and by the undersigned notary will remain attached to the present
minutes for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact that:
I.- the appearing party is the sole owner of the total shares issued of «DCIT Group S.à r.l.» (the «Company»), having
its registered office in L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur, a “société à responsabilité limitée” incorporated under the
name of "BLUE BRIDGE S.à r.l." following a deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, dated October 11
th
, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 3209 of December 17
th
, 2013, the Articles of Incorporation of which have been amended by a deed of Maître
Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated March 31
st
, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 1897 of July 21
st
, 2014;
- the Company is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 181351;
- the appearing party has become the sole shareholder by virtue of a transfer of shares dated May 27
th
, 2015, registered
with the «Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg» on July 27
th
, 2015, and published in the said Mémorial
C number 2480, on September 12
th
, 2015;
II.- the Company has an issued and paid up share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), repre-
sented by twelve thousand five hundred euro (12,500.-) shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each;
III.- the appearing party herewith expressly declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect
as the business activity of the Company has ceased and to act as liquidator of the Company;
IV.- the appearing party declares having full knowledge of the bylaws of the Company and is perfectly aware of the
financial situation of the Company; as sole shareholder, the appearing party approves the intermediary accounts issued for
the tax authorities within the context of the present dissolution;
55142
L
U X E M B O U R G
V.- the appearing party, being sole owner of the shares and liquidator of the Company, hereby declares:
i. that all assets have been realised and/or that all assets are to become the property of the sole shareholder;
ii. that all liabilities towards third parties known to the Company shall be taken over by the Shareholder and/or that all
liabilities towards third parties actually known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
iii. regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and outstanding today, that it will irrevocably
assume the obligation to pay for such liabilities, with the result that the liquidation of the Company is to be considered
closed;
iv. that full discharge is granted to the manager of the Company for the exercise of his mandate;
v. that the corporate books and accounts of the Company shall be kept during a period of five years at the offices of the
dissolved company.
However, the Company's assets shall not be mixed with the assets of nor attributed to the capital of the sole shareholder
before the expiry of 30 days from the date of publication of the present deed (article 69(2) of the law on commercial
companies) and provided that during this period no person declares himself as creditor of and demands payment of any
outstanding debt due from the Company hereby dissolved.
<i>Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated
at EUR 1,260.-.
Whereof, the present deed is drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French Text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, said person signed together with us, the
Notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil quinze, le trente décembre.
Pardevant Maître Martine DECKER notaire de résidence à Hesperange,
A comparu:
- Daniels Capital Investment GmbH, une société de droit suisse, ayant son siège social au Bahnhofstrasse 42, CH-6160
Entlebuch, inscrite au registre de commerce du canton de Lucerne, Suisse, sous le numéro CHE-150.966.336.
ici représentée par Madame Géraldine Nucera, employée, demeurant professionnellement à Hesperange,
en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée le 23 décembre 2015,
laquelle procuration, paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes
pour les besoins de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I.- la comparante est l'unique propriétaire de la totalité des parts sociales de «DCIT Group S.à r.l.» (la «Société»), ayant
son siège social à L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur, une société à responsabilité limitée constituée sous la déno-
mination de «BLUE BRIDGE S.à r.l.», suivant acte reçu par Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 11 octobre 2013, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 3209 du 17 décembre
2013, dont les statuts ont été modifiés une unique fois suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 31 mars 2014, publié audit Mémorial C, numéro 1897 du 21 juillet 2014,
- la Société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181351;
- la comparante est devenue l'unique associée suivant une cession de parts sociales sous seing privé en date du 27 mai
2015, laquelle cession de parts a été déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 27 juillet 2015
et publiée audit Mémorial C numéro 2480, du 12 septembre 2015;
II.- la Société a un capital social entièrement souscrit et libéré de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté
par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune;
III.- la comparante prononce présentement la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat, comme l'activité
de la Société a cessé et d'agir en tant que liquidateur de la Société;
IV.- la comparante déclare avoir pleinement connaissance des statuts de la Société et connaître la situation financière
de la Société; elle approuve à titre d'associé unique les comptes intérimaires préparés pour l'administration fiscale dans le
cadre de la dissolution;
V.- la comparante agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société qu'en tant qu'associée unique, déclare:
i. que tous les actifs ont été réalisés et/ou que tous les actifs à devenir la propriété de l'associée unique;
ii. que tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été pris en charge par l'associée unique et/ou que tous
les passifs actuellement connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
55143
L
U X E M B O U R G
iii. par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la Société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-
vocablement l'obligation de les payer, de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée;
iv. que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société, pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
v. que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années à l'adresse du siège social
de la Société dissoute.
Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de ou remboursement à, l'associée
unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de
la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution
de sûretés.
<i>Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du
présent acte sont évalués à environ EUR 1.260,-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par nom et prénom, état et
demeure, elle a signé ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: G. Nucera, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 05 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/131. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 29 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058607/117.
(160019545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Dirbach Plage Immobilier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9153 Dirbach, Dirbach-Plage.
R.C.S. Luxembourg B 107.890.
L'an deux mille quinze, le dix décembre
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) Monsieur Henri Carel Sigismund WARENDORF, traducteur, né à Amsterdam (Pays-Bas) le 18 mai 1934, demeurant
à 1071SL Amsterdam (Pays-Bas), 23HS Heinzestraat,
ici représenté par Monsieur Ferdinand RAMMELT, au moyen d'une procuration sous seing privé délivrée le 8 décembre
2015 à Amsterdam (Pays-Bas),
2) Monsieur Ferdinand Godefridus Maria RAMMELT, consultant, né à Amsterdam (Pays-Bas) le 17 décembre 1943,
demeurant à L-9153 Dirbach-Plage,
3) La société de droit de l'île de Jersey «EQ Trust (Jersey) Limited», P.O. Box 546, 28-30 The Parade, St. Helier, Jersey
JE4 8XY, Channel Islands, agissant en sa qualité de «trustee» du trust de droit de l'île de Jersey «The FortWarren Trust»,
constituée aux termes d'un document dit «Deed of Settlement» du 21 avril 1994, établi auprès d'elle,
ici représentée par Monsieur Ferdinand RAMMELT, préqualifié, au moyen d'une procuration sous seing privé délivrée
le 10 novembre 2015 à Jersey Channel Islands,
4) Madame Aukje Joanna RAMMELT, artiste-peintre, née à Asperen (Pays-Bas) le 2 avril 1972, demeurant à Nieuwe
Zuiderlingedijk 8,4147BE Asperen, Pays-Bas,
ici représentée par Monsieur Ferdinand RAMMELT, préqualifié, au moyen d'une procuration sous seing privé délivrée
le 9 décembre à Amsterdam (Pays-Bas),
5) Monsieur Crelis Ferdinand RAMMELT, chargé de cours, né à Strasbourg (France) le 11 mai 1974, demeurant à NL-
Amsterdam, Wenslauerstraat 68,
ici représenté par Monsieur Ferdinand RAMMELT, préqualifié, au moyen d'une procuration sous seing privé délivrée
le 8 décembre 2015 à Amsterdam (Pays-Bas),
55144
L
U X E M B O U R G
6) Monsieur Anton Frants RAMMELT, étudiant, né à Strasbourg (France) le 11 février 1984, demeurant à NL-1016
KT Amsterdam (Pays-Bas), Lijnbaansgracht 103, ici représenté par Monsieur Ferdinand RAMMELT, préqualifié, au
moyen d'une procuration sous seing privé délivrée le 9 décembre 2015 à Amsterdam (Pays-Bas).
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées «Ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte, pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
1.- Que les comparants sub 2) à 6) sont les actuels associés de la société à responsabilité limitée «DIRBACH PLAGE
IMMOBILIER S.à.r.l.», avec le siège social à L-9153 Dirbach-Plage, constituée suivant un acte notarié en date du 9 mai
2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1018, du 11 octobre 2005; les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 10 décembre 2015, en cours de publication auprès du Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
Que le capital social de ladite société est fixé à QUARANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 42.500,00),
représenté par quatre cent vingt-cinq (425) parts sociales, d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,00) chacune.
2.- Cession de parts:
La société de droit de l'île de Jersey «EQ Trust (Jersey) Limited», P.O. Box 546, 28-30 The Parade, St. Helier, Jersey
JE4 8XY, Channel Islands, agissant en sa qualité de «trustee» du trust de droit de l'île de Jersey «The FortWarren Trust»
représentée comme dit-est, déclare par la suite et par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de fait et
de droit, avec effet à la date de ce jour, à Monsieur Henri WARENDORF, ici représenté et ce acceptant, DEUX CENT
TRENTE-QUATRE (234) parts sociales de la société.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre.
Les modalités des prédites cessions de parts et les prix ont fait l'objet de conventions séparées entre les parties
Le cessionnaire est propriétaire des parts cédées à partir de ce jour.
En conséquence, le cédant met et subroge le cessionnaire dans tous ses droits et obligations attachés aux parts sociales
présentement cédées.
Ensuite, les associés Henri WARENDORF, Ferdinand RAMMELT, Aukje RAMMELT, Crelis RAMMELT et Anton
RAMMELT ont pris à l'unanimité, en se déclarant dûment convoqués et parfaitement informés de l'ordre du jour de la
présente assemblée générale extraordinaire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social de la société à concurrence de CINQ CENT CINQUANTE-SEPT
MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 557.500,00), pour le porter de son montant actuel de QUARANTE-DEUX MILLE
CINQ CENTS EUROS (EUR 42.500,00) à celui de SIX CENT MILLE EUROS (EUR 600.000,00), par la création de
CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE (5.575) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de CENT EU-
ROS (EUR 100,00) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Les associés, en déclarant au préalable renoncer à tout droit de préemption, constatent et acceptent la souscription des
prédites CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE (5.575) parts sociales nouvelles de la manière suivante:
- Le comparant sub 1), Monsieur Henri WARENDORF, lequel en vertu de ladite procuration du 8 décembre 2015,
déclare souscrire à TROIS MILLE SOIXANTE-SIX (3.066) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par la
conversion partielle en capital d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'associé à l'égard de la société, pour
un montant de TROIS CENT SIX MILLE SIX CENTS EUROS (EUR 306.600,00), tel que cela résulte d'un certificat établi
en date du 10 décembre 2015 par le gérant Ferdinand RAMMELT, lequel certificat, après avoir été paraphé «Ne varietur»
par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexé en original au présent acte, pour être soumis avec lui à la
formalité de l'enregistrement.
- Le comparant sub 2), Monsieur Ferdinand RAMMELT déclare souscrire à DEUX MILLE CENT QUATRE (2.104)
parts sociales nouvelles et les libérer entièrement par la conversion partielle en capital d'une créance certaine, liquide et
exigible détenue par l'associé à l'égard de la société, pour un montant de DEUX CENT DIX MILLE QUATRE CENTS
EUROS (EUR 210.400,00), tel que cela résulte d'un certificat établi en date du 10 décembre 2015 par le gérant Ferdinand
RAMMELT, lequel certificat, après avoir été paraphé «Ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentaire, restera
annexé en original au présent acte, pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement.
- Les comparants sub 5), 6) et 7), les consorts Aukje RAMMELT, Crelis RAMMELT et Anton RAMMELT déclarent
souscrire chacun à CENT TRENTE-CINQ (135) parts sociales nouvelles et les libérer entièrement par la conversion par-
tielle en capital de trois créances certaines, liquides et exigibles détenues chacune par les trois associés à l'égard de la
société, pour un montant de TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 13.500,00) chacune, tel que cela résulte d'un
certificat établi en date du 10 décembre 2015 par le gérant Ferdinand RAMMELT, lequel certificat, après avoir été parafé
«ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexé en original au présent acte, pour être soumis
avec lui à la formalité de l'enregistrement.
55145
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux cessions de parts et augmentations de capital ci-avant constatées, les associés décident de modifier l'article 6
des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à SIX CENT MILLE EUROS (EUR 600.000,00), représenté par SIX MILLE (6.000)
parts sociales de CENT EUROS (EUR 100,00) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
- Monsieur Henri WARENDORF, trois mille trois cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300
- Monsieur Ferdinand RAMMELT, deux mille deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250
- Madame Aukje RAMMELT, cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
- Monsieur Crelis RAMMELT, cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
- Monsieur Anton RAMMELT, cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
Total: six mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000
<i>Déclarationi>
Le gérant, Monsieur Ferdinand RAMMELT, préqualifié, déclare accepter lesdites cessions de parts au nom et pour
compte de la société et dispenser les cédants de les faire notifier à la société, le tout conformément à l'article 1690 du code
civil et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société en
raison des présents est évalué à environ deux mille vingt euros (EUR 2.020,00).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, qualités et adresses,
ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. RAMMELT, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 14 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/39717. Reçu soixante-quinze
euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2015.
Référence de publication: 2016058618/113.
(160018918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Douglas Private S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 157.393.
L'an deux mille seize, le vingt-et-un janvier.
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussignée,
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «DOUGLAS PRIVATE S.A. SPF», ayant son siège social à
L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 157.393, constituée suivant acte notarié suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de
résidence à Sanem, en date du 20 décembre 2013, publié au Mémorial C numéro 231 en date du 4 février 2011 (la «Société»).
La séance est ouverte sous la présidence de M. Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement
à Redange/Attert qui se désigne également comme secrétaire.
L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Re-
dange/Attert.
Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution et mise en liquidation la Société.
2. Nomination d'un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
55146
L
U X E M B O U R G
B) Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par la mandataire des actionnaires représentés, et à laquelle liste de
présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
C) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
D) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-
naires représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.
<i>Seconde résolutioni>
L'assemblée désigne Mayfair Trust S.à r.l., ayant son siège social au 2, Millewee, L-7257 Walferdange (RCS Luxem-
bourg B 112.769), comme liquidateur de la société.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la
loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation
est normalement requise.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Redange/Attert, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 25 janvier 2016. Relation: DAC/2016/1253. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carlo RODENBOUR.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 28 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058622/54.
(160018723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Eiffel Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.001,00.
Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.
R.C.S. Luxembourg B 202.891.
In the year two thousand and sixteen, on the fifteenth of January.
Before Maître Jacques CASTEL, notary, residing in Grevenmacher (Grand-Duchy of Luxembourg), acting as replace-
ment of Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg), absent, the last-mentioned
will remain the depositary of the present deed.
there appeared:
Halma Overseas Funding Limited, a company organised under the laws of England and Wales, with registered office
at Misbourne Court, Rectory Way, Amersham, Bucks HP7 0DE, United Kingdom, registered with the Companies House
under number 6503844,
hereby represented by Peggy Simon, employee, residing professionally in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a
power of attorney given under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
The appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Eiffel Lux S.à r.l., a private limited liability
company existing and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue
des Peupliers, L-2328 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
202.891,
55147
L
U X E M B O U R G
incorporated pursuant to a deed of Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, dated 28 December 2015, in the
process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Company”).
Article 200-2 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time
("Article 200-2") provides that a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the
general meeting and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
The Sole Shareholder, acting in its capacity of sole shareholder of the Company, represented as stated above, passes the
following written resolutions in accordance with Article 200-2 and requests the undersigned notary to record such resolu-
tions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one United States Dollar
(USD 1.-) in order to bring it from its current amount of twenty thousand United States dollars (USD 20,000.-), represented
by twenty thousand (20,000) shares having a nominal value of one United States Dollar (USD 1 each), to an amount of
twenty thousand and one United States Dollars (USD 20,001.-) by the creation and issue of one (1) new share of the
Company having a nominal value of one United States dollar (USD 1).
Therefore, the Sole Shareholder resolves to record the subscription and payment of an aggregate amount of two million
four hundred thousand United States Dollars (USD 2,400,000.-) and to allocate such an amount as provided below:
(i) one United States Dollar (USD 1.-) to the share capital account of the Company;
(ii) two million three hundred ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine United States Dollars (USD
2,399,999.-) to the share premium account of the Company.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder declares to:
(i) subscribe to one (1) share having a nominal value of one United States dollar (USD 1); and
(ii) pay up in full its new share by way of a contribution in an aggregate amount of two million four hundred thousand
United States Dollars (USD 2,400,000.-).
Evidence of the availability of the amount payable in cash for the newly issued share is submitted to the undersigned
notary who acknowledges expressly the availability of the funds so paid.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the
above resolutions, so that it shall read henceforth as follows:
" Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is set at twenty thousand and one United States Dollars (USD 20,001.-), represented
by twenty thousand and one (20,001) shares in registered form having a nominal value of one US Dollar (USD 1) each, all
subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles."
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
hereby empowers and authorises any manager of the Company, under his/her sole signature, on behalf of the Company, to
register the newly issued share in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request the same appearing party, in case
of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Grevenmacher, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le quinze janvier.
Par-devant Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en
remplacement de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel
dernier restera dépositaire du présent acte.
a comparu:
55148
L
U X E M B O U R G
Halma Overseas Funding Limited, une société constituée selon le droit de l'Angleterre et du pays de Galles, ayant son
siège social à Misbourne Court, Rectory Way, Amersham, Bucks HP7 0DE, Royaume Uni, enregistrée auprès de la Com-
panies House sous le numéro 6503844,
dûment représentée par Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en
vertu d'une procuration sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparant est l'associée unique (l' «Associé Unique») de la société Eiffel Lux S.à r.l., une société à responsabilité
limitée soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, rue des Peupliers, L-2328 Lu-
xembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202.891,
constituée suivant un acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 décembre 2015,
en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).
L'article 200-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (l’»Article
200-2») prévoit, dans le cadre d'une société à responsabilité limitée, qu’un associé unique exercera les pouvoirs attribués
à l'assemblée générale des associés et les décisions de l'associé unique seront inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
L'Associé Unique, agissant en sa capacité d'associé unique de la Société, représenté selon les modalités susmentionnées,
adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l'article 200-2 et demande au notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un Dollar US (1,- USD) afin de
porter le capital social de son montant actuel de vingt mille Dollars US (20.000,- USD), représenté par vingt mille (20.000)
parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar US (1 USD) chacune, à un montant de vingt mille et un Dollars US (20.001,-
USD) par la création et l'émission d'une (1,-) nouvelle part sociale ayant une valeur nominale d'un Dollar US (1 USD).
En conséquence, l'Associé Unique décide de prendre acte de la souscription et du paiement de la somme totale de deux
millions quatre cent mille Dollars US (2.400.000,- USD) et d'allouer cette somme comme suit:
(i) Un Dollar US (1,-) sur le compte capital social de la Société;
(ii) Deux millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars US (2.399.999,- USD)
au compte prime d'émission de la Société.
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
L'Associe Unique déclare:
(i) souscrire à une (1) part sociale ayant une valeur nominale d'un Dollar US (1 USD); et de
(ii) payer la part sociale nouvellement émise au moyen d'une contribution d'un montant de deux million quatre cent
mille Dollars US (2.400.000,- USD).
La preuve de la disponibilité des sommes en liquide pour la part sociale nouvellement émise est apportée au notaire
soussigné qui reconnaît expressément la disponibilité des sommes ainsi acquittés.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus, article
qui sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille et un Dollars US (20.001,- USD), représenté par vingt mille et
une (20.001) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un dollar US (USD 1) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par résolution des associés
adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter les modifications ci-
dessus et par la présente donne pouvoir et autorise tout gérant de la Société pour procéder, sous sa seule signature et au
nom de la Société, à l'enregistrement de la part sociale nouvellement émise dans le registre des parts sociales de la Société
et de procéder à toute formalité y afférente.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties
comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Grevenmacher, à la date indiquée en tête des présentes.
55149
L
U X E M B O U R G
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, état civil et
domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, Jacques CASTEL.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 22 janvier 2016. Relation: GAC/2016/595. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): N DIEDERICH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 29 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058623/137.
(160019285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Hong Kong Garden Capellen Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8310 Capellen, 1F, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 145.766.
DISSOLUTION
L'an deux mil quinze, le trente décembre.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1.- Monsieur Wenguang YIN, restaurateur, né à Hunan (Chine), le 10 mai 1955, et son épouse
2.- Madame Chonghua WANG, sans état, née à Zhejiang (Chine), le 4 juin 1954, demeurant ensemble à L-3237 Bet-
tembourg, 15, rue de la Gare.
ici représentés par Madame Babsi SINNES, employée,
demeurant professionnellement à Hesperange, en vertu d’une procuration sous seing privé délivrée à Bettembourg, le
18 décembre 2015,
laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire des comparants et le notaire instrumentant,
restera annexée aux présentes pour êtres enregistrée avec elles.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée «HONG KONG GARDEN CAPELLEN
SARL», établie et ayant son siège social à L-8310 Capellen, 1F, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 145.766 (ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire Maître
Frank MOLITOR, alors de résidence à Dudelange, en date du 2 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 929 du 4 mai 2009.
Que le capital social de la Société s'élève à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent vingt-quatre
(124) parts de cent (100,-) euros chacune.
Que les comparants sont les seuls et uniques associés représentant l’intégralité du capital social de la société «HONG
KONG GARDEN CAPELLEN SARL» en vertu des statuts de la société.
Les comparants, en tant que seuls associés, prononcent la dissolution anticipée de la société «HONG KONG GARDEN
CAPELLEN SARL» avec effet immédiat.
Ils déclarent avoir pleine connaissance des statuts de la Société et connaître parfaitement la situation financière de la
Société,
Que l'activité de la Société a cessé;
Que la Société ne possède pas d'immeuble ni de part(s) d'immeuble(s);
Tant en leur qualité de liquidateurs, que de seuls associés de la Société, ils déclarent que le passif connu de la Société
a été payé ou provisionné, que les associés sont investis de tout l'actif et qu’ils s'engagent expressément à prendre en charge
tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement
à leur personne; partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
Les associés donnent décharge pleine et entière au gérant unique pour l’exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
Les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans au domicile des comparants à L-3237 Bettembourg,
15, rue de la Gare.
Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la Société dissoute et l'avoir social de ou remboursement aux associés
ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la
publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution
de sûretés.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la Société.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu'en tête des présentes.
55150
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant par nom,
prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Sinnes, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 05 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/126. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 29 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058745/56.
(160019221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Santa Fe Relocation Services SA, Société Anonyme,
(anc. Interdean Daleiden S.A.).
Siège social: L-1899 Kockelscheuer, allée de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg B 45.447.
L’an deux mil seize, le dix-huit janvier,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
Ont comparu
pour une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de «INTERDEAN DALEIDEN S.A.» (la
Société), une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est fixé à L-1899 Kockelscheuer, allée de la
Poudrerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45.447,
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 20
octobre 1993, publié au Mémorial C numéro 598 du 16 décembre 1993 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois aux termes d’une assemblée générale extraordinaire actée par le notaire instrumentaire en date du 17 décembre 2014,
publiée au Mémorial C numéro 449 du 18 février 2015.
L’Assemblée est présidée par Monsieur Francis BINSFELD, comptable, demeurant professionnellement à Colmar-Berg,
qui désigne comme secrétaire Madame Manon HOFFMANN, employée privée, demeurant professionnellement à Capellen.
L’Assemblée choisit comme Scrutateur Madame Véronique GILSONBARATON, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à Capellen, (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur formant ensemble le Bureau).
Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions détenues
par les actionnaires sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur, restera annexée
aux présentes.
Monsieur le Président constate, et l’assemblée approuve, que toutes les actions émises de la société sont valablement
représentées, ainsi qu’il résulte de la liste de présence sus-mentionnée et que tous les actionnaires présents ou représentés
renoncent à toute convocation supplémentaire affirmant avoir connu à l’avance l’ordre du jour de la présente assemblée.
Ceci exposé, Monsieur le Président met au vote les résolutions suivantes, approuvées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en «Santa Fe Relocation Services SA».
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier en conséquence l’article 1
er
des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il a été formé une société anonyme sous la dénomination de «Santa Fe Relocation Services SA».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission des administrateurs de Messieurs Lars IVERSEN et Dale COLLINS.
L’assemblée accepte également la démission de l’administrateur délégué Dale COLLINS.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée nomme aux fonctions d’administrateur jusqu’à l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’année 2016:
Monsieur Neil BOTHAMS, administrateur de société, né à Hartlepool, Royaume Uni, le 16 mars 1973, demeurant
professionnellement à NW10 7XW Londres, Central Way, Park Royal London (sans numéro),
Et aux fonctions d’administrateur et d’administrateur délégué jusqu’à l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’année
2016:
Monsieur Christian Moller LAURSEN, administrateur de société, né à Kobenhavn, Danemark, le 18 avril 1966, de-
meurant à NW10 7XW Londres, Central Way, Park Royal London (sans numéro).
55151
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant des frais relatifs au présent acte est estimé à environ € 1.500,-
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Capellen.
Et, après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, les membres du Bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. BINSFELD, M. HOFFMANN, V. BARATON, C. MINES.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 20 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/1873. Reçu soixante-quinze euros
75,-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR COPIE CONFORME
Capellen, le 28 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058794/56.
(160019321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Tellus Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 72.540.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte d'un jugement rendu en date du 14.01.2016 par la VI
ème
Chambre du Tribunal d'Arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur
et le Ministère Public en leurs conclusions que les opérations de liquidation de la société anonyme TELLUS SOPARFI
S.A., ayant eu son siège social d'après ses statuts à L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange dénoncé en date du
01.02.2002, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.540 ont été déclarées
closes pour absence d'actif.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2016.
Maître Sébastien LIMAT
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016058321/18.
(160018152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Heirens Constructions S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7738 Colmar-Berg, Zone Industrielle, route de Cruchten.
R.C.S. Luxembourg B 102.858.
Statuts coordonnés suivant acte du 11 janvier 2016, reçu par Me Urbain THOLL, de résidence à Mersch, déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016058740/10.
(160018649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Horizont Immobilien S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 112.142.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058746/10.
(160019274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
55152
Betvest S.à r.l.
Blue Colibri Capital Partners Fund II SCA, SICAV-SIF
Bluehouse Accession Property Holdings III S.à r.l.
Borletti Group Management S.A.
Cegyco S.A.
Cienega Holding S.à.r.l./B.V.
Dakar Holdings S.C.A.
DCIT Group S.à r.l.
Dirbach Plage Immobilier S.à r.l.
Douglas Private S.A. SPF
Duke Investments & Participations S.A.
Eiffel Lux S.à r.l.
Energy T.I. Industrial S.à r.l.
Ensemble environnement / patrimoine écologique, culturel et artistique
Equifax Luxembourg (No. 7) S.à r.l.
Eudial Nature S.A.
European Healthcare Partners S.C.S.
Falcon Investment A.G.
GPB Credit Risk Management S.A.
Grace Luxembourg S.à r.l.
Granada S.A.
Griffon Capital S.A., SPF
HCP Health Care Products S.A.
Heirens Constructions S.àr.l.
Hong Kong Garden Capellen Sàrl
Horizont Immobilien S.A.
IB Management Services S.A.
Interdean Daleiden S.A.
ITSmart S.A. SPF
Javi Participations S.A.
J. & M. S.A.
John Deere Cash Management S.A.
Lakeside Corporation S.à r.l.
La Maison S.A.
Les Résidences d'Howald S.A.
Louriçal S.C.I.
Mastignac S.A.
Mastu Services S.à r.l.
Midnight Investments Partners SCSp
MOF III Investments S. à r.l.
Mohawk International Holdings S.à r.l.
Murci Group SARL
Negentropy SICAV-SIF
Novilog s.à.r.l.
Ricano S.à r.l.
Santa Fe Relocation Services SA
Tellus Soparfi S.A.
Thot SA