logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1144

18 avril 2016

SOMMAIRE

Aberdeen Property Investors (General Part-

ner) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54873

Alger Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54868

Altmunster Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

54873

ASF Rome Luxembourg 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . .

54896

ASF Rome Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

54896

Auto-Sport Shop s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54911

BAYVK C1-Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54867

Belgian European Agencies  . . . . . . . . . . . . . . .

54874

CCMG Navigator  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54870

Clayax Acquisition Luxembourg 2 S.à r.l.  . . .

54892

Clayax Acquisition Luxembourg 4 S.C.A.  . . .

54884

Clayax Acquisition Luxembourg 5 S.C.A.  . . .

54877

CME Gold & Silver Equity Fund  . . . . . . . . . .

54867

COF II HOLDING FUND LUX I SCS  . . . . . .

54898

Conventum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54869

Dentsply CE S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54894

Dentsply EU Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

54894

Duet Trust and Fiduciary Services S.A.  . . . . .

54887

Etik Supercar SC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54875

European Communication Group  . . . . . . . . . .

54875

Europe Investors & Finance S.A. . . . . . . . . . . .

54875

Exinter S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54875

FIL International Property S.à r.l.  . . . . . . . . .

54876

First Grana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54876

Fisconsult S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54876

FVCM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54867

GBM Asset Management SICAV  . . . . . . . . . .

54869

Grosvenor Americas S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

54876

GTF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54871

Jade Management Holding S.à r.l. . . . . . . . . . .

54880

Jade Portfolio 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54880

Jade Portfolio 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54880

Liquid Stressed Debt Fund  . . . . . . . . . . . . . . . .

54866

ME Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54867

Morgenstern Solid Performer  . . . . . . . . . . . . .

54866

Orbis Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54872

Partsexport Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54911

PATRIZIA Res Publica Hessen I TopCo S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54874

Phaidros Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54866

Pigranel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54874

Prosper Funds SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54871

responsAbility SICAV (Lux)  . . . . . . . . . . . . . .

54870

San Faustin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54867

Solo Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54873

Spie BondCo 3 S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54889

Tyman Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54899

Valauchanrus Sopaneer S.C.A.  . . . . . . . . . . . .

54872

VB Reserve Select  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54866

VERSO HOLDING LUX SCSp  . . . . . . . . . . . .

54912

WAC Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54866

Warburg Invest Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

54899

54865

L

U X E M B O U R G

Phaidros Funds, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Phaidros Funds modifié au 18. Mars 2016 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18. Mars 2016.

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Signature

Référence de publication: 2016080856/11.
(160046866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

Morgenstern Solid Performer, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Morgenstern Solid Performer modifié au 18. Mars 2016 a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18. Mars 2016.

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Signature

Référence de publication: 2016080857/11.
(160046867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

Liquid Stressed Debt Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Liquid Stressed Debt Fund modifié au 18. Mars 2016 a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18. Mars 2016.

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Signature

Référence de publication: 2016080858/11.
(160046868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

VB Reserve Select, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de VB Reserve Select modifié au 18. Mars 2016 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18. Mars 2016.

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Signature

Référence de publication: 2016080853/11.
(160046863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

WAC Fonds, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion modifié au 18. Mars 2016 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18. Mars 2016.

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Signature

Référence de publication: 2016080854/10.
(160046864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

54866

L

U X E M B O U R G

ME Fonds, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion modifié au 18. Mars 2016 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18. Mars 2016.

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Signature

Référence de publication: 2016080855/10.
(160046865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

FVCM, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion modifié au 18. Mars 2016 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18. Mars 2016.

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Signature

Référence de publication: 2016082060/10.
(160048996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

CME Gold & Silver Equity Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion modifié au 18. Mars 2016 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18. Mars 2016.

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Signature

Référence de publication: 2016082061/10.
(160048997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

BAYVK C1-Fonds, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds "BAVVK C1-Fonds" hat mit Wirkung zum 15. Dezember

2015 entschieden, den Fonds gemäß Artikel 15 des Verwaltungsreglements in Liquidation zu setzen. Das Liquidations-
verfahren wurde mit Wirkung zum 11. April 2016 nunmehr abgeschlossen. Die Bücher und Dokumente des Fonds werden
bei der Verwaltungsgesellschaft hinterlegt und für einen Zeitraum von fünf Jahren aufbewahrt.

Die Verwahrstelle hat die Liquidationserlöse vollständig unter den Anteilinhabern des Fonds nach deren Anspruch

verteilt. Eine Hinterlegung von nicht an die Anteilseigner zugeteilten Liquidationserlösen durch die Verwahrstelle bei der
Caisse de Consignation in Luxemburg musste nicht vorgenommen werden.

April 2016

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

<i>Der Liquidator

Référence de publication: 2016093015/13.

San Faustin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 158.593.

Notice is hereby given to the shareholders of San Faustin S.A (the "Company") that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders is to be held at the registered office of the Company at the 3rd floor of 3B Boulevard Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on <i>May 18th, 2016 , at 10:00 a.m. CET (the "Meeting"), to consider
the following agenda:

<i>Agenda:

1. Amendment of article 27 of the Company's articles of association in order to change the financial year of the Company

as from July 1st, 2016 to begin on the first (1st) of January of each year and to terminate on the thirty-first (31st) of

54867

L

U X E M B O U R G

December of the same year and to set, by exception, on December 31st, 2016 the closing date of the financial year
of the Company which will start on July 1st, 2016.

2. Amendment of article 22.1 of the Company's articles of association regarding the date and time of the annual general

meeting.

3. Amendment of article 23.3 of the Company's articles of association regarding the notices for ordinary and extraor-

dinary general meetings of the Company.

4. Amendment of articles 26.2 and 26.3 of the Company's articles of association regarding the timing of a second

shareholders meeting should a quorum not be reached in the first ordinary shareholders meeting and extraordinary
shareholders meeting.

5. Renewal of the authorization granted to the Board of Directors to proceed to the reconversion of Reconvertible

Ordinary  Shares  into  Preferred  Shares  within  the  limit  of  the  authorized  share  capital  until  May  1st,  2021  and
amendment of article 5.6.2 of the Company's articles of association.

The Meeting brochure (that contains the proposals of the Board of Directors for the resolutions to be adopted by the

Meeting  and  the  instructions  to  participate  in  such  Meeting)  is  available  for  the  inspection  of  the  shareholders  at  the
registered  office  of  the  Company.  An  electronic  copy  of  the  Meeting  brochure  will  be  sent  by  electronic  mail  to  the
shareholder's e-mailbox informed to the Company.

Holders of Ordinary Shares, Reconvertible Ordinary Shares and Preferred Shares may attend the Meeting and shall have

the right to vote on the items on the agenda of the Meeting.

Any holder of one or more shares as of May 13th, 2016, being the shareholders meetings record date (the "Record Date")

is entitled to attend the Meeting. She/He may attend the Meeting: (a) personally, in such case, she/he has to request an
admission ticket (hereinafter referred to as the "Admission Ticket") on or before May 13th, 2016. The shareholder can
participate personally or through an attorney-in-fact, appointed on the same Admission Ticket (the Admission Ticket must
be presented and delivered at the Meeting); or (b) may cast their vote by mail by means of a written voting form provided
by the Company (hereinafter referred to as the "Voting Form").

Admission Ticket Request forms and Voting Forms can be requested by any shareholder to "assistance@sanfaustin.lu".
Holders of shares acting through banks, fiduciary companies or issuers of depositary receipts must coordinate with their

banks, fiduciary companies or issuers of depositary receipts the voting instructions for their shares or the Admission Ticket
request  corresponding  to  their  Company's  shares  indirectly  held  through  said  banks,  fiduciary  companies  or  common
depositors.

PLEASE NOTE THAT SEPARATE ADMISSION TICKET REQUEST AND/OR VOTING FORM SHALL BE RE-

QUIRED TO PARTICIPATE IN THE MEETING.

No transfer of shares will be entered in the Share Register from May 11th, 2016, as provided in art 9.5 of the Articles

of Association, in order to avoid the possibility of the attendance to the Meeting by someone that has sold its shares after
the Record Date. Any transfer of shares requested to be entered in the Share Register in the week prior to date of the Meeting
will be recorded on the first business day after the Meeting i.e. on May 19th, 2016.

Luxembourg, March 31st, 2016.

Fernando R. Mantilla

<i>Secretary of the Board of Directors

Référence de publication: 2016090486/51.

Alger Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 55.679.

We have the pleasure of inviting you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Annual Meeting") of Alger SICAV (the "Company"), which will be held on <i>29 April 2016 at 3.00

p.m. at the registered office of the Company at 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation of the directors' report to the shareholders and the independent auditor's report of the Company for the

fiscal year ended 31 December 2015;

2. Approval of the statement of net assets and the statement of operations of the Company for the fiscal year ended 31

December 2015 and of the allocation of results;

3. Discharge to be granted to the directors of the Company with respect to the performance of their duties for the fiscal

year ended 31 December 2015;

4. Re-election of the directors of the Company until the next annual general meeting to be held in 2017;
5. Re-appointment of the independent auditor of the Company until the next annual general meeting to be held in 2017;
6. Approval of directors' fees;
7. Any other business which may be properly brought before the Annual Meeting.

54868

L

U X E M B O U R G

Only shareholders on record at the close of business on 27 April 2016 are entitled to vote at the Annual Meeting and at

any adjournments thereof.

Shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that decisions will be taken if

approved by a simple majority of the votes cast at the Annual Meeting. Each whole share is entitled to one vote.

The annual accounts, including the balance sheet and profit and loss account, the directors' report and the auditor's report

of the Company are available at the registered office of the Company and may be obtained upon request.

Shareholders who will not be able to attend the Annual Meeting may vote by proxy by returning the enclosed proxy

form, which is also available at the registered office of the Company, duly completed, dated and signed, by fax to the
following number: (+352) 46 40 10 413 (to the attention of Solveig Giovanardi / Domiciliary Department) before 12 o'clock
CET (noon) on 27 April 2016 and subsequently by mail to State Street Bank Luxembourg S.C.A., C/o Solveig Giovanardi /
Domiciliary Department, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2016089900/755/33.

GBM Asset Management SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 162.043.

The Board of Directors is pleased to convene the shareholders of GBM Asset Management to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders which will be held at the registered office of the SICAV on <i>6 May 2016 at 10.00 am with the following

agenda (the "Meeting"):

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the approved statutory auditor
2. Approval of the annual accounts as at 31 December 2015
3. Allocation of results
4. Discharge to the directors
5. Appointment of the approved statutory auditor
6. Statutory elections

The shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken by a simple majority of the

votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV.

Shareholders, who wish to attend the Meeting are requested to inform the Board of Directors (ifs.fds@bdl.lu) at least

five calendar days prior to the Meeting.

Référence de publication: 2016093016/755/21.

Conventum, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 70.125.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 mai 2016 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, jusqu'à

l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2016

6. Nominations statutaires : renouvellement du mandat de Antoine Calvisi, Président, Fernand Reiners, Administrateur,

et Nico Thill, Administrateur, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de
l'exercice se clôturant le 31 décembre 2016.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,

pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procurations
sont disponibles au siège social de la SICAV. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à

54869

L

U X E M B O U R G

condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (ifs.fds@bdl.lu) de
leur intention d'assister à l'Assemblée.

Référence de publication: 2016093017/755/24.

CCMG Navigator, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 185.478.

As the Extraordinary General Meeting of the Company held on 31 March 2016 could not deliberate on the agenda for

the lack of quorum, shareholders are invited to assist to a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders which will be held on <i>18 May 2016 at 02:30 p.m. before the notary Maître Henri Hellinckx, 101 r. Cents,

1319 Luxembourg, with the same agenda:

<i>Agenda:

1. Resolution on the liquidation of the Sub-fund and of the Company;
2. Discharge (quitus) to the members of the board of directors for the execution of their mandates;
3. Appointment of Alceda Fund Management S.A., represented by Ms. Désirée Eklund, with professional address at

5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg as sole liquidator of the Fund;

4. Appointment of an independent liquidation auditor;
5. Miscellaneous.

Shareholders may request the Articles of Incorporation in track changes at the registered office of the Company in order

to obtain more detailed information on the changes.

For the second Extraordinary General Meeting ("the Meeting"), no attendance quorum is necessary and resolutions on

the agenda of the Meeting may be passed by qualified majority of two-thirds of the votes cast present or represented.

Record date for the purpose of determining shareholders entitled to vote shall be five days prior to the Meeting according

to article 26 (4) of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment ("the record date").

In order to participate to this meeting, shareholders are requested to send a confirmation of their deposit specifying the

number  of  shares  held,  including  confirmation  that  the  shares  are  blocked  until  the  day  after  the  Meeting,  by  email
(corporate@alceda.lu) followed by mail or by fax (+352 248 329 442) to the Board of Directors of the Company or to the
Management Company, Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, to be received no later than
24 hours before the time fixed for the Meeting.

Shareholders, who cannot attend the Meeting in person, are invited to send a duly completed and signed proxy form

additionally to the aforementioned documents to the address named above.

Proxies can be obtained from the Board of Directors or the Management Company Alceda Fund Management S.A., 5,

Heienhaff, L-1736 Senningerberg (corporate@alceda.lu).

Luxembourg, April 2016

<i>The board of directors

Référence de publication: 2016093018/34.

responsAbility SICAV (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 121.154.

We are pleased to invite the shareholders to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders (the "OGM") which will be held at the registered office of the Company, 23, avenue de la Liberté, L-1931

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on Wednesday, <i>27 April 2016 at 3.00 p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the report of the board of directors to the OGM
2. Approval of the report of the authorized independent auditor
3. Approval of the financial statements as at 31 December 2015
4. Allocation of the net results
5. Discharge to the board of directors
6. Appointment of the board of directors
7. Appointment of the authorized independent auditor

Resolutions on the agenda may be passed without quorum, by a simple majority of the shares present or represented at

the meeting.

54870

L

U X E M B O U R G

In case you should wish to attend the OGM personally, you are kindly invited to inform responsability Management

Company  S.A.  7  calendar  days  prior  to  the  OGM,  either  by  fax  at  +352  24  83  89  61  or  by  e-mail  at
luxembourg@responsability.com.

In order to attend the meeting, shareholders are required to block their shares at the depositary at least 3 calendar days

prior to the meeting and to provide the registered office of the Company with the related certificate, stating that these shares
remain blocked until the end of the OGM.

Shareholders who cannot attend personally the meeting may vote by proxy forms which are available at the registered

office of the Company. In order to be taken in consideration, the proxies duly completed and signed shall be returned to
responsAbility Management Company (address: 23, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg) at the latest by 3 calendar days prior to the OGM, either by fax or by e-mail, with the original to follow by post
to the registered office of the Company.

Each share of whatever class and regardless of the net asset value per share within its class held on the day of the OGM,

is entitled to one vote, subject to limitations imposed by law. Shareholders holding only share fractions are not entitled to
vote on the items on the agenda.

Shareholders are hereby informed that the report of the authorized independent auditor, the report of the board of directors

and the latest annual accounts may be obtained upon request, free of charge, at the registered office of the Company.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2016089894/37.

GTF, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 181.900.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>27 avril 2016 à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre

du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2015
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité

simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social de

la société.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016089214/755/23.

Prosper Funds SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 150.045.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>27 avril 2016 à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre

du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2015
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires

54871

L

U X E M B O U R G

7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité

simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social de

la société.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016089217/755/23.

Valauchanrus Sopaneer S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 140.847.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>27 avril 2016 à 11.00 heures au siège social afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Démission de la société AUMARCHE, de ses fonctions d'actionnaire commandité et de gérant commandité
2. Confirmation de la société SOPANEER B.V. comme actionnaire commandité et gérant commandité
3. Modification subséquente de l'article 1 des statuts :
4. Refonte des statuts sans modification de l'objet social ;
5. Divers.

Les projets de statuts sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social.

<i>Les gérants commandités

Référence de publication: 2016089901/795/17.

Orbis Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 90.049.

The

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ORBIS SICAV and Class meetings of the shareholders of each of its Funds will be held at the

Company's  registered  office  at  31,  Z.A.  Bourmicht,  L-8070  Bertrange,  Luxembourg  at  3:00  p.m.  on  Monday  <i>2  May
2016 for the purpose of considering and voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. Review of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2015.
3. Discharge to the Directors in respect of the proper performance of their duties during the year ended 31 December

2015.

4. Re-election of Messrs William B. Gray, John C.R. Collis, Claude Kremer, Austin J. O'Connor and David T. Smith

as Directors of the Company.

5. Re-appointment of the Auditor.
6. Approval of Directors' fees.
7. Miscellaneous.

<i>Class Meetings Agenda:

To approve and ratify the Directors' dividend recommendation for the Orbis SICAV Global Equity, Japan Equity, Japan

Core Equity, Asia ex-Japan Equity, Europe Equity, Global Balanced and International Equity Funds.

<i>Voting:

Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken as at the majority

of the votes expressed by the shareholders present or represented at each meeting. Separate votes will be held for the
shareholders of each Fund on the Directors' dividend proposal for the Fund.

<i>Voting Arrangements:

Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to

the registered office of the Company to arrive no later than 3:00 p.m. (Luxembourg time) on 22 April 2016. Proxies may
be sent by post or courier to 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg and may also be faxed to +352 45 14 14

54872

L

U X E M B O U R G

439 Attention: Carole Beninger. Proxy forms will be sent to registered shareholders with a copy of this notice and can also
be obtained from the registered office.

<i>Other:

For investors in the Orbis SICAV, we are forwarding a copy of the audited 2015 Abridged Financial Statements for

their Fund. The reports for the Orbis SICAV Global Equity, Japan Equity, Asia ex-Japan Equity, Global Balanced and
International Equity Funds are also available at www.orbis.com. Please navigate to Our Performance ? Fund Reports ?
Annual Statements. If you require a copy of the complete unabridged Annual Report of the Company, it is available upon
request and free of charge at the registered office of the Company.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2016086979/755/41.

Altmunster Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 107.260.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le <i>27 avril 2016 à 17.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2015.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016089902/534/16.

Solo Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.354.

Par résolution signée en date du 10.02.2016, l'associé a pris suivantes:
1. Nomination de Diana Darbinian, avec adresse professionnelle au 31, Rue du Château, 6961, Senningen, Luxembourg,

au mandate de gérant A, avec effet immédiate et pour une durée indéterminée

2. Nomination de Artem Khachatryan, avec adresse professionnelle au 31, Rue du Château, 6961, Senningen, Luxem-

bourg, au mandate de gérant B, avec effet immédiate et pour une durée indéterminée

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10.02.2016.

Référence de publication: 2016064806/14.
(160026638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Aberdeen Property Investors (General Partner) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35a, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 130.335.

EXTRAIT

A titre informatif, veuillez noter que les gérants de la Société, Mme Martha Alexaki et Mme Sarah Barely résident

désormais professionnellement au 35a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec date d'effet au 1 

er

 février

2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2016

Aberdeen Property Investors (General Partner) S.à r.l.

Référence de publication: 2016064947/14.
(160026915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

54873

L

U X E M B O U R G

PATRIZIA Res Publica Hessen I TopCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 181.331.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 4. Februar 2016.

Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notar

Référence de publication: 2016064735/14.
(160026396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Pigranel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 110.617.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2016.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2016064741/14.
(160026413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Belgian European Agencies, Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 22, rue des Tilleuls.

R.C.S. Luxembourg B 104.675.

<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 2016

Il résulte de l'AGE tenue ce 28 janvier 2016 ce qui suit:
1 ) Démission de son poste de d'Administrateur de Christine NTIMA KIZOLA Christine, domiciliée 63, Bodegemstraat

à B-1470 Ternat.

2) Démission de son poste de d'Administrateur de Belahouel KHEIRAT, domicilié 88, avenue Houzea à B-1180 Bru-

xelles.

3) Démission de son poste de d'Administrateur Délégué de Christine NTIMA KIZOLA Christine, domiciliée 63, Bo-

degemstraat à B-1470 Ternat.

4) Nomination au poste d'Administrateur de Monsieur Patrice ROMAN, domicilié 208, avenue Van Volxem à B-1190

Forest et ce pour une période indéterminée.

5) Nomination au poste d'Administrateur de Monsieur Alessandro FASCIANELLA, domicilié 4, Theresiawijk à B-1654

Huizingen et ce pour une période indéterminée.

6) Nomination au poste d'Administrateur-délégué de Monsieur Patrice ROMAN, domicilié 208, avenue Van Volxem à

B-1190 Forest et ce pour une période indéterminée avec pouvoir de signature exclusif.

7) Transfert du siège social du Route d'Arlon n°5 à L-8832 Rombach vers le 22, Rue des Tilleuls à L-8832 Rombach.

Belgian European Agencies SA.

Référence de publication: 2016065793/23.
(160028451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

54874

L

U X E M B O U R G

Exinter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3360 Leudelange, 4, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 71.904.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2016065939/10.
(160028192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

Europe Investors &amp; Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 73.628.

<i>Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 4 février 2016

1. Mme Chai Leng SEOW a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Mr. Steve STEPHAN, administrateur de sociétés, né à Sarreguemines (France) le 02 février 1976, demeurant pro-

fessionnellement à L-2453 Luxembourg, rue Eugène Ruppert 6 (Luxembourg), a été coopté comme administrateur jusqu'à
la prochaine assemblée générale statutaire de 2018, avec effet au 31 décembre 2015.

La ratification de sa cooptation aura lieu lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 12 février 2016.

Pour extrait sincère et conforme
EUROPE INVESTORS &amp; FINANCE S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016065929/17.
(160028409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

European Communication Group, Société Anonyme.

Siège social: L-5532 Remich, 6, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 98.988.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2016, que le mandat de L'administrateur

et administrateur délégué de Monsieur Christian Simon SCASSO, demeurant 13, Résidence du Pré au Bois, à F-92420
Vaucresson est prolongé pour une durée indéterminée.

Rémich, le 15 février 2016.

<i>Pour le conseil d'administration

Référence de publication: 2016065930/13.
(160028693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

Etik Supercar SC, Société Civile.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 30, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg E 5.197.

DISSOLUTION

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 05 février 2016

Ce jour, il a été décidé la dissolution de la Société Civile ETIK SUPERCAR SC avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le gérant

Référence de publication: 2016065926/12.
(160028258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

54875

L

U X E M B O U R G

First Grana S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 200.716.

<i>Extrait des résolutions du conseil d'administration du 11 février 2016

Maître Clive GODFREY, demeurant professionnellement au 8, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg a été nommé

comme dépositaire des certificats d'actions au porteur, en remplacement de la société GHA Avocats Sàrl.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un administrateur

Référence de publication: 2016065962/12.
(160028758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

FIL International Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 135.062.

<i>Résolution de l'actionnaire unique en date du 20 Janvier 2016

Il est
RESOLU d'accepter la démission de M. Simon Fisk en qualité de Gérant de FIL International Property S.à r.l. avec effet

au 1 

er

 Janvier 2016.

RESOLU de nommer M. Mark Takeuchi, ayant son adresse professionnelle à Master Samuelsgatan 20, 9TH FL, Box

7677, Stockholm, 103 95 Suède, en qualité de Gérant de FIL International Property S.à r.l. avec effet au 1 

er

 Janvier 2016.

Luxembourg, le 2 Février 2016.

<i>L'actionnaire unique

Référence de publication: 2016065958/15.
(160028068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

Fisconsult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 145.784.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 08/04/2015

Par la présente, l'assemblée générale extraordinaire décide d'acter avec effet immédiat et pour une durée de 6 années, le

renouvellement:

- Du mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Cédric de Caritat, né le 05/06/1979 à Charleroi (Belgique),

demeurant professionnellement à L-1630 Luxembourg, au 56, Rue Glesener,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016065963/15.
(160028174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

Grosvenor Americas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 157.509.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2016.

Référence de publication: 2016065997/10.
(160028222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

54876

L

U X E M B O U R G

Clayax Acquisition Luxembourg 5 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 161.838.

In the year two thousand and sixteen, on the seventh day of April,
Before the undersigned, Maître Léonie GRETHEN, Notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

acting instead and place of Maître Danielle KOLBACH, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxem-
bourg, temporarily unavailable, who will hold the present minutes,

Was held

a meeting of the shareholders of the Company as defined below; the meeting opened at 3.50 p.m.
The "Company" is Clayax Acquisition Luxembourg 5 S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite

par actions) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under number B 161.838, incorporated pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, then notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 28 June 2011 and whose articles of association (the "Articles")
have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 14 September 2011 (number 2156,
page 103455) (the "Mémorial C"). The Articles have been amended for the last time on 2 September 2011 pursuant to a
deed of the above mentioned notary, published in the Mémorial C dated 2 November 2011 (number 2661, page 127700).

1. Appointment of chairman, Secretary and scrutineer. Mr Mustafa Nezar, lawyer, whose professional address is in

Luxembourg, acted as chairman of the meeting with the consent of the meeting.

The chairman appointed to act as secretary and the meeting elected to act as scrutineer Mrs Barbara Schmitt, employee,

residing professionally in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg

2. Declaration by chairman. These appointments having been made, the chairman declared that:
2.1 The names of the shareholders present at the meeting or represented at the meeting by proxies (together the "Ap-

pearing Shareholders") and the number of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list, signed
by or on behalf of the Appearing Shareholders, the Notary, the chairman, scrutineer and secretary, together with the proxy
forms, signed ne varietur by the shareholders represented at the meeting by proxyholders, the Notary and the chairman,
scrutineer and secretary, shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.

2.2 The attendance list shows that shareholders holding 307,942,801 shares representing the whole share capital of the

Company are present at the meeting or represented at the meeting by proxies. All the Appearing Shareholders have declared
that they have been sufficiently informed of the agenda of the meeting beforehand and have waived all convening requi-
rements and formalities. The meeting is therefore properly constituted and can validly consider all items of the agenda.

2.3 The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

2.3.1 Decrease of the issued share capital of the Company by an amount of three hundred and seven million nine hundred

and eleven thousand eight hundred and one euros (EUR 307,911,801.-) so as to bring it from its current amount of three
hundred and seven million nine hundred and forty-two thousand eight hundred and one euros (EUR 307,942,801.-) to
thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) by the cancellation of three hundred and seven million nine hundred and eleven
thousand eight hundred and one (307,911,801) limited shares each having a nominal value of one euro (EUR 1.-).

2.3.2 Decrease of the legal reserve fund.
2.3.3 Amendment of the article 5.1 of the Articles.
2.3.4 Miscellaneous.

<i>Resolutions

After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

<i>First resolution

The Appearing Shareholders decide to decrease the issued share capital of the Company by an amount of three hundred

and seven million nine hundred and eleven thousand eight hundred and one euros (EUR 307,911,801.-) so as to bring it
from its current amount of three hundred and seven million nine hundred and forty-two thousand eight hundred and one
euros (EUR 307,942,801.-) to thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) by the cancellation of three hundred and seven
million nine hundred and eleven thousand eight hundred and one (307,911,801) limited shares each having a nominal value
of one euro (EUR 1.-).

The Appearing Shareholders expressly waive their right to equal treatment in respect of the reduction of the issued share

capital of the Company.

54877

L

U X E M B O U R G

The reduced amount shall be entirely allocated to the Company's freely distributable reserve and shall be at the free

disposal of the Company's Appearing Shareholders or the general partner, as the case may be.

Reimbursement delay: The undersigned notary has drawn the attention of the Appearing Shareholders to the provisions

of article 69 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, establishing a legal
protection in favour of eventual creditors of the Company, the effective reimbursement to the relevant shareholder cannot
be made freely and without recourse from them before thirty (30) days after publication of the present deed in the Mémorial
C.

<i>Second resolution

Further to the above resolution, the Appearing Shareholders decide to decrease the legal reserve fund of the Company

by an amount of thirty-nine thousand seven hundred and forty-four euros and forty-one cents (EUR 39,744.41) so as to
bring  it  from  its  present  amount  of  forty-two  thousand  eight  hundred  and  forty-four  euros  and  forty-one  cents  (EUR
42,844.41) to three thousand one hundred euros (EUR 3,100.-).

The reduced amount shall be entirely allocated to the Company's freely distributable reserve and shall be at the free

disposal of the Company's Appearing Shareholders or the general partner, as the case may be.

<i>Third resolution

The Appearing Shareholders decide to amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the decision taken under the

first resolution, which shall now read as follows:

5. Share capital.
5.1 The subscribed share capital of the Company is fixed at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) divided into one

(1) share with a nominal value of one euro (EUR 1.-) ("Action de Commandité", the "Unlimited Share") held by the
unlimited shareholder and thirty thousand nine hundred and ninety-nine (30,999) shares with a nominal value of one euro
(EUR 1.-) ("Actions de Commanditaire", the "Limited Shares") held by the limited shareholder(s)."

3. Costs, Conclusion of meeting and notarial deed. The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever

which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately two thousand five
hundred euros (EUR 2,500.-).

Nothing else being on the agenda and nobody raising any further points for discussion by the meeting, the meeting

closed at 4.00 p.m..

The Notary, who understands and speaks English, states that the present deed is written in English, followed by a French

version, and that at the request of the Appearing Shareholders, in case of divergence between the English and the French
texts, the English version will prevail.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
This document having been read to the Appearing Shareholders (or, as appropriate, their proxyholders), who are known

to the Notary by their names, first names, civil status and residence, the Appearing Shareholders (or, as appropriate, their
proxyholders), the Notary, the chairman, the secretary and the scrutineer have together signed this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède introduction

L'an deux mille seize, le septième jour du mois d'avril.
Par-devant la soussignée Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

agissant en remplacement de Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de
Luxembourg, momentanément empêchée, laquelle sera dépositaire des présentes minutes,

S’est tenue

une assemblée des actionnaires de la Société ainsi que définie ci-dessous; l'assemblée s'est ouverte à 15:50.
La "Société" est Clayax Acquisition Luxembourg 5 S.C.A., une société en commandite par actions, constituée et existant

selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 161.838, constituée par un acte de Me Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 28 juin 2011 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations en date du 14 septembre 2011 (numéro 2156, page 103455) (le "Mémorial C"). Les Statuts ont
été modifiés pour la dernière fois en date du 2 septembre 2011 par un acte du notaire susmentionné, publié au Mémorial
C le 2 novembre 2011 (numéro 2661, page 127700).

1. Nomination des président, Secrétaire et scrutateur. Monsieur Mustafa Nezar, juriste, dont l'adresse professionnelle

est à Luxembourg, a agi en tant que président de l'assemblée avec l'accord de l'assemblée.

Le président a nommé pour agir en tant que secrétaire, et l'assemblée a élu pour agir en tant que scrutateur, Madame

Barbara Schmitt, salariée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Déclaration du président. Ces nominations ayant été effectuées, le président a déclaré que:

54878

L

U X E M B O U R G

2.1 Les noms des actionnaires présents et de ceux représentés à l'assemblée (ensemble définis comme les "Actionnaires

Comparants") et le nombre d'actions détenues par eux sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence,
signée par et au nom des Actionnaires Comparants, le Notaire, le président, le scrutateur et le secrétaire, ensemble avec les
formulaires de procuration, signés ne varietur par les actionnaires représentés à l'assemblée par des mandataires, le Notaire
et le président, le scrutateur et le secrétaire, devront rester annexés au présent acte et devront être enregistrés avec cet acte.

2.2 Il ressort de la liste de présence que les actionnaires détenant 307.942.801 actions représentant la totalité du capital

social de la Société sont présents à l'assemblée ou représentés à l'assemblée par des mandataires. Tous les Actionnaires
Comparants ont déclaré avoir été préalablement correctement informés de l'ordre du jour de l'assemblée et ont renoncé aux
formalités de convocation. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous
les points inscrits à l'ordre du jour.

2.3 L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

2.3.1 Réduction du capital social émis de la Société d'un montant de trois cent sept millions neuf cent onze mille huit

cent et un Euros (307.911.801,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trois cent sept millions neuf cent quarante-
deux mille huit cent et un Euros (307.942.801,- EUR) à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) par l'annulation de trois
cent sept millions neuf cent onze mille huit cent et un (307.911.801) actions de commanditaire ayant chacune une valeur
nominale d'un Euro (1,- EUR).

2.3.2 Réduction de la réserve légale.
2.3.3 Modification de l'article 5.1 des Statuts.
2.3.4 Divers.

<i>Résolutions

Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

<i>Première résolution

Les Actionnaires Comparants décident de réduire le capital social souscrit de la Société d'un montant de trois cent sept

millions neuf cent onze mille huit cent et un Euros (307.911.801,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trois
cent sept millions neuf cent quarante-deux mille huit cent et un Euros (307.942.801,- EUR) à trente et un mille Euros
(31.000,- EUR) par l'annulation de trois cent sept millions neuf cent onze mille huit cent et un (307.911.801) actions de
commanditaire ayant chacune une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR).

Les Actionnaires Comparants renoncent expressément à leur droit à un traitement égal pour ce qui est de la réduction

du capital social souscrit de la Société.

Le montant réduit sera entièrement alloué à la réserve distribuable de la Société et sera à la libre disposition des Ac-

tionnaires Comparants ou du gérant commandité de la Société, selon le cas.

Délai de remboursement: Le notaire instrumentant a attiré l'attention des Actionnaires Comparants sur les dispositions

de l'article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales établissant une protection légale en faveur des
créanciers éventuels de la Société, le remboursement effectif de l'actionnaire concerné ne peut pas être fait librement et
sans recours avant trente (30) jours suivant la publication du présent acte au Mémorial C.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution ci-dessus, les Actionnaires Comparants décident de réduire la réserve légale de la Société d'un

montant de trente-neuf mille sept cent quarante-quatre Euros et quarante et un centimes (39.744,41 EUR) afin de le porter
de son montant actuel de quarante-deux mille huit cent quarante-quatre Euros et quarante et un centimes (42.844,41 EUR)
à trois mille cent Euros (3.100,- EUR).

Le montant réduit sera entièrement alloué à la réserve distribuable de la Société et sera à la libre disposition des Ac-

tionnaires Comparants ou du gérant commandité de la Société, selon le cas.

<i>Troisième résolution

Les Actionnaires Comparants décident de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la décision prise dans la

première résolution, qui se lira désormais comme suit:

5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en une (1) action

d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) (l'"Action de Commandité") détenue par l'actionnaire commandité et trente
mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (30.999) actions d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) ("Actions de Comman-
ditaire") détenues par le/les actionnaire(s) commanditaire(s)."

<i>Frais, Conclusion de l'assemblée et acte notarié

Les frais, dépenses et rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

54879

L

U X E M B O U R G

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne n'ayant soulevé d'autres points pour discussion par l'assemblée, l'assemblée

est close à 16:00.

Le Notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version française,

et qu'à la demande des Actionnaires Comparants, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le jour mentionné en haut de ce document.
Ce document ayant été lu aux Actionnaires Comparants (ou, selon le cas à leurs mandataires), qui sont connus par le

Notaire par leurs noms de famille, prénoms, état civil et résidence, les Actionnaires Comparants (ou, selon le cas leurs
mandataires), le Notaire, le président, le secrétaire et le scrutateur ont ensemble signé cet acte.

Signé: M. NEZAR, B. SCHMITT, L. GRETHEN.
Enregistré à Diekirch A.C., le 08 avril 2016. Relation: DAC/2016/5315. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 12 avril 2016.

Référence de publication: 2016091206/178.
(160060510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.

Jade Management Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 116.859.

Jade Portfolio 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 131.455.

Jade Portfolio 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 131.441.

In the year two thousand sixteen, on the fourth of April.
Before Us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in repla-

cement  of  Maître  Jean-Joseph  WAGNER,  notary  residing  in  Sanem,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  who  will  remain
depositary of the present original deed..

There appeared:

1) JADE MANAGEMENT HOLDING S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the

law of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 116.859, incorporated pursuant a notarial deed, on
30 May 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1504 on 5 August 2006 and
whose articles of incorporation have been amended for the last time, pursuant to a notarial deed dated 14 November 2012,
published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on 16 January 2013 under the number 104,

here represented by Mr Anass BEZZARI, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of managers

of JADE MANAGEMENT HOLDING S.à r.l (the «Board of Managers 1»), pursuant to a resolution taken by the Board
of Managers 1 on 24 March 2016 (the «Resolution 1»); and

2) JADE PORTFOLIO 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the law of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 131.455, incorporated pursuant a notarial deed on 20 August 2007, pu-
blished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2280 on 11 October 2007, and whose articles of
incorporation have been amended for the last time on 14 November 2012, pursuant to notarial deed, published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on 16 January 2013 under the number 103,

here represented by Mr Anass BEZZARI, previously named, acting as the representative of the board of managers of

JADE PORTFOLIO 1 S.à r.l. (the «Board of Managers 2»), pursuant to a resolution taken by the Board of Managers 2 on
24 March 2016 (the «Resolution 2»); and

3) JADE PORTFOLIO 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the law of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 131.441, incorporated pursuant a notarial deed deed on 20 August 2007,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2274 on 11 October 2007, and whose articles
of incorporation have been amended for the last time on 14 November 2012, pursuant to a notarial deed, published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on 15 January 2013 under the number 89,

54880

L

U X E M B O U R G

here represented by Mr Anass BEZZARI, previously named, acting as the representative of the board of managers of

JADE PORTFOLIO 2 S.à r.l. (the «Board of Managers 3»), pursuant to a resolution taken by the Board of Managers 2 on
24 March 2016 (the «Resolution 3»).

Hereinafter, the Resolution 1, the Resolution 2, and the Resolution 3 are collectively referred to as the «Resolutions».
The said Resolutions, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have required the undersigned notary to record the

following:

1) Merging parties:
- JADE MANAGEMENT HOLDING S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the law

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 116.859, as acquiring company (hereinafter referred to
as «Absorbing Company»), and

- JADE PORTFOLIO 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the law of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 131.455, as absorbed company (hereinafter referred to as «Absorbed
Company 1»), and

- JADE PORTFOLIO 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the law of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 131.441, as absorbed company (hereinafter referred to as «Absorbed
Company 2»).

The Absorbed Company 1 and the Absorbed Company 2 are collectively referred to as «Absorbed Companies».
The Absorbing Company and the Absorbed Companies are collectively referred to as «Merging Companies».
2) The Absorbing Company holds eight hundred thousand and one (800,001) ordinary shares of the Absorbed Company

1, eighteen thousand and eighteen (18,018) class A shares and eighty two thousand and eighty two (82,082) class B shares
of the Absorbed Company 2, representing the entire share capital and all of the voting rights of the Absorbed Companies,
none of the Merging Companies having issued no other shares and/or securities giving voting rights.

3) The Absorbing Company proposes to absorb the Absorbed Companies by way of a merger by acquisition pursuant

to the provisions of articles 278 through 280 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the
«Law»).

4) As from 31 March 2016, all operations and transactions of the Absorbed Companies are considered for accounting

purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company.

5) As of the Effective Date (as defined below), all rights and obligations of the Absorbed Companies vis-à-vis third

parties shall be taken over by the Absorbing Company at book value. Such takeover is to be carried out in consideration
of the cancellation of the shares in the Absorbed Companies held by the Absorbing Company. The Absorbing Company
will in particular take over debts as own debts and all payment obligations of the Absorbed Companies. The rights and
claims comprised in the assets of the Absorbed Companies shall be transferred to the Absorbing Company with all securities,
either in rem or personal, attached thereto. The Absorbing Company shall from the Effective Date carry out all agreements
and obligations of whatever kind of the Absorbed Companies such as these agreements and obligations exist on the Effective
Date and in particular carry out all agreements existing with the creditors of the Absorbed Companies and shall be subro-
gated to all rights and obligations from such agreements.

6) No special rights or advantages have been granted to the managers of the Merging Companies.
7) All shareholders of the Absorbing Company have, within one month from the publication of this merger project in

the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, access at the registered office of the Absorbed Companies to all
documents listed in article 267 paragraph (1) a), b) and c) of the Law and may obtain copies thereof, free of charge.

8) One or more shareholders of the Absorbing Company holding at least 5% of the subscribed share capital of the

Absorbing Company may within the time period set out in 7) above request the convening of a shareholders’ meeting of
the Absorbing Company to decide whether to approve the proposed merger.

9) Full discharge is granted to the managers of the Absorbed Companies for the exercise of their mandate.
10) Subject to the rights of the shareholders of the Absorbing Company set out in 8) above, the dissolution of the

Absorbed Companies shall become effective and final one month after the publication of this merger project in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Effective Date») and will lead simultaneously to the effects set out in article
274 of the Law.

11) The Absorbing Company shall itself carry out all formalities, including such announcements as are prescribed by

law, which are necessary or useful to carry into effect the merger and the transfer and assignment of the assets and liabilities
of the Absorbed Companies to the Absorbing Company. Insofar as required by law or deemed necessary or useful, appro-
priate transfer instruments shall be executed by the Merging Companies to effect the transfer of the assets and liabilities
transferred by the Absorbed Companies to the Absorbing Company.

54881

L

U X E M B O U R G

12) The books and records of the Absorbed Companies will be held at the registered office of the Absorbing Company

for the period legally prescribed.

13) As a result of the merger, the Absorbed Companies shall cease to exist and all their issued shares shall be cancelled.
The undersigned notary public hereby certifies the existence and legality of the merger project and of all acts, documents

and formalities incumbent upon the merging parties pursuant to the Law.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the said the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille seize, le quatre avril.
Par-devant Nous Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant

en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, lequel
dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) JADE MANAGEMENT HOLDING S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois

du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.859, constituée suivant acte notarié en date du 30 mai
2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1504 le 5 août 2006 dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois, suivant acte notarié en date du 14 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, le 16 janvier 2013 numéro 104,

ici représentée par Monsieur Anass BEZZARI, résidant au Luxembourg, agissant en qualité de mandataire au nom et

pour compte du conseil de gérance de JADE MANAGEMENT HOLDING S.à r.l. (le «Conseil de Gérance 1»), en vertu
d’un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution prise par le Conseil de Gérance 1 le 24 mars 2016 (la «Résolution 1»);
et

2) JADE PORTFOLIO 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.455, constituée suivant acte notarié en date du 20 août 2007, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2280 du 11 octobre 2007, dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois, suivant acte notarié en date du 14 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, le 16 janvier 2013 numéro 103,

ici représentée par Monsieur Anass BEZZARI, prénommé, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte du

conseil de gérance de JADE PORTFOLIO 1 S.à r.l. (le «Conseil de Gérance 2»), en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré
par une résolution prise par le Conseil de Gérance 2 le 24 mars 2016 (la «Résolution 2»);

3) JADE PORTFOLIO 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.441, constituée suivant acte notarié en date du 20 août 2007, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2274 du 11 octobre 2007, dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois, suivant acte notarié en date du 14 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, le 15 janvier 2013 numéro 89,

ici représentée par Monsieur Anass BEZZARI, prénommé, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte du

conseil de gérance de JADE PORTFOLIO 1 S.à r.l. (le «Conseil de Gérance 3»), en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré
par une résolution prise par le Conseil de Gérance 3 le 24 mars 2016 (la «Résolution 3»);

Ci-après, la Résolution 1, la Résolution 2, et la Résolution 3 sont collectivement dénommées les «Résolutions».
Lesdites Résolutions, paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
1) Parties à la fusion:
- JADE MANAGEMENT HOLDING S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois

du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.859, comme société absorbante (la «Société Absor-
bante»); et

- JADE PORTFOLIO 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.455, comme société absorbée (la «Société Absorbée 1»); et

54882

L

U X E M B O U R G

- JADE PORTFOLIO 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.441, comme société absorbée (la «Société Absorbée 2»).

La Société Absorbée 1 et la Société Absorbée 2 sont collectivement dénommées les «Sociétés Absorbées».
La Société Absorbante et les Sociétés Absorbées sont collectivement dénommées les «Sociétés Fusionnantes».
2) La Société Absorbante détient huit cent mille une (800,001) parts sociales ordinaires dans la Société Absorbée 1, dix-

huit mille dix-huit (18,018) parts sociales de catégorie A et quatre-vingt-deux mille quatre vingt-deux (82,082) parts sociales
de catégorie B dans la Société Absorbée 2, représentant l’intégralité du capital social et tous les droits de vote dans les
Sociétés Absorbées, aucune des Sociétés Fusionnantes n’ayant émis aucun(e) autre action/titre conférant des droits de vote.

3) La Société Absorbante propose d’absorber les Sociétés Absorbées par voie de fusion par acquisition suivant les

dispositions des articles 278 à 280 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
«Loi»).

4) A partir du 31 mars 2016, toutes les opérations et les transactions des Société Absorbées sont considérées du point

de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

5) A partir de la Date de Réalisation (telle que définie ci-dessous), tous les droits et obligations des Sociétés Absorbées

vis-à-vis des tiers seront pris en charge par la Société Absorbante à la valeur comptable. Une telle fusion absorption doit
être réalisée en tenant compte de l’annulation des parts sociales des Sociétés Absorbées détenues par la Société Absorbante.
La Société Absorbante assumera en particulier toutes les dettes comme ses dettes propres et toutes les obligations de
paiement des Sociétés Absorbées. Les droits et créances des Sociétés Absorbées seront transférés à la Société Absorbante
avec l’intégralité des sûretés, soit in rem soit personnelles, y attachées. La Société Absorbante exécutera à partir de la Date
de Réalisation tous les contrats et obligations, de quelle que nature qu'ils soient, des Sociétés Absorbées tels que ces contrats
et obligations existent à la Date de Réalisation et exécutera en particulier tous les contrats existant avec les créanciers des
Société Absorbées et sera subrogée à tous les droits et obligations provenant de ces contrats.

6) Aucun droit ou avantage particulier n’a été attribué aux Gérants des Sociétés Fusionnantes.
7) Tous les associés de la Société Absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication de ce projet de

fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de prendre connaissance au siège social des Société Absorbées
de tous les documents énumérés à l’article 267, alinéa (1) a), b) et c) de la Loi et peuvent en obtenir copie intégrale, sans
frais.

8) Un ou plusieurs associés de la Société Absorbante disposant au moins de 5% du capital souscrit de la Société Ab-

sorbante a/ont le droit, pendant le délai indiqué sous le point 7) ci-dessus, de requérir la convocation d’une assemblée
générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion.

9) Décharge pleine et entière est accordée aux gérants des Sociétés Absorbées pour l’exercice de leur mandat.
10) Sous réserve des droits des associés de la Société Absorbante tels que décrits sous le point 8) ci-dessous, la dissolution

des Sociétés Absorbées deviendra effective et définitive un mois après la publication de ce projet de fusion dans le Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Date de Réalisation») et conduira simultanément aux effets tels que prévus
par l’article 274 de la Loi.

11) La Société Absorbante devra elle-même accomplir toutes les formalités, y compris les publications telles que prévues

par la loi, qui sont nécessaires ou utiles à l’entrée en vigueur de la fusion et au transfert et cession des actifs et passifs des
Société Absorbées à la Société Absorbante. Dans la mesure où la loi le prévoit, ou lorsque jugé nécessaire ou utile, des
actes de transfert appropriés seront exécutés par les Sociétés Fusionnantes afin de réaliser la transmission des actifs et
passifs de la Sociétés Absorbées à la Société Absorbante.

12) Les documents sociaux des Sociétés Absorbées seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant

la période prescrite par la loi.

13) Par effet de la fusion, les Sociétés Absorbées cesseront d’exister de plein droit et leurs actions émises seront annulées.
Le notaire soussigné déclare attester de l’existante et de la légalité du projet de fusion et de tous actes, documents et

formalités incombant aux parties à la fusion conformément à la Loi.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par la présente que sur demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des même comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire soussigné par nom, prénom

usuel, état et demeure, le mandataire des comparants a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. BEZZARI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 05 avril 2016. Relation: EAC/2016/8241. Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2016088983/212.
(160057199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.

54883

L

U X E M B O U R G

Clayax Acquisition Luxembourg 4 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 161.831.

In the year two thousand and sixteen, on the seventh day of April,
Before the undersigned, Maître Léonie GRETHEN, Notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

acting instead and place of Maître Danielle KOLBACH, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxem-
bourg, temporarily unavailable, who will hold the present minutes,

Was held

a meeting of the shareholders of the Company as defined below; the meeting opened at 3.40 p.m.
The "Company" is Clayax Acquisition Luxembourg 4 S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite

par actions) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under number B 161.831, incorporated pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, then notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 28 June 2011 and whose articles of association (the "Articles")
have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 14 September 2011 (number 2155,
page 103422) (the "Mémorial C"). The Articles have been amended for the last time on 2 September 2011 pursuant to a
deed of the above mentioned notary, published in the Mémorial C dated 2 November 2011 (number 2660, page 127647).

1. Appointment of chairman, Secretary and scrutineer. Mr Mustafa Nezar, lawyer, whose professional address is in

Luxembourg, acted as chairman of the meeting with the consent of the meeting.

The chairman appointed to act as secretary and the meeting elected to act as scrutineer Mrs Barbara Schmitt, employee,

residing professionally in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg

2. Declaration by chairman. These appointments having been made, the chairman declared that:
2.1 The names of the shareholders present at the meeting or represented at the meeting by proxies (together the "Ap-

pearing Shareholders") and the number of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list, signed
by or on behalf of the Appearing Shareholders, the Notary, the chairman, scrutineer and secretary, together with the proxy
forms, signed ne varietur by the shareholders represented at the meeting by proxyholders, the Notary and the chairman,
scrutineer and secretary, shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.

2.2 The attendance list shows that shareholders holding 308,187,001 shares representing the whole share capital of the

Company are present at the meeting or represented at the meeting by proxies. All the Appearing Shareholders have declared
that they have been sufficiently informed of the agenda of the meeting beforehand and have waived all convening requi-
rements and formalities. The meeting is therefore properly constituted and can validly consider all items of the agenda.

2.3 The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

2.3.1 Decrease of the issued share capital of the Company by an amount of three hundred and eight million one hundred

and fifty-six thousand and one euros (EUR 308,156,001.-) so as to bring it from its current amount of three hundred and
eight million one hundred and eighty-seven thousand and one euros (EUR 308,187,001.-) to thirty-one thousand euros
(EUR  31,000.-)  by  the  cancellation  of  three  hundred  and  eight  million  one  hundred  and  fifty-six  thousand  and  one
(308,156,001) limited shares each having a nominal value of one euro (EUR 1.-).

2.3.2 Amendment of the article 5.1 of the Articles.
2.3.3 Miscellaneous.

<i>Resolutions

After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

<i>First resolution

The Appearing Shareholders decide to decrease the issued share capital of the Company by an amount of three hundred

and eight million one hundred and fifty-six thousand and one euros (EUR 308,156,001.-) so as to bring it from its current
amount of three hundred and eight million one hundred and eighty-seven thousand and one euros (EUR 308,187,001.-) to
thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) by the cancellation of three hundred and eight million one hundred and fifty-six
thousand and one (308,156,001) limited shares each having a nominal value of one euro (EUR 1.-).

The Appearing Shareholders expressly waive their right to equal treatment in respect of the reduction of the issued share

capital of the Company.

The reduced amount shall be entirely allocated to the Company's freely distributable reserve and shall be at the free

disposal of the Company's Appearing Shareholders or the general partner, as the case may be.

54884

L

U X E M B O U R G

Reimbursement delay: The undersigned notary has drawn the attention of the Appearing Shareholders to the provisions

of article 69 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, establishing a legal
protection in favour of eventual creditors of the Company, the effective reimbursement to the relevant shareholder cannot
be made freely and without recourse from them before thirty (30) days after publication of the present deed in the Mémorial
C.

<i>Second resolution

The Appearing Shareholders decide to amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the decision taken under the

first resolution, which shall now read as follows:

5. Share capital.
5.1 The subscribed share capital of the Company is fixed at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) divided into one

(1) share with a nominal value of one euro (EUR 1.-) ("Action de Commandité", the "Unlimited Share") held by the
unlimited shareholder and thirty thousand nine hundred and ninety-nine (30,999) shares with a nominal value of one euro
(EUR 1.-) ("Actions de Commanditaire", the "Limited Shares") held by the limited shareholder(s)."

<i>Costs, Conclusion of meeting and notarial deed

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately two thousand five hundred euros (EUR 2,500.-).

Nothing else being on the agenda and nobody raising any further points for discussion by the meeting, the meeting

closed at 3:50 p.m..

The Notary, who understands and speaks English, states that the present deed is written in English, followed by a French

version, and that at the request of the Appearing Shareholders, in case of divergence between the English and the French
texts, the English version will prevail.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
This document having been read to the Appearing Shareholders (or, as appropriate, their proxyholders), who are known

to the Notary by their names, first names, civil status and residence, the Appearing Shareholders (or, as appropriate, their
proxyholders), the Notary, the chairman, the secretary and the scrutineer have together signed this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille seize, le septième jour du mois d'avril.
Par-devant la soussignée Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

agissant en remplacement de Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de
Luxembourg, momentanément empêchée, laquelle sera dépositaire des présentes minutes,

S’est tenue

une assemblée des actionnaires de la Société ainsi que définie ci-dessous; l'assemblée s'est ouverte à 15:40.
La "Société" est Clayax Acquisition Luxembourg 4 S.C.A., une société en commandite par actions, constituée et existant

selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 161.831, constituée par un acte de Me Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 28 juin 2011 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations en date du 14 septembre 2011 (numéro 2155, page 103422) (le "Mémorial C"). Les Statuts ont
été modifiés pour la dernière fois en date du 2 septembre 2011 par un acte du notaire susmentionné, publié au Mémorial
C le 2 novembre 2011 (numéro 2660, page 127647).

1. Nomination des président, Secrétaire et scrutateur. Monsieur Mustafa Nezar, juriste, dont l'adresse professionnelle

est à Luxembourg, a agi en tant que président de l'assemblée avec l'accord de l'assemblée.

Le président a nommé pour agir en tant que secrétaire, et l'assemblée a élu pour agir en tant que scrutateur, Madame

Barbara Schmitt, salariée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Déclaration du président. Ces nominations ayant été effectuées, le président a déclaré que:
2.1 Les noms des actionnaires présents et de ceux représentés à l'assemblée (ensemble définis comme les "Actionnaires

Comparants") et le nombre d'actions détenues par eux sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence,
signée par et au nom des Actionnaires Comparants, le Notaire, le président, le scrutateur et le secrétaire, ensemble avec les
formulaires de procuration, signés ne varietur par les actionnaires représentés à l'assemblée par des mandataires, le Notaire
et le président, le scrutateur et le secrétaire, devront rester annexés au présent acte et devront être enregistrés avec cet acte.

2.2 Il ressort de la liste de présence que les actionnaires détenant 308.187.001 actions représentant la totalité du capital

social de la Société sont présents à l'assemblée ou représentés à l'assemblée par des mandataires. Tous les Actionnaires
Comparants ont déclaré avoir été préalablement correctement informés de l'ordre du jour de l'assemblée et ont renoncé aux
formalités de convocation. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous
les points inscrits à l'ordre du jour.

54885

L

U X E M B O U R G

2.3 L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

2.3.1 Réduction du capital social émis de la Société d'un montant de trois cent huit millions cent cinquante-six mille et

un Euros (308.156.001,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trois cent huit millions cent quatre-vingt-sept
mille et un Euros (308.187.001,- EUR) à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) par l'annulation de trois cent huit millions
cent cinquante-six mille et une (308.156.001) actions de commanditaire ayant chacune une valeur nominale d'un Euro (1,-
EUR).

2.3.2 Modification de l'article 5.1 des Statuts.
2.3.3 Divers.

<i>Résolutions

Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

<i>Première résolution

Les Actionnaires Comparants décident de réduire le capital social souscrit de la Société d'un montant de trois cent huit

millions cent cinquante-six mille et un Euros (308.156.001,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trois cent huit
millions  cent  quatre-vingt-sept  mille  et  un  Euros  (308.187.001,-  EUR)  à  trente  et  un  mille  Euros  (31.000,-  EUR)  par
l'annulation de trois cent huit millions cent cinquante-six mille et une (308.156.001) actions de commanditaire ayant cha-
cune une valeur nominale d'un Euro (1,-EUR).

Les Actionnaires Comparants renoncent expressément à leur droit à un traitement égal pour ce qui est de la réduction

du capital social souscrit de la Société.

Le montant réduit sera entièrement alloué à la réserve distribuable de la Société et sera à la libre disposition des Ac-

tionnaires Comparants ou du gérant commandité de la Société, selon le cas.

Délai de remboursement: Le notaire instrumentant a attiré l'attention des Actionnaires Comparants sur les dispositions

de l'article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales établissant une protection légale en faveur des
créanciers éventuels de la Société, le remboursement effectif de l'actionnaire concerné ne peut pas être fait librement et
sans recours avant trente (30) jours suivant la publication du présent acte au Mémorial C.

<i>Deuxième résolution

Les Actionnaires Comparants décident de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la décision prise dans la

première résolution, qui se lira désormais comme suit:

5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en une (1) action

d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) (l'"Action de Commandité") détenue par l'actionnaire commandité et trente
mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf (30.999) actions d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) ("Actions de Comman-
ditaire") détenues par le/les actionnaire(s) commanditaire(s)."

<i>Frais, Conclusion de l'assemblée et acte notarié

Les frais, dépenses et rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne n'ayant soulevé d'autres points pour discussion par l'assemblée, l'assemblée

est close à 15:50.

Le Notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version française,

et qu'à la demande des Actionnaires Comparants, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le jour mentionné en haut de ce document.
Ce document ayant été lu aux Actionnaires Comparants (ou, selon le cas à leurs mandataires), qui sont connus par le

Notaire par leurs noms de famille, prénoms, état civil et résidence, les Actionnaires Comparants (ou, selon le cas leurs
mandataires), le Notaire, le président, le secrétaire et le scrutateur ont ensemble signé cet acte.

Signé: M. NEZAR, B. SCHMITT, L. GRETHEN.
Enregistré à Diekirch A.C., le 08 avril 2016. Relation: DAC/2016/5314. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Redange-sur-Attert, le 12 avril 2016.

Référence de publication: 2016091204/161.
(160060454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.

54886

L

U X E M B O U R G

Duet Trust and Fiduciary Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 89.325.

In the year two thousand and sixteen, on the thirteenth day of April.
Before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, at 7.45 pm.

THERE APPEARED

COLFIN GRAND-CUL-DE-SAC FUNDING S.À R.L., a Luxembourg limited liability company (société à responsa-

bilité  limitée)  having  its  registered  office  at  121,  avenue  de  la  Faïencerie,  L-1511  Luxembourg,  registered  with  the
Luxembourg trade and companies’ register under number B 179.985,

here represented by Mr. Pascal Leclerc, employee, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal dated on 13 April 2016.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Duet Trust and Fiduciary Services S.A., a

société anonyme incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 16A, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 89.325
(the “Company”), incorporated pursuant to a deed of Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, on 24 Sep-
tember 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 15 November 2002 under number 1641.
The articles of incorporation of the Company have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of
Maître Francis Kesseler, notary then residing in Esch-sur-Alzette, on 1 

st

 October 2013, published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations on 14 October 2013 under number 2862.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following sole resolution:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder decides to amend article 4 of the articles of association of the Company which shall henceforth

read as follows:

“ Art. 4. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members. However,

where it appears at a shareholders’ meeting that all the shares issued by the Company are held by a sole shareholder, the
Company may be managed by a sole director until the next general meeting of shareholders following the increase of the
number of shareholders. In such case, to the extent applicable and where the term “sole director” is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the “board” or the “board of directors” used in these articles of association is
to be construed as a reference to the “sole director”.

The term of office of a director may not exceed six (6) years and each director shall hold office until a successor is

appointed. Directors may be re-appointed for successive terms.

The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and

term of office.

Each director is appointed by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.
In  the  event  of  a  vacancy  in  the  office  of  a  director  because  of  death,  legal  incapacity,  bankruptcy,  resignation  or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced director by the remaining directors until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment in compliance with the applicable legal provisions.

In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole director, such vacancy must be filled without undue delay

by the general meeting of shareholders.

Any director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of shareholders at

a simple majority of the votes validly cast.

If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a private individual as permanent

representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only
remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a permanent
representative of one (1) director of the Company and may not be a director of the Company at the same time.”

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date first written above.

54887

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the representative of the appearing party, who is known to the notary by his surname,

name, civil status and residence, such representative signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le treizième jour du mois d’avril.
Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-duché de Luxembourg, à 19h45,

A comparu:

COLFIN GRAND-CUL-DE-SAC FUNDING S.À R.L., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, et immatriculée auprès du registre du commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179.985,

ici représentée par Monsieur Pascal Leclerc, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 13 avril 2016, à lui délivrée.
Laquelle procuration paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante est l’actionnaire unique (l’»Actionnaire Unique») de Duet Trust and Fiduciary Services

S.A., une société anonyme constituée et régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16A, avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du registre du commerce et des so-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 89.325 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations le 15 novembre 2002 sous le numéro 1641. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour
la dernière fois suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 1

er

 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 14 novembre 2013 sous le numéro 2862.

La partie comparante, représentant la totalité du capital social, a requis le notaire instrumentant d’acter la résolution

unique suivante:

<i>Résolution unique

L’Actionnaire Unique décide de modifier l’article 4 des statuts qui prendra désormais la teneur suivante:

« Art. 4. La Société est gérée par un conseil d’administration composé d’au moins trois (3) membres. Cependant, lorsqu'il

apparaît, lors d’une assemblée générale d’actionnaires, que toutes les actions émises par une Société sont détenues par un
actionnaire unique, la Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu'à la prochaine assemblée générale d’ac-
tionnaires  consécutive  à  l’augmentation  du  nombre  d’actionnaires.  Dans  cette  hypothèse,  le  cas  échéant  et  lorsque
l’expression «administrateur unique» n’est pas mentionnée expressément dans les présents statuts, une référence au «conseil
d’administration» utilisée dans les présents statuts doit être entendue comme une référence à l’ «administrateur unique».

La durée du mandat d’un administrateur ne peut excéder six (6) ans et chaque administrateur doit rester en fonction

jusqu'à ce qu'un successeur ait été désigné. Les administrateurs peuvent faire l’objet de réélections successives.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui détermine leur rémunération et la durée

de leur mandat.

Chaque administrateur est nommé à la majorité simple des voix valablement exprimées à une assemblée générale des

actionnaires.

Dans l’hypothèse où un poste d’administrateur deviendrait vacant suite au décès, à l’incapacité juridique, à la faillite, à

la retraite ou autre, cette vacance pourra être comblée à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder le mandat
initial de l’administrateur qui fait l’objet d’un remplacement par les administrateurs restants jusqu'à ce que la prochaine
assemblée générale d’actionnaires, appelée à statuer sur la nomination permanente d’un nouvel administrateur en confor-
mité avec les dispositions légales applicables.

Dans l’hypothèse où la vacance surviendrait alors que la Société est gérée que par un administrateur unique, cette vacance

devra être comblée sans délai par l’assemblée générale des actionnaires.

Chaque administrateur peut être révoqué de ses fonctions à tout moment et sans motif par l’assemblée générale des

actionnaires à la majorité simple voix valablement exprimées.

Si une personne morale est nommée en tant qu'administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner une

personne physique en qualité de représentant permanent qui doit assurer cette fonction au nom et pour le compte de la
personne morale. La personne morale peut révoquer son représentant permanent uniquement si elle nomme simultanément
son successeur. Une personne physique peut uniquement être le représentant permanent d’un seul (1) administrateur de la
Société et ne peut être simultanément administrateur de la Société».

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

54888

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par

nom, prénom, qualité et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Leclerc, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 14 avril 2016. GAC/2016/2977. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 14 avril 2016.

Référence de publication: 2016092563/120.
(160061960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.

Spie BondCo 3 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 161.836.

In the year two thousand and sixteen, on the seventh day of April,
Before the undersigned, Maître Léonie GRETHEN, Notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

acting instead and place of Maître Danielle KOLBACH, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxem-
bourg, temporarily unavailable, who will hold the present minutes,

Was held

a meeting of the shareholders of the Company as defined below; the meeting opened at 3.30 p.m.
The "Company" is Spie BondCo 3 S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite par actions) incor-

porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7A, rue Robert
Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 161.836, incorporated pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, then notary residing in Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 28 June 2011 and whose articles of association (the "Articles") have been
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 14 September 2011 (number 2155, page 103407)
(the "Mémorial C"). The Articles have been amended for the last time on 2 September 2011 pursuant to a deed of the above
mentioned notary, published in the Mémorial C dated 2 November 2011 (number 2661, page 127718).

1. Appointment of chairman, Secretary and scrutineer. Mr Mustafa Nezar, lawyer, whose professional address is in

Luxembourg, acted as chairman of the meeting with the consent of the meeting.

The chairman appointed to act as secretary and the meeting elected to act as scrutineer Mrs Barbara Schmitt, employee,

residing professionally in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg

2. Declaration by chairman. These appointments having been made, the chairman declared that:
2.1 The names of the shareholders present at the meeting or represented at the meeting by proxies (together the "Ap-

pearing Shareholders") and the number of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list, signed
by or on behalf of the Appearing Shareholders, the Notary, the chairman, scrutineer and secretary, together with the proxy
forms, signed ne varietur by the shareholders represented at the meeting by proxyholders, the Notary and the chairman,
scrutineer and secretary, shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.

2.2 The attendance list shows that shareholders holding 308,431,201 shares representing the whole share capital of the

Company are present at the meeting or represented at the meeting by proxies. All the Appearing Shareholders have declared
that they have been sufficiently informed of the agenda of the meeting beforehand and have waived all convening requi-
rements and formalities. The meeting is therefore properly constituted and can validly consider all items of the agenda.

2.3 The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

2.3.1 Decrease of the issued share capital of the Company by an amount of three hundred and eight million four hundred

thousand two hundred and one euros (EUR 308,400,201.-) so as to bring it from its current amount of three hundred and
eight million four hundred and thirty-one thousand two hundred and one euros (EUR 308,431,201.-) to thirty-one thousand
euros (EUR 31,000.-) by the cancellation of three hundred and eight million four hundred thousand two hundred and one
(308,400,201) limited shares each having a nominal value of one euro (EUR 1.-).

2.3.2 Amendment of the article 5.1 of the Articles.
2.3.3 Miscellaneous.

<i>Resolutions

After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

54889

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Appearing Shareholders decide to decrease the issued share capital of the Company by an amount of three hundred

and eight million four hundred thousand two hundred and one euros (EUR 308,400,201.-) so as to bring it from its current
amount  of  three  hundred  and  eight  million  four  hundred  and  thirty-one  thousand  two  hundred  and  one  euros  (EUR
308,431,201.-) to thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) by the cancellation of three hundred and eight million four
hundred thousand two hundred and one (308,400,201) limited shares each having a nominal value of one euro (EUR 1.-).

The Appearing Shareholders expressly waive their right to equal treatment in respect of the reduction of the issued share

capital of the Company.

The reduced amount shall be entirely allocated to the Company's freely distributable reserve and shall be at the free

disposal of the Company's Appearing Shareholders or the general partner, as the case may be.

Reimbursement delay: The undersigned notary has drawn the attention of the Appearing Shareholders to the provisions

of article 69 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, establishing a legal
protection in favour of eventual creditors of the Company, the effective reimbursement to the relevant shareholder cannot
be made freely and without recourse from them before thirty (30) days after publication of the present deed in the Mémorial
C.

<i>Second resolution

The Appearing Shareholders decide to amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the decision taken under the

first resolution, which shall now read as follows:

5. Share capital.
5.1 The subscribed share capital of the Company is fixed at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) divided into one

(1) share with a nominal value of one euro (EUR 1.-) ("Action de Commandité", the "Unlimited Share") held by the
unlimited shareholder and thirty thousand nine hundred and ninety-nine (30,999) shares with a nominal value of one euro
(EUR 1.-) ("Actions de Commanditaire", the "Limited Shares") held by the limited shareholder(s)."

<i>Costs, Conclusion of meeting and notarial deed

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately two thousand five hundred euros (EUR 2,500.-).

Nothing else being on the agenda and nobody raising any further points for discussion by the meeting, the meeting

closed at 3.40 p.m..

The Notary, who understands and speaks English, states that the present deed is written in English, followed by a French

version, and that at the request of the Appearing Shareholders, in case of divergence between the English and the French
texts, the English version will prevail.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
This document having been read to the Appearing Shareholders (or, as appropriate, their proxyholders), who are known

to the Notary by their names, first names, civil status and residence, the Appearing Shareholders (or, as appropriate, their
proxyholders), the Notary, the chairman, the secretary and the scrutineer have together signed this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille seize, le septième jour du mois d'avril.
Par-devant la soussignée Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

agissant en remplacement de Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de
Luxembourg, momentanément empêchée, laquelle sera dépositaire des présentes minutes,

S’est tenue

une assemblée des actionnaires de la Société ainsi que définie ci-dessous; l'assemblée s'est ouverte à 15:30.
La "Société" est Spie BondCo 3 S.C.A., une société en commandite par actions, constituée et existant selon les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.836,
constituée par un acte notarié de Me Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en date du 28 juin 2011 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations en date du 14 septembre 2011 (numéro 2155, page 103407) (le "Mémorial C"). Les Statuts ont été modifiés
pour la dernière fois en date du 2 septembre 2011 par un acte du notaire susmentionné, publié au Mémorial C le 2 novembre
2011 (numéro 2661, page 127718).

1. Nomination des président, Secrétaire et scrutateur. Monsieur Mustafa Nezar, juriste, dont l'adresse professionnelle

est à Luxembourg, a agi en tant que président de l'assemblée avec l'accord de l'assemblée.

Le président a nommé pour agir en tant que secrétaire, et l'assemblée a élu pour agir en tant que scrutateur, Madame

Barbara Schmitt, salariée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

54890

L

U X E M B O U R G

2. Déclaration du président. Ces nominations ayant été effectuées, le président a déclaré que:
2.1 Les noms des actionnaires présents et de ceux représentés à l'assemblée (ensemble définis comme les "Actionnaires

Comparants") et le nombre d'actions détenues par eux sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence,
signée par et au nom des Actionnaires Comparants, le Notaire, le président, le scrutateur et le secrétaire, ensemble avec les
formulaires de procuration, signés ne varietur par les actionnaires représentés à l'assemblée par des mandataires, le Notaire
et le président, le scrutateur et le secrétaire, devront rester annexés au présent acte et devront être enregistrés avec cet acte.

2.2 Il ressort de la liste de présence que les actionnaires détenant 308.431.201 actions représentant la totalité du capital

social de la Société sont présents à l'assemblée ou représentés à l'assemblée par des mandataires. Tous les Actionnaires
Comparants ont déclaré avoir été préalablement correctement informés de l'ordre du jour de l'assemblée et ont renoncé aux
formalités de convocation. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous
les points inscrits à l'ordre du jour.

2.3 L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

2.3.1 Réduction du capital social émis de la Société d'un montant de trois cent huit millions quatre cent mille deux cent

et un Euros (308.400.201,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trois cent huit millions quatre cent trente et un
mille deux cent et un Euros (308.431.201,- EUR) à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) par l'annulation de trois cent
huit millions quatre cent mille deux cent et une (308.400.201) actions de commanditaire ayant chacune une valeur nominale
d'un Euro (1,- EUR).

2.3.2 Modification de l'article 5.1 des Statuts.
2.3.3 Divers.

<i>Résolutions

Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

<i>Première résolution

Les Actionnaires Comparants décident de réduire le capital social souscrit de la Société d'un montant de trois cent huit

millions quatre cent mille deux cent et un Euros (308.400.201,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trois cent
huit millions quatre cent trente et un mille deux cent et un Euros (308.431.201,- EUR) à trente et un mille Euros (31.000,-
EUR) par l'annulation de trois cent huit millions quatre cent mille deux cent et une (308.400.201) actions de commanditaire
ayant chacune une valeur nominale d'un Euro (1,-EUR).

Les Actionnaires Comparants renoncent expressément à leur droit à un traitement égal pour ce qui est de la réduction

du capital social souscrit de la Société.

Le montant réduit sera entièrement alloué à la réserve distribuable de la Société et sera à la libre disposition des Ac-

tionnaires Comparants ou du gérant commandité de la Société, selon le cas.

Délai de remboursement: Le notaire instrumentant a attiré l'attention des Actionnaires Comparants sur les dispositions

de l'article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales établissant une protection légale en faveur des
créanciers éventuels de la Société, le remboursement effectif de l'actionnaire concerné ne peut pas être fait librement et
sans recours avant trente (30) jours suivant la publication du présent acte au Mémorial C.

<i>Deuxième résolution

Les Actionnaires Comparants décident de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la décision prise dans la

première résolution, qui se lira désormais comme suit:

5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en une (1) action

d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) (l'"Action de Commandité") détenue par l'actionnaire commandité et trente
mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (30.999) actions d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) ("Actions de Comman-
ditaire") détenues par le/les actionnaire(s) commanditaire(s)."

<i>Frais, Conclusion de l'assemblée et acte notarié

Les frais, dépenses et rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne n'ayant soulevé d'autres points pour discussion par l'assemblée, l'assemblée

est close à 15:40.

Le Notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version française,

et qu'à la demande des Actionnaires Comparants, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le jour mentionné en haut de ce document.

54891

L

U X E M B O U R G

Ce document ayant été lu aux Actionnaires Comparants (ou, selon le cas à leurs mandataires), qui sont connus par le

Notaire par leurs noms de famille, prénoms, état civil et résidence, les Actionnaires Comparants (ou, selon le cas leurs
mandataires), le Notaire, le président, le secrétaire et le scrutateur ont ensemble signé cet acte.

Signé: M. NEZAR, B. SCHMITT, L. GRETHEN.
Enregistré à Diekirch A.C., le 08 avril 2016. Relation: DAC/2016/5313. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 11 avril 2016.

Référence de publication: 2016091620/161.
(160060086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.

Clayax Acquisition Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 161.835.

In the year two thousand and sixteen, on the seventh day of April,
Before the undersigned, Maître Léonie GRETHEN, Notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

acting instead and place of Maître Danielle KOLBACH, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxem-
bourg, temporarily unavailable, who will hold the present minutes,

THERE APPEARED:

Clayax Acquisition Luxembourg 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-

porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7A, rue Robert
Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 94,990,833.-, registered with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 150.282 (the "Sole Shareholder").

here presented by Ms Barbara Schmitt, employee, residing professionally in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Lu-

xembourg, by virtue of a power of attorney, given privately to her in Luxembourg.

The said power of attorney, initiated ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the officiating notary,

will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the Sole Shareholder of Clayax Acquisition Luxembourg 2 S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR
308,664,701.-, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 161.835 (the "Company")
and incorporated pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, dated 28 June 2011 and whose articles of association (the "Articles") have been published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations dated 1 September 2011 (number 2023, page 97058) (the "Mémorial C"). The Articles
have been amended for the last time on 26 August 2011 pursuant to a deed of the above mentioned notary, published in
the Mémorial C dated 28 October 2011 (number 2622, page 125848).

The  appearing  party  representing  the  whole  share  capital  of  the  Company  requires  the  notary  to  act  the  following

resolutions taken in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of
10 August 1915, as amended, pursuant to which a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the
powers of the general meeting of shareholders of the company and the decisions of the sole shareholder are recorded in
minutes or drawn up in writing:

<i>First resolution

The Sole Shareholder decides to decrease the issued share capital of the Company by an amount of three hundred and

eight million six hundred and fifty-two thousand two hundred and one euros (EUR 308,652,201.-) so as to bring it from
its current amount of three hundred and eight million six hundred and sixty-four thousand seven hundred and one euros
(EUR 308,664,701.-) to twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) by the cancellation of three hundred and eight
million six hundred and fifty-two thousand two hundred and one (308,652,201) shares each having a nominal value of one
euro (EUR 1.-).

The reduced amount shall be entirely allocated to the Company's freely distributable reserve and shall be at the free

disposal of the Sole Shareholder or the managers of the Company, as the case may be.

The repayment may only take place in accordance with the respects of the rights of the eventual/existing creditors of

the Company.

54892

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Sole Shareholder decides to amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the decision taken under the first

resolution, which shall now read as follows:

5. Share capital.
5.1 The share capital of the Company is of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) divided into twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Shares"). In these Articles,
"Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly."

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by

reason of the present deed are assessed to two thousand five hundred euros (EUR 2,500.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by her name, first name,

civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le septième jour du mois d'avril.
Par-devant la soussignée Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

agissant en remplacement de Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de
Luxembourg, momentanément empêchée, laquelle sera dépositaire des présentes minutes,

A COMPARU:

Clayax Acquisition Luxembourg 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, ayant un capital social de 94.990.833,- EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 150.282 (l'"Associé Unique").

ici représenté par Madame Barbara Schmitt, salariée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, Grand-Duché

de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui-délivrée.

Ladite  procuration  signée  ne  varietur  par  le  mandataire  de  la  partie  comparante  et  le  notaire  instrumentant,  restera

attachée au présent acte pour être enregistrée avec lui auprès des autorités d'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'Associé Unique de Clayax Acquisition Luxembourg 2 S.à r.l., une société à responsa-

bilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 308.664.701,- EUR et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.835 (la "Société") et constituée par un acte
notarié de Me Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 28 juin
2011 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 1

er

 septembre 2011 (numéro 2023, page 97058) (le "Mémorial C"). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date

du 26 août 2011 par un acte du notaire susmentionné, publié au Mémorial C le 28 octobre 2011 (numéro 2622, page 125848).

La partie comparante, représentant l'ensemble du capital social de la Société requiert le notaire d'acter les résolutions

suivantes prises conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales
du 10 août 1915, telle que modifiée, selon lesquelles l'associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les
pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un
procès-verbal ou rédigées par écrit:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de réduire le capital social souscrit de la Société d'un montant de trois cent huit millions six

cent cinquante-deux mille deux cent et un Euros (308.652.201,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trois cent
huit millions six cent soixante-quatre mille sept cent et un Euros (308.664.701,- EUR) à douze mille cinq cents Euros
(12.500,- EUR) par l'annulation de trois cent huit millions six cent cinquante-deux mille deux cent et une (308.652.201)
parts sociales ayant chacune une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR).

Le montant réduit sera entièrement alloué à la réserve distribuable de la Société et sera à la libre disposition de l'Associé

Unique ou des gérants de la Société, selon le cas.

Le remboursement ne pourra avoir lieu que conformément au respect des droits des créanciers éventuels/existants de la

Société.

54893

L

U X E M B O U R G

<i>Seconde résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la décision prise dans la première résolution,

qui se lira désormais comme suit:

5. Capital social.
5.1 Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par douze

mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales"). Dans
les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs des Parts Sociales et "Associé" doit être interprété conformément."

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur la requête de ladite partie comparante et en cas de
divergence entre le texte en anglais et le texte en français, le texte en anglais fera foi.

DONT ACTE fait et passé à Luxembourg, en date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par son nom,

prénom, statut civil et résidence, la mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. SCHMITT, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 08 avril 2016. Relation: DAC/2016/5312. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 11 avril 2016.

Référence de publication: 2016091202/120.
(160060017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.

Dentsply CE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 150.469.

Dentsply EU Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 73.350.

Certificat émis en application de l’article 273 (1) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que

modifiée

I, Jacques Kesseler,
Notary residing in Pétange,
duly appointed in the Grand Duchy of Luxembourg,
hereby attest and certify the following:
Pursuant to a draft common terms of merger enacted on 2 March, 2016 by the undersigned notary (the "Common Draft

Terms of Merger"), Dentsply CE S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies
register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) (the Register) under registration number B 150.469 (the
Absorbing  Company)  proposed  to  absorb  Dentsply  EU  Holding  S.à  r.l.  a  private  limited  liability  company  (société  à
responsabilité limitée), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 6, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Re-
gister under registration number B 73.350 (the "Absorbed Company") by way of merger by absorption (the "Merger"). The
Absorbing Company and the Absorbed Company are hereafter collectively referred to as the "Merging Companies".

The Merger is performed in accordance with articles 261 et seq. and in particular with article 278 of the law of August

10, 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”).

Pursuant to article 262 of the Law, the Common Draft Terms of Merger were published in the Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, number 685, on 8 March, 2016.

The documents provided for by article 267 paragraph 1 (a), (b) and (c) of the Law have been deposited at the Merging

Companies’ registered office at least one (1) month prior to the date of the present certificate.

All the formalities required under Luxembourg law in relation to the Merger have been accomplished, in particular the

conditions as provided for under article 279 of the Law.

54894

L

U X E M B O U R G

The accounting effective date of the Merger is 1 January 2016.
None of the shareholders of the Absorbing Company did require, during the period of one (1) month following the

publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations of the Common Draft Terms of Merger, the
convening of an extraordinary general meeting of the shareholders of the Absorbing Company, in order to vote on the
approval of the Merger.

Therefore, the Merger, which has now become effective among the Merging Companies as a result of the period of one

(1) month following the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations of the Common Draft
Terms of Merger having elapsed, will also become effective vis-à-vis third parties as from the date of the publication of
this certificate in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, having the following consequences ipso jure:

- the universal transfer of all of the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company;
- the Absorbed Company ceases to exist;
- the cancellation of the shares of the Absorbed Company;
- all other consequences, as listed in the Common Draft Terms of Merger.
Certified in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, on 11 April 2016.

Suit la traduction française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergences, la version anglaise fera

foi.

Le soussigné Jacques Kesseler,
Notaire résidant à Pétange,
dûment nommé au Grand-Duché de Luxembourg,
atteste et certifie que:
En vertu d’un projet commun de fusion notarié du 2 mars 2016 par le notaire instrumentant (le «Projet Commun de

Fusion»), Dentsply CE S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 150.469 (la «Société Absorbante») a projeté d’absorber, par voie de fusion par absorption,
Dentsply EU Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 73.350 (la «Société Absorbée») (la «Fusion»). La Société Absorbante et la Société
Absorbée sont ci-après collectivement nommées les «Sociétés Fusionnantes».

La Fusion est opérée suivant les dispositions des articles 261 et suivants et en particulier de l’article 278 de la loi

luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

Suivant les dispositions de l’article 262 de la Loi, le Projet Commun de Fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 685, en date du 8 mars 2016.

Les documents requis par l’article 267 paragraphe 1 (a), (b) et (c) de la Loi ont été déposés au siège social des Sociétés

Fusionnantes au moins un (1) mois avant la date du présent certificat.

Toutes les formalités requises par la loi luxembourgeoise ont été accomplies, en particulier les conditions prévues par

l’article 279 de la Loi.

Du point de vue comptable, la Fusion prend effet le 1 janvier 2016.
Aucun associé de la Société Absorbante n’a requis, pendant le délai d’un (1) mois suivant la publication au Mémorial

C Recueil des Sociétés et des Associations du Projet Commun de Fusion, la convocation d’une assemblée générale ex-
traordinaire des associés de la Société Absorbante, appelée à se prononcer sur l’approbation de la Fusion.

Par conséquent, la Fusion, qui a déjà pris effet entre les Sociétés Fusionnantes dans la mesure ou la période d’un (1)

mois s’est écoulée depuis la publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et des Associations du Projet Commun de
Fusion, prendra également effet à l’égard des tiers à partir de la publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et des
Associations du présent certificat, avec les conséquences suivantes:

- le transfert universel de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante;
- la Société Absorbée cesse d’exister;
- les parts sociales de la Société Absorbée sont annulées;
- toutes les autres conséquences, tells qu'énumérées dans le Projet Commun de Fusion.

Ainsi certifié à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, le 11 avril 2016.

Référence de publication: 2016091247/83.
(160060460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.

54895

L

U X E M B O U R G

ASF Rome Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 20.000,00.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 204.136.

ASF Rome Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 139.435,00.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 170.839.

In the year two thousand and sixteen, on the fifth day of April.
Before Maître Edouard Delosch, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Mrs. Sophie Wegmann, private employee, with professional address at 24, avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg, acting for and on behalf of the board of managers of:

1. ASF Rome Luxembourg 2 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company ("société à responsabilité limitée")

having its registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 204136, with a share capital of CAD 20,000 (twenty
thousand Canadian Dollars) represented by 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of CAD 1 (one Canadian
Dollar) per share, each fully paid up (hereafter the “Absorbing Company”), and

2. ASF Rome Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company ("société à responsabilité limitée")

having its registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 170839, with a share capital of 139,435 CAD (one
hundred thirty-nine thousand four hundred and thirty-five Canadian Dollars) represented by 139,435 (one hundred thirty-
nine thousand four hundred and thirty-five) shares with a nominal value of CAD 1 (one Canadian Dollar) per share, each
fully paid up (hereafter the “Absorbed Company”).

The appearing person, acting in her aforesaid dual capacity, required the undersigned notary to record the merger (fusion)

of the Absorbing Company and the Absorbed Company as follows:

- the board of managers of the Absorbing Company and the board of managers of the Absorbed Company decided to

proceed with the merger of the Absorbing Company and the Absorbed Company by absorption of the Absorbed Company
into the Absorbing Company;

- the Absorbing Company is the sole holder of all the shares issued by the Absorbed Company and the merger will be

carried out following the simplified mechanism in accordance with articles 278 and following of the law on commercial
companies dated 10 August 1915, as amended (the “Law”);

- the board of managers of the Absorbing Company and of the Absorbed Company have drawn up a merger project

pursuant to articles 261 and 278 of the Law. The merger project has been enacted by notarial deed on 22 February 2016,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 603 dated 1 

st

 March 2016;

- all the shareholders of the Absorbing Company and of the Absorbed Company were entitled for a period of at least

one month before the merger takes effect between the parties to take cognizance of the documents mentioned in article 267
paragraph 1 (a) and (b) of the Law at the registered offices of the Absorbing Company and of the Absorbed Company
without charge and on mere request; and

- the shareholder of the Absorbing Company has not required that an extraordinary general meeting of the shareholder

of the Absorbing Company be convened pursuant to article 279 (c) of the Law and a period of one month has lapsed since
the publication of the merger project in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

This being said, following its merger into the Absorbing Company, the Absorbed Company no longer exists, its shares

being cancelled.

The merger is effective as of this 5 April 2016.

<i>Declaration

In accordance with Article 271 of the Law, the notary acting in this matter declares that he has checked and attests to

the existence and legality of the acts and formalities required of the merging companies and by the merger project. In
accordance with article 273 (1) of the Law, the notary certifies furthermore that the conditions set out in article 279 of the
Law are fulfilled.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing parties, the

present deed is drafted in English followed by a French translation. In the event of a conflict between the English and the
French version, the English version shall prevail.

This DEED is made in Luxembourg on the day before mentioned.

54896

L

U X E M B O U R G

Upon reading the present deed to the appearing parties, the appearing parties, signed with us, the notary, the present

deed.

Suit la version en langue française:

L’an deux mille seize, le cinquième jour du mois d'avril.
Par devant Maître Edouard Delosch, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mme Sophie Wegmann, salariée, ayant son adresse professionnelle sise au 24, avenue Emile Reuter L-2420 Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en qualité de mandataire au nom et pour le compte des conseils de gérance
de:

1. ASF Rome Luxembourg 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

sis au 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 204136, ayant un capital social de 20.000 CAD (vingt mille Dollars
canadiens) représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales d’une valeur nominale de 1 CAD (un Dollar canadien) par
part sociale, chacune entièrement libérée, (ci-après, la «Société Absorbante»), et

2. ASF Rome Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

sis au 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170839, ayant un capital social de 139.435 CAD (cent trente-neuf
mille quatre cent trente-cinq Dollars canadiens) représenté par 139.435 (cent trente-neuf mille quatre cent trente-cinq) parts
sociales d’une valeur nominale de 1 CAD (un Dollar canadien), chacune entièrement libérée, (ci-après, la «Société Ab-
sorbée»),

La comparante, agissant en sa double qualité précitée, a requis du notaire instrumentant d’acter la fusion de la Société

Absorbante et de la Société Absorbée comme suit:

- le conseil de gérance de la Société Absorbante et le conseil de gérance de la Société Absorbée ont décidé de procéder

à la fusion de la Société Absorbante et de la Société Absorbée par absorption de la Société Absorbée dans la Société
Absorbante;

- la Société Absorbante est l’unique détenteur de toutes les parts sociales émises par la Société Absorbée et la fusion

sera accomplie suivant le mécanisme simplifié conformément aux articles 278 et suivants la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»);

- les conseils de gérance de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont arrêté un projet commun de fusion selon

les dispositions des articles 261 et 278 de la Loi. Le projet commun de fusion a été adopté par un acte notarié en date du
22 février 2016, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 603 en date du 1 

er

 mars

2016;

- tous les associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont été en mesure pour une période d’au moins

un mois avant que la fusion n’entre en vigueur entre les parties, de prendre connaissance de tous les documents énumérés
à l’article 267 paragraphe 1 (a) et (b) de la Loi aux sièges sociaux de la Société Absorbante et de la Société Absorbée sans
frais et sur simple demande; et

- l'associé unique de la Société Absorbante n’a pas requis qu'une assemblée générale extraordinaire de l'associé de la

Société Absorbante soit convoquée conformément à l’article 279 (c) de la Loi et une période d’un mois s’est écoulée depuis
la publication du projet de fusion dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Ceci étant dit, suite à sa fusion dans la Société Absorbante, la Société Absorbée n’existe plus, ses parts sociales étant

annulées.

La fusion est réalisée le 5 avril 2016.

<i>Déclaration

Conformément à l’article 271 de la Loi, le notaire agissant dans cette matière déclare qu'il a contrôlé et atteste l’existence

et la légalité des actes et formalités requis des sociétés fusionnantes et par le projet commun de fusion. Conformément à
l'article 273 (1) de la Loi, le notaire certifie en outre que les conditions de l'article 279 de la Loi ont été remplies.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par la présente que sur demande de la comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. En cas de divergences entre la version française
et la version anglaise, cette dernière fera foi.

Le présent acte a été réalisé à Luxembourg le jour mentionné précédemment.
Après lecture du présent acte par les parties comparantes, les parties comparantes, ont signé avec nous, le notaire, le

présent acte.

Signé: S. WEGMANN, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 05 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/10982. Reçu soixante-quinze (75.-)

euros.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

54897

L

U X E M B O U R G

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 11 avril 2016.

Référence de publication: 2016091153/116.
(160059747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.

COF II HOLDING FUND LUX I SCS, Société en Commandite simple.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 205.293.

<i>Extrait du contrat social de COF II HOLDING FUND LUX I SCS exécuté le 8 avril 2016:

1. Precise designation of the members who are jointly and severally liable. PIMCO GP S.à r.l., a Luxembourg private

limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 60, Grand Rue, L-1660 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, and currently in the process of being registered with the Luxembourg trade and companies
register (the “General Partner”).

2. Firm name or the denomination of the company, its object and the place where its registered office is located.
Name
2.1 COF II HOLDING FUND LUX I SCS, hereafter the “Partnership”.
Object
2.2 The Partnership is formed to engage in any lawful activity for which common limited partnerships may be formed

under the Law.

2.3 The purpose of the Partnership is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition and

financing of participations in any company or enterprise, in any form, whatsoever, and the maintenance, administration,
management, control and development of those participations.

2.4 The Partnership may borrow in any form, except by way of public offer. Furthermore, the Partnership may undertake

financing operations by and through transactions pertaining directly or indirectly to the maintenance, administration, ma-
nagement, control and development of participating interests with companies belonging to the members of the same groups
of companies to which the Partnership belongs, including, without limitation, the granting of the loans and facilities to
these companies, the granting of any assistance, advances or guarantees to these companies.

2.5 The Partnership may also carry out any such transactions, which are directly or indirectly connected with its corporate

purpose.

2.6 The Partnership does not qualify as an alternative investment fund within the meaning of article 1(39) of the Lu-

xembourg law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers.

Registered Office
2.7 The registered office of the Partnership is established in 80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

3. Designation of the managers and their signatory powers.
3.1 The Partnership is managed by the General Partner, who is its sole manager.
3.2 The Partnership is bound towards third parties in all matters by the corporate signature of the General Partner or by

the individual or joint signatures of any other persons to whom authority has been delegated by the General Partner as the
General Partner may determine in its discretion.

4. Date on which the partnership commences and the date on which it ends.
4.1 The Partnership has been formed on 8 April 2016 and will continue until the Partnership is terminated in accordance

with the limited partnership agreement.

Traduction française:

1. Associés conjointement et solidairement responsables. PIMCO GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée, con-

stituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 60, Grand Rue, L-1660 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg et en cours d’immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxem-
bourg (l’“ Associé Commandité “).

2. Nom, Objet et siège social.
Nom
2.1 „COF II HOLDING FUND LUX I SCS“, ci-après la “ Société “.
Objet
2.2 La Société est formée dans le but d’exercer toute activité légale pour laquelle une société en commandite simple

peut être formée en vertu de la Loi.

54898

L

U X E M B O U R G

2.3 L’objet de la Société est d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement au financement

et à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise, ainsi que le maintien,
l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

2.4 La Société peut emprunter sous toute forme, exceptée par voie d’offre au public. En outre, la Société peut accomplir

des opérations de financement à travers des transactions se rapportant directement ou indirectement au maintien, à l’ad-
ministration, à la gestion, au contrôle et au développement des participations dans les sociétés appartenant au même groupe
de sociétés que la Société, y compris, sans limitation, l’octroi de prêts et de subventions à ces sociétés, l’octroi d’aide
financière, d’avances ou des garanties à ces sociétés.

2.5 La Société peut également accomplir toutes opérations directement ou indirectement liées à son objet social.
2.6 La Société n’est pas un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 1(39) de la loi du 12 juillet 2013 relative

aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

Siège
2.7 La Société a son siège social au 80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

3. Désignation du gérant et pouvoirs de signatures.
3.1 La Société est gérée par l’Associé Commandité, qui est son gérant unique.
3.2 La Société est engagée envers les tiers en toutes circonstances par la signature d’entreprise de l’Associé Commandité

agissant par l’intermédiaire de ses organes ou représentants ou par la signature conjointe de toutes autres personnes à qui
le pouvoir a été délégué par l’Associé Commandité à sa discrétion.

4. Dates auxquelles la société doit commencer et se terminer. La Société a été formée le 8 avril 2016 et poursuivra son

activité jusqu'à sa dissolution conformément aux termes du contrat social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016091912/73.
(160060987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.

Warburg Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place François-Joseph Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 29.905.

Das koordinierte Verwaltungsreglement " HILUX SV SIF Fonds " wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von

Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016091732/10.
(160060063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.

Tyman Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.211.000,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 177.782.

In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of December.
Before Us, Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Jasper Acquisition Holdings Limited, a company incorporated and existing under the laws of the United-Kingdom,

having its registered office at 29 Queen Anne’s Gate, GB-SW1H 9BU, London, United-Kingdom and registered with the
Companies House Registrar of Companies for England and Wales under number 6078798 (the “Sole Shareholder”).

here represented by Mr. Mustafa Nezar, notary’s clerk, with professional address at 10 avenue Guillaume, L-1650

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 18 December 2015.

Said proxy signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:
I. That Jasper Acquisition Holdings Limited, described above, is the Sole Shareholder of Tyman Finance S.à r.l., a

private limited liability company (société à responsabilitié limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg,  registered  with  the  Luxembourg  Register  Trade  and  Companies  (Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de
Luxembourg) under number B 177.782, incorporated by a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, notary residing in

54899

L

U X E M B O U R G

Luxembourg on 29 May 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 26 July 2013, number
1803 (the “Company”).

II. That the articles of association of the Company have been amended one time by a deed enacted by Maître Martine

Schaeffer, notary residing in Luxembourg acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, prenamed on 2 July 2013,
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 13 August 2013, number 1954 (the “Articles”).

III. That the Company’s share capital amounts globally to two million two hundred eleven thousand Dollars of the

United States of America (USD 2,211,000) represented by eleven thousand one hundred ten (11,110) ordinary shares with
a nominal value of one hundred Dollars of the United States of America (USD 100) each (the "Ordinary Shares") and
eleven thousand (11,000) mandatory redeemable preferred shares with a nominal value of one hundred Dollars of the United
States of America (USD 100) each (the "MRPS"), all fully subscribed and entirely paid up.

IV. That on 18 December 2015 (the “Board Meeting”), the board of managers of the Company proposed to the Sole

Shareholder to amend the MRPS features, provided in the Articles, so as to align such MRPS features from a tax and an
accounting perspective.

V. That the Board Meeting also invited the Sole Shareholder to resolve on the following:

<i>Agenda

1. Change of the features of the MRPS of the Company.
2. Subsequent restatement of the Articles in order to reflect the change of the features of the MRPS of the Company.
3. Miscellaneous.
VI. That, on basis of the agenda, the Sole Shareholder took the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to approve the restatement of the MRPS features of the Company as well as the subsequent

amendments, as required in relation thereto throughout the Articles.

<i>Second resolution

Pursuant to the above resolution, the Sole Shareholder resolved to amend, restate and renumber the Articles, which shall

henceforth be read as follows:

“ Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company (private limited liability company), which

will be governed by the laws pertaining to such an entity (the "Company"), and in particular by the law of August 10 

th

 ,

1915 on commercial companies as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the "Articles")
which specify in the articles 6, 8 and 13 the exceptional rules applying to one-shareholder companies.

Art. 2. Corporate purpose. The corporate purpose of the Company is the holding of participations, in any form what-

soever, in other Luxembourg or foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and
to own, administer, develop and manage its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow money in any form, raise funds, and proceed by private placement to the issuance of bonds,

notes, promissory notes, debentures and any kind of debt or equity securities, convertible or not, or otherwise.

In a general fashion it may grant assistance (whether by way of loans, guarantees, pledges or any other form of security,

personal covenant or charge upon all or part of its undertaking or assets) to companies belonging to the same group of
companies to which the Company belongs, or other enterprises in which the Company has an interest, take any controlling
and supervisory measures and carry out on an ancillary basis to this assistance any administrative, management, advisory
and marketing operation with its affiliated companies which it may deem useful in the accomplishment and development
of its purposes.

The Company can finally perform all commercial, industrial, technical and financial operations, connected directly or

indirectly to all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose, including any transactions
on real estate or on movable property.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination "Tyman Finance S.a r.l.".

Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary

general meeting of its shareholder(s) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

54900

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Share capital and shares.
6.1 Subscribed share capital
The issued share capital of the Company amounts to two million two hundred eleven thousand United States Dollars

(USD 2,211,000) represented by eleven thousand one hundred ten (11,110) ordinary shares with a nominal value of one
hundred United States Dollars (USD 100) each (the "Ordinary Shares") and eleven thousand (11,000) mandatory redee-
mable preferred shares with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100) each (the "MRPS"), all fully
subscribed and entirely paid up.

MRPS will rank prior to Ordinary Shares meaning that the rights attached to the MRPS will be senior to the rights

attached to the Ordinary Shares. For the sake of clarity, “shares” in the present Articles shall include Ordinary Shares and
MRPS. As long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a sole shareholder company (société
unipersonnelle) in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and 200-2, amongst others,
will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each agreement entered into between the sole
shareholder and the Company represented by him shall be established in writing.

6.2 Share premium
Ordinary Shares and MRPS (together referred to as the “classes” of shares and each referred to as a “class” of shares)

can be issued with or without a share premium, subject to legal requirements and the provisions of the present Articles.
Any amount of share premium which has been paid in addition to the par value of the Ordinary Shares (the “Ordinary Share
Premium”) shall remain attached to the Ordinary Shares and shall be designated as the “Ordinary Share Premium Account”.
Any amount of share premium which has been paid in addition to the par value of the MRPS (the “MRPS Premium”) shall
remain attached to the MRPS and shall be designated as the “MRPS Premium Account”.

The shareholder(s) may also resolve to increase the amount of the Ordinary Share Premium Account and/or MRPS

Premium Account by way of a contribution or by incorporation of Company’s available reserves, provided that shareholder
(s) representing more than half of each class of shares of the Company and representing together more than half of the
entire share capital of the Company are present or represented at the meeting where such resolution is taken and that two
thirds of the shareholder(s) present or represented vote in favor.

Amounts so recorded to the Ordinary Share Premium Account and/or MRPS Premium Account will constitute freely

distributable reserves of the Company.

A portion of Ordinary Share Premium equal to ten percent (10%) of the share capital (composed of both Ordinary Shares

and MRPS) should be allocated to the legal reserve.

6.3 Voting rights.
Each Ordinary Share is entitled to one vote.
Each MRPS will only carry limited voting rights meaning that the holders of MRPS shall only be entitled to vote (each

MRPS giving right to one vote) in every general meeting called upon to deal with the following matters:

- The issue of new shares carrying preferential rights,
- The determination of the Preferred Distributable Amount, as defined in Article 12, attaching to the MRPS,
- The conversion of MRPS into Ordinary Shares,
- The decrease of the share capital of the Company,
- Any change to its corporate purpose,
- The issue of convertible bonds,
- The dissolution of the Company before its term,
- The conversion of the Company into a company of another legal form,
The MRPS may be issued only if the following cumulative conditions are complied with:
- The Company is held by a sole shareholder;
- MRPS do not represent more than half of the share capital of the Company;
- MRPS will confer the right to a Preferred Distributable Amount, as defined in Article 12;
- MRPS will confer a preferential right to the reimbursement of the contribution.
Should the conditions stated above cease to be fulfilled, the holders of MRPS will recover the voting rights attached to

the Ordinary Shares.

If the Preferred Distributable Amount, as defined in Article 12, has not been paid in its entirety for any reason whatsoever

for a period of two successive financial years (and until such time as it shall have been paid in full), the holders of MRPS
will recover the voting rights attached to the Ordinary Shares.

6.4 Modification of share capital
The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general

shareholders' meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of the
Law.

As long as the Company has a sole shareholder, if an impairment is booked in the Company's quarterly accounts on the

value of any of its subsidiaries and if the quarterly accounts show that further to such impairment the Company is in a loss

54901

L

U X E M B O U R G

position, the shareholder shall, before the end of the financial year during which the impairment is booked, decrease the
Ordinary Share Premium Account in order to absorb such loss.

6.5 Redemption of shares
6.5.1 Redemption of Ordinary Shares
Subject to this article 6.5.1, the Company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its Ordinary

Shares. Redemptions of the Ordinary Shares of the Company shall be carried out by means of a resolution of the sole
shareholder or where there is more than one shareholder by unanimous resolution of all the shareholders for the time being
of the Company, who may attend personally or through representation at an extraordinary general meeting of the share-
holders or of the sole shareholder (as the case may be).

Such repurchase shall be subject to the following conditions:
- any repurchase of Ordinary Shares made by the Company may only be made out of the Company's distributable retained

profits and free reserves,

- the repurchased Ordinary Shares will be immediately cancelled and the share capital reduced as a consequence thereof

in accordance with the legal requirements.

6.5.2. Redemption of MRPS
All MRPS are issued in the form of redeemable shares within the meaning of article 49-8 of the Law. Without prejudice

to the conditions set forth in article 49-8 of the Law, including the fact that the redemption of the MRPS can only be made
by means of sums available for distribution pursuant to article 72-1 of the Law or proceeds of a new issue made for the
redemption purpose MRPS will be redeemed partially or in full, pursuant to the terms and conditions set forth below.

MRPS are redeemable (partially or in full) at any time until maturity at the option of the Company (an “Early Redemption

Date”). The Company shall redeem the MRPS at the latest ten (10) years after their issuance date (the “Maturity Date”).

The MRPS shall be redeemed for an amount corresponding to (i) the aggregate par value of the redeemed MRPS, (ii)

the MRPS Premium attached to the redeemed MRPS as well as (iii) any Preferred Distributable Amount as defined in
article 12 accrued but not yet declared on the redeemed MRPS at the time of redemption (the “Redemption Price”). Non-
etheless, the MRPS shall only be redeemed at the Maturity Date if the Company has sufficient available funds to do so
(“Available Funds”) on the concerned date in accordance with article 72-1 of the Law. In case the Company disposes of
Available Funds (for the calculation of which the accrued but unpaid Preferred Distributable Amount, as defined in article
12, should be added) to pay the Redemption Price but has no sufficient cash available at the Maturity Date, it may, at its
sole discretion, pay the Redemption Price in kind (partially or in full). In case the Company has Available Funds (for the
calculation of which the accrued but unpaid Preferred Distributable Amount, as defined in article 12 should be added) to
pay the Redemption Price in cash, the Redemption Price can nonetheless be paid in kind (either at the Maturity Date or an
Earlier Redemption Date), if the MRPS holder(s) so agree. The Company may perform early repayments without penalty.

MRPS redeemed by the Company shall be immediately cancelled and the amount of share capital shall be reduced

accordingly. In addition, the MRPS Premium Account shall be reduced accordingly.

6.5.3.The Company shall not redeem or repurchase any shares when such shares are pledged or subject to any other

security interest, unless the Company: (i) obtains the prior written consent of the beneficiary of such pledge or another
security interest and (ii) complies in full with any conditions which such beneficiary may set out in its consent. This provision
shall prevail over any other provision of these articles of association to the contrary and may not be amended without the
consent of the beneficiary of such security.

6.6 Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.7 Transfer of shares
In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the

requirements of article 189 and 190 of the Law.

The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.
6.8 Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance

with article 185 of the Law.

6.9 Profit participation
Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence and subject to the provisions stated in the Articles and the respective rights and obligations attached to each class
of shares as set forth herein.

Art. 7. Management.
7.1 Appointment and removal

54902

L

U X E M B O U R G

The Company is managed by one or more managers. In case of several managers, the sole shareholder, or as the case

may be, the shareholders, may decide to have categories of managers, named either a "category A manager" or a "category
B manager".

The manager(s) do/does not need to be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and, may be dismissed ad nutum,

by the shareholder(s) of the Company.

7.2 Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the manager, or in case of several managers, the board of managers,

will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Company's object and provided the terms of this article shall have been complied with.

The Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its manager, and in case of

plurality of managers, by the joint signature of a category A manager and a category B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his/its powers

for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers
will determine these agents' responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of their agency.

7.3 Powers
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.4 Procedures
The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the

registered office of the Company or, as the case may be, at any other place in Luxembourg indicated in the convening
notice.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty four (24) hours

in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or

represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram or telefax or

email or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone to
be confirmed in writing at a later stage.

The board of managers can discuss or act validly only if two managers are present, with at least one manager of each

category in case of several categories of managers at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or repre-

sented at such meeting, with necessarily a majority in each category of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the board

of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication initiated from the Grand Duchy of Luxembourg allowing all the managers
taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting, even though such kind of participation shall remain an exception as in general, the managers
shall attend the board of manager meetings in person.

7.5 Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders' meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders'

meeting. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing. Each contract entered into
between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn-
up in writing.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which the shareholder owns. Each shareholder has voting rights commensurate with such shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires an unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital,
subject to the provisions of the Law.

54903

L

U X E M B O U R G

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed

twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to
be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders' meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), an annual

general meeting of shareholders shall be held in accordance with article 196 of the Law at the registered office of the
Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the company shall be supervised

by one or more statutory auditors in accordance with article 200 of the Law. If there is more than one statutory auditor, the
statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year / Annual accounts. The Company's accounting year starts on January 1 

st

 and ends on December 31

st

 of each year. Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory,

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and
loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet and profit and loss

accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the Law.

Art. 12. Distribution of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general

expenses and amortization represent the net profit for purposes of a distribution to be approved by the annual general
meeting of the shareholders or by sole shareholder’s decisions. An amount equal to five percent (5%) of the net profit of
the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) proportionally to the Ordinary Shares they hold,

carried forward, or transferred to a distributable reserve and, as the case arise, then distributed as part of an exceptional
distribution upon a shareholder(s) decision.

The annual general meeting of the shareholders or the sole shareholder may also decide to pay a Preferred Distributable

Amount, as defined below. The net profit and the Preferred Distributable Amount are together referred to as the “Distri-
butable Amount”.

For every financial year of the company, and for the first time at the occasion of its first financial year, a cumulative

preferred distributable amount of zero point one percent (0,1%) a year, shall accrue on the MRPS on a monthly basis (30-
day month), and is to be computed on the first day of each month in arrears on the par value of the MRPS and MRPS
Premium Account until the MRPS' redemption (“Preferred Distributable Amount”).

Preferred Distributable Amount may be either (i) declared each year to the extent the Company has sufficient Distri-

butable Amount available, or (ii) cumulated. If the current year's Preferred Distributable Amount is not declared (due to a
lack of Distributable Amount or otherwise), it shall be cumulated and can be declared at any time until the redemption of
the MRPS to the extent that there is sufficient Distributable Amount to distribute.

The holders of the Ordinary Shares are entitled to the net profit of the Company for any given financial year ("Ordinary

Dividend"), but no dividends will be paid to the holders of the Ordinary Shares until all rights to Preferred Distributable
Amount of holders of MRPS of the current year and the prior years have been paid.

The above Preferred Distributable Amount does not have any impact on the obligation for each shareholder to participate

to the losses under the sequence described in article 13 of the present Articles.

The holders of MRPS are not entitled to the Ordinary Dividend, except when holding Ordinary Share(s) as well as

MRPS.

The Ordinary Dividend may be paid in cash or in kind, if the Ordinary Shareholder(s) so agree.
The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay one or more interim

Preferred Distributable Amount with respect to the MRPS (“Preferred Interim Distributable Amount”) and interim divi-
dends on Ordinary Shares (“Ordinary Interim Dividend”), including during the first financial year, subject to the drafting
of an interim balance sheet showing a Distributable Amount. The declaration of Preferred Interim Distributable Amount
shall be limited to the Preferred Distributable Amount accumulated on the MRPS as at the day this decision is taken. The
Ordinary Interim Dividend shall be limited to what is in excess of the amounts necessary to declare the Preferred Interim
Distributable Amount until the financial year end. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim
balance sheet reviewed by an independent auditor at the Company's expense.

The total amount to be distributed / paid may not exceed the Distributable Amount since the end of the last financial

year, if existing, increased by the Distributable Amount carried forward and available reserves, less losses carried forward
and amount to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

Art. 13. Dissolution / Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to

54904

L

U X E M B O U R G

the Articles. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Upon dissolution of the Company, subject to the prior payment of the Company's creditors and to the availability of

funds, the holders of the MRPS have a preferred right to the repayment of their contributions (i.e.: MRPS and MRPS
Premium Account) and Preferred Distributable Amount accumulated/accrued or declared but not yet paid at that time.

The holders of the Ordinary Shares are not entitled to the repayment of their contribution (i.e.: Ordinary Shares, Ordinary

Share Premium Account and Ordinary Share Premium allocated to the legal reserve or any other reserve if any) until all
rights to repayment of the holders of MRPS have been discharged. Should there be insufficient funds to pay entirely the
preferred repayment right of MRPS, available funds will be allocated to the holders of MRPS pro rata their repayment
rights. Holders of the Ordinary Shares are entitled to the entire liquidation proceeds (liquidation profits) of the Company
after the holders of MRPS have received their preferred rights to repayment. Holders of MRPS are thus excluded from any
liquidation surplus of the Company after they have received their preferred right to repayment.

In case of liquidation losses, such losses will be supported firstly by the holders of the Ordinary Shares, and then by the

holders of the MRPS when necessary.

Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.”

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand six hundred euros (EUR 1,600.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy of the person appearing, who is known to the notary by his surname, first

name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois de décembre.
Par-devant Nous, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Jasper Acquisition Holdings Limited, une société constituée et valablement existante selon les lois du Royaume-Uni,

ayant son siège social au 29 Queen Anne’s Gate, GB-SW1H 9BU, Londres, Royaume-Uni et enregistrée auprès du registre
des sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles (Companies House) sous le numéro 607898 (l’ «Associé Unique»).

ici représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 10 Avenue Guil-

laume, L-1650 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, par une procuration donnée le 18 décembre 2015.

Ladite procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

La comparante, représentée par son mandataire a requis le notaire d’acter que:
I. Jasper Acquisition Holdings Limited, décrite ci-dessus, est l’Associé Unique de Tyman Finance S.à r.l., une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
177.782, constituée par un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 29 mai 2013, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 26 juillet 2013 sous le numéro 1803 (la «Société»).

II. Les Statuts de la Société ont été modifiés une fois par un acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence

à Luxembourg agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx, prénommé, le 2 juillet 2013, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1954 le 13 août 2013 (les «Statuts»).

III. Le capital social de la Société est égal à un total de deux millions deux cent onze mille Dollars Américains (2.211.000

USD) représenté par onze mille cent dix (11.110) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de cent Dollars
Américains  (100  USD)  chacune  (les  «Parts  Sociales  Ordinaires»)  et  onze  mille  (11.000)  parts  sociales  préférentielles
obligatoirement rachetables ayant une valeur nominale de cent Dollars Américains (100 USD) chacune (les «MRPS»),
toutes entièrement souscrites et libérées.

IV. Le 18 décembre 2015, le conseil de gérance de la Société (le «Conseil de Gérance») a proposé à l’Associé Unique

de modifier les caractéristiques des MRPS comme elles existent actuellement dans les Statuts pour aligner ces caractéris-
tiques des MRPS d’un point de vue fiscal et comptable.

V. A l’occasion de la réunion du Conseil de Gérance, l’Associé Unique a également été invité par le conseil de gérance

de la Société pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

54905

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

4. Modification des caractéristiques des MRPS.
5. Modification subséquente des Statuts afin de refléter le changement des caractéristiques des MRPS de la Société.
6. Divers.
VI. En conséquence de l’ordre du jour, l’Associé Unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique a décidé d’approuver la modification des caractéristiques des MRPS de la Société, ainsi que les

modifications subséquentes, telles que requises dans le corps des Statuts.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’Associé Unique décide de modifier, de reformuler et de renuméroter les

Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Forme sociale.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par les lois applicables

à une telle entité (la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»), et par les présents statuts (les «Statuts») qui précisent à l’article 6, 8 et 13, les règles particulières applicables
aux sociétés unipersonnelles.

Art. 2. Objet de la société. La Société a pour objet la détention de participations de toute forme dans toute société

luxembourgeoise ou étrangère, l’acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par
vente, échange ou autre d’actions, obligations, billets à ordre et autres titres de toute forme, et de détenir, administrer,
développer et gérer ce portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des partenariats.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, réunir des fonds et procéder par placement privé à l'émission

d’obligations, billets à ordre et tout type instrument de capital ou d’endettement, convertible ou non, ou autre.

D’une façon générale, la Société peut fournir assistance (par voie de prêts, garanties, gages ou toute autre forme de titre,

engagement personnel ou charge sur tout ou partie de ses entreprises et de ses actifs) aux sociétés appartenant au même
groupe de sociétés auquel la Société appartient, ou d’autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt, prend toute
mesure de contrôle ou de supervision et de façon auxiliaire à cette assistance, effectue des opérations administratives, de
gestion, de conseil et de marketing avec ces sociétés affiliées, qu’elle estime utiles à l’accomplissement et le développement
de son objet social.

La Société peut finalement effectuer toute opération commerciale, industrielle, technique ou financière, liée directement

ou indirectement aux activités décrites ci-dessus, pour faciliter l’accomplissement de son objet, y-compris toute transaction
relative à des propriétés immobilières et mobilières.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société a pour nom «Tyman Finance S.à r.l.».

Art. 5. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de

l’assemblée générale extraordinaire de son/ses associé(s) délibérant à la manière prévue pour modifier les Statuts.

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la municipalité, par simple décision du gérant, ou en cas

de pluralité de gérants, par une décision du conseil de gérance.

La Société peut avoir des succursales et d'autres bureaux soit au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

Art. 6. Capital social et parts sociales.
6.1 Capital social souscrit
Le capital émis de la Société est fixé à deux millions deux cent onze mille Dollars Américains (2.211.000 USD) repré-

senté par onze mille cent dix (11.110) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de cent Dollars Américains (100
USD) chacune (les «Parts Sociales Ordinaires») et onze mille (11.000) parts sociales préférentielles obligatoirement ra-
chetables ayant une valeur nominale de cent Dollars Américains (100 USD) chacune (les «MRPS»), toutes entièrement
souscrites et libérées.

Les MRPS auront un rang prioritaire sur les Parts Sociales Ordinaires, ceci signifie que les droits attachés aux MRPS

seront seniors par rapport aux droits attachés aux Parts Sociales Ordinaires. Dans un objectif de clarté, les «parts sociales»
dans ces présents Statuts incluront les Parts Sociales Ordinaires et les MRPS. Aussi longtemps que les parts sociales sont
détenues par un associé unique, la Société est unipersonnelle, au sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, parmi d’autres, seront appliqués, ceci entraînant que chaque décision de l’associé unique et
chaque contrat entre l’associé unique et la Société représentée par lui, sera établi par un écrit.

6.2 Prime d’émission.
Les Parts Sociales Ordinaires et les MRPS (ensemble les «classes» de parts sociales et chacune une «classe» de parts

sociales) peuvent être émises avec ou sans prime d’émission, soumise aux exigences légales et aux provisions des présents

54906

L

U X E M B O U R G

Statuts. Tout montant de prime d’émission qui a été payé en complément de la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires
(la «Prime d’Emission de Parts Sociales Ordinaires») devra rester attaché aux Parts Sociales Ordinaires et sera désigné
comme le «Compte de Prime d’Emission de Parts Sociales Ordinaires»). Tout montant de prime d’émission qui a été payé
en complément de la valeur nominale des MRPS (la «Prime d’Emission de MRPS») devra rester attaché aux MRPS et sera
désigné comme le “ Compte de Prime d’Emission de MRPS»).

Le(s) associé(s) peut/peuvent également décider d’augmenter le montant du Compte de Prime d’Emission de Parts

Sociales Ordinaires et/ou du Compte de Prime d’Emission de MRPS par voie d’apport ou d’incorporation des réserves
disponibles de la Société, à condition que l’/les associé(s) représentant plus de la moitié de chaque classe de parts sociales
de la Société et représentant ensemble plus de la moitié de l’ensemble du capital social de la Société soit/soient présent(s)
ou représenté(s) à l’assemblée durant laquelle une telle décision est prise et que les deux tiers des associés présents ou
représentés votent en sa faveur.

Les montants ainsi enregistrés sur le Compte de Prime d’Emission de Parts Sociales Ordinaires et/ou sur le Compte de

Prime d’Emission de MRPS constitueront les réserves librement distribuables de la Société.

Une partie de la Prime d’Emission de Parts Sociales Ordinaires égale à dix pourcents (10%) du capital social (composé

des Parts Sociales Ordinaires ainsi que des MRPS) sera allouée à la réserve légale.

6.3 Droits de vote
Chaque Part Sociale Ordinaire donne droit à un vote.
Chaque MRPS porte seulement des droits de vote limités, ceci signifie que les détenteurs de MRPS ont seulement le

droit de voter (chaque MRPS donnant droit à un vote) lors des assemblées générales extraordinaires convoquées pour
décider des sujets suivants:

i. L’émission de nouvelles parts sociales portant des droits de préférence,
ii. La détermination du Montant Distribuable Préférentiel, tel que défini à l’Article 12, attaché au MRPS,
iii. La conversion des MRPS en Parts Sociales Ordinaires,
iv. La réduction du capital de la Société,
v. Tout changement de son objet social,
vi. L’émission de titres convertibles,
vii. La dissolution de la Société avant son terme,
viii. La conversion de la Société en société d’une autre forme juridique,
Les MRPS peuvent seulement être émises si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
ix. La Société est détenue par un associé unique,
x. Les MRPS ne représentent pas plus de la moitié du capital social de la Société,
xi. Les MRPS confèrent le droit au Montant Distribuable Préférentiel, tel que défini à l’Article 12,
xii. Les MRPS confèrent un droit de préférence au remboursement de l’apport.
Si les conditions énoncées ci-dessus cessent d’être remplies, les détenteurs de MRPS recouvreront les droits de vote

attachés aux Parts Sociales Ordinaires.

Si le Montant Distribuable Préférentiel, tel que défini à l’Article 12, n’a pas été payé dans son intégralité pour quelque

raison que ce soit, pendant une période de deux années fiscales successives (et jusqu'à la fin de cette période comme il
aurait dû être payé intégralement), les détenteurs de MRPS recouvreront les droits de vote attachés aux Parts Sociales
Ordinaires.

6.4 Modification du capital social
Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou une décision de l’assemblée

générale des associés, conformément à l’article 8 de ces Statuts et dans les limites prévues par l’article 199 de la Loi.

Aussi longtemps que la Société a un associé unique, si une dépréciation est enregistrée dans les comptes trimestriels de

la Société sur la valeur de n’importe laquelle de ses filiales et si les comptes trimestriels montrent qu’en plus de cette
dépréciation, la Société est en situation de perte, les associés doivent, avant la fin de l’exercice fiscal au cours duquel la
dépréciation a été enregistrée, diminuer le Compte de Prime d’Emission de Parts Sociales Ordinaires pour absorber cette
perte.

6.5 Remboursement des parts sociales
6.5.1 Remboursement des Parts Sociales Ordinaires
Selon l’article 6.5.1, la Société peut, selon et dans les termes permis par la loi, acheter ses Parts Sociales Ordinaires. Le

Remboursement des Parts Sociales Ordinaires de la Société s’effectuera par décision de l’associé unique ou si il existe plus
d’un associé, par décision unanime de tous les associés durant l’existence de la Société, qui peuvent se rendre personnel-
lement à l’assemblée générale extraordinaire de(s) l’associé/associés selon le cas, ou s’y faire représenter.

Un tel remboursement est sujet aux conditions suivantes:
- tout remboursement de Parts Sociales Ordinaires effectué par la Société, peut uniquement provenir des profits non

distribués distribuables de la Société et des réserves libres,

54907

L

U X E M B O U R G

- les Parts Sociales Ordinaires remboursées seront immédiatement annulées et le capital social sera réduit en conséquence

conformément aux prescriptions légales.

6.5.2 Remboursement des MRPS
Toutes les MRPS sont émises sous la forme de parts sociales remboursables au sens de l’article 49-8 de la Loi. Sans

préjudice des conditions fixées par l’article 49-8 de la Loi, ceci incluant le fait que le remboursement des MRPS peut
uniquement être fait au moyen des sommes distribuables aux termes de l’article 72-1 de la Loi et des produits d’une nouvelle
émission effectuée dans le but de ce remboursement. Les MRPS seront remboursées partiellement ou intégralement, con-
formément aux termes et conditions susmentionnés.

Les MRPS sont remboursables (partiellement ou intégralement) à tout moment jusqu'à maturité à l’option de la Société

(une «Date de Rachat Anticipé»). La Société remboursera les MRPS au plus tard dix (10) ans après la date d’émission de
leurs séries (la «Date de Maturité»).

Les MRPS seront remboursées pour un montant correspondant à (i) la valeur nominale agrégée des MRPS remboursées,

(ii) la Prime d’Emission de MRPS attachée aux MRPS remboursées et à (iii) tout Montant Distribuable Préférentiel comme
défini à l’article 12, accumulé mais non encore émis sur les MRPS remboursées au jour du remboursement (le «Prix de
Rachat»). Néanmoins, les MRPS seront uniquement remboursés à la Date de Maturité si la Société a les fonds suffisants
pour le faire (les «Fonds Disponibles») à la date considérée conformément à l’article 72-1 de la Loi. Au cas où la Société
disposerait des Fonds Disponibles (pour le calcul duquel le Montant Distribuable Préférentiel accumulé mais non payé,
comme défini à l’article 12, devrait être ajouté) pour payer le Prix de Rachat mais n’a pas le numéraire disponible suffisant
à la Date de Maturité, elle peut, à sa seule discrétion, payer le Prix de Rachat en nature (partiellement ou en totalité). Au
cas où la Société a les Fonds Disponibles (pour le calcul duquel le Montant Distribuable Préférentiel accumulé mais non
payé, comme défini à l’article 12, devrait être ajouté) pour payer le Prix de Rachat en numéraire, le Prix de Rachat peut
néanmoins être payé en nature (soit à la Date de Maturité soit à la Date de Rachat Anticipé), si les détenteurs de MRPS
l’acceptent. La Société peut effectuer des remboursements anticipés sans pénalité.

Les MRPS remboursées par la Société seront immédiatement annulées et le montant du capital social sera diminué du

même montant. De plus, le Compte de Prime d’Emission des MRPS sera réduit du même montant.

6.5.3
La Société ne remboursera ni ne rachètera aucune part sociale lorsque ces parts sociales sont gagées ou soumises à tout

autre garantie, sauf si la Société: (i) obtient l’accord préalable écrit du bénéficiaire d’un tel gage ou de l’autre garantie et
(ii) respecte totalement les conditions que ce bénéficiaire a pu exprimer lors de son accord. Cette disposition prévaut sur
toute autre disposition contraire de ces Statuts et ne pourra être modifiée qu’avec l’accord du bénéficiaire de la garantie.

6.6 Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, puisqu'un seul propriétaire est admis par part sociale.
Les propriétaires conjoints doivent désigner une personne unique comme leur représentant envers la Société.
6.7. Cession des Parts Sociales
En cas d’associé unique, les parts sociales de la Société détenues par l’associé unique sont librement cessibles.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales détenues par chaque associé peuvent être cédées en conformité avec les

articles 189 et 190 de la Loi.

La Société peut acheter ses propres parts sociales dans le but de leur annulation immédiate.
6.8. Enregistrement des Parts Sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom de la personne spécifique, et enregistrées sur le registre des associés

conformément à l’article 185 de la Loi.

6.9. Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et profits de la Société en proportion directe du nombre de parts

sociales en existence et soumis aux provisions des Statuts et aux droits et obligations respectifs attachés à chaque classe
de parts sociales, comme indiqué ici.

Art. 7. Administration.
7.1. Nomination et révocation.
La Société est administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, l’associé unique, ou le cas échéant,

les associés, peuvent décider d’avoir des catégories de gérants, dénommés soit «gérant de catégorie A» ou «gérant de
catégorie B».

Le/Les gérant(s) n’a/ont pas besoin d’être associé(s). Le/les gérants est/sont nommés et, peuvent être révoqués à tout

moment avec ou sans motif par le/les associé(s) de la Société.

7.2 Mandat et pouvoir de signature
Lorsqu'il traite avec des tiers ainsi que lorsqu'il agit en justice, le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de

gérance, a tous les pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et porter et approuver tous les actes et
opérations conformes à l’objet de la Société, à condition que les conditions de cet article soient remplies.

54908

L

U X E M B O U R G

La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature unique de son gérant, ou en cas de pluralité de

gérants, par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut sous-déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques, à un ou plusieurs agent(s) ad hoc. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
détermine les responsabilités et rémunération (le cas échéant) de cet/ces agent(s) ad hoc, ainsi que la durée de son/leur
mandat et toute autre condition intéressant son/leur mandat.

7.3 Pouvoirs des gérants.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

7.4 Procédures
Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que les intérêts de la Société le requièrent, ou sur convocation d’un gérant

au siège social de la Société, ou le cas échéant, à tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg, indiqué dans la
convocation.

Préavis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date fixée pour cette réunion, sauf en cas d’urgence pour lequel les natures de ces circonstances doivent être
formulées dans la convocation à la réunion du conseil de gérance.

Tout gérant peut prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, par télégramme, par téléfax,

par email ou par lettre, un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut également nommer un autre gérant pour le
représenter par téléphone, ceci devant être confirmé par écrit a posteriori.

Le conseil de gérance peut seulement délibérer ou prendre une décision si deux gérants sont présents, avec au moins un

gérant de chaque catégorie en cas de pluralité de catégories de gérants à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les décisions sont prises par une majorité des gérants présents ou représentés à cette

réunion, avec la nécessité d’avoir une majorité par catégorie de gérants.

Les décisions par écrit approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les décisions prises aux réunions

du conseil de gérance. Une telle approbation peut se faire par document unique ou par plusieurs documents séparés.

Chaque gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéoconférence ou par tout autre

moyen de communication initié depuis le Grand-Duché de Luxembourg, permettant à tous les gérants participant à cette
réunion d’écouter les autres gérants. La participation à une réunion par ces biais est équivalente à une participation en
personne à une telle réunion, bien que ce type de participation doive rester une exception, du fait que généralement les
gérants doivent se rendre aux réunions du conseil de gérance en personne.

7.5 Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) n’assume(nt) du fait de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle en relation avec les engage-

ments régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés. L’associé unique assume tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des

associés. Les décisions de l’associé unique sont retranscrites sur un procès-verbal ou établies à l’écrit. Chaque contrat entre
l’associé unique et la Société représentée par l’associé unique doit être retranscrit sur un procès-verbal ou établi à l’écrit.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives, peu important le nombre de parts

sociales qu’il détient. Chaque associé a des droits de vote proportionnels à sa détention. Les décisions collectives sont
seulement validement prises lorsqu'elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les décisions de modification des Statuts, sauf le cas de changement de nationalité qui requiert un vote

unanime, sont seulement prises à la majorité des associés détenant au moins les trois-quarts du capital de la Société, selon
les dispositions de la Loi.

La tenue d’assemblées générales extraordinaires n’est pas obligatoire lorsque le nombre de membres ne dépasse pas les

vingt-cinq (25). Dans un tel cas, chaque membre reçoit l’énoncé précis du texte des résolutions ou décisions devant être
adoptées et donne son vote par écrit.

Art. 9. Réunion de l’assemblée générale des associés. Lorsque le nombre d’associés excède vingt-cinq (25), une réunion

de l’assemblée générale extraordinaire des associés est tenue conformément à l’article 196 de la Loi, au siège social de la
Société, ou à un autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg comme il peut être spécifié dans la convocation à
l’assemblée.

Art. 10. Audit. Lorsque le nombre d’associé excède vingt-cinq, les opérations de la Société sont supervisées par un ou

plusieurs  commissaire(s)  aux  comptes  conformément  à  l’article  200  de  la  Loi.  S’il  existe  plus  d’un  commissaire  aux
comptes, les commissaires aux comptes agissent sous la forme de collège et forment un conseil des commissaires aux
comptes.

Art. 11. Année fiscale / Comptes annuels. L’année comptable de la Société débute au 1 

er

 janvier et finit au 31 décembre

de chaque année. Chaque année, le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire qui
inclue une indication de la valeur des actifs et passifs de la Société, ainsi qu’un bilan et un compte de profits et pertes dans
lequel les dotations aux amortissements nécessaires sont faites.

54909

L

U X E M B O U R G

Chaque associé peut inspecter, au siège social de la Société, l’inventaire, le bilan, le compte de profits et pertes ci-dessus

et, le cas échéant, le rapport du/des commissaire(s) aux comptes établi conformément à l’article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits. Les bénéfices bruts de la Société indiqués dans les comptes annuels, après déduction

des dépenses générales et amortissements représentent le profit net pour les besoins d’une distribution devant être approuvée
par les décisions de l’assemblée générale des associés ou de l’associé unique. Un montant égal à cinq pourcents (5%) du
profit net de la Société est alloué à la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pourcents (10%) du capital
social de la Société.

Le solde du profit net peut être distribué à l’/aux associé(s) proportionnellement aux Parts Sociales Ordinaires qu’il(s)

détient/détiennent, reporté(s), ou transféré(s) à une réserve distribuable et, le cas échéant, ensuite distribué(s) en tant que
dividende exceptionnel suite à une décision de l’assemblée générale des associés ou une décision de l’associé unique.

L’assemblée générale annuelle des associés ou de l’associé unique peut également décider de payer un Montant Dis-

tribuable Préférentiel, comme définit ci-dessous. Le profit net et le Montant Distribuable Préférentiel sont ensemble appelés
le «Montant Distribuable».

Pour chaque exercice fiscal de la Société, et pour la première fois à l’occasion de ce premier exercice fiscal, un montant

distribuable préférentiel cumulatif, égal à zéro virgule un pourcent (0,1%) par an s’accumulera sur les MRPS mensuellement
(sur une base de 30 jours par mois) et sera calculé au premier jour de chaque mois en arriérés sur la valeur des MRSP et le
Compte de Prime d’Emission du MRPS jusqu’au rachat («Montant Distribuable Préférentiel»).

Le Montant Distribuable Préférentiel peut être soit (i) émis chaque année à condition que la Société ait un Montant

Distribuable suffisant disponible, ou (ii) cumulé. Si le Montant Distribuable Préférentiel de l’année en cours n’est pas
déclaré (à cause d’un manque de Montant Distribuable ou autre), il devra être cumulé et peut être déclaré à tout moment
jusqu'au rachat des MRPS à condition qu’il existe un Montant Distribuable suffisant à distribuer.

Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires ont droit au profit net de la Société pour tout exercice social (le «Dividende

Ordinaire»), mais aucun dividende ne sera payé aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires tant que tous les droits au
Montant Distribuable Préférentiel des détenteurs de MRPS de l’année en cours et des années précédentes n’ont pas été
payés.

Le Montant Distribuable Préférentiel ci-dessus n’a aucun impact sur l’obligation de chaque associé de participer aux

pertes selon la phrase décrite à l’article 13 des présents Statuts.

Les détenteurs de MRPS n’ont pas droit au Dividende Ordinaire, sauf s’ils détiennent une/des Part(s) Ordinaire(s) en

plus des MRPS.

Le Dividende Ordinaire peut être payé en numéraire ou en nature, si le(s) Associé(s) Ordinaire(s) l’accepte(nt).
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer un ou plusieurs Montants

Distribuables Préférentiels concernant les MRPS («Montant Distribuable Intérimaire Préférentiel») et des dividendes in-
térimaires sur les Parts Sociales Ordinaires («Dividende Intérimaire Ordinaire»), incluant durant le premier exercice fiscal,
à  condition  d’avoir  un  bilan  intérimaire  montrant  un  Montant  Distribuable.  La  déclaration  d’un  Montant  Distribuable
Intérimaire Préférentiel sera limitée au Montant Distribuable Préférentiel accru sur les MRPS au jour où cette décision est
prise. Le Dividende Ordinaire Intérimaire sera limité à ce qui excède les montants nécessaires à la décision de déclarer un
Montant Distribuable Intérimaire Préférentiel jusqu'à la fin de l’exercice fiscal. Chaque gérant peut décider, à sa seule
discrétion, de faire revoir le bilan intérimaire par un réviseur d’entreprises aux frais de la Société.

Le montant total à distribuer/payer ne doit pas excéder le Montant Distribuable depuis la fin du dernier exercice fiscal,

le cas échéant, augmenté du Montant Distribuable reporté et des réserves disponibles, moins les pertes reportées et le
montant à allouer aux réserves conformément aux exigences de la Loi et des Statuts.

Art. 13. Dissolution / Liquidation. La Société ne sera pas dissoute en raison du décès, incapacité, insolvabilité ou faillite

de l’associé unique ou de l’un des associés.

Excepté en cas de dissolution décidée par une décision judiciaire, la dissolution de la Société peut seulement avoir lieu

conformément à une décision adoptée par une assemblée générale des associés conformément aux conditions prévues pour
modifier les Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, nommés par les associés qui détermineront ses pouvoirs et sa rémunération.

Suite à la liquidation de la Société, à condition du paiement préalable des créanciers de la Société et de la disponibilité

des fonds, les détenteurs de MRPS ont un droit préférentiel au remboursement de leur apport (i.e. MRPS et Compte de
Prime d’Emission de MRPS) et du Montant Distribuable Préférentiel accumulé/accru mais non encore payé à ce jour.

Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires n’ont pas le droit au remboursement de leur apport (i.e. Parts Sociales

Ordinaires, Compte de Prime d’Emission de Parts Sociales Ordinaires, Prime d’Emission de Parts Sociales Ordinaires
alloué à la réserve légale ou à toute autre réserve le cas échéant) jusqu'à ce que tous les droits au remboursement des
détenteurs de MRPS aient été payés. Au cas où les fonds seraient insuffisants pour payer entièrement le droit de rembour-
sement préférentiel des MRPS, les fonds disponibles seront alloués aux détenteurs des MRPS au prorata de leurs droits au
remboursement. Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires ont droit à tous les produits de la liquidation (boni de liqui-
dation) de la Société après que les détenteurs de MRPS aient reçu leurs droits préférentiels au remboursement. Les détenteurs
de MRPS sont ainsi exclus de tout surplus de liquidation de la Société après avoir reçu leurs droits préférentiels au rem-
boursement.

54910

L

U X E M B O U R G

En cas de pertes de liquidation, ces pertes seront supportées en premier par les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires,

et ensuite par les détenteurs de MRPS si nécessaire.

Art. 14. Référence à la loi. Référence est faite aux dispositions de la Loi pour toutes les matières pour lesquelles il n’ait

fait référence à aucune disposition particulière dans ces Statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Coûts

Les dépenses, coûts, rémunérations et charges sous toute forme supportés par la Société en conséquence du présent acte

sont estimés à environ mille six cents euros (EUR 1.600.-).

Le notaire soussigné, qui connait la langue anglaise, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte a

été rédigé en anglais, suivi d’une version en français et en cas de divergence, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée, au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par son

nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé: Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41229. Reçu soixante-quinze

euros (75,00 €)

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 15 janvier 2016.

Référence de publication: 2016058312/659.
(160018060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.

Partsexport Sàrl, Société à responsabilité limitée,

(anc. Auto-Sport Shop s.à.r.l.).

Siège social: L-7526 Mersch, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 102.138.

L'an deux mille seize, le treize janvier.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

A comparu:

Monsieur Nico REDING, commerçant, né à Ettelbrück le 15 décembre 1965 (matricule 1965 12 15 210), demeurant à

L-9081 Ettelbruck, 22, rue Tony Schmit

en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée AUTO-SPORT SHOP S.à.r.l. (matricule: 1993 2401

234), ayant son siège social à L-7526 Mersch, 17, allée J.W. Léonard,

inscrite au registre de commerce sous le numéro B 102.138,
constituée suivant acte reçu le notaire Marc Cravatte, alors de résidence à Ettelbruck, en date du 16 février 1993, publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 222 du 14 mai 1993,

Lequel comparant agissant en sa qualité d'associé unique de la société à responsabilité limitée précitée a requis le notaire

d'acter la résolution suivante prise en assemblée générale:

<i>Unique résolution

L’associé unique déclare modifier la dénomination sociale de la société et par conséquent de changer l’article 1 

er

 des

statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de «PARTSEXPORT Sàrl».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour l’assemblée a été clôturée.

<i>Déclaration du comparant

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu’elle a été modifiée par la suite, être

le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l’objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/ droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-5
du Code Pénal (financement du terrorisme).

La partie comparante a évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ huit cent euros (800,00

€).

54911

L

U X E M B O U R G

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeures,

il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Nico REDING, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 13 janvier 2016. Relation: DAC/2016/632. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): Rodenbour.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 29 janvier 2016.

Référence de publication: 2016058449/43.

(160019389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2016.

VERSO HOLDING LUX SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 203.370.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de société sous seing privé en date du 27 janvier 2016 (les "Statuts") que la société en commandite

spéciale VERSO HOLDING LUX SCSp (la "Société") a été constituée ce même jour.

1. La dénomination de la Société est VERSO HOLDING LUX SCSp.
2. L'objet de la Société est le suivant: "l'acquisition de participations, à Luxembourg ou à l'étranger, dans toute société

ou entreprise indépendamment de leur forme, ainsi que la gestion de ces participations. La Société peut en particulier
acquérir, en souscrivant, achetant et en échangeant ou de quelque manière que ce soit, des stocks, des parts de capital social
ou autres titres, obligations, bons de souscriptions, certificats de dépôt et autres instruments de dette, plus généralement,
toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par une entité publique ou privée. Elle peut participer à la création,
au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. De plus, elle peut investir dans l'acquisition et
la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de toute nature ou origine.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut émettre des obligations, bonds et tous types d'ins-

truments de dette. Elle peut émettre, par des placements privés seulement, tous types de titre de capital. Elle peut prêter
des fonds, incluant, sans limitation, les recettes de tout emprunt, à ses filiales, à des sociétés affiliées ou à toutes autres
sociétés.

Elle peut aussi accorder des garanties, et donner en gage, transférer, grever ou autrement créer et accorder des garanties

sur une partie ou la totalité de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société, et, généra-
lement, pour ses propres intérêts et ceux de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la Société ne peut
pas exercer des activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu au préalable l'autorisation requise.

La Société peut utiliser toutes techniques, moyens et instruments légaux pour gérer ses investissements de manière

efficace et se protéger contre les risques de crédit, de la fluctuation du taux de change et d'intérêts, et autres risques.

La Société peut effectuer toute opération commerciale financière ou industrielle et toute transaction en rapport avec des

biens immobiliers ou meubles, directement ou indirectement, dans l'intérêt ou en rapport avec son objet social."

3. La date de constitution de la Société est le 27 janvier 2016, la Société est établie pour une durée illimitée.
4. L'associé commandité de la Société est VERSO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ-

CIĄ,, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de la République de Pologne, ayant son siège social au
62 ul. WSPÓLNA., 00-684, Varsovie, République de Pologne et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
polonais sous le numéro 0000572384 (l'"Associé Commandité").

5. Le siège social de la Société est au 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
6. Le gérant de la Société est l'Associé Commandité. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du

gérant unique, en cas de plusieurs gérants, par la signature d'un seul gérant ou par la signature de toute personne à laquelle
le gérant à délégué le pouvoir de signature. Le gérant unique a été nommé le 27 janvier 2016; pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2016.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016058333/42.
(160018258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

54912


Document Outline

Aberdeen Property Investors (General Partner) S.à r.l.

Alger Sicav

Altmunster Investment S.A.

ASF Rome Luxembourg 2 S.à r.l.

ASF Rome Luxembourg S.à r.l.

Auto-Sport Shop s.à.r.l.

BAYVK C1-Fonds

Belgian European Agencies

CCMG Navigator

Clayax Acquisition Luxembourg 2 S.à r.l.

Clayax Acquisition Luxembourg 4 S.C.A.

Clayax Acquisition Luxembourg 5 S.C.A.

CME Gold &amp; Silver Equity Fund

COF II HOLDING FUND LUX I SCS

Conventum

Dentsply CE S.à r.l.

Dentsply EU Holding S.à r.l.

Duet Trust and Fiduciary Services S.A.

Etik Supercar SC

European Communication Group

Europe Investors &amp; Finance S.A.

Exinter S.à r.l.

FIL International Property S.à r.l.

First Grana S.A.

Fisconsult S.A.

FVCM

GBM Asset Management SICAV

Grosvenor Americas S.à r.l.

GTF

Jade Management Holding S.à r.l.

Jade Portfolio 1 S.à r.l.

Jade Portfolio 2 S.à r.l.

Liquid Stressed Debt Fund

ME Fonds

Morgenstern Solid Performer

Orbis Sicav

Partsexport Sàrl

PATRIZIA Res Publica Hessen I TopCo S.à r.l.

Phaidros Funds

Pigranel S.A.

Prosper Funds SICAV

responsAbility SICAV (Lux)

San Faustin S.A.

Solo Consulting S.à r.l.

Spie BondCo 3 S.C.A.

Tyman Finance S.à r.l.

Valauchanrus Sopaneer S.C.A.

VB Reserve Select

VERSO HOLDING LUX SCSp

WAC Fonds

Warburg Invest Luxembourg S.A.