logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1124

15 avril 2016

SOMMAIRE

Audrey Germany Investment S.à r.l. . . . . . . . .

53930

Audrey Holdco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53930

Blue Moon Software  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53915

Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53951

Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53949

Degroof Petercam Asset Services S.A. . . . . . . .

53949

FACT Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53907

Finagen International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

53907

Finca Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53907

Frankfurt BICC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53916

Gondburg Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

53906

Gondburg Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

53908

Gracewell Properties (Frome) S.à r.l.  . . . . . . .

53916

Groupe Acticall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53907

Guardtek S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53908

Heico Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

53908

Hermes Trade Receivables Sàrl  . . . . . . . . . . . .

53917

HICL Infrastructure 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

53944

Highstreet VI PropCo II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

53917

LEKHOM s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53908

Leold S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53914

Lugaro Financing Holding S.A.  . . . . . . . . . . . .

53909

Luxembourg Investment Company 122 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53909

Luxembourg Investment Company 127 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53909

Luxembourg Marine Services S.A.  . . . . . . . . .

53910

L.V.I. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53910

Maison De Gorée S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53914

Mara International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53913

MB Tomahawk (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . .

53950

Mohawk International (Europe) S.à r.l.  . . . . .

53912

Mohawk International Financing S.à r.l.  . . . .

53913

Mohawk Kai Luxembourg Holding S.à r.l.  . .

53912

Monier Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53913

Neo Holdings Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .

53912

Newberg Investment SCSp  . . . . . . . . . . . . . . . .

53910

NHR Fund S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53911

Noble Drilling (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . .

53911

Novit S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53911

NRF Luxembourg Holding S.à r.l. . . . . . . . . . .

53913

NRF Luxembourg KC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

53914

Octulex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53916

Pan Ocean Financial Corp. S.A.  . . . . . . . . . . .

53906

Penelope 83 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53917

Platin Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53906

Platin Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

53906

Sharehood S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53952

Silverlands Luxembourg (T2) S.à r.l.  . . . . . . .

53952

S Lux SCSp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53915

Summit Partners (GGV) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

53918

UBS (Lux) Key Selection SICAV 2  . . . . . . . . .

53948

53905

L

U X E M B O U R G

Pan Ocean Financial Corp. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 199.487.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 25 janvier 2016 que:
1. La démission de la société BDO Audit, commissaire de la Société a été acceptée avec effet immédiat.
2. La société Audiex S.A., ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, enregistrée auprès du

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B65.469, a été nommée commissaire de la Société
avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2016.

Référence de publication: 2016064712/15.
(160026020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Platin Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.000,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jen Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 199.073.

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société en date du 31 décembre 2015

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 4, rue

Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 janvier 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Platin Capital S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2016064720/14.
(160026077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Platin Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 165.345.

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société en date du 31 décembre 2015

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 4, rue

Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 janvier 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Platin Investments S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2016064721/14.
(160026079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Gondburg Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 98.657.

Par la présente, nous remettons avec effet immédiat notre démission en tant que Commissaire aux Comptes de votre

estimée société.

Le 29 janvier 2016.

TRIPLE A CONSULTING

Référence de publication: 2016065247/11.
(160026728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

53906

L

U X E M B O U R G

Finagen International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 143.515.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg en date du 10 février 2016

1. L'administrateur restant constate et décide d'accepter la démission de Monsieur Jérémy LEQUEUX de son mandat

d'administrateur en date du 15 octobre 2015.

2. L'administrateur restant décide de coopter Monsieur Vishal SOOKLOLL, né à Goodlands (République de Maurice)

le 14 juin 1975, demeurant professionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Muhlenbach, comme administrateur
de la Société, avec effet au 15 octobre 2015, en remplacement de Monsieur Jérémy Lequeux, dont il achèvera le mandat.

3. Les administrateurs restant constatent et décident d'accepter la démission de Monsieur Alexandre TASKIRAN de son

mandat d'administrateur en date du 23 décembre 2015.

4. Les administrateurs restant décident de coopter Madame Valérie POSS, née à Algrange (France) le 2 août 1965,

demeurant professionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Muhlenbach, L-2168 Luxembourg, comme adminis-
trateur de la Société, avec effet au 23 décembre 2015, en remplacement de Monsieur Alexandre TASKIRAN, dont il
achèvera le mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2015.

Référence de publication: 2016065208/21.
(160027634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Finca Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 100.835.

Par la présente, je vous informe que je démissionne de ma fonction de administrateur B de la société Finca Holding

S.A., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B100835 et ayant son siège social au 15, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, avec effet immédiat.

Le 8 février 2016.

Wim Rits.

Référence de publication: 2016065209/11.
(160026987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

FACT Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 180.220.

Je soussigné, Maurizio MAUCERI, déclare démissionner de la fonction d'administrateur unique de la société FACT

Luxembourg S.A., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg, B180220, ayant son siège social au 10, rue
Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, à compter du 11 février 2016.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 11 février 2016.

Référence de publication: 2016065202/12.
(160027211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Groupe Acticall, Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 171.740.

Le siège de la Société a été transféré du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, au 8-10, avenue de la Gare,

L-1610 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 janvier 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016065253/10.
(160027140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

53907

L

U X E M B O U R G

Guardtek S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.105.270,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 176.609.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises pas l'associé unique de la Société du 2 février 2016 que:
- La démission de Mme Sandrine BISARO, gérant de classe B de la Société, a été acceptée avec effet au 10 février 2016;
- La personne suivante a été nommée gérant de classe B de la Société, avec effet au 10 février 2016 et ce pour une durée

indéterminée:

* Madame Caroline GOERGEN, née le 9 juin 1979 à Verviers, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue

Pasteur L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2016.

Référence de publication: 2016065254/17.
(160027183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Heico Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 193.266.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique datées du 2 février 2016

En date du 2 février 2016, l'associé unique de la Société a pris connaissance de la démission de Simon Maire, gérant de

classe B, avec effet au 9 octobre 2015.

En cette même date, l'associé unique de la Société a décidé de nommer Laetitia Borucki, née le 15 mars à Creutzwald

en France, résidant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que gérant de classe B
avec effet au 9 octobre 2015 et ce pour une durée indéterminée;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2016.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016065257/18.
(160027685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Gondburg Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 98.657.

Par la présente, je remets avec effet immédiat ma démission en tant qu'administrateur de votre estimée société.

Le 29 janvier 2016.

Fabrice CAURLA.

Référence de publication: 2016065244/9.
(160026728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

LEKHOM s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Merl, 225, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 138.131.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 7 mars 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016075981/10.
(160040630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.

53908

L

U X E M B O U R G

Luxembourg Investment Company 122 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 202.143.

<i>Extrait du contrat de cession

En date du 3 février 2016, l'associé unique de la Société, Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., a transféré la totalité de ses

parts détenues dans la Société, de la manière suivante:

- 12,500 parts sociales à Ying Zhan Investment (HK) Limited, une limited liability company, avec siège sociale au 402,

Jardine HSE1 Connaught, Place Central, HK- 210000 Hong Kong, immatriculée auprès du companies registry sous le
numéro 2327772;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2016.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2016065338/18.
(160027007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Luxembourg Investment Company 127 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 202.146.

<i>Extrait du contrat de cession

En date du 3 février 2016, l'associé unique de la Société, Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., a transféré la totalité de ses

parts détenues dans la Société, de la manière suivante:

- 12,500 parts sociales à Luxembourg Investment Company 122 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège

sociale au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg sous le numéro B 202143

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2016.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2016065339/18.
(160027006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Lugaro Financing Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 76.174.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 11 février 2016 a renouvelé les mandats des administrateurs et

du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Madame Nicole Thommes
- Monsieur Marc Koeune
- Monsieur Michaël Zianveni
- Monsieur Jean-Yves Nicolas
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2022.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016065358/18.
(160027648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

53909

L

U X E M B O U R G

Luxembourg Marine Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 53.040.

EXTRAIT

Le 09 février 2016 s'est tenue au siège social de la société, une Assemblée Générale Ordinaire, durant laquelle ladite

Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé la démission, avec effet au 18 janvier 2016, de Monsieur Jean-Pierre DE WOLF, demeurant

professionnellement au 20, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur de la Société.

2. L'Assemblée a nommé, avec effet immédiat, la société RIVA BELLA S.A., avec siège social au 20, Avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur de la Société, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de la prochaine Assemblée Générale Annuelle, qui se tiendra en 2018.

Monsieur Vincent MULDER, avec adresse professionnelle au 20, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, a été nommé

Représentant Permanent, afin de représenter la société RIVA BELLA S.A.

3. L'Assemblée a décidé de renouveler, avec effet immédiat, le mandat des administrateurs, Monsieur Vincent MULDER

et Monsieur James LITTLE, tous deux avec adresse professionnelle au 20, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, ainsi
que les mandats d'Administrateur-délégué et de Président de Monsieur Vincent MULDER, avec adresse professionnelle
au 20, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg. Leur mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle
qui se tiendra en 2018.

4. Le mandat du commissaire aux comptes, à savoir la société RIVA BELLA S.A., avec siège social au 20, Avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscrite sous le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B129.488 est renouvelé jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2018.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016065360/26.
(160027276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

L.V.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5693 Elvange, 29, Cité Waertzgaertchen.

R.C.S. Luxembourg B 81.801.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société L.V.I. S.A.

Lors de sa réunion du 8 février 2016, le conseil d'administration a pris la décision suivante:
- Me Lex THIELEN, avocat à la Cour, né le 21 juillet 1962 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-1636

Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, est nommé comme dépositaire des actions au porteur de la société, conformément à
l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des
actions nominatives et du registre des actions au porteur.

Luxembourg, le 8 février 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016065323/14.
(160026807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Newberg Investment SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 195.603.

EXTRAIT

L'Associé commandité a informé du changement d'adresse de son siège social comme suit:
Newberg Investments Spolka z o.o, société à responsabilité limitée de droit polonais immatriculée au Registre des

sociétés KRS sous le numéro 0000396339 et ayant désormais son siège social à Ul. Szwedzka 25/2, 30-324 Cracovie
(Pologne).

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2016065411/14.
(160027681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

53910

L

U X E M B O U R G

NHR Fund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 13.032.798,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 164.181.

EXTRAIT

En date du 09 février 2016, l'associé unique de la société a pris les résolutions suivantes:
- Les démissions de Wim José August Rits et Freddy de Petter, en tant que gérants B de la société, sont acceptées avec

effet immédiat.

-  Benoit  Caillaud  et  Eric-Jan  van  de  Laar,  ayant  leur  adresse  professionnelle  au  15,  rue  Edward  Steichen,  L-2540

Luxembourg, sont nommés gérants B de la société avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 11 février 2016.

Référence de publication: 2016065421/16.
(160027130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Noble Drilling (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: USD 100.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 135.475.

L'associé unique de la Société, Noble Services (Switzerland) GmbH, a décidé en date du 28 janvier 2016 de changer sa

dénomination sociale de sorte qu'elle est désormais dénommée Noble Holding (Switzerland) GmbH.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2016.

<i>Pour Noble Drilling (Luxembourg) S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016065422/15.
(160026817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Novit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 90.572.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la Société, tenue au siège social de la Société en

date du 4 février 2016, que l'associé unique, après avoir entendu le rapport du commissaire, a pris les résolutions suivantes:

1) Décharge au liquidateur, la société Fides (Luxembourg) S.A., ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg et immatriculée sous le numéro B 41469 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Lu-
xembourg.

2) Décharge au Commissaire à la liquidation, la société EQ Audit S.à r.l. ayant son siège social au 2, rue Joseph Hackin,

L-1746 Luxembourg et immatriculée sous le numéro B 124782 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Lu-
xembourg.

3) Clôture de la liquidation volontaire de la Société.
4) Désignation de l'endroit où seront conservés les livres et les documents sociaux pendant cinq ans:
46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fides (Luxembourg) S.A.
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2016065424/23.
(160027040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

53911

L

U X E M B O U R G

Mohawk Kai Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 38.333.864,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 130.792.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 5 février 2016:

Hermanus Roelof Willem Troskie a démissionné de sa fonction de gérant de catégorie B avec effet immédiat.
Andrew Smith, ayant pour adresse professionnelle le 56 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, est nommé gérant de

catégorie B avec effet immédiat pour une période illimitée.

Luxembourg, le 10 février 2016.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016065404/16.
(160026742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Neo Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 169.036.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique datées du 30 janvier 2016

En date du 30 janvier 2016, l'associé unique de la Société a pris connaissance des changements suivants;
- La démission de Simon Maire, gérant de classe B, avec effet au 9 octobre 2015;
- La nomination de Laetitia Borucki, née le 15 mars à Creutzwald en France, résidant professionnellement au 6, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que gérant de classe B avec effet au 9 octobre 2015 et ce pour une durée
indéterminée;

- La démission de Joost Tulkens, gérant de classe B, avec effet au 1 

er

 décembre 2015;

- La nomination de Universal Management Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée, immatriculée au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B64474, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, en tant que gérant de classe B, avec effet au 1 

er

 décembre 2015 et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2016.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016065409/22.
(160027684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Mohawk International (Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.550,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 110.609.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 5 février 2016:

Hermanus Roelof Willem Troskie a démissionné de sa fonction de gérant de classe B avec effet immédiat.
Andrew Smith, ayant pour adresse professionnelle le 56 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, est nommé gérant de

classe B avec effet immédiat pour une période illimitée.

Luxembourg, le 12 février 2016.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016065379/16.
(160027739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

53912

L

U X E M B O U R G

Mohawk International Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 60.000,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 182.772.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 5 février 2016:

Hermanus Roelof Willem Troskie a démissionné de sa fonction de gérant de catégorie B avec effet immédiat.
Andrew Smith, ayant pour adresse professionnelle le 56 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, est nommé gérant de

catégorie B avec effet immédiat pour une période illimitée.

Luxembourg, le 10 février 2016.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016065380/16.
(160026743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Monier Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.100.000,00.

Siège social: L-1748 Senningerberg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 156.846.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg.

Le siège social de l'associé unique de la Société, Braas Monier Building Group Holding S.à r.l., a changé et doit désormais

se lire comme suit: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2016.

Monier Finance S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2016065383/16.
(160027312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Mara International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 148.931.

EXTRAIT

Il est pris acte de la démission des administrateurs Messieurs Marc Koeune et Michaël Zianveni, ainsi que du commis-

saire-aux-comptes, la société CeDerLux-Services Sàrl, avec effet au 15 décembre 2015.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2016065388/12.
(160027464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

NRF Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 125.905.

En date du 24 novembre 2015, l'adresse professionnelle de M. Manuel Hauser a changé de 2, Wengertswee, L-5485

Wormeldange-Haut au Luxembourg à 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au Luxembourg.

Luxembourg, le 11 février 2016.

Référence de publication: 2016065425/10.
(160026756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

53913

L

U X E M B O U R G

Maison De Gorée S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 199.820.

L'an deux mille seize, le 11 février,
En vertu du contrat de cession de parts sociales signé en date du 29 janvier 2016, les parts sociales de la société ont été

transférées comme suit:

Monsieur Donald Hayes GOREE, né au Texas (USA) le 28 janvier 1958 demeurant à 5116 Bissonnet St. 170, Bellaire,

TX 77401 -4407 Texas (USA)

a transféré 100 parts sociales de 125 Euro chacune détenues dans la société Maison de Gorée S.à r.l. ayan son siège

social à L-9227 Diekirch, 50 Esplanade, à Monsieur Patrice SUSLIAN né le 1 

er

 mai 1957 à Marseille (France), demeurant

à Quartier Les Beaux Tonis, 122 route Croix Blanche, 84660 Maubec (France).

L'associé décide en date du 29 janvier 2016 la nomination à la fonction de gérant avec effet immédiat de:

- Monsieur Patrice SUSLIAN né le 1 

er

 mai 1957 à Marseille (France), demeurant à Quartier Les Beaux Tonis, 122

route Croix Blanche, 84660 Maubec (France).

L'associé décide en date du 29 janvier in 2016 la révocation à la fonction de gérant avec effet immédiat de:
- Monsieur Nicholas James MARTIN né le 03 janvier 1974 à Guernsey (Royaume-Uni), demeurant professionnellement

au 50 Esplanade, 9227 Diekirch (Luxembourg).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 11 février 2016.

<i>Pour la société
Coficom Trust S.à r.l.
B.P. 126
50, Esplanade
L-9227 Diekirch
Signature

Référence de publication: 2016065371/29.
(160027035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Leold S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 195.661.

Nous certifions par la présente qu'une cession de 20.000 (vint mille) parts sociales, représentant 100% du capital de

notre société, a été effectuée avec effet au 21 avril 2015:

- de Madame RAVEGNINI Luana, demeurant au 99, Oakwood Court, GB - W14 8JZ London
- en faveur de la société PRIVATE TRUSTEES SA, société anonyme luxembourgeoise avec siège au 92 rue de Bon-

nevoie, L-1260 Luxembourg, agissant en qualité de Trustee du LEOLD TRUST.

Fait à Luxembourg, le 10 février 2016.

Catherine DOGAT
<i>Gérant

Référence de publication: 2016065345/15.
(160027238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

NRF Luxembourg KC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 135.913.

En date du 24 novembre 2015, l'adresse professionnelle de M. Manuel Hauser a changé de 8a, Boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg à 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 février 2016.

Référence de publication: 2016065427/10.
(160026757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

53914

L

U X E M B O U R G

S Lux SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 203.347.

STATUTS

<i>Extrait du 22 janvier 2016 de la convention de société en commandite (la «convention») de S Lux SCSp, société en com-

<i>mandite spéciale.

1. Associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux. S Finanse S.à.r.l., ayant

son siège social au 25A, boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg («l’associé commandité»).
L’associé commandité a été constitué le 28.07.2015 en tant que société à responsabilité limitée («S.à.r.l.»), régie par les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée de temps en temps (ci-après la «loi de 1915»), et a été enregistré sous le numéro B199353 auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg (ci-après le «RCSL»).

2. Dénomination sociale, objet social, siège social, exercice.
(I) Dénomination sociale
La société en commandite spéciale aura le nom: «S Lux SCSp» (ci-après la «Société»).
(ii) Objet social
L'objet social de la Société est (i) la prise de participation sous forme d’intérêts et des droits de toute nature dans des

entités luxembourgeoises ou étrangères et/ ou sous forme d'autres arrangements et dans toute autre forme d'investissement,
(ii) l'acquisition par achat, souscription ou autre, ainsi que le transfert par vente, échange, ou autre, des titres de toute nature.

(iii) Siège social
La société demeure à 25A, boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
(iv) Exercice
L’exercice social de la société coïncide à l'année calendrier.

3. Nomination du gérant et de pouvoirs de signature. L’associé commandité est investi des pouvoirs les plus étendus

pour administrer et gérer la SCSp, conformément à la présente convention de société en commandite et aux lois en vigueur
au Grand-Duché de Luxembourg.

Dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente, l’associé commandité doit indiquer qu'il agit au nom de la

SCSp, et tous les actions entamés ci-après par l’associé commandité seront réputées être à ce titre, sauf indication contraire.

L’associé commandité a le pouvoir exclusif d’entamer toutes les décisions à l'égard de la SCSp, à condition qu'un tel

pouvoir  n'a  pas  été  délégué  ou  attribué  à  une  autre  entité  ou  prestataire  de  services  qui  seront  responsables  que  pour
l’exécution de leur mandat, conformément à la convention présente et à la Loi de 1915, en particulier la «sous-section 2.
- sociétés en commandite spéciale» de la Loi de 1915.

4. Date de commencement et durée de la société. La société est établie à partir du 22 janvier 2016, pour une durée

indéterminée.

Référence de publication: 2016057676/38.
(160017810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Blue Moon Software, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 201.823.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2016

Suite à la modification et refonte des statuts du 8 janvier 2016, la société est dirigée par un Directoire et non plus par

un Conseil d'Administration.

Ainsi Monsieur Pierre LENTZ n'est plus administrateur de catégorie B et Président, de même que Monsieur Reno

Maurizio TONELLI n'est plus administrateur de catégorie B.

Mesdames Alyson GREENWOOD et Anna Karin PORTUNATO et Monsieur Guy SEMMENS ne sont plus adminis-

trateurs de catégorie A.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 8 février 2016.

Référence de publication: 2016062812/16.
(160024859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

53915

L

U X E M B O U R G

Gracewell Properties (Frome) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 159.723.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse de Monsieur Tony WHITEMAN, gérant de catégorie B1 de la Société, est désormais la suivante:
- 39, rue de l'Europe, L-7225 Bereldange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2016.

Gracewell Properties (Frome) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2016063723/16.
(160025651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Frankfurt BICC, Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.018.500,00.

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 127.692.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 04 janvier 2016

L'Assemblée décide de:
- Accepter la démission des administrateurs suivants avec effet immédiat:
* M. Brian Conroy, administrateur de type A;
* M. Andrew Whitty, administrateur de type A.
- Désigner les administrateurs suivants avec effet immédiat au 04 janvier 2016 pour une durée de mandat fixée jusqu'à

l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2016.

* M. Kevin Fox, né le 29 mars 1985 à Dublin, Irlande, résidant à Gildstraat, 153, 3572EM Utrecht, Pays-Bas, mandat

d'administrateur de type A.

* M. David Endersen, né le 18 février 1984 à Dublin, Irlande, résidant à 107 Northview Road, Londres, N8 71r, Royaume-

Uni, mandat d'administrateur de type A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016063688/21.
(160025207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Octulex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 151.000.

<i>Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue en date du 28 décembre 2015

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée

générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015:

1) Monsieur Michel BULACH, avocat à la Cour, né le 06 avril 1974 à Metz, France, demeurant professionnellement

au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

2) Monsieur François BROUXEL, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966 à Metz, France, demeurant profession-

nellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

3) Monsieur Pierre METZLER, avocat à la Cour, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,

demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064704/17.
(160026434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

53916

L

U X E M B O U R G

Penelope 83 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1309 Luxembourg, 79, rue Charles IV.

R.C.S. Luxembourg B 83.312.

<i>Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mars 2015

L'assemblée générale des actionnaires de la société PENELOPE 83 S.A. a décidé, en date du 12 mars 2015, de prendre

les résolutions suivantes:

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de:
- GT Experts Comptables Sàrl, ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,
de son poste de commissaire aux comptes avec effet au 31.12.2014. Par conséquent, l'assemblée générale décide de

nommer:

-  LUX-AUDIT  S.A.  avec  siège  social  à  L-1510  Luxembourg,  57,  avenue  de  la  Faïencerie,  inscrite  au  Registre  de

Commerce de Luxembourg, sous le numéro B 25.797

au poste de commissaire aux comptes en remplacement du commissaire démissionnaire, pour une durée de quatre ans,

c'est à dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019.

Luxembourg, le 12 mars 2015.

Pour extrait conforme
Signatures

Référence de publication: 2016064739/21.
(160026326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Highstreet VI PropCo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 201.935.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte de cession sous seing privé signé en date du 28 décembre 2015 que HIGHSTREET Premium I HoldCo

S.à r.l. (anciennement HIGHSTREET VI HoldCo S.à r.l.), une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège
social à L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 201838, a cédé 30.000 parts sociales de la Société à Corestate Capital Holding S.A., une société anonyme,
établie et ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, enregistrée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199780.

Partant, les parts sociales de la Société sont dès lors détenues comme suit:

Corestate Capital Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2016064509/20.
(160026044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Hermes Trade Receivables Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 172.277.

L'adresse de Thomondview Trust Limited, Trustee de HTR Trust, associé de la société Hermes Trade Receivables S.à

r.l., est modifiée comme suit:

Thomondview Trust Limited, siège sociale first floor, Unit 2A, Nangor Road Business Park, Nangor Road - Dublin 12

(Irlande).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2016.

Référence de publication: 2016064507/13.
(160026479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

53917

L

U X E M B O U R G

Summit Partners (GGV) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.000,00.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 203.292.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the eleventh day of January.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Summit Partners Credit Fund II, L.P., a Delaware limited partnership registered under number 5367757, having its

registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 (“Summit Partners Credit Fund II”), represented by
its general partner Summit Partners Credit II, L.P.,

here represented by Michael Rebholz, residing in Luxembourg, by virtue of a duly given proxy,
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company

(société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Summit Partners (GGV) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds

a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies,
the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate
properties.

2.5 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such
intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property
rights.

2.6 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-

53918

L

U X E M B O U R G

dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000.-), represented by (i) one

million four hundred and ninety-one thousand (1,491,000) class A shares (the “Class A Shares”), (ii) one thousand (1,000)
class B shares (the “Class B Shares”), (iii) one thousand (1,000) class C shares (the “Class C Shares”), (iv) one thousand
(1,000) class D shares (the “Class D Shares”), (v) one thousand (1,000) class E shares (the “Class E Shares”), (vi) one
thousand (1,000) class F shares (the “Class F Shares”), (vii) one thousand (1,000) class G shares (the “Class G Shares”),
(viii) one thousand (1,000) class H shares (the “Class H Shares”), (ix) one thousand (1,000) class I shares (the “Class I
Shares”), and (x) one thousand (1,000) class J shares (the “Class J Shares”, and together with the Class A Shares, Class B
Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares and Class I Shares
the “Shares” and each a “Class”), with a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company

6.5 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of a Class, in whole but not in part,

consisting in the repurchase and cancellation of all Shares in issue of such Class as may be determined from time to time
by the board of managers.

6.6 The Shares shall be repurchased in reverse alphabetical order of the Classes, starting with the Class J Shares.
6.7 Subsequent Classes shall only become available for repurchase once all the Shares of the preceding Class have been

repurchased in full. Each Class becoming available for repurchase according to the rule specified in this article 6 shall be
referred to as the “Relevant Class of Shares”.

6.8 The Relevant Class of Shares shall be repurchased and cancelled for an aggregate price equal to the fair market value

of such Class as determined in article 6.11 below (the “Total Cancellation Amount”).

6.9 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class (in the order

provided for in article 6.6), such Class gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such Class to the
Available Amount (as defined below) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class shall receive from
the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined below) for each Share of the Relevant Class
of Shares held by them and cancelled.

6.10 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount (as defined below)

by the number of Shares in issue in the class of Shares to be repurchased and cancelled.

6.11 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers on the basis of the relevant

interim accounts of the Company as of a date not more than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation
of the relevant Class. The Total Cancellation Amount for each Class shall be the Available Amount (increased by the
nominal value per share to be cancelled) of the relevant Class at the time of the cancellation of the relevant Class unless
otherwise resolved by the board of managers provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher
than such Available Amount (increased by the nominal value per share to be cancelled). The board of managers can choose
to include or exclude in its determination of the Total Cancellation Amount, the freely distributable share or assimilated
premium either in part or in totality.

6.12 The “Available Amount” shall be the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)

to the extent the holders of Shares of the relevant Class would have been entitled to distributions according to articles 22
and/or 23 of these articles of association, (i) increased by any freely distributable reserves including, as the case may be,
the amount of the share premium or assimilated premium and legal reserve reduction relating to the relevant Class to be
cancelled, and (ii) reduced by (a) any losses (included carried forward losses), (b) any sums to be placed into non-distri-
butable reserves, each time as set out in the relevant interim accounts and (c) any accrued and unpaid dividends to the extent
those have not already reduced the NP (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that: AA = (NP + P)
- (L + LR + LD). Whereby: AA= Available Amount; NP= net profits (including carried forward profits); P= any freely
distributable reserves including, as the case may be, the amount of the share premium reduction and legal reserve reduction
relating to the Class to be cancelled; L= losses (including carried forward losses); LR = any sums to be placed into non-
distributable reserve(s) pursuant to the requirements of law or of these articles of association; LD = any accrued and unpaid
dividends to the extent those have not already reduced the NP.

53919

L

U X E M B O U R G

6.13 Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will

become due and payable by the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by

the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the

transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by the
surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, des-
cendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.

53920

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office. The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class
A managers (the “Class A Managers”) and class B managers (the “Class B Managers”). Any reference made hereinafter
to the “managers” shall be construed as a reference to the Class A Managers and/or the Class B Managers, depending on
the context and as applicable.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

Art. 15. Convening meetings of the board of managers.
15.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

15.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

15.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any

convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

Art. 16. Conduct of meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

16.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.

16.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

16.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means

of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

16.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers, the board of managers may deliberate or act validly only if at least one (1) Class A Manager and one
(1) Class B Manager is present or represented at the meeting.

16.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. In the event

the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers, decisions shall be taken by a majority of
the managers present or represented including at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager. The chairman,
if any, shall not have a casting vote.

16.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.

Art. 17. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
17.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by (i) the chairman, if any or in his absence

by the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or (ii) by one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager,
if applicable, or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial procee-
dings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager,
if applicable, or by any two (2) managers.

17.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 18. Dealing with third parties.
18.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or

if the Company has several managers, by the joint signatures of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager, if
applicable, or of any two (2) managers, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such
signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

53921

L

U X E M B O U R G

E. Audit and supervision

Art. 19. Auditor(s).
19.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the statutory auditor(s) and shall determine their term of office.

19.2 A statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

19.3 The statutory auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
19.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))

in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.

19.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 20. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 21. Annual accounts and allocation of profits.
21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the

Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

21.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.

21.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

21.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

21.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

21.6 In the event of a distribution, amounts distributed shall be allocated as follows:
(i) Class A Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one point nine

per cent (1.9%) per year of the nominal value of the Class A Shares issued by the Company;

(ii) Class B Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one point eight

per cent (1.8%) per year of the nominal value of the Class B Shares issued by the Company;

(iii) Class C Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one point seven

per cent (1.7%) per year of the nominal value of the Class C Shares issued by the Company;

(iv) Class D Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one point six

per cent (1.6%) per year of the nominal value of the Class D Shares issued by the Company;

(v) Class E Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one point five

per cent (1.5%) per year of the nominal value of the Class E Shares issued by the Company;

(vi) Class F Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one point four

per cent (1.4%) per year of the nominal value of the Class F Shares issued by the Company;

(vii) Class G Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one point three

per cent (1.3%) per year of the nominal value of the Class G Shares issued by the Company;

(viii) Class H Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one point two

per cent (1.2%) per year of the nominal value of the Class H Shares issued by the Company;

(ix) Class I Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one point one

per cent (1.1%) per year of the nominal value of the Class I Shares issued by the Company;

(x) Class J Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one per cent (1%)

per year of the nominal value of the Class J Shares issued by the Company;

all as long as they are in existence, and
(xi) the remainder shall be distributed to the Relevant Class of Shares.

Art. 22. Interim dividends - Share premium and assimilated Premiums.
22.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year of which the annual accounts have been approved, increased

53922

L

U X E M B O U R G

by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

22.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 23. Liquidation.
23.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators  shall  have  the  most  extensive  powers  for  the  realisation  of  the  assets  and  payment  of  the  liabilities  of  the
Company.

23.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in accordance with the provisions of article 21 of these articles of association.

H. Final clause - Governing law

Art. 24. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2016.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.

<i>Subscription and payment

Summit Partners Credit Fund II, L.P., aforementioned, has subscribed for the following shares issued by the Company:
(i) one million four hundred and ninety-one thousand (1,491,000) Class A Shares,
(ii) one thousand (1,000) Class B Shares,
(iii) one thousand (1,000) Class C Shares,
(iv) one thousand (1,000) Class D Shares, (v) one thousand (1,000) Class E Shares,
(vi) one thousand (1,000) Class F Shares,
(vii) one thousand (1,000) Class G Shares,
(viii) one thousand (1,000) Class H Shares,
(vix) one thousand (1,000) Class I Shares, and
(x) one thousand (1,000) Class J Shares.
All one million five hundred thousand (1,500,000) shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in

cash so that the amount of fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000) is as of now available to the Company, as
it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000) is entirely allocated to the

share capital.

Proof of the existence and the value of the above-mentioned contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne

by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

<i>Resolutions of the shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 5, rue du Plébiscite, L-2343 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
(i) Freeland, James, born in Pennsylvania, United States of America, on 2 October 1976, professionally residing at 222

Berkeley Street, Boston, Massachusetts 02116, United States of America, is appointed as Class A Manager;

(ii) Devereux, Robin, born in Albany, New York, on 9 March 1959, professionally residing at 222 Berkeley Street,

Boston, Massachusetts 02116, United States of America, is appointed as Class A Manager;

(iii) Jallow, Abdoulie Yorro, born in Fajara, Gambia, on 12 February 1975, professionally residing at 412F, route d’Esch,

L-1030 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as Class B Manager; and

53923

L

U X E M B O U R G

(iv) Bouchareb, Smaïn, born in Mulhouse, France, on 19 August 1978, professionally residing at 412F, route d’Esch,

L-1030 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as Class B Manager.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and

residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède.

L’an deux mille seize, le onze janvier.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Summit Partners Credit Fund II, L.P., un limited partnership (existant selon les lois de l’Etat du Delaware (USA),

immatriculée sous le numéro 5367757, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 («Summit
Partners Credit Fund II»), représenté par son associé commandité Summit Partners Credit II, L.P.,

dûment représenté par Michael Rebholz, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

Le comparant a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte de constitution d’une société à responsabilité limitée

qu'il souhaite constituer avec les statuts suivants:

A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom - Forme.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Summit Partners (GGV)

S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l’admi-
nistration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des

sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 Excepté par voie d’appel publique à l’épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute

forme ou en émettant toute sorte d’obligations, de titres ou d’instruments de dettes, d’obligations garanties ou non garanties,
et d’une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société a, en outre, pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg,

soit à l’étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises ou
étrangères dont l’objet principal est l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de
biens immobiliers.

2.5 L’objet de la Société est également (i) l’acquisition par achat, l’enregistrement ou de toute autre manière ainsi que

le transfert par la vente, l’échange ou autre de droits de propriété intellectuelle et industrielle, (ii) l’octroi de licence sur de
tels droits de propriété intellectuelle et industrielle, et (iii) la détention et la gestion de droits de propriété intellectuelle et
industrielle.

2.6 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété

intellectuelle qu'elle estime utile pour l’accomplissement de ces objets.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l’assemblée générale des associés, adoptée

selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être

transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

53924

L

U X E M B O U R G

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision

du conseil de gérance.

4.4 Dans l’hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, écono-

mique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité
normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation
complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de
la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à quinze mille dollars américains (USD 15.000), représenté par (i) un million

quatre cent quatre-vingt-onze mille (1.491.000) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»), (ii)
mille (1.000) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), (iii) mille (1.000) parts sociales de catégorie
C (les «Parts Sociales de Catégorie C»), (iv) mille (1.000) parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie
D»), (v) mille (1.000) parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»), (vi mille (1.000) parts sociales
de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»), (vii) mille (1.000) parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales
de Catégorie G»), (viii) mille (1.000) parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»), (ix) mille (1.000)
parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I») et (x) mille (1.000) parts sociales de catégorie J (les «Parts
Sociales de Catégorie J» et ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts
Sociales de Catégorie C, les Parts Sociales de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie
F, les Parts Sociales de Catégorie G, les Parts Sociales de Catégorie H et les Parts Sociales de Catégorie I les «Parts Sociales»
et chacune une «Catégorie»), ayant une valeur nominale d’un cent de dollar américain (USD 0.01) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des associés

de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l’insolvabilité ou tout autre

événement similaire d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la Société.

6.5 Le capital social de la Société pourra être réduit par annulation d’une Catégorie, en totalité mais non en partie,

consistant en un rachat et en l’annulation de toutes les Parts Sociales émises de la Catégorie concernée, tel que déterminé
par le conseil de gérance au fil de temps.

6.6 Les Parts Sociales devront être rachetées dans l’ordre alphabétique inverse, en commençant par les Parts Sociales

de Catégorie J.

6.7 Les Catégories suivantes ne pourront être rachetées qu'une fois que toutes les Parts Sociales de la Catégorie précé-

dente auront été intégralement rachetées. Chaque Catégorie pouvant être rachetée selon les règles prévues au présent article
6, sera ci-après désignée comme suit «Catégorie de Parts Sociales Concernée».

6.8 La Catégorie de Parts Sociales Concernée devra être rachetée et annulée pour un prix total correspondant à la valeur

de marché d’une telle Catégorie, telle que définie à l’article 6.11 ci-dessous (le «Montant Total de l’Annulation»).

6.9 Dans le cas où le capital social serait réduit par le rachat et l’annulation d’une Catégorie (dans l’ordre prévu à l’article

6.6), cette Catégorie donnera droit à ces détenteurs, au prorata de leur participation dans cette Catégorie, au Montant
Disponible (tel que défini ci-dessous) et les détenteurs de Parts Sociales de la Catégorie rachetée et annulée recevront de
la Société un montant égal à la Valeur d’Annulation par Part Sociale (telle que définie ci-dessous) pour chaque Part Sociale
de la Catégorie de Parts Sociales Concernée qu'ils détiennent et qui a été annulée.

6.10 La Valeur d’Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total de l’Annulation (tel que défini

ci-dessous) par le nombre de Parts Sociales émises dans la catégorie de Parts Sociales devant être rachetée et annulée.

6.11 Le Montant Total de l’Annulation doit être un montant déterminé par le conseil de gérance sur la base de comptes

intérimaires de la Société arrêtés à une date qui ne peut précéder de plus de huit (8) jours la date de rachat et d’annulation
de la Catégorie concernée. Le Montant Total de l’Annulation pour chaque Catégorie correspondra au Montant Disponible
(augmenté de la valeur nominale de chaque part sociale à annuler) de la Catégorie concernée au moment de l’annulation
de ladite Catégorie à moins que le conseil de gérance n’en décide autrement étant entendu toutefois que le Montant Total
de l’Annulation ne doit jamais être plus élevé que le Montant Disponible (augmenté de la valeur nominale de chaque part
sociale à annuler). Le conseil de gérance peut décider, lors de la détermination du Montant Total de l’Annulation, d’inclure
ou d’exclure les primes d’émission ou primes assimilées librement distribuables en partie ou en totalité.

6.12 Le «Montant Disponible» correspond au montant total du bénéfice net de la Société (y compris le bénéfice reporté),

dans la mesure où les détenteurs de Parts Sociales de la Catégorie concernée auraient eu droit aux distributions conformé-
ment aux articles 22 et/ou 23 des présents statuts (i) augmenté de toute réserve librement distribuable, y compris, le cas

53925

L

U X E M B O U R G

échéant, le montant des primes d’émission ou primes assimilées et de la réduction de la réserve légale relatives à la Catégorie
concernée à annuler, et (ii) diminué de (a) toute perte (y compris les pertes reportées), (b) toute somme à porter en réserves
non-distribuables, chaque fois tel qu'indiqué dans les comptes intérimaires concernés et (c) tous dividendes accumulés et
impayés dans la mesure où ils ne sont déjà pas venus réduire le BN (pour éviter toute ambiguïté, sans double comptage),
de sorte que: MD = (BN + B) - (P + RL + DL). Où: MD = Montant Disponible; BN = bénéfice net (y compris le bénéfice
reporté); B = toute réserve librement distribuable, y compris, le cas échéant, le montant de la réduction de la prime d’émis-
sion et de la réduction de réserve légale relatives à la Catégorie à annuler; P = toute perte (y compris les pertes reportées);
RL = toute somme à porter en réserve(s) non-distribuable(s) conformément aux dispositions de la loi ou des présents statuts;
DL = tous dividendes accumulés et impayés dans la mesure où ils ne sont pas déjà venus réduire le BN.

6.13 Une fois que les Parts Sociales de la Catégorie concernée auront été rachetées et annulées, la Valeur d’Annulation

par Part Sociale sera exigible et payable par la Société.

Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour

consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d’inscription peuvent être émis
sur demande et aux frais de l’associé demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant

unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à
cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession

ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après

l’acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

7.6 En cas de décès, les parts sociales de l’associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous

réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants représentant les trois quarts des droits des survivants.
Un tel agrément n’est cependant pas requis dans l’hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants,
descendants ou au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l’associé décédé.

C. Décisions des associés

Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les

présents statuts.

8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il

détient.

8.3 Dans l’hypothèse où et tant que la Société n’a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui

relèveraient d’ordinaire de la compétence de l’assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.

8.4 En cas d’associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés en vertu des

dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l’assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l’associé unique selon le contexte et le cas échéant et
les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés seront exercés par l’associé unique.

Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l’hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une

assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l’exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée
générale. D’autres assemblées générales d’associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations
aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale des
associés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication pré-
alable.

Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d’un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés

de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital social.

Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement

unanime des associés.

53926

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l’accord d’une (i) majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social.

D. Gérance

Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un

conseil de gérance.

13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n’est pas

expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme
une référence au «gérant unique».

13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute

mesure nécessaire ou utile pour l’accomplissement de l’objet social de la Société, à l’exception des pouvoirs réservés par
la Loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale des associés.

Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l’assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et

la  durée  de  son  (leur)  mandat.  L’assemblée  générale  des  associés  peut  décider  de  nommer  des  gérants  de  différentes
catégories, nommés gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et gérants de catégorie B (les «Gérants de
Catégorie B»). Toute référence faite aux «gérants» devra être entendue comme une référence aux Gérants de Catégorie A
et/ou Gérants de Catégorie B, selon le contexte et le cas échéant.

14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par

une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Art. 15. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
15.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au

siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

15.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures

à l’avance par rapport à l’heure fixée dans la convocation, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs d’une
telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d’accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d’un tel document signé
constituera une preuve suffisante d’un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance
dont le lieu et l’heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d’un précédent conseil de gérance, communiquée
à tous les membres du conseil de gérance.

15.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l’hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés

à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l’hypothèse de décisions écrites et approu-
vées par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 16. Conduite des réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner

un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance.

16.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,

le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.

16.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme

son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du
mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l’intégralité des membres
du conseil de gérance.

16.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout

autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans
discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s’être tenue
au siège social de la Société.

16.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente

ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Dans le cas où l’assemblée générale des associés a nommé plusieurs
classes de gérants, Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres
est présente ou représentée, en ce inclus au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B.

16.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de

gérance. Dans le cas où l’assemblée générale des associés a nommé plusieurs classes de gérants, les décisions sont prises
à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, en ce inclus au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1)
Gérant de Catégorie B. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d’une voix prépondérante.

53927

L

U X E M B O U R G

16.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l’ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions
sera la date de la dernière signature.

Art. 17. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
17.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par (i) le président, le cas échéant,

ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou (ii) un (1) Gérant de Catégorie A et un
(1) Gérant de Catégorie B, si applicable, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront
être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par un (1) Gérant de Catégorie A et un (1)
Gérant de Catégorie B, si applicable, ou par deux (2) gérants.

17.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés
par le gérant unique.

Art. 18. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par

la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de un (1) Gérant de Catégorie
A et un (1) Gérant de Catégorie B, si applicable, ou par deux (2) gérants, ou (ii) par la signature conjointe ou la seule
signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance,
dans les limites de cette délégation.

E. Audit et surveillance

Art. 19. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
19.1 Dans l’hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront

surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la
durée de leurs fonctions.

19.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.
19.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
19.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69

de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.

19.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif

ou avec son accord.

F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 20. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le

trente-et-un décembre de la même année.

Art. 21. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
21.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif

et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

21.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.

21.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve

légale, si cet associé consent à cette affectation.

21.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

21.5  Sur  proposition  du  conseil  de  gérance,  l'assemblée  générale  des  associés  décide  de  l’affectation  du  solde  des

bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

21.6 En cas de distribution, les montants distribués seront répartis comme suit:
(i) les Parts Sociales de Catégorie A donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant un

virgule neuf pour cent (1,9%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie A émises par la Société;

(ii) les Parts Sociales de Catégorie B donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant un

virgule huit pour cent (1,8%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie B émises par la Société;

(iii) les Parts Sociales de Catégorie C donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant

un virgule sept pour cent (1,7%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie C émises par la Société;

(iv) les Parts Sociales de Catégorie D donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant

un virgule six pour cent (1,6%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie D émises par la Société;

53928

L

U X E M B O U R G

(v) les Parts Sociales de Catégorie E donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant un

virgule cinq pour cent (1,5%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie E émises par la Société;

(vi) les Parts Sociales de Catégorie F donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant un

virgule quatre pour cent (1,4%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie F émises par la Société;

(vii) les Parts Sociales de Catégorie G donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant

un virgule trois pour cent (1,3%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie G émises par la Société;

(viii) les Parts Sociales de Catégorie H donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant

un virgule deux pour cent (1,2%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie H émises par la Société;

(ix) les Parts Sociales de Catégorie I donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant un

virgule un pour cent (1,1%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie I émises par la Société;

(x) les Parts Sociales de Catégorie J donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant un

pour cent (1%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie J émises par la Société;

chacune d’entre elles et pour autant qu'elles n’auront pas été rachetées, et
(xi) le solde sera distribué à la Catégorie de Parts Sociales Concernée.

Art. 22. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
22.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d’un état comptable

intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social
pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais
diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts
interdisent la distribution.

22.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-

formément à la Loi et aux présents statuts.

G. Liquidation

Art. 23. Liquidation.
23.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l’article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée

par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera
les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l’actif et du passif de la Société.

23.2 Le surplus résultant de la réalisation de l’actif et du passif sera distribué entre les associés en conformité avec les

dispositions de l’article 21 des présents statuts.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2016.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

<i>Souscription et paiement

- Summit Partners Credit Fund II, L.P., susmentionné a souscrit les parts sociales ci-dessous émises par la Société:
(i) un million quatre cent quatre-vingt-onze mille (1.491.000) Parts Sociales de Catégorie A.
(ii) mille (1.000) Parts Sociales de Catégorie B,
(iii) mille (1.000) Parts Sociales de Catégorie C,
(iv) mille (1.000) Parts Sociales de Catégorie D,
(v) mille (1.000) Parts Sociales de Catégorie E,
(vi) mille (1.000) Parts Sociales de Catégorie F,
(vii) mille (1.000) Parts Sociales de Catégorie G,
(viii) mille (1.000) Parts Sociales de Catégorie H,
(ix) mille (1.000) Parts Sociales de Catégorie I, et
(x) mille (1.000) Parts Sociales de Catégorie J.
L’intégralité des un million cinq cent mille (1.500.000) parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par

voie d’apport en numéraire, de sorte que le montant de quinze mille dollars américains (USD 15.000) est dès à présent à
la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

L’apport global d’un montant de quinze mille dollars américains (USD 15.000) est entièrement affecté au capital social.
La preuve de l’existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.

53929

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ EUR 1.500,-.

<i>Résolutions de l’associé

L’associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convo-

cation, a adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 5, rue du Plébiscite, L-2343 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

2. Les personnes suivantes sont nommées gérant pour une durée indéterminée:
(i) James Freeland, né en Pennsylvanie, Etats-Unis d’Amérique le 2 octobre 1976, résidant professionnellement à 222

Berkeley Street, Boston, Massachusetts 02116, Etats-Unis d’Amérique, est nommé Gérant de Classe A;

(ii) Robin Devereux née à Albany, New York, le 9 mars 1959, résidant professionnellement à 222 Berkeley Street,

Boston, Massachusetts 02116, Etats-Unis d’Amérique est nommé Gérant de Classe A;

(iii) Abdoulie Yorro Jallow né(e) à Fajara, Gambia, le 12 février 1975, résidant professionnellement à 421F, route d’Esch,

L-1030 Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg est nommé Gérant de Classe B; et

(iv) Smaïn Bouchareb né(e) à Mulhouse, France, le 19 août 1978, résidant professionnellement à 421F, route d’Esch,

L-1030 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg est nommé Gérant de Classe B.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande du comparant que le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande du même comparant et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. REBHOLZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 14 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/1185. Reçu soixante-quinze euros

(75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 25 janvier 2016.

Référence de publication: 2016057022/692.
(160016572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.

Audrey Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Audrey Germany Investment S.à r.l.).

Capital social: NOK 6.484.624.078,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 198.974.

In the year two thousand and fifteen, on the thirty-first day of December.
Before Us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared

Audrey Topco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a
share capital of one hundred fifty thousand Norwegian Krone (NOK 150,000) being registered with the Registre de Com-
merce et des Sociétés in Luxembourg under number B 201.835, (the “Sole Shareholder”),

represented by Maître Vianney de Bagneaux, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a

proxy which shall remain annexed to the present deed after having been signed ne varietur by the proxyholder and the
undersigned notary,

being the Sole Shareholder of Audrey Holdco S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée with its regis-

tered office at 2-4, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Cosita Delvaux, notary
residing in Luxembourg, dated 17 July 2015, which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the "Mémorial") number 2570 dated 22 September 2015.

The articles of association of the Company were amended for the last time on 20 November 2015 by deed of Maître

Leonie Grethen, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Cosita Delvaux, prenamed, not yet pu-
blished in the Mémorial.

53930

L

U X E M B O U R G

The appearing party, represented as stated above, declared and the notary recorded as follows:
I. That the appearing party is the sole shareholder of the Company and holds all the five hundred shares (500) in issue

in the Company so that the entire share capital is represented and decisions can be validly taken by the Sole Shareholder.

II. That the Sole Shareholder wishes to take a decision on the items of the following agenda:
1. Reclassification of all the five hundred (500) shares with a par value of three hundred Norwegian Krone (NOK 300.-)

each into ordinary shares and amendment of the par value of the shares from three hundred Norwegian Krone (NOK 300.-)
each to one Øre (NOK 0.01) each, so that the share capital of the Company which is currently represented by five hundred
(500) shares with a par value of three hundred Norwegian Krone (NOK 300.-) each, be now represented by fifteen million
(15,000,000) ordinary shares of a par value of Øre (NOK 0.01) each;

2. Creation of a second class of shares, namely the mandatory redeemable preferred class of shares with those rights

and obligations as set forth in the articles of association as amended pursuant to the resolutions taken in accordance with
the terms of the present agenda;

3. Increase of the Company’s share capital from one hundred fifty thousand Norwegian Krone (NOK 150,000) to six

billion  four  hundred  forty-four  million  six  hundred  twenty-four  thousand  seventy-eight  Norwegian  Krone  (NOK
6,484,624,078) by (i) the issuance and the subscription of six billion four hundred sixty-nine million six hundred twenty-
four thousand one hundred (6,469,624,100) ordinary shares (the “Ordinary Shares”), having a nominal value of one Øre
(NOK 0.01) each, for a total subscription price of sixty-four million six hundred ninety-six thousand two hundred forty-
one Norwegian Krone (NOK 64,696,241) (the “Ordinary Shares Subscription Price”) by Audrey Topco S.à r.l. and (ii) the
issuance and the subscription of six hundred forty-one billion nine hundred seventy-seven million seven hundred eighty-
three thousand seven hundred (641,977,783,700) mandatory redeemable preferred shares (the “MRPS”), having a nominal
value of one Øre (NOK 0.01) each, for a total subscription price of six billion four hundred nineteen million seven hundred
seventy-seven thousand eight hundred thirty-seven Norwegian Krone (NOK 6,419,777,837) (the “MRPS Subscription
Price” and together with the Ordinary Shares Subscription Price, the “Subscription Price”) by Audrey Topco S.à r.l., to be
subscribed by way of a contribution in kind consisting in the contribution and transfer of a receivable held by Audrey Topco
S.à r.l. against the Company for an amount of six billion four hundred eighty-four million four hundred seventy-four
thousand seventy-eight Norwegian Krone (NOK 6,484,474,078) (the “Contribution in Kind”); acknowledgement of the
report of the sole manager of the Company dated 31 December 2015 on the valuation of the Contribution in Kind (the
“Valuation Report”); approval of the valuation of the Contribution in Kind and issue of the Ordinary Shares and the MRPS;
payment of the Subscription Price by way of the Contributions in Kind; and, allocation of (i) an amount of sixty-four million
six hundred ninety-six thousand two hundred forty-one Norwegian Krone (NOK 64,696,241) to the share capital account
of the Company for the subscription of the Ordinary Shares and (ii) an amount of six billion four hundred nineteen million
seven hundred seventy-seven thousand eight hundred thirty-seven Norwegian Krone (NOK 6,419,777,837) to the share
capital account of the Company for the subscription of the MRPS;

4. Consequential amendment and restatement of the articles of association of the Company in order to include in parti-

cular but without limitation the rights and obligations of the different classes of shares namely the Ordinary Shares and the
MRPS,  the  reclassification  of  shares  and  such  other  amendments  as  set  forth  therein  (without  amending  however  the
corporate object), so that the articles of association shall read as attached to the proxy.

Thereafter, the Sole Shareholder passed the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to reclassify all the five hundred (500) shares with a par value of three hundred Norwegian

Krone (NOK 300.-) each into ordinary shares and amend the par value of the shares from three hundred Norwegian Krone
(NOK 300.-) each to one Øre (NOK 0.01) each, so that the share capital of the Company which is currently represented by
hundred (500) shares with a par value of three hundred Norwegian Krone (NOK 300.-) each, be now represented by fifteen
million (15,000,000) ordinary shares of a par value of one Øre (NOK 0.01) each (the “Ordinary Shares”);

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to create a second class of shares, namely the mandatory redeemable preferred shares

with those rights and obligations as described in the articles of association of the Company as amended below.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the share capital of the Company from one hundred fifty thousand Norwegian

Krone (NOK 150,000) to six billion four hundred forty-four million six hundred twenty-four thousand seventy-eight Nor-
wegian Krone (NOK 6,484,624,078) by (i) the issuance of six billion four hundred sixty-nine million six hundred twenty-
four thousand one hundred (6,469,624,100) ordinary shares (the “Ordinary Shares”), having a nominal value of one Øre
(NOK 0.01) each, for a total subscription price of sixty-four million six hundred ninety-six thousand two hundred forty-
one Norwegian Krone (NOK 64,696,241) (the “Ordinary Shares Subscription Price”), and (ii) the issuance of six hundred
forty-one  billion  nine  hundred  seventy-seven  million  seven  hundred  eighty-three  thousand  seven  hundred
(641,977,783,700) mandatory redeemable preferred shares (the “MRPS”), having a nominal value of one Øre (NOK 0.01)
each, for a total subscription price of six billion four hundred nineteen million seven hundred seventy-seven thousand eight

53931

L

U X E M B O U R G

hundred thirty-seven Norwegian Krone (NOK 6,419,777,837) (the “MRPS Subscription Price” and together with the Or-
dinary Shares Subscription Price, the “Subscription Price”).

Thereupon the Sole Shareholder, represented by [Me Vianney de Bagneaux] pursuant to a proxy dated 31 December

2015 (the proxy given shall be initialled ne varietur by the notary and shall be attached to the present deed and registered
therewith), has fully subscribed to all (i) the Ordinary Shares of a nominal value of one Øre (NOK 0.01) and (ii) the MRPS
of a nominal value of one Øre (NOK 0.01) and the corresponding Subscription Price has been paid to the Company by way
of the Contribution in Kind.

The Contributions in Kind is valued based on the Valuation Report at an aggregate amount of six billion four hundred

eighty-four million four hundred seventy-four thousand seventy-eight Norwegian Krone (NOK 6,484,474,078).

The conclusion of the Valuation Report is as follows:
“On the basis of the aforementioned, the Sole Manager considers that the documentation and assurance received provide

adequate substantiation as to the existence and extent of the Contribution in Kind.

The Sole Manager is of the opinion that the Contribution in Kind as described above is equal to an aggregate amount

of six billion four hundred eighty-four million four hundred seventy-four thousand seventy-eight Norwegian Krone (NOK
6,484,474,078) which corresponds at least to the nominal value of the six billion four hundred sixty-nine million six hundred
twenty-four thousand one hundred (6,469,624,100) Ordinary Shares and the six hundred forty-one billion nine hundred
seventy-seven million seven hundred eighty-three thousand seven hundred (641,977,783,700) MRPS to be issued by the
Company.

Therefore the Sole Manager proposes to the Sole Shareholder to value the Contribution in Kind at six billion four hundred

eighty-four million four hundred seventy-four thousand seventy-eight Norwegian Krone (NOK 6,484,474,078).”

The Sole Shareholder has confirmed that the Contribution in Kind is at least equal to the value of the Ordinary Shares

and the MRPS to be issued by the Company in consideration therefore.

Proof of the Contribution in Kind and the payment of the Subscription Price of six billion four hundred eighty-four

million four hundred seventy-four thousand seventy-eight Norwegian Krone (NOK 6,484,474,078) by such Contribution
in Kind has been shown to the undersigned notary.

Out of the Subscription Price, the Sole Shareholder resolved to allocate (i) an amount of sixty-four million six hundred

ninety-six thousand two hundred forty-one Norwegian Krone (NOK 64,696,241), equal to the Ordinary Shares Subscription
Price, to the share capital account of the Company for the subscription of the Ordinary Shares and (ii) an amount of six
billion four hundred nineteen million seven hundred seventy-seven thousand eight hundred thirty-seven Norwegian Krone
(NOK 6,419,777,837), equal to the MRPS Subscription Price, to the share capital account of the Company for the sub-
scription of the MRPS.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to amend and restate the articles of association of the Company in particular without

limitation the rights and obligations of the different classes of shares namely the Ordinary Shares and the MRPS, the
reclassification of shares and such other amendments as set forth therein (without amending however the corporate object)
so that they shall read as attached to the proxy, i.e. as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) with the name “Audrey

Holdco S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.

The  Company  may  also  carry  out  all  transactions  pertaining  directly  or  indirectly  to  the  acquisition  of  real  estate,

properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.

The Company may further give guarantees (including up-stream and sidestream guarantees), grant security interests,

grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the
same group of companies as the Company.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance

money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such

53932

L

U X E M B O U R G

lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly

in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered. Office The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.  It  may  be  transferred  to  any  other  place  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  by  means  of  a  resolution  of  an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case

may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,

economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital.
5.1 The issued share capital of the Company is set at six billion four hundred eighty-four million six hundred twenty-

four thousand seventy-eight Norwegian Krone (NOK 6,484,624,078) represented by:

- six billion four hundred forty-four million six hundred twenty-four thousand one hundred (6,484,624,100) ordinary

shares with a nominal value of one Øre (NOK 0.01) each (the “Ordinary Shares”); and

- six hundred forty-one billion nine hundred seventy-seven million seven hundred eighty three thousand seven hundred

(641,977,783,700) mandatory redeemable preferred shares with a nominal value of one Øre (NOK 0.01) each (the “MRPS”
and together with the Ordinary Shares, the “Shares”).

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner

required for amendment of these articles of association, subject to and in accordance with the provisions of these articles
of association including, as to reductions of capital, through the cancellation of Ordinary Shares or MRPS and the Company
may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders.

5.2 Any payment made by the shareholder(s) upon an issue of Ordinary Shares in excess of the nominal value of the

Ordinary Shares then issued shall be allocated to a related share premium account (the “Ordinary Share Premium”). Any
payment made by the shareholder(s) upon an issue of MRPS in excess of the nominal value of the MRPS then issued shall
be  allocated  to  a  related  share  premium  account  (the  “MRPS  Share  Premium”,  and  together  with  the  Ordinary  Share
Premium, the “Share Premium”).

The shareholder(s) shall make additional capital contributions (without a related issue of shares) in relation to, as the

case may be, the Ordinary Shares (the “Ordinary Share Capital Contributions”) to be allocated to the Ordinary Share Capital
Contributions account, or the MRPS (the “MRPS Capital Contributions”, and together with the Ordinary Share Capital
Contributions, the “Share Capital Contributions”) to be allocated to MRPS Capital Contributions account.

Any available share premium (including the Ordinary Share Premium, the MRPS Share Premium, the Ordinary Share

Capital Contributions and the MRPS Capital Contributions) shall be distributable.

5.3 Rights attached to the Shares
5.3.1 Each MRPS entitles a holder thereof (the “MRPS Holder”), in priority to the payment of dividends to the holders

of Ordinary Shares, to a first annual preferential cumulative distribution right (the “First Dividend”) equal to an annual rate
of 0.5%% (the “MRPS Rate”) of (i) the nominal value of the share capital represented by such MRPS, (ii) the related MRPS
Share Premium and (iii) the MRPS Capital Contributions (the “MRPS Amount”) o. The MRPS Distribution Rights arise
daily from the Date of Issuance of such MRPS and shall be calculated assuming a year of 365 days. The MRPS Distribution
Rights not declared and not paid shall accumulate (but shall not be due until declaration thereof has been made).

5.3.2 Secondly, each MRPS entitles a MRPS Holder to a second preferential and cumulative dividend (the “Second

Dividend”), which shall accrue daily from the date of acquisition by the Company of Underlying Assets and shall be
calculated assuming a year of 360 days. The Second Dividend shall be equal to 99% of the (i) capital gains (including
foreign exchange gains) realised by the Company (recorded during the relevant financial period of the Company according
to Luxembourg GAAP) and deriving from each of the Underlying Assets and financed by the MRPS or income derived

53933

L

U X E M B O U R G

from the MRPS, less (ii) the amount corresponding to the First Dividend (the “Difference”). The Second Dividend per
MRPS will be the amount of the Difference divided by the total number of outstanding MRPS.

For the purpose of this article, Underlying Assets means the financial assets (including loans, shares and similar equity

instruments) acquired by the Company or to be acquired and financed by the Company directly or indirectly (further to a
contribution in kind or by the capitalization of outstanding dividends payable) by the proceeds of the issuance of the MRPS,
including MRPS Share Premium, and MRPS Capital Contributions, as the case may be, and/or any other financial assets
replacing any such financial assets, or purchased or financed with the income or proceeds arising out of such financial
assets or of a disposal of all or part of such financial assets.

5.3.3  The  First  Dividend  and  Second  Dividend  (the  “MRPS  Distribution  Rights”)  shall  arise  only  (i)  when  and  as

recommended by the board of managers of the Company provided that the Company has sufficient distributable reserves
or profits (for the avoidance of doubt, including but not limited to the MRPS Share Premium) and declared by general
meeting of the shareholders or by the sole shareholder (as the case may be) (each a “MRPS Dividend Payment Date”) or
(ii) upon redemption of the MRPS in accordance with article 5.3 or (iii) upon winding-up or liquidation of the Company.

No MRPS Distribution Rights shall be paid if at the time of the distribution the Company does not have sufficient

distributable reserves or profits to make such distribution and not sufficient liquid assets to cover its current expenses after
each MRPS Distribution Rights payment is made.

Any Share Premium or Share Capital Contributions or any freely distributable reserves may be distributed to the sha-

reholders upon a decision of the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) in accordance
with the provisions of this article. The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may
decide  to  distribute  any  amount  of  the  Share  Premium  or  Share  Capital  Contributions  regardless  whether  such  Share
Premium or Share Capital Contribution is related to the Ordinary Shares or related to the MRPS.

Should the profits or distributable reserves be sufficient to distribute a MRPS Distribution Rights, in whole or in part,

and the shareholder, or in case of plurality of shareholders, the general meeting, decides to make no distribution with respect
to such MRPS Distribution Rights, the amount of the MRPS Distribution Rights that should have been distributed to the
MRPS Holder shall be automatically allocated to a distributable reserve booked in a MRPS reserve account (hereinafter
referred to as the “MRPS Reserve Account”).

5.3.4 Subject to the decision of the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be), the

MRPS are redeemable (the “Final Redemption”) on the date falling 10 years from the date of their issuance (the “Final
Redemption Date”).

Any MRPS Holder may request in writing and the board of managers of the Company may propose to the general

meeting of the shareholders of the Company, that the Company redeems all or part of the MRPS held by such MRPS Holder
prior to the Final Redemption Date (the “Optional Redemption”).

The Optional Redemption and the Final Redemption shall be submitted to the decision of the general meeting of sha-

reholders on the requested date subject to there being sufficient amounts available for such redemption (being, for the
avoidance of doubt, the nominal value of the MRPS and the part of the legal reserve related thereto, the MRPS Share
Premium, MRPS Capital Contributions and other distributable reserves).

The redemption price per MRPS is payable in cash or in kind and will be equal to (a) the accumulated unpaid MRPS

Distribution Rights of such MRPS at the time of the redemption plus (b) the MRPS Amount plus (c) the MRPS Reserve
Account plus (d) any amount of the MRPS Distribution Rights that should have been distributed to the MRPS Holder but
not allocated to the MRPS Reserve Account (the “Redemption Price”).

If, in case of Final Redemption (excluding, for the avoidance of doubt the Optional Redemption) there are no sufficient

available funds for the redemption of all the MRPS, only part of the MRPS (as the case may be) shall be redeemed within
the limits of the available funds, with an obligation for the Company to immediately redeem, in priority to any payment to
the  holder(s)  of  Ordinary  Shares  (the  “Ordinary  Shareholder(s)”),  the  residual  portion  of  the  MRPS  as  and  when  the
Company will have sufficient funds for redemption at a price per residual MRPS equal to the Redemption Price.

5.3.5 The MRPS Holder(s) entire entitlement to dividends, other distributions and/or redemptions is limited as specified

in this article 5.3 and provided the amounts required to be paid to the MRPS Holder (s) under this article 5.3 have been
paid, any distributions, whether by way of interim dividend, dividend or return of contributions or premium, shall be made
exclusively to the Ordinary Shareholder. For the avoidance of doubt, distributions out of the Ordinary Share Premium and
the Ordinary Share Capital Contributions can be carried out, provided that the Company has sufficient distributable reserves
and subject to the approval of the general meeting of shareholders (or the sole shareholder (as the case may be)), even in
the absence of distributions to the MRPS Holder(s) in accordance with article 5.3.

No decimal of Ordinary Shares will be available. The board of managers of the Company may (in case of decimals)

either round up or round down to the closest appropriate number of Ordinary Shares.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%)
of the Company's share capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be

shareholders.

53934

L

U X E M B O U R G

The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business

of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.

Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to

act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-

holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,

by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.

As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the

board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.

53935

L

U X E M B O U R G

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of

the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal

to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed

by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in

the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed

in  the  register  of  shareholders  held  by  the  Company  at  least  eight  (8)  days  before  the  proposed  effective  date  of  the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions  (or  subject  to  the  satisfaction  of  the  majority  requirements,  on  the  date  set  out  therein).  Unanimous  written
resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to

become a shareholder of the Company.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on 31 

st

 December of the

same year, save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

 December

2015.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account. The Ordinary Share Premium, the Ordinary Share Capital Contributions, the MRPS Share Premium and
the MRPS Capital Contributions may be distributed to allow distributions (including interim dividend distributions) in the
absence of distributable profits in accordance with these articles of association.

No distribution shall be made to the holders of the Ordinary Shares unless the First Dividend and the Second Dividend

have been paid.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

In the event of any liquidation, dissolution or winding up of the Company, after payment of all third party debts and

liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the MRPS Holder(s) will first, and in priority to any
entitlement of the Ordinary Shareholder(s), be entitled to the aggregate or residual Redemption Price as calculated in
accordance with article 5.3.4 The MRPS Holder will not have any other rights to liquidation proceeds, the balance of which,
if any, exclusively reverts to the Ordinary Shareholder(s).

53936

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies;

in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated

at EUR 7,700.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,

these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and German version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Englischen Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am einunddreißigsten Tag des Monats Dezember,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen,

Audrey Topco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen

Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschafts-
kapital von einhundertfünfzigtausend Norwegischen Kronen (NOK 150.000) beträgt und die eingetragen ist im Registre
du Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Handels- und Gesellschaftsregister) von und zu Luxemburg unter der Nummer
B 201.835 (der „Alleinige Gesellschafter“),

hier vertreten durch Herrn Vianney de Bagneaux, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer

privatschriftlichen Vollmacht, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde
eingereicht zu werden,

als Alleiniger Gesellschafter der Audrey Holdco S.à r.l. (die „Gesellschaft“), einer société à responsabilité limitée mit

Gesellschaftssitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet am 17. Juli
2015 durch einen Akt von Maître Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (das «Mémorial»), Nummer 2570 vom 22. September 2015.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 20. November 2015 abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch

Maître Leonie Grethen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, in Vertretung von Maître Cosita Delvaux, wie oben genannt,
noch nicht im Mémorial veröffentlicht.

Der Erschienene gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar Folgendes zu beurkunden:
I. Der Erschienene ist der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft und besitzt alle fünfhundert (500) von der Gesell-

schaft ausgegebenen Gesellschaftsanteile, sodass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und der Alleinige Gesell-
schafter wirksam über alle Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

II. Die Punkte, über welche Beschlüsse getroffen werden sollen, lauten wie folgt:
1. Re-klassifizierung der fünfhundert (500) existierenden Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je dreihundert

Norwegischen Kronen (NOK 300) in Stammanteile und Abänderung des Nennwerts der Gesellschaftsanteile von je drei-
hundert Norwegischen Kronen (NOK 300) auf je einen Norwegischen Øre (NOK 0,01), sodass das Gesellschaftskapital,
das zurzeit in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je dreihundert Norwegischen Kronen (NOK
300) eingeteilt ist, jetzt in fünfzehn Millionen (15,000,000) Stammanteile mit einem Nennwert von je einem Norwegischen
Øre (NOK 0,01) eingeteilt ist;

2. Schaffung einer zweiten Klasse von Gesellschaftsanteilen, und zwar der verpflichtend rückkaufbaren Vorzugsanteile

(mandatory redeemable preferred shares) mit solchen Rechten und Pflichten wie in der, den Beschlüssen dieser Tages-
ordnung folgend, abgeänderten Fassung der Gesellschaftssatzung dargelegt;

3. Erhöhung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals von dem aktuellen Betrag von einhundertfünfzigtausend Norwe-

gischen Kronen (NOK 150.000) auf sechs Milliarden vierhundertvierundachtzig Millionen sechshundertvierundzwanzig-
tausendachtundsiebzig  Norwegischen  Kronen  (NOK  6.484.624.078)  durch  Ausgabe  und  Zeichnung  von  (i)  sechs
Milliarden  vierhundertneunundsechzig  Millionen  sechshundertvierundzwanzigtausendeinhundert  (6.469.624.100)
Stammanteile (die „Stammanteile“) mit einem Nennwert von je einem Øre (NOK 0,01) für einen Gesamtzeichnungspreis
in  Höhe  von  vierundsechzig  Millionen  sechshundertsechsundneunzigtausendzweihunderteinundvierzig  Norwegischen
Kronen (NOK 64.696.241) (der „Stammanteile - Zeichnungspreis“) durch Audrey Topco S.à r.l. und durch Ausgabe und
Zeichnung von (ii) sechshunderteinundvierzig Milliarden neunhundertsiebenundsiebzig Millionen siebenhundertdreiun-
dachtzigtausendsiebenhundert (641.977.783.700) verpflichten Rückkaufbaren Anteilen (die „MRPS“) mit einem Nennwert
von je einem Øre (NOK 0,01), für einen Gesamtzeichnungspreis in Höhe von sechs Milliarden vierhundertneunzehn Mil-

53937

L

U X E M B O U R G

lionen  siebenhundertsiebenundsiebzigtausendachthundertsiebenundreißig  Norwegischen  Kronen  (NOK  6.419.777.837)
(der „MRPS-Zeichnungspreis“ und zusammen mit dem Stammanteile - Zeichnungspreis, der „Zeichnungspreis“) durch
Audrey Topco S.à r.l. durch Sacheinlage, bestehend aus dem Beitrag einer Forderung des Alleinigen Gesellschafters ge-
genüber der Gesellschaft für den Gesamtbetrag von sechs Milliarden vierhundertvierundsiebzig Millionen achtundsiebzig
Norwegischen Kronen (NOK 6.484.474.078) (die „Sacheinlage“); Bestätigung des Berichts des alleinigen Geschäftsführers
der  Gesellschaft,  datiert  auf  den  31.  Dezember  2015  über  die  Bewertung  der  Sacheinlage  (der  „Bewertungsbericht“);
Genehmigung der Bewertung der Sacheinlagen und Ausgabe der Stammanteile und MRPS; Zahlung des Zeichnungspreises
durch die Sacheinlage; und, Zuweisung der Summe von vierundsechzig Millionen sechshundertsechsundneunzigtausend-
zweihunderteinundvierzig Norwegischen Kronen (NOK 64.696.241) für die Zeichnung der Stammanteile in das Gesell-
schaftskapitalkonto sowie die Summe von sechs Milliarden vierhundertneunzehn Millionen siebenhundertsiebenundsieb-
zigtausendachthundertsiebenundreißig Norwegischen Kronen (NOK 6.419.777.837) in das Gesellschaftskapitalkonto für
die Zeichnung der MRPS;

4. Folgeänderung und Neufassung der Satzung der Gesellschaft um, insbesondere, aber nicht ausschließlich, die Rechte

und Pflichten der unterschiedlichen Anteilsklassen hinzuzufügen, und zwar der Stammanteile und MRPS, die Re-klassi-
fizierung der Anteile und sonstige Änderungen wie darin festgelegt (ohne jedoch den Gesellschaftszweck zu ändern), sodass
die Satzung wie in der Anlage zur Vollmacht ausgelegt lautet:

Woraufhin der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse trifft:

<i>Erster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, alle fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je

dreihundert Norwegischen Kronen (NOK 300) in Stammanteile zu re-klassifizieren und den Nennwert der Gesellschafts-
anteile von je dreihundert Norwegischen Kronen (NOK 300) auf je einen Norwegischen Øre (NOK 0,01) abzuändern,
sodass das Gesellschaftskapital, das zurzeit in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je dreihun-
dert Norwegischen Kronen (NOK 300) eingeteilt ist, jetzt in fünfzehn Millionen (15,000,000) Stammanteile mit einem
Nennwert von je einem Norwegischen Øre (NOK 0,01) eingeteilt ist (die „Stammanteile“).

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, eine zweite Klasse von Gesellschaftsanteilen zu schaffen, und zwar die

verpflichtend rückkaufbaren Vorzugsanteile (mandatory redeemable preferred shares) mit solchen Rechten und Pflichten
wie in der hierunter beschlossenen abgeänderten Fassung der Gesellschaftssatzung beschrieben.

<i>Dritter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen das ausgegebene Gesellschaftskapital von aktuell einhundertfünfzigtau-

send  Norwegischen  Kronen  (NOK  150.000)  auf  sechs  Milliarden  vierhundertvierundachtzig  Million  sechshundertvie-
rundzwanzigtausendachtundsiebzig Norwegischen Kronen (NOK 6.484.624.078) zu erhöhen und dies durch die Ausgabe
von  (i)  sechs  Milliarden  vierhundertneunundsechzig  Millionen  sechshundertvierundzwanzigtausendeinhundert
(6.469.624.100) Stammanteile (die „Stammanteile“) mit einem Nennwert von je einem Norwegischen Øre (NOK 0,01) für
einen Gesamtzeichnungspreis in Höhe von vierundsechzig Millionen sechshundertsechsundneunzigtausendzweihunder-
teinundvierzig Norwegischen Kronen (NOK 64.696.241) (der „Stammanteile - Zeichnungspreis“) sowie die Ausgabe von
(ii) sechshunderteinundvierzig Milliarden neunhundertsiebenundsiebzig Millionen siebenhundertdreiundachtzigtausend-
siebenhundert (641.977.783.700) verpflichten Rückkaufbaren Anteilen (die „MRPS“) mit einem Nennwert von je einem
Øre (NOK 0,01), für einen Gesamtzeichnungspreis in Höhe von sechs Milliarden vierhundertneunzehn Millionen sieben-
hundertsiebenundsiebzigtausendachthundertsiebenundreißig  Norwegischen  Kronen  (NOK  6.419.777.837)  (der
„MRPSZeichnungspreis“ und zusammen mit dem Stammanteile - Zeichnungspreis, der „Zeichnungspreis“).

Daraufhin  hat  der  Alleinige  Gesellschafter,  vertreten  durch  Maître  Vianney  de  Bagneaux,  Rechtsanwalt,  beruflich

wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 31. Dezember 2015, welche vor-
liegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden, alle Stammanteile mit
einem Nennwert von je einem Norwegischen Øre (NOK 0,01) und alle MRPS mit einem Nennwert von je einem Norwe-
gischen Øre (NOK 0,01) gezeichnet und der entsprechende Zeichnungsbetrag wurde der Gesellschaft durch die Sacheinlage
gezahlt.

Die Sacheinlage wird auf Grundlage des Bewertungsberichtes auf den Gesamtbetrag von sechs Milliarden vierhundert-

vierundsiebzig Millionen achtundsiebzig Norwegischen Kronen (NOK 6.484.474.078) geschätzt.

Die Schlussfolgerungen des Bewertungsberichtes sind wie folgt:
„Im Hinblick auf das Vorgenannte, ist der Alleinige Geschäftsführer der Annahme, dass die erhaltene Dokumentation

sowie Sicherheiten, eine adäquate Substanz bezüglich der Existenz und des Ausmaßes der Sacheinlage bieten.

Der Alleinige Geschäftsführer ist der Annahme, dass sich der Wert der Sacheinlage wie oben beschrieben auf sechs

Milliarden  vierhundertvierundsiebzig  Millionen  achtundsiebzig  Norwegischen  Kronen  (NOK  6.484.474.078)  beläuft,
welches mindestens dem Gesamtzeichnungspreis der sechs Milliarden vierhundertneunundsechzig Millionen sechshun-
dertvierundzwanzigtausendeinhundert (6.469.624.100) von der Gesellschaft ausgegebenen Stammanteile und der sechs-
hunderteinundvierzig Milliarden neunhundertsiebenundsiebzig Millionen siebenhundertdreiundachtzigtausendsiebenhun-
dert (641.977.783.700) von der Gesellschaft ausgegebenen MRPS entspricht, der zur Ausgabe vorgeschlagen wurde.

53938

L

U X E M B O U R G

Folglich, schlägt der alleinige Geschäftsführer dem Alleinigen Gesellschafter vor, die Sacheinlage auf sechs Milliarden

vierhundertvierundsiebzig Millionen achtundsiebzig Norwegischen Kronen (NOK 6.484.474.078) zu bewerten.“ Die er-
scheinende Partei bestätigt, dass die Sacheinlagen mindestens dem Wert der von der Gesellschaft in Gegenleistung dafür
auszugebenden Stammanteile und MRPS entsprechen.

Beweis der Sacheinlage und der Zahlung des Zeichnungspreises in Höhe von sechs Milliarden vierhundertvierundsiebzig

Millionen achtundsiebzig Norwegischen Kronen (NOK 6.484.474.078) wurde dem unterzeichnenden Notar vorgelegt.

Der  Alleinige  Gesellschafter  beschließt  aus  dem  Zeichnungspreis  vierundsechzig  Millionen  sechshundertsechsund-

neunzigtausendzweihunderteinundvierzig Norwegischen Kronen (NOK 64.696.241) welche dem Stammanteile -Zeich-
nungspreis entsprechen dem Gesellschaftskapitalkonto zuzufügen für die Zeichnung der Stammanteile, sowie den Saldo
in  Höhe  von  sechs  Milliarden  vierhundertneunzehn  Millionen  siebenhundertsiebenundsiebzigtausendachthundertsiebe-
nundreißig Norwegischen Kronen (NOK 6.419.777.837), welche dem MRPS - Zeichnungspreis entsprechen, dem Gesell-
schaftskapitalkonto für die Zeichnung der MRPS hinzuzufügen.

<i>Vierter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen die Satzung der Gesellschaft abzuändern und neu zu fassen um, insbe-

sondere, aber nicht ausschließlich, die Rechte und Pflichten der unterschiedlichen Anteilsklassen hinzuzufügen, und zwar
der Stammanteile und der MRPS, die Re-klassifizierung der Anteile und sonstige Änderungen wie im Anhang zu der
Vollmacht festgelegten Art und Weise hinzuzufügen (ohne jedoch den Gesellschaftszweck zu ändern), so dass die Satzung
wie folgt lautet:

Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Na-

men ??Audrey Holdco S.à r.l.“ (die „Gesellschaft“) wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die
zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die entspre-
chende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-

und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Ver-
waltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen, welche sich direkt oder indirekt auf den Erwerb von Grundbesitz,

Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben (einschließlich up-stream und sidestream Bürgschaften), Sicherheiten leisten,

Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften, an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die
zur Gruppe von Gesellschaften gehören, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen vergeben, Kapital in jeder be-

liebigen Form verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-
liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und
alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
Lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-

denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Insbesondere wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und Auf-

sicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,

durch  Beschluss  einer  außerordentlichen  Gesellschafterversammlung  die  sich,  in  der  für  die  Abänderung  der  Satzung
vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

53939

L

U X E M B O U R G

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-

schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-

liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende
solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung
auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf sechs Milliarden vierhundertvierundachtzig

Millionen sechshundertvierundzwanzigtausendachtundsiebzig Norwegischen Kronen (NOK 6.484.624.078), eingeteilt in:

sechs 

Milliarden 

vierhundertvierundachtzig 

Millionen 

sechshundertvierundzwanzigtausendeinhundert

(6.484.624.100) Stammanteile mit einem Nennwert von je einem Norwegischen Øre (NOK 0,01) (die „Stammanteile“);
und

- sechshunderteinundvierzig Milliarden neunhundertsiebenundsiebzig Millionen siebenhundertdreiundachtzigtausend-

siebenhundert (641.977.783.700) verpflichtend rückkaufbare Vorzugsanteile mit einem Nennwert von je einem Norwe-
gischen Øre (NOK 0,01) (die „MRPS“ und zusammen mit den Stammanteilen, die „Anteile“).

Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen

Art und Weise erhöht oder verringert werden, vorbehaltlich und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Satzung
einschließlich, in Bezug auf Kapitalherabsetzungen, durch die Annullierung von Stammanteilen oder MRPS und die Ge-
sellschaft kann ihre anderen Gesellschaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

5.2. Jede Zahlung des Gesellschafters/ der Gesellschafter nach Ausgabe von Stammanteilen über dem Nennwert der

dann ausgegebenen Stammanteile soll dem betreffenden Agio (das „Stammagio“) zugeteilt werden. Jede Zahlung des
Gesellschafters/ der Gesellschafter nach Ausgabe von MRPS über dem Nennwert der dann ausgegebenen MRPS soll dem
betreffenden Agio (das „MRPS-Agio“ und, zusammen mit dem Stammagio, das „Agio“) zugeteilt werden.

Der/die Gesellschafter sollen in Bezug auf die Stammanteile zusätzliche Kapitaleinlagen leisten (ohne Ausgabe von

Anteilen) (die „Stammkapitaleinlagen“), die dem Stammkapitaleinlagenkonto zugeteilt werden sollen, oder, in Bezug auf
die MRPS (die „MRPS-Kapitaleinlagen“ und zusammen mit den Stammkapitaleinlagen, die „Kapitaleinlagen“), die dem
MRPS-Kapitaleinlagenkonto zugeteilt werden.

Jedes verfügbare Agio (einschließlich des Stammagios, des MRPS-Agios, der Stammkapitaleinlagen und der MRPS-

Kapitaleinlagen) ist frei ausschüttbar.

5.3 Mit den Anteilen verbundene Rechte
5.3.1 Jeder MRPS berechtigt seinen Inhaber (der „MRPS-Inhaber“) bevorzugt zu Zahlung von Dividenden an Inhaber

von Stammanteilen, zu einem ersten jährlichen bevorzugten und kumulativen Distributionsrecht (die „Erste Dividende“)
mit einem Jahressatz von 0,5% (die „MRPS-Rate“) (i) des Nennwerts des in solche MRPS eingeteilten Gesellschaftska-
pitals, (ii) des betreffenden MRPSAgios und (iii) der MRPS-Kapitaleinlagen (der „MRPS-Betrag“). Die MRPSAusschüt-
tungsrechte entstehen täglich ab dem Tag der Ausgabe solcher MRPS und werden unter Annahme eines Jahres von 365
Tagen berechnet. Die nicht angegebenen und nicht bezahlten MRPS-Ausschüttungsrechte werden zusammengerechnet
(sind aber nicht fällig bis zu ihrer Deklaration).

5.3.2 Zweitens berechtigt jedes MRPS einen MRPS-Inhaber zu einer zweiten bevorzugten und kumulativen Dividende

(die „Zweite Dividende“), die ab dem Tage des Erwerbs der zugrunde liegenden Vermögenswerte durch die Gesellschaft
täglich anfallen und auf der Basis eines 360-Tage-Jahres berechnet werden sollen. Die Zweite Dividende entspricht 99%
(i)  der  Kapitalgewinne  (einschließlich  ausländischer  Währungsgewinne),  die  von  der  Gesellschaft  erzielt  worden  sind
(aufgezeichnet während der relevanten Finanzperiode der Gesellschaft nach luxemburgischem GAAP) und die auf den
zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen und durch die MRPS oder durch aus den MRPS stammendes Einkommen
finanziert wurde, abzüglich (ii) des Betrags, der der Ersten Dividende entspricht (die „Differenz“). Die Zweite Dividende
pro MRPS entspricht dem Betrag der Differenz geteilt durch die Gesamtzahl der ausgegebenen MRPS.

Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnen die zugrunde liegenden Vermögenswerte diejenigen Vermögenswerte (ein-

schließlich Darlehen, Anteilen und ähnliche Eigenkapitalinstrumente), die von der Gesellschaft erworben wurden oder von
der Gesellschaft direkt oder indirekt erworben und finanziert werden sollen (durch eine Sacheneinlage oder durch die
Kapitalisierung zahlbarer ausstehender Ausschüttungen) durch den Erlös der Ausgabe der MRPS, einschließlich MRPSA-
gio, MRPS-Kapitaleinlagen und/oder andere Vermögenswerte, die diese Vermögenswerte ersetzen, oder die mit dem Ertrag
oder den Erlösen aus solchen Vermögenswerten oder durch die Veräußerung von allen oder einem Teil dieser Vermö-
genswert erworben oder finanziert worden sind.

5.3.3 Die Erste Dividende und die Zweite Dividende (die „MRPSAusschüttungsrechte“) sollen nur entstehen (i) wenn

und wie von der Gesellschaftsführung vorgeschlagen, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft über hierfür ausreichende aus-

53940

L

U X E M B O U R G

schüttbare Reserven oder Gewinne verfügt (dies, um jeden Zweifel auszuschließen, einschließlich des MRPS-Agios), und
auf Beschluss der Gesellschafterversammlung oder, gegebenenfalls, des Alleinigen Gesellschafters (jeweils ein „MRPS-
Dividenden-Ausschüttungstag“) oder (ii) im Falle eines Rückkaufs von MRPS in Übereinstimmung mit Artikel 5.3 oder
(iii) im Falle der Auflösung oder Liquidation der Gesellschaft.

Keine MRPS-Ausschüttungsrechte sollen gezahlt werden, falls die Gesellschaft nicht über für eine solche Zahlung

ausreichende ausschüttbare Reserven oder Gewinne und, nach einer Zahlung solcher MRPS-Ausschüttungsrechte, über
ausreichende liquide Vermögenswerte für die Begleichung laufender Ausgaben verfügt.

Sämtliches Agio sowie sämtliche Kapitaleinlagen und andere frei ausschüttbare Reserven können auf Beschluss der

Gesellschafterversammlung oder, gegebenenfalls, des Alleinigen Gesellschafters, in Übereinbestimmung mit den Bestim-
mungen dieses Artikels, an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Die Gesellschafterversammlung oder, gegebenenfalls,
der Alleinige Gesellschafter, kann beschließen, jedweden Betrag aus dem Agio oder den Kapitaleinlagen zu verteilen,
unabhängig davon ob ein solchesAgio oder solche Kapitaleinlagen mit den Stammanteilen oder den MRPS verbunden sind.

Sollten die Gewinne ausreichen um MRPS-Ausschüttungsrechte auszuzahlen, im Ganzen oder zum Teil, und der Al-

leingesellschafter oder, im Falle mehrerer Gesellschafter, die Gesellschafterversammlung, entscheiden keine Auszahlung
solcher MRPS-Ausschüttungsrechte durchzuführen, dann soll der Betrag, der an die MRPS-Inhaber hätte verteilt werden
sollen, automatisch einer ausschüttbaren Reserve in einem MRPS-Reservekonto (nachfolgend das „MRPS-Reservekonto“
genannt) zugewiesen werden.

5.3.4 Gemäß einer Entscheidung der Gesellschafterversammlung oder, gegebenenfalls, des Alleingesellschafters, sind

die MRPS rückkaufbar (der „Finale Rückkauf“) 10 Jahre nach dem Ausgabedatum (das „Finale Rückkaufdatum“).

Jeder MRPS-Inhaber kann schriftlich verlangen und die Gesellschaftsführung kann der Gesellschafterversammlung

vorschlagen, dass die Gesellschaft alle oder einen Teil der MRPS, die von einem solchen MRPS-Inhaber gehalten werden,
vor dem Finalen Rückkaufdatum zurückkauft werden (der „Optionale Rückkauf“).

Der Optionale Rückkauf und der Finale Rückkauf werden der Entscheidung der Gesellschafterversammlung am ge-

wünschten Datum unterbreitet, vorausgesetzt, dass es ausreichende Beträge für eine solchen Rückkauf gibt (solche Beträge
sind, um jeden Zweifel auszuschließen, den Nennwert der MRPS und den damit verbundenen Teil der gesetzlichen Reserve,
des MRPS-Agios, der MRPSKapitaleinlagen und anderer ausschüttbarer Reserven).

Der Rückkaufpreis per MRPS muss in bar oder durch Sacheinlage gezahlt werden und wird (a) der Summe sämtlicher

nicht ausgezahlter MRPSAusschüttungsrechte zum Zeitpunkt des Rückkaufs plus (b) dem MRPS-Betrag plus (c) dem
MRPS-Reservekonto plus (d) sämtliche MRPS-Ausschüttungsrechte, die an den MRPS-Inhaber hätten verteilt aber nicht
dem MRPS-Reservekonto zugeteilt werden sollen, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen MRPS zum Zeitpunkt des
Rückkaufs, entsprechen (der „Rückkaufpreis“).

Falls im Falle eines Finalen Rückkaufs (ausschließlich, um jeden Zweifel auszuschließen, eines Optionalen Rückkaufs)

keine ausreichenden verfügbaren Mittel für den Rückkauf aller MRPS verfügbar sind, soll nur ein Teil der MRPS (gege-
benfalls) innerhalb der Grenzen der verfügbaren Mittel zurückgekauft werden, mit einer Pflicht für die Gesellschaft den
verbleibenden Teil der MRPS, vorrangig jeder Zahlung an die Inhaber von Stammanteilen (die „Stammanteilsinhaber“),
zurückzukaufen sobald die Gesellschaft über ausreichende Mittel für einen solchen Rückkauf zum Rückkaufpreis verfügt.

5.3.5 Die Rechte von MRPS-Inhabern auf Auszahlung von Dividenden und anderer Ausschüttungen oder Rückkäufen

soll beschränkt sein wie in diesem Artikel 5.3 vorgesehen und, sofern sämtliche Beträge ausgezahlt wurden zur Auszahlung
welcher die MRPS-Inhaber im Sinne dieses Artikels 5.3 berechtigt sind, sämtliche weiteren Ausschüttungen, ob durch
Zwischendividenden, Dividenden oder Rückausschüttungen von Kapitaleinlagen oder Agio, sollen ausschließlich an die
Stammanteilsinhaber vorgenommen werden. Ausschüttungen aus dem Stammagio oder den Stammkapitaleinlagen können,
um jeden Zweifel auszuschließen, auf Beschluss der Gesellschafterversammlung (oder, gegebenenfalls, des Alleinigen
Gesellschafters) und vorausgesetzt die Gesellschaft verfügt ausreichende ausschüttbare Reserven, vorgenommen werden,
auch wenn keine Ausschüttungen an MRPS-Inhaber in Übereinstimmung mit Artikel 5.3 vorgenommen wurden.

Es sind keine Dezimalstammanteile für Stammanteile verfügbar. Die Geschäftsführung kann (im Falle von Dezimalen)

auf die nächsthöhere- oder niedrigere Stammanteilanzahl aufrunden oder abrunden.

Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht

anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.

Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die

keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-

gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse

um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im

53941

L

U X E M B O U R G

Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Gesellschafterversammlung gewählt und abberufen,

welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu jeder Zeit
mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der

Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung

mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,

von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig

abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen

Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder
einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich

haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder

leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“
und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen

unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;

(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-

schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder

von der Geschäftsführung genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das

Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern  und  Verwaltern  einer  solchen  Person  dienen.  Nichts  hierin  Enthaltenes  berührt  die  Rechte  zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.

53942

L

U X E M B O U R G

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder

Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.

Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl

seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-

schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.

Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage

vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses

mindestens  acht  (8)  Tage  bevor  der  Beschluss  wirksam  werden  soll,  an  alle  Gesellschafter  an  ihre  im  Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-

schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen

Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember

eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember
2015 enden.

Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die

Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich

vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die  Gesellschafter  können  auf  der  Grundlage  eines  von  dem  alleinigen  Geschäftsführer,  beziehungsweise  der  Ge-

schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet

werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage  zu  übertragen.  Das  Stammagio,  die  Stammkapitaleinlagen,  das  MRPS-Agio  und  die  MRPS-Kapitaleinlagen
können in Übereinstimmung mit dieser Satzung um bei fehlenden ausschüttbaren Gewinnen Ausschüttungen zu ermögli-
chen, (einschließlich Interimsdividende), verteilt werden.

Es soll keine Ausschüttung für die Inhaber von Stammanteilen stattfinden, es sei denn die Erste Dividende und die

Zweite Dividende wurden ausgezahlt.

53943

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-

datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.

Im Falle einer Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft, nach Zahlung aller Schulden und Verbindlichkeiten ge-

genüber Dritten der Gesellschaft oder Hinterlegung von Mitteln zu diesem Zweck sind die MRPS-Inhaber erstrangig, vor
den Ansprüchen der Stammgesellschafter, dem wie in Übereinstimmung mit Artikel 5.3.4 berechneten gesamten oder
zurückbleibenden Rückzahlungspreis berechtigt. Der MRPS-Inhaber hat keine anderen Rechte am Liquidationserlös, des-
sen Saldo, wenn überhaupt, exklusiv dem/den Stammgesellschafter zurückkommt.

Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179

(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.

Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich

nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen oder Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund des vorlie-

genden Beschlusses entstehen, werden ungefähr EUR 7.700,-. betragen.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen

Partei, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-

schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Esch-sur-Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen hat dieser mit dem amtierenden Notar diese

Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: V. DE BAGNEAUX, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 05 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/211. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 25. Januar 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016055625/804.
(160015604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

HICL Infrastructure 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 155.520.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of September.
Before Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared

“INFRASTRUCTURE INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED”, a limited liability company incorporated and exi-

sting under the laws of the United Kingdom, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under the
number 6555131 and having its registered office at 12, Charles II street, SW1Y 4QU London, United Kingdom (“the sole
shareholder”),

here represented by Mrs Caroline RAMIER, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy

given under private seal.

The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of the company HICL Infrastructure 3 S.à r.l., a société à responsabilité

limitée (private limited liability company) incorporated and organised under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg,
with a share capital of CAD 130,000.00 having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg and registered
with the Luxembourg Companies Register under number B 115.520 (“the Company”), incorporated pursuant to a notarial
deed on 15 September 2010, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Association, number 2295 of 27 October
2010. The Articles of incorporation have been amended according to a deed before the undersigned notary on 22 September
2015, not published to the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, yet.

The appearing party, represented as stated here above, representing the whole corporate capital require the notary to act

the following resolutions:

53944

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

It is resolved to create two categories of shares, i.e. the shares of category A and the shares of category B and to transform

the existing 6,500 shares into 6,500 shares of category A.

<i>Second resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of thirty seven Million two hundred fifty seven

thousand eight hundred and forty Canadian Dollars (CAD 37,257,840.00) so as to raise it from its current amount of one
hundred and thirty thousand Canadian Dollars (CAD 130,000.00).- to thirty seven Million three hundred eighty seven
thousand eight hundred and forty Canadian Dollars (CAD 37,387,840.00) by the creation and issuance of one Million eight
hundred sixty two thousand eight hundred and ninety two (1,862,892) new shares of category B with a nominal value of
twenty Canadian Dollars (CAD 20.00) each, to be fully paid up as follows:

-  The  amount  of  fifteen  Million  six  hundred  thirteen  thousand  two  hundred  and  forty  Canadian  Dollars  (CAD

15,613,240.00) through a contribution in kind consisting in the conversion in capital of a part of a receivable held by the
sole shareholder against the Company for a total amount of fifteen Million seven hundred forty three thousand two hundred
fifty seven Canadian Dollars and eighty four cents (CAD 15,613,257.84) (“the Claim”);

-  The  amount  of  twenty-one  Million  six  hundred  forty  four  thousand  and  six  hundred  Canadian  Dollars  (CAD

21,644.600.00), through a contribution in cash.

<i>Intervention - Subscription - Payment

The sole shareholder, through its proxy holder, declares to subscribe to the above mentioned share capital increase of

thirty seven Million two hundred fifty seven thousand eight hundred and forty Canadian Dollars (CAD 37,257,840.00), by
the creation and issuance of one Million eight hundred sixty two thousand eight hundred and ninety two (1,862,892) new
shares of category B with a nominal value of twenty Canadian Dollars (CAD 20.00) each, by way of a contribution in kind
consisting in the conversion in capital of a part of a receivable held by the sole shareholder against the Company for the
amount of fifteen Million six hundred thirteen thousand two hundred and forty Canadian Dollars (CAD 15,613,240.00)
and by a contribution in cash for the amount of twenty-one Million six hundred forty four thousand and six hundred Canadian
Dollars (CAD 21,644,600.00).

<i>Evidence of the contribution's existence

Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, the

sole shareholder resolves to amend Article 6 of the articles of association of the Company to read as follows:

Art. 6. Corporate capital. The capital is set at thirty seven Million three hundred eighty seven thousand eight hundred

and forty Canadian Dollars (CAD 37,387,840.00) represented by six thousand five hundred (6,500) shares of category A
and one Million eight hundred sixty two thousand eight hundred and ninety two (1,862,892) shares of category B, with a
nominal value of twenty Canadian Dollars (CAD 20.00) each."

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolves to set up different financial rights attached to each category of shares in case of redemption

of shares by the Company, so that the shares of category B may only be redeemed at their par value, and decides to insert
a new Article 12 of the article of association of the Company which shall read as follows:

“ Art. 12. Redemption of shares. The share capital of the Company may be decreased by the repurchase and cancellation

of the all or part of one or more categories of shares. In case of share capital decrease through the repurchase and cancellation
of shares of Category A, the shareholder(s) of Category A will be entitled (in proportion to their participation in these shares
of category A) at a fraction of the total amount of the cancellation of shares, as determined by the managers and approved
by the General meeting. In case of share capital decrease through the repurchase and cancellation of shares of category B,
shareholders of category B will be entitled to reimbursement of their respective shares of category B at their par value”,

<i>Fifth resolution

As a consequence of the previous resolution, the sole shareholder decides to change the numbering of the former Articles

12-28 of the articles of associations into Articles 13-29.

<i>Sixth resolution

The sole shareholder resolves to set up different financial rights attached to each category of shares in case of liquidation

of the Company, so that the eventual liquidation surplus may be distributed to the sole shareholder or the shareholders as
follows;

- Shares of category B will entitle to the repayment of their par value,
- Shares of category A will entitle to the remaining amount corresponding to the liquidation surplus.

53945

L

U X E M B O U R G

<i>Seventh resolution

As a consequence of the previous resolution, it is resolved to include a second paragraph of Article 28 of the articles of

association of the Company to read as follows:

“After having cleared all debts and liabilities of the Company (including liquidation costs), the net liquidation surplus

will be distributed to the sole shareholder or the shareholders, as follows:

- Shares of category B will entitle to the repayment of their par value,
- Shares of category A will entitle to the remaining amount corresponding to the liquidation surplus.”
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,

followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English and the
French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing, parties, the proxy holder signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-quatre septembre,
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, sous-

signé.

A comparu:

«INFRASTRUCTURE INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED», une société à responsabilité limitée, constituée et

existant selon les lois du Royaume-Uni, immatriculé auprès du registre de commerce et des sociétés d'Angleterre et du
Pays de Galles sous le numéro 6555131 and ayant son siège social au 12, Charles II street, SW1Y 4QU London, United
Kingdom («l'associé unique»),

dûment représenté par Madame Caroline RAMIER, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé.

Cette procuration, signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera

annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de la société «HICL Infrastructure 3 S.à r.l.», une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.520, constituée selon un acte notarié en date du 15 septembre 2010, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2295 du 27 octobre 2010. Les statuts ont été modifiés selon
un acte du notaire soussigné en date du 22 septembre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé de créer des catégories de parts sociales, à savoir des catégories de parts sociales A et des catégories de

parts sociale B, et de transformer les actuelle 6.500 parts sociales existantes en 6.500 parts sociales de catégorie A.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de trente-sept millions deux cent

cinquante-sept mille huit cent quarante dollars Canadien (CAD 37.257.840,00) pour le porter de son montant actuel de cent
trente mille dollars Canadien (CAD 130.000,00) à trente-sept millions trois cent quatre-vingt-sept mille huit cent quarante
dollars Canadien (CAD 37.387.840,00) par l'émission de un million huit cent soixante-deux mille huit cent quatre-vingt-
douze (1.862.892) nouvelles parts sociales de catégorie B, d'une valeur nominale de vingt dollars Canadien (CAD 20,00)
chacune, libérées comme suit:

- Pour le montant de quinze millions six cent treize mille deux cent quarante dollars Canadien (CAD 15.613.240.00)

par un apport en nature consistant en la conversion en capital d'une créance, détenue par l'associé unique envers la Société
pour un montant total de quinze millions six cents treize mille deux cents cinquante-sept mille Dollars Canadien et quatre-
vingt-quatre cents (CAD 15.613.257,84) («la Créance»);

- Pour le montant de vingt et un millions six cent quarante-quatre mille six cents dollars Canadien (CAD 21.644.600,00),

par un apport en numéraire.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

L'associé unique, représentée par son mandataire, a déclaré souscrire à l'augmentation de capital susmentionnée d'un

montant de trente-sept millions deux cent cinquante-sept mille huit cent quarante dollars Canadien (CAD 37.257.840,00)

53946

L

U X E M B O U R G

par la création et l'émission de un million huit cent soixante-deux mille huit cent quatre-vingt-douze (1.862.892) nouvelles
parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale de vingt Dollars Canadien (CAD 20,00) chacune, par l'apport en
nature consistant en l'apport de la Créance pour le montant de quinze millions six cent treize mille deux cent quarante
dollars Canadien (CAD 15.613.240,00) et par apport en numéraire pour le montant de vingt et un millions six cent quarante-
quatre mille six cents dollars Canadien (CAD 21.644.600,00).

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l'apport ayant été pleinement effectué, l'associé unique

a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à trente-sept millions trois cent quatre-vingt-sept mille huit cent quarante

dollars Canadien (CAD 37.387.840.00), représenté par six mille cinq cents (6.500) parts sociales de catégorie A et un
million huit cent soixante-deux mille huit cent quatre-vingt-douze (1.862.892) parts sociales de catégorie B d'une valeur
de vingt Dollars Canadiens (CAD 20,00) chacune.»

<i>Quatrième résolution

L'associé unique décide d'attribuer différents droits financiers attachés à chaque catégorie de parts sociales en cas de

rachat de parts par la Société, de sorte que les parts sociales de catégorie B pourront uniquement être rachetées à leur valeur
nominale, et décide d'insérer un nouvel article 12 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

« Art. 12. Rachat de Parts Sociales. Le capital social de la Société peut être réduit par le rachat et l'annulation de tout

ou partie d'une ou plusieurs catégories de parts sociales.

En cas de réduction du capital social par rachat et annulation de parts sociales de catégorie A, les associés détenteurs

de ces parts sociales de catégorie A auront droit (proportionnellement à leur participation respectives dans cette catégorie
de parts sociales A) à une fraction du montant total d'annulation de ces parts sociales, tel que fixé par les gérants et approuvé
par l'assemblée générale des associés. En cas de réduction du capital social par rachat et annulation de parts sociales de
catégorie B, les associés détenteurs de ces parts sociales de catégorie B auront droit au remboursement de ces parts sociales
à leur valeur nominale.».

<i>Cinquième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de changer la numérotation des anciens articles 12

à 28 des statuts en 13 à 29.

<i>Sixième résolution

L'associé unique décide d'attribuer différents droits financiers attachés à chaque catégorie de parts sociales en cas de

liquidation de la Société, de sorte que l'éventuel boni de liquidation soit distribué à l'associé unique ou aux associés, de la
manière suivante:

- Les parts sociales de catégories B donneront droit à la perception d'un boni de liquidation à hauteur de leur valeur

nominale,

- Les parts sociales de catégorie A donneront droit à la perception du surplus du montant correspondant audit boni de

liquidation.

<i>Septième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé d'intégrer un second alinéa à l'article 28 des statuts, et qui

aura la teneur suivante:

«Après avoir réglé l'ensemble des dettes et passifs de la Société (y compris les frais de liquidation), le boni net de

liquidation sera distribué à l'associé unique ou aux associé(s) comme suit:

- Les parts sociales de catégories B donneront droit à la perception d'un boni de liquidation à hauteur de leur valeur

nominale,

- Les parts sociales de catégorie A donneront droit à la perception du surplus du montant correspondant audit boni de

liquidation.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de la même partie comparante et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Ramier, Jean-Paul Meyers.

53947

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 septembre 2015. Relation: EAC/2015/22151. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Amédé SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2016057442/193.
(160017708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

UBS (Lux) Key Selection SICAV 2, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 129.049.

In the year two thousand and sixteen, on the third day of March at 9:30 a.m.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 (hereafter the

"Company"), a société d'investissement à capital variable with registered office at 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 129.049), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant
to a notarial deed drawn on 18 June 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mé-
morial”) number 1319 on 30 June 2007.

The articles of incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted on 8

April 2011, published in the Mémorial number 1942 on 24 August 2008.

The Meeting was chaired by Ms. Amanda ANOUSAKI, professionally residing in 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and the Meeting elected as scrutineer Ms. Norma CHRISTMANN, professionally

residing in 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the Meeting has originally been scheduled for 1 March 2016 at 11:00 a.m. but had to be adjourned to today due

to logistical reasons.

II.- That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

1. Dissolution and liquidation of the Company;
2. Appointment of UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. as liquidator of the Company (the "Liquidator"), represented

by Mr Axel Keufen, subject to approval of the CSSF, for a liquidation fee of EUR 10,000.- and determination of its powers;

3. Appointment of Ernst &amp; Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, as

independent auditor on the liquidation of the Company;

4. Authorization of the portfolio managers of the Company to deviate from the respective investment policy/restrictions

mentioned in the sales prospectus of the Company as well as to keep all the assets in cash in the context of the liquidation
process;

5. Instruction of the Liquidator to pay the liquidation costs and effect payment of liquidation proceeds in cash;
6. Miscellaneous.
III.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the shareholders present (if any), the proxies of the
represented shareholders, the bureau of the Meeting and the undersigned notary will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.

IV.- That, pursuant to the attendance list, the whole share capital of the Company is represented in this Meeting, that

the shareholders have been informed of the agenda prior to this Meeting and consent to waive the convening requirements,
and that therefore this Meeting can validly deliberate.

Then the Meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to dissolve and put the Company into liquidation with immediate effect.

53948

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Meeting resolves to appoint UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., represented by Mr Axel KEUFEN, having its

registered office in 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as liquidator (the "Liquidator") with the broadest
powers determined by articles 144 to 148 bis of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended
(the "1915 Law").

The Liquidator will be entitled to perform the deeds and operations provided for in article 145 of the 1915 Law without

any special authorisation of the general meeting of shareholders in the situations where this authorisation would be required.

The Liquidator is not required to draw up any inventory and may rely on the accounts of the Company.
The Liquidator is authorised, under his responsibility, to delegate, with regard to special and determined operations, to

one or more proxy holders, such part of its authorities and for such duration as he may determine.

The Meeting resolves that the Liquidator shall be entitled to remuneration of EUR 10,000.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to appoint Ernst &amp; Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365

Munsbach, as liquidation auditor of the Company.

<i>Fourth resolution

The  Meeting  resolves  to  allow  the  portfolio  managers  of  the  Company  to  waive  the  investment  policy/restrictions

mentioned in the prospectus of the Company as well as to keep all the assets in cash, in the context of the liquidation
process.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to instruct the Liquidator to pay the liquidation costs and effect payment of liquidation proceeds

in cash.

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Signé: A. ANOUSAKI, N. CHRISTMANN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 4 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/7360. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 15 mars 2016.

Référence de publication: 2016079813/77.
(160045573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

DPAS, Degroof Petercam Asset Services S.A., Société Anonyme,

(anc. Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 104.980.

L’an deux mille seize, le premier avril.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agis-

sant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

s’est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg», une société

anonyme, régie par le droit luxembourgeois ayant son siège social au 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 104980, constituée suivant acte notarié en date
du  20  décembre  2004,  publié  au  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  C  numéro  270  du  25  mars  2005  (la
"Société"). Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, en date du 28
septembre 2015, publié au Mémorial C numéro 3161 du 20 novembre 2015.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christophe Serwy, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert,

L-2453 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine Thiry, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg.

53949

L

U X E M B O U R G

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Carole Coïs, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert,

L-2453 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de la dénomination sociale en Degroof Petercam Asset Services S.A. en abrégé DPAS et modification

subséquente de l'article 1 des Statuts.

2) Modification de l'alinéa 3 de l'article 15 des Statuts.
3) Divers.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs
avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des
convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée  décide  de  modifier  la  dénomination  sociale  en  «Degroof  Petercam  Asset  Services  S.A.»  en  abrégé

«DPAS».

En conséquence, l'article 1 

er

 des statuts est modifié comme suit:

Art. 1 

er

 .  «Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir actionnaires par la suite une société constituée

sous  la  forme  d’une  société  anonyme  sous  la  dénomination  de  «Degroof  Petercam  Asset  Services  S.A.»  en  abrégé
«DPAS» (ci-après «la société»).»

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier le troisième alinéa 3 de l'article 15 des statuts comme suit:

Art. 15. (Troisième alinéa). «Le terme «intérêt opposé», tel qu’il est utilisé à l'alinéa précédent, ne s’appliquera pas aux

relations ou aux intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit, en rapport
avec une société fournissant des conseils à la société, ou en rapport avec Banque Degroof Petercam S.A., Banque Degroof
Petercam Luxembourg S.A. ou l'une de leurs filiales ou encore avec toute autre société ou entité juridique que le conseil
d’administration pourra déterminer.»

Plus rien n’étant à l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci a été clôturée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ceux-ci ont signé le présent acte avec Nous notaire.
Signé: C. SERWY, C. THIRY, C. COÏS, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 05 avril 2016. Relation: EAC/2016/8240. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2016089376/62.
(160058111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.

MB Tomahawk (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 193.321.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2016.

Référence de publication: 2016057570/10.
(160017562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

53950

L

U X E M B O U R G

Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 104.980.

L’an deux mille seize, le premier avril.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agis-

sant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

«Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg», une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois ayant son

siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg sous le numéro B 104 980, constituée suivant acte notarié en date du 20 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 270 du 25 mars 2005 (la "Société"). Les statuts de la société ont été modifiés à
plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem,
en date du 28 septembre 2015, publié au Mémorial C numéro 3161 du 20 novembre 2015,

ici représentée par Monsieur Christophe Serwy, résidant professionnellement au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lu-

xembourg, nommé à cet effet par résolution circulaire du Conseil d’Administration en date du 18 février 2016, dont un
extrait restera ci-annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

Ladite  partie  comparante,  agissant  dans  la  capacité  ci-dessus  énoncée,  a  demandé  au  notaire  soussigné  d’acter  ses

déclarations et observations comme suit:

1) Conformément au projet commun de fusion acté le 22 février 2016 par Maître Jean-Joseph Wagner, publié dans le

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 597 du 29 février 2016 (la «Publication») «Degroof Gestion Institu-
tionnelle - Luxembourg», agissant en tant que société absorbante et «Petercam Institutional Asset Management (Luxem-
bourg) S.A.», une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 3, rue Pierre d’Aspelt, L-1142
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.184.031, agissant en tant
que société absorbée, conformément à la procédure de fusion simplifiée des articles 278 et suivants de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») (la «Fusion»).

«Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg», et «Petercam Institutional Asset Management (Luxembourg) S.A.»

étant collectivement désignées ci-après comme les «Sociétés Fusionnées».

2) Aucun actionnaire de la Société Absorbante détenant au moins cinq pour cent (5%) des parts du capital souscrit n’a

demandé durant la période d’un (1) mois suivant la Publication qu’une assemblée générale extraordinaire de la Société
Absorbante soit convoquée afin de décider de l'approbation de la Fusion.

3) La Fusion est effective entre les Sociétés Fusionnées et conduit ce jour ipso jure aux effets exposés dans l'article 274

de la Loi, notamment le transfert universel de la propriété de tous les actifs et passifs de «Petercam Institutional Asset
Management (Luxembourg) S.A.» à «Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg». Elle sera effective vis-à-vis des
tiers à la date de publication dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du présent acte.

4) La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable et fiscal

comme accomplies pour le compte de la société absorbante, a été fixée au 1 

er

 janvier 2016.

5) En conséquence de la Fusion, «Petercam Institutional Asset Management (Luxembourg) S.A.» cesse d’exister et

toutes les actions ont été annulées. Tous les livres, registre des actionnaires et autres dossiers de cette Société Absorbée
seront conservés pendant le délai légal (cinq (5) ans) au siège de la Société Absorbante, étant actuellement au 12, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Conformément à l'article 273 de la Loi, le notaire soussigné déclare par le présent qu’il a fait les vérifications nécessaires

et certifie l'existence et la validité des actes et formalités à effectuer par les Sociétés Fusionnées et que par conséquent les
conditions de l'article 279 de la Loi ont été remplies.

Dont acte est fait et passé à Luxembourg à la date figurant au début de ce document.
Le document ayant été lu au représentant de la partie comparante ci-dessus connu du notaire soussigné, ladite personne

a signé ensemble avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: C. SERWY, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 05 avril 2016. Relation: EAC/2016/8239. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2016088877/55.
(160057190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.

53951

L

U X E M B O U R G

Silverlands Luxembourg (T2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 191.963.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2016057685/14.
(160017476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Sharehood S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 81.612.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue de manière extraordinaire le 9 no-

<i>vembre 2015

<i>Résolution:

L'Assemblée constate que les mandats d'Administrateurs sont échus et décide de nommer pour la période expirant lors

de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2018:

- Ms. Audrey Petrini, résidant professionnellement à Luxembourg, 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, admi-

nistrateur et président;

- Mr. Antonio Quaratino, résidant professionnellement à Luxembourg, 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ad-

ministrateur;

- Mr. Denis Callonego, résidant professionnellement à Luxembourg, 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, admi-

nistrateur;

- Mr. Francesco Costa, résidant à London, 10-12 Cadoagn Square, Mais Grd Front, 1 

st

 floor, GB - SW1X0JU, admi-

nistrateur;

- Mr. Hank Uberoi, USA 321, Upper Mountain Avenue - 07043 Montclair (NJ), administrateur;

- Mr. Daniel Lizio-Katzen, USA, 60e, 42 

nd

 Street, Suite 1111- NY10165New York, administrateur;

- Mr. Luca Ascani, London, 6, Holland Park Road, GB-W148LZ London, administrateur;

- Mrs Cecelia Kurzman, USA, 950, 3 

rd

 avenue, 20 

th

 floor, NY-10022 New York, administrateur;

L'Assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux Comptes, à savoir, la société International Corporate

Services (Luxembourg) S.à r.l

L'Assemblée  décide  de  nommer  avec  effet  immédiat,  pour  la  période  expirant  à  l'Assemblée  Générale  statuant  sur

l'exercice clôturé au 31 décembre 2015, la société FCS Services S.à.r.l., ayant son siège social au 2, place de Strasbourg,
L-2562 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.493, en
qualité de Commissaire aux Comptes.

L'Assemblée décide de transférer avec effet au 1 

er

 janvier 2016 le siège social de la société du 50, route d'Esch L-1470

Luxembourg au 8, rue de Beggen L-1220 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Sharehood S.A.
Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2016057713/36.
(160017240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

53952


Document Outline

Audrey Germany Investment S.à r.l.

Audrey Holdco S.à r.l.

Blue Moon Software

Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg

Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg

Degroof Petercam Asset Services S.A.

FACT Luxembourg S.A.

Finagen International S.A.

Finca Holding S.A.

Frankfurt BICC

Gondburg Real Estate S.A.

Gondburg Real Estate S.A.

Gracewell Properties (Frome) S.à r.l.

Groupe Acticall

Guardtek S.à r.l.

Heico Luxembourg S.à r.l.

Hermes Trade Receivables Sàrl

HICL Infrastructure 3 S.à r.l.

Highstreet VI PropCo II S.à r.l.

LEKHOM s.à r.l.

Leold S.à.r.l.

Lugaro Financing Holding S.A.

Luxembourg Investment Company 122 S.à r.l.

Luxembourg Investment Company 127 S.à r.l.

Luxembourg Marine Services S.A.

L.V.I. S.A.

Maison De Gorée S.à r.l.

Mara International S.A.

MB Tomahawk (Luxembourg) S.à r.l.

Mohawk International (Europe) S.à r.l.

Mohawk International Financing S.à r.l.

Mohawk Kai Luxembourg Holding S.à r.l.

Monier Finance S.à r.l.

Neo Holdings Luxembourg S.à r.l.

Newberg Investment SCSp

NHR Fund S.à r.l.

Noble Drilling (Luxembourg) S.à r.l.

Novit S.à r.l.

NRF Luxembourg Holding S.à r.l.

NRF Luxembourg KC S.à r.l.

Octulex S.A.

Pan Ocean Financial Corp. S.A.

Penelope 83 S.A.

Platin Capital S.à r.l.

Platin Investments S.à r.l.

Sharehood S.A.

Silverlands Luxembourg (T2) S.à r.l.

S Lux SCSp

Summit Partners (GGV) S.à r.l.

UBS (Lux) Key Selection SICAV 2