logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1123

15 avril 2016

SOMMAIRE

2512 H S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53862

Aguila 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53858

ALM Logistics Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

53869

Arcano Real Estate GP, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

53858

Archand Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53865

Asia Pacific Performance  . . . . . . . . . . . . . . . . .

53860

Assenagon Select Plus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53858

Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie  . . . . . . .

53859

Banque Degroof Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

53903

Banque Degroof Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

53878

BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEM-

BOURG S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53878

Bgold et Westfield, S.e.n.c.  . . . . . . . . . . . . . . . .

53866

BMBG Bond Finance S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . .

53867

Borasco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53867

Braas Monier Building Group S.A.  . . . . . . . . .

53866

Breds Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53866

BSN medical Luxembourg Group Holding S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53867

Bureau 1G Consult S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

53861

Catamaran S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53868

Centrum Development S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

53868

Chaptwo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53867

Château de Beggen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53868

Chi Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53869

Chiron Technology S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

53869

Cygnus Holding S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . .

53865

DB Advisors SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53865

db Advisory Multibrands  . . . . . . . . . . . . . . . . .

53864

DB PWM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53863

Degroof Equities  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53859

Deutsche Invest II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53862

E.01 Euro-Innovation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53862

Entreprise Mario Contato et Fils  . . . . . . . . . . .

53904

Foodip  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53863

Glow Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53904

Ireco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53864

JBS Berg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53870

JBS Petrusse Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

53859

Lecorsier Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53880

MB Tomahawk (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . .

53894

Micaboul Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53904

Polar Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53861

Redline Capital Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53858

Regus plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53870

Reno Holding (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . .

53861

Synapsia SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53875

THE WORLD COMPANY (en abrégé: TWC)

Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53863

Veda International S.à .rl.  . . . . . . . . . . . . . . . .

53881

WAI S.C.A., SICAV - FIS . . . . . . . . . . . . . . . . .

53860

Waterproof Property S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

53860

WAVE Private Equity SICAV-SIF  . . . . . . . . .

53864

53857

L

U X E M B O U R G

Assenagon Select Plus, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016088795/7.
(160057286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.

Redline Capital Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Redline Capital Fund a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
«The management regulations of Redline Capital Fund were deposited with the Registre de commerce et des societies.»
For publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.»
Référence de publication: 2016089094/9.
(160057311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.

Arcano Real Estate GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11/13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 198.374.

L'actionnaire unique de la Société, en date du 25 janvier 2016, par voie de résolutions écrites:
- a pris connaissance de la démission de Monsieur Yvon Lauret en tant que gérant de la Société, en date effective du 29

janvier 2016.

et
- a décidé de nommer Monsieur Christophe Arnould en tant que gérant de la Société, en date effective du 29 Janvier

2016, pour une période de six ans en remplacement de Monsieur Yvon Lauret.

Le conseil de gérance de la Société est alors composé comme suit:
- Monsieur Christophe Arnould, résidant professionnellement au 19, rue de l'Industrie, L-8069 Bertrange;
- Monsieur Alberto Saugar, résidant professionnellement au Calle López de Hoyos, 42 E - 28006 Madrid;
- Mr. Nigel Williams, résidant professionnellement au 3, avenue Monterey L-2163 Luxembourg;

<i>Pour Arcano Real Estate GP, S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
RBC Investor Services Bank S.A.
Société anonyme

Référence de publication: 2016064967/22.
(160026881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Aguila 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 70.733.122,11.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 43-45, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 157.660.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales en date du 11 février 2016 que Aguila Investissement Luxembourg

S.C.A. a transféré 210.921.499 parts sociales de classe B qu'elle détenait dans la Société à Aguila PAI S.à r.L, une société
à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 43-45, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 157 660.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2016.

Référence de publication: 2016064956/16.
(160027146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

53858

L

U X E M B O U R G

Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion du fonds commun de placement " Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie " modifié au 18 mars

2016 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, mars 2016

HANSAINVEST LUX S.A.
Signature

Référence de publication: 2016077933/11.
(160043074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

Degroof Equities, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 24.189.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>26 avril 2016 à 11.00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2015
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et les décisions seront

prises à la majorité simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social de

la Société.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016087449/755/22.

JBS Petrusse Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 202.300.

Il  résulte  d'une  convention  sous  seing  privé  en  date  du  23  décembre  2015  que  l'associé  unique  de  la  Société,  JBS

Ansembourg Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante au Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 202 222, a transféré les parts qu'il détient dans la Société à JBS Luxembourg S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 202 366.

A compter du 23 décembre 2015, JBS Luxembourg S.à r.l. détient les 20.000 parts de la Société et devient donc associé

unique de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
La Société
Signature

Référence de publication: 2016064552/21.
(160025931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

53859

L

U X E M B O U R G

Asia Pacific Performance, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 50.269.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>26 avril 2016 à 14.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du

jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2015
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité

simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social de

la société.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016087450/755/23.

WAI S.C.A., SICAV - FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 131.834.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 26. November 2015

Am 26. November 2015 um 13.00 Uhr kamen am Gesellschaftssitz die Aktionäre obiger Gesellschaft zusammen.
Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Das Mandat des Wirtschaftsprüfers BDO Audit S.A. wird um ein Jahr und damit bis zum Ablauf der im Jahr 2016

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre verlängert.

Luxemburg, den 10.02.2016.

WAI S.C.A., SICAV-FIS

Référence de publication: 2016064908/15.
(160026272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Waterproof Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 161.581.

En date du 20 janvier 2016, l'associé Oliver Wolfensberger, avec adresse au 346, Seestrasse, 8038 Zurich, Suisse, a

transféré 25.000 parts sociales à Sascha Prinz, avec adresse professionnelle au 4, Per Romanov, 125009 Moscou, Russie,
qui les acquiert.

En conséquence, les associés de la société sont les suivants:
- Oliver Wolfensberger, précité, avec 500 parts sociales
- Sascha Prinz, précité, avec 49.500 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2016.

Référence de publication: 2016064909/16.
(160026369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

53860

L

U X E M B O U R G

Reno Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 72.857.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 31 août 2015

<i>1 

<i>ère

<i> Résolution:

L'Assemblée Générale accepte la démission de la société Certifica Luxembourg S.à r.l. de son poste de Commissaire

aux Comptes et décide nommer avec effet au 24 juin 2015, en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire,
Monsieur Henri Vanherberghen demeurant professionnellement au 78, rue A. Asselbergs, B-1180 Bruxelles, Belgique. Il
terminera le mandat de son prédécesseur.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Henri Vanherberghen expira à l'Assemblée Générale qui se tiendra

en 2018.

<i>Pour la société
Joao Luis Da Fonseca Ferreira
<i>Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2016064778/18.
(160025867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Polar Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 154.371.

Die Anteilinhaber der SICAV Polar Investments werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>27. April 2016 um 11:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2015.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-

inhaber  berechtigt,  die  bis  spätestens  22.  April  2016  die  Depotbestätigung  eines  Kreditinstitutes  bei  der  Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im April 2016

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2016088115/755/26.

Bureau 1G Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4687 Differdange, 307, rue Woiwer.

R.C.S. Luxembourg B 127.681.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 7 mars 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016075726/10.
(160040629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.

53861

L

U X E M B O U R G

Deutsche Invest II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 169.544.

Die Anteilinhaber der SICAV Deutsche Invest II werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>27. April 2016 um 11:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2015.

3. 3Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-

inhaber  berechtigt,  die  bis  spätestens  22.  April  2016  die  Depotbestätigung  eines  Kreditinstitutes  bei  der  Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im April 2016

<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2016088122/755/26.

2512 H S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 152.678.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 17 décembre 2015 à 14.00 heures à Luxem-

<i>bourg

<i>44, avenue J.F. Kennedy

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateur de Messieurs Jean-Charles

THOUAND, Koen LOZIE et de la société JALYNE S.A, 44, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, représentée par
M. Jacques BONNIER, 44, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de la société THE CLOVER, au poste de Com-

missaire aux comptes de la société.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale

Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2015.

Référence de publication: 2016065673/17.
(160027071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

E.01 Euro-Innovation, Société Anonyme.

Siège social: L-3980 Wickrange, 7, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 55.315.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour E.01 EURO-INNOVATION
Signature

Référence de publication: 2016075791/11.
(160040600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.

53862

L

U X E M B O U R G

THE WORLD COMPANY (en abrégé: TWC) Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2737 Luxembourg, 23, rue Wurth-Paquet.

R.C.S. Luxembourg B 167.772.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de la société The World Company (en abrégé: TWC)

<i>S.A.R.L. en date du 10 décembre 2015 à 11h30

L'Assemblée dûment constituée et représentée a pris la décision suivante:
1. L'Assemblée décide d'accepter le transfert du siège social de la société THE WORLD COMPANY (en abrégé: TWC)

S.A.R.L. de L-2560 Luxembourg; 12 rue de Strasbourg à L-2737 Luxembourg; 23 rue Wurth-Paquet

Luxembourg, le 10 décembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme
THE WORLD COMPANY (en abrégé: TWC) S.A.R.L.
Représentée par Angela Ximena FUENTES BELLO / Harald-Sven SONTAG
<i>Gérante / Associé unique

Référence de publication: 2016065618/17.
(160026879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

DB PWM, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 163.660.

Die Anteilinhaber der SICAV DB PWM werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>27. April 2016 um 10:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2015.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-

inhaber  berechtigt,  die  bis  spätestens  22.  April  2016  die  Depotbestätigung  eines  Kreditinstitutes  bei  der  Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im April 2016

<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2016088126/755/26.

Foodip, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 25, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 181.993.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016075835/11.
(160040560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.

53863

L

U X E M B O U R G

WAVE Private Equity SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 164.909.

Bestellung von Herrn Ingo Prummenbaum als Verwaltungsrat und Rücktritt von Herrn Hermann Knödgen als Verwal-

tungsrat

Gemäß dem Vorschlag des Verwaltungsrates, wurde Herr Ingo Prummenbaum, berufsansässig in 2 Place François-

Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg, am 15. Dezember 2015 als neuer Verwaltungsrat der WAVE Private Equity SICAV-
SIF durch die CSSF genehmigt.

Bei der nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2016 soll der Rücktritt von Herrn Hermann Knödgen und

die Bestellung von Herrn Ingo Prummenbaum von den Aktionären bestätigt werden.

Luxemburg, den 11.02.2016.

WAVE Private Equity SICAV-SIF

Référence de publication: 2016065645/16.
(160027689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Ireco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 10.339.

Les comptes annuels au 31.03.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IRECO S.A.
Société anonyme
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2016075928/12.
(160040904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.

db Advisory Multibrands, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 167.637.

Die Anteilinhaber der SICAV db Advisory Multibrands werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>27. April 2016 um 15:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2015.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-

inhaber  berechtigt,  die  bis  spätestens  22.  April  2016  die  Depotbestätigung  eines  Kreditinstitutes  bei  der  Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im April 2016

<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2016088127/755/26.

53864

L

U X E M B O U R G

DB Advisors SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 145.884.

Die Anteilinhaber der SICAV DB Advisors werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>27. April 2016 um 11:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2015.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-

inhaber  berechtigt,  die  bis  spätestens  22.  April  2016  die  Depotbestätigung  eines  Kreditinstitutes  bei  der  Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im April 2016

<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2016088128/755/26.

Archand Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 81.040.

Par la présente, je vous informe que je démissionne de ma fonction de gérant B de la société Archand Holding S.à

r.l.,immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B81040 et ayant son siège social au 15, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, avec effet immédiat.

Le 8 février 2016.

Wim Rits.

Référence de publication: 2016065009/11.
(160026988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Cygnus Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 28.227.

1. Madame Anne MARTENS demeurant 12, route d'Arlon, 1140 Luxembourg, dépose son mandat d'administrateur de

CYGNUS HOLDING S.A., SPF (RCS Lux. B 28.227).

2. Madame Ginette DOUSSEAU demeurant 12, route d'Arlon, 1140 Luxembourg, dépose son mandat d'administrateur

de CYGNUS HOLDING S.A., SPF (RCS Lux. B 28.227).

3. Monsieur Marc MOLITOR demeurant 12, route d'Arlon, 1140 Luxembourg, dépose son mandat d'administrateur de

CYGNUS HOLDING S.A., SPF (RCS Lux. B 28.227).

4.  EUROFIDUCIAIRE,  société  anonyme,  ayant  son  siège  social  12,  route  d'Arlon,  1140  Luxembourg,  dépose  son

mandat de commissaire aux comptes de CYGNUS HOLDING S.A., SPF (RCS Lux. B 28.227).

Ces décisions sont prises avec effet au 1 

er

 janvier 2016.

Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2016065133/17.
(160027475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

53865

L

U X E M B O U R G

Breds Management S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 180.408.

EXTRAIT

Il  résulte  de  la  décision  de  l'associé  unique  de  la  Société  en  date  du  09  février  2016  que  M  Randall  Rothschild  a

démissionné en tant que Administrateur de la Société avec effet au 09 février 2016.

En date du 09 février 2016, les actionnaires de la Société ont pris la résolution suivante:
- de nommer M Anthony Marone, demeurant professionnellement 345 Park Avenue, 10 

th

 floor, New York, 10154, et

née le 09 August 1982, à Massachusetts, États-Unis d'Amérique, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet
au 09 février 2016 et ce pour une durée détermine jusqu'à 2019.

Le conseil d'administration de la Société est dès lors composé comme suit à compter du 09 février 2016:
- Mme S. Diana Hoffmann;
- M Jean-François Bossy;
- M Anthony Marone
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 février 2016.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2016065053/23.
(160027283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Bgold et Westfield, S.e.n.c., Société en nom collectif.

Capital social: EUR 501.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 157.593.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

La clôture de la liquidation de la Société a été décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé

le 28 décembre 2015. La Société a donc cessé d'exister à partir de ce jour.

Les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal de 5 ans au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10.02.2016.

Signature.

Référence de publication: 2016065040/16.
(160026794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Braas Monier Building Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Senningerberg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 148.558.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 8 janvier 2016

En date du 8 janvier 2016, le conseil d'administration de la Société a pris la résolution suivante:
- d'accepter la démission de Monsieur Pepijn DINANDT de ses mandats d'administrateur et de délégué à la gestion

journalière de la Société avec effet au 15 janvier 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2016.

Braas Monier Building Group S.A.
Signature

Référence de publication: 2016065032/15.
(160027425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

53866

L

U X E M B O U R G

BMBG Bond Finance S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1748 Senningerberg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 185.849.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg.

Le siège social de l'associé gérant commandité de la Société, BMBG Bond Finance GP S.à r.l., a changé et doit désormais

se lire comme suit: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2016.

BMBG Bond Finance S.C.A.
Signature

Référence de publication: 2016065048/15.
(160027422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Borasco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 112.827.

La Société a été informée du changement d'adresse du gérant Magne Jordanger comme suit:
- La nouvelle adresse de Magne Jordanger est 12 Avenue des Spèlugues, 98000 Monte Carlo, Monaco.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Manacor (Luxembourg) S.A
<i>Gérant

Référence de publication: 2016065052/14.
(160026974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

BSN medical Luxembourg Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.944.250,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 169.985.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique du 04.02.2016

L'actionnaire unique de la Société a pris les décisions suivantes avec effet au 15.02.2016:
- Démission de Mme. Andrea Pabst en tant que gérant;
- Nomination de Mr. John Lhoest, né le 12.08.1984 à Huy (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 23, Rue

Aldringen, L - 1118 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une période indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016065056/14.
(160026789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Chaptwo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4a, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 200.304.

<i>Extrait des décisions des associés de la Société du 30 Septembre 2015:

Les associés de la Société décide conformément aux statuts de la Société:
D'accepter la démission de Monsieur Robert Viksten en qualité de gérant de la Société avec effet au 30 Septembre 2015.
Référence de publication: 2016065069/11.
(160026784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

53867

L

U X E M B O U R G

Centrum Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 105.723.

EXTRAIT

En date du 9 février 2016, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
- Les mandats de M. Didier Lévêque et Mme. Odile Muracciole en tant que membres du conseil de surveillance sont

renouvelés pour une durée d'un an, à compter du 22 janvier 2016,

- Nomination de Mme Vanessa Barthe, née le 22 décembre 1979, à Asnières-sur-Seine (France), avec adresse profes-

sionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg en tant que nouvel administrateur avec effet au 31 décembre
2015 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016065067/15.
(160027091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Château de Beggen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 133.856.

EXTRAIT

ERRATUM dans le dépôt du 14/01/2016 portant les références: B133856 - L160008224
Le Conseil d'Administration constate qu'il y a eu l'erreur suivante dans le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Ad-

ministration ainsi que dans le dépôt du 14/01/2016:

Le prénom de Madame VINCENT, née le 6 juillet 1958 à Bruxelles (Belgique), et demeurant à B-1180 Uccles, 19,

avenue des Mûres est Catherine et non Christine.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2016065068/15.
(160027725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Catamaran S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 26.797,00.

Siège social: L-2242 Luxembourg, 1, rue Isaac Newton.

R.C.S. Luxembourg B 170.535.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 1 

<i>er

<i> février 2016

L'associé unique de la Société a décidé:
1. d'acter la démission de Madame Marjorie ALLO en tant que gérante de la Société, avec effet immédiat;
2. de nommer Monsieur Luc SUNNEN en tant que gérant de catégorie B de la Société, avec effet immédiat et pour une

durée indéterminée;

3. de nommer Monsieur Christophe FENDER en tant que gérant de catégorie B de la Société, avec effet immédiat et

pour une durée indéterminée;

4. de nommer Monsieur Robert Worth OBERRENDER, né dans l'état de New York, États-Unis d'Amérique, le 18

janvier  1960,  ayant  son  adresse  professionnelle  au  9900  Bren  Road  East,  Minnetonka,  55343  Minnesota,  États-Unis
d'Amérique, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

5. de nommer Monsieur Bruce Paul PRASKA, né dans l'état du Dakota du Nord, États-Unis d'Amérique, le 7 mars 1960,

ayant son adresse professionnelle au 9900 Bren Road East, Minnetonka, 55343 Minnesota, États-Unis d'Amérique, en tant
que nouveau gérant de catégorie A de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2016065065/24.
(160027120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

53868

L

U X E M B O U R G

Chi Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 93.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 179.262.

EXTRAIT

En date du 11 février 2016, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Alan Botfield, en tant que gérant B de la Société, a été acceptée avec effet au 28 janvier

2016.

Monsieur Petr Klimo, né le 22 septembre 1976 à Karvina, République Tchèque, demeurant professionnellement au 51,

avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommé aux fonctions de gérant B de la Société avec effet au 28 janvier
2016 et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2016.

Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2016065070/19.
(160027506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Chiron Technology S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 179.324.

EXTRAIT

En date du 11 février 2016, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Alan Botfield, en tant que gérant B de la Société, a été acceptée avec effet au 28 janvier

2016.

- Monsieur Petr Klimo, né le 22 septembre 1976 à Karvina, République Tchèque, demeurant professionnellement au

51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommé aux fonctions de gérant B de la Société avec effet au 28
janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2016.

Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2016065071/19.
(160027521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

ALM Logistics Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 187.913.

<i>Extrait des Résolutions du Conseil de Gérance datées du 24 janvier 2016.

Avec effet au 1 

er

 octobre 2015, le Conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 22, avenue

Marie Thérèse L-2132 Luxembourg au 2, Rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg.

Avec effet au 1 

er

 octobre 2015, le Conseil de gérance a décidé de transférer les adresses professionnelles des gérants

de Classe B Monsieur Thomas Heymans et Madame Nathalie Canzerini du 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg
au 2, Rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2016.

Référence de publication: 2016065001/16.
(160027550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

53869

L

U X E M B O U R G

JBS Berg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.002,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 202.174.

Il résulte d'une notification de l'associé unique de la Société, JBS USA Food Company, une société constituée sous les

lois du Delaware (États-Unis), ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, New Castle
County (États-Unis), immatriculée au Secrétariat de l'Etat du Delaware sous le numéro 38866331, qu'en date du 23 dé-
cembre 2015, l'associé unique de la Société a transféré les parts qu'il détient dans la Société à JBS Ansembourg Holding
S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante au Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 202.222.

A compter du 23 décembre 2015, JBS Ansembourg Holding S.à r.l. détient les 20.002 parts de la Société et devient donc

associé unique de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
La Société
Signature

Référence de publication: 2016065298/21.
(160027262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Regus plc, Société Anonyme.

Siège de direction effectif: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 141.159.

Notice is hereby given that this

YEAR'S ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING

of the Company will be held at 11.00 a.m. (Luxembourg time) on Tuesday, <i>17 May 2016 at 26 Boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Shareholders will be asked to consider and vote upon the resolutions set out below. Resolutions 1 to 12 and 19 to 20

(inclusive) will be proposed as ordinary resolutions. This means that for each of those resolutions to be passed, more than
half of the votes cast must be in favour of the resolution. Resolutions 13 to 18 (inclusive) will be proposed as ordinary
resolutions,  and  shall  also  require  separate  approval  by  the  Independent  Shareholders.  Resolutions  21  and  22  will  be
proposed as ordinary resolutions, in which only votes cast by Independent Shareholders will be counted. Mark Dixon has
confirmed to the Company that he and any persons acting in concert with him will abstain from voting on resolutions 21
and 22. This means that for each of those resolutions to be passed, more than half of those votes cast by Independent
Shareholders on the poll must be in favour of the resolution. Resolutions 23 to 25 (inclusive) will be proposed as special
resolutions. This means that for each of those resolutions to be passed, at least two-thirds of the votes cast must be in favour
of the resolution.

As required by the Company's Memorandum and Articles of Association, voting in respect of all resolutions to be put

to the AGM will be conducted by means of a poll vote. The quorum for the AGM is two members present in person or by
proxy and entitled to vote (but no fewer than two individuals shall constitute a quorum).

<i>Agenda of Annual General Meeting and proposed resolutions

The consolidated financial statements for the Group and standalone financial statements of the Company for the financial

year ended 31 December 2015, and the reports of the Board and the independent auditor thereon, will be laid before
Shareholders for their consideration at the beginning of the AGM.

Ordinary resolutions

1. To approve the consolidated financial statements of the Group for the financial year ended 31 December 2015 having

received the reports of the Board and the independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) thereon.

2. To approve the standalone financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2015

having received the reports of the Board and the independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) thereon.

3. To approve, with effect from 1 January 2016, the Remuneration Policy as set out on pages 44 to 47 of the Company's

annual report for the financial year ended 31 December 2015.

4. To approve, on an advisory basis, the Annual Report on Remuneration for the financial year ended 31 December

2015, as set out on pages 48 to 52 of the Company's annual report for the financial year ended 31 December 2015.

53870

L

U X E M B O U R G

5. To approve, with effect from 1 January 2016, the Regus PSP, the full text of which is available on the Company's

website, www.regus.com.

6. To approve, with effect from 1 January 2016, the Regus DSBP, the full text of which is available on the Company's

website, www.regus.com.

7. To grant discharge to each person who has served as a director of the Company during the financial year ended 31

December 2015 in respect of certain duties owed to Shareholders under Luxembourg law during the financial year.

8. To approve the allocation of the net profit of the Company for the year ended 31 December 2015 in an aggregate

amount of GBP 119.9 million on the following basis:
(A) an interim dividend of 1.4 pence per Ordinary Share, corresponding to an aggregate amount of GBP 13.0 million,
which was paid on 2 October 2015 to Shareholders on the register of members at the close of business on 4 September
2015;
(B) a final dividend of 3.1 pence per Ordinary Share, corresponding to an aggregate amount of GBP 28.8 million,
to be paid on 27 May 2016 to Shareholders on the register of members at the close of business on 29 April 2016;
and
(C) the balance of the Company's net profit in an amount of GBP 78.1 million to be allocated to the Company's
retained earnings account.

9. To approve the re-appointment of KPMG Luxembourg, Société coopérative as approved independent auditor (ré-

viseur d'entreprises agréé) of the Company to hold office until the conclusion of next year's annual general meeting.

10. To authorise the Directors to determine the remuneration of KPMG Luxembourg, Société coopérative as approved

independent auditor (réviseur d'entreprises agréé).

11. To re-elect Mark Dixon as a director of the Company for a term of up to three years.
12. To elect Dominik de Daniel as a director of the Company for a term of up to three years.
13. To re-elect Lance Browne as a director of the Company for a term of up to three years.
14. To re-elect Elmar Heggen as a director of the Company for a term of up to three years.
15. To re-elect Nina Henderson as a director of the Company for a term of up to three years.
16. To re-elect François Pauly as a director of the Company for a term of up to three years.
17. To re-elect Florence Pierre as a director of the Company for a term of up to three years.
18. To re-elect Douglas Sutherland as a director of the Company for a term of up to three years.
19. To resolve that, in substitution for any like authority conferred on them at a previous general meeting, the Directors

of the Company be generally and unconditionally authorised to exercise all or any of the powers of the Company
pursuant to the Company's Memorandum and Articles of Association to allot and issue Relevant Securities (as defined
in Article 11(H)(viii) of the Company's Memorandum and Articles of Association) and to allot and issue shares in
pursuance of an employee share scheme (including any employee share scheme of any company that is a subsidiary
of the Company):
(A) up to an aggregated nominal amount of GBP 3,106,245; and
(B) comprising equity securities (as defined in Article 11(H)(iv) of the Company's Memorandum and Articles of
Association) up to a nominal amount of GBP 6,212,490 (after deducting from such limit any Relevant Securities
allotted under paragraph (A) above) in connection with an offer by way of a rights issue:

(i) to ordinary shareholders in proportion (as nearly as may be practicable) to their existing holdings; and

(ii) to holders of other equity securities as required by the rights of those securities or as the Board otherwise

considers necessary, and so that the Board may impose any limits or restrictions and make any arrangements which
it considers necessary or appropriate to deal with treasury shares, fractional entitlements, record dates, legal, regu-
latory or practical problems in, or under the laws of, any territory or any other matter, for a period expiring (unless
this authority is previously renewed, varied or revoked by the Company in a general meeting) at the conclusion of
next year's annual general meeting (or, if earlier, at the close of business on 16 August 2017), save that the Company
may before such expiry make an offer or agreement which would or might require Relevant Securities (or shares in
pursuance of an employee share scheme) to be allotted and issued after such expiry and the Directors may allot and
issue Relevant Securities (or shares in pursuance of an employee share scheme) pursuant to such offer or agreement
as if the authority conferred hereby had not expired.

20. To authorise the Company to hold as treasury shares any shares purchased or contracted to be purchased by the

Company pursuant to the authority granted in resolution 24 prior to the conclusion of next year's annual general
meeting (or, if earlier, at the close of business on 16 August 2017), if the Directors of the Company resolve to hold
as treasury shares any shares so purchased or contracted to be purchased.

21. To approve the waiver granted by the Panel of the obligation which may otherwise arise, pursuant to Rule 9 of the

Code, for Mr. Dixon (or any entity through which Mr. Dixon holds shares in the Company) to make a general offer
to the other Shareholders for all of their Ordinary Shares as a result of market purchases of up to 15,000,000 Ordinary
Shares by the Company pursuant to the authority granted under resolution 24 that could, taking into account all
Existing Waivers, potentially increase Mr. Dixon's shareholding from approximately 31.62 per cent of the total voting
rights in the Company to a maximum of approximately 32.27 per cent of the total voting rights in the Company (and,
taking into account the Second Waiver and all Existing Waivers, up to a maximum potential holding of approximately
32.31 per cent of the total voting rights in the Company).

53871

L

U X E M B O U R G

22. To approve the waiver granted by the Panel of the obligation which may otherwise arise, pursuant to Rule 9 of the

Code, for Mr. Dixon (or any entity through which Mr. Dixon holds shares in the Company) to make a general offer
to the other Shareholders of the Company for all of their Ordinary Shares as a result of the exercise by Mr. Dixon of
any of the 2016 PSP Options, pursuant to which Mr. Dixon's interest in the shares of the Company could, taking into
account all Existing Waivers, potentially increase from approximately 31.62 per cent of the total voting rights in the
Company to a maximum of approximately 31.79 per cent of the total voting rights in the Company (and, taking into
account the First Waiver and all Existing Waivers, up to a maximum potential holding of approximately 32.31 per
cent of the total voting rights in the Company).
In accordance with the requirements of the Code, Mr. Dixon will not be voting, in respect of resolutions 21 and 22,
his interest in 294,701,874 Ordinary Shares, representing approximately 31.62 per cent of the total voting rights in
the Company. The votes in respect of resolutions 21 and 22, as is the case for all resolutions to be put to the AGM,
will be held by means of a poll.

Special resolutions

23. To resolve that:

(A) any Director be authorised to make (or cause to be made) from time to time, all necessary amendments to the
provisions of the Company's Memorandum and Articles of Association which state the Company's issued share
capital to reflect changes in the Company's issued share capital; and
(B) the secretary (as defined in the Company's Memorandum and Articles of Association) or any Director be au-
thorised to make (or cause to be made) all necessary:
(i) entries in the Company's records and accounts; and
(ii) all other formalities, actions, deeds and filings in Jersey or Luxembourg, in connection with each such amendment
to the Company's Memorandum and Articles of Association.

24. To resolve that the Board be generally and unconditionally authorised pursuant to article 57 of the Companies (Jersey)

Law 1991, article 49-2 of the Luxembourg Companies Laws (as defined in the Company's Memorandum and Articles
of Association) and Article 8 of the Company's Memorandum and Articles of Association, to make market purchases
of Ordinary Shares, provided that:
(A) the maximum number of Ordinary Shares authorised to be purchased is 93,187,347 (representing approximately
10 per cent of issued share capital (excluding treasury shares) at the date hereof) further provided that no purchase
shall be made from time to time if the nominal value of the Ordinary Shares so purchased together with all other
Ordinary Shares held in treasury by the Company would exceed 10 per cent of the nominal value of the issued share
capital of the Company at that time;
(B) the minimum price, exclusive of any expenses, which may be paid for an Ordinary Share is GBP 0.01;
(C) the maximum price, exclusive of any expenses, which may be paid for an Ordinary Share shall be the higher of:

(i) an amount equal to five per cent above the average of the middle market quotations for Ordinary Shares taken

from the London Stock Exchange Daily Official List for the five business days immediately preceding the day on
which such shares are contracted to be purchased; and

(ii) the higher of the price of the last independent trade and the highest current independent bid on the London

Stock Exchange Daily Official List at the time that the purchase is carried out; and
(D) the authority hereby conferred shall expire at the conclusion of next year's annual general meeting (or, if earlier,
at the close of business on 16 August 2017) except that the Company may make a contract or contracts to purchase
Ordinary Shares under this authority before the expiry of this authority, which will or may be executed wholly or
partly after the expiry of this authority, and may make purchases of Ordinary Shares in pursuance of any such contract
as if such authority had not expired.

25. To resolve that the Directors be empowered pursuant to the Company's Memorandum and Articles of Association

to allot and issue equity securities (as defined in Article 11(H)(iv) of the Company's Memorandum and Articles of
Association) wholly for cash pursuant to the authority conferred by resolution 19 above, and / or where such allotment
and  issue  constitutes  an  allotment  and  issue  of  equity  securities  by  virtue  of  Article  11(H)(i)  of  the  Company's
Memorandum and Articles of Association, as if the pre-emption rights referred to in Article 12 did not apply to such
allotment and issue, provided that this power:
(A) shall expire on the conclusion of next year's annual general meeting (or, if earlier, at the close of business on 16
August 2017), save that the Company may, before such expiry, make an offer or agreement which would or might
require equity securities to be allotted and issued after such expiry and the Directors may allot and issue equity
securities pursuant to any such offer or agreement as if the power conferred hereby had not expired; and
(B) shall be limited to:
(i) the allotment and issue of equity securities in connection with a rights issue, open offer or pre-emptive offer in
favour of holders of Ordinary Shares (excluding any shares held by the Company as treasury shares) where the equity
securities respectively attributable to the interests of such holders of Ordinary Shares on a fixed record date are
proportionate (as nearly as may be) to the respective numbers of Ordinary Shares subject to any exclusions or other
arrangements as the Directors may deem necessary or expedient to deal with equity securities representing fractional
entitlements and / or to deal with legal or practical problems arising under the laws of, or requirements of, any
recognised regulatory body or any stock exchange in any territory or any other matter whatsoever; and

53872

L

U X E M B O U R G

(ii) the allotment and issue of equity securities wholly for cash otherwise than pursuant to paragraph (B)(i) above up
to an aggregate nominal amount of GBP 931,873 (representing approximately ten per cent of the Company's issued
share capital (excluding shares held in treasury) as at the date hereof).

Notes

1. Members are entitled to appoint a proxy to exercise all or any of their rights to attend and to speak and vote on their

behalf at the AGM. A Shareholder may appoint more than one proxy in relation to the AGM provided that each proxy is
appointed to exercise the rights attached to a different share or shares held by that Shareholder and further provided that
either (i) each proxy is appointed in respect of a different shareholding account of that Shareholder, or (ii) the Shareholder
appointing multiple proxies in respect of its shareholding is a professional that is acting on behalf of other individuals or
bodies corporate in respect of its shareholding. A proxy need not be a Shareholder of the Company. A Form of Proxy which
may be used to make such appointment and give proxy instructions accompanied the notice of AGM that Shareholders
have been sent by post. If you do not have a Form of Proxy and believe that you should have one, or if you require additional
forms, please contact Capita Asset Services on 0871 664 0300. Calls to this number cost 12p per minute plus your phone
company's access charge. If you are outside of the United Kingdom, please call +44 371 664 0300. Calls outside the United
Kingdom will be charged at the applicable international rate. Lines are open 9.00 a.m. (UK time) to 5.30 p.m. (UK time),
Monday to Friday (with the exception of UK bank and public holidays).To be valid, any Form of Proxy or other instrument
appointing a proxy must be received by post or (during normal business hours only) by hand at Capita Registrars (Jersey)
Limited, PXS, 34 Beckenham Road, Beckenham, BR3 4TU no later than 11.00 a.m. (Luxembourg time) on 15 May 2016.
Shareholders wishing to appoint a proxy electronically should do so by 11.00 a.m. (Luxembourg time) on 15 May 2016
by visiting www.capitashareportal.com and following the instructions.

2. The return of a completed Form of Proxy or online proxy appointment or CREST Proxy Instruction (as defined in

paragraph 10 below) will not prevent a Shareholder attending the AGM and voting in person if he / she wishes to do so.

3. In the case of a member which is a company, the Form of Proxy must be executed under its common seal or signed

on its behalf by an officer of the company or an attorney for the company.

4. Any power of attorney or any other authority under which the Form of Proxy is signed (or a duly certified copy of

such power or authority) must be included with the Form of Proxy.

5. Any person to whom this notice is sent who is a person nominated under Article 62 of the Company's Articles of

Association  to  enjoy  information  rights  (a  "Nominated  Person")  may,  under  an  agreement  between  him  /  her  and  the
Shareholder by whom he / she was nominated, have a right to be appointed (or to have someone else appointed) as a proxy
for the AGM. If a Nominated Person has no such proxy appointment right or does not wish to exercise it, he / she may,
under any such agreement, have a right to give instructions to the Shareholder as to the exercise of voting rights.

6. The statements of the rights of Shareholders in relation to the appointment of proxies in paragraphs 1 and 2 above do

not apply to Nominated Persons. The rights described in these paragraphs can only be exercised by Shareholders. Nominated
persons are reminded that they should contact the registered holder of their shares (and not the Company) on matters relating
to their investment in the Company.

7. The Company has chosen not to require Shareholders to notify the Company of their intention to participate in the

AGM at least 14 days ahead of the meeting. Pursuant to Article 40(1) of the Companies (Uncertificated Securities) (Jersey)
Order 1999, to be entitled to attend and vote at the AGM (and for the purpose of the determination by the Company of the
votes they may cast), Shareholders must be registered in the register of members of the Company at 6.00 p.m. (Luxembourg
time) on 15 May 2015 (or, in the event of any adjournment, 6.00 p.m. (Luxembourg time) on the date which is two days
before the time of the adjourned meeting). Changes to the register of members after the relevant deadline shall be disregarded
in determining the rights of any person to attend and vote at the meetings. Any person who has sold or otherwise transferred
his or her registered holding of Ordinary Shares in the Company (the "Transferring Shareholder") should pass all the
documentation he or she has received in relation to the AGM to the purchaser or transferee or to the person who arranged
for the sale or transfer so they can pass those documents to the person who now holds the shares. In selling or otherwise
transferring such shares, the Transferring Shareholder will cede his/her/its rights to attend and vote at the AGM to the
purchaser or transferee. All Shareholders, and only those Shareholders, who are registered in the register of members of
the Company at 6.00 p.m. (Luxembourg time) on 15 May 2016 shall be entitled to attend and vote at the AGM.

8. As at 13 April 2016, the Company's issued share capital consists of 950,969,822 Ordinary Shares, of which 19,096,349

are held in treasury. The total voting rights in the Company are therefore 931,873,473.

9. CREST members who wish to appoint a proxy or proxies through the CREST electronic proxy appointment service

may do so by using the procedures described in the CREST Manual. CREST Personal Members or other CREST sponsored
members, and those CREST members who have appointed a service provider(s), should refer to their CREST sponsor or
voting service provider(s), who will be able to take the appropriate action on their behalf.

10. In order for a proxy appointment or instruction made using the CREST service to be valid, the appropriate CREST

message (a "CREST Proxy Instruction") must be properly authenticated in accordance with Euroclear UK &amp; Ireland Lim-
ited's specifications, and must contain the information required for such instruction, as described in the CREST Manual
(available at www.euroclear.com). The message, regardless of whether it constitutes the appointment of a proxy or is an
amendment to the instruction given to a previously appointed proxy must, in order to be valid, be transmitted so as to be
received by the issuer's agent (ID RA10) by 11.00 a.m. (Luxembourg time) on 15 May 2016. For this purpose, the time of

53873

L

U X E M B O U R G

receipt will be taken to be the time (as determined by the time stamp applied to the message by the CREST Application
Host) from which the issuer's agent is able to retrieve the message by enquiry to CREST in the manner prescribed by
CREST. After this time any change of instructions to proxies appointed through CREST should be communicated to the
appointee through other means.

11. CREST members and, where applicable, their CREST sponsors or voting service providers should note that Euroclear

UK &amp; Ireland Limited does not make available special procedures in CREST for any particular message. Normal system
timings and limitations will, therefore, apply in relation to the input of CREST Proxy Instructions. It is the responsibility
of the CREST member concerned to take (or, if the CREST member is a CREST personal member, or sponsored member,
or has appointed a voting service provider, to procure that his CREST sponsor or voting service provider(s) take(s)) such
action as shall be necessary to ensure that a message is transmitted by means of the CREST system by any particular time.
In this connection, CREST members and, where applicable, their CREST sponsors or voting system providers are referred,
in particular, to those sections of the CREST Manual concerning practical limitations of the CREST system and timings.

12. The Company may treat as invalid a CREST Proxy Instruction in the circumstances set out in Article 34 of the

Companies (Uncertificated Securities) (Jersey) Order 1999.

13. A Shareholder which is a body corporate and which wishes to be represented at the AGM, other than by way of a

proxy, by a person with authority to speak and vote (a "corporate representative") must appoint such a person by resolution
of its directors or other governing body. A corporate representative has the same powers on behalf of the body corporate
he / she represents as that body corporate could exercise if it was an individual member of the Company.

14. As provided in Article 82 of the Company's Memorandum and Articles of Association, voting on all resolutions set

out in this notice (which are Substantive Resolutions under the Company's Memorandum and Articles of Association) will
be conducted by way of a poll rather than on a show of hands.

15. In the case of joint holders, where more than one of the joint holders purports to appoint a proxy, only the appointment

submitted by the most senior holder will be accepted. Seniority is determined by the order in which the names of the joint
holders appear in the Company's register of members in respect of the joint holding (the first-named being the most senior).

16. If you submit more than one valid proxy appointment in respect of the same share, the appointment received last

before the latest time for the receipt of proxies will take precedence.

17. The Company intends to seek the separate approval of its Independent Shareholders for each of resolutions 13-18

proposing  the  election  of  an  independent  Director.  Such  approval  will  be  sought  following  the  vote  on  each  of  those
resolutions by the Shareholders and will be sought by discounting from the result of the vote on each such resolution the
votes of those Shareholders who are identified as controlling shareholders of the Company as at 6.00 p.m. (Luxembourg
time) on 15 May 2016 (or, in the event of any adjournment, 6.00 p.m. (Luxembourg time) on the date which is two days
before the time of the adjourned meeting). As at the Latest Practicable Date, Mr. Dixon held 294,701,874 Ordinary Shares
in the Company, representing approximately 31.62 per cent of the total voting rights in the Company. Separate approval
will be given by the Independent Shareholders if it is given by Independent Shareholders representing a simple majority
of the total voting rights of Independent Shareholders who vote. The Company will, on announcing the result of the AGM,
announce, in respect of resolutions 13-18, the result of both the vote of the Shareholders and the vote of the Independent
Shareholders. If separate Independent Shareholder approval is not given for any relevant resolution, the Company intends
that  the  relevant  appointment  will  continue  for  120  days  from  the  date  of  the  original  vote,  unless  a  further  ordinary
resolution for re-election is passed. If a further resolution to approve the re-election of the relevant Director is defeated,
his or her appointment will cease on that resolution being defeated.

18. Members who have general queries about the AGM should contact the Company's registrar, Capita on its shareholder

helpline 0871 664 0300. Calls to this number cost 12p per minute plus your phone company's access charge. Calls outside
the United Kingdom will be charged at the applicable international rate. Lines are open 9.00 a.m. (UK time) to 5.30 p.m.
(UK time), Monday to Friday (with the exception of UK bank and public holidays). No other method of communication
will be accepted. You may not use any electronic address provided either in this notice or any related documents (including
the letter from the Chairman and Form of Proxy) to communicate with the Company for any purposes other than those
expressly stated.

19. Under Article 64 of the Company's Memorandum and Articles of Association, Shareholders meeting the threshold

requirements set out in that Article have the right to require the Company to publish on a website a statement setting out
any matter relating to: (i) the audit of the Company's accounts; or (ii) any circumstance connected with an auditor of the
Company ceasing to hold office. The Company would not require the Shareholders requesting such a website publication
to pay the Company's expenses in complying with Article 64 and, if required to place a statement on a website under that
Article, it will forward the statement to the Company's auditor not later than the time it makes the statement available on
the website. The business which may be dealt with at the AGM includes any statement that the Company has been required
under Article 64 to publish on a website.

20. Any member attending the AGM has the right to ask questions. The Company must cause to be answered any such

question relating to the business being dealt with at the meeting but no such answer need be given if: (i) to do so would
interfere unduly with the preparation for the meeting or involve the disclosure of confidential information, (ii) the answer
has already been given on a website in the form of an answer to a question, or (iii) it is undesirable in the interests of the
Company or the good order of the meeting that the question be answered.

53874

L

U X E M B O U R G

21. Shareholders have certain rights to request that the Company add an item to the agenda of the AGM or to provide

a draft resolution to be proposed at the AGM. To be valid, such a request must be received by the Company at its head
office (26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg or Lynsey.Blair@regus.com) not later
than 25 April 2016 and must meet certain other requirements. Further information regarding the other requirements that
must be met for Shareholders to exercise these rights can be found in Article 60 (Members' resolutions) and Article 63
(Addition of points to agenda) of the Company's Memorandum and Articles of Association, which are available on the
Company's website at www.regus.com.

22. A copy of this notice (which contains the full unabridged text of the resolutions to be proposed at the AGM), a copy

of the Company's Memorandum and Articles of Association and, where relevant, any members' statements, members'
resolutions  and  members'  matters  of  business  received  by  the  Company  after  the  date  of  this  notice,  can  be  found  at
www.regus.com. The documents to be submitted to the AGM (being the consolidated and standalone financial statements
of the Company for the financial year ended 31 December 2015, and the reports of the Board and the approved independent
auditors thereon) form part of the annual report of the Company for the year ended 31 December 2015, which is also
available at www.regus.com. Should you wish to request a further copy of this document or the annual report, please send
your  request  to  Capita  Registrars  (Jersey)  Limited,  12  Castle  Street,  St  Helier,  Jersey  JE2  3RT  or
shareholderenquiries@capita.co.uk. Other relevant documents and information relating to the AGM will be available for
inspection at the Company's head office in Luxembourg at 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, the Company's
registered office in Jersey at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX and at the offices of Slaughter and May, One
Bunhill Row, London EC1Y 8YY from 15 April 2016 until the end of the AGM as well as on the Company's website
(www.regus.com).

23. Capitalised terms in this notice shall have the meaning as set out in the Company's Memorandum and Articles of

Association and the circular dated 15 April 2016 relating to the AGM, which are available for inspection according to item
22 above.

15 April 2016

Regus plc (société anonyme)

<i>The Board of Directors

Référence de publication: 2016091760/303.

Synapsia SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 159.857.

DISSOLUTION

In the year two thousand sixteen, on the fourth day of April.
Before the undersigned Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg.

Was held

an Extraordinary General Meeting of shareholders of "SYNAPSIA S.A.” (the Company), established under the laws of

Luxembourg, having its registered office at 52, route d'Esch, L-2965 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 159.857, incorporated pursuant to a deed of the notary Gérard LECUIT, residing
then in Luxembourg, dated 17 March 2011, published on 21 June 2011 in the Luxembourg official gazette (Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations) C-N°1339. The articles of which have been amended for the last time pursuant to a
notarial deed of the same notary on 20 March 2012, published in the Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et associations
number 877 on 4 April 2012.

The company was set into liquidation by a deed of the undersigned notary on 16 March 2016, not yet published in the

Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened by Mr Karl PITTEVILS, private employee, residing professionally in Luxembourg, being in

the chair,

who appointed as secretary Mrs. Mrs Ingrid LENTZ, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Geoffroy PIERRARD, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. It appears from the attendance list that all 1,310 (one thousand three hundred and ten) shares in registered form

representing the entire subscribed share capital of the Company amounting to EUR 131,000 (one hundred thirty-one thou-
sand euros), are present or duly represented at the Meeting.

The shareholders present or represented declare that they have had due notice of, and have been duly informed of the

agenda, prior to the Meeting. The Meeting decides to waive the convening notices.

II. The agenda of the meeting is the following:
1. Approval of the audit report.
2. Discharge to the liquidator and the independent auditor (commissaire à la liquidation) for the performance of their

mandate.

53875

L

U X E M B O U R G

3. Closing of the liquidation.
4. Fixing of the place where the company’s documents and vouchers are to be kept during the five years following the

closing of the liquidation.

5. Sundries
III. The extraordinary general meeting of shareholders, at its meeting held in private deed on 4 April 2016, has nominated

as “commissaire à la liquidation” ERNST &amp; YOUNG, independent auditor, with registered office located L-1855 Luxem-
bourg, avenue John F. Kennedy 35E, after having heard the liquidator’s report,

and has fixed at this day, hour and location the present meeting.
IV. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their

shares, all issued in registered form, are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the
proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
V. As appears from the said attendance list, 1,310 (one thousand three hundred and ten) shares out of 1,310 (one thousand

three hundred and ten) shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting
can validly decide on all the items of the agenda.

VI.  As  a  consequence,  more  than  half  of  the  capital  being  present  or  represented,  the  present  meeting  is  regularly

constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting hears the audit report of ERNST &amp; YOUNG, with registered office at L-1855 Luxembourg, avenue

John F. Kennedy 35E, previously named, on the verification of the documents of the liquidation and the work of the
liquidator.

This report proposes to adopt the accounts of the liquidation and to grant discharge to the liquidator.

<i>Second resolution

Adopting the conclusion of the audit report, the general meeting approves the accounts of the liquidation and grants full

and complete discharge, without any reserve nor restriction, to the liquidator, ING Luxembourg, Société Anonyme, re-
presented by Mr Jean-Philippe FOHAL, having its registered office at 52 route d’Esch, L-2965 Luxembourg, RCS B 6041.

The general meeting grants the same discharge to the “commissaire à la liquidation”, previously named.

<i>Third resolution

The general meeting declares the liquidation as accomplished and the company "SYNAPSIA S.A.” to have ceased to

exist.

ING Luxembourg, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, declares to be committed to the extent

necessary, to assume any liability of the Company which has not been declared and taken into the Company’s liquidation
account.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides that the company’s documents and vouchers are to be kept during the five years following

the closing of the liquidation at the registered seat of ING Luxembourg S.A., 52, route d’Esch, L-2965 Luxembourg or any
change its registered seat thereafter.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la version française:

L'an deux mil seize, le quatre avril.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SYNAPSIA S.A.», une société anonyme

de droit luxembourgeois ayant son siège social au 52, route d'Esch, L-2965 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159857, constituée suivant acte du notaire Gérard LECUIT,

53876

L

U X E M B O U R G

alors de résidence à Luxembourg, du 17 mars 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C ? N° 1339,
en date du 21 juin 2011, les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du même notaire en date du
20 mars 2012, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et associations 877 du 4 avril 2012.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 mars 2016, en cours de

publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Karl PITTEVILS, employé, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Ingrid LENTZ, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée  choisit  comme  scrutateur  Monsieur  Geoffroy  PIERRARD,  employé,  demeurant  professionnellement  à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Qu’il ressort de la liste de présence que la totalité des 1.310 (mille trois cent dix) actions, toutes sous forme nominative,

représentant la totalité du capital souscrit de la Société qui s’élève à EUR 131.000 (cent trente et un mille euros) est présente
ou représentée à la présente assemblée générale. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente
assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant
l'assemblée, l'assemblée décide de faire abstraction des convocations d’usage.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Approbation du rapport du commissaire
2) Décharge au liquidateur et au réviseur d’entreprises (commissaire à la liquidation) pour l'exécution de leur mandat
3) Clôture de la liquidation
4) Fixation de l'endroit où les livres et documents de la société seront gardés durant les cinq années qui suivront la clôture

de la liquidation.

5) Divers.
III.- Que l'assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé en date du 4 avril 2016, après avoir entendu le rapport

du liquidateur, a nommé en sa qualité de commissaire à la liquidation:

ERNST &amp; YOUNG, réviseur d’entreprises, avec siège social à L-1855 Luxembourg, avenue John F. Kennedy 35E, a

fixé à ce jour, heure et lieu la présente assemblée.

IV.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, toutes émises sous forme nominatives, sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de
présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés
ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne

varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

V.- Qu’il ressort de la dite liste de présence que 1.310 (mille trois cent dix) actions sur les 1.310 (mille trois cent dix)

actions en circulation sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale.

VI.- Qu’en conséquence la présente assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement constituée

et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-

tration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée entend le rapport de ERNST &amp; YOUNG, réviseur d’entreprises, sur l'examen des documents de la liqui-

dation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.

<i>Deuxième résolution

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et

entière, sans réserve ni restriction, au liquidateur ING Luxembourg, Société Anonyme, représentée par Monsieur Jean-
Philippe FOHAL, avec siège social sis 52 route d’Esch, L-2965 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B6041, au sujet de sa gestion de liquidateur de la société.

L'assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l'exécution de son mandat.

53877

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'assemblée prononce la clôture de liquidation et constate que la société «SYNAPSIA S.A.» a définitivement cessé

d'exister.

La société ING Luxembourg, en tant qu’actionnaire unique de la Société, s’engage pour autant que de besoin, à reprendre

à sa charge toute dette éventuelle de la Société qui n’aurait pas été déclarée et prise en compte dans le cadre de la liquidation.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir

d'aujourd'hui au siège social d’ING Luxembourg, à L-2965 Luxembourg, route d’Esch ou à tout changement d’adresse de
son siège social dans le future.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, profession, état et demeure,

ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. PITTEVILS, I. LENTZ, G. PIERRARD, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 06 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/11208. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016091632/162.
(160059916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2016.

BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. Banque Degroof Luxembourg S.A.).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 25.459.

L’an deux mille seize, le premier avril, à 14.00 heures.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agis-

sant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

s’est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.», une société

anonyme, régie par le droit luxembourgeois ayant son siège social au 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B25459, constituée suivant acte notarié en date
du 29 janvier 1987, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 116 du 29 avril 1987. Les statuts
de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER,
en date du 28 septembre 2015, publié au Mémorial C numéro 3160 du 20 novembre 2015 (la "Société").

L'assemblée  est  présidée  par  Monsieur  Alain  Schockert,  demeurant  professionnellement  au  44,  rue  de  L’industrie,

B-1040 Bruxelles.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Serwy, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-François Leidner, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Le Président expose ensuite:
(i) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:
a. au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 754 du 14 mars 2016 et N°840 du 23 mars 2016;
b. au «Luxemburger Wort», le 14 mars 2016 et le 23 mars 2016;
(ii) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

53878

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale en «BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG S.A.» et modi-

fication subséquente de l'article 1 des Statuts;

2. Modification de l'objet social afin de l'étendre à l'activité de courtier en assurance, et modification subséquente de

l'Article 3 des Statuts;

3. Nomination de nouveaux Administrateurs;
4. Divers.
(ii)  Que  les  actionnaires  présents  ou  représentés,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés,  ainsi  que  le  nombre

d’actions, qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants resteront

pareillement annexées aux présentes.

(iv) Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les sept cent quarante mille (740.000) actions formant l'intégralité

du capital social, sept cent trente-neuf mille sept cent deux (739.702) actions sont présentes ou représentées à la présente
assemblée et les actionnaires présents ou représentés.

(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les

points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de modifier la dénomination sociale en «BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG

S.A.».

En conséquence, l'Article 1 

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe, par les présentes, une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de «BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG S.A.».»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier l'objet social afin de l'étendre à l'activité de courtier en assurance.
En conséquence, l'Article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«  Art. 3.  La  société  a  pour  l'objet  d’exercer,  tant  au  Grand-Duché  de  Luxembourg  qu’à  l'étranger,  toutes  activités

bancaires et financières autorisées aux banques aux termes de la loi luxembourgeoise relative au secteur financier telle
qu’en vigueur.

La société peut effectuer toutes opérations financières, comprenant notamment (mais non exclusivement) la réception

de dépôt à vue et à terme libellés en n’importe quelle monnaie, l'octroi de prêts de toute nature libellées en n’importe quelle
monnaie, arbitrage en devises, conservation de valeurs mobilières, gestion de patrimoines, prises fermes d’actions et/ou
d’obligations, encaissement de coupons, avec pouvoir de faire des opérations d’endossement, d’escompte ou de réescompte,
de vente, de disposition, ainsi que toutes autres opérations relatives à des bons, traites acceptées, bons de caisse et d’autres
obligations de toutes espèces, et avec pouvoir d’accorder des crédits de toutes sortes, d’émettre et de confirmer des lettres
de crédit ainsi que des crédits documentaires de toutes espèces, ainsi que toutes autres activités industrielles, commerciales
ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à son objet principal décrit ci-dessus et toutes participations
à des emprunts ou prêts, ainsi que l'acquisition, la détention et la disposition, par n’importe quelle voie, de parts, actions,
obligations, bons et valeurs de toutes espèces de toute autre société. La société peut aussi entreprendre pour son propre
compte ou pour compte de tiers la préparation et la promotion de projets d’investissement et de développement ainsi que
toutes opérations financières ou bancaires, pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation des objets ci-
avant décrits. Les dispositions qui précèdent doivent être entendues dans le sens le plus large.

La société a également pour objet le courtage en assurances par l'intermédiaire d’une ou plusieurs personnes physiques

dûment agréées, et toutes les activités connexes qui peuvent s’y rattacher, conformément aux dispositions de la loi modifiée
du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide, sur proposition du conseil d’administration, de nommer quatre (4) nouveaux administrateurs pour

une durée de trois (3) ans, à savoir:

- Monsieur Christian Jacobs, Administrateur, demeurant au 26, Osselstraat, B-1785 Brussegem,
- Madame Nathalie Basyn, Administrateur, demeurant professionnellement au 44, rue de l'Industrie, B-1040 Bruxelles,
- Monsieur Gilles Firmin, Administrateur, demeurant professionnellement au 44, rue de l'Industrie, B-1040 Bruxelles.

53879

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Xavier Van Campenhout, Administrateur, demeurant professionnellement au 44, rue de l'Industrie, B-1040

Bruxelles.

Plus rien n’étant à l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci a été clôturée à

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ceux-ci ont signé le présent acte avec Nous notaire.
Signé: A. SCHOCKERT, C. SERWY, J.F. LEIDNER, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 05 avril 2016. Relation: EAC/2016/8238. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2016089295/90.
(160058096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.

Lecorsier Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.760.

L'an deux mille quinze, le vingt et un décembre.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Lecorsier Finance S.A, une société anonyme ayant

son siège social au 49, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 112.760, constituée suivant acte du notaire instrumentant
en date du 12 décembre 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 532 du 14 mars 2006 (la
"Société"). Les statuts on été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant du 23 décembre 2014,
publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 630 du 6 mars 2015.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy DECKER, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Ingrid LAFOND, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Karl GUÉNARD, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Réduction du capital social de la Société du montant de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000) en vue de

le porter de son montant actuel de DEUX CENT QUARANTE-HUIT MILLE EUROS (248.000.-EUR) à DEUX CENT
DIX SEPT MILLE EUROS (217.000.-EUR) par annulation des TROIS CENT DIX (310) actions de classe H détenues par
la Société.

2. Modification de l’article 3 des statuts de la société.
3. Divers.
- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste de présence, signée par les comparants, le notaire, le président, le scrutateur et le secrétaire, ensemble
avec les procurations signées «Ne Varietur» par les comparants, le notaire, le président, le scrutateur et le secrétaire resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des

convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de même que le projet des résolutions.

- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement

délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

L'assemblée générale (l’«Assemblée»), après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social de la société à concurrence du montant de TRENTE ET UN MILLE

EUROS (EUR 31.000) en vue de le porter de son montant actuel de DEUX CENT QUARANTE-HUIT MILLE EUROS
(248.000,-EUR) à DEUX CENT DIX SEPT MILLE EUROS (217.000,-EUR) par annulation des TROIS CENT DIX (310)
actions de classe H rachetées par la société conformément aux dispositions de l’article 49-8 de la loi du 8 août 1915 sur les
sociétés commerciales et l’article 4 des statuts.

<i>Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l’Assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur

suivante:

53880

L

U X E M B O U R G

« Art. 3.
3.1 Le capital social de la Société est fixé à deux cent dix sept mille euros (EUR 217.000,-) représenté par:
- trois cent dix (310) actions de classe A (les «Actions de Classe A»),
- trois cent dix (310) actions de classe B (les «Actions de Classe B»),
- trois cent dix (310) actions de classe C (les «Actions de Classe C»),
- trois cent dix (310) actions de classe D (les «Actions de Classe D»),
- trois cent dix (310) actions de classe E (les «Actions de Classe E»),
- trois cent dix (310) actions de classe F (les «Actions de Classe F»),
- trois cent dix (310) actions de classe G (les «Actions de Classe G»),
ayant une valeur nominale par action de cent euros (EUR 100).
Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
3.2 Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
3.3 Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

3.4 Toute prime d'émission disponible est librement distribuable. Sur décision de l'assemblée générale des actionnaires,

la prime d'émission peut être affectée à la réserve légale.»

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges relatifs au présent acte s'élèvent approximativement à mille soixante quinze

euros (1.075 EUR).

<i>Déclaration

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, connus du notaire par leur nom, prénom, état

civil et lieu de résidence, lesdites parties signent ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: G. DECKER, I. LAFOND, K. GUÉNARD, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41836. Reçu soixante-quinze

euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Référence de publication: 2016057534/77.
(160017579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Veda International S.à .rl., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 203.303.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the fourteenth day of January.
Before Us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

KKR European Fund IV L.P., a exempted limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, with regis-

tered office at Maples Corporate Services Limited, Ugland House, P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands, and registered with the Cayman Islands registrar of limited partnerships under number MC-80290,

here represented by:
Ben Brouscher, private employee, residing in Diekirch, by virtue of a proxy, given under private seal, such proxy, signed

by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such proxy holder, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of

incorporation of a société à responsabilité limitée, which the prenamed party declared to form:

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name There is hereby established a société à responsabilité limitée (the “Company”) governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the “Articles of Incorpora-
tion”).

53881

L

U X E M B O U R G

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of “Veda International S.à r.l.”

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Manager

(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the

Manager(s).

In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of com-
munications  with  such  office  or  between  such  office  and  persons  abroad,  the  Company  may  temporarily  transfer  the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by
the Manager(s).

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in

foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other

kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets

in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well

as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by

the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

divided into

Thousand two hundred and fifty (1,250) class A shares (the “Class A Shares”),
Thousand two hundred and fifty (1,250) class B shares (the “Class B Shares”),
Thousand two hundred and fifty (1,250) class C shares (the “Class C Shares”),
Thousand two hundred and fifty (1,250) class D shares (the “Class D Shares”),
Thousand two hundred and fifty (1,250) class E shares (the “Class E Shares”),
Thousand two hundred and fifty (1,250) class F shares (the “Class F Shares”),
Thousand two hundred and fifty (1,250) class G shares (the “Class G Shares”),
Thousand two hundred and fifty (1,250) class H shares (the “Class H Shares”),
Thousand two hundred and fifty (1,250) class I shares (the “Class I Shares”),
Thousand two hundred and fifty (1,250) class J shares (the “Class J Shares”),
with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles

of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make dis-
tributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst

them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.

53882

L

U X E M B O U R G

When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders but

the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least three
quarters (3/4) of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the shareholder(s).

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several

times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles
of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Death, Suspension of civil rights, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, death,

suspension of civil rights, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the
Company into liquidation.

Chapter III. Managers, Auditors

Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves

(the “Manager(s)”).

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the “Board of Managers”).
The  Managers  will  be  appointed  by  the  shareholder(s),  who  will  determine  their  number  and  the  duration  of  their

mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the “Class A Managers”) or

class B Managers (the “Class B Managers”).

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or

useful for accomplishing the Company’s object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder

(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or proxies,

or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the signature

of any one manager if more than one Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company

will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom

special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the “Chairman”). It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board of Managers (the “Secretary”).

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers

may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present
or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days’ written

notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent
of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places specified
in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers

may from time to time determine.

53883

L

U X E M B O U R G

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent
one or several members of the Board of Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers holding

office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers, such
quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means of

communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary

(if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed

by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a

management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the pursuit
of the Company’s corporate object.

Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any

transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an

opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager,  associate,  member,  shareholder,  officer  or  employee  of  such  other  company  or  firm.  Any  person  related  as
described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not,
by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Managers’ Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal

obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any Manager, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors,

heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or
employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder
or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally
adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement,
indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company
is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The
foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the
Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company’s annual statutory and/or consolidated accounts

must be audited by an approved statutory auditor, the business of the Company and its financial situation, including in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory auditors
who need not be shareholders themselves.

The statutory or approved statutory auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the

number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at
any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved statutory
auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.

53884

L

U X E M B O U R G

Chapter IV. Shareholders

Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the

Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of
shareholders.

Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the

Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on first Wednesday of June at 10 a.m.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the

next following business day.

Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five

(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a
single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders
are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed
resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the
transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the
general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement
of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a

general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or
the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders repre-
senting more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and,
if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of sha-

reholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as
a proxy holder.

Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person

designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending

the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority
requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and majority rules set
for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than
half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders
shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares
represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the

purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to
the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements shall
be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and

may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.

53885

L

U X E M B O U R G

Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting

of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by any two (2)
Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits

Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager

(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the
Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If

the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year

be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits

will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available

reserves derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect shall be distributed
in the following order of priority:

- First, the holders of Class A Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an

amount of one point ninety per cent (1.90%) of the nominal value of the Class A Shares held by them, then,

- the holders of Class B Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of one point eighty per cent (1.80%) of the nominal value of the Class B Shares held by them, then,

- the holders of Class C Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of one point seventy per cent (1.70%) of the nominal value of the Class C Shares held by them, then,

- the holders of Class D Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of one point sixty per cent (1.60%) of the nominal value of the Class D Shares held by them, then,

- the holders of Class E Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of one point fifty per cent (1.50%) of the nominal value of the Class E Shares held by them, then,

- the holders of Class F Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of one point forty per cent (1.40%) of the nominal value of the Class F Shares held by them, then

- the holders of Class G Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of one point thirty per cent (1.30%) of the nominal value of the Class G Shares held by them, then

- the holders of Class H Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of one point twenty per cent (1.20%) of the nominal value of the Class H Shares held by them, then

- the holders of Class I Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of one point ten per cent (1.10%) of the nominal value of the Class I Shares, and then,

- the holders of Class J Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
Should the whole last (by alphabetical order) outstanding class of shares have been cancelled following its redemption,

repurchase or otherwise at the time of the distribution (e.g. Class J Shares), the remainder of any dividend distribution shall
then be allocated to the preceding last outstanding class of shares in the reverse alphabetical order (e.g. Class I Shares).

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)

may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half

of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may

be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compen-
sation.

53886

L

U X E M B O U R G

After  payment  of  all  the  debts  of  and  charges  against  the  Company,  including  the  expenses  of  liquidation,  the  net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Chapter VII. Applicable law

Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company’s shares have

been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one hundred
per cent (100%) paid in cash as follows:

Shareholder

Class of shares Subscribed

capital

number

of

shares

amount

paid-in

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Class A Shares

1,250

1,250

1,250

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Class B Shares

1,250

1,250

1,250

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Class C Shares

1,250

1,250

1,250

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Class D Shares

1,250

1,250

1,250

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Class E Shares

1,250

1,250

1,250

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Class F Shares

1,250

1,250

1,250

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Class G Shares

1,250

1,250

1,250

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Class H Shares

1,250

1,250

1,250

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Class I Shares

1,250

1,250

1,250

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Class J Shares

1,250

1,250

1,250

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500

12,500

12,500

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) was thus as from that moment at the disposal of the

Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for
in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).

<i>Transitory Provisions

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day

of December of 2016.

<i>Shareholders resolutions

<i>First Resolution

The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 61, rue de Rollingergrund, L-2440

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Second Resolution

The general meeting of shareholders resolved to set at four (4) the number of Manager(s) and further resolved to appoint

the following for an unlimited duration:

- Edouard Pillot, born on 19 December 1977 in Paris, France, with professional address at Stirling Square, 7 Carlton

Gardens, SW1Y 5AD, London, United Kingdom.;

- Anders Borg, born on 24 November 1976 in Lundby, Sweden, with professional address at Stirling Square, 7 Carlton

Gardens, SW1Y 5AD, London, United Kingdom;

- Stefan Lambert, born on 8 January 1964 at Trier, Germany, professionally residing at 61, rue de Rollingergrund, L-2440

Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg); and

- Dr Wolfgang Zettel, born on 15 November 1962 at Konstanz, Germany, professionally residing at 61, rue de Rollin-

gergrund, L-2440 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present deed

has been worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.

53887

L

U X E M B O U R G

Whereupon the present deed was drawn up in Diekirch by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning

of this document.

The document having been read to the appearing person(s), who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le quatorzième jour de janvier.
Par devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

ont comparu:

KKR European Fund IV L.P., une société en commandite constituée en vertu du droit des îles Caïmans, ayant son siège

à Ugland House, South Church Street, PO Box 309GT, Grand Cayman KY1-1104, Îles Caïmans et enregistré auprès du
Registre des sociétés des Îles Cayman sous le numéro MC-80290,

ici représentée par:
Ben Brouscher, employé privé, demeurant à Diekirch, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé; laquelle

procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins d’enregistrement.

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire soussigné de dresser ainsi qu’il suit les statuts d’une

société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée a déclaré constituer:

Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie

par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans la

limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination «Veda International S.à r.l.»

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision des Gérants.
Des  succursales  ou  d’autres  bureaux  peuvent  être  établis  soit  au  Grand-Duché  de  Luxembourg  ou  à  l’étranger  par

décision des Gérants.

Dans l’hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social

sont de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou entre ce siège et l’étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer
provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures pro-
visoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera
régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les Gérants.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et

entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés

sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d’entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société
fait partie.

La Société peut également investir dans l’immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier

ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission privée d’obligations, de billets à

ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d’actions.

D’une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu’elle estime

utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité

requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l’article 29 des Statuts.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cent Euro (EUR 12.500,-) divisé en mille

deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie A (les “Parts Sociales de Catégorie A”), mille deux cent cinquante
(1.250) parts sociales de catégorie B (les “Parts Sociales de Catégorie B”) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales
de catégorie C (les “Parts Sociales de Catégorie C”) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie D (les
“Parts Sociales de Catégorie D”) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie E (les “Parts Sociales de
Catégorie E”) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie F (les “Parts Sociales de Catégorie F”) mille
deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie G (les “Parts Sociales de Catégorie G”) mille deux cent cinquante

53888

L

U X E M B O U R G

(1.250) parts sociales de catégorie H (les “Parts Sociales de Catégorie H”) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales
de catégorie I (les “Parts Sociales de Catégorie I”) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie J (les “Parts
Sociales de Catégorie J”),

ayant une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.
Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes

d’émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d’émission peut être
utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette
réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou

non parmi eux.

Lorsque la Société ne compte qu’un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales

ne peuvent être cédées à des non-associés qu’avec l’autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital
social.

La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Une telle cession n’est

opposable à la Société ou aux tiers qu’après avoir été dûment notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément à
l’article 1690 du code civil luxembourgeois.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.
La propriété d’une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement

adoptées par les associés.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou

plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou,
le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Incapacité, Décès, Suspension des droits civils, Faillite ou Insolvabilité d’un Associé. L’incapacité, le décès, la

suspension des droits civils, la faillite, l’insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un associé n’entraîne pas
la mise en liquidation de la Société.

Chapitre III. Gérants, Commissaires

Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n’ont pas besoin d’être associés (les

«Gérants»).

Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.
Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants

peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Les associés pourront qualifier les gérants nommés de Gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») ou Gérants

de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

Les associés ne participeront ni ne s’immisceront dans la gestion de la Société.

Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés
par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la compétence des Gérants.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des

mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature d’un des

Gérants si plus d’un Gérant a été nommé.

Toutefois, si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société ne

sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d’un Gérant de Catégorie A et d’un Gérant de Catégorie B.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute

personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Dans l’hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes

s’appliqueront:

Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un

secrétaire qui n’a pas besoin d’être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procèsverbaux du Conseil de
Gérance (le «Secrétaire»).

53889

L

U X E M B O U R G

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée

si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera

un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Sauf en cas d’urgence ou avec l’accord préalable de tous ceux qui ont le droit d’y assister, une convocation écrite devra

être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout
moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit. La convocation indiquera la date, l’heure et le lieu
de la réunion ainsi que l’ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un
accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera requise
pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil de
Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance pourra

déterminer de temps à autre.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout

moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout Gérant
peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est

présente ou représentée, sous réserve que dans l’hypothèse où des Gérants de Catégorie A ou des Gérants de Catégorie B
ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B sont
présents ou représentés.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.
Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre

moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément
les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée

à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou
plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.

Art. 13. Résolutions des Gérants. Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire

(s’il y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs,

pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d’un Gérant a été nommé.

Art. 14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l’approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une ré-

munération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu’ils auront exposées
en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l’objet social de la Société.

Art. 15. Conflits d’Intérêt. Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de

la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote
sur une telle transaction.

Dans l’hypothèse d’un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues

entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l’opération en question est conclue à des

conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le

simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant,
collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entreprise. Toute personne liée de la
manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d'affaires,  ne  devra  pas  en  raison  de  cette  affiliation  à  cette  société  ou  entreprise,  être  automatiquement  empêchée  de
délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

Art. 16. Responsabilité des Gérants-Indemnisation. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque,

dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout Gérant, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs,

leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu’ils ont à payer et tous frais
raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des
procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de Gérant(s),
de fondé de pouvoir ou d’employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la

53890

L

U X E M B O U R G

Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur
responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation
ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit
confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’est pas coupable de négligence grave ou mauvaise
gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d’autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre
en vertu des Statuts.

Art. 17. Commissaires. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la

Société doivent être vérifiés par un réviseur d’entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en
particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être contrôlés par un ou plusieurs
commissaires qui n’ont pas besoin d’être eux-mêmes associés.

Le(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d’entreprises agréé(s) seront, le cas échéant, nommés par les associés qui détermi-

neront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d’entreprises agréé peut seulement, par
dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves ou d’un commun accord.

Chapitre IV. Des associés.

Art. 18. Pouvoirs des Associés. Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si la

Société ne compte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l’assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l’ensemble des associés.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle des Associés L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas

où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le premier mercredi de juin à 10 heures.

Si ce jour n’est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable

suivant.

Art. 20. Autres Assemblées Générales. Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés,

les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou
plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont
été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un dans un délai de quinze (15)
jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d’exprimer leur vote par écrit en le retournant à
la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit. Les exigences de quorum et de
majorité imposées pour l’adoption de résolutions par l’assemblée générale s’applique mutatis mutandis à l’adoption de
résolution écrites.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social

de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourra se tenir à l’étranger, chaque fois que des
circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.

Art. 21. Convocation des Assemblées Générales. A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent aussi

se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des
Gérants, subsidiairement, du commissaire (s’il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la
moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale ainsi que l’ordre du

jour et la nature des affaires à traiter lors de l’assemblée générale des associés. L’ordre du jour d’une assemblée générale
d’associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte
des modifications relatives à l’objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s’ils déclarent avoir été dûment

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Art. 22. Présence - Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée

générale des associés.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte

écrit, un mandataire qui n’a pas besoin d’être lui-même associé.

Art. 23. Procédure. Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée

par les Gérants, ou, faute d’une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l’assemblée générale des
associés.

Le Président de l’assemblée générale des associés désigne un secrétaire.
L’assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l’assemblée générale des

associés.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l’assemblée générale.

Art. 24. Vote. Lors de toute assemblée générale des associés autre qu’une assemblée générale convoquée en vue de la

modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum et

53891

L

U X E M B O U R G

de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus
de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit),
les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépen-
damment du nombre de parts sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la modi-

fication des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum et de
majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des associés
représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

Art. 25. Procès-Verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents et

peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d’associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l’associé unique seront établies par écrit et signées par l’associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées

générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant con-
jointement dès lors que plus d’un Gérant aura été nommé.

Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

Art. 26. Exercice Social. L’exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier et s’achève le dernier jour de décembre

de chaque année.

Art. 27. Approbation des Comptes Annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les Gérants

dressent l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux Lois.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société. Si

la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours calendaires
qui précèdent l’assemblée générale annuelle des associés.

Art. 28. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %)

qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la
Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital émis de la Société.

Chaque année où la Société décide de procéder à des distributions de dividendes, à partir des bénéfices nets et des

réserves disponibles issues de bénéfices non distribués, incluant toute prime d’émission, le montant attribuable à cet effet
sera distribué suivant l’ordre de priorité suivant:

- Tout d’abord, les propriétaires de Parts Sociales de Catégorie A aura droit pour chaque année considérée à une distri-

bution de dividendes égale à un virgule quatre-vingt-dix pour cent (1,90 %) de la valeur nominale de leurs Parts Sociales
de Catégorie A;

-  les  propriétaires  de  Parts  Sociales  de  Catégorie  B  aura  droit  pour  chaque  année  considérée  à  une  distribution  de

dividendes égale à un virgule quatre-vingt pour cent (1,80 %) de la valeur nominale de leurs Parts Sociales de Catégorie
B;

-  les  propriétaires  de  Parts  Sociales  de  Catégorie  C  aura  droit  pour  chaque  année  considérée  à  une  distribution  de

dividendes égale à un virgule soixante-dix pour cent (1,70 %) de la valeur nominale de leurs Parts Sociales de Catégorie
C;

-  les  propriétaires  de  Parts  Sociales  de  Catégorie  D  aura  droit  pour  chaque  année  considérée  à  une  distribution  de

dividendes égale à un virgule soixante pour cent (1,60 %) de la valeur nominale de leurs Parts Sociales de Catégorie D;

-  les  propriétaires  de  Parts  Sociales  de  Catégorie  E  aura  droit  pour  chaque  année  considérée  à  une  distribution  de

dividendes égale à un virgule cinquante pour cent (1,50 %) de la valeur nominale de leurs Parts Sociales de Catégorie E;

- les propriétaires de Parts Sociales de Catégorie F aura droit pour chaque année considérée à une distribution de divi-

dendes égale à un virgule quarante pour cent (1,40 %) de la valeur nominale de leurs Parts Sociales de Catégorie F;

-  les  propriétaires  de  Parts  Sociales  de  Catégorie  G  aura  droit  pour  chaque  année  considérée  à  une  distribution  de

dividendes égale à un virgule trente pour cent (1,30 %) de la valeur nominale de leurs Parts Sociales de Catégorie G;

-  les  propriétaires  de  Parts  Sociales  de  Catégorie  H  aura  droit  pour  chaque  année  considérée  à  une  distribution  de

dividendes égale à un virgule vingt pour cent (1,20 %) de la valeur nominale de leurs Parts Sociales de Catégorie H;

- les propriétaires de Parts Sociales de Catégorie I aura droit pour chaque année considérée à une distribution de divi-

dendes égale à un virgule dix pour cent (1,10 %) de la valeur nominale de leurs Parts Sociales de Catégorie I; et enfin

- les propriétaires de Parts Sociales de Catégorie J aura droit pour chaque année considérée au reste de toute distribution

de dividendes.

Si l’entièreté de la dernière (par ordre alphabétique) catégorie de parts sociales a été annulée à la suite de son rembour-

sement, rachat ou autre au moment de la distribution (par exemple les Parts Sociales de Catégorie J), le reste de toute

53892

L

U X E M B O U R G

distribution de dividendes devra alors être attribué à la dernière catégorie de parts sociales la précédant dans l’ordre al-
phabétique inversé (par exemple les Parts Sociales de Catégorie I).

Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils

peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau
ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d’émission, aux associés, chaque
part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Sous réserve des conditions (s’il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants

peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi que
la date de paiement de tels acomptes.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art 29. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés possédant

les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être une

personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation

sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les
règles relatives à la distribution de dividendes.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 30. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois,

en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et Paiement

Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et la

valeur nominale de ces parts sociales, de même que la prime d’émission, le cas échéant a été payée à cent pour cent (100%)
en espèces ainsi qu’il suit:

Associé

Classe

des parts

sociales

Capital

souscrit

Nombre

de parts
sociales

Montant

libéré

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classe A

1,250

1,250

1,250

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classe B

1,250

1,250

1,250

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classe C

1,250

1,250

1,250

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classe D

1,250

1,250

1,250

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classe E

1,250

1,250

1,250

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classe F

1,250

1,250

1,250

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classe G

1,250

1,250

1,250

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classe H

1,250

1,250

1,250

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classe I

1,250

1,250

1,250

KKR European Fund IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classe J

1,250

1,250

1,250

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500

12,500

12,500

Le montant de douze mille cinq cent Euro (EUR 12.500,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve

en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

sont estimés à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s’achèvera le dernier jour de décembre

2016.

<i>Assemblée générale extraordinaire

<i>Première Résolution

L’assemblée générale des associés a décidé d’établir le siège social à 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg,

Grand-Duché du Luxembourg.

53893

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième Résolution

L’assemblée générale des associés a décidé de fixer à quatre (4) le nombre de Gérants et a décidé de plus de nommer

les personnes suivantes pour une période indéterminée:

- Edouard Pillot, né le 19 décembre 1977 à Paris, France, ayant sa résidence professionnelle au Stirling Square, 7 Carlton

Gardens, SW1Y 5AD, London, United Kingdom.;

- Anders Borg, né le 24 novembre 1976 à Lundby, Suède, ayant sa résidence professionnelle au Stirling Square, 7 Carlton

Gardens, SW1Y 5AD, London, United Kingdom;

- M. Stefan Lambert, né le 8 janvier 1964 à Trèves, Allemagne, ayant sa résidence professionnelle au 59, rue de Rol-

lingergrund, L-2440 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg); et

- Dr Wolfgang Zettel, né le 15 novembre 1962 à Konstanz, Deutschland, ayant son adresse professionnelle au 61, rue

de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu’à la demande du comparant, le

présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: B. BROUSCHER, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/1484. Reçu soixante-quinze (75.-)

euros.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Référence de publication: 2016057125/698.
(160016839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.

MB Tomahawk (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: NOK 244.790.772,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 193.321.

In the year two thousand and fifteen, on the thirty-first day of December.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

the extraordinary general meeting of shareholders of MB Tomahawk (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité

limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 12C,
Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register under registration number B 193.321, incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary
residing in Luxembourg, on 19 December 2014 published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations under
number 274 on 3 February 2015 (the “Company”). The articles of association of the Company have been last amended
pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Belvaux, on 8 December 2015 which has not been
published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations yet.

The meeting was opened with Stéphane Joly-Meunier in the chair and with Blazej Gladysz as secretary, both residing

in Luxembourg. The meeting elected Marie Thomine as scrutineer, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to

record that:

I The shareholders, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance

list which, signed by the board of the meeting and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the
present deed.

II The proxies of the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the proxyholders of the appearing

parties will also remain annexed to the present deed for registration purposes.

III It appears from the attendance list mentioned here above, that all the shares representing the entire share capital of

the Company are duly represented at the present meeting. The represented shareholders declare that they have had due
notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

The present meeting, at which all the shares representing the entire share capital of the Company are duly represented,

is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda (the “Agenda”):

53894

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. Change of the currency of the share capital of the Company from Euro to Norwegian Krone with effect as from 1

January 2016, conversion of the Company’s share capital from twenty-five million four hundred fifty-six thousand six
hundred twenty-one Euro (EUR 25,456,621), represented by seventeen million eight hundred nineteen thousand six hundred
twenty-nine (17,819,629) A-shares, seven million six hundred thirty-six thousand nine hundred eighty-four (7,636,984) B-
shares, one (1) C-1 share, one (1) C-2 share, one (1) C-3 share, one (1) C-4 share, one (1) C-5 share, one (1) C-6 share, one
(1) C-7 share, and one (1) C-8 share, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, to two hundred forty-four million
seven hundred ninety thousand eight hundred sixty-seven Norwegian Krone and fifty-four øre (NOK 244,790,867.54)
pursuant to the EUR/NOK closing exchange rate of nine point six one six (9.616) Norwegian Krone for one Euro (EUR
1) on 30 December 2015 published by the European Central Bank, represented by one hundred seventy-one million three
hundred fifty-three thousand four hundred ninety (171,353,490) A-shares, seventy-three million four hundred thirty-seven
thousand two hundred ten (73,437,210) Bshares, nine (9) C-1 shares, nine (9) C-2 shares, nine (9) C-3 shares, nine (9) C-4
shares, nine (9) C-5 shares, nine (9) C-6 shares, nine (9) C-7 shares, and nine (9) C-8 shares, with a nominal value of one
Norwegian Krone (NOK 1) each, all of them being still held by the current shareholders of the Company in the same
proportion as the shares denominated in Euro, and reduction of the share capital of the Company for rounding purposes by
the surplus amounting to ninety-five Norwegian Krone and fifty-four øre (NOK 95.54) in order to reduce it from its present
amount of two hundred forty-four million seven hundred ninety thousand eight hundred sixty-seven Norwegian Krone and
fifty-four øre (NOK 244,790,867.54) to two hundred forty-four million seven hundred ninety thousand seven hundred
seventy-two Norwegian Krone (NOK 244,790,772), without the cancellation of any shares and with the allocation of an
amount of ninety-five Norwegian Krone and fifty-four øre (NOK 95.54) to the share premium 111 under Luxembourg
Standard Chart of Accounts (Compte 111 du Plan Comptable Luxembourgeois - Prime d’émission) of the Company;

2. Amendment to article 1 of the Company’s articles of association to reflect the above resolution;
3. Amendment to article 6.1 of the Company’s articles of association to reflect the above resolution;
4. Amendment to paragraph 5 of article 12.3.4 of the Company’s articles of association to reflect the above resolutions;

and

5. Miscellaneous.
Further to the review of the different items composing the Agenda, the extraordinary general meeting of the shareholders,

representing the entire share capital of the Company, requested the undersigned notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of the shareholders resolves to (i) change the currency of the share capital of the

Company from Euro to Norwegian Krone with effect as from 1 January 2016, (ii) convert the Company’s share capital
from twenty-five million four hundred fifty-six thousand six hundred twentyone Euro (EUR 25,456,621), represented by
seventeen  million  eight  hundred  nineteen  thousand  six  hundred  twenty-nine  (17,819,629)  A-shares,  seven  million  six
hundred thirty-six thousand nine hundred eighty-four (7,636,984) B-shares, one (1) C-1 share, one (1) C-2 share, one (1)
C-3 share, one (1) C-4 share, one (1) C-5 share, one (1) C-6 share, one (1) C-7 share, and one (1) C-8 share, with a nominal
value of one Euro (EUR 1) each, to two hundred forty-four million seven hundred ninety thousand eight hundred sixty-
seven Norwegian Krone and fifty-four øre (NOK 244,790,867.54) pursuant to the EUR/NOK closing exchange rate on 30
December 2015 of nine point six one six (9.616) Norwegian Krone for one Euro (EUR 1) published by the European Central
Bank,  represented  by  one  hundred  seventy-one  million  three  hundred  fifty-three  thousand  four  hundred  ninety
(171,353,490) A-shares, seventy-three million four hundred thirty-seven thousand two hundred ten (73,437,210) B-shares,
nine (9) C-1 shares, nine (9) C-2 shares, nine (9) C-3 shares, nine (9) C-4 shares, nine (9) C-5 shares, nine (9) C-6 shares,
nine (9) C-7 shares, and nine (9) C-8 shares, with a nominal value of one Norwegian Krone (NOK 1) each, all of them
being still held by the current shareholders of the Company in the same proportion as the shares denominated in Euro, and
(iii) reduce the share capital of the Company by the surplus amounting to ninety-five Norwegian Krone and fifty-four øre
(NOK 95.54) for rounding purposes in order to reduce it from its present amount of two hundred forty-four million seven
hundred ninety thousand eight hundred sixty-seven Norwegian Krone and fifty-four øre (NOK 244,790,867.54) to two
hundred  forty-four  million  seven  hundred  ninety  thousand  seven  hundred  seventy-two  Norwegian  Krone  (NOK
244,790,772), being represented by the same number and classes of shares stated in this resolution, without the cancellation
of any shares.

As a consequence of this resolution, the extraordinary general meeting of the shareholders further resolves that no

payment shall be made to the shareholders and the amount of ninety-five Norwegian Krone and fifty-four øre (NOK 95.54)
shall be allocated to the share premium 111 under Luxembourg Standard Chart of Accounts (Compte 111 du Plan Comptable
Luxembourgeois -Prime d’émission) of the Company.

As  a  consequence  of  the  conversion  of  the  share  capital  from  Euro  to  Norwegian  Krone,  Tamweelview  European

Holdings S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its  registered  office  at  13  rue  Edward  Steichen,  L-2540  Luxembourg  and  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and
Companies’ Register under number B 93.081, holds one hundred seventy-one million three hundred fifty-three thousand
four hundred ninety (171,353,490) A-shares, MB Tomahawk Co-Investor S.à r.l., a société à responsabilité limitée incor-
porated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 12C, Impasse

53895

L

U X E M B O U R G

Drosbach, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 199.839,
holds seventy-three million four hundred thirty-seven thousand two hundred ten (73,437,210) Bshares, and Meyer Bergman
European Retail Partners III Scottish Limited Partnership, a limited partnership incorporated and existing under the laws
of Scotland, having its registered office at 5 

th

 Floor, Quartermile Two, Lister Square, Edinburgh EH3 9GL and registered

number SL21479, holds nine (9) C-1 shares, nine (9) C-2 shares, nine (9) C-3 shares, nine (9) C-4 shares, nine (9) C-5
shares, nine (9) C-6 shares, nine (9) C-7 shares, and nine (9) C-8 shares.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend

article 1 of the Company’s articles of association, which shall henceforth read as follows:

“Art. 1. Definitions.

“A-share”

means an “A” share of NOK 1 in the capital of the Company having the rights and
being subject to the restrictions set out in the Articles and the Shareholders’
Agreement.

“Agreed Financing Parameters” means the parameters set out in the Shareholders’ Agreement.
“A-Shareholder”

means the holder of the A-Shares including any person to whom A-shares have been
transferred or issued in accordance with the provisions of the Shareholders’
Agreement and who has agreed to be bound by the Shareholders’
Agreement.

“A-Proportion”

means the amount of Distributable Profits, excluding any sum payable pursuant to
Article 25.1.1.(1) and/or Article 25.1.1.(2), held by the Company at any given time
multiplied by the Equity Investment Proportion held by the AShareholder.

“Accounts”

means accounts showing both the consolidated position of the Group and the sole
position of the Company.

“Annual Budget”

means the Initial Annual Budget or any subsequent Annual Budget subsequently
approved pursuant to the terms hereof (as the case may be).

“Articles”

means the Company’s articles of association as amended from time to time.

“Available Amount”

has the meaning given to it in Article 7.6.7.

“B-share”

means a “B” share of NOK 1 in the capital of the Company having the rights and being
subject to the restrictions set out in the Articles and the Shareholders’ Agreement.

“B-Proportion”

means the amount of Distributable Profits, excluding any sum payable pursuant to
Article 25.1.1.(1) and/or Article 25.1.1.(2), held by the Company at any given time
multiplied by the Equity Investment Proportion held by the BShareholder.

“B-Shareholder”

means the holder of the B-Shares including any person to whom B-shares have been
transferred or issued in accordance with the provisions of the Shareholders’
Agreement and who has agreed to be bound by the Shareholders’ Agreement.

“Board”

means the board of managers of the Company.

“Board Consent”

means the consent of at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager
at a Board meeting or as evidenced in writing (which may be by means of several
documents in the like form, each signed by one or more managers).

“Board Matters”

means any of the matters indicated in Article 18.4.

“Business”

means the business intended to be carried on by the Group, as described in the
Shareholders’Agreement.

“Business Day”

means a day other than a Saturday or Sunday or public holiday in England and Wales,
Luxembourg and Abu Dhabi on which banks generally are open in London,
Luxembourg and Abu Dhabi for general commercial business.

“C-1 share”

means a “C-1” share of NOK 1 in the capital of the JVC having the rights and being
subject to the restrictions set out in the Articles and the Shareholders’ Agreement.

“C-2 share”

means a “C-2” share of NOK 1 in the capital of the JVC having the rights and being
subject to the restrictions set out in the Articles and the Shareholders’ Agreement.

“C-3 share”

means a “C-3” share of NOK 1 in the capital of the JVC having the rights and being
subject to the restrictions set out in the Articles and the Shareholders’ Agreement.

“C-4 share”

means a “C-4” share of NOK 1 in the capital of the JVC having the rights and being
subject to the restrictions set out in the Articles and the Shareholders’ Agreement.

“C-5 share”

means a “C-5” share of NOK 1 in the capital of the JVC having the rights and being
subject to the restrictions set out in the Articles and the Shareholders’ Agreement.

“C-6 share”

means a “C-6” share of NOK 1 in the capital of the JVC having the rights and being
subject to the restrictions set out in the Articles and the Shareholders’ Agreement.

53896

L

U X E M B O U R G

“C-7 share”

means a “C-7” share of NOK 1 in the capital of the JVC having the rights and being
subject to the restrictions set out in the Articles and the Shareholders’ Agreement.

“C-8 share”

means a “C-8” share of NOK 1 in the capital of the JVC having the rights and being
subject to the restrictions set out in the Articles and the Shareholders’ Agreement.

“C-shares”

means, collectively, the C-1 shares, the C-2 shares, the C-3 shares, the C-4 shares, the
C-5 shares, the C-6 shares, the C-7 shares and the C-8 shares.

“Class A List”

has the meaning given to it in Article 16.2.

“Class B List”

has the meaning given to it in Article 16.2.

“Class A Manager”

has the meaning given to it in Article 15.

“Class B Manager”

has the meaning given to it in Article 15.

“Company”

means MB Tomahawk (Luxembourg) S.à r.l.

“Company Act”

means the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended.

“Control” and and “Controller”,
“Controlled”, and “Controlling”

have the meaning set out in the Shareholders’ Agreement.

“C-share”

means a “C” share of NOK 1 in the capital of the Company having the rights and being
subject to the restrictions set out in the Articles and the Shareholders’ Agreement.

“Cure Loan”

has the meaning given to it in the Shareholders’ Agreement.

“Deadlock”

has the meaning given to it in Article 20.

“Deadlock Notice”

has the meaning given to it in Article 20.

“Deadlock Representative”

has the meaning given to it in Article 20.

“Equity Instrument Proportion” means the number of A-shares or B-shares held by the relevant Investor expressed as

a proportion of the total number of A-shares and Bshares issued by the Company.

“Financial Year”

means a financial period of the Company commencing, other than in the case the Initial
Financial Year, on 1 January and ending on 31 December, unless otherwise resolved
by the Board with Requisite Approval.

“Group”

means the Company and all entities Controlled by the Company from time to time.

“Initial Annual Budget”

means the annual budget relating to the Financial Year in which the Shareholders’
Agreement is entered into.

“Interested Manager”

has the meaning given to it in Article 18.8.1.

“Interested Shareholder”

has the meaning given to it in Article 12.8.1.

“Investors”

means the A-Shareholder and the B-Shareholder (and “Investor” means any one of
them).

“Investor Consent”

means the unanimous consent of the A – Shareholder and the B – Shareholder.

“Investor Matters”

means any of the matters indicated in Article 12.3.4.

“IRR”

means the annualised discount rate, at which the net present value of the difference
between an Investor’s Total Capital Contributions to and distributions from the
Company (including any repayment of any Shareholder Loans other than Cure Loans)
is zero. This annualised discount rate shall be calculated using the “XIRR” formula
in Microsoft Excel 2007 or any superseding version.

“Manager Conflict”

has the meaning set in the Shareholders’ Agreement.

“Managers”

means the Class A Managers and the Class B Managers from time to time.

“Reserved Matters”

means Board Matters and Investor Matters.

“Shareholders”

means the A–Shareholder , the B–Shareholder and the holder of C-shares.

“Shareholder Conflict”

has the meaning given to it in the Shareholders’ Agreement.

“Shareholder Instrument”

means:
(a) any A-shares or B-shares; and
(b) any Shareholder Loans; and
(c) loan stock or any other instrument or security evidencing indebtedness issued by
any member of the Group (excluding any third party debt financings).

“Shareholder Loans”

means the loans made by Investors to the Company from time to time by any Investor
pursuant to the Shareholders’ Agreement.

“Shares”

means the A-shares, B-shares and the C-shares in the capital of the Company, from
time to time.

“Shareholders’ Agreement”

means the shareholders’ agreement entered into between the Shareholders and the
Company, as amended or restated from time to time.

53897

L

U X E M B O U R G

“Total Capital Contribution”

means all payments made to the Company by an Investor by way of subscription for
Shareholder Instruments (excluding any Cure Loans), assessed at the relevant time.

“Total Cancellation Amount”

means any of the matters indicated in Article 7.6.3

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend

article 6.1 of the Company’s articles of association, which shall henceforth read as follows:

“ 6.1. The Company’s share capital is set at two hundred forty-four million seven hundred ninety thousand seven hundred

seventy-two Norwegian Krone (NOK 244,790,772), represented by:

(i) one hundred seventy-one million three hundred fifty-three thousand four hundred ninety (171,353,490) class A shares

(the “A-shares”),

(ii) seventy-three million four hundred thirty-seven thousand two hundred ten (73,437,210) class B shares (the “B-

shares”),

(iii) nine (9) class C1 shares (the “C-1 shares”),
(iv) nine (9) class C2 shares (the “C-2 shares”)
(v) nine (9) class C3 shares (the “C-3 shares”),
(vi) nine (9) class C4 shares (the “C-4 shares”),
(vii) nine (9) class C5 shares (the “C-5 shares”),
(viii) nine (9) class C6 shares (the “C-6 shares”),
(ix) nine (9) class C7 shares (the “C-7 shares”),
(x) nine (9) class C8 shares (the “C-8 shares” and together with the A-shares, B-shares, C-1 shares, C-2 shares, C-3

shares, C-4 shares, C-5 shares, C-6 shares and C-7 shares the “Shares”), with a nominal value of one Norwegian Krone
(NOK 1) each.

The C-1 shares, C-2 shares, C-3 shares, C-4 shares, C-5 shares, C-6 shares, C-7 shares and C-8 Shares are together

referred to as the “Cshares” and each a “Class”.”

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend

paragraph 5 of article 12.3.4. of the Company’s articles of association, which shall henceforth read as follows:

“ (5) Acquisitions. Any member of the Group acquiring (whether in a single transaction or series of transactions) any

properties or any other assets or business or any shares in any company where the value of that property, assets, business
or shares exceeds NOK 961,600;”

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at one thousand seven hundred Euro (EUR 1,700.-).

<i>Statements

There being no further business, the meeting is closed..

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholders of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le trente et unième jour du mois de décembre.
Par-devant nous le soussigné, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg,

s’est tenue

l’assemblée générale extraordinaire des associés de MB Tomahawk (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité

limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 12C, Impasse
Drosbach, L-1882 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg  sous  le  numéro  B  193.321,  constituée  suivant  acte  reçu  par  Maître  Carlo  Wersandt,  notaire  résidant  à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 19 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 274 du 3 février 2015 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant

53898

L

U X E M B O U R G

acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Belvaux, le 8 décembre 2015, lequel n’a pas encore été
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée générale a été ouverte avec Stéphane Joly-Meunier comme président et Blazej Gladysz comme secrétaire,

tous deux résidant à Luxembourg. L’assemblée générale a élu Marie Thomine comme scrutateur résidant à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée générale ayant été ainsi constitué, le président a déclaré et requis le notaire soussigné d’acter

ce qui suit:

I. Les associés, les procurations des associés représentés et le nombre de leurs parts sociales sont mentionnés sur la liste

de présence, laquelle signée par le bureau de l’assemblée générale et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Les procurations des associés représentés, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des parties compa-

rantes, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

III. Il apparaît selon la liste de présence mentionnée ci-dessus que toutes les parts sociales représentant l’intégralité du

capital social de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée générale. Les associés représentés déclarent
qu’ils ont dûment reçu un préavis et eu connaissance de l’ordre du jour avant la tenue de cette assemblée générale, et que
par conséquent aucune convocation préalable n’était nécessaire.

La présente assemblée générale, à laquelle toutes les parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société

sont dûment représentées, est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du
jour (l’«Ordre du Jour»):

<i>Ordre du Jour

1. Changement de la devise du capital social de la Société d’euro en couronne norvégienne avec effet à partir du 1 

er

janvier 2016, conversion du capital social de la Société de vingt-cinq millions quatre cent cinquante-six mille six cent vingt
et un euros (EUR 25.456.621), représenté par dix-sept millions huit cent dix-neuf mille six cent vingt-neuf (17.819.629)
parts sociales A, sept millions six cent trente-six mille neuf cent quatre-vingt-quatre (7.636.984) parts sociales B, une (1)
part sociale C-1, une (1) part sociale C-2, une (1) part sociale C-3, une (1) part sociale C-4, une (1) part sociale C-5, une
(1) part sociale C-6, une (1) part sociale C-7, une (1) part sociale C-8, d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune,
en deux cent quarante-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-sept couronnes norvégiennes et
cinquante-quatre øre (NOK 244.790.867,54) conformément au taux de change de clôture EUR/NOK du 30 décembre 2015
de neuf point six un six (9,616) couronnes norvégienne pour un euro (EUR 1) publié par la Banque Centrale Européenne,
représenté par cent soixante et onze millions trois cent cinquante-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix (171.353.490)
parts sociales A, soixante-treize millions quatre cent trente-sept mille deux cent dix (73.437.210) parts sociales B, neuf (9)
parts sociales C-1, neuf (9) parts sociales C-2, neuf (9) parts sociales C-3, neuf (9) parts sociales C-4, neuf (9) parts sociales
C-5, neuf (9) parts sociales C-6, neuf (9) parts sociales C-7, et neuf (9) parts sociales C-8, d’une valeur nominale d’une
couronne norvégienne (NOK 1) chacune, la totalité desquelles étant encore détenue par les associés actuels de la Société
dans les mêmes proportions que les parts sociales libellées en euro, et réduction du capital social de la Société à des fins
d’arrondi à la hauteur du surplus d’un montant de quatre-vingt-quinze couronnes norvégiennes et cinquante-quatre øre
(NOK 95,54) afin de réduire son capital social actuel de deux cent quarante-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix mille
huit cent soixante-sept couronnes norvégiennes et cinquante-quatre øre (NOK 244.790.867,54) à deux cent quarante-quatre
millions sept cent quatre-vingt-dix mille sept cent soixante-douze couronnes norvégiennes (NOK 244,790,772), sans l’an-
nulation  d’aucune  part  sociale  et  avec  l’allocation  d’un  montant  de  quatre-vingt-quinze  couronnes  norvégiennes  et
cinquante-quatre øre (NOK 95,54) au compte 111 du Plan Comptable Luxembourgeois - Prime d’émission de la Société;

2. Modification de l’article 1 des statuts de la Société afin de rendre compte de la résolution susmentionnée;
3. Modification de l’article 6.1 des statuts de la Société afin de rendre compte de la résolution susmentionnée;
4.  Modification  du  paragraphe  5  de  l’article  12.3.4  des  statuts  de  la  Société  afin  de  rendre  compte  des  résolutions

susmentionnées; et

5. Divers.
Suite à la revue des points de l’Ordre du Jour, l’assemblée générale extraordinaire de l’associé, représentant l’intégralité

du capital social de la Société, a requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de (i) changer la devise du capital social de la Société d’euro

en couronne norvégienne avec effet à partir du 1 

er

 janvier 2016, (ii) convertir le capital social de la Société de vingt-cinq

millions quatre cent cinquante-six mille six cent vingt et un euros (EUR 25.456.621), représenté par dix-sept millions huit
cent dix-neuf mille six cent vingt-neuf (17.819.629) parts sociales A, sept millions six cent trente-six mille neuf cent quatre-
vingt-quatre (7.636.984) parts sociales B, une (1) part sociale C-1, une (1) part sociale C-2, une (1) part sociale C-3, une
(1) part sociale C-4, une (1) part sociale C-5, une (1) part sociale C-6, une (1) part sociale C-7, et une (1) part sociale C-8,
d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, en deux cent quarante-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix mille
huit cent soixante-sept couronnes norvégiennes et cinquante-quatre øre (NOK 244.790.867,54) conformément au taux de
change de clôture EUR/NOK du 30 décembre 2015 de neuf point six un six (9,616) couronnes norvégiennes pour un euro
(EUR 1) publié par la Banque Centrale Européenne, représenté par cent soixante et onze millions trois cent cinquante-trois

53899

L

U X E M B O U R G

mille quatre cent quatre-vingt-dix (171.353.490) parts sociales A, soixante-treize millions quatre cent trente-sept mille deux
cent dix (73.437.210) parts sociales B, neuf (9) parts sociales C-1, neuf (9) parts sociales C-2, neuf (9) parts sociales C-3,
neuf (9) parts sociales C-4, neuf (9) parts sociales C-5, neuf (9) parts sociales C-6, neuf (9) parts sociales C-7, et neuf (9)
parts sociales C-8, d’une valeur nominale d’une couronne norvégienne (NOK 1) chacune, la totalité desquelles étant encore
détenue par les associés actuels de la Société dans les mêmes proportions que les parts sociales libellées en euro, et (iii)
réduire le capital social de la Société à la hauteur du surplus d’un montant de quatre-vingt-quinze couronnes norvégiennes
et cinquante-quatre øre (NOK 95,54), à des fins d’arrondi et de réduire son capital social actuel de deux cent quarante-
quatre millions sept cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-sept couronnes norvégiennes et cinquante-quatre øre
(NOK 244.790.867,54) à deux cent quarante-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix mille sept cent soixante-douze
couronnes norvégiennes (NOK 244,790,772), étant représenté par le même nombre et classe de part sociale mentionné
dans cette résolution, sans l’annulation d’aucune part sociale.

En conséquence de cette résolution, l’assemblée générale extraordinaire des associés décide également qu’aucun paie-

ment ne sera fait aux associés et que le montant de quatre-vingt-quinze couronnes norvégiennes et cinquante-quatre øre
(NOK 95,54) sera alloué au compte 111 du Plan Comptable Luxembourgeois - Prime d’émission de la Société.

En conséquence de la conversion du capital social de l’euro en couronne norvégienne, Tamweelview European Holdings

S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au
13 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93.081, détient cent soixante et onze millions trois cent cinquante-trois mille
quatre cent quatre-vingt-dix (171.353.490) parts sociales A, MB Tomahawk Co-Investor S.à r.l., une société à responsabilité
limitée  constituée  et  existant  selon  les  lois  du  Grand-Duché  du  Luxembourg,  ayant  son  siège  social  au  12C,  Impasse
Drosbach, L-1882 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg  sous  le  numéro  B  199.839,  détient  soixante-treize  millions  quatre  cent  trente-sept  mille  deux  cent  dix
(73.437.210) parts sociales B, et Meyer Bergman European Retail Partners III Scottish Limited Partnership, un limited
partnership constitué et existant selon les lois d’Ecosse, ayant son siège social au 5 

th

 Floor, Quartermile Two, Lister Square,

Edinburgh EH3 9GL et portant le numéro d’immatriculation SL21479, détient neuf (9) parts sociales C-1, neuf (9) parts
sociales C-2, neuf (9) parts sociales C-3, neuf (9) parts sociales C-4, neuf (9) parts sociales C-5, neuf (9) parts sociales C-6,
neuf (9) parts sociales C-7, et neuf (9) parts sociales C-8.

<i>Deuxième Résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier

l’article 1 des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1 

er

 . Définitions.

«Part Sociale A» s’entend d’une part sociale «A» de NOK 1 dans le capital de la Société, assortie des droits et soumise

aux restrictions prévu(e)s dans les Statuts ainsi que dans le Pacte d’Associés.

«Paramètres de Financement Convenus» s’entend des paramètres établis dans le Pacte d’Associés.
«Associé A» s’entend de tout porteur de Parts Sociales A, y compris toute personne en faveur de laquelle des Parts

Sociales A ont été transférées ou émises conformément aux dispositions du Pacte d’Associés et ayant consenti à être tenue
par les dispositions du Pacte d’Associés.

«Proportion  A»  s’entend  du  montant  des  Bénéfices  Distribuables,  à  l’exclusion  de  toute  somme  exigible  selon  les

dispositions de l’article 25.1.1.(1) et/ou de l’article 25.1.1.(2), détenu par la Société à tout moment donné, tel que multiplié
par la Proportion d’Investissement en Capitaux Propres détenue par l’Associé A.

«Comptes» s’entend des comptes reprenant à la fois la situation consolidée du Groupe et la situation individuelle de la

Société.

«Budget Annuel» signifie le Budget Annuel Initial ou tout Budget Annuel subséquent approuvé par la suite selon les

modalités des présentes (le cas échéant).

«Statuts» s’entend des statuts de la Société, tels que modifiés en temps opportun.
«Montant Disponible» a la signification qui lui est donnée à l’article 7.6.7.
«Part Sociale B» s’entend d’une part sociale «B» de NOK 1 dans le capital de la Société, assortie des droits et soumise

aux restrictions prévu(e)s dans les Statuts ainsi que dans le Pacte d’Associés.

«Proportion B» signifie le montant des Bénéfices Distribuables, à l’exclusion de toute somme exigible selon les dispo-

sitions de l’article 25.1.1.(1) et/ou de l’article 25.1.1.(2), détenu par la Société à tout moment donné, tel que multiplié par
la Proportion d’Investissement en Capitaux Propres détenue par l’Associé B.

«Associé B» signifie tout porteur de Parts Sociales B, y compris toute personne en faveur de laquelle des Parts Sociales

B ont été transférées ou émises conformément aux dispositions du Pacte d’Associés et ayant consenti à être tenue par les
dispositions du Pacte d’Associés.

«Conseil» s’entend du conseil de gérance de la Société.
«Consentement du Conseil» signifie le consentement d’au moins un (1) Gérant de Catégorie A et d’un (1) Gérant de

Catégorie B à une réunion du Conseil ou tel qu’attesté par écrit (pareille attestation pouvant revêtir la forme de plusieurs
documents de forme similaire, chacun signé par un ou plusieurs gérants).

53900

L

U X E M B O U R G

«Questions Réservées au Conseil» s’entend de toute question indiquée à l’article 18.4.
«Activité» s’entend de l’activité que le Groupe compte mener, telle que décrite dans le Pacte d’Associés.
«Jour Ouvrable» s’entend d’un jour, autre que les samedis, dimanches et les jours fériés en Angleterre et au Pays de

Galles, au Luxembourg et à Abu Dhabi, au cours duquel les banques sont généralement ouvertes à Londres, à Luxembourg
et à Abu Dhabi, aux fins de leur activité commerciale générale.

«Part Sociale C-1» s’entend d’une part sociale «C-1» de NOK 1 dans le capital de la joint venture, assortie des droits

et soumise aux restrictions prévu(e)s dans les Statuts ainsi que dans le Pacte d’Associés.

«Part Sociale C-2» s’entend d’une part sociale «C-2» de NOK 1 dans le capital de la joint venture, assortie des droits

et soumise aux restrictions prévu(e)s dans les Statuts ainsi que dans le Pacte d’Associés.

«Part Sociale C-3» s’entend d’une part sociale «C-3» de NOK 1 dans le capital de la joint venture, assortie des droits

et soumise aux restrictions prévu(e)s dans les Statuts ainsi que dans le Pacte d’Associés.

«Part Sociale C-4» s’entend d’une part sociale «C-4» de NOK 1 dans le capital de la joint venture, assortie des droits

et soumise aux restrictions prévu(e)s dans les Statuts ainsi que dans le Pacte d’Associés.

«Part Sociale C-5» s’entend d’une part sociale «C-5» de NOK 1 dans le capital de la joint venture, assortie des droits

et soumise aux restrictions prévu(e)s dans les Statuts ainsi que dans le Pacte d’Associés.

«Part Sociale C-6» s’entend d’une part sociale «C-6» de NOK 1 dans le capital de la joint venture, assortie des droits

et soumise aux restrictions prévu(e)s dans les Statuts ainsi que dans le Pacte d’Associés.

«Part Sociale C-7» s’entend d’une part sociale «C-7» de NOK 1 dans le capital de la joint venture, assortie des droits

et soumise aux restrictions prévu(e)s dans les Statuts ainsi que dans le Pacte d’Associés.

«Part Sociale C-8» s’entend d’une part sociale «C-8» de NOK 1 dans le capital de la joint venture, assortie des droits

et soumise aux restrictions prévu(e)s dans les Statuts ainsi que dans le Pacte d’Associés.

«Parts Sociales C» signifie, collectivement, les Parts Sociales C-1, les Parts Sociales C-2, les Parts Sociales C-3, les

Parts Sociales C-4, les Parts Sociales C-5, les Parts Sociales C-6, les Parts Sociales C-7 et les Parts Sociales C-8.

«Liste de Catégorie A» a le sens qui lui est donné à l’article 16.2.
«Liste de Catégorie B» a le sens qui lui est donné à l’article 16.2.
«Gérant de Catégorie A» a le sens qui lui est donné à l’article 15.
«Gérant de Catégorie B» a le sens qui lui est donné à l’article 15.
«Société» signifie MB Tomahawk (Luxembourg) S.à r.l.
«Loi» signifie la loi luxembourgeoise du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
«Contrôle(r)» et «Contrôleur» et «Contrôlé(es)» et «Contrôlant» ont la signification donnée dans le Pacte d’Associés.
«Part Sociale C» s’entend d’une part sociale «C» de NOK 1 dans le capital de la Société, assortie des droits et soumise

aux restrictions prévu(e)s dans les Statuts ainsi que dans le Pacte d’Associés.

«Prêt de Correction» (Cure Loan): a la signification donnée dans le Pacte d’Associés.
«Blocage» a la signification donnée à l’article 20.
«Avis de Blocage» a la signification donnée à l’article 20.
«Représentant Affecté au Blocage» a la signification donnée à l’article 20.
«Proportion  d’Investissement  en  Capitaux  Propres»  signifie  le  nombre  de  Parts  Sociales  A  ou  de  Parts  Sociales  B

détenues par l’Investisseur concerné et représentant une proportion du nombre total de Parts Sociales A et de Parts Sociales
B émises par la Société.

«Exercice» signifie l’exercice financier de la Société prenant cours, hormis à l’occasion de l’Exercice Initial, le 1 

er

janvier et se terminant le 31 décembre, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le Conseil, sous réserve de l’Approbation
Requise.

«Groupe» signifie la Société et toutes les entités Contrôlées par la Société au fil du temps.
«Budget Annuel Initial» s’entend du budget annuel relatif à l’Exercice au cours duquel le Pacte d’Associés est conclu.
«Gérant Intéressé» a la signification donnée à l’article 18.8.1.
«Associé Intéressé» a la signification donnée à l’article 12.8.1.
«Investisseurs» signifie l’Associé A et l’Associé B (et «Investisseur» s’entend de l’un d’entre eux).
«Consentement des Investisseurs» signifie le consentement unanime de l’Associé A et de l’Associé B.
«Questions Réservées aux Investisseurs» s’entend de toute question indiquée à l’article 12.3.4.
«TIR» signifie le taux de remise annuel auquel la valeur actuelle nette de la différence entre les Apports en Capital

Totaux d’un Investisseur en faveur de la Société et les distributions effectuées par cette dernière (y compris tout rembour-
sement de Prêts d’Associés autres que les Prêts de Correction) se chiffre à zéro. Pareil taux de remise annuel se calcule à
l’aide de la formule «XIRR» dans Microsoft Excel 2007 ou toute version la remplaçant.

«Conflit de Gérants» a la signification donnée dans le Pacte d’Associés.
«Gérants» s’entend des Gérants de Catégorie A et des Gérants de Catégorie B au fil du temps.

53901

L

U X E M B O U R G

«Questions Réservées» signifie les Questions Réservées au Conseil et les Questions Réservées aux Investisseurs.
«Associés» signifie l’Associé A, l’Associé B et le titulaire de Parts Sociales C.
«Conflit d’Associés» a la signification donnée dans le Pacte d’Associés.
«Instrument d’Associés» signifie: (a) toute Part Sociale A ou Part Sociale B; et (b) tout prêt d’associés; et (c) un emprunt

ou autre instrument ou titre constatant un endettement émis par tout membre du Groupe (à l’exclusion de tout financement
par emprunt de tiers).

«Prêts d’Associés» s’entend des prêts effectués en temps opportun par des Investisseurs en faveur de la Société et ce,

par tout Investisseur selon les dispositions du Pacte d’Associés.

«Parts Sociales»: s’entend des Parts Sociales A, des Parts Sociales B et des Parts Sociales C dans le capital de la Société

au fil du temps.

«Pacte d’Associés» signifie le pacte d’associés conclu entre les Associés et la Société, tel que modifié ou reformulé en

temps opportun.

«Apport en Capital Total» s’entend de l’ensemble des paiements effectués en faveur de la Société par un Investisseur

par le biais de souscriptions d’Instruments d’Associés (à l’exclusion de tout Prêt de Correction), tels qu’évalués en temps
opportun.

«Montant d’Annulation Total» s’entend de tout élément repris à l’article 7.6.3.

<i>Troisième Résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier

l’article 6.1 des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

« 6.1. Le capital social de la Société est fixé à deux cent quarante-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix mille sept

cent soixante-douze couronnes norvégiennes (NOK 244.790.772), représenté par:

(i) cent soixante et onze millions trois cent cinquante-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix (171.353.490) parts sociales

de classe A (les «Parts Sociales A»),

(ii) soixante-treize millions quatre cent trente-sept mille deux cent dix (73.437.210) parts sociales de classe B (les «Parts

Sociales B»),

(iii) neuf (9) parts sociales de classe C1 (les «Parts Sociales C-1»),
(iv) neuf (9) parts sociales de classe C2 (les «Parts Sociales C-2»),
(v) neuf (9) parts sociales de classe C3 (les «Parts Sociales C-3»),
(vi) neuf (9) parts sociales de classe C4 (les «Parts Sociales C-4»),
(vii) neuf (9) parts sociales de classe C5 (les «Parts Sociales C-5»),
(viii) neuf (9) parts sociales de classe C6 (les «Parts Sociales C-6»),
(ix) neuf (9) parts sociales de classe C7 (les «Parts Sociales C-7»),
(x) neuf (9) parts sociales de classe C8 (les «Parts Sociales C-8» et ensemble avec les Parts Sociales A, Parts Sociales

B, Parts Sociales C-1, Parts Sociales C-2, Parts Sociales C-3, Parts Sociales C-4, Parts Sociales C-5, Parts Sociales C-6,
Parts Sociales C-7, les «Parts Sociales»), d’une valeur nominale d’une couronne norvégienne (NOK 1) chacune.

Les Parts Sociales C-1, Parts Sociales C-2, Parts Sociales C-3, Parts Sociales C-4, Parts Sociales C-5, Parts Sociales

C-6, Parts Sociales C-7, Parts Sociales C-8 sont dénommées ensemble comme les «Parts Sociales C» et chacune comme
une «Classe».»

<i>Quatrième Résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier le

paragraphe 5 de l’article 12.3.4 des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

« (5) Acquisitions. N’importe quel membre du Groupe acquérant (que ce soit par une transaction unique ou une série

de transactions) des propriétés quelconques ou tout autre actif ou activité ou toutes parts sociales dans toute société où la
valeur de cette propriété, actif, activité ou ces parts sociales n’excèdent pas NOK 961,600;»

<i>Frais et dépenses

Le montant des coûts, frais, dépenses et charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à la charge de la Société

en raison du présent acte notarié est évalué à environ mille sept cents Euros (EUR 1.700.-).

<i>Déclarations

L’Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes que sur demande des parties comparantes,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes parties comparantes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

53902

L

U X E M B O U R G

L'acte ayant été lu au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,

lesdits mandataires des parties comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Joly-Meunier, B. Gladysz, M. Thomine et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 8 janvier 2016. Relation: 2LAC/2015/501. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 27 janvier 2016.

Référence de publication: 2016057569/490.
(160017315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Banque Degroof Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 25.459.

L’an deux mille seize, le premier avril.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agis-

sant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

«BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.», une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est

établi au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 25.459, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-
Alzette, en date du 29 janvier 1987, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 116 du 29 avril
1987. Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître
Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 28 septembre 2015, publié au Mémorial C numéro 3160 du
20 novembre 2015,

ici représentée par Monsieur Christophe Serwy, résidant professionnellement au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lu-

xembourg, nommé à cet effet par résolution circulaire du Conseil d’Administration en date du 17 février 2016, dont une
copie restera ci-annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

Ladite  partie  comparante,  agissant  dans  la  capacité  ci-dessus  énoncée,  a  demandé  au  notaire  soussigné  d’acter  ses

déclarations et observations comme suit:

1) Conformément au projet commun de fusion acté le 22 février 2016 par Maître Jean-Joseph Wagner, publié dans le

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 597 du 29 février 2016 (la «Publication») «BANQUE DEGROOF
LUXEMBOURG S.A.», agissant en tant que société absorbante et «PETERCAM (Luxembourg) S.A.», une société ano-
nyme de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 1a, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 22.418, agissant en tant que société absorbée,
conformément à la procédure de fusion simplifiée des articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») (la «Fusion»).

«BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.», et «PETERCAM (Luxembourg) S.A.» étant collectivement désignées

ci-après comme les «Sociétés Fusionnées».

2) Aucun actionnaire de la Société Absorbante détenant au moins cinq pour cent (5%) des parts du capital souscrit n’a

demandé durant la période d’un (1) mois suivant la Publication qu’une assemblée générale extraordinaire de la Société
Absorbante soit convoquée afin de décider de l'approbation de la Fusion.

3) La Fusion est effective entre les Sociétés Fusionnées et conduit ce jour ipso jure aux effets exposés dans l'article 274

de la Loi, notamment le transfert universel de la propriété de tous les actifs et passifs de «PETERCAM (Luxembourg)
S.A.» à «BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.». Elle sera effective vis-à-vis des tiers à la date de publication dans
le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du présent acte.

4) La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable et fiscal

comme accomplies pour le compte de la société absorbante, a été fixée au 1 

er

 janvier 2016.

5) En conséquence de la Fusion, «PETERCAM (Luxembourg) S.A.» cesse d’exister le 1 

er

 avril 2016 et toutes les actions

ont été annulées. Tous les livres, registre des actionnaires et autres dossiers de cette Société Absorbée seront conservés
pendant le délai légal (cinq (5) ans) au siège de la Société Absorbante, étant actuellement au 12, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

53903

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Conformément à l'article 273 de la Loi, le notaire soussigné déclare par le présent qu’il a fait les vérifications nécessaires

et certifie l'existence et la validité des actes et formalités à effectuer par les Sociétés Fusionnées et que par conséquent les
conditions de l'article 279 de la Loi ont été remplies.

Dont acte est fait et passé à Luxembourg à la date figurant au début de ce document.
Le document ayant été lu au représentant de la partie comparante ci-dessus connu du notaire soussigné, ladite personne

a signé ensemble avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: C. SERWY, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 05 avril 2016. Relation: EAC/2016/8237. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2016088829/56.
(160057179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.

Micaboul Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 14.117.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 21 janvier 2016

1. Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

Monsieur Thierry JACOB né le 07 juillet 1967 à Thionville (France), résidant professionnellement au 412F, Route d'Esch
L-1471 Luxembourg est réélu Président du Conseil d'Administration.

Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire devant

se tenir en 2021.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2016057576/14.
(160017798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Glow Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 8.412.500,00.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 198.674.

<i>Extrait de décision de l'associé unique prise au Luxembourg le 30 Septembre 2015

L'associé unique décide de vendre et transférer à Glow Co-lnvest GmbH &amp; Co. KG, ayant son adresse à Eschenheimer

Anlage 1, 60316 Frankfurt am Main, Allemagne, les parts suivantes détenues dans la société:

- 2,500,000 parts sociales préférentielles de Classe A;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Glow Investment S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016064475/16.
(160026145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Entreprise Mario Contato et Fils, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3514 Dudelange, 266, route de Kayl.

R.C.S. Luxembourg B 20.383.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076455/9.
(160041059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

53904


Document Outline

2512 H S.A.

Aguila 1 S.à r.l.

ALM Logistics Luxembourg

Arcano Real Estate GP, S.à r.l.

Archand Holding S.à r.l.

Asia Pacific Performance

Assenagon Select Plus

Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie

Banque Degroof Luxembourg S.A.

Banque Degroof Luxembourg S.A.

BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG S.A.

Bgold et Westfield, S.e.n.c.

BMBG Bond Finance S.C.A.

Borasco S.à r.l.

Braas Monier Building Group S.A.

Breds Management S.A.

BSN medical Luxembourg Group Holding S.à r.l.

Bureau 1G Consult S.à r.l.

Catamaran S.à r.l.

Centrum Development S.A.

Chaptwo S.à r.l.

Château de Beggen S.A.

Chi Holdings S.à r.l.

Chiron Technology S.à r.l.

Cygnus Holding S.A., SPF

DB Advisors SICAV

db Advisory Multibrands

DB PWM

Degroof Equities

Deutsche Invest II

E.01 Euro-Innovation

Entreprise Mario Contato et Fils

Foodip

Glow Investment S.à r.l.

Ireco S.A.

JBS Berg S.à r.l.

JBS Petrusse Finance S.à r.l.

Lecorsier Finance S.A.

MB Tomahawk (Luxembourg) S.à r.l.

Micaboul Holding S.A.

Polar Investments

Redline Capital Fund

Regus plc

Reno Holding (Luxembourg) S.A.

Synapsia SA

THE WORLD COMPANY (en abrégé: TWC) Sàrl

Veda International S.à .rl.

WAI S.C.A., SICAV - FIS

Waterproof Property S.à r.l.

WAVE Private Equity SICAV-SIF