logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1027

7 avril 2016

SOMMAIRE

2B-Natural S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49288

4i S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49274

8 Grussgaass S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49277

Access Capital Fund II SICAV-SIF . . . . . . . . .

49250

Affrètements, Distributions, Services, Logistic

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49282

Agir Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49279

Albemarle Management S.àr.l. . . . . . . . . . . . . .

49278

Alifa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49279

Alpha Trains Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

49278

Apsys Poznan Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49281

Avery Dennison Investments Luxembourg . . .

49279

BBFD Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49280

Buddha Bar S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49277

Carmudi Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49274

Centrum NS Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . . . . .

49287

Efiparind B.V. & Cie S.C.P.A.  . . . . . . . . . . . . .

49280

Europa Ruby S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49280

Freo Asset Management Invest Holding S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49288

Horn & Co. Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . . . . . .

49295

Kinetic Partners (Luxembourg) Management

Company S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49296

Lincoln Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49296

RoMei S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49283

Russian Acquisition Company N°1 S.à r.l.  . . .

49283

Seventh Century Partners S.à r.l.  . . . . . . . . . .

49281

Sialina Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49281

Sioux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49281

Somuchmore Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

49292

SSCP Titan S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49282

Sungem Serfinco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49282

TES Global Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

49283

Tili S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49284

Troichem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49296

Vaulux International SPF S.A. . . . . . . . . . . . . .

49273

Weinberg Real Estate S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

49262

WFS Holding I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49289

Xtreme Equipment Group  . . . . . . . . . . . . . . . .

49289

Zaphira S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49274

49249

L

U X E M B O U R G

Access Capital Fund II SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 204.966.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of March,
before Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Access Capital Partners Group SA, a limited company incorporated under the laws of the Kingdom of Belgium, with

registered office at IT Tower - Avenue Louise 480, Brussels 1050, Belgium, registered with the Belgium Registry of Trades
under number 0889.320.744 (the Subscriber),

here represented by Vincent Herjean, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Subscriber and the undersigned notary, shall

remain attached to and shall be filed together with this notarial deed with the registration authorities.

The Subscriber, represented as stated above, has requested the undersigned notary to enact the following articles of

incorporation of a limited company (société anonyme), which it declares to establish as follows:

1 Art. 1. Form.
1.1 There exists among the existing shareholders and all those who may become holders of shares in the SIF (the

"Shareholder(s)"), a company in the corporate form of a sociéte anonyme (public limited company), qualifying as a société
d'investissement a capital variable (investment company with variable share capital), governed by the Law of 10 August
1915 relating to commercial companies, as amended (the "1915 Law"), the 2007 Law and the present articles (the "SIF
Articles").The specialised investment fund status may only be abandoned by the SIF with the prior approval of the CSSF
and the unanimous consent of the Shareholders.

2 Art. 2. Name.
2.1 The company's name is "Access Capital Fund II SICAV-SIF" (the "SIF").

3 Art. 3. Purpose.
3.1 The SIF's purpose is to invest the funds available to it in participations of companies including but not limited to

interests in partnerships and shares in corporations and, for the purpose of temporarily managing any excess of liquidity,
other permissible assets under the 2007 Law, with a view to spreading investment risks and enabling its Shareholders to
benefit from the results of the management thereof.

3.2 The investment objectives and strategy of the SIF are more fully described in the SIF Issue Document.
3.3 In addition, the SIF can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly

to all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the
2007 Law.

4 Art. 4. Registered Office.
4.1 The SIF has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by a resolution of the

Board of Directors.

4.3 The registered office of the SIF may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means

of a resolution of an extraordinary general meeting of Shareholders deliberating in the manner required for amendment of
these SIF Articles.

4.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur that are likely to

affect the normal functioning of the registered office or communications with foreign countries, the registered office may
be provisionally transferred to another foreign country until such time as circumstances have completely returned to normal
provided however that the registered office shall not be transferred to a country which is neither a member state of the
European Economic Area (EEA) nor a full member of the Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD). Such decision will not affect the SIF's nationality which will, notwithstanding such transfer, remain a Luxembourg
incorporated company. The decision as to the transfer the registered office to another country will be made by the Board
of Directors.

4.5 The SIF may have offices, branches (whether or not a permanent establishment) and subsidiaries either in Luxem-

bourg or abroad.

5 Art. 5. Duration.
5.1 The SIF is constituted for an unlimited period of time.

49250

L

U X E M B O U R G

5.2 The SIF does not come to an end upon the death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any of its

Shareholders.

5.3 The Board of Directors may, at its own initiative, dissolve the SIF at any date, subject to the voting conditions set

forth in the 1915 Law.

5.4 In addition, the SIF will be dissolved upon the occurrence of any one (1) of the following events:
(a) if the registration of the SIF on the list of approved fonds d'investissement specialises held by the CSSF is withdrawn

on a final basis;

(b) if the amount of the Net Asset Value of the SIF remains below EUR 1,250,000 (one million two hundred and fifty

thousand euro) or the equivalent in any foreign currencies, for a period of 120 days; and

(c) should the agreement between the Depositary and the SIF be terminated by either party and should no other Depositary

be proposed by the SIF.

6 Art. 6. Liability.
6.1 The Shareholders shall be liable only to the extent of their capital contribution to the SIF.

7 Art. 7. Share Capital and Securities.
7.1 The share capital of the SIF shall at all times be equal to its net assets.
7.2 The share capital of the SIF is represented by the following Classes of shares:
(a) the class A shares (the "Class A Shares");
(b) the class B shares (the "Class B Shares"); and
(c) the class C shares (the "Class C Shares")
7.3 The characteristics of Class A Shares, Class B Shares and Class C Shares are further detailed in the SIF Issue

Document. The SIF Issue Document contains information about certain matters, where specific rights are attributed to the
different Classes of shares.

7.4 The Board of Directors may decide to create additional Classes of shares within the SIF, subject to the terms of the

SIF Issue Document.

7.5 At the date of incorporation the SIF's share capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros), represented

by 31,000 (thirty-one thousand) Class C Shares to the Shareholders.

7.6 Each Class A Share, Class B Share and Class C Share grants the right to one (1) vote at every Shareholders' meeting

and at, for each Class of shares, separate meetings of the holders of shares of each of the Classes, if any. Fractional shares
may be issued up to two (2) places after the decimal and shall carry rights in proportion to the fraction of a share they
represent but shall carry no voting rights, except to the extent that their number is such that they represent a whole share,
in which case they confer a voting right.

7.7 The minimum capital of the SIF, which must be achieved within 12 (twelve) months as from the date on which the

SIF has been authorised as a SIF under Luxembourg applicable laws, shall be EUR 1,250,000 (one million two hundred
and fifty thousand euros) as required by the 2007 Law, or the equivalent in any foreign currencies.

7.8 Within each Sub-Fund, Shares can furthermore be issued in series representing all Shares issued on any Valuation

Day in any Class of Shares.

7.9 For the purpose of determining the capital of the SIF, the net assets attributable to each Class of Shares shall, if not

expressed in Euro, be converted into Euro and the capital shall be the total of the net assets of all the Classes of Shares.

8 Art. 8. Establishment of Sub-Funds.
8.1 The Board of Directors may establish portfolios of assets, each constituting a sub-fund (each a "Sub-Fund" and

together the "Sub-Funds") within the meaning of Article 71 of the 2007 Law for one Class of Shares or for multiple Classes
of Shares in the manner described in Article 7 hereof. As between Shareholders, each portfolio of assets shall be invested
for the exclusive benefit of the relevant Class or Classes of Shares. The SIF shall be considered as one single legal entity.
However, with regard to third parties, in particular towards the SIF's creditors, each Sub-Fund shall be exclusively res-
ponsible for all liabilities attributable to it.

8.2 The Board of Directors may create each Sub-Fund for a maximum period of time which shall be in compliance with

Article 5 as mentioned above. At the expiry of the duration of a Sub-Fund, the SIF shall redeem all the Shares in the relevant
Class(es) of Shares, in accordance with Article 10 below. In respect of the relationships between the Shareholders, each
Sub-Fund is treated as a separate entity.

8.3 The SIF Issue Document shall indicate the duration of each Sub-Fund.

9 Art. 9. Issuance of Shares.
9.1 Persons may be admitted as Shareholders by the Board of Directors at any time during the lifetime of the SIF provided

that they each (i) sign and deliver to the Board of Directors a Subscription Agreement, and (ii) are a Well-Informed Investor.
The Board of Director's acceptance of a Subscription Agreement (or, if the Subscription Agreement is accepted by the
Board of Directors subject to receipt by the SIF of the applicant's Commitment) shall constitute the applicant as a Share-
holder of the SIF and, following such acceptance (or if applicable the receipt by the SIF of the Commitment), the applicant

49251

L

U X E M B O U R G

shall have all the rights and shall comply with all the obligations of a Shareholder set out in the SIF Issue Document, the
SIF Articles, and its Subscription Agreement.

9.2 Unless otherwise provided for herein or in the SIF Issue Document, no preferential subscription rights shall apply.
9.3 Existing Shareholders may be permitted, at the absolute discretion of the Board of Directors, to increase the amount

of their Commitments at any closing date determined by the Board of Directors, provided that they each sign and deliver
to the Board of Directors a further or amended Subscription Agreement reflecting such increase of Commitment, and such
Shareholders shall be treated as though they were Subsequent Shareholders in respect of the increased amount of their
Commitments for the purposes of the SIF Issue Document.

9.4 The minimum amount for an initial Commitment in the SIF is EUR 125,000 (one hundred twenty five thousand

euros) or the equivalent in any foreign currencies. The Board of Directors may decide

(a) on higher initial Commitments for each sub-fund as - if applicable - more fully described in the SIF Issue Document:

or

(b) on lower minimum subsequent Commitments for existing Shareholders of the SIF.

10 Art. 10. Redemption of Shares.
10.1 Unless otherwise specified in the SIF Issue Document, the Shareholders shall not have the right to request the SIF

to redeem shares.

10.2 However, the Board of Directors may decide, at its discretion, to redeem Shares for distribution purposes in ac-

cordance with the respective provisions of the SIF Issue Document. The SIF may also, with the consent of the relevant
Shareholder, satisfy payments of the redemption price to any Shareholder in specie by allocating to the Shareholder in-
vestments from the portfolio of assets of any Sub-Fund, to the extent permitted by the SIF Issue Document.

10.3 All redeemed shares shall be cancelled.

11 Art. 11. Conversion of Shares.
11.1 Unless otherwise determined by the Board of Directors or set out in the SIF Issue Document for certain Sub-Funds

and/or Classes of Shares, no Shareholder is entitled to require the conversion of whole or part of his Shares of one Class
into Shares of another Class. However, upon the request of a Shareholder the Board of Directors may decide at its reasonable
discretion to convert Shares from one Sub-Fund into another Sub-Fund or from one Class into another within the same
Sub-Fund, subject to such restrictions as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the
Board of Directors shall determine.

11.2 The price for the conversion of Shares from one Class into another Class shall be computed by reference to the

respective Net Asset Value of the two Classes of Shares, calculated on the same Valuation Day.

11.3 If as a result of any request for conversion the number or the aggregate Net Asset Value of the Shares held by any

Shareholder in any Class of Shares would fall below such number or such value as determined by the Board of Directors,
then the Board of Directors may decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such
Shareholder's holding of Shares in such Class. At the Board of Directors' discretion, the Board of Directors reserves the
right to transfer any existing Shareholder who falls below the minimum Shareholding requirement for one Class of Shares
into another appropriate Class of Shares without charge. Shares of any Class will not be converted in circumstances where
the calculation of the Net Asset Value per Share of such Class is suspended pursuant to 17 hereof.

11.4 The Shares which have been converted into Shares of another Class shall be cancelled.

12 Art. 12. Restriction of Ownership.
12.1 The Board of Directors may restrict or prevent the ownership of Shares in the SIF by any person, firm or corporate

body, if, in the reasonable judgment of the Board of Directors, there is a material risk to the SIF that the continued parti-
cipation of such Shareholder in the SIF would result in a material violation of any law, rule or regulation or impose a
material tax, regulatory or other burden on the SIF, a Sub-Fund or its Shareholders, whether Luxembourg or foreign, that
it would not have otherwise incurred (such persons, firms or corporate bodies to be determined by the Board of Directors
being herein referred to as "Prohibited Persons").

12.2 Notwithstanding any additional requirements set out in the SIF Issue Document, the SIF may for such purposes:
(a) decline to issue any Shares and decline to register any Transfer of a Share, where it appears to it that such registry

or Transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such Shares by a Prohibited Person; and

(b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the Transfer of Shares on

the register of Shareholders, to furnish the Board of Directors with any information, supported by affidavit, which the Board
of Directors may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such Share-
holder's Shares rests in a Prohibited Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such Shares by
a Prohibited Person; and

(c) decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of Shareholders of the SIF; and
(d) where it appears to the Board of Directors that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other

person is a beneficial owner of Shares, direct such Shareholder to sell his Shares and to provide to the SIF evidence of the
sale within thirty (30) days of the notice. If such Shareholder fails to comply with the direction, the Board of Directors may

49252

L

U X E M B O U R G

compulsorily redeem or cause to be compulsorily redeemed from any such Shareholder all Shares held by such Shareholder
(each a "Compulsorily Redemption") in the following manner:

(i) The Board of Directors shall serve a notice (the "Compulsorily Redemption Notice") upon the Shareholder holding

such Shares or appearing in the register of Shareholders as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares
to be compulsorily redeemed and the manner in which the Compulsorily Redemption Price, defined hereafter, will be
calculated.

Any such notice may be served upon such Shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed

to such Shareholder at his last address known to or appearing in the books of the SIF. The said Shareholder shall thereupon
forthwith be obliged to deliver to the General Partner the Share certificate or certificates, if any, representing the Shares
specified in the Compulsorily Redemption Notice.

Immediately after the close of business on the date specified in the Compulsorily Redemption Notice, such Shareholder

shall cease to be the owner of the Shares specified in such notice; in the case of registered Shares, his name shall be removed
from the register of Shareholders, and the certificate or certificates representing such registered Shares will be cancelled.

(ii) The price at which each such Share is to be compulsorily redeemed (the "Compulsorily Redemption Price") shall

be an amount based on the Net Asset Value per Share of the relevant Class as at the Valuation Day specified by the Board
of Directors for the redemption of Shares in the SIF next preceding the date of the Compulsorily Redemption Notice or
next  succeeding  the  surrender  of  the  Share  certificate  or  certificates  representing  the  Shares  specified  in  such  notice,
whichever is lower, all as determined in accordance with Article 16 hereof, less any service charge provided therein.

(iii) Payment of the Compulsorily Redemption Price will be made available to the former owner of such Shares normally

in the currency fixed by the Board of Directors for the payment of the Compulsorily Redemption Price of the Shares of the
relevant Class and will be deposited for payment to such owner by the SIF with a bank in Luxembourg or elsewhere (as
specified in the Compulsorily Redemption Notice) upon final determination of the Compulsorily Redemption Price fol-
lowing surrender of the Share certificate or certificates specified in such notice and unmatured dividend coupons attached
thereto. Upon service of the Compulsorily Redemption Notice as aforesaid such former owner shall have no further interest
in such Shares or any of them, nor any claim against the SIF or its assets in respect thereof, except the right to receive the
Compulsorily Redemption Price (without interest) from such bank following effective surrender of the Share certificate or
certificates as aforesaid. Any Compulsorily Redemption Price receivable by a Shareholder under this paragraph, but not
collected within a period of five years from the date specified in the Purchase Notice, may not thereafter be claimed and
shall revert to the relevant Class or Classes of Shares. The Board of Directors shall have the power from time to time to
take all steps necessary to perfect such reversion and to authorize such action on behalf of the Board of Directors.

(iv) The exercise by the SIF of the power conferred by this Article 12 shall not be questioned or invalidated in any case,

on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership of any
Shares was otherwise than appeared to the SIF at the date of any Compulsorily Redemption Notice, provided in such case
the said powers were exercised by the SIF in good faith.

"Prohibited Person" as used herein does neither include any subscriber to Shares of the SIF issued in connection with

the incorporation of the SIF while such subscriber holds such Shares nor any securities dealer who acquires Shares with a
view to their distribution in connection with an issue of Shares by the SIF.

(v) Shares of the SIF may only be issued to Well-Informed Investors within the meaning of the 2007 Law. Any person

who is not a Well-Informed Investor is also to be considered as a Prohibited Person.

(vi) Irrespective the provisions of this Article 12, the SIF Issue Document may provide for additional compulsorily

redemption of Shares from Shareholders such as compulsorily redemption in case a Shareholder fails to advance to the SIF
the amount which the Shareholder is obliged to pay. In case of any conflict between the provisions of this Article 12 and
the specific provisions in the SIF Issue Document the specific provisions in the SIF Issue Document shall prevail.

13 Art. 13. Shareholders.
13.1 The holding of shares is exclusively restricted to "Well-Informed Investors" as defined under article 2 of the 2007

Law.

13.2 The Board of Directors shall have the power to impose such restrictions as it may think necessary for the purpose

notably of ensuring that (i) no shares in the SIF are acquired or held by (a) any person in breach of these SIF Articles, the
SIF Issue Document, the law or requirement of any country or governmental authority, or (b) any person in circumstances
which in the opinion of the Board of Directors might result in the SIF incurring any liability to taxation or suffering any
other pecuniary disadvantage which the SIF might not otherwise have incurred or suffered.

13.3 For such purposes the Board of Directors may:
(a) decline to issue any share and decline to register any Transfer of a share where it appears to it that such registration

action or Transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such share being held by a person who is
precluded from holding shares of the SIF;

(b) at any time require any person whose name is entered in the Shareholders' register to furnish it with any information,

supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not legal or beneficial
ownership of such Shareholder's shares rests or will rest in a person who is precluded from holding shares of the SIF; and

49253

L

U X E M B O U R G

(c) where it appears to the SIF that any person, who is precluded from holding shares of the SIF is a legal or beneficial

owner of shares or holds shares, cause the SIF compulsorily to repurchase from any such Shareholder all shares held by
such Shareholder in the manner specified in Article 12 of these SIF Articles.

14 Art. 14. Form of Shares / Shareholders' Register.
14.1 Shares will only be issued in registered form.
14.2 All issued shares of the SIF shall be registered in the Shareholders' register, which shall be kept by the Registrar

and Transfer Agent. Such register shall contain the name and address of each Shareholder, the number of shares held by it
and, if applicable, their date of Transfer. Transfer of ownership, where available, will become effective only after its entry
in the Shareholders' register of the SIF.

14.3 The registration of the Shareholder's name in the Shareholder' register evidences its right of ownership over such

registered shares. The Shareholder shall receive a written confirmation of its shareholding. Certificates representing the
shares will be issued only upon written request made to the Registrar and Transfer Agent by the relevant Shareholder. The
requesting Shareholder will have to bear the cost thereof.

14.4 The Shareholder may, at any time, change its address as entered in the Shareholders' register by means of a written

notification to the SIF at its registered office, or at such other address as may be set by the SIF from time to time.

14.5 The shares are indivisible with regard to the SIF, which admits only one owner per share.

15 Art. 15. Transfer of Shares and Securities.
15.1  The  Board  of  Directors  may  determine  restrictions  on  the  transfer  of  Shares  to  be  described  in  the  SIF  Issue

Document.

15.2 No transfer of a Share in violation of the restrictions provided in the SIF Issue Document shall be valid or effective,

and the Company shall not recognise the same, for the purposes of making distributions or otherwise with respect to other
rights attached to the Shares in the Company.

16 Art. 16. Calculation of Net Asset Value per Share.
16.1 The Net Asset Value per Share of each Class within the relevant series within the relevant Sub-Fund shall be

calculated in the Reference Currency (as defined in the SIF Issue Document for the Shares) of the relevant Sub-Fund and,
to the extent applicable within a Sub-Fund, expressed in the unit currency for the relevant Class of Shares in such series
within such Sub-Fund. It shall be determined as of any Valuation Day, by dividing the net assets of the SIF attributable to
each Class of Shares in such series within such Sub-Fund, being the value of the portion of assets less the portion of liabilities
attributable to such Class in such series, on any such Valuation Day, by the number of Shares in the relevant Class in the
relevant series within the Sub-Fund then outstanding, in accordance with the valuation rules set forth below. The Net Asset
Value per Share may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the Board of Directors shall
determine. If since the time of determination of the Net Asset Value there has been a material change in the quotations in
the markets on which a substantial portion of the investments attributable to the relevant Class of Shares are dealt in or
quoted, the SIF may, in order to safeguard the interests of the Shareholders and the SIF, cancel the first valuation and carry
out a second valuation, in which case all relevant subscription and redemption requests will be dealt with on the basis of
that second valuation.

16.2 The calculation of the Net Asset Value of the different Classes of Shares in the relevant series shall be made in the

following manner; however notwithstanding the below, additional valuation rules may be set out separately for each Sub-
Fund in the SIF Issue Document.

(a) The assets of the SIF shall include:
- the value of any partnership interest held as an investment;
- all cash in hand or on deposit, including any outstanding accrued interest;
- all bills and promissory notes and accounts receivable, including outstanding proceeds of any sale of securities;
- all securities, shares, bonds, time notes, debenture stocks, options or subscription rights, warrants, money market

instruments, and all other investments and transferable securities belonging to the relevant Sub- Fund;

- all dividends and distributions payable to the Sub-Fund either in cash or in the form of stocks and shares (the SIF may,

however, make adjustments to account for any fluctuations in the market value of transferable securities resulting from
practices such as ex-dividend or ex-claim negotiations);

- all outstanding accrued interest on any interest-bearing securities belonging to the Sub-Fund, unless this interest is

included in the principal amount of such securities;

- all other assets whatever their nature, including the proceeds of swap transactions and advance payments.
The value of such assets shall be determined as follows:
- the value of any cash in hand or on deposit, discount notes, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid

expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received, shall be equal to the entire
amount thereof, unless the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined
after making such discount as the Board of Directors may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;

49254

L

U X E M B O U R G

- the value of all portfolio securities (including interests or units or shares of target funds other than private equity funds),

shares and money market instruments or derivatives that are listed on an official stock exchange or traded on any other
regulated market will be based on the last available price on the principal market on which such securities, shares, money
market instruments or derivatives are traded, as supplied by a recognised pricing service approved by the Board of Directors.
If such prices are not representative of the fair value, such securities, shares, money market instruments or derivatives as
well as other permitted assets may be valued at a fair value at which it is expected that they may be resold, as determined
in good faith by and under the direction of the Board of Directors;

- the value of private equity securities (including units or shares of target funds other than private equity funds) as well

as any securities (including any partnership interest in private equity funds held as an investment and units or shares of
target funds other than private equity funds) and money market instruments which are not quoted or traded on a regulated
market will be valued in accordance with the most recent International Private Equity and Venture Capital Valuation
Guidelines developed by the Association Française des Investisseurs en Capital, the British Private Equity and Venture
Capital Association and the European Private Equity and Venture Capital Association (or any replacement thereof);

- the value of other assets will be determined prudently and in good faith by and under the direction of the Board of

Directors in accordance with generally accepted valuation principles and procedures.

The Board of Directors, at its discretion, may authorize the use of other methods of valuation if it considers that such

methods would enable the fair value of any asset of the SIF to be determined more accurately.

Where necessary, the fair value of an asset is determined by the Board of Directors, or by a committee appointed by the

Board of Directors, or by a designee of the Board of Directors.

The valuation of each Sub-Fund's assets and liabilities expressed in foreign currencies shall be converted into the relevant

Reference Currency, based on the latest known exchange rates.

All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with the generally accepted

accounting principles of Luxembourg.

For each Sub-Fund, adequate provisions will be made for expenses incurred and due account will be taken of any off-

balance sheet liabilities in accordance with fair and prudent criteria.

For each Sub-Fund and for each Class, the Net Asset Value per Share shall be calculated in the relevant Reference

Currency on each Valuation Day by dividing the net assets attributable to such Class (which shall be equal to the assets
minus the liabilities attributable to such Class) by the number of Shares issued and in circulation in such Class.

The SIF's net assets shall be equal to the sum of the net assets of all its Sub-Funds.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision to determine the Net Asset Value taken

by the Board of Directors or by any bank, company or other organization which the Board of Directors may appoint for
such purpose, shall be final and binding on the SIF and present, past or future Shareholders.

(b) The liabilities of the SIF shall include:
- all borrowings, bills, promissory notes and accounts payable;
- all known liabilities, whether or not already due, including all contractual obligations that have reached their term,

involving payments made either in cash or in the form of assets, including the amount of any dividends declared by the
SIF regarding the Sub-Fund but not yet paid;

- a provision for capital tax and income tax accrued on the Valuation Day and any other provisions authorized or approved

by the Board of Directors;

- the SIF's or relevant Sub-Fund's preliminary expenses, to the extent that such expenses have not already been written-

off;

- all other liabilities of the SIF of any kind with respect to the Sub- Fund, except liabilities represented by Shares in the

SIF. In determining the amount of such liabilities to be borne by the relevant Sub-fund, the SIF shall take into account all
expenses payable by the SIF including, but not limited to:

- formation expenses,
- expenses in connection with and fees payable to, its investment manager(s), advisors(s), accountants, custodian, de-

positary and correspondents, registrar, transfer agents, paying agents, brokers, distributors, permanent representatives in
places of registration and auditors,

- administration, domiciliary, services, promotion, printing, reporting, publishing (including advertising or preparing

and printing of prospectuses, explanatory memoranda, registration statements, annual reports) and other operating expen-
ses,`

- the cost of buying and selling assets,
- interest and bank charges, and
- taxes and other governmental charges.
The SIF may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated basis for yearly

or other periods in advance and may accrue the same in equal proportions over any such period.

(c) The assets shall be allocated as follows:

49255

L

U X E M B O U R G

The Board of Directors may establish a Class of Shares in respect of each Sub Fund and may establish multiple Classes

of Shares in respect of each Sub Fund in the following manner:

(i) If multiple Classes of Shares relate to one Sub-Fund, the assets attributable to such Classes shall be commonly invested

pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned provided however, that within a Sub-Fund, the Board
of Directors is empowered to define Classes of Shares so as to correspond to (i) a specific distribution policy, such as
entitling to distributions or not entitling to distributions and/or (ii) a specific sales and redemption charge structure and/or
(iii) a specific management or advisory fee structure, and/or (iv) a specific assignment of distribution, Shareholder services
or other fees and/or (v) the currency or currency unit in which the Class may be quoted and based on the rate of exchange
between such currency or currency unit and the Reference Currency of the relevant Sub-Fund and/or (vi) the use of different
hedging techniques in order to protect in the Reference Currency of the relevant Sub-Fund the assets and returns quoted
in the currency of the relevant Class of Shares against long-term movements of their currency of quotation and/or (vii) such
other features as may be determined by the Board of Directors from time to time in compliance with applicable law;

(ii) The proceeds to be received from the issue of Shares of a Class shall be applied in the books of the SIF to the relevant

Class of Shares issued in respect of such Sub-Fund, and, as the case may be, the relevant amount shall increase the proportion
of the net assets of such Sub-Fund attributable to the Class of Shares to be issued;

(iii) The assets, liabilities, income and expenditure attributable to a Sub-Fund shall be applied to the Class or Classes

of Shares issued in respect of such Sub-Fund, subject to the provisions here above under Article 16.2(c)(i));

(iv) Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be attributable in the books of the SIF to

the same Class or Classes of Shares as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase
or decrease in value shall be applied to the relevant Class or Classes of Shares;

(v) In the case where any asset or liability of the SIF cannot be considered as being attributable to a particular Class of

Shares, such asset or liability shall be allocated to all the Classes of Shares pro rata to the respective amounts committed
by investors in relation to each Class or in such other manner as determined by the Board of Directors acting in good faith,
provided that (i) where assets, on behalf of several Sub-Funds are held in one account and/or are co-managed as a segregated
pool of assets by an agent of the Board of Directors, the respective right of each Class of Shares shall correspond to the
prorated portion resulting from the contribution of the relevant Class of Shares to the relevant account or pool, and (ii) the
right shall vary in accordance with the contributions and withdrawals made for the account of the Class of Shares, as
described in the SIF Issue Document for the Shares of the SIF;

(vi) Upon the payment of distributions to the holders of any Class of Shares, the Net Asset Value of such Class of Shares

shall be reduced by the amount of such distributions.

All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted ac-

counting principles.

(d) For the purpose of this Article:
(i) Shares of the SIF to be redeemed under Article 10 hereof shall be treated as existing and taken into account until

immediately after the time specified by the Board of Directors on the redemption day on which such valuation is made and
from such time and until paid by the SIF the price therefore shall be deemed to be a liability of the SIF;

(ii) Shares to be issued by the SIF shall be treated as being in issue as from the time specified by the Board of Directors

on the Valuation Day on which such valuation is made and from such time and until received by the SIF the price therefore
shall be deemed to be a debt due to the SIF;

(iii) all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the Reference Currency of the

relevant Sub-Fund shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and
time for determination of the Net Asset Value of Shares; and

(iv) where on any Valuation Day the SIF has contracted to:
- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the SIF and

the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the SIF;

- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the SIF and the

asset to be delivered shall not be included in the assets of the SIF;

provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation

Day then its value shall be estimated by the SIF.

17 Art. 17. Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share, of Issue and Redemption

of Shares.

17.1 With respect to each Class of Shares, the Net Asset Value per Share in each series and the price for the issue,

redemption and conversion of Shares shall be calculated from time to time by the SIF or any agent appointed thereto by
the SIF, on such days as set by the Board of Directors (each such day being a "Valuation Day"), provided that there will
be at least one Valuation Day per year, subject however to any temporary suspension of the calculation of the Net Asset
Value pursuant to these Articles or the SIF Issue Document. The disclosure of each valuation shall take place at the latest
on the end of the second month after the end of the relevant year or month, respectively. The Net Asset Value shall be made
available at the registered office of the SIF.

49256

L

U X E M B O U R G

17.2 Notwithstanding the provisions of Article 16 above, the SIF may temporarily suspend the determination of the Net

Asset  Value  per  Share  of  any  particular  Class  and  independently  from  suspending  the  Net  Asset  Value,  the  SIF  may
temporarily suspend the issue, redemption and conversion of its Shares from its Shareholders from and to Shares of each
Class:

(a) during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which any substantial portion of

the investments of the SIF attributable to such Sub-Fund from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise than
for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended, provided that such restriction or sus-
pension affects the valuation on the investments of the SIF attributable to a Sub-Fund quoted thereon; or

(b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Board of Directors

as a result of which disposals or valuation of assets owned by the SIF attributable to such Sub-Fund would be impracticable
or unfeasible; or

(c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any

of the investments of such Sub-Fund or the current price or values on any stock exchange or other market in respect of the
assets attributable to such Sub-Fund; or

(d) when for any other reason the prices of any investments owned by the SIF attributable to any Sub-Fund cannot

promptly or accurately be ascertained; or

(e) during any period when the SIF is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption

of the Shares of such Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments
or payments due on redemption of Shares cannot in the opinion of the Board of Directors be effected at normal rates of
exchange; and

(f) upon the publication of a notice convening a general meeting of Shareholders for the purpose of resolving the winding-

up of the SIF.

17.3 Any such suspension may be notified to Shareholders having made an application for subscription, conversion or

redemption of Shares for which the calculation of the Net Asset Value has been suspended.

17.4 Such suspension as to any Class of Shares shall have no effect on the calculation of the Net Asset Value per Share

in the relevant series, the issue, redemption and conversion of Shares of any other Class of Shares if the assets within such
other Class of Shares are not affected to the same extent by the same circumstances.

17.5 Any request for subscription, redemption or conversion may be revocable
(a) with the approval of the Board of Directors or
(b) in the event of a suspension of the calculation of the Net Asset Value, in which case Shareholders may give notice

that they wish to withdraw their application. If no such notice is received by the SIF, such application will be dealt with
on the first Valuation Day, as determined for each Class of Shares, following the end of the period of suspension.

18 Art. 18. Administration and Management of the SIF.
18.1 The SIF shall be managed by a board of directors (the "Board of Directors") composed of at least three (3) and no

more than seven (7) members appointed by the general meeting of Shareholders from a list of candidates proposed by
holders of Class A Shares of the SIF and subject to any required consent of the CSSF. The members of the Board of Directors
are appointed by the general meeting of the Shareholders and need not be Shareholders.

18.2 The general meeting of Shareholders will determine the number of directors, their remuneration, if applicable, and

the term of their office. Directors shall remain in office for a term not exceeding six (6) years and until their successors as
the case may be, are elected and qualify.

18.3 Directors may also be re-elected as members of the Board of Directors.
18.4 Subject to any required consent of the CSSF, any member of the Board of Directors may be removed by the general

meeting of Shareholders.

18.5 The Board of Directors shall choose from among its members a chairman who will not have a casting vote in case

of equal vote for and against a proposition. It shall also choose a secretary, who need not be a director, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board of Directors and of the Shareholders.

18.6 The Board of Directors shall meet upon a meeting called by the chairman or any two directors, at the place indicated

in the notice of meeting.

18.7 There will be at least two meetings of the Board of Directors per year.
18.8 The Board of Directors can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
18.9 Except as otherwise provided in the SIF Issue Document, resolutions of the Board of Directors are taken by a

majority vote of the members present or represented at meetings of the Board of Directors, subject to a minimum of three
(3) positive votes.

18.10 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed in writing and may

consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every member of the Board of
Directors.

18.11 In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of Shareholders.

49257

L

U X E M B O U R G

19 Art. 19. Power.
19.1 Unless otherwise provided by 1915 Law or by these SIF Articles, the Board of Directors shall have the broadest

powers to perform all acts of administration and disposition of the SIF.

19.2 All powers not expressly reserved by the 1915 Law or these SIF Articles to the general meeting of Shareholders

shall be exercised by the Board of Directors.

19.3 In particular, subject to the restrictions contained in the SIF Issue Document and the 1915 Law, the Board of

Directors shall have the broadest powers to implement the investment policy of the SIF as well as the course of conduct of
the management and business affairs of the SIF and to manage the Investments for the account of the SIF with a view to
achieving the investment policy of the SIF. The Board of Directors shall have complete discretion and full power, authority
and right to represent and bind the SIF.

19.4 Investments of the SIF may be made either directly or indirectly through subsidiaries, as the Board of Directors

may from time to time decide. Reference in these SIF Articles to "Investments" and "assets" shall mean, either, investments
made and assets held directly by the SIF, or investments made and assets held indirectly by the aforementioned subsidiaries,
as appropriate.

19.5 The Shareholders shall refrain from acting on behalf of the SIF in any manner or capacity other that by exercising

their rights as Shareholder in general meetings.

20 Art. 20. Delegation of Power.
20.1 The Board of Directors may from time to time and under its responsibility sub-delegate its power to perform specific

tasks to one or more agent(s). In particular, the Board of Directors may, from time to time, appoint one or more investment
committees and investment advisors.

20.2 Subject to the terms of the SIF Issue Document, the Board of Directors will determine the powers, duties and

remuneration (if any) of its agent(s), the duration of their appointment and any other relevant conditions to their appointment.
The Board of Directors will disclose relevant information relating to such delegation in the SIF Issue Document.

21 Art. 21. Representation of the SIF.
21.1 The SIF will be bound towards third parties by the joint signatures of any two members of the Board of Directors

as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Board of Directors has delegated such
signatory power, within the limits of such power.

22 Art. 22. Conflicts of Interest.
22.1 No contract or other transaction between the SIF and any other company, firm or entity shall be affected or inva-

lidated by the fact that the Board of Directors or one or more of the officers of the SIF is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company, firm or entity. The Board of Directors or any officer of the SIF who
serves as a director, officer or employee of any company, firm or entity with which the SIF shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company, firm or entity be prevented from
considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

22.2 Potential conflicts of interest would include, for example, the members of the Board of Directors (i) providing

services to other customers, (ii) becoming directors in, or (iii) holding or dealing in securities held by the SIF.

22.3 Complementary conflict of interest rules and guidance are further described in the SIF Issue Document.

23 Art. 23. Signature.
23.1 The SIF shall be bound by any resolutions of the Board of Directors taken by a majority vote of the members present

or represented at meetings of the Board of Directors, subject to a minimum of three (3) positive votes, except as otherwise
provided in the SIF Issue Document. Members of the Board of Directors may act through one or more duly authorized
signatories, or (iii) such person(s) to which power has been delegated.

24 Art. 24. Indemnification.
24.1 As more fully described in the SIF Issue Document, the SIF shall indemnify any Indemnified Person out of the

assets of the SIF against any claims, damages and liabilities to which they may become subject as a result of their status,
or as a result of any of their acts or omissions on their part in the performance of their duties.

25 Art. 25. General Meetings of Shareholders.
25.1 The decisions of the Shareholders are taken by resolutions passed at meetings of the Shareholders held at a time

and place specified in the notice of the meeting.

25.2 The general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders of the SIF. Its resolutions shall

be binding upon all the Shareholders of the SIF.

25.3 General meetings of Shareholders are convened by the Board of Directors pursuant to a notice setting forth the

agenda and sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to each Shareholder at the Shareholder's
address recorded in the Shareholders register. General meetings of Shareholders may also be called upon the written request
of Shareholders representing at least ten percent (10%) of the share capital of the SIF.

49258

L

U X E M B O U R G

25.4 The agenda shall be prepared by Board of Directors except in the instance where the meeting is called on the written

demand of the Shareholders in which instance the Board of Directors may prepare a supplementary agenda.

25.5 If all Shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed

of the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

25.6 The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by the Shareholders for them to

take part in any meeting of Shareholders. Any Shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by
fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means another person who needs not
be Shareholder.

25.7 Each Shareholder may participate in general meetings of Shareholders.
25.8 All general meetings of Shareholders shall be chaired by the Board of Directors.
25.9 The annual general meeting shall be held on the third Wednesday of the month of May at 3 p.m. at the registered

office or at a place specified in the notice for such meeting. If such day is not a Business day in Luxembourg, the annual
general meeting shall be held on the next following Business Day.

25.10 Other meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices

of meeting.

25.11 Unless otherwise provided by law, the SIF Issue Document, or herein, general meetings of Shareholders shall not

validly deliberate unless Shareholders representing the majority of the capital of the SIF are present or duly represented.
If this condition is not satisfied, a second meeting may be convened, by means of registered mails sent at least eight (8)
calendar days to Shareholders before the meeting.

25.12 Unless otherwise provided for by law, the SIF Issue Document or in these SIF Articles, Shareholders' resolutions

are validly passed by Shareholders' representing a simple majority of the voting rights at Shareholders' meetings validly
convened and quorate in accordance with the above.

26 Art. 26. General Meetings of Shareholders in a Sub-Fund or in a Class of Shares.
26.1 The Shareholders of the Class or Classes issued in respect of any Sub-Fund may hold, at any time, general meetings

to decide on any matters which relate exclusively to such Sub-Fund.

26.2 In addition, the Shareholders of any Class of Shares may hold, at any time, general meetings for any matters which

are specific to such Class.

26.3 Unless otherwise determined in the SIF Issue Document, including, but not limited to specific requirements relating

to the quorum or the majority of Shareholders the provisions of Article 25, paragraphs 25.11 and 25.12 shall apply to such
general meetings.

27 Art. 27. Termination of Sub-Funds or Classes of Shares.
27.1 Any of the SIF's Sub-Funds or Classes of Shares may be terminated pursuant to the provisions set out in the SIF

Issue Document.

28 Art. 28. Accounting Period.
28.1 The term of the Accounting Period shall be a period of 12 months. It shall commence on 1 January of each year

and shall end on 31 December of each year. As an exception, the first Accounting Period shall commence on the date of
incorporation of the SIF and shall end on 31 December 2016, and the last Accounting Period shall end on the date of the
Final Liquidation Date of the SIF.

29 Art. 29. Accounts.
29.1 Each year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the SIF, as further outlined in the SIF Issue

Document.

29.2 The annual accounts shall be approved by the annual general meeting of Shareholders upon proposal of the Board

of Directors.

29.3 The accounts shall be expressed in Euro.

30 Art. 30. Supervision.
30.1 The operations of the SIF and its financial situation shall be supervised by one independent auditor qualifying as

a reviseur d'entreprises agree who shall be appointed by the general meeting of Shareholders for one (1) Accounting Period.

30.2 The statutory auditor shall be remunerated by the SIF and shall remain in office until its successor is appointed.
30.3 The statutory auditor shall fulfil all duties prescribed by the 2007 Law.

31 Art. 31. Distribution.
31.1 Subject to permitted reinvestments, and the requirements of Luxembourg law, distributions shall be payable by the

SIF on its shares further to the provisions ascribed within the SIF Issue Document.

31.2 No distribution may be made if, after the declaration of such distribution, the net assets of the SIF would fall below

EUR 1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand euros) or the equivalent in any foreign currencies.

49259

L

U X E M B O U R G

32 Art. 32. Depositary.
32.1 The SIF shall enter into a depositary bank agreement with a financial institution, which shall satisfy the requirements

of the 2007 Law.

32.2 The Depositary shall assume towards the SIF and the Shareholders the responsibilities set out in the 2007 Law

(notably in articles 33 to 37 of the 2007 Law), the depositary bank agreement and any other law applicable.

32.3 After dismissal, the Depositary must continue to carry out its function as long as is necessary to enable the entire

assets of the SIF to be transferred to the new Depositary.

33 Art. 33. Liquidation.
33.1 The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed at a general

meeting of Shareholders pursuant to the 2007 Law, provided that the nomination right shall be reserved to the holder of
the Class A Share. Such decision to appoint a liquidator shall also specify the liquidator’s powers and fix their remuneration,
as also described in the SIF Issue Document.

33.2 Such liquidator(s) appointed must be approved by the CSSF and must provide all requisite guarantees of honorability

and professional skills.

33.3 Once the SIF is placed in liquidation, the assets of the SIF will be distributed to the Shareholders in accordance

with the principles described the SIF Issue Document.

34 Art. 34. Amendments to these SIF Articles.
34.1 Notwithstanding anything to the contrary these SIF Articles, these SIF Articles may be amended in adherence with

the following quorum and voting requirements.

34.2 Any resolution of a general meeting of Shareholders to the effect of amending these SIF Articles or creating rights

and/or obligations vis-à-vis third parties must be passed with a quorum of fifty percent of the Share capital and the approval
of a majority of at least two-thirds of the Shareholders present or represented at the meeting and the consent of the holder
of the Class A Share.

34.3 Each amendment to these SIF Articles entailing a variation of rights of a Sub-Fund/Class must be approved by a

resolution of the general meeting of Shareholders of the SIF and of a separate meeting(s) of the holders of Shares of the
relevant Sub-Fund(s)/Class(es) concerned. All such meetings such require a quorum of fifty percent of the relevant Share
capital (or equivalent thereof, as applicable).

35 Art. 35. Applicable Law.
35.1 Reference is made to the provisions of the 1915 Law and the 2007 Law for which no specific provision is made in

these SIF Articles.

36 Art. 36. Definitions and Interpretation.
36.1 In these SIF Articles, unless inconsistent with the context or otherwise defined, the following expressions shall

have the following meaning:

- "2007 Law": The Luxembourg law dated 13 February 2007 governing specialized investment funds, as amended or

supplemented from time to time.

- "1915 Law": The Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as the same may be amended from

time to time.

- "Administrative Agent": the administrative agent of the SIF.
- "Affiliate": any body corporate or other entity which, in relation to the Person concerned, is its Subsidiary, its Holding

Company or a Subsidiary of that Person's Holding Company.

- "Business Days": a full day (not being a Saturday or Sunday) on which banks are open for non-automated business in

Luxembourg.

- "Class": Any class of shares issued by any Sub-Fund of the SIF.
- "Commitment": the total amount that a Shareholder commits to invest in the SIF as specified in the Subscription

Agreement or Transfer Agreement of that Shareholder.

- "Depositary": the Depositary of the SIF.
- "First Closing Date": the first closing date as defined in the SIF Issue Document.
- "Holding Company": an entity is the holding company of a Person if it holds, directly or indirectly:
* a majority of the voting rights of and/or shares in such Person; or
* an interest in such Person and has the power to appoint its manager, its chairman, the majority of members of its board

of directors or the majority of members of its supervisory board, as applicable; or

* an interest in such Person and controls, alone or pursuant to an agreement with other Shareholders (or other holders

of securities), the majority of the voting rights of this Person or has the power to appoint its manager, its chairman, the
majority of members of its board of directors or the majority of members of its supervisory board, as applicable.

- "Indemnified Person": any officer, director, Shareholder, agent, member, adviser, consultant, partner or employee of

the SIF or of its appointed investment advisor or investment manager.

49260

L

U X E M B O U R G

- "Person": any individual, body corporate, partnership, unincorporated organisation or association, trust or other entity.
- "Registrar and Transfer Agent": the registrar and transfer agent
- "SIF Issue Document": The offering document of the SIF including all Appendices, as amended from time to time.
- "Subscription Agreement": the agreement drawn up in any form which the Board of Directors may have authorised,

whereby a Shareholder subscribes for shares in the SIF.

- "Subsidiary": an entity is a subsidiary of a Person if such Person is the Holding Company of such entity.
- "Transfer": the sale, assignment, transfer, exchange, pledge, encumbrance or other disposition of the SIF shares.
- "Transfer Agreement": the agreement, in such form as the Board of Directors may approve, under which the transferee

of shares in the SIF adheres to the SIF Issue Document.

- "Valuation Day": the meaning given in Art. 17.1.
- "Well Informed Investors" within the meaning of the 2007 Law:
Any institutional investor, professional investor or any other investor who meets the following conditions:
(a) he has confirmed in writing that he adheres to the status of Well-Informed Investor; and
(b) (i) he invests minimum of EUR 125,000 in the SIF; or (ii) he has been subject to an assessment made by a credit

institution within the meaning of Directive 2006/48/EC, by an investment firm within the meaning of Directive 2004/39/
EC, or by a management company within the meaning of Directive 2009/65/EC, certifying his expertise, his experience
and his knowledge in adequately appraising an investment in risk capital.

The conditions set forth in this definition do not apply to directors or other Persons taking part in the management of

the SIF.

<i>Transitional provisions

The first financial year begins at the date of the present deed and ends on 31 December 2016.
The first annual General Meeting will be held in 2017.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed in its entirety by the appearing party, the Subscriber, who hereby subscribes to 31.000

(thirty-one thousand) Class C Shares having a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each for an aggregate amount of EUR
31,000.- (thirty-one thousand Euro), the subscription amount is allocated to the share capital account of the Company.

All these shares have been paid up in cash for an aggregate amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) and

therefore the amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) is now at the disposal of the Company, proof of which
has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder of the Company, representing the entirety of

the subscribed share capital has passed the following resolutions:

- The following company is appointed as independent auditor of the Company for a term which shall expire at the first

coming annual general meeting of the Shareholders of the Company:

PricewaterhouseCoopers, a cooperative company (société cooperative) with registered address 2, rue Gerhard Mercator,

L-2182 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 65.477, for a period ending at the annual general meeting to be held in 2017.

- The following are appointed as Directors for a term of a 3 (three) year duration:
i. Simon Henin, born on 29 July 1975, with personal address at 5, rue de la Forêt, L-8354 Garnich, Grand Duchy of

Luxembourg;

ii. Agnès Nahum, born on 19 January 1961, with personal address at 74, rue de Villier, 75017 Paris, France;
iii. Philippe Poggioli, born on 3 November 1966, with personal address at 75, rue de Longchamp, 75116 Paris, France;
iv. Vesa-Matti Vana-Honko, born on 15 November 1955, with professional address at 41, Kalkkivuorentie, 00760,

Helsinki, Finland; and

v. Mirko Dietz, born on 20 October 1974, with permanent address at Maison 25, L-6225, Hersberg, Grand Duchy of

Luxembourg.

- The registered office of the Company is set in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English.

49261

L

U X E M B O U R G

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxyholder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by

name, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with the notary the present deed.

Signé: V. Herjean, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 mars 2016. Relation: EAC/2016/7374. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2016.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2016085072/686.
(160052643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

Weinberg Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 130.907.

DEMERGER PROPOSAL

This demerger proposal is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancy between the English

and the French versions, the English version will be prevailing.

The Company, Weinberg Real Estate S.à r.l. was incorporated as a Luxembourg société à responsabilité limitée on 6

July 2007 by a deed enacted by Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2115 of 27 September 2007. Its articles of
association have been amended for the last time on 22 April 2013 pursuant to a deed drawn up by Maître Martine Schaeffer,
pre-named published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1589 of 3 July 2013. The Company
has its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

The object of the Company is namely to act as the general parter (associé commandité) of Weinberg Real Estate Partners

#1 S.C.A., a partnerhip limited by shares (société en commandite par actions), incorporated and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and
registered with the Luxembourg Register of Commmerce and Companies (the "RCS") under number B 132468 and Wein-
berg Real Estate Partners #2 S.C.A, a partnerhip limited by shares (société en commandite par actions), incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg and registered with the RCS under number B 171445.

I. Demerger
The board of managers of the Company has approved the demerger (the "Demerger") of the Company whereby, pursuant

to article 288 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the Company shall transfer
without dissolution, to a newly-incorporated company (the "Recipient Company"), part of its assets and liabilities in ex-
change for the allocation to the Company's shareholders of shares in the Recipient Company in accordance with the Law
and this demerger proposal (the "Demerger Proposal").

Pursuant to the Demerger, the Company will continue the business of the Company related to its holding of general

partnership interests in Weinberg Real Estate Partners #1 SCA (the "Retained Business") and the Recipient Company will
be transferred the business of the Company related to its holding of general partnership interests in Weinberg Real Estate
Partners #2 SCA (the "Transferred Business").

II. General meeting of the shareholders of the Company
The board of managers of the Company shall convene the shareholders of the Company to an extraordinary general

meeting of shareholders to be held before a Luxembourg notary as soon as practicable after one month following the
publication of this Demerger Proposal in accordance with article 9 of the Law, in order to approve the Demerger Proposal
including the articles of association of the Recipient Company and the Demerger of the Company in accordance with this
Demerger Proposal (the "Meeting").

It is noted that, during the Meeting, the share capital of the Company will be increased in order to reach at least EUR

25,000 prior to the Demerger.

III. Exchange ratio of the shares/Terms of the delivery of the shares
The exchange ratio of the shares in the share capital of the Company is such that all the shares of the Recipient Company

shall be allocated to the shareholders of the Company in proportion to their rights in the Company at the date of the Meeting.

49262

L

U X E M B O U R G

The shares in the Recipient Company will be in registered form and the relevant shareholders will be registered in the

shareholders register of the Recipient Company as from its incorporation. The shares of the Recipient Company shall carry
the right to participate in any distribution of profits by the Recipient Company as from the date of its incorporation.

IV. The Recipient Company
The Recipient Company shall be incorporated effective as of the date of the Meeting in the form of a Luxembourg

société à responsabilité limitée with registered office at 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg and will be denominated Weinberg Real Estate #2 S.à r.l.

The articles of association of the Recipient Company shall be as follows:

«I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

Weinberg Real Estate #2 S.à r.l. (hereafter the "Company"), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular
by the law dated 10 

th

 August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present

articles of association (hereafter the "Articles").

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred  within  the  boundaries  of  the  municipality  by  a  resolution  of  the  board  of  managers  of  the  Company.  The
registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines that
extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or
events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated
company.

Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is to act as the general partner (associé commandité) of a société en commandite par

actions, acting under the name of Weinberg Real Estate Partners #2 SCA.

3.2 Furthermore the purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,

in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other
securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and
financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.3. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge,
transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

3.4. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and other risks.

3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by

twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed
and fully paid-up.

49263

L

U X E M B O U R G

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the general

meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior approval

of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of

the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers composed of one A manager and two B managers. The managers

are appointed and designated as A manager or B manager by a resolution of the shareholders which sets the term of their
office. The managers need not to be shareholders.

7.2. The A manager shall be designated as Chairman of the board of managers.
7.3. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, by a unanimous decision

of the board of managers of the Company, in accordance with article 9.6 of the present articles of association.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circums-
tances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or

represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. For matters valued up to an amount of ten thousand euro (EUR 10,000.-) (or its foreign currency equivalent), the

board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented, including at
least the A manager and one B manager. In such cases, resolutions of the board of managers are validly taken by the majority
of the votes cast provided that at least the A manager and a B manager agreed on those resolutions.

9.6. For matters valued above the amount of ten thousand euro (EUR 10,000.-) (or its foreign currency equivalent), the

board of managers can validly deliberate and act only if all of its members are present or represented. Resolutions of the
board of managers are validly taken by the unanimous vote of the A manager and the two B managers. For all matters, the
resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the
meeting.

9.7. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by

any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.8. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

49264

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties (i) for the day-to-day management up to an

amount of ten thousand euro (EUR 10,000.-) (or its foreign currency equivalent) by the single signature of the A manager,
and (ii) in all other matters by the joint signatures of the A manager together with the two B managers, or the single or joint
signature(s) of any agent to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these
Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single shareholder, if any, assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December of the same year.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the board of managers must prepare the balance sheet

and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's
assets  and  liabilities,  with  an  annex  summarising  all  the  Company's  commitments  and  the  debts  of  the  managers,  the
statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased
by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the general meeting of shareholders;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who

do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the general meeting of shareholders which will determine their
powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators
shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

49265

L

U X E M B O U R G

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by
each shareholder in the Company.

VI. General provision

Art. 17. General Provision. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.»

It is proposed that M. Robert Jan Schol, having its professional address at 46A, avenue John F. Kennedy, Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg be appointed as class A manager of the Recipient Company and that M. Stéphane D'Agostino
having its professional address at 20, rue Quentin bauchart, 75008 Paris and M. Gérald Welvaert, having its professional
address at 46A, avenue John F. Kennedy, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg be appointed as class B managers
of the Recipient Company.

V. Effective date of the Demerger
From an accounting point of view and towards the shareholders of the Company, the operations of the Company will

be treated as carried out on behalf of the Company and the Recipient Company, respectively, as from the date of the Meeting
in accordance with the allocation of the assets and liabilities between the Company and the Recipient Company as provided
in the present Demerger Proposal.

VI. Advantages
No special advantage will be granted to the directors and auditors of the Company and of the Recipient Company in

connection with or as a result of the Demerger of the Company.

The Company has not issued, to any person, any securities other than the shares composing the share capital of the

Company.

VII. Allocation of assets and liabilities
1) The Company will transfer part of its assets and liabilities to the Recipient Company as follows:

Description of the Assets and Liabilities transferred fromWeinberg Real Estate S.à r.l.

to the Recipient Company

Book Value of the Assets and

Liabilities transferred to the

Recipient Company (EUR)

Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

767 277,96

230000 - Financial fixed assets
Part. Weinberg Real Estate Resort Holding S.à r.l. (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 500,00

PARTICIPATIONS Weinberg Real Estate Co-Invest (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224 816,00

Weinberg Real Estate Partners #2 SCA - * (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145 308,00

LOAN TO Weinberg Real Estate Partners #2 SCA (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

365 984,56

410000 - Amounts owed by affiliates and part interests
Weinberg Real Estate Finance - Invest (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000,00

INTERESTS RECEIVABLE Weinberg Real Estate Partners #2 SCA (EUR) . . . . . . . .

8 744,25

420000 - Other receivables
Tax advance 2013 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 605,00

CIT advance 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 605,00

CIT advance 2015 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 605,00

NWT advance 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270,00

NWT advance 2015 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

292,50

NWT advance 2016 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 605,00

DEBTOR - LUX VAT RECEIVABLE 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 942,65

Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(498 191,22)

440000 - Trade payables and bills of exchange payable
PROV_TAX_FILING_FEES (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(750,00)

PROVISION EQUITY TRUST (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(715,00)

450000 - Amounts payable to affiliates and part interests
Advance from Weinberg Real Estate Partners #2 SCA (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(458 948,20)

460000 - Tax and social debts
Accruals CIT 2013 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 605,00)

Accruals CIT 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(11 597,50)

Accruals CIT 2015 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(23 975,00)

PROVISION NWT 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(252,50)

PROVISION NWT 2015 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(177,50)

49266

L

U X E M B O U R G

CCSS (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(170,52)

Net Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

269 086,74

2) The Company will retain the following assets and liabilities:

Description of the Assets and Liabilities retained by Weinberg Real Estate S.à r.l.

Book Value of the Assets and
Liabilities held by Weinberg

Real Estate S.à r.l. after the

Demerger (EUR)

Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197 504,73

230000 - Financial fixed assets
Capital Pierre Paris Prime OPCI (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,00

PARTICIPATIONS - Weinberg Real Estate Holding SARL (EUR) . . . . . . . . . . . . . . .

172,00

PARTICIPATIONS - Weinberg Real Estate Partners #1 SCA (EUR) . . . . . . . . . . . . . .

2 172,50

LOAN TO Weinberg Real Estate Partners #1 SCA (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84,38

410000 - Amounts owed by affiliates and part interests
Advance from Weinberg Real Estate Holding (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 138,78

INTEREST RECEIVABLE Weinberg Real Estate Partners #1 SCA (EUR) . . . . . . . . .

0,91

420000 - Other receivables
Tax advance 2013 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 605,00

CIT advance 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 605,00

CIT advance 2015 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 605,00

NWT advance 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270,00

NWT advance 2015 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

292,50

NWT advance 2016 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 605,00

DEBTOR - LUX VAT RECEIVABLE 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 942,65

510000 - Cash at bank/in hand/in postal cheque a/cs/cheques
SG - LU30 061 248541 2600 EUR (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113 511,01

Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(138 994,31)

440000 - Trade payables and bills of exchange payable
PROV_TAX_FILING_FEES (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(750,00)

PROVISION EQUITY TRUST (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(715,00)

450000 - Amounts payable to affiliates and part interests
Advance from Weinberg Real Estate Partners #1 SCA (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(16 823,80)

Payable to Weinberg Real Estate Partners #1 SCA - OPCI Pierre,
Castle project (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(82 927,49)

460000 - Tax and social debts
Accruals CIT 2013 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 605,00)

Accruals CIT 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(11 597,50)

Accruals CIT 2015 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(23 975,00)

PROVISION NWT 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(252,50)

PROVISION NWT 2015 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(177,50)

CCSS (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(170,52)

Net Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 510,42

It being understood that any assets and liabilities belonging to the Company at the date of the Meeting and not further

described in this Demerger Proposal shall be allocated to the Company and the Recipient Company as follows:

- any cash shall be allocated to the Company and the Recipient Company on a 50/50 basis;
- any other assets and liabilities pertaining to the Transferred Business shall be allocated to the Recipient Company; and
- any other assets and liabilities pertaining to the Retained Business shall remain with the Company.
The employees of the Company shall be allocated to the Retained Business and the Transferred Business as follows:
The work time of the two employees currently working for the Company will, following the Demerger, be split between

the Company and the Recipient Company on a 50/50 basis.

It being understood that the Company will proceed to the notification and information obligations provided by articles

L 127-3 and L 127-6 of the Luxembourg Labor Code in due course.

Suit la traduction française du texte qui précède:

Le présent projet de scission est rédigé en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence entre la version

anglaise et la version française, la version anglaise fait foi.

49267

L

U X E M B O U R G

La Société, Weinberg Real Estate S.à r.l. a été constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois le 6 juillet 2007 par acte sous seing privé passé devant Maître Martine Schaeffer, notaire au Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2115 du 27 septembre
2007. Ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 22 avril 2013 par acte sous seing privé établi par Maître Martine
Schaeffer, publié au Mémorial C du Recueil des Sociétés et Associations numéro 1589 du 3 juillet 2013. Le siège social
de la Société est sis au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

La Société a pour objet d’agir en qualité d’associé commandité de Weinberg Real Estate Partners #1 S.C.A., une société

en commandite par actions constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché du Luxembourg, dont le siège social
est sis au 46A avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg (le "RCS") sous le numéro B 132468 et Weinberg Real Estate Partners #2 S.C.A, une société en commandite
par actions constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché du Luxembourg, dont le siège social est sis au 46A
avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée au RCS sous le numéro B 171445.

I. Scission
Le conseil de gérance de la Société a approuvé la scission (la "Scission") de la Société par laquelle, en vertu de l’article

288 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), la Société transférera, sans
dissolution, à une société nouvellement constituée (la "Société Absorbante"), une partie de ses actifs et de son passif, en
échange de l’attribution aux associés de la Société de parts dans la Société Absorbante, conformément à la Loi et au présent
projet de scission (le "Projet de Scission").

Postérieurement à la Scission, la Société poursuivra son activité de détention de participations d'associé commandité

dans Weinberg Real Estate Partners #1 SCA (l’"Activité Conservée") et la Société Absorbante verra transférée à son profit
l’activité de la Société liée à sa détention de participations d'associé commandité dans Weinberg Real Estate Partners #2
SCA (l’"Activité Transférée").

II. Assemblée générale des associés de la Société
Le conseil d’administration de la Société convoquera les associés de la Société à une assemblée générale extraordinaire

des associés qui se tiendra devant un notaire luxembourgeois, dès que possible à l’expiration d’un délai d’un mois à compter
de la publication du présent Projet de Scission conformément à l’article 9 de la Loi, afin d’approuver le Projet de Scission,
y compris les statuts de la Société Absorbante et la Scission de la Société conformément au présent Projet de Scission
(l’"Assemblée").

Il est entendu que, au cours de l’Assemblée, le capital social de la Société sera augmenté pour atteindre au moins 25.000

EUR préalablement à la Scission.

III. Ratio d’échange des parts/Modalité de livraison des parts
Le ratio d’échange des parts du capital social de la Société est fixé de manière à ce que toutes les parts sociales de la

Société Absorbante soient réparties entre les associés de la Société au prorata de leurs droits dans la Société à la date de
l’Assemblée.

Les parts sociales de la Société Absorbante seront nominatives et les associés concernés seront inscrits au registre des

associés de la Société Absorbante dès sa constitution. Les parts sociales de la Société Absorbante seront assorties d’un
droit de participation à toute distribution des bénéfices effectuée par la Société Absorbante à compter de sa date de con-
stitution.

IV. La Société Absorbante
La Société Absorbante sera constituée à la date de l’Assemblée sous la forme d’une société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois, dont le siège social sera sis au 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg
et sera dénommée Weinberg Real Estate #2 S.à r.l.

Les statuts de la Société Absorbante seront rédigés comme suit:

«I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination Weinberg Real Estate

#2 S.à r.l. (la "Société"), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi") et par les présents statuts (les "Statuts").

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modi-
fication des Statuts.

2.2. Il peut être créé par décision du conseil de gérance de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou des événements
extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre les activités normales de la Société au siège social
ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire
n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

49268

L

U X E M B O U R G

Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet d'agir comme associé commandité d'une société en commandite par actions sous la déno-

mination de Weinberg Real Estate Partners # 2 S.C.A.

3.2 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par
souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.
Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra
en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de
quelque nature ou origine que ce soit, incluant l'acquisition et l'octroi de brevets concernant de tels droits de propriété
intellectuelle, de quelque nature ou origine que ce soit.

3.3 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder,

par  voie  de  placement  privé,  à  l'émission  de  parts  et  d'obligations  et  d'autres  titres  représentatifs  d'emprunts  et/ou  de
créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à
ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au profit
de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute
autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.4 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque crédit, le risque
de change, de fluctuations de taux d'intérêt et tout autres risques.

3.5 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de
son objet social.

4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cent (12.500)

parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra

être consulté par chaque associé qui le requiert.

6.5. La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'un gérant A et de deux gérants B. Les gérants sont nommés

et désignés comme gérant A ou gérant B par résolution des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Les gérants n'ont
pas besoin d'être associés.

7.2 Le gérant A sera désigné Président du conseil de gérance.

49269

L

U X E M B O U R G

7.3 Les gérants sont révocables à tout moment ad nutum (sans aucun motif).

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, par

décision unanime du conseil de gérance de la Société, conformément à l'article 9.6 des présents statuts.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants

au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants une notification écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de telles circonstances sera
mentionnée dans la notification de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou

représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être
renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme,
télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Pour les matières dont la valeur n'excède pas dix mille euros (EUR 10.000,-) (ou l'équivalent en devise étrangère),

le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée,
incluant au moins le gérant A et un gérant B. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des
voix des gérants présents ou représentés, à condition que au moins le gérant A et un gérant B aient donnés leur accord sur
ces résolutions.

9.6. Pour les matières dont la valeur excède dix mille euros (EUR 10.000,-) (ou l'équivalent en devise étrangère), le

conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si tous les gérants sont présents ou représentés. Les décisions
du conseil de gérance sont prises valablement à l'unanimité des voix du gérant A et des deux gérants B. Pour toutes matières,
les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.7. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre

moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre
et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.8. Dans les cas d'urgence, des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant

valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par
lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers, (i) pour la gestion journalière

n'excédant pas un montant de dix mille euros (EUR 10.000,-) (ou son équivalent en devise étrangère) par la signature
individuelle du gérant A et (ii) pour toutes les autres matières, par la signature conjointe du gérant A et des deux gérants
B ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été
valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit,

soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne ou entité comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par

résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax
ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés
apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

49270

L

U X E M B O U R G

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société

seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même

année.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance doit préparer le bilan et les comptes de profits et

pertes de la Sociétés ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société, avec une
annexe présentant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, de l'auditeur statutaire (s'il y en a) et des
associés à l'égard de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à
la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition
contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus
étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Disposition Générale. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il

est fait référence à la Loi.»

Il est proposé que Mr Robert Jan Schol, ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue John F. Kennedy, Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg soit désigné en tant que gérant de classe A de la Société Absorbante et que Monsieur Stéphane
D'Agostino ayant son adresse professionnelle au 20, rue Quentin bauchart, 75008 Paris et Mr Gérald Welvaert, ayant son
adresse professionnelle au 46A, avenue John F. Kennedy, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg soient désignés en
tant que gérants de classe B de la Société Absorbante.

V. Date de prise d’effet de la Scission
D’un point de vue comptable et à l’égard des associés de la Société, les opérations de la Société seront réputées exercées

pour le compte de la Société et de la Société Absorbante, respectivement, à compter de la date de l’Assemblée, conformé-
ment à la répartition des actifs et passifs entre la Société et la Société Absorbante, telle que prévue au présent Projet de
Scission.

VI. Avantages
Aucun avantage spécifique ne sera accordé aux administrateurs et commissaires aux comptes de la Société et de la

Société Absorbante dans le cadre ou en conséquence de la Scission de la Société.

La Société n’a émis, en faveur d’aucune personne, des titres autres que les parts composant le capital social de la Société.
VII. Répartition des actifs et passifs
1) La Société transférera une partie de ses actifs et passifs à la Société Absorbante comme suit:

Description des Actifs et Passifs transférés de Weinberg Real Estate S.à r.l. à la

Société Absorbante

Valeur Comptable des Actifs

et Passifs transférées à la

Société Absorbante (EUR)

49271

L

U X E M B O U R G

Actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

767 277,96

230000 - Immobilisations financières
Part. Weinberg Real Estate Resort Holding S.à r.l. (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 500,00

PARTICIPATIONS Weinberg Real Estate Co-Invest (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224 816,00

Weinberg Real Estate Partners #2 SCA - * (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145 308,00

PRET AWeinberg Real Estate Partners #2 SCA (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

365 984,56

410000 - Créances détenues sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles
la société a un lien de participation
Weinberg Real Estate Finance - Investissement (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000,00

INTERETS COURUS Weinberg Real Estate Partners #2 SCA (EUR) . . . . . . . . . . . . .

8 744,25

420000 - Autres créances
avance fiscale 2013 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 605,00

avance IRC 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 605,00

avance IRC 2015 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 605,00

avance ISF 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270,00

avance ISF 2015 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

292,50

avance ISF 2016 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 605,00

DEBITEUR - CREANCE TVA LUX 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 942,65

Passif
440000 - Dettes sur achats et prestations de services et dettes représentées par des effets
de commerce
PROV_FRAIS DE DEPOT DE DECLARATION FISCALE (EUR) . . . . . . . . . . . . . .

(750,00)

PROVISION EQUITY TRUST (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(715,00)

450000 - Dettes envers des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles
la société a un lien de participation
Avance de Weinberg Real Estate Partners #2 SCA (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(458 948,20)

460000 - Dettes fiscales et dettes envers la sécurité sociale
Charges IRC 2013 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 605,00)

Charges IRC 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(11 597,50)

Charges IRC 2015 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(23 975,00)

PROVISION ISF 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(252,50)

PROVISION ISF 2015 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(177,50)

CCSS (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(170,52)

Actif Net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

269 086,74

2) La Société conservera les actifs et passifs suivants:

Description des Actifs et Passifs conservés par Weinberg Real Estate S.à r.l.

Valeur Comptable des Actifs

et Passifs détenus par

Weinberg Real Estate S.à r.l.
à l'issue de la Scission (EUR)

Actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197 504,73

230000 - Immobilisations financières
Capital Pierre Paris Prime OPCI (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,00

PARTICIPATIONS - Weinberg Real Estate Holding SARL (EUR) . . . . . . . . . . . . . . .

172,00

PARTICIPATIONS - Weinberg Real Estate Partners #1 SCA (EUR) . . . . . . . . . . . . . .

2 172,50

PRET A Weinberg Real Estate Partners #1 SCA (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84,38

410000 - Créances détenues sur des entreprises liées et sur des entreprises avec
lesquelles la société a un lien de participation
Avance de Weinberg Real Estate Holding SARL (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 138,78

INTERETS COURUS Weinberg Real Estate Partners #1 SCA (EUR) . . . . . . . . . . . . .

0,91

420000 - Autres créances
avance fiscale 2013 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 605,00

avance IRC 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 605,00

avance IRC 2015 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 605,00

avance ISF 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270,00

avance ISF 2015 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

292,50

49272

L

U X E M B O U R G

avance ISF 2016 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 605,00

DEBITEUR - CREANCE TVA LUX 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 942,65

510000 - Avoirs en banque, avoirs en comptes de chèque postaux, chèques et encaisse
SG - LU30 061 248541 2600 EUR (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113 511,01

Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(138 994,31)

440000 - Dettes sur achats et prestations de services et dettes représentées par des effets
de commerce
PROV_FRAIS DE DEPOT DE DECLARATION FISCALE (EUR) . . . . . . . . . . . . . .

(750,00)

PROVISION EQUITY TRUST (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(715,00)

450000 - Dettes envers des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles la société
a un lien de participation
Avance de Weinberg Real Estate Partners #1 SCA (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(16 823,80)

Dette payable à Weinberg Real Estate Partners #1 SCA - OPCI Pierre,
Castle project (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(82 927,49)

460000 - Dettes fiscales et dettes envers la sécurité sociale
Charges IRC 2013 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 605,00)

Charges IRC 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(11 597,50)

Charges IRC 2015 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(23 975,00)

PROVISION ISF 2014 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(252,50)

PROVISION ISF 2015 (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(177,50)

CCSS (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(170,52)

Actif Net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 510,42

Étant entendu que les actifs et passifs appartenant à la Société à la date de l’Assemblée qui ne sont pas plus amplement

décrits dans le présent Projet de Scission seront affectés à la Société et à la Société Absorbante comme suit:

- tous les montants en numéraire seront répartis, à parts égales, entre la Société et la Société Absorbante;
- les autres actifs et passifs appartenant à l’Activité Transférée seront transférés à la Société Absorbante; et
- les autres actifs et passifs appartenant à l’Activité Conservée seront conservés par la Société.
Les salariés de la Société seront affectés à l’Activité Conservée et à l’Activité Transférée comme suit:
Le temps de travail des deux employés qui travaillent actuellement pour la Société sera, à l'issue de la Scission, partagé

entre la Société et la Société Absorbante sur une base de 50/50.

Étant entendu que la Société se conformera à ses obligations de notification et d’information prévues aux articles L

127-3 et L 127-6 du Code du Travail luxembourgeois dans les délais requis.

Gérald Welvaert
<i>Class B manager on behalf of the board of managers

Référence de publication: 2016088742/633.
(160056222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2016.

Vaulux International SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 65.828.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 16 décembre 2015

1. L'Assemblée Générale décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes actuel Maypark Associates Ltd.
2. L'Assemblée Générale décide de nommer commissaire aux comptes:
- LUX-AUDIT S.A., 57 ave de la Faïencerie L-1510 Luxembourg
Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se statuera sur les comptes au 31 décembre 2015

Luxembourg, le 18 janvier 2015.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour VAULUX SPF S.A.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS S.à R.L.

Référence de publication: 2016057797/16.
(160017690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

49273

L

U X E M B O U R G

Zaphira S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 176.298.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement de la dénomination sociale de l'administrateur

suivant:

-  la  société  CAPITAL  OPPORTUNITY  S.A.  (B  149.718),  ayant  son  siège  social  au  5,  rue  de  Bonnevoie,  L-1260

Luxembourg, avec Monsieur Laurent TEITGEN, né le 5 janvier 1979 à Thionville (France) et demeurant professionnel-
lement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, comme représentant permanent, porte dorénavant la dénomination
SECURED INTERNATIONAL TRANSACTIONS SERVICES S.A., en abrégé SITS S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ZAPHIRA S.A.

Référence de publication: 2016057824/15.
(160017320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Carmudi Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 21.875,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 180.458.

Suite à un apport en nature de 21.875 parts des associés de la Société, Asia Internet Holding S.à r.l. (12.500 parts sociales),

TEC Global Invest VIII GmbH (3.125 parts de série A2), SHCO 57 S.à r.l. (3.125 parts de série A3) et Aismare Lux
Holdings S.à r.l. (3.125 parts de série A1), à la société:

- Carmudi Global S.à r.l. (anciennement Digital Services XXVI S.à r.l.), une société à responsabilité limitée, constituée

et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B188487,

intervenu lors d'une assemblée générale extraordinaire de la société Carmudi Global S.à r.l., qui s'est tenue devant notaire

en date du 13 janvier 2015, les parts de la Société sont désormais détenues comme suit:

Carmudi Global S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500 parts sociales

3.125 parts de série A1
3.125 parts de série A2
3.125 parts de série A3

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2016.

Carmudi Holding S.à r.l.

Référence de publication: 2016057934/23.
(160017987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.

4i S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 59.898.

L'an deux mille quinze, le trente-et-unième jour du mois de décembre,
Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois «4i S.A.» (ci-après

la «Société»), ayant son siège social à L-8437 Steinfort, 50, Rue de Koerich, inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 59.898, constituée suivant acte de Maître Frank Baden, notaire alors de
résidence à Luxembourg, en date du 04 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 08
octobre 1997, numéro 553. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Frank
Baden, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 01 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations du 14 décembre 1999, numéro 957.

L'assemblée est ouverte à 14 heures sous la présidence de Madame Khadigea Klingele, senior legal counsel, demeurant

professionnellement à Mondorf-les-Bains,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Chris Oberhag, employé, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains.

49274

L

U X E M B O U R G

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, clerc de notaire, demeurant professionnellement à

Mondorf-les-Bains.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation, envoyés par lettre

recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2015.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un montant de quarante-quatre mille treize Euro et

trente-et-un cents (EUR 44.013,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros
et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à soixante-quinze mille Euro (EUR 75.000,00) sans émission d’actions nouvelles.

3. Libération totale des actions par les actionnaires existants au prorata de leur participation par incorporation partielle

des résultats reportés d’un montant de quarante-quatre mille treize Euro et trente-et-un cents (EUR 44.013,31) tels que
figurant aux comptes intérimaires de la Société à la date du 30 octobre 2015.

4. Insertion d’un nouveau capital autorisé à hauteur de quatre cent quatre-vingt mille Euros (EUR 480.000,00) capital

social inclus.

5. Refonte intégrale de l’article 5 des statuts de la Société.
6. Divers.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

IV.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, les actionnaires présents

ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable.

V.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’assemblé générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution:

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de quarante-quatre

mille treize Euro et trente-et-un cents (EUR 44.013,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-
vingt-six Euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à soixante-quinze mille Euro (EUR 75.000,00) sans émission
d’actions nouvelles.

<i>Troisième résolution:

L’assemblée générale décide la libération totale des actions par les actionnaires existants, au prorata de leur participation,

par incorporation partielle des résultats reportés d’un montant de quarante-quatre mille treize Euro et trente-et-un cents
(EUR 44.013,31) tels que figurant aux comptes intérimaires de la Société à la date du 30 octobre 2015 fournis au notaire
instrumentant.

<i>Quatrième résolution:

L’assemblée générale décide d’insérer un nouveau capital autorisé à hauteur de quatre cent quatre-vingt mille Euros

(EUR  480.000,00),  capital  social  inclus,  par  la  création  et  l'émission  de  six  mille  sept  cent  cinquante  (6.750)  actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution:

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de refondre intégralement l’article 5 des statuts de la

Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-quinze mille Euro (EUR 75.000,-), représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) actions sans dénomination de valeur nominale.

Les actions sont nominatives.

49275

L

U X E M B O U R G

La propriété des actions nominatives s'établit par leur inscription sur le registre prescrit par la loi, registre dont tout

actionnaire pourra prendre connaissance et qui contiendra entre autres:

- la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions,
- l'indication des versements effectués,
- les transfert avec leur date.
La souscription d'une action ou sa possession comporte de plein droit adhésion aux statuts.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel de soixante-quinze mille Euro (EUR 75.000,-) à

quatre cent quatre-vingt mille Euros (EUR 480.000,-), capital social inclus, par la création et l'émission de six mille sept
cent (6.750) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes, outre une prime d'émission que le Conseil d'Administration pourra déterminer.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation
de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut

être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas
été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de

cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée
dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

<i>Droit de préemption:

L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d'administration par lettre recom-

mandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les noms, prénoms, profession et
domicile des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmet
la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce

droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice, total ou
partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont fractionnées;
si le nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles s'exerce le droit
de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du conseil
d'administration.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le conseil d'administration par lettre recom-

mandée dans les deux mois de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son
droit de préemption. Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement les actionnaires jouiront d'un délai supplé-
mentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux actionnaires pour faire connaître
leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces actions sera déterminé, soit de commun accord entre l'actionnaire cédant et le

ou les actionnaire(s) acquéreur(s), soit par un expert-comptable et fiscal, désigné de commun accord par l'actionnaire cédant
et l'(les) actionnaire(s) acquéreur(s), soit, en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce
du ressort du siège social de la société, à la requête de la partie la plus diligente. L'expert rendra son rapport sur la déter-
mination du prix dans le mois de la date de sa nomination. L'expert aura accès à tous les livres et autres documents de la
société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa tâche.

En cas de refus des actionnaires d'acquérir les actions proposées ou en cas de non-réponse de leur part dans le délai

imparti, l'actionnaire sera libre de céder ses actions au cessionnaire proposé par lui.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ deux mille euros (EUR 2.000.-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14h15.

DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains date qu'en tête.

49276

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom,

qualité et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. Klingele, C. Oberhag, F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 janvier 2016. GAC/2016/218. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 25 janvier 2016.

Référence de publication: 2016056438/134.
(160015873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Buddha Bar S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. 8 Grussgaass S.à r.l.).

Siège social: L-9420 Vianden, 9, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 196.425.

L'an deux mil seize, le treize janvier.
Par-devant, Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

Madame Fernanda DUARTE TAVARES, salariée, née le 28 août 1969 à Agueda (P), demeurant à L-9424 Vianden,

6A, rue du Ruisseau

Laquelle comparante déclare qu'elle est la seule associée de la société à responsabilité limitée "8 GRUSSGAASS S. à

r.l.", avec siège social à L-9240 Diekirch, 8 Grand'rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro B 196.425, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 avril 2015, acte publié
au Mémorial, C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1607 du 30 juin 2015 (ci-après "la Société").

La requérante est devenue propriétaire de la totalité des parts de la prédite société en vertu d'une convention de cession

de parts sous seing privé datée du 27 novembre 2016, enregistrée à Diekirch, actes civils le 01 décembre 2015 sous la
relation DAC/2015/20424,; la partie comparante déclare par les présentes accepter purement et simplement cette cession
de parts au nom de la société elle-même conformément à l'article 1690 nouveau du Code Civil et l'article 190 de la loi sur
les sociétés commerciales.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter les constatations et résolutions suivantes, prises en as-

semblée générale extraordinaire, à laquelle elle se reconnaît comme dûment convoqué.

<i>Première résolution

L'associée décide de changer la dénomination sociale de la société et de changer en conséquence l'article 4 des statuts

qui aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 4. La société prend la dénomination de «BUDDHA BAR s.à r.l.»

<i>Deuxième résolution

L'associée décide d'accepter la démission de son mandat de gérant technique de Madame Carla Manuela TEIXEIRA

BICHAO  avec  décharge  pour  l'exercice  de  ses  fonctions  et  de  Madame  Patricia  Alexandra  TEIXEIRA  BICHAO  DE
CASTRO comme gérante administrative avec décharge pour l'exercice de ses fonctions. Madame Fernanda DUARTE
TAVARES, préqualifiée, sera seule gérante de la société avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

<i>Troisième résolution

L'associée décide de changer le siège social de la société pour l'établir à L-9420 Vianden, 9, rue de la Gare, de sorte que

l'article 5 des statuts prendra dorénavant la teneur suivante:

„ Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Vianden.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité

de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par
assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.“
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est close.

<i>Déclaration du comparant

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être

le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/ droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant

49277

L

U X E M B O U R G

une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5
du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à

raison des présentes, est évalué à environ huit cent cinquante euros (850,00 €).

DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états

et demeures, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Fernanda DUARTE TAVARES, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 13 janvier 2016. Relation: DAC/2016/630. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): Rodenbour.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 25 janvier 2016.

Référence de publication: 2016056439/61.
(160015500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Albemarle Management S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 141.790.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 15 janvier 2016 que:
- Geoffrey Henry, a démissionné de ses fonctions de gérant unique de la Société, avec effet immédiat; et
- M. Alex Pschorr, né le 22 Juillet 1970 à Munich (Allemagne), demeurant à D-22761 Hamburg, 42, Theodorstrasse

(Allemagne) a été nommé aux fonctions de gérant de la Société pour une durée indéterminée, avec effet immédiat;

- Mr. Alberto Morandini, né le 9 Février 1968 à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg) demeurant professionnellement

à L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire (Grand-Duché of Luxembourg) a été nommé aux fonctions de gérant de
la Société pour une durée indéterminée, avec effet immédiat;

- Mrs Emilie Bordaneil, née le 30 Janvier 1981 à Perpignan (France) demeurant professionnellement à L-1528 Luxem-

bourg, 1, boulevard de la Foire (Grand-Duché of Luxembourg) a été nommée aux fonctions de gérant de la Société pour
une durée indéterminée, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016057175/20.
(160017375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Alpha Trains Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2175 Luxembourg, 22, rue Alfred de Musset.

R.C.S. Luxembourg B 140.872.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique de la Société adoptées le 25 janvier 2016

L'associé unique de la Société a accepté la démission de Jan Vanhoutte de ses fonctions de gérant de type A de la Société

avec effet au 26 janvier 2016.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer Barbara Neuerburg dont l'adresse professionnelle se situe au 15, rue

Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, aux fonctions de gérant de type A de la Société à compter du 26 janvier 2016 pour
une durée indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance se compose à compter du 26 janvier 2016 de la manière suivante:
- Barbara Neuerburg, gérant de type A; et
- Shaun Mills, gérant de type B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

49278

L

U X E M B O U R G

Alpha Trains Luxembourg S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016057178/20.
(160017686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Avery Dennison Investments Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-4801 Rodange, Zone Industrielle P.E.D.

R.C.S. Luxembourg B 97.945.

EXTRAIT

Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'associé unique en date du 24 novembre 2015:
1. Avec effet au 24 juillet 2015, la démission de Madame Marcia Tuten Greci, de son mandat de gérant de la société, a

été acceptée.

2. Avec effet au 24 novembre 2015 à 13h00, la démission de Monsieur Andrew Crawford de son mandat de gérant de

la société, a été acceptée.

3. Les personnes suivantes ont été nommées en tant que nouveaux gérants de la société, avec effet au 24 novembre 2015

à 13h00 et pour une période indéterminée:

- Madame Patricia Horreaux, née le 14 mai 1968 à Watermael-Boitsfort, Belgique, avec adresse professionnelle à Zone

Industrielle P.E.D., B.P. 38, L-4801 Rodange, Grand-Duché du Luxembourg, et;

- Monsieur Frédéric Noël, né le 19 décembre 1974 à Steinfort/Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, avec adresse

professionnelle à Zone Industrielle P.E.D., B.P. 38, L-4801 Rodange, Grand-Duché du Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 27 janvier 2016.

Référence de publication: 2016057196/23.
(160017859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Agir Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.131.

EXTRAIT

Suite à une réunion du conseil d'administration en date du 23 janvier 2015, les modifications suivantes ont été adoptées:
- La société ARTEMIS AUDIT &amp; ADVISORY, RCS Luxembourg n° B166.716, avec siège social au 25A, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg a été nommé au poste de réviseur de la société en remplacement de la société TEAMAUDIT
S.A.

Le mandat du nouveau Réviseur commence avec la mission de Contrôle de l'exercice 2014 et prendra fin lors de la

clôture du contrôle de l'exercice 2015.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2016057207/15.
(160017706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Alifa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 138.502.

CLOSURE OF LIQUIDATION

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2015

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2015 que l'Assemblée:
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a cessé d'exister.
-  décide  que  les  livres  et  documents  sociaux  seront  déposés  et  conservés  pendant  une  durée  de  cinq  ans  à  L-1258

Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

49279

L

U X E M B O U R G

Luxembourg.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016057217/17.
(160017983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

BBFD Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 163.400,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 117.936.

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 26 janvier 2016 lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société

<i>BBFD Investment S.à r.l.

- La démission de M. Alexandre TASKIRAN de son mandat de gérant de la Société a été acceptée avec effet au 23

décembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BBFD Investment S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016057246/15.
(160017947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Europa Ruby S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.666.650,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 128.413.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des associés (l'«Assemblée») de la Société à Lu-

<i>xembourg en date du 21 janvier 2016

L'Assemblée a décidé:
1. de révoquer Monsieur Fabrice Léonard, gérant de la Société, avec effet immédiat;
2. d'élire, pour une durée indéterminée, en tant que gérant de la Société Monsieur Grégory Gosselin, né le 8 novembre

1982 à Libramont-Chevigny, Belgique et résidant professionnellement au 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lu-
xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2016.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2016057324/19.
(160017391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Efiparind B.V. &amp; Cie S.C.P.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 8.535.

En date du 2 février 2015, le gérant commandité de la Société a transféré le siège social de la Société et se trouve à

présent au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2016.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Efiparind B.V. &amp; Cie S.C.P.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2016057331/14.
(160017362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

49280

L

U X E M B O U R G

Apsys Poznan Lux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 191.617.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 22 décembre 2015

L'assemblée générale extraordinaire a prise les résolutions suivantes:
1. Démission de Monsieur Pascal FABECK de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
2. Election de L'alliance Révision Sàrl (RCS B46498), dont le siège social est au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg,

comme commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au 31 décembre
2016.

Pour extrait conforme
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2016057187/15.
(160017327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Seventh Century Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.900,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 191.561.

La Société porte à la connaissance de toute personne intéressée que l'adresse de Mr. Samuel Aidan, associé et gérant de

catégorie A de la Société, est au 39 Avenue de l'Argensol 84100 Orange, France.

<i>Pour SEVENTH CENTURY PARTNERS S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2016057711/12.
(160017438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Sialina Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 164.580.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire le 28 décembre 2015

1. L'Assemblée décide de donner décharge au liquidateur, C.G. Consulting, ayant son siège social 40, avenue Monterey

à L-2163 Luxembourg pour l'exécution de son mandat.

2. Après avoir examiné le rapport du commissaire-vérificateur, Co-Ventures S.A., ayant son siège social 40, avenue

Monterey à L-2163 Luxembourg, l'Assemblée décide de lui donner décharge pour l'exécution de son mandat.

3. L'Assemblée décide de clôturer la liquidation.
4. L'Assemblée décide que les documents et registres de la société seront conservés pendant une période de cinq ans

suivant la publication de la présente résolution au Journal officiel au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2016057714/17.
(160017595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Sioux S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 52.893.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 17 août 2015

Il résulte dudit procès-verbal que:
le mandat de Madame Nathalie PRIEUR, consultant fiscal, demeurant 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, de

Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, demeurant 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, et de Monsieur
Raphaël GAILLARD, banquier, demeurant professionnellement 18 place Longemalle, CH-1204 Genève, en tant qu'ad-
ministrateur ainsi que le mandat de la société Benoy Kartheiser Management S.à r.l., ayant son siège social 45-47, route

49281

L

U X E M B O U R G

d'Arlon, L-1140 Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes a été prolonger jusqu'à l'assemblée générale qui se
tiendra en l'année 2016.

Luxembourg, le 17 août 2015.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2016057719/17.
(160017377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

SSCP Titan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 201.903.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la société SSCP Titan S.à r.l. du 12 janvier 2016

1, Acceptation de la démission de Monsieur Alexander James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield, Roy-

aume-Uni, résidant au 7, rue Lou Hemmer, 1748, Luxembourg - Findel, en tant que gérant de la Société avec effet au 11
janvier 2016.

2. Acceptation de la nomination de Madame Monica Morsch, née le 3 juin 1987 à Craiova, Roumanie, résidante au 7,

rue Lou Hemmer, 1748, Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 11 janvier 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Référence de publication: 2016057734/16.
(160017202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

A.D.S.L., Affrètements, Distributions, Services, Logistic S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 92.134.

<i>Extrait des décisions prises à l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 01.04.2015

1) L'assemblée décide la prolongation des mandats des administrateurs et de l'administrateur délégué jusqu'à l'assemblée

générale qui se tiendra en l'année 2021.

2) L'assemblée accepte la démission de Mme Christine Andry comme administrateur et nomme nouveau administrateur,

Mr Calluaud François, né le 21.03.1961 à Thionville demeurant à 39 rue St. Hubert F-57190 Florange jusqu'à l'assemblée
générale qui se tiendra en l'année 2021.

3) L'assemblée nomme nouveau commissaire au compte, GEFCO PARTICIPATIONS S.A. 51 RUE DES 3 CANTONS

L-3961 EHLANGE/MESS (B64277) jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2021.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Howald, le 25.01.2016.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société

Référence de publication: 2016057203/20.
(160017472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Sungem Serfinco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 142.456.

EXTRAIT

Il est pris acte de la nouvelle adresse de l'associé Stefano Ghersi: 48B Jalan Kampong Chantek, 587797 Singapore

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2016057744/12.
(160017001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

49282

L

U X E M B O U R G

RoMei S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 7.550,00.

Siège social: L-5534 Remich, 2, rue Foascht.

R.C.S. Luxembourg B 171.375.

<i>Mitgliederversammlung der RoMei S.A. vom 01.07.2015

Grund der Versammlung: Umzug der Firma
Am 01.07.2015 wurde einstimmig beschlossen das der Firmensitz von der RoMei S.A. 2, rue Foascht L-5534 Remich

nach 43, Esplanade L-5533 Remich Verlegt wird.

Anwesende Mitglieder
Christiane Meier Rechnungskommissar
Robert Meier Mitglied des Verwaltungsrates

Robert Meier / Christiane Meier.

Référence de publication: 2016057661/16.
(160017460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Russian Acquisition Company N°1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 145.125.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique du 18 janvier 2016

L'Associé unique prend les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé unique décide de nommer, avec effet immédiat et pour une période illimitée, Mr. Federigo Cannizzaro di

Belmontino, avec adresse professionnelle au 11 avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, né à La Spezia (I), le 12
Septembre 1964, en qualité de Gérant de classe B de la Société.

<i>Deuxième résolution

L'Associé unique décide d'accepter la démission, avec effet immédiat, de la société Luxembourg International Consulting

S.A. de sa fonction de gérant de classe B de la Société.

L'adresse du gérant Mr. François Manti est désormais la suivante: 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.

Pour mandat
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2016057662/21.
(160017831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

TES Global Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 269.879,25.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 178.804.

EXTRAIT

En date du 15 janvier 2016, Louise Rogers, une associée de la Société, a cédé à Appleby Trust (Jersey) Limited, un autre

associé de la Société, les parts sociales suivantes:

- 37.681 Parts Sociales de Classe A, Catégorie SWE-2,
- 37.681 Parts Sociales de Classe B, Catégorie SWE-2,
- 37.681 Parts Sociales de Classe C, Catégorie SWE-2,
- 37.681 Parts Sociales de Classe D, Catégorie SWE-2,
- 37.681 Parts Sociales de Classe E, Catégorie SWE-2,
- 37.682 Parts Sociales de Classe F, Catégorie SWE-2,
- 37.682 Parts Sociales de Classe G, Catégorie SWE-2,

49283

L

U X E M B O U R G

- 37.682 Parts Sociales de Classe H, Catégorie SWE-2,
- 37.682 Parts Sociales de Classe I, Catégorie SWE-2,
- 37.681 Parts Sociales de Classe J, Catégorie SWE-2,
- 68.500 Parts Sociales de Classe A, Catégorie SWE-3,
- 68.500 Parts Sociales de Classe B, Catégorie SWE-3,
- 68.500 Parts Sociales de Classe C, Catégorie SWE-3,
- 68.500 Parts Sociales de Classe D, Catégorie SWE-3,
- 68.500 Parts Sociales de Classe E, Catégorie SWE-3,
- 68.500 Parts Sociales de Classe F, Catégorie SWE-3,
- 68.500 Parts Sociales de Classe G, Catégorie SWE-3,
- 68.500 Parts Sociales de Classe H, Catégorie SWE-3,
- 68.500 Parts Sociales de Classe I, Catégorie SWE-3,
- 68.500 Parts Sociales de Classe J, Catégorie SWE-3, et
- 21.488 Parts Sociales de Classe A, Catégorie O-1,
- 21.488 Parts Sociales de Classe B, Catégorie O-1,
- 21.488 Parts Sociales de Classe C, Catégorie O-1,
- 21.487 Parts Sociales de Classe D, Catégorie O-1,
- 21.487 Parts Sociales de Classe E, Catégorie O-1,
- 21.487 Parts Sociales de Classe F, Catégorie O-1,
- 21.487 Parts Sociales de Classe G, Catégorie O-1,
- 21.487 Parts Sociales de Classe H, Catégorie O-1,
- 21.487 Parts Sociales de Classe I, Catégorie O-1,
- 21.487 Parts Sociales de Classe J, Catégorie O-1.
D'autre part, Louise Rogers a transféré en date du 15 janvier 2016 à TPG Airbourne Holdings, L.P., un autre associé de

la Société, les parts sociales suivantes:

- 10.743 Parts Sociales de Classe A, Catégorie O-1,
- 10.743 Parts Sociales de Classe B, Catégorie O-1,
- 10.743 Parts Sociales de Classe C, Catégorie O-1,
- 10.744 Parts Sociales de Classe D, Catégorie O-1,
- 10.744 Parts Sociales de Classe E, Catégorie O-1,
- 10.744 Parts Sociales de Classe F, Catégorie O-1,
- 10.744 Parts Sociales de Classe G, Catégorie O-1,
- 10.744 Parts Sociales de Classe H, Catégorie O-1,
- 10.744 Parts Sociales de Classe I, Catégorie O-1,
- 10.744 Parts Sociales de Classe J, Catégorie O-1.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2016.

Référence de publication: 2016056375/55.
(160016116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Tili S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 203.272.

STATUTS

L'an deux mille seize, le huit janvier.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société de droit luxembourgeois "Jean PV S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-1320 Luxembourg, 90, rue

de Cessange, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199.916,

ici représentée par deux de ses gérants actuellement en fonctions, Monsieur Franck VERDEIL, dirigeant de sociétés,

né le 7 mai 1973 à Mazamet (France), demeurant à L-2560 Luxembourg, 6, rue de Strasbourg et Monsieur Pierre-Olivier
WURTH, avocat, né le 03 décembre 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg, 18, rue
Robert Stümper.

49284

L

U X E M B O U R G

Laquelle comparante par ses représentants a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité

limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2.  La  Société  a  pour  objet,  sur  le  territoire  luxembourgeois  et  à  l’international,  toutes  activités  concernant  les

transports de marchandises par voies aériennes, maritimes et terrestres.

Elle pourra agir en qualité de commissionnaire de transport, commissionnaire en douane et exercer toutes activités liées

aux transports routiers, à l’entreposage ou encore à la location de véhicules avec ou sans chauffeur.

La Société pourra faire d'une manière générale toutes opérations financières, mobilières et immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à l'objet social ou de nature à en favoriser la réalisation.

La Société a, en outre, pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties.

En général, la Société pourra faire toutes transactions commerciales connexes, industrielles, financières, mobilières et

immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société est constituée sous le nom de «TILI S.à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société
peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres
pays par décision du gérant ou du conseil de gérance.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-

cinq (125) parts sociales, d'une valeur de cent euros (EUR 100,-).

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants,
proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en numéraire.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à

des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés
que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont librement

révocables à tout moment et sans cause.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature unique du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants

ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura
été délégué par le conseil de gérance.

Art. 12. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir

parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

49285

L

U X E M B O U R G

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de

convocation.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance; en son absence, les

associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la
présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion par courrier électronique, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de
chaque gérant par écrit ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation  spéciale  ne  sera  pas  requise  pour  une  réunion  du  conseil  de  gérance  se  tenant  à  une  heure  et  un  endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par courrier

électronique ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visio-conférence ou d'autres

moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les
autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,

par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du

capital social.

Art. 18. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés

par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 19. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre

de la même année.

Art. 20. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un

inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication
au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le conseil
de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution sont dispo-
nibles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,

nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

49286

L

U X E M B O U R G

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

L'intégralité des cent vingt-cinq (125) parts sociales a été souscrite par la société Jean PV S.à r.l., préqualifiée.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de décembre

2016.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

<i>Résolutions

Et aussitôt, la société Jean PV S.à r.l., préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions

suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.

2. L'associé unique décide de nommer Monsieur Franck VERDEIL, prénommé, en tant que gérant unique de la Société

pour une durée indéterminée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants de la comparante, ils ont signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. VERDEIL, P.-O. WURTH et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 14 janvier 2016. 1LAC/2016/1103. Reçu soixante quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur (signé): MOLLING Paul.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 25 janvier 2016.

Référence de publication: 2016056379/149.

(160015581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Centrum NS Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 85.523.

CLOSURE OF LIQUIDATION

<i>Extrait

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 3 décembre 2015, les associés de la Société ont:

- prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la Société a définitivement cessé d'exister;

- décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à partir du 3

décembre 2015 au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 10 décembre 2015.

Référence de publication: 2016057960/16.

(160018494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.

49287

L

U X E M B O U R G

Freo Asset Management Invest Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 181.512.

Freo Group S.à r.l. mit Firmensitz in der 6d route de Tréves, L -2633 Senningerberg hat zum 16.06.2015 Ihre 1,260

Anteile an der Gesellschaft Freo Asset Management Invest Holding S.à r.l. an die Gesellschaft Freo Management Holding
S.à r.l. mit Firmensitz in der 6d route de Tréves, L -2633 Senningerberg verkauft.

Freo Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 Anteile

Freo Management Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.260 Anteile

1.260 Anteile

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2016057357/16.
(160017572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

2B-Natural S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 158.672.

DISSOLUTION

L’an deux mille seize, le douze janvier.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Gerardus Jozef BIK, commerçant, né le 23 juillet 1973 à Leiden (Pays-Bas), demeurant à Strausslaan 15,

NL-2151 NE Nieuw Vennop (Pays-Bas),

représenté par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d’une pro-

curation donnée sous seing privé.

Laquelle  procuration  restera,  après  avoir  été  signées  «ne  varietur»  par  le  mandataire  de  la  comparant  et  le  notaire

instrumentant, annexée aux présente pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations

et constatations:

I. Que la société à responsabilité «2B-NATURAL S.à r.l.», ayant son siège social à: L-2121 Luxembourg, 117 Val des

Bons Malades, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 158.672, a été
constituée suivant acte reçu par devant le notaire Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 25 janvier 2011, publiée au Mémorial C en date du 3 mai 2011, numéro 886, page 42.486 et sv.

II. Que le capital social de la société à responsabilité limitée, 2BNATURAL S.àrl, pré-désignée, s’élève actuellement à

EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros) représenté par 100 (cent parts sociales) de EUR 125,-(cent vingt-cinq euro)
chacune, chacune intégralement libérée.

III. Que le comparant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

«2B-NATURAL S.à r.l.».

IV. Que le comparant est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'associé unique,

agissant en tant que liquidateur, il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société, et ceci avec un effet
au 31 décembre 2015.

V. Que le comparant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute.

VI. Que le comparant déclare que la société «2B-NATURAL S.à r.l.», ne possède pas d’immeubles, ni de participations.
VII. Que le comparant déclare dès lors que la liquidation de la société «2B-NATURAL S.à r.l.» est achevée sans préjudice

du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux, et ceci avec un effet au 31 décembre 2015.

VI. Qu'il a été procédé à l’annulation du registre des associés et des parts sociales de la société dissoute.
VII. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants, de la société dissoute pour l’exécution de leurs

mandats jusqu'au 31 décembre 2015.

VIII. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux situés à 117 Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.

49288

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille euros, sont à la charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 15 janvier 2016. Relation GAC/2016/457. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016056437/50.
(160015576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Xtreme Equipment Group, Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 151.988.

Les statuts coordonnés au 23 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2016056427/11.
(160015252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

WFS Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 197.064.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of December.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

THERE APPEARED:

WFS Midco S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under the laws of the

Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 197062;

duly represented by Mrs. Fleur MARCHAL, lawyer, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, Boulevard de

la Pétrusse, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, having been signed “ne varietur” by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed to be filed with it with the registration authorities.

The appearing party is the sole member (the “Sole Member”) of the company WFS Holding I S.à r.l., a private limited

liability company (société à responsabilité limitée), existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with
registered office at 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 197064 (the “Company”), incorporated by a deed received by the undersigned notary, on
May 13, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1816 dated July 22, 2015 page
87146, which articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed received by
the undersigned notary on September 30, 2015, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated
December 7, 2015 number 3279 page 157346.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state the following

resolutions that it takes in its capacity as the Sole Member of the Company:

<i>First resolution

The Sole Member resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of three million six hundred

forty-one thousand six hundred sixty-one Euros and forty-two Euro cents (EUR 3,641,661.42) so as to bring it from its
present amount of fifteen million four hundred seventy thousand seven hundred thirty-six Euros and eleven Euro cents
(EUR 15,470,736.11) represented by one billion five hundred forty-seven million seventy-thee thousand six hundred eleven
(1,547,073,611) corporate units each with a par value of one Euro cent (EUR 0.01), to an amount of nineteen million one
hundred twelve thousand three hundred ninety-seven Euros and fifty-three Euros cents (EUR 19,112,397.53) represented
by one billion nine hundred eleven million two hundred thirty-nine thousand seven hundred fifty-three (1,911,239,753)
corporate units each with a par value of one Euro cent (EUR 0.01).

49289

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Sole Member resolves to issue three hundred sixty-four million one hundred sixty-six thousand one hundred forty-

two (364,166,142) corporate units with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each.

<i>Subscription and payment

Then appears Mrs. Fleur MARCHAL, previously named, acting in her capacity as duly appointed attorney in fact of the

Sole Member, above identified, acting by virtue of a power of attorney given under private seal.

The appearing person, prenamed, declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Member to three hundred

sixty-four million one hundred sixty-six thousand one hundred forty-two (364,166,142) newly issued corporate units in
the capital of the Company, in consideration for a contribution in kind consisting in of two claims held by the Sole Member
against the Company, in an aggregate amount of three million six hundred forty-one thousand six hundred sixty-one Euros
and forty-two Euro cents (EUR 3,641,661.42) (the “Contribution”),

It results from a valuation report (the “Report”) issued by the management of the Company dated December 23, 2015

that the value of the Contribution may be set at least at three million six hundred forty-one thousand six hundred sixty-one
Euros and forty-two Euro cents (EUR 3,641,661.42).

A copy of the Report, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and by the undersigned notary, will

remain attached to the present deed.

Having acknowledged the above described Contribution, the Sole Member, represented as stated above, expressly agreed

with the description of the Contribution, with its valuation and confirmed the validity of the subscription and payment of
the newly issued corporate units.

<i>Third resolution

The Sole Member resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company, which shall read as follows:

“ Art. 5. The subscribed capital is set at nineteen million one hundred twelve thousand three hundred ninety-seven Euros

and fifty-three Euros cents (EUR 19,112,397.53) represented by one billion nine hundred eleven million two hundred thirty-
nine thousand seven hundred fifty-three (1,911,239,753) corporate units with a par value of one cent of Euro (EUR 0.01)
each.”

<i>Fourth resolution

The Sole Member resolves to authorize any manager of the Company to do everything necessary and incidental to the

above resolutions, namely to create and/or amend the relevant members’ register referring to the corporate units issued and
outstanding, representing the entire corporate capital of the Company.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated,

are evaluated at approximately three thousand two hundred Euros (EUR 3,200.-).

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le trente décembre.
Par devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

WFS Midco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 69, boulevard

de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 197062;

dûment représentée par Mademoiselle Fleur MARCHAL, juriste, demeurant professionnellement au 69, Boulevard de

la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Cette procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui à l’enregistrement.

La partie comparante est l’associé unique (ci-après l’ «Associé Unique») de la société WFS Holding I S.à r.l., une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, Boulevard de la Pétrusse,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197064 (la «Société»), constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 13 mai 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1816 en date du 22 juillet 2015 page 87146 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte

49290

L

U X E M B O U R G

reçu par le notaire instrumentant le 30 Septembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en
date du 7 décembre 2015 numéro 3279 page 157346.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire d’acter comme suit les résolutions suivantes

qu’elle prend en sa qualité d’Associé Unique de la Société:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de trois millions six cent quarante et

un mille six cent soixante et un Euros et quarante-deux centimes d’Euros (EUR 3.641.661,42) pour l’amener de son montant
actuel  de  quinze  millions  quatre  cent  soixante-dix  mille  sept  cent  trente-six  Euros  et  onze  centimes  d’Euro  (EUR
15.470.736,11)  représenté  par  un  milliard  cinq  cent  quarante-sept  millions  soixante-treize  mille  six  cent  onze
(1.547.073.611) parts sociales ayant une valeur nominale d’un centime d’Euro (EUR 0,01) chacune, au montant de dix-
neuf  millions  cent  douze  mille  trois  cent  quatre-vingt-dix-sept  Euros  et  cinquante-trois  centimes  d’Euro  (EUR
19.112.397,53) représenté par un milliard neuf cent onze millions deux cent trente-neuf mille sept cent cinquante-trois
(1.911.239.753) parts sociales, ayant une valeur nominale d’un centime d’Euro (EUR 0,01) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’Associé  Unique  décide  d’émettre  trois  cent  soixante-quatre  millions  cent  soixante-six  mille  cent  quarante-deux

(364.166.142) parts sociales ayant une valeur nominale d’un centime d’Euro (EUR 0,01) chacune.

<i>Souscription et paiement

Apparaît maintenant Mademoiselle Fleur MARCHAL, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire dûment nommé

par l’Associé Unique, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Le comparant prénommé, déclare souscrire au nom et pour le compte de l’Associé Unique, à trois cent soixante-quatre

millions cent soixante-six mille cent quarante-deux (364.166.142) parts sociales nouvelles, émises dans le capital de la
Société en contrepartie d’un apport en nature, consistant en deux créances, détenues par l’Associé Unique envers la Société
d’un montant total de trois millions six cent quarante et un mille six cent soixante et un Euros et quarante-deux centimes
d’Euros (EUR 3.641.661,42) (la «Contribution»).

Il résulte d’un rapport d’évaluation (le «Rapport») émis par l’organe de gestion de la Société du 23 décembre 2015, que

la valeur de l’Apport est au moins égal à trois millions six cent quarante et un mille six cent soixante et un Euros et quarante-
deux centimes d’Euros (EUR 3.641.661,42).

Le Rapport, après avoir été signé «ne varietur» par la partie comparante et par le notaire soussigné, restera annexé au

présent acte.

Ayant reconnu les Apports décrites ci-dessus, l’Associé Unique, représenté comme ci-avant, donne expressément son

accord sur la description de l’Apport, son évaluation et confirme la validité de la souscription et du paiement des parts
sociales émises.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société et en conséquence de le remplacer par le texte

qui suit:

« Art. 5. Le capital social souscrit est fixé dix-neuf millions cent douze mille trois cent quatre-vingt-dix-sept Euros et

cinquante-trois centimes d’Euro (EUR 19.112.397,53) représenté par un milliard neuf cent onze millions deux cent trente-
neuf mille sept cent cinquante-trois (1.911.239.753) parts sociales d'une valeur nominale d’un centime d’Euro (EUR 0,01)
chacune.»

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide d’autoriser tout gérant de la Société d’effectuer toutes les formalités nécessaires en relation

avec les présentes résolutions, nommément la création et/ou la modification du registre des Associés détenteurs des parts
sociales émises représentant le capital social de la Société.

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit incombant à la Société en raison du présent acte,

sont estimés approximativement à trois mille deux cents euros (EUR 3.200.-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et lecture faite à la mandataire de la partie comparante, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. MARCHAL, C. WERSANDT.

49291

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 4 janvier 2016. 2LAC/2016/68. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Référence de publication: 2016056422/145.
(160015491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Somuchmore Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.175,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.356.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of December,
before us, Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Somuchmore Global S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 194134 (hereinafter “Somuchmore Global”),

being the holder of eleven thousand one hundred eighteen (11,189) common shares, and becoming the holder of four

thousand eight hundred eighty nine (4,889) common shares,

here represented by Mr. Bastien Burin, Avocat, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal; and
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability business enterprise (Unternehmergesellschaft (haf-

tungsbeschränkt)) incorporated and existing under the laws of Germany, registered with the commercial register (Han-
delsregister) at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 126893 B, having
its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter “Bambino 53. V V”),

being the holder of three thousand ninety seven (3,097) common shares,
here represented by Mr. Bastien Burin, Avocat, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The parties 1. to 2. (the “Shareholders”) are all the current shareholders of Somuchmore Holding S.à r.l. (hereinafter

the “Company”), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 194356,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 7 January 2015, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n° 730 on 17 March 2015.

The articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 23 April

2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1712 on 10 July 2015.

The Shareholders represent the entire share capital and have waived any notice requirement, the general meeting of

shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. Increase of the Company’s share capital by an amount of four thousand eight hundred eighty nine euros (EUR 4,889.-)

so as to raise it from its current amount of fourteen thousand two hundred eighty six euros (EUR 14,286.-) to nineteen
thousand  one  hundred  seventy  five  euros  (EUR  19,175.-)  by  issuing  four  thousand  eight  hundred  eighty  nine  (4,889)
common shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

2. Subsequent amendment of article five point one 5.1 of the articles of association of the Company, so that it shall

henceforth read as follows:

“ 5.1. The Company's share capital is set at nineteen thousand one hundred seventy five Euros (EUR 19,175.-), repre-

sented by nineteen thousand one hundred seventy five (19,175) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a
nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.”

3. Subsequently, decision to grant power to any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mrs.

Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the share-
holders’ register of the Company.

49292

L

U X E M B O U R G

4. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following

resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the Company’s share capital by an amount of four thousand

eight hundred eighty nine euros (EUR 4,889.-) so as to raise it from its current amount of fourteen thousand two hundred
eighty six euros (EUR 14,286.-) to nineteen thousand one hundred seventy five euros (EUR 19,175.-) by issuing four
thousand eight hundred eighty nine (4,889) common shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

<i>Subscription

The issued four thousand eight hundred eighty nine (4,889) common shares have been duly subscribed by Somuchmore

Global, aforementioned, for the price of four thousand eight hundred eighty nine euros (EUR 4,889.-).

<i>Payment

The four thousand eight hundred eighty nine (4,889) common shares subscribed by Somuchmore Global, aforementio-

ned, have been entirely paid up through a contribution in kind in the aggregate amount of four thousand eight hundred
eighty  nine  euros  (EUR  4,889.-)  consisting  in  a  receivable  held  by  Somuchmore  Global,  aforementioned,  against  the
Company, which is valued at least at four thousand eight hundred eighty nine euros (EUR 4,889.-).

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of four thousand eight hundred eighty nine euros (EUR 4,889.-) shall be allocated

to the share capital of the Company.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article five point one 5.1 of the articles of association of the

Company, so that it shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The Company's share capital is set at nineteen thousand one hundred seventy five Euros (EUR 19,175.-), repre-

sented by nineteen thousand one hundred seventy five (19,175) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a
nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.”

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders hereby grants power to any manager of the Company, regardless of his category,

as well as to Mrs. Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign
solely, the shareholders’ register of the Company.

<i>Costs and Expenses

The  expenses,  costs,  remunerations  or  charges  in  any  form  whatsoever  which  shall  be  borne  by  the  Company  are

estimated at approximately EUR 1,500.-

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the German texts, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunundzwanzigsten Dezember,
vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notarin, ansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Sind erschienen:

1. Somuchmore Global S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), eingetragen

im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 194.134, mit eingetragener Adresse 5, Heien-
haff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, (“Somuchmore Global”),

Inhaberin von elftausendeinhundertneunundachtzig (11.189) Stammanteilen und zukünftige Inhaberin von viertausen-

dachthundertneunundachtzig (4.889) Stammanteilen,

hier vertreten durch Herrn Bastien Burin, Avocat, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen

Vollmacht; und

49293

L

U X E M B O U R G

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft mit beschränkter Haftung, die gemäß den

Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde und weiterhin besteht, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 126893 B mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Deutschland (der “Treuhänder”),

Inhaberin von dreitausendsiebenundneunzig (3.097) Stammanteilen,
hier vertreten durch Herrn Bastien Burin, Avocat, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen

Vollmacht.

Besagte Vollmachten wurden durch den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien sowie durch den Notar ne varietur

paraphiert. Sie verbleiben im Anhang der vorliegenden Urkunde und werden gemeinsam bei der zuständigen Stelle ein-
gereicht.

Die Parteien 1. und 2. (die “Gesellschafter”) sind die derzeitigen Gesellschafter der Somuchmore Holding S.à r.l (nach-

folgend die “Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 5,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg unter der Nummer B 194356 gegründet gemäß einer Urkunde der unterzeichneten Notarin vom 7. Januar 2015,
welche im im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2133, am 17. März 2015 veröffentlicht wurde.

Die Satzung wurde zuletzt geändert am 23. April 2015 gemäß einer Urkunde der unterzeichneten Notarin, welche im

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1712, am 10. Juli 2015 veröffentlicht wurde.

Die  Gesellschafter  vertreten  das  gesamte  Stammkapital  und  haben  auf  das  Erfordernis  der  vorherigen  Einberufung

verzichtet. Die Generalversammlung ist ordnungsgemäß zusammengekommen und im Hinblick auf die folgende Tages-
ordnung beschlussfähig:

<i>Tagesordnung

1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft in Höhe von aktuell vierzehntausendzweihundertsechsundachtzig Euro

(EUR 14.286,-) um einen Betrag von viertausendachthundertneunundachtzig Euro (EUR 4.889,-) auf insgesamt neun-
zehntausendeinhundertfünfundsiebzig Euro EUR (19.175,-) durch Ausgabe von viertausendachthundertneunundachtzig
(4.889) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

2. Anschließende Änderung des Artikels fünf Punkt eins (5.1) der Satzung der Gesellschaft, sodass dieser nun wie folgt

lauten soll:

“ 5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist auf neunzehntausendeinhundertfünfundsiebzig Euro (EUR 19.175) fest-

gesetzt, repräsentiert durch neunzehntausendeinhundertfünfundsiebzig (19.175) Stammanteile.

Die an die Anteile gebundenen Rechte und Pflichten sind identisch, soweit durch diese Satzung oder das Gesetz von

1915 nichts Gegenteiliges bestimmt ist.”

3. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie

Magdalena Staniczek zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit un-
eingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und zu unterzeichnen.

4. Verschiedenes.
Nachdem jeder Punkt der Tagesordnung ordnungsgemäß geprüft wurde, fasst die Generalversammlung einstimmig die

folgenden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von aktuell vierzehntausendzweihun-

dertsechsund  achtzig  Euro  (EUR  14.286,-)  um  einen  Betrag  von  viertausendachthundertneunundachtzig  Euro  (EUR
4.889,-) auf insgesamt neunzehntausendeinhundertfünfundsiebzig Euro EUR (19.175,-) durch Ausgabe von viertausen-
dachthundertneunund achtzig (4.889) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Die viertausendachthundertneunundachtzig (4.889) ausgegebenen Stammanteile wurden ordnungsgemäß von Somuch-

more  Global  zu  dem  oben  genannten  Preis  in  Höhe  von  viertausendachthundertneunundachtzig  Euro  (EUR  4.889,-)
gezeichnet.

<i>Zahlung

Die oben genannten viertausendachthundertneunundachtzig (4.889) durch Somuchmore Global gezeichneten Stamm-

anteile, wurden vollständig durch Leistung einer Sacheinlage in Höhe von viertausendachthundertneunundachtzig Euro
(EUR 4.889,-) eingezahlt. Die Sacheinlage besteht aus einer offenen Forderung der Somuchmore Global gegen die Ge-
sellschaft,  die  auf  einen  Betrag  in  Höhe  von  mindestens  viertausendachthundertneunundachtzig  Euro  (EUR  4.889,-)
geschätzt wird.

Der Nachweis über das Bestehen und den Wert der oben genannten Sacheinlage wurde gegenüber der unterzeichneten

Notarin erbracht.

49294

L

U X E M B O U R G

Der Gesamtbetrag der Sacheinlage in Höhe von viertausendachthundertneunundachtzig Euro (EUR 4.889,-) wird dem

Stammkapital der Gesellschaft zugewiesen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel fünf Punkt eins (5.1) der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

“ 5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist auf neunzehntausendeinhundertfünfundsiebzig Euro (EUR 19.175) fest-

gesetzt, repräsentiert durch neunzehntausendeinhundertfünfundsiebzig (19.175) Stammanteile.

Die an die Anteile gebundenen Rechte und Pflichten sind identisch, soweit durch diese Satzung oder das Gesetz von

1915 nichts Gegenteiliges bestimmt ist.”

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie,

sowie Magdalena Staniczek, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneingeschränkter
Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.

<i>Kosten und Ausgaben

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen oder Gebühren gleich welcher Art, welche durch die Gesellschaft getragen werden,

werden auf ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.

Die vorliegende Urkunde wurde in Luxemburg, am oben angegebenen Tag ausgefertigt.
Die unterzeichnete Notarin ist der englischen Sprache in Wort und Schrift mächtig und erklärt hiermit, dass auf Anfrage

der anwesenden Parteien die vorliegende Urkunde auf Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung verfasst wurde.
Auf Anfrage der anwesenden Parteien gilt im Fall einer Abweichung gegenüber der deutschen Fassung die englische
Fassung dieser Urkunde.

Nachdem diese Urkunde dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notarin mit Namen und Wohnort

bekannt ist, vorgelesen wurde, unterzeichnet der Bevollmächtigte gemeinsam mit der Notarin die vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: B. BURIN, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 31 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/4254. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 18. Januar 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016053882/185.
(160012305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Horn &amp; Co. Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 159.610.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor Uns Roger ARRENSDORFF, Notar im Amtssitze zu Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft deutschen Rechts Horn &amp; Metzger Verwaltungs-GmbH, mit dem Gesellschaftssitz in D-57076 Siegen,

12, Herrenfeldstrasse, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen unter der Nummer HRB 3851,

hier rechtsgültig vertreten durch Brigitte CZOSKE, Rechtsanwältin, geschäftsansässig zu 20, avenue Marie-Thérèse,

L-2014 Luxembourg,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 21. Dezember 2015,
welche Vollmacht nach gehöriger «ne varietur» Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden,

handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Anteilinhaberin der Gesellschaft Horn &amp; Co. Luxembourg SARL, mit Sitz

zu L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen vor Notar Roger ARRENS-
DORFF aus Bad-Mondorf am 4. März 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
Nummer 1197 vom 3, Juni 2011, welche Statuten seither nicht abgeändert wurden, eingetragen im Handelsregister unter
der Nummer B159.610.

Sodann hat die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den Notar ersucht um ihre Erklärungen und Feststellungen wie

folgt zu beurkunden:

1) Dass die Gesellschaft "Horn &amp; Co. Luxembourg SARL" gegründet wurde wie hiervor erwähnt.

49295

L

U X E M B O U R G

2) Dass das Gesellschaftskapital vorgenannter Gesellschaft ZWANZIG TAUSEND EURO (20.000.-EUR) beträgt und

in ZWEI HUNDERT (200) Anteile von je EIN HUNDERT EURO (100.-EUR) eingeteilt ist.

3) Dass die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, alleinige Eigentümerin der genannten Gesellschaft ist, welche das

gesamte  Gesellschaftskapital  von  ZWANZIG  TAUSEND  EURO  (20.000.-EUR)  darstellen  und  dementsprechend  den
ausdrücklichen Wunsch äussert die Gesellschaft aufzulösen und sich bereit erklärt alle Aktiva und Passiva der Gesellschaft
zu übernehmen und für allfällige Schulden aufzukommen und dass somit dieselbe vollständig liquidiert ist.

4) Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, ernennt sich zum Liquidator der Gesellschaft.
5) Sodann erteilt die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den Geschäftsführern der aufgelösten Gesellschaft Ent-

lastung.

6) Die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft werden für die Dauer von fünf (5) Jahren am Gesellschaftssitz der

aufgelösten Gesellschaft hinterlegt.

Worüber Urkunde, Errichtet wurde zu Luxemburg.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparentin, hat derselbe mit dem Notar gegenwär-

tige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet.: CZOSKE, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41680. Reçu soixante-quinze

euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Référence de publication: 2016054351/45.
(160014360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2016.

Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 65, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 112.519.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016055002/9.
(160014056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.

Lincoln Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 88.469.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016074191/9.
(160038470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.

Troichem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 75.825.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

TROICHEM S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2016073155/13.

(160036731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

49296


Document Outline

2B-Natural S.à.r.l.

4i S.A.

8 Grussgaass S.à r.l.

Access Capital Fund II SICAV-SIF

Affrètements, Distributions, Services, Logistic S.A.

Agir Luxembourg S.A.

Albemarle Management S.àr.l.

Alifa S.A.

Alpha Trains Luxembourg S.à r.l.

Apsys Poznan Lux

Avery Dennison Investments Luxembourg

BBFD Investment S.à r.l.

Buddha Bar S.à r.l.

Carmudi Holding S.à.r.l.

Centrum NS Luxembourg Sàrl

Efiparind B.V. &amp; Cie S.C.P.A.

Europa Ruby S.à r.l.

Freo Asset Management Invest Holding S.à r.l.

Horn &amp; Co. Luxembourg Sàrl

Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l.

Lincoln Invest S.A.

RoMei S.A.

Russian Acquisition Company N°1 S.à r.l.

Seventh Century Partners S.à r.l.

Sialina Investment S.A.

Sioux S.A.

Somuchmore Holding S.à r.l.

SSCP Titan S.à r.l.

Sungem Serfinco S.à r.l.

TES Global Investments S.à r.l.

Tili S.à r.l.

Troichem S.A.

Vaulux International SPF S.A.

Weinberg Real Estate S.à r.l.

WFS Holding I S.à r.l.

Xtreme Equipment Group

Zaphira S.A.