logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 749

12 mars 2016

SOMMAIRE

Avalon Holding S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35949

Avia Partners S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35949

Aya S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35950

BCSS SSD Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

35944

Bhoutan 4 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35944

Bienne SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35945

Bikecourier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35950

BioPharma Credit Investments IV, S.à r.l.  . . .

35952

Bluegems Investments S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

35943

Borasco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35943

Brennholz vum Wolef S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

35917

Brook Green S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35943

Cavaliere Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

35952

Cervia SCSp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35942

Cira Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35945

Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35945

Construction Royale S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35946

Covidien International Finance S.A.  . . . . . . . .

35946

Darden Global Finance 3 S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

35946

Dentsply CE S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35947

Docarpa Corporation N.V.  . . . . . . . . . . . . . . . .

35939

D.P. Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35946

East Capital (Lux) General Partner S.à r.l.  . .

35940

Ecurie Paradis Luxembourg SA  . . . . . . . . . . .

35936

Engenia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35925

Expansion 17 S.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . .

35934

Expansion 17 S.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . .

35935

Finnery Acquisitions IV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

35939

Fisterra Energy Luxembourg II S.à r.l.  . . . . .

35939

Global Performance 17 S.A., SICAR . . . . . . . .

35937

Global Performance 17 S.A., SICAR . . . . . . . .

35942

Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l.  . . .

35947

Intesa Sanpaolo Holding International S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35925

Italinvest Real Estate S.A. SICAV-SIF  . . . . . .

35906

K.D.T.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35950

Misys Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35928

Senvion S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35916

Sigma Lux, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35919

Speed'Immat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35951

Turaz Global TRM S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

35931

35905

L

U X E M B O U R G

Italinvest Real Estate S.A. SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 204.371.

STATUTES

In the year two thousand sixteen, on the twenty-fourth day of February.

Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Banque Degroof Luxembourg S.A., a public company limited by shares (société anonyme) incorporated under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand
Duchy  of  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  trade  and  companies  register  (Registre  du  Commerce  et  des
Sociétés deLuxembourg), under number B 25.459,

here represented by Pierre Buisseret, Employee, whose professional address is 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lu-

xembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on 22 February 2016.

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the power

of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles

of incorporation of a public company limited by shares (société anonyme), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “ITALINVEST REAL ESTATE S.A. SICAV-SIF” (the Fund). The Fund is

a public company limited by shares (société anonyme) qualifying as an investment company with variable share capital -
specialized investment fund ("société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé") governed by
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915, on commercial companies, as
amended (the 1915 Law), the law of February 13, 2007 on specialised investment funds, as amended (the 2007 Law), and
these articles of incorporation (the Articles). Capitalised terms used but not defined in this Articles shall have the same
meaning as in the private placement memorandum of the Fund as amended and updated from time to time (the Private
Placement Memorandum).

Art. 2. Registered office.

2.1 The Fund’s registered office is established in Luxembourg-city, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of directors (the Board of Directors). It may be transferred to any other
location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the General Meeting),
acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board of Directors. If the Board of Directors determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Fund at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Fund, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.

3.1 The purpose of the Fund is to invest the funds available to it in any kind of assets eligible under the 2007 Law with

the aim of spreading investment risks and affording its shareholders (the Shareholders) the results of the management of
its assets.

3.2 The Fund may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the accomplishment

and development of its purpose to the fullest extent permitted under the 2007 Law.

Art. 4. Duration.

4.1 The Fund is established for an unlimited duration and shall end with the dissolution and liquidation of its last Sub-

Fund (as defined below).

4.2 The Fund shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or more Shareholders.

35906

L

U X E M B O U R G

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1 The share capital of the Fund shall be represented by shares of no nominal value and shall at any time be equal to

the total net assets of the Fund and its Sub-Funds (as defined below), if any. The initial capital is set at thirty-one thousand
euro (EUR 31,000.-), represented by thirty-one (31) shares of no nominal value.

5.2 The minimum capital of the Fund shall be one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000), which

must be reached within twelve (12) months after the date on which the Fund has been authorised in accordance with the
2007 Law.

Art. 6. Sub-Funds.
6.1 The Fund is composed of one or more sub-funds (the Sub-Funds), in accordance with article 71 of the 2007 Law,

each of them constituting a distinct pool of assets, managed in the benefit of the Shareholders of the relevant Sub-Fund. A
first Sub-Fund will be launched by decision of the Board of Directors. The name of each Sub-Fund shall comprise the first
part of the name of the Fund, followed by the denomination determined at the discretion of the Board of Directors.

6.2 The Board of Directors may, at any time, establish additional Sub-Fund(s) and determine the name and specific

features thereof (including, but not limited to investment objectives, policy, strategy and/or restrictions, specific fee struc-
ture, reference currency) as further set out in the Private Placement Memorandum and which shall be fully described in the
relevant Part II of the Private Placement Memorandum (the Sub-Fund Specifications), which forms an integral part of the
Private Placement Memorandum for purposes of the relevant Sub-Fund.

6.3 The Fund is one single legal entity. However, by way of derogation to article 2093 of the Luxembourg Civil Code

and in accordance with the provisions of article 71 of the 2007 Law, the assets of any given Sub-Fund are only available
for the satisfaction of the debts, obligations and liabilities, which are attributable to such Sub-Fund. Amongst Shareholders,
each Sub-Fund is treated as a separate entity.

Art. 7. Shares.
7.1 The shares (the Shares) are indivisible and the Fund recognises only one (1) owner per Share.
7.2 The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
7.3 A register of Shares shall be kept at the registered office of the Fund or at the office of the registrar and transfer

agent and may be examined by any Shareholder on request.

7.4 The Board of Directors may, at any time, issue different classes of Shares (each a Class or Classes as appropriate)

in respect of each Sub-Fund, which may carry different rights and obligations inter alia with regard to eligible investors,
income and profit entitlements, redemption features, reporting obligations and/or fee and cost features as described in the
relevant Sub-Fund Specifications.

7.5 The Shares may only be subscribed for by investors who comply with the status of Qualifying Investor. The com-

pliance of each subscriber with the status of Well-Informed Investor will be verified by the Board of Directors or any agent
to which such function has been delegated by the Board of Directors. This restriction is not applicable to the Board of
Directors and other persons involved in the management of the Fund.

7.6 Investors wishing to subscribe for Shares in a Sub-Fund shall execute a subscription agreement (the Subscription

Agreement), which upon acceptance will be signed by the Board of Directors. Investors thus commit themselves to sub-
scribing and accepting Shares in accordance with the Articles as well as the terms and conditions set forth in the Private
Placement Memorandum.

7.7 The issue price of Shares is determined by the Board of Directors on a Class by Class basis as fully described in the

relevant Sub-Fund Specifications.

Art. 8. Transfer of Shares.
8.1 Shares are only transferable between Qualifying Investors each time and may be subject to such other transfer

conditions as set forth in the relevant Sub-Fund Specifications.

8.2 A share transfer shall be carried out by the entry in the register of shares of a declaration of transfer, duly signed and

dated by either:

(a) both the transferor and the transferee or their authorised representatives; or
(b) any authorised representative of the Fund,
following a notification to, or acceptance by, the Fund, in accordance with Article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
8.3 Any document recording the agreement between the transferor and the transferee, which is validly signed by both

parties, may be accepted by the Fund as evidence of a share transfer, subject to the concomitant transfer of any undrawn
subscription commitment, if applicable.

Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 Unless otherwise provided for in the relevant Sub-Fund Specifications, a redemption of Shares is only possible at

the discretion of the Board of Directors in accordance with the relevant Sub-Fund Specifications and these Articles. In-
vestors are not entitled to request any redemption of their Shares.

35907

L

U X E M B O U R G

9.2 The Fund may, upon serving a repurchase notice to any Shareholder, repurchase the Shares of any Investor and such

Investor shall be obliged to sell its Shares to the Fund at a price determined in accordance with the relevant Sub-Fund
Specifications. The Fund shall furthermore cause the transfer or the redemption of the Shares of any Shareholder if the
Shareholder ceases to qualify as a Qualifying Investor.

9.3 No distribution for redemption of Shares may be made as a result of which the capital of the Fund would fall below

the minimum capital amount required by the 2007 Law.

9.4 A redemption of Shares shall be subject to such further terms and conditions, including but not limited to any

redemption charges, as set forth in the relevant Sub-Fund Specifications.

9.5 Any Shares repurchased by the Fund cannot be reissued and shall be cancelled.

Art. 10. Conversion of Shares. The conversion of Shares in a given Sub-Fund into Shares of another Sub-Fund or the

conversion of Shares of one Class into another Class within the same Sub-Fund or of another Sub-Fund may be authorised
by the Board of Directors on a Sub-Fund by Sub-Fund basis as well as on a Class by Class basis as set forth in the relevant
Sub-Fund Specifications.

III. Net asset value

Art. 11. Calculation of the Net Asset Value. The reference currency of the Fund is the Euro. Each Sub-Fund (and each

Class) may have a different reference currency. The NAV of each Sub-Fund’s Shares is expressed in the reference currency
of the relevant Sub-Fund and within each Sub-Fund the NAV of each Class, if applicable, is expressed in the reference
currency of the relevant Class, as further described in the relevant Sub-Fund Specifications. The NAV is calculated by the
Administrative Agent under the responsibility of the Board of Directors.

The NAV per Share is calculated on a Class by Class basis (if applicable) on such frequency as set forth in the relevant

Sub-Fund Specifications.

For the purpose of determining the NAV of the Fund, the net assets attributable to each Class within each Sub-Fund

shall, if not denominated in Euro, be converted into Euro and the NAV of the Fund shall be the aggregate of the net assets
of all the Sub-Funds. All accounting gains, losses, income or expenditure as well as movements in cash relating to the use
of foreign exchange hedging for a specific Class within a given Sub-Fund shall be attributed entirely to the specific Class
within the Sub-Fund on behalf of which the hedging was entered into and will not be attributed to any other Class.

The Fund reserves the right to suspend the determination of the NAV of a Sub-Fund under the circumstances set forth

under Art.12 “Suspension of the Calculation of the NAV” below.

As between Shareholders, each Sub-Fund is treated as a separate entity, generating (without restriction) its own contri-

butions, capital gains and capital losses, fees and expenses. The Fund constitutes a single legal entity. However with regard
to third parties, in particular towards the Fund’s creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities
attributable to it.

All assets and liabilities of the Fund shall be valued at fair value in compliance with the accounting principles applicable

to the Fund. The Board of Directors, in its discretion and in good faith, may permit some other method of valuation to be
used, if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Fund.

If since the time of determination of the NAV there has been a material change in the quotations in the markets on which

a substantial portion of the investments of the Fund are dealt in or quoted, the Board of Directors may, in order to safeguard
the interests of the Shareholders and the Fund, cancel the first valuation and carry out a second valuation.

In the absence of bad faith, negligence or manifest error, every decision in calculating the NAV taken by the Board of

Directors or by the Administrative Agent, shall be final and binding on the Fund and present, past or future Shareholders.

I. The assets of the Fund shall include:
1. all cash in hand, receivable or on deposit, including any interest accrued thereon;
2. all bills and notes payable on demand and any account due (including the proceeds of securities sold but not delivered);
3. all securities, shares, bonds, time notes, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants and other securities,

money market instruments and similar assets owned or contracted for by the Fund (including shares, units or other parti-
cipation rights in collective investment vehicles or managed accounts);

4. all interest accrued on any interest-bearing assets, except to the extent that the same is included or reflected in the

principal amount of such assets;

5. all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Fund to the extent information thereon is

reasonably available to the Fund;

6. all properties or property rights registered directly or indirectly in the name of or on behalf of the Fund;
7. the preliminary expenses of the Fund, including the cost of issuing and distributing Shares of the Fund, insofar as the

same have not been written off and insofar the Fund shall be reimbursed for the same;

8. the liquidating value of all forward contracts and all call or put options in which the Fund has an open position; and
9. all other assets of any kind and nature, including expenses paid in advance.
II. The value of such assets shall be determined at fair value with due regard to the following principles:

35908

L

U X E M B O U R G

1. the value of any cash on hand or deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash

dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof, unless
in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after making
such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true thereof;

2. securities listed and traded primarily on 1 (one) or more recognised securities exchanges shall be valued at their last

known prices on the Valuation Day;

3. investment in underlying undertakings for collective investment are taken at their last official NAV known in Lu-

xembourg at the time of calculating the NAV of the relevant Sub-Fund. If such price is not representative of the fair value
of such assets, then the price shall be determined by the Board of Directors on a fair value basis. Investments subject to
bid and offer prices are valued at their mid-price, if not otherwise determined by the Board of Directors;

4. unlisted securities for which over-the-counter market quotations are readily available (included listed securities for

which the primary market is believed to be the over-the-counter-market) shall be valued at a price equal to the last reported
price as supplied by recognised quotation services or broker-dealers;

5. properties or property rights registered in the name of the Fund or any of its subsidiaries, joint-ventures or affiliates

as well as direct or indirect shareholdings of the Fund or any of its subsidiaries, joint-ventures or affiliates in intermediary
companies shall be valued by one or more independent valuers, provided that the Fund may deviate from such valuation
if deemed in the interest of the Fund and its Shareholder and provided further that such valuation may be established at the
end of the financial year (such properties will be held at cost until the financial year-end valuation) and used throughout
the following financial year unless there is a change in the general economic situation or in the condition of the relevant
properties or property rights held by the Fund or by any of its subsidiaries, joint ventures or affiliates or by any controlled
property companies which requires new valuations to be carried out under the same conditions as the annual valuations;
and

6.  all  other  non-publicly  traded  securities,  other  securities  or  instruments  or  investments  for  which  reliable  market

quotations are not available, and securities, instruments or investments which the Fund determines in its discretion that the
foregoing valuation methods do not fairly represent the fair value of such securities, instruments or investments, will be
valued by the Fund either at their cost basis to the Sub-Fund or in good faith using methods it considers appropriate.

Assets expressed in a currency other than the reference currency of the Sub-Fund concerned respectively in Euro shall

be converted on the basis of the rate of exchange ruling on the relevant Valuation Day. If such rate of exchange is not
available, the rate of exchange will be determined in good faith by or under procedures established by the Board of Directors.

III. The liabilities of the Fund shall include:
1. all loans, bills and accounts payable;
2. all accrued interest on loans (including accrued fees for commitment for such loans);
3. all accrued or payable expenses (including administrative expenses, advisory and management fees, including in-

centive fees, depositary fees, and corporate agents’ fees);

4. all known liabilities, present or future, including all matured contractual obligations for payment of money, including

the amount of any unpaid distributions declared by the Fund;

5. an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the calculation day, as determined from time

to time by the Fund, and other reserves (if any) authorised and approved by the Board of Directors, as well as such amount
(if any) as the Board of Directors may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of
the Fund;

6. all other liabilities of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted accounting prin-

ciples; and

7. the costs and disbursements of any committees incurred in relation to the furtherance of the business of the Fund (if

applicable) and shareholder meetings.

In determining the amount of such liabilities the Board of Directors shall take into account all expenses payable by the

Fund which shall include formation expenses, fees, expenses, disbursements and out-of-pocket expenses payable to its
accountants, lawyers, depositary and its correspondents, investment manager as well as any other agent employed by the
Fund, the remuneration of the directors and their reasonable out-of-pocket expenses, insurance coverage and reasonable
travelling costs in connection with the Board of Directors meetings and investment committee meetings, fees and expenses
for legal and auditing services, any fees and expenses involved in registering and maintaining the registration of the Fund
with any governmental agencies or stock exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other country, licensing
fees for the use of the various indexes, reporting and publishing expenses, including the cost of preparing, translating,
printing, advertising and distributing the Private Placement Memorandum, further explanatory sales documents, periodical
reports or registration statements, the costs of publishing the NAV and any information relating to the estimated value of
the Fund, the cost of printing certificates, if any, and the costs of any reports to Shareholders, the cost of convening and
holding committee meetings, all taxes, duties, governmental and similar charges, and all other operating expenses, including
the cost of buying and selling assets, transaction fees, the cost of publishing the issue and redemption prices, interests, bank
charges and brokerage, postage, insurance, telephone and telex. The Fund may accrue administrative and other expenses

35909

L

U X E M B O U R G

of a regular or recurring nature based on an estimated amount for yearly or other periods. Such liabilities will be allocated
among the Sub-Funds on a pro rata basis in proportion to their respective net assests.

IV. The assets and liabilities of different Sub-Funds or different Classes within the same Sub-Fund shall be allocated

as follows:

1. the proceeds to be received from the issue of Shares of a Sub-Fund and Class, if applicable shall be applied in the

books of the Fund to the relevant Sub-Fund and Class, if applicable;

2. where an asset is derived from another asset, such derived asset shall be applied in the books of the Fund to the same

Sub-Fund and Class, if applicable as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase
or diminution in value shall be applied to the relevant Sub-Fund and Class, if applicable;

3. where the Fund incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund and Class, if applicable or to any

action taken in connection with an asset of a particular Sub-Fund and Class, if applicable, such liability shall be allocated
to the relevant Sub-Fund and Class, if applicable;

4. upon the record date for determination of the person entitled to any dividend declared on Shares of any Sub-Fund and

Class, if applicable, the assets of such Sub-Fund and Class, if applicable shall be reduced by the amount of such dividends;
and

5. in the case where any asset or liability of the Fund cannot be considered as being attributable to a particular Sub-Fund

and Class, if applicable, such asset or liability shall be allocated to all the Sub-Funds and Classes, pro rata to the NAV of
the relevant Sub-Fund and Class, if applicable or in such other manner as determined by the Board of Directors acting in
good faith.

V. For the purposes of the Net Asset Value computation:
1. Shares to be redeemed in accordance with the terms of the Private Placement Memorandum shall be treated as existing

and taken into account until immediately after the time specified by the Board of Directors on the relevant Valuation Day
and from such time and until paid by the Fund the price therefor shall be deemed to be a liability of the relevant Sub-Fund
and Class, if applicable;

2. Shares to be issued shall be treated as being in issue as from the time specified by the Board of Directors on the

Valuation Day, and from such time and until received by the relevant Sub-Fund and Class, if applicable, the price therefor
shall be deemed to be a debt due to the relevant Sub-Fund and Class, if applicable;

3. all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the currency in which the NAV for

the relevant Sub-Fund and Class, if applicable, is calculated shall be valued after taking into account the rate of exchange
prevailing on the principal regulated market of each such asset on the dealing day preceding the Valuation Day; and

4. where on any Valuation Day the Fund has contracted to:
a) purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the relevant

Sub-Fund and Class, if applicable and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the relevant Sub-
Fund and Class, if applicable;

b) sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the relevant

Sub-Fund and Class, if applicable and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Fund;

provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such valuation

time, then its value shall be estimated by the Board of Directors in good faith.

Art. 12. Suspension of the calculation of the net asset value. The Fund is authorised to temporarily suspend the calculation

of the NAV and the issue, conversion and redemption of Shares in any Sub-Fund in the following cases and in respect of
a specific Sub-Fund, as authorised in the relevant Sub-Fund Specifications.

(a) during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which any substantial portion of

the investments of the Fund attributable to such Sub-Fund from time to time is quoted or dealt on is closed otherwise than
for ordinary holidays, or during which dealings thereon are restricted or suspended, provided that such restriction or sus-
pension affects the valuation on the investments of the Fund attributable to a Sub-Fund; or

(b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Board of Directors

as a result of which disposals or valuation of assets owned by the Fund attributable to such Sub-Fund would be impracticable;
or

(c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any

of the investments of the Fund attributable to such Sub-Fund or the current price or values on any stock exchange or other
market in respect of the assets attributable to such Sub-Fund; or

(d) when for any other reason the prices of any investments owned by the Fund attributable to any Sub-Fund cannot

promptly or accurately be ascertained; or

(e) during any period when the Fund is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption

of the Shares of such Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments
or payments due on redemption of Shares cannot in the opinion of the Board of Directors be effected at normal rates of
exchange.

35910

L

U X E M B O U R G

Shareholders holding Shares which are the subject of a suspension will be notified of any suspension of issue, redemption

or determination of NAV or of any reinstatement following a suspension thereof, in each case within ten (10) days of the
relevant event.

Where possible, all reasonable steps will be taken to bring any period of suspension to an end as soon as possible.
The relevant Sub-Fund Specifications may provide that the calculation of the NAV of a Sub-Fund or a Class within that

Sub-Fund may also be suspended for other reasons.

IV. Management - Representation

Art. 13. Board of Directors.
13.1 Composition of the Board of Directors
(a) The Fund shall be managed by the Board of Directors, which shall comprise at least three (3) members. The directors

need not be Shareholders.

(b) The General Meeting shall appoint the directors, subject to the prior approval of the CSSF, and determine their

number, their remuneration and the term of their office. Directors cannot be appointed for a term of office of more than six
(6) years but are eligible for re-appointment at the expiry of their term of office.

(c) Directors may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting.
(d) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative to perform its duties. The

permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if he had exercised his functions in
his own name and on his own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it represents.

(e) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint another

permanent representative.

(f) If the office of a director becomes vacant, the other directors, acting by a simple majority, may fill the vacancy on a

provisional basis until a new director is appointed by the next General Meeting.

13.2 Powers of the Board of Directors
(a) All powers not expressly reserved to the shareholders by the 1915 Law, the 2007 Law or the Articles fall within the

competence of the Board of Directors, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Fund’s corporate object.

(b) The Board of Directors is responsible for all investment management of the assets of the Fund and each of its Sub-

Funds, for the day-to-day management of the affairs of the Fund as well as for the administration and marketing functions
related to the Fund and its Sub-Fund. The Board of Directors retains legal decision-making power and has the exclusive
authority with regard to any decisions not specifically delegated or attributed to another entity or service provider and
supervises the administrative agent, the registrar and transfer agent, the investment advisor and any other service providers
of the Fund in the performance of their duties.

(c) The Board of Directors may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
(d) The Board of Directors is authorised to delegate the day-to-day management, and the power to represent the Fund

in this respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either
individually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or more directors, the Board must report to the
annual General Meeting any salary, fee and/or any other advantage granted to those director(s) during the relevant financial
year.

13.3 Procedure
(a) The Board of Directors must appoint a chairperson from among its members, and may choose a secretary who need

not be a director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(b) The Board of Directors shall meet at the request of the chairperson or any two (2) directors, at the place indicated

in the notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(c) Written notice of any Board of Directors meeting shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in

advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.

(d) No notice is required if all members of the Board of Directors are present or represented and each of them states that

they have full knowledge of the agenda for the meeting. A director may also waive notice of a meeting, either before or
after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board of Directors.

(e) A director may grant to another director a power of attorney in order to be represented at any Board of Directors

meeting.

(f) The Board of Directors may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented.

Board Resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the directors present or represented. The chairman
shall have a casting vote in the event of a tied vote. Board of Directors resolutions shall be recorded in minutes signed by
the chairperson, by all the directors present or represented at the meeting, or by the secretary (if any).

35911

L

U X E M B O U R G

(g) Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by telephone or video conference, or by any

other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(h) Circular resolutions signed by all the directors shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held

Board of Directors meeting, and shall bear the date of the last signature.

(i) A director who has an interest in a transaction carried out other than in the ordinary course of business which conflicts

with the interests of the Fund must advise the Board accordingly and have the statement recorded in the minutes of the
meeting. The director concerned may not take part in the deliberations concerning that transaction. A special report on the
relevant transaction shall be submitted to the shareholders at the next General Meeting, before any vote on any other
resolution.

13.4 Representation
(a) The Fund shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) directors.
(b) The Fund shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom special

signatory powers have been delegated by the Board of Directors.

Art. 14. Liability of the Directors. The directors may not be held personally liable by reason of their office for any

commitment they have validly made in the Fund’s name, provided those commitments comply with the Articles, the 1915
Law and the 2007 Law.

Art. 15. Delegation of Powers.
15.1 The Board of Directors may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers

as well as any other officers that the Fund deems necessary for the operation and management of the Fund or any Sub-
Fund. Such appointments may be cancelled at any time by the Board of Directors. The officers need not be Shareholders
of the Fund. Unless otherwise provided for by these Articles, the officers shall have the rights and duties conferred upon
them by the Board of Directors. The Board of Directors may furthermore appoint other agents, who need not to be members
of the Board of Directors and who will have the powers determined by the Board of Directors.

15.2 The Board of Directors may, under its full responsibility, be assisted, while managing the Fund’s assets by one or

several investment managers and/or investment advisors or, delegate its powers in relation to the management of the Fund
or a specific Sub-Fund to one or several agents.

15.3 The Board of Directors may establish on a Sub-Fund per Sub-Fund basis an advisory committee and/or an investors’

committee, which shall have those powers as provided for in the relevant Sub-Fund Specifications.

15.4 The Board of Directors may be assisted by one or several committees in view of implementing appropriate risk

management systems, minimising the risk of Shareholders’ interests being prejudiced by conflicts of interests and esta-
blishing compliance management systems.

Art. 16. Investment Policies and Restrictions.
16.1 The Board of Directors, based upon the principle of risk diversification and in accordance with the Private Placement

Memorandum, has the power to determine the investment policies and strategies of each Sub-Fund and of the Fund and
the course of conduct of the management and business affairs of the Fund, within the restrictions as shall be set forth by
the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations.

16.2 The Fund may employ, for each Sub-Fund as set forth in the relevant Sub-Fund Specifications, techniques and

instruments relating to transferable securities, currencies or any other financial assets or instruments for the purpose of
hedging.

Art. 17. Conflicts of Interest. No contract or other transaction between the Fund and any other company or firm shall

be affected or invalidated by the fact that any one (1) or more of the members of the Board of Directors is interested in, or
is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any member of the Board of Directors who
serves as a manager, director, officer or employee of any company or firm, with which the Fund shall contract or otherwise
engage in business shall, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any member of the Board of Directors may have in any transaction of the Fund an interest different to

the interests of the Fund, such director shall make known to the Board of Directors such conflict of interest and shall not
consider or vote on any such transaction and such transaction, and such director’s interest therein shall be reported to the
next succeeding meeting of Shareholders.

The term conflict of interests, as used in the preceding paragraph, shall not include any relationship with or interest in

any matter, position or transaction involving the Initiator, an Investment Manager, an Investment Advisor, the Depositary,
legal counsel, the Administrative Agent, the Registrar and Transfer Agent and the Domiciliary Agent, the distributors or
any other person, company or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors on its discretion.

V. Shareholders

Art. 18. General Meetings of Shareholders.
18.1 Powers and voting rights

35912

L

U X E M B O U R G

(a) Resolutions of the Shareholders shall be adopted at a general meeting of Shareholders (each a General Meeting).

The General Meeting has full powers to adopt and ratify all acts and operations which are consistent with the Fund’s
corporate object.

(b) Each Share entitles the holder to one (1) vote.
18.2 Notices, quorum, majority and voting proceedings
(a) The Shareholders may be convened to General Meetings by the Board of Directors or the statutory auditor(s). The

Shareholders must be convened to a General Meeting following a request from Shareholders representing at least one-tenth
(1/10) of the share capital.

(b) Written notice of any General Meeting shall be given to all Shareholders at least eight (8) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.

(c) The convening notices for the General Meeting may set out that the quorum of the presence at the General Meeting

be determined according to the Shares issued and outstanding at midnight on the fifth (5 

th

 ) day prior to the relevant General

Meeting (the Record Date). The rights of a Shareholder to participate in a General Meeting and to exercise the voting right
attached to his Shares are determined according to the Shares held by this Shareholder at the Record Date.

(d) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(e) If all the Shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda

of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(f) A Shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to

be represented at any General Meeting.

(g) Any Shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at the meeting.

(h) Any Shareholder may vote by using the forms provided by the Fund for that purpose. Voting forms must contain

the date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form must
contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or an abstention. Shareholders must return the voting
forms to the Fund’s registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting shall be taken into account
in calculating the quorum for the meeting. Voting forms which indicate neither a voting intention nor an abstention shall
be considered void.

(i) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by a simple majority vote, regardless of the proportion

of share capital represented.

(j) An extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least one-half of the share capital is represented

and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment to the
Fund’s object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting shall be convened by means of notices
published twice in the Mémorial and two Luxembourg newspapers, at an interval of at least fifteen (15) days and fifteen
(15) days before the meeting. These notices shall state the date and agenda of the General Meeting and the results of the
previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of capital
represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes cast.

(k) Any change in the nationality of the Fund and any increase in a shareholder’s commitment in the Fund shall require

the unanimous consent of the Shareholders and bondholders (if any).

Art. 19. General Meetings of Sub-Fund(s).
19.1 The Board of Directors may at any time convene a general meeting of Shareholders of one or several specific Sub-

Fund(s) in order to decide on any matter, which relate exclusively to such Sub-Fund(s).

19.2 Legal provisions as well as provisions of these Articles relating to the general meetings of Shareholders of the Fund

shall apply to the extent possible mutatis mutandis to the general meetings of Shareholders of one or several specific Sub-
Fund(s).

Art. 20. Sole Shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(a) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the 1915 Law to the General Meeting;
(b) any reference in the Articles to the Shareholders or the General Meeting is to be read as a reference to the sole

shareholder, as appropriate; and

(c) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

VI. Supervision - Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 21. Auditor.
21.1 The accounting data related in the annual report of the Fund shall be examined by an auditor (réviseur d’entreprises

agréé) appointed by the Board of Directors and remunerated by the Fund (the Auditor).

21.2 The Auditor shall fulfil the duties prescribed by the 2007 Law.

35913

L

U X E M B O U R G

Art. 22. Reference Currency. The Fund shall prepare annual accounts in Euro. For the purpose of determining the capital

of the Fund, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if not denominated in Euro, be converted into Euro at the
rates used in the most recent net asset value calculation and the capital shall be the aggregate of the net assets of all the
Sub-Funds.

Art. 23. Financial Year and Approval of Annual Accounts.
23.1 The financial year of the Fund begins each year on 1 January and ends on 31 December of the same year, with the

exception of the first financial year.

23.2 The Fund shall provide the Sub-Fund’s Investor (within six (6) months after the end of fiscal year and in any event

before the annual general meeting of the Fund) with an audited annual report and a review of the performance of the assets
of the Sub-Fund over the year free of charge. The report shall contain at least a balance sheet, a statement of income, a
statement of changes in equity and a cash flow statement as well as explanatory notes and reviews of (i) the performance
of the Sub-Fund, (ii) the allocation of assets against the investment restrictions of the Sub-Fund, and (iii) the current
investment strategy.

23.3 The annual General Meeting shall be held at the registered office or in any other place within the municipality of

the registered office, as specified in the notice, on the last Thursday of June of each year at 11.00 a.m. If that day is not a
business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.

Art. 24. Allocation of Profits.
24.1 The General Meeting shall determine the allocation of the balance of the annual net profits proposed by the Board

of Directors in accordance with the allocations rules set out in the Private Placement Memorandum and in particular as set
forth in each of the Sub-Fund Specifications. It may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve
account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

24.2 The Board of Directors may in its discretion decide to pay interim dividends at any point in time unless otherwise

provided for in the Private Placement Memorandum and, in particular, as set forth in the relevant Sub-Fund Specifications.

24.3 Distributions shall be paid in Euro or in the base currency of a Sub-Fund and at such time and place that the Board

of Directors shall determine from time to time.

24.4 No distribution may be made which would result in the net asset value of the Fund to fall below the minimum

capital required by the 2007 Law, as set out in Art. 5.3 above.

VII. Dissolution - Liquidation

Art. 25. Term, Liquidation and Amalgamation of Sub-Funds.
25.1 The Sub-Funds may be created for any undetermined period or for a fixed period as provided for in the Private

Placement Memorandum and, specifically, in the relevant Sub-Fund Specifications. Any Sub-Fund created for a fixed
period will terminate automatically on the expiration date (if any) provided for in the relevant Sub-Fund Specifications,
except if a general meeting of Shareholders of the concerned Sub-Fund decide to pospone the termination date of such
Sub-Fund.

25.2 The Board of Directors may also decide to liquidate one Sub-Fund if the net assets of such Sub-Fund have decreased

to, or have not reached, an amount determined by the Board of Directors to be the minimum level for such Sub-Fund to be
operated in an economically efficient manner or if a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund
concerned would justify such liquidation. Shareholders of the relevant Sub-Fund will be notified by the Board of Directors
of any decision to liquidate the relevant Sub-Fund prior to the effective date of the liquidation and the notice will indicate
the reasons for, and the procedures applicable to the liquidation.

25.3 Unless otherwise provided for in the relevant Sub-Fund Specifications, the Shareholders of the Sub-Fund concerned

may request the redemption of their Shares, in accordance with the terms contained in the relevant Sub-Fund Specifications,
upon or prior to the liquidation by application of the applicable liquidation NAV as determined by the Board of Director.
Assets which cannot be distributed to their beneficiaries upon the close of liquidation of the Sub-Fund concerned will be
deposited with the Depositary for a period of 9 (nine) months after the opening of the liquidation. After such time, the
assets will be deposited with the Caisse des Consignations on behalf of their beneficiaries.

25.4 In the same circumstances as provided in 25.2 above, the Board of Directors may decide to terminate one Sub-

Fund and contribute its assets into another existing or new Sub-Fund or into another existing or new collective investment
scheme or an assimilated entity. The Board of Directors may organise the amalgamation of two or more Sub-Funds or two
or more Share Classes within a Sub-Fund if it believes that such a course of action is in the best interests of the Shareholders
of the relevant Sub-Funds. Shareholders will be notified of any such decision as well as the relevant information in relation
to the new Sub-Fund, the new collective investment scheme or assimilated entity or the new Class of Shares. Notice will
be provided at least one month before the amalgamation in order to enable Shareholders to request that their Shares be
redeemed before the amalgamation is completed.

25.5 Where assets are to be contributed to another collective investment vehicle, the amalgamation will be binding only

on Shareholders in the relevant Sub-Fund who expressly consent to such amalgamation.

25.6 Notwithstanding the foregoing, no amalgamation will take place during any period during which the calculation

of the net asset value and the issue, conversion or redemption of any Shares in any Class involved in the amalgamation has

35914

L

U X E M B O U R G

been suspended, except if the consent of all of the Shareholders holding Shares in each of the involved Sub-Funds has been
obtained.

25.7 As soon as the decision to liquidate or merge a Sub-Fund is taken, the issue of Shares in such Sub-Fund is prohibited

and shall be deemed void.

25.8 Each Sub-Fund may be separately dissolved without impacting any other Sub-Fund. The dissolution of the last

Sub-Fund causes ipso jure the liquidation of the Fund.

Art. 26. Dissolution and Liquidation of the Fund.
26.1 The Fund may at any time be dissolved by a resolution of the General Meeting resolving in the conditions prescribed

for the amendment of these Articles. The Fund shall also be dissolved upon dissolution of the last existing Sub-Fund.

26.2 Whenever the share capital falls below two third of the minimum capital indicated in Art. 5.2 above, the question

of the dissolution of the Fund shall be referred to the General Meeting by the Board of Directors. In such an event, the
General  Meeting  shall  be  held  without  any  quorum  requirements  and  the  dissolution  may  be  decided  by  the  votes  of
Shareholders holding 50% of the Shares represented at such General Meeting.

26.3 Whenever the share capital falls below one quarter of the minimum capital indicated in Art. 25.2 above, the question

of the dissolution of the Fund shall be referred to the General Meeting by the Board of Directors. In such an event, the
General  Meeting  shall  be  held  without  any  quorum  requirements  and  the  dissolution  may  be  decided  by  the  votes  of
Shareholders holding 25% of the Shares represented at such General Meeting.

26.4 Where the holding of a General Meeting is required in accordance with Art. 26.2 or 26.3 above, such General

Meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from the assessment that the net assets of the Fund
have fallen below two third or one quarter of the legal minimum, as the case may be.

26.5 In the event of dissolution of the Fund, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be

physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding on such dissolution and subject to the approval
of the CSSF. The operations of liquidation will be carried out pursuant to Luxembourg applicable laws.

Art. 27. Liquidation proceeds.
27.1 The net proceeds of liquidation corresponding to each Sub-Fund shall be distributed, including distributions in

kind, by the liquidator(s) to the Shareholders of the relevant Sub-Fund in accordance with the rules applicable to the
allocation of profits in such Sub-Fund as referred to under Art. 24 above.

27.2 Any liquidation proceeds that cannot be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the liquidation

will be deposited with the Luxembourg «Caisse de Consignation».

Art. 28. Consolidation and splitting of Shares.
28.1 The Board of Directors may decide to consolidate or split the Shares within a given Class of a Sub-Fund.

<i>General provisions

28.2 Notices and communications may be made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, by fax,

email or any other means of electronic communication.

28.3 Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a director, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board of
Directors.

28.4 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video con-
ference may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute
one and the same document.

28.5 All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law

and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.

<i>Transitional provisions

1.- The Fund’s first financial year shall begin on the date of this deed and end on the thirty-first (31) of December 2016.
2.- The first annual general meeting will be exceptionally be held in 2017.

<i>Subscription and payment

The Articles of the Fund having thus been drawn up by the appearing party, the said appearing party, here represented

as stated here above, declares to subscribe to the Shares as follows:

Shareholder

Capital

subscribed

Number

of shares

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000.-

31

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000.-

31

35915

L

U X E M B O U R G

Evidence of the above payment, i.e. thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) was given to the undersigned notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Fund in connection with its incorporation

are estimated at approximately EUR 3,000.-

<i>Statements

The notary drawing up this deed declares that the conditions set forth in Article 26, 26-3 and 26-5 of the law of 10

August 1915 on commercial companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Resolutions of the shareholder

Immediately after the incorporation of the Fund, it shareholder, representing the entire subscribed share capital, adopted

the following resolutions:

1. The following are appointed as directors of the Fund for a period ending at the annual general meeting to be held in

2022:

(i) Bastiaan Schreuders, born on 12 December 1954 in Breda, The Netherlands, having his professional address at 10-12

rue de Medernach, L-7619 Larochette, Grand-Duchy of Luxembourg;

(ii) Arnaud Schreiber, born on 8 May 1975 in Charleroi, Belgium, having his professional address at 7, route d’Esch,

L-1470 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg; and

(iii) Moyse Dargaa, born on 1 September 1970 in Liège, Belgium, having his professional address at 40, rue du Curé,

L-1368 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

2. PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, with registered office at 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxem-

bourg,  registered  with  the  Luxembourg  Register  of  Commerce  and  Companies  under  number  65.477  is  appointed  as
approved external auditor (réviseur d’entreprises agréé) of the Fund for a period ending at the annual general meeting to
be held in 2017.

3. The registered office of the Fund is located at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that this deed is worded in English only.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by his surname, Christian name, civil

status and residence, said person appearing signed together with us, the notary, this original deed.

Signé: P. BUISSERET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 24 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5995. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 4 mars 2016.

Référence de publication: 2016075347/594.
(160040302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.

Senvion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 186.599.

Die Gesellschaft hat beschlossen, im Rahmen der Umwandlung der Gesellschaft in eine société anonyme und gleich-

zeitiger Umwandlung der Namenaktien der Gesellschaft in dematerialisierte Aktien, LuxCSD S.A., mit eingetragenem Sitz
in 42, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingeschrieben im Handelsregister Luxem-
burg unter der Nummer B 154449 als alleiniges Abwicklungsorgan (organisme de liquidation) zu bestellen, gemäß Artikel
4 und Artikel 8 des Gesetzes vom 6. April 2013 über dematerialisierte Aktien.

Luxemburg, den 1 März 2016.

<i>Für gleichlautenden Auszug
Für Veröffentlichung
Senvion S.à r.l.
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2016075524/18.
(160040654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.

35916

L

U X E M B O U R G

Brennholz vum Wolef S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7390 Blaschette, 6, rue Hiel.

R.C.S. Luxembourg B 203.782.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend sechzehn.
Den ersten Februar.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

SIND ERSCHIENEN:

1.- Frau Jill STRENZLER, Privatangestellte, wohnhaft in L-7390 Blaschette, 6, rue Hiel.
2.- Herr Daniel WOLFF, Rentner, wohnhaft in L-7390 Blaschette, 8, rue Hiel.
3.- Herr Guy WOLFF, Gemeindearbeiter, wohnhaft in L-7390 Blaschette, 4a, rue Hiel.
Welche Komparenten hier vertreten sind durch Peggy Simon, Privatangestellte, beruflich ansässig in L-6475 Echternach,

9, Rabatt, aufgrund von drei Vollmachten unter Privatschrift vom 14. Dezember 2015,

welche Vollmachten nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Bevollmächtigte und dem amtierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde als Anlagen beigebogen bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche  Komparenten,  vertreten  wie  eingangs  erwähnt,  den  instrumentierenden  Notar  ersuchten,  folgende  Gesell-

schaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie

durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "Brennholz vum Wolef S.à r.l.".

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Lorentzweiler.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf von Holz, Holzprodukten und Pflanzen sowie alle dazugehörigen

Dienstleistungen.

Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-

Transaktionen  zu  tätigen,  welche  mit  dem  Gesellschaftszweck  verbunden  werden  können  und  der  Entwicklung  der
Gesellschaft förderlich sind.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in EIN

HUNDERT (100) Anteile von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-).

Art. 7. Zur Abtretung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der

Generalversammlung, in welcher wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten sein müssen.

Die Übertragung der Gesellschaftsanteile an Nichtgesellschafter infolge Sterbefalls bedarf der Zustimmung von Ge-

sellschaftern, welche drei Viertel der den Überlebenden zustehenden Rechte vertreten.

Die laut Absatz 2 vorgesehene Zustimmung ist nicht erfordert, wenn die Anteile, sei es an Reservaterben, sei es an den

überlebenden Ehegatten oder, soweit dies durch die Statuten vorgesehen ist, an die andern gesetzlichen Erben übertragen
werden.

Die Erben sowie die durch Verfügung von Todeswegen eingesetzten Vermächtnisnehmer, welche obige Zustimmung

nicht erhalten, sowie auch keinen Abnehmer gefunden haben, welcher die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt, können
die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft veranlassen und zwar drei Monate nach einer Inverzugsetzung, die den Ge-
schäftsführern durch den Gerichtsvollzieher zugestellt und den Gesellschaftern durch Einschreibebrief durch die Post zur
Kenntnis gebracht wird.

Innerhalb  der  besagten  Frist  von  drei  Monaten  können  die  Gesellschaftsanteile  des  Verstorbenen  jedoch  erworben

werden, entweder durch die Gesellschafter, unter Vorbehalt der Bestimmungen des letzten Satzes von Artikel 199 des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen, oder durch einen von ihnen
genehmigten Dritten, oder auch durch die Gesellschaft selbst, wenn sie die Bedingungen erfüllt, welche von einer Gesell-
schaft zum Erwerb ihrer durch sie verausgabten Wertpapiere verlangt werden.

35917

L

U X E M B O U R G

Der Rückkaufpreis der Gesellschaftsanteile wird auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten Jahre, und wenn

die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre aufzuweisen hat, auf Grund der Bilanz des letzten oder derjenigen der zwei
letzten Jahre berechnet.

Wenn kein Gewinn verteilt worden ist, oder wenn keine Einigung über die Anwendung der im vorhergehenden Absatz

angegebenen Rückkaufgrundlagen zustande kommt, wird der Preis im Uneinigkeitsfalle gerichtlich festgesetzt.

Die den Gesellschaftsanteilen des Erblassers zustehenden Rechte können nicht ausgeübt werden, bis deren Übertragung

der Gesellschaft gegenüber rechtswirksam ist.

Die Abtretungen von Gesellschaftsanteilen müssen durch notariellen oder Privatvertrag beurkundet werden.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie, gemäß Artikel 1690

des bürgerlichen Gesetzbuches, der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die

Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht wor-
den,  so  werden  die  Gesellschafter  ein  zweites  Mal  durch  Einschreibebrief  zusammengerufen  oder  befragt  und  die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesell-

schaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschaf-

terversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtungen

bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates
verantwortlich.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der

Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt.

Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch-
geführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit

beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

35918

L

U X E M B O U R G

<i>Zeichnung und Einzahlung des gesellschaftskapitals

Die einhundert (100) Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

1.- Frau Jill STRENZLER, vorgenannt, fünfundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

2.- Herr Daniel WOLFF, vorgenannt, fünfundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

3.- Herr Guy WOLFF, vorgenannt, zehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€

12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachge-
wiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2016.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr ein tausend Euro (€ 1.000.-).

<i>Erklärung

Die Komparenten erklären, dass der unterfertigte Notar ihnen Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst

nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen Gene-

ralversammlung  zusammengetreten,  und  haben  einstimmig  und  laut  entsprechender  Tagesordnung  nachfolgende  Bes-
chlüsse gefasst:

a) Zur Geschäftsführerin der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Frau Jill STRENZLER, Privatangestellte, wohnhaft in L-7390 Blaschette, 6, rue Hiel.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift der Geschäftsführerin rechtsgültig vertreten und

verpflichtet. Sie kann Vollmachten an Dritte erteilen.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-7390 Blaschette, 6, rue Hiel.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräu-

chlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 02 février 2016. Relation: GAC/2016/911. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesell-

schaftsregister.

Echternach, den 11. Februar 2016.

Référence de publication: 2016064283/144.
(160026822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Sigma Lux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1514 Luxembourg, 18, rue Xavier Feller.

R.C.S. Luxembourg B 203.489.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the twenty first of January.
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

1.- Mr Ahmed KHALIL, managing director, born in Riyadh (Saudi Arabia) on the 13 March 1983, residing at L-2269

Luxembourg, 3, rue Jean Origer,

2.- Mr Michal BOHOSIEWICZ, managing director, born in Szczecin (Poland), on 6 January 1981, residing at L-1514

Luxembourg, 18, rue Xavier Feller.

35919

L

U X E M B O U R G

Such appearing parties required the officiating notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité

limitée which they declare to incorporate and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There exists a société à responsabilité limitée (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law

of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the online sale of beekeeping products.
The Company-may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all commercial, financial

movable and immovable operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are
related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. The Company will be incorporated under the name of "Sigma Lux, S. à r.l.".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general

meeting of its shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through resolution of the
manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg
or abroad through resolution of the manager or the board of managers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion to
the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to

new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the

approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

If there is only one manager, the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of the manager.
In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any two managers

or by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.

Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and may

choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who
shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all-meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-

holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in advance

of the date scheduled for the meeting by electronic mail (without electronic signature), except in case of emergency, in
which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in
case of assent of each manager in writing, by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication.

35920

L

U X E M B O U R G

A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by electronic mail (without

electronic signature) or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will
form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise, shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 18. If the Company has only one shareholder, such sole shareholder exercises the powers granted to the general

meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 19. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 20. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

The board of managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are

sufficient.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which

do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their
powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the
liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of

the Company held by them.

Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of

10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All of the five hundred (500) shares are subscribed as follows:

35921

L

U X E M B O U R G

1.- Mr Ahmed KHALIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 shares
2.- Mr Michal BOHOSIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 shares

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of December

2016.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

<i>Business licence

The undersigned notary informed the appearing persons that before any business or any change in the objects of the

Company, they must be in possession of a business license in good standing in relation to the purpose, as expressly reco-
gnized by the appearing persons.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders prenamed, representing the entirety of the sub-

scribed capital have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at L-1514 Luxembourg, 18, rue Xavier Feller.
2. The shareholders resolve to elect as managers of the Company for an indefinite period:
1.- Mr Ahmed KHALIL, managing director, born in Riyadh (Saudi Arabia) on the 13 March 1983, residing at L-2269

Luxembourg, 3, rue Jean Origer,

2.- Mr Michal BOHOSIEWICZ, managing director, born in Szczecin (Poland), on 6 January 1981, residing at L-1514

Luxembourg, 18, rue Xavier Feller.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

party, this deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the English and
the French text, the English version prevails.

The document having been read to the appearing party, said person appearing signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1.- M. Ahmed KHALIL, gérant, né à Riyadh (Arabie Saoudite) le 13 mars 1983, demeurant à L-2269 Luxembourg, 3,

rue Jean Origer,

2.- M. Michal BOHOSIEWICZ, gérant né à Szczecin (Pologne), le 6 janvier 1981, demeurant à L-1514 Luxembourg,

18, rue Xavier Feller.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet le commerce en ligne de produits d'apiculture.
La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations,

commerciales, financières mobilières et immobilières qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social
ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société est constituée sous le nom de «Sigma Lux, S. à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

35922

L

U X E M B O U R G

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société
peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres
pays par décision du gérant ou du conseil de gérance.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants,
proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en numéraire.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à

des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés
que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont librement

révocables à tout moment et sans cause.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature unique du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants

ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura
été délégué par le conseil de gérance.

Art. 12. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir

parmi ses membres un vice-président.

Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-

verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de

convocation.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance; en son absence, les

associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la
présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion par courrier électronique, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de
chaque gérant par écrit ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation  spéciale  ne  sera  pas  requise  pour  une  réunion  du  conseil  de  gérance  se  tenant  à  une  heure  et  un  endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par courrier

électronique ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visio-conférence ou d'autres

moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les
autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

35923

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,

par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du

capital social.

Art. 18. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés

par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 19. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre

de la même année.

Art. 20. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un

inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication
au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le conseil
de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution sont dispo-
nibles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,

nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

L'intégralité des cinq cents (500) parts sociales a été souscrite comme suit:

1.- M. Ahmed KHALIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 parts

2.- M. Michal BOHOSIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 parts

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de décembre

2016.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

<i>Autorisation de commerce

Le notaire soussigné a informé les comparants qu'avant toute activité commerciale ou toute modification de l'objet social

relative à une activité commerciale, ceux-ci doivent être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due
forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

35924

L

U X E M B O U R G

<i>Résolutions

Et aussitôt les associés préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-1514 Luxembourg, 18, rue Xavier Feller.
Les associés décident de nommer en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:
1.- M. Ahmed KHALIL, gérant, né à Riyadh (Arabie Saoudite) le 13 mars 1983, demeurant à L-2269 Luxembourg, 3,

rue Jean Origer,

2.- M. Michal BOHOSIEWICZ, gérant né à Szczecin (Pologne), le 6 janvier 1981, demeurant à L-1514 Luxembourg,

18, rue Xavier Feller.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la
version anglaise fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. KHALIL, M. BOHOSIEWICZ et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 22 janvier 2016 1LAC / 2016 / 2134. Reçu soixante quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 1 

er

 février 2016.

Référence de publication: 2016060643/290.
(160021289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 44.318.

Engenia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 203.932.

L'an deux mille seize, le troisième jour du mois de mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

I.  Monsieur  Christophe  VELLE,  employé  privé,  demeurant  professionnellement  au  35  Boulevard  du  Prince  Henri,

L-1724 Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de:
- Intesa Sanpaolo Holding International S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 35 Boulevard du Prince

Henri, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Luxembourg B 44.318, au capital social
de deux milliards deux cent millions quatre-vingt-sept mille quatre cent quarante euros (2.200.087.440.- EUR), ayant pour
objet social, dans le cadre du groupe dont elle fait partie, la prise de participations dans des sociétés ou personnes morales
qui ont leur siège social hors d'Italie et exercent leur activité dans le domaine bancaire et financier, ainsi que l'organisation
et la coordination patrimoniale et financière de ces participations;

en vertu des pouvoirs lui conférés en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg en date du 18 février 2016;
II. Monsieur Ubaldo MIGLIORATI, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de:
- la société Engenia S.A., société anonyme ayant son siège au Luxembourg, 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724,

Luxembourg, société anonyme de droit luxembourgeois inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 203 932, au capital social de trente et un mille euros (31.000.- EUR), ayant pour objet l'acquisition, la vente, la valorisation
ainsi que la gestion de tous biens immobiliers sis à Luxembourg ou à l'étranger,

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution du conseil d'administration, prise lors de sa réunion du

29 février 2016.

La procuration précitée et une copie du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration précité, après avoir été

signés «ne varietur» par les personnes comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être
formalisés avec lui.

Lesdites personnes comparantes, agissant en leur qualité prémentionnée, a requis le notaire instrumentant d'acter le

projet de scission plus amplement spécifié ci-après:

35925

L

U X E M B O U R G

PROJET DE SCISSION

1. Objectifs de la scission. La scission partielle par absorption qui fait l'objet de ce projet s'intègre dans une opération

de réorganisation de la détention de la participation bancaire de droit hongrois CIB Bank Ltd (ci-après «CIB»), détenue à
soixante-sept pourcent virgule six neuf zéro cinq (67,6905%) par Intesa Sanpaolo Holding International S.A. (ci-après la
«Société Scindée»), au sein du groupe Intesa Sanpaolo (le «Groupe»).

L'opération de scission s'opèrera par le transfert de cent pourcent (100%) des actions CIB détenue par la Société Scindée

au bénéfice de la société Engenia S.A. (ci-après la «Société Bénéficiaire»), selon les modalités décrites dans le présent
projet de scission.

Cette opération prévoit (i) la scission partielle de la Société Scindée en faveur de la Société Bénéficiaire en ce qui

concerne la participation dans CIB et (ii) l'incorporation de la Société Bénéficiaire dans Intesa Sanpaolo SpA, cette dernière
détenant à 100% la Société Bénéficiaire.

Après approbation du projet de scission par les conseils d'administration respectifs des entités participantes à la scission,

les actionnaires de la Société Scindée et de la Société Bénéficiaire se réuniront en assemblée générale extraordinaire par-
devant notaire. Celle-ci aura lieu au plus tôt un mois après la publication du présent projet de scission au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, et aura pour objet d'approuver le projet de scission partielle par lequel la Société
Scindée transfère une partie de son patrimoine, activement et passivement, sans dissolution mais par réduction de son
capital social et de ses réserves, à la Société Bénéficiaire conformément aux articles 287 et suivants de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»).

2. Sociétés participantes à la scission (forme, dénomination, siège social).
2.1 Société Scindée
Intesa Sanpaolo Holding International S.A., une société existante sous forme de société anonyme de droit luxembour-

geois, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 35 Boulevard du Prince Henri et inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro RCS Luxembourg B 44.318.

La Société Scindée a un capital social souscrit de deux milliards deux cent millions quatre-vingt-sept mille quatre cent

quarante euros (EUR 2.200.087.440,-) représenté par vingt-deux millions deux cent vingt-trois mille cent quatre-vingt-
douze (22.223.192) actions ordinaires et deux millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-quatre (2.222.224)
actions  privilégiées  obligatoirement  rachetables  d'une  valeur  nominale  de  quatre-vingt-dix  euros  (EUR  90,-)  chacune,
intégralement libérées.

2.2 Société Bénéficiaire
Engenia S.A., une société existante sous forme de société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à

L-1724 Luxembourg, 19/21 Boulevard du Prince Henri et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
RCS Luxembourg B 203932.

La Société Bénéficiaire a un capital social souscrit de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et

une mille (31.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, intégralement libérées.

3. Description des éléments du patrimoine actif et passif faisant l'objet de la scission. A la Date Effective de la scission

partielle (telle que définie ci-après au point 8), les éléments du patrimoine activement et passivement faisant l'objet de la
scission partielle seront transférés à la Société Bénéficiaire comme suit:

3.1. Activement
Une participation égale à soixante-sept pourcent virgule six neuf zéro cinq (67,6905%) du capital social de la société

de droit hongrois CIB Bank Ltd, ayant son siège social à Budapest 1027, Medve u. 4-14., inscrite auprès du registre de
commerce de Budapest sous le numéro 01-10-041004, au capital social de cinquante milliards et deux florins hongrois
(HUF 50.000.000.002,-) représentée par cinquante milliards et deux (50.000.000.002) actions nominatives d'une valeur
d'un florin hongrois (HUF 1,-) chacune. Sur le plan comptable, la participation est évaluée dans les comptes de la Société
Scindée au 31 décembre 2015 au montant de cent quatre-vingts millions neuf cent vingt-quatre mille vingt-trois euros (EUR
180.924.023,-).

3.2 Passivement
Par suite de la scission partielle, la Société Scindée réduira son capital social de son montant actuel de deux milliards

deux cent millions quatre-vingt-sept mille quatre cent quarante euros (EUR 2.200.087.440,-) représenté par vingt-deux
millions deux cent vingt-trois mille cent quatre-vingt-douze (22.223.192) actions ordinaires et deux millions deux cent
vingt-deux mille deux cent vingt-quatre (2.222.224) actions privilégiées obligatoirement rachetables d'une valeur nominale
de quatre-vingt-dix euros (EUR 90,-) chacune, pour le ramener à un montant de deux milliards cent cinquante-sept millions
neuf cent cinquante-sept mille deux cent soixante-dix euros (EUR 2.157.957.270,-) représenté par vingt-et-un millions sept
cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent trente-trois (21.797.633) actions ordinaires et deux millions cent soixante-dix-neuf
mille six cent soixante-dix (2.179.670) actions privilégiées obligatoirement rachetables d'une valeur nominale de quatre-
vingt-dix euros (EUR 90,-) chacune, soit une réduction de capital à hauteur de quarante-deux millions cent trente mille
cent soixante-dix euros (EUR 42.130.170,-) à réaliser par l'annulation de quatre cent vingt-cinq mille cinq cent cinquante-
neuf (425.559) actions ordinaires et quarante-deux mille cinq cent cinquante-quatre (42.554) actions privilégiées obliga-
toirement rachetables d'une valeur nominale de quatre-vingt-dix euros (EUR 90,-) chacune. La Société Scindée réduira

35926

L

U X E M B O U R G

également son compte de réserve libre d'un montant de cent trente-huit millions sept cent quatre-vingt-treize mille huit cent
cinquante-trois euros (EUR 138.793.853,-) de sorte que le montant total de la réduction des fonds propres s'élève à cent
quatre-vingt millions neuf cent vingt-quatre mille vingt-trois euros (EUR 180.924.023,-).

4. Modalités de l'opération. La scission est régie par les articles 287 et suivants. Elle revêt les caractéristiques suivantes:
4.1 La Société Scindée transfère, sans dissolution, à la Société Bénéficiaire une partie de son patrimoine, activement et

passivement, tout en continuant à opérer avec la partie restante de son patrimoine actif et passif, de sorte que l'opération
est qualifiée de scission partielle.

4.2 La Société Scindée est intégralement détenue par l'actionnaire unique de la Société Bénéficiaire, Intesa Sanpaolo

SpA, société par actions de droit italien, ayant son siège statutaire à Piazza San Carlo 156, 10 121 Turin (Italie) (ci-après
«l'Actionnaire Unique»). Il en résulte que la partie du patrimoine de la Société Scindée qui, par suite de l'opération de
scission, est transférée intégralement à la Société Bénéficiaire, sera, suite à l'opération, détenue indirectement par l'Ac-
tionnaire Unique.

4.3 La Société Bénéficiaire, par suite de la scission partielle procèdera à une augmentation de capital d'un montant de

cent soixante-quinze millions deux cent soixante-dix mille cent quarante-huit euros (EUR 175.270.148,-) au profit de
l'Actionnaire Unique, au moyen de l'émission de cent soixante-quinze millions deux cent soixante-dix mille cent quarante-
huit (175.270.148) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune. La Société Bénéficiaire procèdera
aussi à la constitution d'une réserve libre à hauteur de cinq millions six cent cinquante-trois mille huit cent soixante-quinze
euros (EUR 5.653.875,-) de sorte que le montant de l'augmentation du capital social de cent soixante-quinze millions deux
cent soixante-dix mille cent quarante-huit euros (EUR 175.270.148,-) ajouté au montant de la réserve libre nouvellement
créée de cinq millions six cent cinquante-trois mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 5.653.875,-) soient égal au
montant de la valeur de la participation dans CIB.

Les actions ainsi émises dans le cadre de l'augmentation de capital seront numérotées de 31.001 à 175.301.148.
L'opération de scission partielle aura ainsi comme effet final et définitif (au-delà des actes même qui composent l'opé-

ration) l'attribution à l'Actionnaire Unique de la Société Scindée d'actions nouvelles.

Conformément à l'article 26-1 de la Loi, l'intervention d'un réviseur d'entreprises agréé en cas d'émission d'actions émises

en contrepartie d'apports autres qu'en numéraires est requise. Dès lors, KPMG Luxembourg, Société Coopérative, sera
mandaté aux fins de produire le rapport prescrit par ledit article 26-1.

5. Rapport d'échange et modalités de remise des actions.
5.1 L'émission d'actions nouvelles en contrepartie de l'apport implique la fixation d'un rapport d'échange. En consé-

quence, le rapport d'échange est déterminé comme suit:

1. La Société Scindée réduira son capital social d'un montant de quarante-deux millions cent trente mille cent soixante-

dix euros (EUR 42.130.170,-) par l'annulation de quatre cent vingt-cinq mille cinq cent cinquante-neuf (425.559) actions
ordinaires et quarante-deux mille cinq cent cinquante-quatre (42.554) actions privilégiées obligatoirement rachetables d'une
valeur nominale de quatre-vingt-dix euros (EUR 90,-) chacune. La Société Scindée réduira également son compte de réserve
libre d'un montant de cent trente-huit millions sept cent quatre-vingt-treize mille huit cent cinquante-trois euros (EUR
138.793.853,-).

2. Les cent soixante-quinze millions deux cent soixante-dix mille cent quarante-huit (175.270.148) nouvelles actions

de la Société Bénéficiaire émises par l'apport résultant de la scission partielle, sont attribuées à l'Actionnaire Unique au
prorata de la détention des actions annulées de la Société Scindée soit à raison de quatre cent soixante-huit mille cent treize
(468.113)  actions  annulées  contre  cent  soixante-quinze  millions  deux  cent  soixante-dix  mille  cent  quarante-huit
(175.270.148) actions émises suite à l'augmentation de capital dont mention ci-avant. Une réserve libre d'un montant de
cinq millions six cent cinquante-trois mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 5.653.875) sera nouvellement créée par
la Société Bénéficiaire.

3. Le ratio d'échange est partant calculé comme suit:

- nombre d'actions émises par la Société Bénéficiaire:
Cent soixante-quinze millions deux cent soixante-dix mille cent quarante-huit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.270.148
- nombre d'actions annulées par la Société Scindée:
Quatre cent soixante-huit mille cent treize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

468.113

- ratio : trois cent soixante-quatorze virgule quarante-deux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

374.42

5.2 Les actions nouvellement émises de la Société Bénéficiaire seront inscrites au nom de l'Actionnaire Unique sur le

registre des actions nominatives de la Société Bénéficiaire dès que la scission sera approuvée, à la Date Effective de scission
(telle que définie au point 8 ci-après). Les actions de la Société Scindée, correspondant aux actifs nets transférés, seront
annulées le jour de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Scindée approuvant la scission, à la Date Effective de
scission (telle que définie au point 8 ci-après).

Conformément à l'article 289 (d) de la Loi, il y a lieu de préciser que les actions nouvellement émises donnent droit de

participer aux bénéfices à compter de leur création sans modalités particulières attachées à ce droit.

35927

L

U X E M B O U R G

6. Etat comptable, rapport des organes de gestion et rapport d'expert indépendant. L'opération de scission se réalisera,

considérant respectivement pour la Société Scindée les comptes annuels audités au 31 décembre 2015 et sur base d'une
situation intermédiaire au 17 février 2016 de la Société Bénéficiaire (reprises en annexe).

Conformément à l'article 296 de la Loi, les actionnaires participant à la scission renoncent aux dispositions prévues par

les articles y mentionnés, de sorte que:

- ni rapport des conseils d'administration des sociétés participant à la scission, expliquant et justifiant du point de vue

juridique et économique le projet de scission, le rapport d'échange des actions et le critère pour leur répartition; et

- ni examen et rapport écrit d'expert indépendant quant au projet de scission et au rapport d'échange pertinent ou nom

et raisonnable, au sens de l'article 294 (1) et (2) de la Loi n'ont été établis.

7. Modalités de remise du patrimoine scindé à la Société Bénéficiaire. Le patrimoine net de scission partielle sera

transféré à la Société Bénéficiaire en application de l'article 303 de la Loi. Partant, les trente-trois millions huit cent quarante-
cinq millions deux cent trente-neuf mille cent cinquante-quatre (33.845.239.154) actions nominatives de CIB représentant
soixante-sept pourcent virgule six neuf zéro cinq (67,6905%) du capital social de celle-ci seront transférées à compter de
la Date Effective (telle que définie au point 8 ci-après), au nom de la Société Bénéficiaire, par inscription à effectuer dans
le registre des actions nominatives de CIB et, le cas échéant, par toute autre modalité complémentaire requis par le droit
hongrois en matière de transfert de propriété d'actions.

8. Effets de la scission. Conformément à l'art. 289 (2) d) de la Loi, les opérations de la Société Scindée en relation avec

l'apport et avec les droits et obligations qui s'y rattachent seront considérées, accomplies à la date d'effet («Date Effective»)
indiquée dans les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la Société Scindée et de la Société Bénéficiaire,
appelées à se prononcer sur le projet de scission. Conformément à l'art. 289 (2) e) de la Loi, les opérations de la Société
Scindée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Bénéficiaire à la Date
Effective.

Les biens représentatifs du patrimoine objet de la scission et les rapports juridiques actifs et passifs y afférents seront

transférés dans l'état de droit et de fait dans lequel ils se trouveront à la Date Effective.

9. Droits et avantages particuliers. Conformément à l'art. 289 (2) f) et g) de la Loi , il est précisé qu'aucun droit n'est

assuré par la Société Bénéficiaire aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions
ni aucune mesure n'est proposée, à leur égard et aucun avantage particulier, en dehors de la rémunération d'usage, n'est
attribué aux experts, aux membres des organes de gestion ainsi qu'à la personne chargée du contrôle des comptes des
sociétés participant à la scission.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte de projet de scission ayant été lu en langue française aux comparants qui ont signé avec nous, notaire,

le présent acte.

Signé: C. VELLE, U. MIGLIORATI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 mars 2016. Relation: EAC/2016/5754. Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2016075909/186.
(160041289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.

Misys Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 55.354.

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of February.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

MIBS Holdings Limited, a limited liability company incorporated under the laws of England and Wales, having its

registered address at One Kingdom Street, London W2 6BL and registered under number 00874912,

here represented by Mr. Michael Rebholz, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a duly given proxy,
being the sole shareholder of Misys Europe, a société anonyme (public limited liability company) incorporated and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 287-289, route d’Arlon, L-1150
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B. 55.354, incorporated pur-
suant to a deed of Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 31 May
1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 21 September 1996 under number 471. The
articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg dated 25 March 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations on 17 June 2014 under number 1555 (the “Company”).

35928

L

U X E M B O U R G

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement and may validly

deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda

1. Approval of the transfer of the branch of activities of Turaz Global TRM S.à r.l. to the Company, in accordance with

the transfer plan set out on 22 January 2016, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
218 of 28 January 2016;

2. Miscellaneous.
has requested the officiating notary to enact the following resolutions:
WHEREAS, the sole shareholder has been able to take knowledge of:
- the transfer plan set out on 22 January 2016, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number

218 of 28 January 2016 (the “Transfer Plan”), whereby Turaz Global TRM S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B. 164.587 (hereinafter the “Transferor”) transfers to the Company, without dissolution, its activities
consisting in (i) the specification, development, marketing, sales, implementation and maintenance of the Misys software
products sold by the Company and (ii) the provision of related consulting services which are carried on by the Company
and particularly all the assets and liabilities related to such activities as further set out in the Transfer Plan (the “Branch of
Activities”), (the “Transfer”);

- the annual accounts and the management reports for the three last financial years of the Company; and
- the annual accounts and the management reports for the three last financial years of the Transferee.
WHEREAS, in accordance with article 295 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as

amended (the “Law”), the abovementioned documents were at the shareholder’s disposal at the registered office of the
Company, at least one month before the date of the present resolutions.

WHEREAS, all the shareholders have provided the Company and the Transferee with waiver letters, whereby each of

them expressly confirms that it has been sufficiently informed about the Transfer and expressly waives the requirement of
(hereby expressly waives the requirement of (i) an independent experts’ examination and report on the Transfer Plan in
accordance with Article 296 (1) of the Law, (ii) interim financial statements in accordance with Article 296 (2) of the Law,
and (iii) the report of the management bodies in accordance with Article 296 (2) of the Law.

<i>Sole resolution:

The sole shareholder resolves to approve the Transfer as set out in the Transfer Plan and to confirm that the Branch of

Activities shall be transferred to the Transferee for the consideration of one euro (EUR 1.-).

The sole shareholder resolves further that the Transfer will be effective between the Company and the Transferee at the

date of the present general meeting.

The sole shareholder resolves that, from an accounting and tax perspective, the Transfer shall be deemed effective as

of the date of the present resolutions.

The sole shareholder resolves that the Transfer is subject to the provisions on de-mergers as set out in Articles 285 to

308, except for Article 303 of the Law, and that the whole Branch of Activities, and in particular all the assets and liabilities
related to the Branch of Activities, will be transferred ipso jure and without dissolution by the Company to the Transferee,
in accordance with Article 308 bis-5 of the Law and with the Transfer Plan.

The undersigned notary, verified and hereby certifies the existence and legality of the acts and formalities the Company

was in charge as well as of the Proposal and the publication.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at EUR 6,500.-.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified in the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this

deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and

residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille seize, le vingt-neuf février.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

35929

L

U X E M B O U R G

A comparu:

MIBS Holdings Limited, une société à responsabilité limitée, valablement constituée sous les lois de l’Angleterre et du

Pays-de-Galles, ayant son siège social à One Kingdom Street, Londres W2 6BL,, et enregistrée sous le numéro 00874912,

dûment représentée par Monsieur Michael Rebholz, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation dûment donnée,

étant l’actionnaire unique de Misys Europe, une société anonyme dûment constituée et existant sous les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 55.354, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire
de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 31 mai 1996, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations en date du 21 septembre 1996, numéro 471. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en
date du 25 mars 2014 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1555, en date du 17 juin 2014
(la «Société»).

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

La comparante représentant l’intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation et peut

valablement délibérer sur tous les points figurant à l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Approbation de la cession de la branche d’activités de Turaz Global TRM S.à r.l. à la Société, conformément au projet

de cession établi le 22 janvier 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 218 en date du
28 janvier 2016;

2. Divers.
a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
ATTENDU QUE, les actionnaires ont pu prendre connaissance:
- du projet de cession établi le 22 janvier 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro

218 en date du 28 janvier 2016 (le «Projet de Cession»), aux termes duquel Turaz Global TRM S.à r.l., une société à
responsabilité limitée dûment constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 164.587 (ci-après le «Cédant») cède à la Société, sans dissolution, ses activités consistant dans (i) la spécification, le
développement, le marketing, les ventes, la mise en place et la maintenance des produits logiciels de Misys vendus par la
Société et (ii) la prestation de services de conseil afférant qui est effectuée par la Société ainsi que les passifs et actifs qui
s’y rattachent tel que décrit plus en détail dans le Plan de Transfert (la «Branche d’Activités»), (le «Cessionnaire»), (la
«Cession»);

- les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices de la Société; et
- les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices du Cessionnaire.
ATTENDU QUE, conformément à l’article 295 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), les documents susmentionnés ont été mis à disposition de l’actionnaire unique
au siège social de la Société au moins un mois avant la date des présentes résolutions.

ATTENDU QUE, tous les actionnaires ont transmis des lettres de renonciation à la Société et au Cessionnaire, aux

termes desquelles chacun d’entre eux confirme expressément avoir été suffisamment informé sur la Cession et renonce
expressément à l’exigence (i) de l’examen du Projet de Cession et du rapport établis par un expert indépendant, en vertu
de l’article 296 (1) de la Loi, (ii) de l’établissement d’un état comptable, en vertu de l’article 296 (2) de la Loi et (ii) du
rapport des organes de gestion de la Société et du Cessionnaire expliquant le Projet de Cession et le justifiant du point de
vue juridique et économique, en vertu de l’article 296 (2) de la Loi.

<i>Résolution unique:

L’actionnaire unique décide d’approuver la Cession telle que prévue dans le Projet de Cession et de confirmer que la

Branche d’Activités sera cédée en contrepartie de la somme d’un euro (EUR 1,-).

L’actionnaire unique décide en outre que la Cession sera effective entre la Société et les Cessionnaire à la date des

présentes résolutions.

L’actionnaire unique décide que, d’un point de vue comptable et fiscal, la Cession sera considérée comme effective à

compter de la date des présentes résolutions.

L’actionnaire unique décide que la Cession est soumise aux dispositions concernant les scissions telles qu'énoncées aux

articles 285 à 308, à l’exception de l’article 303 de la Loi et que l’ensemble de la Branche d’Activités, et en particulier tous
les actifs et les passifs qui s’y rattachent, seront transférés par la Société de plein droit et sans dissolution au Cessionnaire,
conformément à l’article 308 bis-5 de la Loi et au Projet de Cession.

Le notaire instrumentant atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, ainsi que du projet

d’apport et de sa publication, ce qu'il a vérifié.

35930

L

U X E M B O U R G

<i>Frais et dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la Société suite à cet acte sont estimés à EUR 6.500,-.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate, sur demande du comparant, que le présent acte est rédigé

en langue anglaise, suivi d'une traduction en français; à la demande du même comparant et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. REBHOLZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 2 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/7023. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 7 mars 2016.

Référence de publication: 2016076003/146.
(160040644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.

Turaz Global TRM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 111.324,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 164.587.

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of February.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Turaz Global S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 287-289, route d’Arlon, L-1150 Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B.164.046,

here represented by Mr. Michael Rebholz, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a duly given proxy,
being the sole shareholder of Turaz Global TRM S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité

limitée)  incorporated  and  existing  under  the  laws  of  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  having  its  registered  office  at
287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under num-
ber B. 164.587, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, on 3 November 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 21 November
2011, number 2834. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine
Schaeffer, prenamed, dated 4 March 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 4 June
2014, number 1436 (the “Company”).

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement and may validly

deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda

1. Approval of the transfer of the branch of activities of the Company to Misys Europe, in accordance with the transfer

plan set out on 22 January 2016, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 218 of 28
January 2016;

2. Miscellaneous.
has requested the officiating notary to enact the following resolutions:
WHEREAS, the sole shareholder has been able to take knowledge of:
- the transfer plan set out on 22 January 2016, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number

218 of 28 January 2016 (the “Transfer Plan”), whereby the Company transfers, without dissolution, its activities consisting
in (i) the specification, development, marketing, sales, implementation and maintenance of the Misys software products
sold  by  the  Company  and  (ii)  the  provision  of  related  consulting  services  which  are  carried  on  by  the  Company  and
particularly all the assets and liabilities related to such activities as further set out in the Transfer Plan (the “Branch of
Activities”), to Misys Europe, a société anonyme, duly incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register under number B 55.354 (the “Transferee”), (the “Transfer”);

35931

L

U X E M B O U R G

- the annual accounts and the management reports for the three last financial years of the Company; and
- the annual accounts and the management reports for the three last financial years of the Transferee.
WHEREAS, in accordance with article 295 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as

amended (the “Law”), the abovementioned documents were at the shareholder’s disposal at the registered office of the
Company, at least one month before the date of the present resolutions.

WHEREAS, all the shareholders have provided the Company and the Transferee with waiver letters, whereby each of

them expressly confirms that it has been sufficiently informed about the Transfer and expressly waives the requirement of
(hereby expressly waives the requirement of (i) an independent experts’ examination and report on the Transfer Plan in
accordance with Article 296 (1) of the Law, (ii) interim financial statements in accordance with Article 296 (2) of the Law,
and (iii) the report of the management bodies in accordance with Article 296 (2) of the Law.

<i>Sole resolution:

The sole shareholder resolves to approve the Transfer as set out in the Transfer Plan and to confirm that the Branch of

Activities shall be transferred to the Transferee for the consideration of one euro (EUR 1.-).

The sole shareholder resolves further that the Transfer will be effective between the Company and the Transferee at the

date of the present general meeting.

The sole shareholder resolves that, from an accounting and tax perspective, the Transfer shall be deemed effective as

of the date of the present resolutions.

The sole shareholder resolves that the Transfer is subject to the provisions on de-mergers as set out in Articles 285 to

308, except for Article 303 of the Law, and that the whole Branch of Activities, and in particular all the assets and liabilities
related to the Branch of Activities, will be transferred ipso jure and without dissolution by the Company to the Transferee,
in accordance with Article 308 bis-5 of the Law and with the Transfer Plan.

The undersigned notary, verified and hereby certifies the existence and legality of the acts and formalities the Company

was in charge as well as of the Proposal and the publication.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at EUR 6,500.-.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified in the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this

deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and

residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille seize, le vingt-neuf février.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Turaz Global S.à r.l., une société à responsabilité limitée, valablement constituée et existante sous les lois du Grand-

Duché du Luxembourg, ayant son siège social au287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, et enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 164.046,

dûment représentée par Monsieur Michael Rebholz, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation dûment donnée,

étant  l’actionnaire  unique  de  Turaz  Global  TRM  S.à  r.l.,  une  société  à  responsabilité  limitée  dûment  constituée  et

existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 287-289, route d’Arlon, L-1150 Lu-
xembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 164.587, constituée suivant acte reçu
par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Luxembourg, en date du 3 novembre 2011, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 21 novembre 2011, numéro 2834. Les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, prénommée, en date du 4 mars 2014 publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1436, en date du 4 juin 2014 (la «Société»).

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

La comparante représentant l’intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation et peut

valablement délibérer sur tous les points figurant à l’ordre du jour suivant:

35932

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1. Approbation de la cession de la branche d’activités de la Société à Misys Europe, conformément au projet de cession

établi le 22 janvier 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 218 en date du 28 janvier
2016;

2. Divers.
a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
ATTENDU QUE, les actionnaires ont pu prendre connaissance:
- du projet de cession établi le 22 janvier 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro

218 en date du 28 janvier 2016 (le «Projet de Cession»), aux termes duquel la Société cède, sans dissolution, ses activités
consistant dans (i) la spécification, le développement, le marketing, les ventes, la mise en place et la maintenance des
produits logiciels de Misys vendus par la Société et (ii) la prestation de services de conseil afférant qui est effectuée par la
Société ainsi que les passifs et actifs qui s’y rattachent tel que décrit plus en détail dans le Plan de Transfert (la «Branche
d’Activités»), à Misys Europe, une société anonyme, dûment constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Lu-
xembourg, ayant son siège social 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 55354 (le «Cessionnaire»), (la «Cession»);

- les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices de la Société; et
- les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices du Cessionnaire.
ATTENDU QUE, conformément à l’article 295 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), les documents susmentionnés ont été mis à disposition de l’actionnaire unique
au siège social de la Société au moins un mois avant la date des présentes résolutions.

ATTENDU QUE, tous les actionnaires ont transmis des lettres de renonciation à la Société et au Cessionnaire, aux

termes desquelles chacun d’entre eux confirme expressément avoir été suffisamment informé sur la Cession et renonce
expressément à l’exigence (i) de l’examen du Projet de Cession et du rapport établis par un expert indépendant, en vertu
de l’article 296 (1) de la Loi, (ii) de l’établissement d’un état comptable, en vertu de l’article 296 (2) de la Loi et (ii) du
rapport des organes de gestion de la Société et du Cessionnaire expliquant le Projet de Cession et le justifiant du point de
vue juridique et économique, en vertu de l’article 296 (2) de la Loi.

<i>Résolution unique:

L’actionnaire unique décide d’approuver la Cession telle que prévue dans le Projet de Cession et de confirmer que la

Branche d’Activités sera cédée en contrepartie de la somme d’un euro (EUR 1,-).

L’actionnaire unique décide en outre que la Cession sera effective entre la Société et les Cessionnaire à la date des

présentes résolutions.

L’actionnaire unique décide que, d’un point de vue comptable et fiscal, la Cession sera considérée comme effective à

compter de la date des présentes résolutions.

L’actionnaire unique décide que la Cession est soumise aux dispositions concernant les scissions telles qu'énoncées aux

articles 285 à 308, à l’exception de l’article 303 de la Loi et que l’ensemble de la Branche d’Activités, et en particulier tous
les actifs et les passifs qui s’y rattachent, seront transférés par la Société de plein droit et sans dissolution au Cessionnaire,
conformément à l’article 308 bis-5 de la Loi et au Projet de Cession.

Le notaire instrumentant atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, ainsi que du projet

d’apport et de sa publication, ce qu'il a vérifié.

<i>Frais et dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la Société suite à cet acte sont estimés à EUR 6.500,-.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate, sur demande du comparant, que le présent acte est rédigé

en langue anglaise, suivi d'une traduction en français; à la demande du même comparant et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. REBHOLZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 2 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/7022. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 7 mars 2016.

Référence de publication: 2016076150/146.
(160040634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.

35933

L

U X E M B O U R G

Expansion 17 S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 5, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 180.975.

L'an deux mille quinze, le vingt deux décembre
Par-devant, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Jean-Yves HÉMERY, Directeur de société, avec adresse professionnelle à Luxembourg, agissant en sa qualité

de délégué à la gestion journalière d’Expansion 17, (ci-après la «Société»), une société anonyme constituée régie par le
droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 180.975, en vertu de décisions
du conseil d'administration de la Société en date du 20 octobre 2015.

Une copie de l’extrait desdites décisions restera annexée au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité

de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire soussigné de documenter les déclarations et constatations

suivantes:

1. La Société a été constituée suivant acte notarié en date du 30 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 3059 du 3 décembre 2013. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant
actes reçus le 27 novembre 2015 par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Le capital souscrit est fixé à cinq cent soixante-et-un millions cinquante-huit mille et un euros (EUR 561.058.001),

représenté par (i) cinquante et un millions trois cent cinquante-neuf mille deux cent vingt (51.359.220) Actions de Catégorie
A8 et par cinq cent dix-huit mille sept cent quatre-vingt (518.780) Actions de Catégorie B8 représentatives du Compartiment
Saham, (ii) par une (1) part bénéficiaire (iii) par onze millions neuf cent vingt-trois mille cinq cent soixante (11.923.560)
actions de Catégorie A9 et par cent vingt mille quatre cent quarante (120.440) actions de Catégorie B9 représentatives du
Compartiment NOP, (iv) par soixante dix huit millions six cent soixante et onze mille trois cent quarante (78 671 340)
actions de Catégorie A10, par sept cent quatre vingt quatorze mille six cent soixante (794 660) actions de Catégorie B10
représentatives du Compartiment CSP Technologies, (v) par deux cent quatre-vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-
dix cinq cent soixante (282.490.560) actions de Catégorie A11, par deux millions huit cent cinquante-trois mille quatre
cent quarante (2.853.440) actions de Catégorie B11 représentatives du Compartiment Constantia Flexibles, (vi) par cent
trente-et-un millions deux mille sept cent quarante (131.002.740) actions de Catégorie A12, par un million trois cent vingt-
trois  mille  deux  cent  soixante  (1.323.260)  actions  de  Catégorie  B12  représentatives  du  Compartiment  Expansion  17-
AlliedBarton, d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.

3. L’article 5.2 des statuts dispose que le capital autorisé, en ce compris le capital social émis, est fixé à un milliard sept

cent cinquante millions d’euros (EUR 1.750.000.000). Le Conseil d’Administration est autorisé, sans limite de temps, à
augmenter le capital de la Société, en une ou plusieurs fois, par l’émission de nouvelles Actions de Catégorie A et Actions
de Catégorie B, ou à accorder à de nouveaux actionnaires ou aux Actionnaires des options de souscription pour des Actions
de la Société, selon les dispositions qu’il déterminera.

4. Le 20 octobre 2015, le Conseil d’administration de la Société a décidé de procéder à une augmentation du capital

social en numéraire d’un montant en euros correspondant à l’équivalent de 2'120’000 USD, soit, sur la base d’une parité
de 1,- EUR/USD, d’un montant maximum de EUR 2'120’000 afin de le porter de sa valeur actuelle de EUR 561'058’001,
à un maximum de EUR 563'178’001, par la création d’un maximum:

- de 2'098’800 actions de catégorie A10, représentatives du Compartiment Expansion 17-CSP Technologies, d’un mon-

tant de EUR 1;

- de 21’200 actions de catégorie B10, représentatives du Compartiment Expansion 17-CSP Technologies, d’un montant

de EUR 1;

5. Le délégué à la gestion journalière a constaté que le capital social de la Société a été augmenté à concurrence d’un

montant d’un million neuf cent soixante-seize mille euros (EUR 1.976.000,-) et a été porté de cinq cent soixante-et-un
millions cinquante- huit mille et un euros (EUR 561.058.001) à cinq cent soixante-trois millions trente-quatre mille et un
euros (EUR 563.034.001) par l’émission de un million neuf cent cinquante-six mille deux cent quarante (1’956’240) actions
de catégorie A10 et dix-neuf mille sept cent soixante (19??760) actions de catégorie B10 ayant une valeur nominale d’un
euro (EUR 1,-) chacune;

6. Les nouvelles actions de catégorie A10 et B10 ont été entièrement souscrites et libérées intégralement comme indiqué

ci-dessous:

- neuf cent soixante-dix mille deux cent soixante-cinq (970’265) actions de catégorie A10 nouvellement émises d’une

valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, ont été intégralement souscrites et libérées pour un montant global de neuf
cent soixante-dix mille deux cent soixante-cinq euros (EUR 970’265,-) de valeur nominale et douze mille neuf cent quatre-
vingt-neuf  (12’989)  nouvelles  actions  de  catégorie  B10  ayant  une  valeur  nominale  d’un  euro  (EUR  1,-),  ont  été
intégralement souscrites et libérées pour un montant global de douze mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros (EUR 12’989,-)

35934

L

U X E M B O U R G

de valeur nominale par Trief Corporation S.A., une société anonyme existante et régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social 5, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg («Trief»), par un apport en numéraire;

- neuf cent quatre-vingt-trois mille soixante (983’060) actions de catégorie A10 nouvellement émises d’une valeur

nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, ont été intégralement souscrites et libérées pour un montant global de neuf cent
quatre-vingt trois mille soixante euros (EUR 983’060,-) de valeur nominale, par Oranje-Nassau Investments B.V., une
société de droit néerlandais, ayant son siège social Rembrandt Tower, 22 

nd

 floor, Amstelplein 1, 1090HC Amsterdam,

Pays-Bas («ONI»), par un apport en numéraire;

- deux mille neuf cent quinze (2’915) actions de catégorie A10 nouvellement émises d’une valeur nominale d’un euro

(EUR 1,-) chacune, ont été intégralement souscrites et libérées pour un montant global de deux mille neuf cent quinze euros
(EUR 2’915,-) de valeur nominale et six mille sept cent soixante-et-onze (6.771) nouvelles actions de catégorie B10 ayant
une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-), ont été intégralement souscrites et libérées pour un montant global de six mille
sept cent soixante-et-onze euros (EUR 6.771,-) de valeur nominale, par les co-investisseurs tels que définis en annexe 1
(«Co-investisseurs»), par un apport en numéraire.

7. Il résulte que suite à l’augmentation précitée la somme totale d’un million neuf cent soixante-seize mille euros (EUR

1.976.000,-) est à la libre disposition de la Société tel qu’il l’a été prouvé au notaire soussigné et est comprise dans un
montant global d’un million neuf cent soixante-seize mille euros (EUR 1.976.000,-) mis à la disposition par les actionnaires,
dont la preuve a été rapportée au notaire soussigné, qui la reconnaît expressément.

8. Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l'Article 5.1 des statuts

est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

Le capital souscrit est fixé à cinq cent soixante-trois millions trente-quatre mille et un euros (EUR 563.034.001), re-

présenté par (i) cinquante et un millions trois cent cinquante-neuf mille deux cent vingt (51.359.220) Actions de Catégorie
A8 et par cinq cent dix-huit mille sept cent quatre-vingt (518.780) Actions de Catégorie B8 représentatives du Compartiment
Saham, (ii) par une (1) part bénéficiaire (iii) par onze millions neuf cent vingt-trois mille cinq cent soixante (11.923.560)
actions de Catégorie A9 et par cent vingt mille quatre cent quarante (120.440) actions de Catégorie B9 représentatives du
Compartiment NOP, (iv) par quatre-vingts millions six cent vingt-sept mille cinq cent quatre-vingts (80.627.580) actions
de Catégorie A10, par huit cent quatorze mille quatre cent vingt (814.420) actions de Catégorie B10 représentatives du
Compartiment CSP Technologies, (v) par deux cent soixante sept millions trois cent mille (267 300 000) actions de Caté-
gorie  A11,  par  deux  millions  sept  cent  mille  (2  700  000)  actions  de  Catégorie  B11  représentatives  du  Compartiment
Constantia Flexibles, (vi) par cent trente et un millions deux mille sept cent quarante (131 002 740) actions de Catégorie
A12, par un million trois cent vingt trois mille deux cent soixante (1 323 260) actions de Catégorie B12 représentatives du
Compartiment Expansion 17- AlliedBarton, d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.

<i>Frais

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme

de 3.050, -EUR.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux personnes comparantes, connue du notaire par ses nom, prénom usuels, état et demeure, lesdites

personnes comparantes ont signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Jean-Yves HÉMERY, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 décembre 2015. Relation GAC/2015/11744. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Nathalie DIEDERICH.

Référence de publication: 2016001045/102.
(150240452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Expansion 17 S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 5, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 180.975.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 30 décembre 2015.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2016001046/11.
(150240461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

35935

L

U X E M B O U R G

Ecurie Paradis Luxembourg SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 66, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 133.248.

L'an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois de décembre;
Pardevant  Nous  Maître  Carlo  WERSANDT,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  (Grand-Duché  de  Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“Assemblée”) de la société anonyme régie par les lois du Grand-

Duché de Luxembourg “Ecurie Paradis Luxembourg S.A.”, ayant eu son siège social à L-5969 Itzig, 13, rue de la Libération
et dont le contrat de domiciliation a été dénoncé avec effet en date du dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés, à
savoir le 17 juillet 2014, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
133248, (la “Société”), constituée originairement sous la dénomination sociale de “BAXLEY LUXEMBOURG”, suivant
acte reçu par Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 31
octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2796 du 4 décembre 2007,

et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant acte reçu par ladite notaire Martine DECKER, en date du 28

juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1777 du 31 août 2010, contenant notamment
l'adoption par la Société de sa dénomination sociale actuelle.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Julien DEMELIER-MOERENHOUT, juriste, demeurant professionnellement

à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

Le Président désigne Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean

Engling, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur Hervé TYDGAT, comptable confirmé, demeurant professionnellement à L-1470 Lu-

xembourg, 66, route d'Esch, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Fixation du siège social à L-1470 Luxembourg, 66, route d'Esch et modification subséquente de la première phrase

de l'article 2 des statuts;

2. Nomination du conseil d’administration et fixation de la durée de leur mandat;
3. Nomination de Monsieur Roger Pierre JERABEK comme nouveau commissaire aux comptes et détermination de la

durée de son mandat;

6. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés

sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les mandataires et les membres du bureau

de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  et  que  les  actionnaires,  présents  ou  représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de fixer le siège social à L-1470 Luxembourg, 66, route d'Esch et de modifier subséquemment la

première phrase de l'article 2 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

“Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).”

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide:
- de nommer les personnes suivantes aux fonctions d'administrateurs, leur mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée

générale annuelle de l'année 2020:

* Madame Isabelle Marie FLORENTIN, nom d'usage REYNAUD, administrateur de société, née à Nancy (France), le

4 août 1963, demeurant à 00280 Santiago de Veraguas, Detrave de la escuela primeria, La Pena (République de Panama);

35936

L

U X E M B O U R G

* Madame Clémentine, Charlie REYNAUD, nom d'usage REYNAUDFLORENTIN, employée, née à Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg), le 17 mai 1989, et demeurant à 00280 Santiago de Veraguas, Detrave de la escuela primeria,
La Pena (République de Panama); et

* La société anonyme Baxley Group Inc, ayant son siège social à Mossfon Building, East 54 

th

 Street, 0886 W.T.C,

Panama (République de Panama), immatriculée au Registro Publico de Panama sous le numéro 627359, par son représentant
permanent désigné, Madame Carmen Elena WONG RAMIREZ, administrateur de société, née à El Salvador (République
de Panama), le 8 novembre 1978, demeurant professionnellement à Mossfon Building, East 54 

th

 Street, 0886 W.T.C,

Panama (République de Panama).

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide:
- de nommer Monsieur Roger Pierre JERABEK expert-comptable né à Lyon (France), le 30 septembre 1966, demeurant

professionnellement à L-1466 Luxembourg, 66, route d’Esch, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle de l'année 2020, comme nouveau commissaire aux comptes.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne

demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

<i>Réunion du conseil d’administration

Et aussitôt, les membres du conseil d’administration, présents ou représentés, se sont réunis, et après avoir délibéré

valablement, ils décident de nommer Madame Isabelle Marie FLORENTIN, nom d'usage REYNAUD, pré-qualifiée, à la
fonction d'administrateur-délégué, avec tous pouvoirs d'engager la Société par sa seule signature dans tous les actes de
gestion journalière y compris toutes opérations bancaires.

Le mandat de l'administrateur-délégué ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année

2020.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. UHL, H. TYDGAT, J. DEMELIER-MOERENHOUT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 décembre 2015. 2LAC/2015/29063. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 24 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001036/90.
(150240168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Global Performance 17 S.A., SICAR, Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 5, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 180.980.

L'an deux mille quinze, le vingt-deux décembre
Par-devant, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Jean-Yves HÉMERY, Directeur de société, avec adresse professionnelle à Luxembourg, agissant en sa qualité

de délégué à la gestion journalière de Global Performance 17 S.A., SICAR, (ci-après la «Société»), une société anonyme
constituée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Pierre d’Aspelt, L-1142, Grand-Duché de
Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 180.980, en
vertu de résolutions du conseil d'administration de la Société en date du 20 octobre 2015.

Une copie de l’extrait desdites résolutions restera annexée au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité

de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire soussigné de documenter les déclarations et constatations

suivantes:

35937

L

U X E M B O U R G

1. La Société a été constituée suivant acte notarié en date du 30 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 3056 du 3 décembre 2013. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant
actes reçus le 27 novembre 2015 par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Le capital souscrit est fixé à cinq cent soixante et un millions cinquante mille et un euros (EUR 561 050 001,-)

représenté par cent soixante-treize millions deux cent cinquante mille (173 250 000) Actions de Catégorie AM1 et par un
million sept cent cinquante mille (1 750 000) Actions de Catégorie BM1, d’une valeur nominale de trois euros et deux
mille soixante cents (EUR 3,2060) chacune et par une (1) part bénéficiaire d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1).

3. L'article 5.2 des statuts de la Société dispose que le capital autorisé, en ce compris le capital social émis, est fixé à un

milliard sept cent cinquante mille euros (EUR 1.750.000.000). Le Conseil d’Administration est autorisé, sans limite de
temps, à augmenter le capital de la Société, en une ou plusieurs fois, par l’émission de nouvelles Actions de Catégorie AM1
et Actions de Catégorie BM1, par l’augmentation du nominal des dites actions ou à accorder à de nouveaux actionnaires
ou aux Actionnaires des options de souscription pour des Actions de la Société, selon les dispositions qu’il déterminera.

4. Suivant ses décisions du 20 octobre 2015, le Conseil d'administration a décidé de procéder à une augmentation du

capital social en numéraire correspondant à l’équivalent de 2'117’500 USD, soit, sur la base d’une parité de 1,0000 EUR/
USD, d’un montant maximum de deux millions cent dix-sept mille cinq cents euros (EUR 2'117’500,-) à un maximum de
cinq cent soixante-trois millions cent soixante-sept mille cinq cents euros (EUR 563'167’500,-), par l'augmentation du
nominal des cent soixante-quinze millions (175'000’000) d’actions préexistantes à concurrence d'un maximum de:

- zéro euro et zéro cent vingt-et-un cents (EUR 0,0121) par action AM1, soit deux millions quatre-vingt-seize mille trois

cent vingt-cinq euros (EUR 2'096’325,-) pour les cent soixante-treize millions deux cent cinquante mille (173'250’000)
actions de catégorie AM1 préexistantes;

- zéro euro et zéro cent vingt-et-un cents (EUR 0,0121) par action BM1, soit vingt-et-un mille cent soixante-quinze

euros (EUR 21’175,-) pour les un million sept cent cinquante mille (1'750’000) actions de catégorie BM1 préexistantes

5. Le délégué à la gestion journalière a constaté que le capital social de la Société a été augmenté à concurrence d’un

montant d’un million neuf cent soixante-dix-sept mille cinq cents euros (EUR 1.977.500,-) et a été porté de sa valeur de
cinq cent soixante-et-un millions cinquante mille et un euros (EUR 561'050’001,-) à cinq cent soixante-trois millions vingt-
sept mille cinq cent un euros (EUR 563.027.501,-), par l’augmentation du nominal de trois euros et deux mille soixante
cents (EUR 3,2060) à trois euros et deux mille cent soixante-treize cents (EUR 3,2173) des cent soixante-quinze millions
(175'000’000) actions préexistantes à concurrence de:

- un million neuf cent cinquante-sept mille sept cent vingt-cinq euros (EUR 1.957.725,-) pour les cent soixante-treize

millions deux cent cinquante mille (173'250’000) Actions de Catégorie AM1 préexistantes;

- dix-neuf mille sept-cent soixante-quinze euros (EUR 19.775,-) pour les un million sept cent cinquante mille (1'750’000)

Actions de Catégorie BM1 préexistantes.

7. Les actions préexistantes de catégorie AM1 et BM1 ont été augmentées de leur nominal de trois euros et deux mille

soixante cents (EUR 3,2060) à trois euros et deux mille cent soixante-treize cents (EUR 3,2173) par le versement comme
indiqué ci-dessous:

- 85'926’575 actions préexistantes de catégorie AM1 et 1'141’175 actions préexistantes de catégorie BM1 par Trief

Corporation S.A., une société anonyme existante et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social 5, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg («Trief»), par un apport en numéraire de neuf cent quatre-vingt-trois
mille huit cent soixante-cinq euros et cinquante-huit cents (EUR 983.865,58);

- 87'062’500 actions préexistantes de catégorie AM1 par Oranje-Nassau Investments B.V., une société de droit néer-

landais, ayant son siège social Rembrandt Tower, 22 

nd

 floor, Amstelplein 1, 1090HC Amsterdam, Pays-Bas («ONI»), par

un apport en numéraire de neuf cent quatre-vingt-trois mille huit cent six euros et vingt-cinq cents (EUR 983.806,25);

- 260’925 actions préexistantes de catégorie AM1 et 608‘825 actions préexistantes de catégorie BM1 par les co-inves-

tisseurs tels que définis en annexe 1 («Co-investisseurs»), par des apports en numéraire de neuf mille huit cent vingt-huit
euros et dix-huit cents (EUR 9.828,18).

7. Il résulte que suite à l’augmentation précitée de la Société que la somme totale d’un million neuf cent soixante-dix-

sept mille cinq cents euros (EUR 1.977.500,-) est à la libre disposition de la Société tel qu’il l’a été prouvé au notaire
soussigné et est comprise dans un montant global d’un million neuf cent soixante-dix-sept mille cinq cents euros (EUR
1.977.500,-) mis à la disposition par les actionnaires, dont la preuve a été rapportée au notaire soussigné, qui la reconnaît
expressément.

8. Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l'Article 5.1 des statuts

est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à cinq cent soixante-trois millions vingt-sept mille cinq cent un euros (EUR 563.027.501,-)

représenté par cent soixante-treize millions deux cent cinquante mille (173'250’000) Actions de Catégorie AM1 et par un
million sept cent cinquante mille (1 750 000) Actions de Catégorie BM1, d’une valeur nominale de trois euros et deux
mille cent soixante-treize cents (EUR 3,2173) chacune et par une (1) part bénéficiaire d’une valeur nominale d’un euro
(EUR 1).»

35938

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme

de 3.050,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuels, état et demeure, ladite

personne comparante a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Jean-Yves HÉMERY, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 décembre 2015. Relation GAC/2015/11745. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Nathalie DIEDERICH.

Référence de publication: 2016001144/86.
(150240480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Finnery Acquisitions IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 197.503.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001086/10.
(150240196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Fisterra Energy Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 178.928.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001090/10.
(150240329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Docarpa Corporation N.V., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 90.668.

L'an deux mille quinze, le huitième jour du mois de décembre.
Par-devant Nous, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue

l'Assemblée Générale Extraordinaire de l’actionnaire unique de la société anonyme "DOCARPA CORPORATION

N.V.", constituée à Curaçao le 25 août 1989 et dont le siège social a été transféré de Curaçao vers le Luxembourg suivant
acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 23 décembre
2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 170 du 18 février 2003 et dont un rectificatif a
été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1314 du 2 décembre 2015.

L'assemblée est présidée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Monique DRAUTH, salariée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gilles WECKER, salarié, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1) Transfert du siège social de la Société du 204, route d’Arlon, L-8010 Strassen au 11, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg;

2) Modification subséquente de l'article 1, 2 

ème

 alinéa et du premier alinéa de l’article 9 des statuts;

3) Divers.

35939

L

U X E M B O U R G

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle est signée par les actionnaires présents, le mandataire des actionnaires représentés, ainsi que par
les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires
singées «ne varietur» par le mandataire des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises
avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est

régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu
connaissance avant la tenue de l'assemblée.

Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 204, route d’Arlon, L-8010 Strassen au 11, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 1 des statuts ainsi que le

premier alinéa de l’article 9 des statuts, qui auront désormais la teneur suivante tant en version française qu'en version
anglaise:

En version française:

«  Art. 1 

er

 . (Alinéa 2 

e

 ).  Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.»

« Art. 9. (Alinéa 1). L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois de juin à 11.00

heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

En version anglaise:

« Art. 1. (Second paragraph). The registered office is established in Luxembourg, grand-Duchy of Luxembourg.»

« Art. 9. (First pagraph). The Annual General Meeting shall be held at the registered office or such other place as indicated

in the convening notices on the last Wednesday in the month of June at 11.00 a.m.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à mille cent euros (1.100.- EUR) sont à charge de la

Société.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Nezar, Drauth, Wecker, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/39246. Reçu soixante-quinze

euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001031/61.
(150240622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

East Capital (Lux) General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 154.914.

In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of December,
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

East Capital Holding AB, a company duly incorporated and existing under the laws of Sweden, corporate registration

number 556584-9899, having the registered address Kungsgatan 30, Box 1364, SE-111 93 Stockholm, Sweden (the “Sole
Shareholder”),

35940

L

U X E M B O U R G

here represented by Maître Philippe Burgener, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a

proxy, given on 11 December 2015.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the Sole Shareholder of East Capital (Lux) General

Partner S.à r.l. (the "Company") having its registered office in 31, Zone d'Activités Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand
Duchy of Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary on July 15, 2010, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 2055 on 1 October 2010.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
I. The Sole Shareholder holds all the one hundred and twenty-five (125) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each,

representing the entire share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), so that the resolution can validly
be taken on all items of the agenda.

II. The Sole Shareholder hereby expressly confirms having full and prior knowledge of the agenda and expressly waives

any prior convening requirements.

III. That the item on which the sole resolution is to be passed is as follows:
1. Amendment of the paragraph 3 of the article 2 of the articles of association of the Company (the "Articles") so as to

read as follows: “The Company may further guarantee, grant loans, grant security in favour of or otherwise assist the
companies, including their employees, in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same
group of companies as the Company.”

The appearing party requested the undersigned notary to record the following resolution which has been taken by the

Sole Shareholder:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the paragraph 3 of the article 2 of the Articles so as to read as follows:
“The Company may further guarantee, grant loans, grant security in favour of or otherwise assist the companies, in-

cluding  their  employees,  in  which  it  holds  a  direct  or  indirect  participation  or  which  form  part  of  the  same  group  of
companies as the Company.”

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto,

the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and French version, the English version shall prevail.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing known to the notary by his name, first name,

civil status and residence, the proxyholder of the appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le onze décembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu

East Capital Holding AB, dûment constituée selon le droit suédois, numéro d'enregistrement 556584-9899, ayant son

siège social à Kungsgatan 30, Box 1364, SE-111 93 Stockholm, Suède («l’Associé Unique»),

représentée par Maître Philippe Burgener, Avocat à la Cour, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu

d'une procuration conférée le 11 décembre 2015, attachée au présent acte.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme prédécrit, déclare être l'Unique Associé de East Capital (Lux) General Partner S.à

r.l. (la «Société») ayant son siège social à 31, Zone d'Activités Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 juillet 2010, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations le 1 octobre 2010 numéro 2055.

I. L'Associé Unique détient toutes les cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant

la totalité du capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), de sorte que les résolutions peuvent être
valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II. L’Associé Unique confirme expressément par la présente avoir eu préalablement connaissance de l’agenda dans son

entièreté et renonce expressément à toute exigence de convocation préalable.

III. Le point sur lequel la résolution doit être prise est le suivant:
1 - Modification du paragraphe 3 de l'article 2 des statuts de la Société (les «Statuts») comme suit: “La Société peut

également garantir, accorder des prêts, accorder des sûretés en faveur de ou assister autrement des sociétés, y compris leurs

35941

L

U X E M B O U R G

employés, dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés
que la Société.»

Le comparant a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes qui ont été prises par l'unique associé:

<i>Résolution Unique

L'Associé Unique décide de modifier le paragraphe 3 de l'article 2 des Statuts comme suit: “La Société peut également

garantir, accorder des prêts, accorder des sûretés en faveur de ou assister autrement des sociétés, y compris leurs employés,
dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la
Société.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé en

anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. BURGENER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40878. Reçu soixante-quinze

euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001035/90.
(150239982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Global Performance 17 S.A., SICAR, Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 5, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 180.980.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 30 décembre 2015.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2016001145/11.
(150240495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Cervia SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35 F, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 200.380.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions des gérants en date du 12 décembre 2015

Les gérants de la Société ont décidé comme suit, de:
- transférer le siège social de la Société au 35 F, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet immédiat.
- transférer le siège social de son gérant associé commandité et de son associé au 35 F, Avenue John F. Kennedy, L-1855

Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Cervia SCSp

Référence de publication: 2016005381/15.
(160004051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

35942

L

U X E M B O U R G

Borasco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 112.827.

En date du 02 Décembre 2015, les gérants de la Société BORASCO S.à r.l. ont décidé son changement d'adresse:
La nouvelle adresse de la société est la suivante:
- Borasco S.à r.l.
13, rue Edward Steichen
I-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Luxembourg.

<i>Pour la société
Manacor (Luxembourg) S.A
<i>Gérant

Référence de publication: 2016005364/17.
(160003918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Bluegems Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: USD 20.001,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 123.528.

Il est notifié qu'en date du 04 janvier 2016 l'associé unique de la Société a pris la décision suivante:
-  transfert  du  siège  social  de  la  Société  du  40,  Avenue  Monterey,  L-2163  Luxembourg,  au  48  Boulevard  Grande-

Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Il est aussi notifié que l'associé unique de la Société a pris acte:
- de la démission de Monsieur Wayne Fitzgerald en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2015;
- de la démission de Monsieur Amine Zouari en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2015;
- de la démission de Monsieur Costas Constantinides en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2015;
L'associé unique de la Société a également décidé de nommer:
- Monsieur Joost Anton Mees, né le 27 septembre 1978 à Delft (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 48, Boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que gérant de la Société avec
effet au 31 décembre 2015 et pour une durée indéterminée;

- Monsieur Robert van 't Hoeft, né le 13 janvier 1958 à Schiedam (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 48,

Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que gérant de la
Société avec effet au au 31 décembre 2015 et pour une durée indéterminée.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- M. Chaim Schechter, gérant;
- M. Joost Anton Mees, gérant;
- M. Robert van 't Hoeft, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bluegems Investments S.à r.l.
Joost A. Mees
<i>Gérant

Référence de publication: 2016005327/30.
(160003952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Brook Green S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.125.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 14, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 193.320.

Dieses Dokument dient dazu die bisher eingeschriebenen Informationen beim Luxemburger Gesellschafts- und Han-

delsregister zu aktualisieren.

35943

L

U X E M B O U R G

- Die Name der alleinigen Gesellschafterin der Gesellschaft, IVG Institutional Funds GmbH, wurde mit Wirkung vom

28. August 2015 geändert in:

* TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 6. Januar 2015.

Brook Green S.à r.l.
Unterschrift

Référence de publication: 2016005334/17.
(160003869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

BCSS SSD Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 198.917.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions adoptées le 15 décembre 2015 par l'associé unique de la Société, BCSS SSD Holding S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à
76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198878, que l'associé unique précité a décidé d'augmenter le nombre des
gérants de la Société de trois à quatre et de nommer Monsieur Michael Blumstein, né le 13 septembre 1956 à New York,
États-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 1114 Avenue of the Americas, 27 

th

 Floor, New York, NY

10036, États-Unis d'Amérique, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de classe A de la
Société.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- Monsieur Richard Munn, gérant de Classe A, ayant son adresse professionnelle au 45, Pall Mall, 4 

ème

 étage, GB -

SW1Y 5JG Londres, Angleterre;

- Monsieur Michael Blumstein, gérant de Classe A, ayant son adresse professionnelle au 1114 Avenue of the Americas,

27 

th

 Floor, New York, NY 10036, États-Unis d'Amérique;

- Monsieur Jean-Philippe Mersy, gérant de Classe B, ayant son adresse professionnelle au 45, rue des Scillas, L-2529

Howald, Luxembourg;

- Monsieur Jean-Claude Lucius, gérant de Classe B, ayant son adresse professionnelle au 45, rue des Scillas, L-2529

Howald, Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 janvier 2016.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2016005344/30.
(160004522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Bhoutan 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 99.721.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 18 décembre 2015

1. L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur:
- Monsieur Marc WALKER, né le 26/03/1963 à Knutsford Cheshire (Royaume-Uni), demeurant professionnellement

à Oakland House, Talbot Road, Old Trafford M16 0PQ Manchester (Royaume-Uni). Le mandat viendra à expiration à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2022.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016005349/13.
(160004427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

35944

L

U X E M B O U R G

Bienne SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.223.

EXTRAIT

Suite à la démission de Monsieur Arsène Kronshagen de ses fonctions d'administrateur par lettre en date du 18 décembre

2015, le Conseil d'administration décide de coopter en son remplacement Monsieur Jérôme Demimuid, employé privé, né
le 14 juillet 1975 à Reims (France), résidant professionnellement au 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Son mandat
viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale de l'an 2016.

Le Conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

au 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

<i>Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2016005351/17.
(160004617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Cira Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 29.168.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 23 septembre 2015

- Conformément à l'article 64(2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration a

décidé de nommer Madame Natalia VENTURINI comme Président du Conseil d'Administration pendant la durée de son
mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2018.

Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Certifié sincère et conforme
CIRA HOLDING S.A.
Signatures

Référence de publication: 2016005424/15.
(160004232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 5.735.

<i>Auszug aus dem Protokoll Ordentliche Generalversammlung vom 29. Oktober 2015

Die Ordentliche Generalversammlung hat folgenden Beschluss einstimmig gefasst:
Ernennung:
Herrn Peter Bömelburg (Verwaltungsratsmitglied)
wohnhaft in D - 48653 COESFELD Südring 32
mit Amtszeit bis zur Ordentlichen Generalversammlung die im Jahr 2021 stattfinden wird.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Foetz, den 28. Dezember 2015.

COMPTOIR PHARMACEUTIQUE LUXEMBOURGEOIS S.A.
Antoine SECK
<i>Directeur général

Référence de publication: 2016005435/18.
(160004894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

35945

L

U X E M B O U R G

Construction Royale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 31, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 54.411.

Il résulte d'une Assemblée Générale Ordinaire du 11 décembre 2015 que Monsieur Eric Man, demeurant à L-1710

Luxembourg, 35, rue Paul Henkes est nommé Commissaire aux Comptes.

Les mandats des administrateurs Mr Man Wah Hing demeurant à L-1710 Luxembourg, 35, rue Paul Henkes de Madame

Chan Shui Ping demeurant à L-1710 Luxembourg, 35, rue Paul Henkes et de Monsieur Jacky Hing Choi Man demeurant
à L- 4995 Schouweiller, 47, rue Grande-Duchesse Charlotte sont prorogés.

Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en l'année 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2015.

Fiduciaire comptable B+C s.à.r.l.

Référence de publication: 2016005437/16.
(160003988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Covidien International Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 123.527.

Il est à noter que l'adresse de M. Michelangelo Stefani est désormais la suivante: 3b Boulevard Prince Henri, L-1724

Luxembourg.

Pour extrait conforme et sincère
Covidien International Finance S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016005441/13.
(160004904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

D.P. Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 148.902.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration tenu le 22 décembre 2015 a décidé d'approuver le transfert du siège social de la société du

1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005451/11.
(160004849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Darden Global Finance 3 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 181.233.

Par résolutions signées en date du 4 janvier 2016, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Carl Bradford Richmond, avec adresse professionnelle au 1000, Darden Center Dr,

FL 32837 Orlando, Florida, États-Unis, de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 22 octobre 2015;

2. Nomination de Ricardo Cardenas, avec adresse professionnelle au 1000, Darden Center Drive, FL 32837 Orlando,

États-Unis, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 22 octobre 2015 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Référence de publication: 2016005456/15.
(160004360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

35946

L

U X E M B O U R G

Dentsply CE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 578.004.569,26.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 150.469.

EXTRAIT

Avec effet au 20 décembre 2015, un changement dans l'actionnariat de la société ci-dessus a eu lieu comme suit:
TDP NT LLC, détenant 57.800.456.926 parts sociales dans la société ci-haut mentionnée, a cédé la totalité de ses parts

à:

Dentsply US Inc., une société constituée selon les lois du Delaware, États-Unis d'Amérique, enregistrée au Registre de

Commerce du Delaware sous le numéro 5888163, avec adresse au 2711 Centreville Rd., Wilmington, DE 19808, États-
Unis d'Amérique.

Dès lors, l'associé unique de la société est à inscrire comme suit:

Dentsply US inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.800.456.926 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2016005459/21.
(160004074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.557.749,00.

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 167.151.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fifteen, on the twentieth day of November.
Before US Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Halliburton U.S. International Holdings, Inc., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, having

its  registered  office  at  The  Corporation  Trust  Center,  1209  Orange  Street,  Wilmington,  Delaware  19801,  New  Castle
County, the United States of America (the “Sole Shareholder”),

duly represented by Mr. Mustafa NEZAR, lawyer, with professional address at 10, Avenue Guillaume, L-1650 Lu-

xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:
- The Sole Shareholder holds all the shares in Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, with registered office at 2B, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg and re-
gistered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg)
under number B 167.151 (the “Company”) incorporated by a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach,
dated February 27, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 948, on April 12,
2012.

- The articles of association of the Company (the “Articles”) have been amended for the last time on October 1 

st

 , 2013,

pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2865, on November 14, 2013.

- The Company's capital is set at two million five hundred fifty-seven thousand seven hundred and forty-nine United

States Dollars (USD 2,557,749.-) represented by two million five hundred fifty-seven thousand seven hundred and forty-
nine (2,557,749) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all fully subscribed and entirely
paid up.

- The Sole Shareholder has full knowledge of the articles of association of the Company and perfectly knows the financial

situation of the Company.

35947

L

U X E M B O U R G

- The Sole Shareholder resolves to proceed with the dissolution of the Company with effect as from the present deed.
- The Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company.
- The Sole Shareholder grants full discharge to the managers of the Company for their mandates from the date of their

respective appointments up to the date of the present meeting.

- The Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the

known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the
assets - including any participation the Company may hold at the time this present deed in any subsidiaries - and hereby
expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular those
hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself.

- The Sole Shareholder waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation)

and to hear a report of an auditor to the liquidation.

- The Company is liquidated and the liquidation is closed; and
- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting

at the registered office of the Company, being 2B, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version shall prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the undersigned notary

by his surname, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Halliburton U.S. International Holdings, Inc., une société constituée selon les lois de l’état du Delaware, ayant son siège

social à The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, New Castle County, Etats-Unis
d'Amérique (l’«Associé Unique»),

ici dûment représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement au 10, Avenue Guillau-

me, L-1650 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au

présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
- L`Associé Unique détient toutes les parts sociales de Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à respon-

sabilité limité de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2B, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand-Duché
de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 167.151 (la «Société»), constituée
par un acte de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, le 27 février 2012,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 948 du 12 avril 2012.

- Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Henri Beck notaire

de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg en date du 1 

er

 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 2865 le 14 novembre 2013.

- Le capital social de la Société est fixé à deux millions cinq cent cinquante-sept mille sept cent quarante-neuf dollars

américains  (2.557.749.-  USD)  représenté  par  deux  millions  cinq  cent  cinquante-sept  mille  sept  cent  quarante-neuf
(2.557.749) parts sociales d'une valeur nominale d’un dollar américain (1.- USD) chacune, toutes entièrement souscrites
et libérées.

- L’Associé Unique a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci.
- Par la présente l`Associé Unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.
- L`Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société.
- L’Associé Unique donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour leur mandat à compter de la date de

leur nomination respectives jusqu'à la date de la présente assemblée.

- L`Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de la Société a été payé ou provisionné, qu’il est investi de tout l’actif - y compris toute participation détenue par la
Société dans ses filiales à la date des présentes - et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant
éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa
personne.

- L`Associé Unique renonce à la formalité de la nomination d'un commissaire à la liquidation et à la préparation d'un

rapport du commissaire à la liquidation.

35948

L

U X E M B O U R G

- Partant la liquidation de la Société est à considérer comme réalisée et clôturée; et
- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la

présente assemblée au siège social de la Société au 2B, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand-Duché de Luxem-
bourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été établi

en anglais, suivi d'une version française et qu’en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version
anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé au Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant, par ses

noms, prénoms usuels, état et demeure, il a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37028. Reçu soixante-quinze

euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Référence de publication: 2016000321/107.
(150240521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Avalon Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 69.750.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder notaire de résidence à L-Mersch, en date du 07 mai 1999,

publié au Mémorial Recueil Spécial C n°547 du 16 juillet 2009.

- Statuts modifiés par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 13 décembre 2010,
publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 954 du 10 mai 2011.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 16 décembre 2015 que:
Suite à la démission de Monsieur Felix FABER de son poste d'administrateur, est nommé en remplacement:
Madame Lada RÖLL, demeurant à Genovevastrasse, 6, D-54675 WALLENDORF, jusqu'à la prochaine assemblée

générale ordinaire qui se tiendra en 2021:

Suite à la démission de la société Revilux en tant que commissaire aux comptes, est nommé en remplacement:
Monsieur Rudolf WILLEMS, demeurant à 9a, rue Gabriel Lippmann, L-5365 MUNSBACH, jusqu'à la prochaine as-

semblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021.

Luxembourg, le 16 décembre 2015.

<i>Pour la société AVALON HOLDING S.A., SPF
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2016005311/21.
(160004660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Avia Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 199.350.

<i>Résolution unique prise en date du 15 décembre 2015

Le Conseil de Gérance a pris acte de la démission de monsieur Philippe Bruneton dans sa fonction de gérant de la société

AVIA PARTNERS S.À R.L. en date du 31 décembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005312/11.
(160004410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

35949

L

U X E M B O U R G

Aya S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 61, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 93.560.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 07 Janvier 2016

S'est réunie ce jour l'assemblée générale extraordinaire de la Société AYA SARL.
L'assemblée, décide à l'unanimité des voix:
Le transfert du siège social de la société au: 61 rue de Merl à L-2146 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société.

Luxembourg, le 07 Janvier 2016.

Pour extrait conforme
LUXDISTRI LTD

Référence de publication: 2016005313/15.
(160005005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Bikecourier, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 4, rue Louis XIV.

R.C.S. Luxembourg B 165.854.

<i>Résolutions

<i>Première résolution

L'associé unique prend acte de la démission de ANDREW EDMONDSTON-LOW, né à Luxembourg, le 12 janvier

1983, demeurant à L-1948 Luxembourg, 4, rue Louis XIV, de ses fonctions de Gérant, à compter du 01/01/2016.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique nomme, en qualité de nouveau Gérant, PHIL SCHEUER, né à Luxembourg, le 21 février 1986, de-

meurant à L-2537 Luxembourg, 1, rue Sigismond, qui accepte.

Le Gérant exercera son mandat dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Luxembourg, le 1 

er

 janvier 2016.

Référence de publication: 2016005353/17.
(160004354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

K.D.T.S., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 20A, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 181.061.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 octobre 2015 au siège social

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs,
- Monsieur Sylvain CHERY, employé privé, né le 25 juillet 1973 à Bar-le-Duc (France), demeurant à F-57950 Montigny-

lès-Metz, 201, rue de Pont-à-Mousson, en tant qu'administrateur;

- Monsieur Pascal CLAUS, employé privé, né le 3 avril 1972 à Thionville (France), demeurant à F-57160 Rozerieulles,

9, rue Jeanne d'Arc, en tant qu'administrateur;

sont reconduits pour une période de 5 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale se tenant en 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AFC Benelux Sàrl
Signature

Référence de publication: 2016004767/18.
(160002659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

35950

L

U X E M B O U R G

Speed'Immat, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3562 Dudelange, 21, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 190.560.

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze.
Le vingt-trois décembre
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

1.- Madame Cyrielle POIRSON, agent administratif, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 2, Impasse de l'Economat.
2.- Monsieur Benjamin DICQUE, mécanicien, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 2, Impasse de l'Economat.
Lesquels comparants sont ici représentés par Madame Sophie BATARDY, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées en date
du 18 décembre 2015,

lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par la mandataire des comparants et le notaire, resteront

annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants représentés comme ci-avant ont requis le notaire instrumentaire de de documenter comme suit

leurs déclarations:

a. Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée SPEED'IMMAT, établie et ayant son siège social

à 21, rue Schiller, L-3562 Dudelange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 190560, (ci-après la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à
Junglinster, en date du 24 septembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
3240 du 4 novembre 2014.

b.  Que  le  capital  de  la  Société  est  actuellement  fixé  à  DOUZE  MILLE  CINQ  CENTS  EUROS  (12.500,00  EUR),

représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de CENT VINGT CINQ EUROS (125,00 EUR) chacune.

c. Que la société ne possède pas d’immeubles ou de parts d’immeuble.
d. Que les Comparants déclarent expressément que la société SPEED'IMMAT n'est impliquée dans aucun litige ou

procès de quelque nature qu'il soit et que les part s sociales ne sont pas mises en gage ou nantissement.

e. Que les comparants, en tant que seuls associés de la Société (les "Associés") déclarent que l’activité de la Société a

cessé et ils prononcent la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation.

f. Que les Associés déclarent avoir pleine connaissance des statuts de la Société et qu'ils connaissent parfaitement la

situation financière de la Société.

g. Que les Associés se désignent comme liquidateurs de la Société.
h. Que les liquidateurs requièrent le notaire instrumentant d’acter qu'ils déclarent que le passif connu de la Société a été

payé ou provisionné.

i. Que les Associés sont investis de tout l'actif et qu'ils s'engagent expressément à prendre à leur charge tout passif

pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour au prorata de sa participation
dans la Société

j. Que, partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
k. Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société pour l'exécution de son mandat.
l. Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins chez Monsieur Benjamin

DICQUE, prénommé, à F-57330 Hettange-Grande, 2, Impasse de l'Economat.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la Société.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. BATARDY, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11696. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): N. DIEDERICH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 31 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001612/55.
(150241046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

35951

L

U X E M B O U R G

BioPharma Credit Investments IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 200.867.

<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 9 décembre 2015

A la suite de plusieurs cessions de parts, les 2.000.000 parts sociales détenues par la société à responsabilité limitée

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., sont dorénavant toutes détenues comme suit:

- 102,500 parts sociales par la société ArvinMeritor, Inc. Retirement Plan, 2135 West Maple Road, Troy, MI 48084,

Etats-Unis d'Amérique, inscrite auprès du registre de commerce de Troy sous le n° 38-3354643;

-  341,600  parts  sociales  par  la  société  Mousserena  LP,  135  South  Church  Street,  George  Town,  Grand  Cayman,

KY1-9005, Cayman Islands,, inscrite auprès du Registrar of Limited Partnerships Cayman Islands sous le n°20443;

- 170,800 parts sociales par la société Alfred I. DuPont Testamentary Trust, 510 Alfred DuPont Place, Jacksonville, FL

32202 Etats-Unis d'Amérique, inscrite auprès du registre de commerce de Floride sous le n° 59-0226560;

- 170,800 parts sociales par la société Regents of the University of Michigan, 101 N Main Street, Suite 525, Ann Arbor,

MI 48104, Etats-Unis d'Amérique, inscrite auprès du registre de commerce du Michigan sous le n° 28-6006309;

- 102,500 parts sociales par la société The Megan S. Tagliaferri Separate Property Trust, 233 Wilshire Blvd, Suite 515,

Santa  Monica,  CA  90401,  Etats-Unis  d'Amérique,  inscrite  auprès  du  registre  de  commerce  de  Californie  sous  le  n°
541-04-1309;

- 34,200 parts sociales par Pablo LEGORRETA, né le 30.10.1963 à Mexico City, Mexique, demeurant à 119 East 79

th

 Street, New York, NY 10075, Etats-Unis d'Amérique;

- 102,500 parts sociales par la société Molly E. McCabe Trust, 233 Wilshire Blvd, Suite 515, Santa Monica, CA 90401,

Etats-Unis d'Amérique, inscrite auprès du registre de commerce de Californie sous le n° 541-04-1323;

- 87,300 parts sociales par la société Danbury Health Systems Pension Plan, 24 Hospital Avenue, Danbury, CT 06810,

Etats-Unis d'Amérique, inscrite auprès du du registre de commerce du Connecticut sous le n° 22-2594977;

- 20,500 parts sociales par la société The Nemours Foundation Pension Plan, 510 Alfred DuPont Place, Jacksonville,

FL 32202 Etats-Unis d'Amérique, inscrite auprès du registre de commerce de Floride sous le n° 56-2059085;

- 102,500 parts sociales par la société YRC Worldwide Inc., Master Pension Plans Trust, 10990 Roe Avenue, Overland

Park, KS 66211, Etats-Unis d'Amérique, inscrite auprès du registre de commerce de Overland Park sous le n° 04-3852884;

- 320,700 parts sociales par la société BioPharma Credit Investments IV (Cayman) LP, 27 Hospital Road, George Town,

Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands, inscrite auprès du Registrar of Limited Partnerships Cayman Islands;

- 341,600 parts sociales par la société Kinsale Financial Services, Dunderrow, Kinsale, County Cork, Ireland, inscrite

auprès du registre de commerce d'Irlande sous le n° 8227010M;

- 102,500 parts sociales par la société The JPB Foundation, 9 West 57 

th

 Street, 38 

th

 Floor, New York, NY 10019, Etats-

Unis d'Amérique, inscrite auprès du registre de commerce de New York sous le n° 90-0747216.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BioPharma Credit Invesmtents IV, S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2016000893/41.
(150240875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Cavaliere Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 1, cote d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 177.063.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2015.

Référence de publication: 2016000934/10.
(150240268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

35952


Document Outline

Avalon Holding S.A., SPF

Avia Partners S.à r.l.

Aya S.à r.l.

BCSS SSD Investment S.à r.l.

Bhoutan 4 S.A.

Bienne SA

Bikecourier

BioPharma Credit Investments IV, S.à r.l.

Bluegems Investments S.àr.l.

Borasco S.à r.l.

Brennholz vum Wolef S.à r.l.

Brook Green S.à r.l.

Cavaliere Holdings S.à r.l.

Cervia SCSp

Cira Holding S.A.

Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois S.A.

Construction Royale S.A.

Covidien International Finance S.A.

Darden Global Finance 3 S.àr.l.

Dentsply CE S.à r.l.

Docarpa Corporation N.V.

D.P. Consulting S.A.

East Capital (Lux) General Partner S.à r.l.

Ecurie Paradis Luxembourg SA

Engenia S.A.

Expansion 17 S.A., SICAR

Expansion 17 S.A., SICAR

Finnery Acquisitions IV S.à r.l.

Fisterra Energy Luxembourg II S.à r.l.

Global Performance 17 S.A., SICAR

Global Performance 17 S.A., SICAR

Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l.

Intesa Sanpaolo Holding International S.A.

Italinvest Real Estate S.A. SICAV-SIF

K.D.T.S.

Misys Europe

Senvion S.à r.l.

Sigma Lux, S.à r.l.

Speed'Immat

Turaz Global TRM S.à r.l.