logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 684

8 mars 2016

SOMMAIRE

1798 US Special Situations Master Fund  . . . .

32821

AA Iberian Natural Resources & Tourism S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32830

Agramunt GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32831

Agramunt SCSp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32831

Agrifinco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32831

ArcelorMittal Rodange et Schifflange  . . . . . . .

32786

ArcelorMittal Rodange et Schifflange  . . . . . . .

32789

ArcelorMittal Rodange et Schifflange  . . . . . . .

32787

Backstein Finanzgesellschaft A.G.  . . . . . . . . . .

32786

Banque de Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32821

Baumann and Partners - Premium Select . . . .

32820

B Medical Systems Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

32799

B Medical Systems Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

32817

Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32786

Brixton 3 Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32821

Bundesverband Investmentkraft S.A.  . . . . . . .

32822

CaixaBank Global SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . .

32822

Candle LuxCo 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32824

Cervia GP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32822

Citibank International Limited (Luxembourg

Branch)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32823

Clover Investments Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32823

C.M. Transports S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32822

Colt Group S.A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32823

Colt Lux MP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32824

Concrete Investment II S.C.A.  . . . . . . . . . . . . .

32824

e-conomic international MidCo S.à r.l.  . . . . . .

32830

Fiducis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32832

GEFIP INVEST  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32830

Generali European Real Estate Investments

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32788

Global Advantage Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32790

Gunco Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32793

Irma Finances Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32825

KHM SP Neuhauser Straße 20 Beteiligung S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32832

King George Holdings Luxembourg IIA S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32832

Konnick Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32787

L'Hautain Chat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32790

Mateco Location de Nacelles S.A.  . . . . . . . . . .

32793

PNR Global (ex-Japan) Aggregate Bond  . . . .

32803

Rue Elisabeth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32791

RUE ELISABETH S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

32791

Strategie Pro Rendite SICAV-FIS  . . . . . . . . . .

32821

32785

L

U X E M B O U R G

Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch, Société Anonyme.

Siège social: L-9214 Diekirch, 1, rue de la Brasserie.

R.C.S. Luxembourg B 96.275.

Les porteurs de parts sociales de la société sont invités à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra 1, rue de la Brasserie à Diekirch, le mercredi <i>23 mars 2016 à 17 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Communication des rapports du Conseil d'administration et du réviseur d'entreprise sur l'exercice 2015.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d'entreprise.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination d'un réviseur d'entreprise pour la vérification des comptes sociaux de l'exercice 2016.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016074483/17.

ArcelorMittal Rodange et Schifflange, Société Anonyme.

Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, boulevard Aloyse Meyer.

R.C.S. Luxembourg B 10.643.

Les actionnaires de la société anonyme ArcelorMittal Rodange et Schifflange, immatriculée au Registre du Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10643 (ci-après, la " Société "), sont invités à assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>17 mars 2016 à partir de 12h00 au bâtiment de l'AOB situé au 66, RUE DE LUXEMBOURG,

L-4221 Esch-sur-Alzette.

Les actionnaires sont invités à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Vote spécial conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales concernant

la continuité de l'entreprise.

Pour assister à cette assemblée, les Actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de l'article 27 des statuts.
Les propriétaires de titres nominatifs qui désirent prendre part à l'assemblée générale doivent aviser la Société six jours

francs au moins avant la date de l'assemblée (soit au plus tard le jeudi 10 mars 2016) de leur intention de se prévaloir de
leurs titres et se présenteront à l'assemblée munis de leurs certificats d'inscription nominative.

Les propriétaires de titres au porteur auront à justifier du dépôt de leurs titres six jours francs au moins avant la date de

l'assemblée (soit au plus tard le jeudi 10 mars 2016), soit au siège social de la Société, soit dans l'un des établissements
suivants au Luxembourg :

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
ARENDT SERVICES SA
CLEARSTREAM BANKING, S.A. LUXEMBOURG
Il  est  rappelé  aux  actionnaires  qu'en  vertu  de  l'article  26  des  statuts  "  Tout  Actionnaire  peut  se  faire  représenter  à

l'Assemblée Générale par un mandataire spécial, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait droit d'assister
à l'Assemblée ". Les procurations éventuelles devront être déposées au siège social de la Société au plus tard le jeudi 10
mars 2016.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016070191/30.

Backstein Finanzgesellschaft A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.

R.C.S. Luxembourg B 93.219.

Il a été décidé le transfert du siège social de la société du 4A, Rue Henri Schnadt L-2530 Luxembourg au 16, Rue

d'Epernay L-1490 Luxembourg avec effet au 28.12.2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

32786

L

U X E M B O U R G

<i>L'Administrateur Unique

Référence de publication: 2016001853/11.
(160000118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

ArcelorMittal Rodange et Schifflange, Société Anonyme.

Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, boulevard Aloyse Meyer.

R.C.S. Luxembourg B 10.643.

Les actionnaires de la société anonyme ArcelorMittal Rodange et Schifflange, immatriculée au Registre du Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10643 (ci-après, la " Société "), sont invités à assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 17 mars 2016 à partir de 11h00 au bâtiment de l'AOB situé au 66, RUE DE LUXEMBOURG,

L-4221 Esch-sur-Alzette.

Les actionnaires sont invités à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et attestation du Réviseur d'Entreprises sur les comptes clôturés au

31 décembre 2015 ;

2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2015 ;
3. Affectation du résultat ;
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice 2015 ;
5. Désignation d'un Réviseur d'Entreprises pour l'exercice 2016 ;
6. Nomination d'administrateurs;
7. Divers.

Pour assister à cette assemblée, les Actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de l'article 27 des statuts.
Les propriétaires de titres nominatifs qui désirent prendre part à l'assemblée générale doivent aviser la Société six jours

francs au moins avant la date de l'assemblée (soit au plus tard le jeudi 10 mars 2016) de leur intention de se prévaloir de
leurs titres et se présenteront à l'assemblée munis de leurs certificats d'inscription nominative.

Les propriétaires de titres au porteur auront à justifier du dépôt de leurs titres six jours francs au moins avant la date de

l'assemblée (soit au plus tard le jeudi 10 mars 2016), soit au siège social de la Société, soit dans l'un des établissements
suivants au Luxembourg :

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
ARENDT SERVICES SA
CLEARSTREAM BANKING, S.A. LUXEMBOURG
Il  est  rappelé  aux  actionnaires  qu'en  vertu  de  l'article  26  des  statuts  "  Tout  Actionnaire  peut  se  faire  représenter  à

l'Assemblée Générale par un mandataire spécial, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait droit d'assister
à l'Assemblée ". Les procurations éventuelles devront être déposées au siège social de la Société au plus tard le jeudi 10
mars 2016.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016070192/36.

Konnick Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 32.270.

Nous avons l'honneur d'informer les actionnaires qu'ils sont convoqués, <i>le 16 mars 2016 , à 10 heures, au siège social,

en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

tenue extraordinairement, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

• Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos

le 31 décembre 2014, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes,

• Affectation du résultat
• Questions diverses

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2016070196/16.

32787

L

U X E M B O U R G

Generali European Real Estate Investments S.A., Société Anonyme - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.362.

In the year two thousand and fifteen,
on the tenth day of the month of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

is held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of Generali European Real Estate Investments

S.A. (the "Company"), a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the provisions of the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time, and qualifying as a specialised investment
fund (fonds d'investissement spécialisé) under the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as
amended from time to time, having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg and registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under the number B 121.362, incorporated
pursuant to a notarial deed drawn up notary Jean-Joseph WAGNER, prenamed, dated 17 November 2006, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial") on 29 November 2006, number 2236 (the "Articles of
Incorporation") and amended for the last time pursuant to a deed drawn up by the undersigned notary dated 26 November
2014, published in the Memorial on 19 January 2015, number 142.

The Meeting was opened at 3.00 p.m. by Mr Willy Fiorucci, employee, professionally residing in Luxembourg, having

been appointed chairman, who appointed as secretary Mr Kristof Meynaerts, Avocat au Barreau de Bruxelles, professionally
residing in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Mr Christophe Proffit, employee, professionally residing in Luxembourg.
The Board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I.- A convening notice reproducing the agenda of the present meeting was sent by registered mail to each of the registered

shareholders of the Company on 30 November 2015 in accordance with article 22 of the articles of incorporation of the
Company, so that the Meeting is properly constituted and can validly consider all items of the agenda.

II.- The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, after been signed "ne varietur" by the shareholders, the proxy-
holders of the represented shareholders, the board of the Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed. The proxies of the represented shareholders after been signed by the board of the Meeting and the undersigned
notary will also remain annexed to the present deed.

III.- It appears from the attendance list that one million seven hundred fifty-one thousand one hundred seventy-four

(1,751,174) registered shares, representing ninety-six point zero seven percent (96.07%) of the share capital of the Company
are present or represented at this extraordinary general meeting, so that the quorum requirement of fifty percent (50%) of
the capital as imposed by article 67-1 of the Luxembourg law of 15 August 1915 on commercial companies, as amended,
is met and that the meeting can therefore validly deliberate on the proposed agenda.

IV.- That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

1. Approval of (i) the cancellation of 317,022 Class A Shares in the Generali European Real Estate Investments S.A. -

GREF Compartment, (ii) the decrease of the share capital of the Company by an amount of one million four hundred ninety-
nine thousand five hundred fourteen euro and six Euro cents (EUR 1,499,514.06) corresponding to the nominal value of
the cancelled shares of the Class A Shares in the Generali European Real Estate Investments S.A. - GREF Compartment,
(iii) the granting of power to any two directors of the Company to proceed with all actions in connection to the payments
of the distributions, and (iv) the amendment to article 5.1 of the articles of incorporation of the Company, which shall read
as follows:

"The Company has a subscribed share capital of seven million one hundred twenty four thousand four hundred forty-

five euros and sixty-six euro cents (EUR 7,124,445.66) divided into one million one hundred and forty-nine thousand two
hundred and nineteen (1,149,219) fully paid up redeemable Class A Shares in the Generali European Real Estate Invest-
ments  S.A.  -  GREF  Compartment  and  two  hundred  and  fifty-six  thousand  eight  hundred  and  eighty-one  (256,881)
redeemable Class A Shares in Generali European Real Estate Investments S.A. - Generali Real Estate Crossborder Equity
and ninety-nine thousand six hundred and twenty-five (99,625) redeemable Class A Shares in Generali European Real
Estate Investments S.A. - Generali Real Estate Crossborder Debt, all with a par value of four Euro and seventy-three
Eurocents (EUR 4.73) per Share."

2. Miscellaneous
After deliberation, the following resolutions were taken by the Meeting:

32788

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Meeting RESOLVES to approve (i) the cancellation of three hundred seventeen thousand and twenty-two (317,022)

Class A Shares in the Generali European Real Estate Investments S.A. - GREF Compartment and (ii) the decrease of the
share capital of the Company by an amount of one million four hundred ninety-nine thousand five hundred fourteen euros
and six Eurocents (EUR 1,499,514.06) corresponding to the nominal value of the cancelled shares of the Class A Shares
in the Generali European Real Estate Investments S.A. - GREF Compartment, (iii) the granting of power to any two directors
of the Company to proceed with all actions in connection to the payments of the distributions.

<i>Second resolution

In order to reflect points (i) to (iii) decided by the fist resolution taken here above, the Meeting RESOLVES to amend

article 5.1 of the articles of incorporation of the Company, which shall read as follows:

Art. 5.1. "The Company has a subscribed share capital of seven million one hundred twenty four thousand four hundred

forty-five euros and sixty-six euro cents (EUR 7,124,445.66) divided into one million one hundred and forty-nine thousand
two hundred and nineteen (1,149,219) fully paid up redeemable Class A Shares in the Generali European Real Estate
Investments S.A. - GREF Compartment and two hundred and fifty-six thousand eight hundred and eighty-one (256,881)
redeemable Class A Shares in Generali European Real Estate Investments S.A. - Generali Real Estate Crossborder Equity
and ninety-nine thousand six hundred and twenty-five (99,625) redeemable Class A Shares in Generali European Real
Estate Investments S.A. - Generali Real Estate Crossborder Debt, all with a par value of four Euro and seventy-three
Eurocents (EUR 4.73) per Share."

Nothing else being on the agenda and no other person wished to speak, the Chairman closed the Meeting at 3.15 p.m..

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English only, in accordance with article 26 of the Luxembourg law of 13 February
2007 relating to specialised investment funds, as amended.

The document having been read to the appearing Members of the Board of the Meeting, known to the notary by their

surnames, names, civil status and residences, said persons signed together with Us, undersigned notary, the present original
deed.

Signé: W. FIORUCCI, K. MEYNAERTS, C. PROFFIT, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 décembre 2015. Relation: EAC/2015/29679. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2016074723/88.
(160039491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

ArcelorMittal Rodange et Schifflange, Société Anonyme.

Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, boulevard Aloyse Meyer.

R.C.S. Luxembourg B 10.643.

Les actionnaires de la société anonyme ArcelorMittal Rodange et Schifflange, immatriculée au Registre du Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10643 (ci-après, la " Société "), sont invités à assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>17 mars 2016 à partir de 10h00 au bâtiment de l'AOB situé au 66, RUE DE LUXEMBOURG,

L-4221 Esch-sur-Alzette.

Les actionnaires sont invités à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Réduction de capital conformément à la loi du 28 juillet 2014 sur l'immobilisation des actions et parts au porteur.

Pour assister à cette assemblée, les Actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de l'article 27 des statuts.
Les propriétaires de titres nominatifs qui désirent prendre part à l'assemblée générale doivent aviser la Société six jours

francs au moins avant la date de l'assemblée (soit au plus tard le jeudi 10 mars 2016) de leur intention de se prévaloir de
leurs titres et se présenteront à l'assemblée munis de leurs certificats d'inscription nominative.

Les propriétaires de titres au porteur auront à justifier du dépôt de leurs titres six jours francs au moins avant la date de

l'assemblée (soit au plus tard le jeudi 10 mars 2016), soit au siège social de la Société, soit dans l'un des établissements
suivants au Luxembourg :

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
ARENDT SERVICES SA
CLEARSTREAM BANKING, S.A. LUXEMBOURG

32789

L

U X E M B O U R G

Il  est  rappelé  aux  actionnaires  qu'en  vertu  de  l'article  26  des  statuts  "  Tout  Actionnaire  peut  se  faire  représenter  à

l'Assemblée Générale par un mandataire spécial, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait droit d'assister
à l'Assemblée ". Les procurations éventuelles devront être déposées au siège social de la Société au plus tard le jeudi 10
mars 2016.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016070193/29.

L'Hautain Chat S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 178.342.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>17 mars 2016 à 14.30 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes

pour l'exercice clos au 31 décembre 2015,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016071335/833/18.

Global Advantage Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 42.433.

We are pleased to invite you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the shareholders (the "Meeting"), of Global Advantage Funds (the "Company") which will be held on <i>29 March

<i>2016 at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Allocation of results and approval of the annual report including the Chairman's Statement, the report of the Auditor

and the balance sheet and profit &amp; loss account as of 31 December 2015.

2. Discharge to be granted to the directors of the Company with respect to the performance of their duties during the

financial year ended 31 December 2015.

3. Re-election of the following persons as directors of the Company until the next annual general meeting to be held

in 2017:
- Mr. Michael Keppler,
- Mr. Wolfgang Hoetzendorfer,
- Mr. William Derek Russell Street

4. Re-election of PricewaterhouseCoopers Société cooperative as Auditor of the Company to hold office until the next

annual general meeting to be held in 2017.

5. Any others business which may be properly brought before the Meeting.

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the decisions will be taken

at the majority vote of the shares represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at
any Meeting by proxy.

The annual report including the Chairman's Statement, the report of the Auditor and the balance sheet and profit &amp; loss

account as of 31 December 2015, can be obtained upon request at the registered office of the Company by fax: + 352 46
40 10 413 or by e-mail at: Luxembourg-Finrep3@statestreet.com

Should you not be able to attend this meeting, kindly complete, date, sign and return the form of proxy no later than 72

hours before the meeting by fax to the attention of the Domiciliary Department at number +352 46 40 10 413 or/and by e-
mail at Luxembourg-Domiciliary@statestreet.com , or by mail to the registered office.

<i>By order of the board of directors of the Company

Référence de publication: 2016075086/755/33.

32790

L

U X E M B O U R G

RUE ELISABETH S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Rue Elisabeth).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, IMPASSE DROSBACH.

R.C.S. Luxembourg B 203.262.

L’an deux mille quinze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Edgard ROTTIE, demeurant à B-2970 Schilde, 21, Biekenschei,
2. Madame Natalia SIKOURSKAIA, demeurant à B-2970 Schilde, 21, Biekenschei,
Les deux ici représentés par Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319

Luxembourg, En vertu de deux procurations sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant en leurs qualités de seuls et unique associés actuels de la société civile immobilière Rue

Elisabeth, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach, constituée suivant acte reçu sous seing privé
en date du 30 mars 2012, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 1156 du 8 mai 2012, ont déclaré se réunir en
assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1) Transformation de la forme juridique de la Société en société à responsabilité limitée.
2) Fixation du capital social.
3) Changement du nom de la Société.
4) Refonte des statuts avec modification de l’objet social.
5) Nominations statutaires.
6) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de transformer conformément à la faculté prévue à l’article 3 de la loi sur les sociétés commerciales

la Société en société à responsabilité limitée sans changement de la personnalité juridique de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de fixer le capital social de la société à responsabilité limitée à EUR 12.500.- (douze mille cinq

cents) parts sociales divisé en cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

1. Monsieur Edgard ROTTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2. Madame Natalia SIKOURSKAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Il résulte d’une situation intérimaire de la Société, au 21 décembre 2015 ci-annexée, que les capitaux propres de la

Société sont au moins égaux au montant de son capital social de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros).

<i>Troisièmes résolution

L’Assemblée décide de changer le nom de la Société en RUE ELISABETH S.à r.l.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «RUE ELISABETH S.à r.l.».

Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente, respectivement la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou

parts d’immeubles qu’elle pourra acquérir, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social et pouvant en faciliter l’extension et le développement.

La société a encore pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute

32791

L

U X E M B O U R G

autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux actionnaires et aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances
ou garanties.

La  société  pourra  également  accomplir  toutes  opérations  commerciales,  industrielles  ou  financières,  ainsi  que  tous

transferts de propriété immobilières ou mobilières.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) divisé en cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune.

Art. 6. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé.

Art. 8. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée générale des associés,

laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’ac-
complissement de son objet social.

En cas de gérant unique, la société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique et en

cas de pluralité de gérants, les pouvoirs de signature seront déterminés par l’assemblée générale des associés/par l’associé
unique lors de la nomination des gérants.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont consignées dans un registre

tenu au siège social.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 15.  L'excédent  favorable  du  bilan,  déduction  faite  des  charges  sociales,  amortissements  et  moins-values  jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions

légales.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme gérant unique:
NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant.

<i>Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes est évalué approximativement à la somme de EUR 2.500.-

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

32792

L

U X E M B O U R G

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 28 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41972. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 janvier 2016.

Référence de publication: 2016056245/110.
(160015017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Gunco Invest, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000.000,00.

Siège social: L-1113 Luxembourg, 12A, rue John L. Mac Adam.

R.C.S. Luxembourg B 173.589.

Mateco Location de Nacelles S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 135.000,00.

Siège social: L-1113 Luxembourg, 12A, rue John L. Mac Adam.

R.C.S. Luxembourg B 56.496.

In the year two thousand and sixteen, on the first day of March.
Before us, Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) the board of managers of Gunco Invest, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly

incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 12A, rue
J.L. Mac Adam, L-1113 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 173.589 and having a share capital of
thirty million euros (EUR 30,000,000,-) incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
on December 5, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 246 on February
1, 2013, which articles of association have been subsequently amended and for the last time by a deed of Maître Patrick
Serres, notary residing in Remich, on September 29, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions under number 3269 on December 4, 2015,

here represented by Mr. Mustafa NEZAR, lawyer, with professional address at 10, Avenue Guillaume, L-1650 Luxem-

bourg, Grand-Duchy of Luxembourg, acting as representative duly authorized and empowered by resolutions of the board
of managers taken on February 29, 2016 (hereinafter, the "Absorbing Company"),

2) the board of directors of MATECO LOCATION DE NACELLES S.A., a public company limited by shares (société

anonyme) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office
at 12A, Rue J.L. Mac Adam, L-1113 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 56.496 and having a
share capital of one hundred thirty-five thousand euros (EUR 135,000,-) incorporated by a deed of Maître Frank Molitor,
notary then residing in Mondorf-les-Bains, on October 4, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under number 649 on December 13, 1996, which articles of association have been subsequently amended and
for the last time by a deed of Maître Patrick Serres, notary residing in Remich, on May 21, 2013, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1754 on July 22, 2013,

here represented by Mr. Mustafa NEZAR, prenamed, acting as representative duly authorized and empowered by re-

solutions of the board of directors taken on February 29, 2016 (hereinafter, the "Absorbed Company").

Copies of the minutes of the meeting of the board of managers of the Absorbing Company and of the board of directors

of the Absorbed Company, having been signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned
notary shall remain appended to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, represented as here above stated, have required the undersigned notary to record the following:
The board of managers and board of directors of the abovementioned companies have agreed by resolutions taken on

February 29, 2016 on the following common terms of merger:

COMMON TERMS OF SIMPLIFIED MERGER

(PROJET COMMUN DE FUSION SIMPLIFIEE)

BETWEEN:
1) Gunco Invest, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incorporated and validly

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 12A, rue J.L. Mac Adam, L-1113

32793

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 173.589 and having a share capital of thirty million euros
(EUR 30,000,000,-) (hereafter the "Absorbing Company"), and

2) MATECO LOCATION DE NACELLES S.A., a public company limited by shares (société anonyme) duly incor-

porated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 12A, Rue J.L.
Mac Adam, L-1113 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 56.496 and having a share capital of
one hundred thirty-five thousand euros (EUR 135,000,-) (hereafter the " Absorbed Company").

The Absorbing Company and the Absorbed Company are hereinafter collectively referred to as the "Merging Parties"

or the "Companies".

WHEREAS:
(A) The Absorbing Company has a fully paid up share capital of thirty million euros (EUR 30,000,000,-) represented

by thirty thousand (30,000) shares having a par value of one thousand euros (EUR 1,000,-) each.

(B) The Absorbed Company has a fully paid up share capital of one hundred thirty-five thousand euros (EUR 135,000,-)

represented by five thousand two hundred fifty (5,250) shares without par value.

(C) For sound economic and commercial reasons, the respective board of managers and board of directors of the Com-

panies  proposed  to  their  respective  sole  shareholder  to  proceed  to  a  merger  between  the  Absorbed  Company  and  the
Absorbing Company (the “Merger”).

(D) Considering that the Absorbing Company holds one hundred percent (100%) of the share capital of the Absorbed

Company, the Merging Parties have decided to perform the Merger pursuant to the simplified merger procedure set forth
by Articles 278 and sub. of the Luxembourg law of August 10 1915 on commercial companies, as amended (the "Companies
Law").

(E) The present notarial deed is passed in full compliance with the requirements of Article 271 of the Companies Law.
Thereupon, the following has been acknowledged and agreed among the Merging Parties:

1. Ownership of shares. The Merging Parties hereto acknowledge that the Absorbing Company owns all of the issued

shares and related voting rights of the Absorbed Company.

2. Merger. The Absorbing Company hereby wishes to absorb the Absorbed Company with a retroactive accounting

effect as of October 1 

st

 , 2015 (the “Accounting Effective Date”).

As of the Accounting Effective Date, all operations and transactions of the Absorbed Company will be considered for

accounting and tax purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company.

Whereas between the parties, the Merger shall be enforceable on the date on when the undersigned notary shall enact

the sole shareholder’s meeting to be held at the level of the Absorbing Company, towards third parties, the Merger shall
be enforceable upon publication of the sole shareholder’s meeting to be held at the level of the Absorbing Company, which
in both cases shall take place at least one month after the date of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations of the present common terms of simplified merger (the “Corporate Effective Date”).

As a result of the Merger, the Absorbed Company will be dissolved without liquidation, its shares will be cancelled and

all of its assets and liabilities will be transferred at their net book value to the Absorbing Company.

The transfer includes all the assets whose book value amounts as of September 30, 2015 to four million two hundred

seven thousand four hundred forty-eight euros (EUR 4,207,448,-) as described in the annual accounts dated September 30,
2015. The existing liabilities of the Absorbed Company as of September 30, 2015 and which the Absorbing Company
accepts to take over and pay on behalf of the Absorbed Company amount to seven hundred seventy-nine thousand one
hundred seventy-five euros (EUR 779,175,-) as described in the annual accounts dated September 30, 2015.

As a result of the foregoing, the net contributions made by the Absorbed Company to the Absorbing Company represents

a positive amount of three million four hundred twenty-eight thousand two hundred seventy-three euros (EUR 3,428,273,-)
which amount is equal to the net equity of the Absorbed Company. The net equity of the Absorbed Company of three
million four hundred twenty-eight thousand two hundred seventy-three euros (EUR 3.428.273,-) less the book value of all
the shares held by the Absorbing Company in the Absorbed Company amounting to five million five hundred seventy-one
thousand nine hundred sixty-six euros (EUR 5.571.966,-), will be considered as a merger difference amounting to two
million one hundred forty-three thousand six hundred ninety-three euros (EUR 2.143.693,-).

The Merger will include all the assets and rights referred to above such as they stand on the date of completion of the

Merger.

The Absorbed Company guarantees the value of the net assets contributed on the date of completion of the Merger.
The Absorbing Company will carry out all agreements and obligations of whatever kind of the Absorbed Company,

such as these agreements and obligations exist on the Corporate Effective Date and in particular those existing with the
creditors of the Absorbed Company, and will be subrogated to all rights and obligations there under.

The  Absorbing  Company  will  carry  out,  in  particular,  the  employment  contracts  concluded  with  the  Absorbed

Company’s employees, including temporary employment contracts, in accordance with Articles L 127-1 and seq. of the
Luxembourg Labor Code relating to transfer of undertakings (transfert d'entreprises).

32794

L

U X E M B O U R G

The Absorbing Company will take over all liabilities of any kind whatsoever, of the Absorbed Company and pay in

particular principal and interest on all debts due by the Absorbed Company as of the Corporate Effective Date.

As of the Corporate Effective Date, the Absorbing Company will pay all taxes, contributions, duties and assessments,

whether ordinary or extraordinary, due or that may become due with respect to the property of the assets transferred.

Pursuant to the provisions of article 268 of the Companies Law, the creditors of the Companies, whose receivable exists

before the date of publication of effectiveness of this merger proposal will be able to request to a judge the creation of a
security within the two months following such date of publication of a statement of effectiveness of Merger if the Merger
makes such protection necessary.

3. Reports. Pursuant to provisions of Article 278 of the Companies Law, the common merger plan will not be subject

to (i) an examination and a written report to the shareholders carried out by a qualified auditor and (ii) a detailed written
report to be issued by the management bodies of each of the Absorbing Company and the Absorbed Company.

4. Date from which the Absorbing Company will dispose of the assets of the Absorbed Company and assume all its

liabilities. The Merging Parties acknowledge and agree that as from the Corporate Effective Date, the Absorbing Company
will be the sole and full owner of and may dispose over the assets of the Absorbed Company and will assume all of its
liabilities  pay  off  its  creditors  and  execute  all  ongoing  agreements  of  the  Absorbed  Company.  The  rights  and  claims
comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred to the Absorbing Company with all securities, in
rem or in personam, attached thereto.

The Absorbed Company undertakes neither to dispose of any assets nor to take any action that could jeopardize the

Merger until the Corporate Effective Date.

5. Special rights and advantages. The Absorbing Company does not grant special rights to its sole shareholder or holders

of securities, if any.

No special advantage is granted to the members of the board of directors or board of managers, the day-to-day director

or managers or to the statutory auditors of the Merging Parties.

6. Termination of mandates and discharge. The mandates of the directors, the day-to-day director and the statutory

auditor of the Absorbed Company will be terminated with effect on the Corporate Effective Date, and the Absorbing
Company, in its capacity as sole shareholder of the Absorbed Company hereby, grants discharge to the directors, the day-
to-day director and the statutory auditor of the Absorbed Company for the performance of their respective mandates until
the date hereof.

7. Information of the shareholders of the Merging Parties (Article 267 of the Companies Law). The shareholders of the

Merging Parties will have, during the month following the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations of the common merger terms, access at the registered office of the Merging Parties to all documents listed in Article
267 (1) a) and b) of the Companies Law, as follows:

- the present common terms of merger; and
- the annual accounts and the management reports of the Merging Parties for the last three financial years.
A full or partial copy of the documents listed above may be obtained by the shareholders of the Merging Parties upon

request and free of charge.

Where a shareholder of the Merging Parties has consented to the use by the Companies of electronic means for conveying

information, such copies may be provided by electronic mail.

8. Validity and execution of the common merger terms. These common terms of merger are valid as per their approval

and execution by the respective board of managers and board of directors of the Merging Parties.

The Merging Parties undertake to take all necessary actions in order to effect the Merger without delay and to cooperate

as far as necessary, in particular by issuing all documents and giving all information required by the undersigned notary
and public authorities.

The respective board of managers and board of directors of the Merging Parties are hereby given full authority to amend

these  common  merger  terms  to  the  extent  required  by  the  competent  authorities  and/or  registries,  provided  that  such
amendments do not substantially change the goal and characteristics of the Merger, as above described.

9. Bookkeeping of the Absorbed Company. The books and records of the Absorbed Company (including related archives,

originals of all deeds, agreements, accounting documents, and titles of ownership) will be kept at the registered office of
the Absorbing Company for a period of five years starting on the Corporate Effective Date.

10. Effectiveness and consequences of the Merger.  The  Absorbing  Company  is  the  owner  of  all  the  shares  of  the

Absorbed Company, so that no increase of share capital of the Absorbing Company is required. As the conditions of Article
279 of the Companies Law have been fulfilled, the Merger needs not to be approved by the general meeting of shareholders
of the Companies.

Considering the foregoing and provided that no extraordinary general meeting of the Absorbing Company is convened

in order to decide on the Merger, the Merger shall become effective and final on the Corporate Effective Date and will
simultaneously carry the legal effects set out in Article 274 of the Companies Law.

32795

L

U X E M B O U R G

However, it is recalled that the board of managers of the Absorbing Company convened its sole shareholder, through

resolutions dated February 29, 2016, to an extraordinary general meeting to be held before the undersigned notary or any
other Luxembourg notary in order to approve the Merger described in the present common terms and to approve during
this extraordinary general meeting, the proposition of the board of managers of the Absorbing Company to proceed to (i)
the modification of the Company’s denomination, (ii) the transfer of the Company’s registered office and (iii) the amend-
ment of the Company’s corporate object. It is further reported that the sole shareholder shall appoint M. Laurent Planche
as new manager of the Absorbing Company at the occasion of this extraordinary general meeting of the sole shareholder
of the Absorbing Company.

As a result of the Merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its issued shares shall be immediately

cancelled.

11. Formalities. The Absorbing Company shall:
- carry out all the legal formalities, including such announcements as are prescribed by law relating to the transfers made

in the framework of the Merger;

- perform the formalities and notifications necessary with all relevant administrative matters in order to put all assets

and commitments of the Absorbed Company in its name and on its behalf;

- carry out any formality required by law or deemed necessary or useful to render the transfer of goods and rights

enforceable towards third parties.

For information purposes, the conditions set forth in Article 279 of the Companies Law are listed below:
- the publication provided by Article 262 of the Companies Law has been made regarding the Merging Parties at least

one month before the operation takes effect between the said parties;

- the shareholder of the Absorbing Company is entitled at least one month before the Merger has become effective, to

inspect at the registered office of the Absorbing Company, the documents and information referred to in Article 267 (1) a)
and b) of the Companies Law;

- the shareholder of the Absorbing Company is entitled, at least one month before the operation takes effect, to require

that a general meeting be called in order to resolve on the approval of the Merger. The meeting must be convened so as to
be held within one month as of the request for it to be held.

12. Fees and duties. Any charge, duties or fees owing as a result of the Merger shall be borne by the Absorbing Company.
In accordance with Articles 271(2) of the Companies Law, the notary acting in this matter declares that she certifies and

attests the existence and legality of the common merger terms and of all acts, documents and formalities incumbent of the
Merging Parties pursuant to the Companies Law.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the proxy holder, the

present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same proxy holder and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail between the parties.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned in the beginning of this

document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, known to the Notary by his surname, first

name, civil status and residence, the said proxy holder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

PROJET COMMUN DE FUSION SIMPLIFIE

ENTRE:
1) Gunco Invest, une société à responsabilité limitée constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au

12A, Rue J.L. Mac Adam, L-1113 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173.589 et ayant un capital social de trente millions d’euros
(30.000.000.- EUR) (ci-après «la Société Absorbante»), et

2) MATECO LOCATION DE NACELLES S.A., une société anonyme constituée sous le droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 12A, Rue J.L. Mac Adam, L-1113 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.496 et ayant un capital social de cent trente-
cinq mille euros (135.000.-EUR) (ci-après «la Société Absorbée»).

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont toutes deux ci-après dénommées les «Parties à la Fusion» ou les

«Sociétés».

CONSIDERANT QUE:
(A) Le capital social de la Société Absorbante d’un montant de trente millions d’euros (30.000.000.- EUR) est entière-

ment libéré et représenté par trente mille (30.000) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune.

(B) Le capital social de la Société Absorbée d’un montant de cent trente-cinq mille euros (135.000.- EUR) est entièrement

libéré et représenté par cinq mille deux cent cinquante (5.250) actions sans valeur nominale.

32796

L

U X E M B O U R G

(C) Pour des raisons économiques et commerciales, les conseil de gérance et conseil d’administration respectifs des

Sociétés ont proposé à leur associé et actionnaire uniques respectifs de procéder à une fusion entre la Société Absorbée et
la Société Absorbante (la «Fusion»).

(D) Etant donné que la Société Absorbante détient à cent pourcent (100%) le capital social de la Société Absorbée, les

Parties à la Fusion ont décidé de procéder à la Fusion conformément à la procédure de fusion simplifiée énoncée aux articles
278 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur
les Sociétés»).

(E) Le présent acte notarié est passé en conformité avec les exigences de l'article 271 de la Loi sur les Sociétés.
Par conséquent, les Parties à la Fusion ont reconnu et convenu ce qui suit:

1. La propriété des actions. Les Parties à la Fusion reconnaissent que la Société Absorbante détient toutes les actions en

circulation et les droits de vote s’y attachant de la Société Absorbée.

2. Fusion. La Société Absorbante souhaite absorber la Société Absorbée avec effet comptable rétroactif au 1 

er

 octobre

2015 (la «Date d’Effet Comptable»).

A compter de la Date d’Effet Comptable, toutes les opérations et transactions de la Société Absorbée seront considérées

d’un point de vue comptable et fiscal comme étant effectuées pour le compte de la Société Absorbante.

La Fusion prendra effet entre les parties à la date de la tenue de l’assemblée générale de l’associé unique de la Société

Absorbante devant un notaire, alors qu'envers les tiers, la Fusion prendra effet lors de la publication du procès-verbal de
l’assemblée générale de l’associé unique de la Société Absorbante qui, dans chacun des cas, aura lieu au moins un mois
après la date de publication du présent projet commun de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la
«Date d’Effet Juridique»).

Par l’effet de la Fusion, la Société Absorbée sera dissoute sans liquidation, ses actions seront annulées et la totalité de

son actif et passif sera transmis à la valeur nette comptable à la Société Absorbante.

Le transfert comprend l'ensemble des actifs dont la valeur comptable au 30 septembre 2015 est de quatre millions deux

cent sept mille quatre cent quarante-huit euros (4.207.448.- EUR), tels que décrits dans les comptes annuels au 30 septembre
2015. Le passif existant au 30 septembre 2015 de la Société Absorbée et que la Société Absorbante accepte de reprendre
et d'acquitter pour le compte de la Société Absorbée est de sept cent soixante-dix-neuf mille cent soixante-quinze euros
(779.175.- EUR), tels que décrits dans les comptes annuels au 30 septembre 2015.

En conséquence de ce qui précède, les apports nets effectués par la Société Absorbée à la Société Absorbante représentent

un montant positif de trois millions quatre cent vingt-huit mille deux cent soixante-treize euros (3.428.273.- EUR), lequel
montant est égal aux capitaux propres de la Société Absorbée. Les capitaux propres de la Société Absorbée de trois millions
quatre cent vingt-huit mille deux cent soixante-treize euros (3.428.273.- EUR) moins la valeur comptable de toutes les
actions détenues par la Société Absorbante dans la Société Absorbée s’élevant à cinq millions cinq cent soixante et onze
mille neuf cent soixante-six euros (5.571.966.- EUR), constitue un mali de fusion d’un montant de deux millions cent
quarante-trois mille six cent quatre-vingt-treize euros (2.143.693.- EUR).

La Fusion comprendra tous les actifs et les droits décrits ci-dessus tels qu'ils se trouvent au jour de la réalisation de la

Fusion.

La Société Absorbée garantie la valeur des actifs nets apportés au jour de la réalisation de la Fusion.
La Société Absorbante assumera tous les contrats et toutes les obligations de quelque nature que ce soit, de la Société

Absorbée, tels que ces contrats et obligations existent à la Date d’Effet Juridique et en particulier tous les contrats existants
avec les créanciers de la Société Absorbée et sera subrogée dans tous les droits et obligations nés de ces contrats.

La Société Absorbante reprendra, en particulier, les contrats de travail conclus avec les employés de la Société Absorbée,

y compris les contrats de travail intérimaire, en conformité avec les articles L 127-1 et suivants du Code du travail luxem-
bourgeois concernant le transfert d'entreprises.

La Société Absorbante assumera l'ensemble du passif, de quelque nature que ce soit, de la Société Absorbée et paiera

en particulier le principal et les intérêts de toute dette de la Société Absorbée à compter de la Date d’Effet Juridique.

A compter de la Date d’Effet Juridique, la Société Absorbante s'acquittera de toutes les taxes, cotisations et estimations,

ordinaires ou extraordinaires, dues ou à naître, en relation avec la propriété des actifs transférés.

Conformément aux dispositions de l’article 268 de la Loi, les créanciers des sociétés fusionnantes dont la créance est

antérieure à la date de publication du constat de la Fusion auront la faculté de demander à un juge la constitution d'une
sûreté dans les deux mois à compter de la date de publication de ce constat de la Fusion si l’opération de Fusion réduit leur
gage.

3. Rapports. Conformément aux dispositions de l’article 278 de la Loi sur les Sociétés, le projet commun de fusion ne

sera pas soumis (i) à un examen et un rapport écrit établi par un expert indépendant destiné aux actionnaires, et (ii) à un
rapport écrit détaillé établi par les organes de gestion de la Société Absorbante et de la Société Absorbée.

4. Date à partir de laquelle la Société Absorbante disposera des actifs de la Société Absorbée et assumera tous ses

passifs. Les Parties à la Fusion reconnaissent et conviennent qu'à partir de la Date d’Effet Juridique, la Société Absorbante
sera l’unique et pleine propriétaire et pourra disposer des actifs de la Société Absorbée. La Société Absorbante assumera

32797

L

U X E M B O U R G

tous les passifs, remboursera les créanciers et réalisera tous les contrats en cours de la Société Absorbée. Les droits et
créances compris dans les actifs de la Société Absorbée devront être transférés à la Société Absorbante avec l’ensemble
des garanties, in rem or in personam, s’y attachant.

La Société Absorbée s’engage à ne disposer d’aucun actif et de ne prendre aucune mesure pouvant compromettre la

Fusion jusqu'à la Date d’Effet Juridique.

5. Droits spéciaux et avantages. La Société Absorbante n’accorde aucun droit spécial à son associé unique ou à ses

porteurs de titres, le cas échéant.

Aucun avantage spécial n'est accordé aux membres des conseil de gérance et conseil d’administration, aux délégués à

la gestion journalière ou aux commissaires aux comptes des Parties à la Fusion.

6. Fin des mandats et décharges. Les mandats des administrateurs, du délégué à la gestion journalière et du commissaire

aux comptes de la Société Absorbée prendront fin avec effet à la Date d’Effet Juridique et la Société Absorbante, en sa
qualité d’actionnaire unique de la Société Absorbée, donne décharge aux administrateurs, délégué à la gestion journalière
et au commissaire aux comptes de la Société Absorbée pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date du présent acte.

7. Information des actionnaires des Parties à la Fusion (article 267 de la Loi sur les Sociétés). Les actionnaires des Parties

à la Fusion auront le droit, durant le mois suivant la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du
projet commun de fusion, de prendre connaissance, au siège social des Parties à la Fusion de tous les documents énumérés
à l’article 267 (1) a) et b) de la Loi sur les Sociétés, comme suit:

- le présent projet commun de fusion; et
- les comptes annuels des trois derniers exercices des Parties à la Fusion.
Copie intégrale ou partielle des documents énumérés ci-dessus peut être obtenue par les actionnaires des Parties à la

Fusion sans frais et sur simple demande.

Lorsqu'un actionnaire des Parties à la Fusion a consenti à l’utilisation, par les Sociétés, de moyens électroniques pour

la communication des informations, les copies des documents énumérés ci-dessus pourront lui être fournies par courrier
électronique.

8. Validité et signature du projet commun de fusion. Les présents termes du projet commun de fusion sont valides dès

leur approbation et signature par les conseil de gérance et conseil d’administration respectifs des Parties à la Fusion.

Les Parties à la Fusion s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin de réaliser la Fusion sans délai et de

coopérer autant que nécessaire, en particulier par la délivrance de tous documents et toutes informations exigés par le
notaire instrumentant et les autorités publiques.

Les conseil de gérance et conseil d’administration respectifs des Parties à la Fusion sont, par le présent acte, autorisés

à modifier les termes du projet commun de fusion dans la limite exigée par les autorités compétentes et/ou registres, à
condition que de telles modifications ne changent pas substantiellement le but et les caractéristiques de la Fusion, telle
qu'exposés ci-dessus.

9. Conservation des documents et livres sociaux de la Société Absorbée. Les documents et livres sociaux de la Société

Absorbée (y compris les archives afférentes, les originaux de tous les actes, contrats, documents comptables, titres de
propriété) seront conservés au siège social de la Société Absorbante pour une durée de cinq ans à compter de la Date d’Effet
Juridique.

10. Effectivité et conséquences de la Fusion. La Société Absorbante est le détenteur de toutes les actions de la Société

Absorbée, de sorte qu'aucune augmentation de capital de la Société Absorbante n’est exigée. Puisque les conditions de
l’article 279 de la Loi sur les Sociétés ont été remplies, la Fusion ne requiert pas d’être approuvée par l’assemblée générale
des actionnaires des Sociétés.

Considérant ce qui précède et à condition qu'aucune assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante n’ait

été convoquée afin de se prononcer sur la Fusion, la Fusion deviendra effective à la Date d’Effet Juridique et produira
simultanément les effets juridiques énoncés à l’article 274 de la Loi sur les Sociétés.

Toutefois, il est précisé en l’espèce que le conseil de gérance de la Société Absorbante a convoqué son associé unique

par des résolutions prises en date du 29 février 2016 à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir par devant le
notaire instrumentant, ou par devant tout autre notaire du Grand-Duché de Luxembourg afin d’approuver la Fusion décrite
dans le présent projet de fusion et d’approuver lors de cette assemblée générale extraordinaire, la proposition du conseil
de gérance de la Société Absorbante de procéder à (i) un changement de dénomination de la Société, (ii) au transfert du
siège social de la Société et (iii) à la modification de l’objet social de la Société. Il est ensuite rappelé que l’associé unique
nommera M. Laurent Planche en tant que nouveau gérant de la Société Absorbante, à l’occasion de l’assemblée générale
extraordinaire de l’associé unique de la Société Absorbante.

Par l’effet de la Fusion, la Société Absorbée cessera d’exister et toutes ses actions émises seront immédiatement annulées.

11. Formalités. La Société Absorbante devra:
-  accomplir  toutes  les  formalités  légales,  y  compris  toutes  les  publications  prescrites  en  droit  pour  les  besoins  des

transferts réalisés dans le cadre de la Fusion;

32798

L

U X E M B O U R G

- se charger des formalités et notifications nécessaires pour toutes les questions administratives afin de prendre tous les

actifs et les engagements de la Société Absorbée en son nom propre;

- réaliser toutes les formalités légales nécessaires ou utiles pour rendre le transfert des biens et des droits reçus opposable

aux tiers.

A titre d’information, les conditions énoncées à l’article 279 de la Loi sur les Sociétés sont énumérées ci-dessous:
- la publicité prescrite à l’article 262 est faite pour chacune des sociétés participant à l’opération, un mois au moins avant

que l’opération ne prenne effet entre lesdites parties;

- l’associé unique de la Société Absorbante a le droit, un mois au moins avant que la Fusion ne prenne effet, de prendre

connaissance, au siège social de cette société, des documents énumérés à l’article 267 (1) a) et b) de la Loi sur les Sociétés;

- l’associé unique de la Société Absorbante a le droit, au moins un mois avant que l’opération ne prenne effet, de requérir

la convocation d’une assemblée générale appelée à se prononcer sur l’approbation de la Fusion. L’assemblée doit être
convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

12. Frais et dépens. Toutes charges, droits ou frais dus en conséquence de la Fusion seront pris en charge par la Société

Absorbante.

Conformément à l’article 271 de la Loi sur les Sociétés, le notaire instrumentant déclare qu'elle a contrôlé et atteste de

l'existence et de la légalité du projet commun de fusion et des actes, documents et formalités incombant aux Parties à la
Fusion en application de la Loi sur les Sociétés.

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi entre les parties.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant par

ses nom, prénom, état et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 01 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/6912. Reçu douze euros (12,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 2 mars 2016.

Référence de publication: 2016074056/359.
(160038491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.

B Medical Systems Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, 17, Op der Hei.

R.C.S. Luxembourg B 94.593.

In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth day of February.
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of B Medical Systems Holding S.A., a public limited

liability company (société anonyme) incorporated and exiting under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 17, Op der Hei, L-9809 Hosingen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 94593 (the Company).

The Company was incorporated on 3 July 2001 pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niede-

ranven,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  published  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  des  Associations  (the
Mémorial), N° - 3 of 2 January 2002. Since that date, the Company’s articles of association (the Articles) have been amended
several times, for the last time pursuant to a deed of Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange sur Attert, Grand
Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, dated 1 September 2015, published in the Mémorial N° - 2950 of 28 October 2015.

The Meeting was opened at 9.30 a.m. and chaired by Annick Braquet, employee, residing professionally in Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Arlette Siebenaler, employee, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Annick Braquet, employee, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

The chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to as the Board of the Meeting.
The Board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:

32799

L

U X E M B O U R G

I. The sole shareholder of the Company (the Shareholder) is represented by virtue of a proxy given under private seal

and the number of its shares is shown on an attendance list (the Attendance List). Such list and the proxy, after having been
signed ne varietur by the Board of the Meeting and the undersigned notary, shall remain attached to the present minutes.

II. It appears from the Attendance List that all the shares are represented at the present Meeting so that the Meeting can

validly decide on all the items of the agenda of which the participants have been beforehand informed.

III. That the agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of the convening notice;
2. Acknowledgement of the joint merger proposal providing for the absorption by the Company of its 100% subsidiary

B Medical Systems Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (the Absorbed Company);

3. Acknowledgement that all the documents required by articles 267 and 278 of the law on commercial companies dated

10 August 1915, as amended, have been deposited at the Company’s registered office or its website for due inspection by
the Shareholder at least one month before the date of the general meeting of the Shareholder of the Company resolving on
the joint draft merger terms;

4. Approval of the joint merger proposal and decision to carry out the merger by way of the absorption by the Company

of the Absorbed Company; acknowledgment that from an accounting point of view, the operations of Absorbed Company
will be treated as having been carried out on behalf of the Company as from the date of this Meeting; acknowledgment of
the effective date of the merger between the parties and of the date of enforceability of the merger towards third parties;

5. Granting of all powers to any member of the Company’s board of directors and to any lawyer and/or employee of

Loyens &amp; Loeff Luxembourg SARL, each acting individually, with full power of substitution, to execute any documents
and perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the merger; and

6. Miscellaneous.
IV. These facts having been exposed and recognized as true and correct by the Meeting, after the foregoing has been

discussed and approved by the Meeting, the Meeting unanimously decides on the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the

convening notice, the Shareholder represented considering himself as duly convened and declaring having perfect know-
ledge of the agenda which had been communicated to him in advance.

<i>Second resolution

The Meeting acknowledges that it has been acquainted with the joint merger proposal dated 23 December 2015, published

in the Mémorial, N°- 3474 of 30 December 2015 (the Joint Merger Proposal) in accordance with article 262 of the law of
10 August1915 on commercial companies, as amended (the Law) and providing for the absorption by the Company of B
Medical Systems Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, Op der Hei, L-9809 Hosingen,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
166303 (the Absorbed Company and together with the Company, the Merging Companies or individually, a Merging
Company).

<i>Third resolution

The Meeting acknowledges that the Joint Merger Proposal, the Merging Companies’ annual accounts and annual reports

(if any) of the last three financial years and the Merging Companies interim balance sheet dated 30 November 2015 have
been deposited at the Company’s registered office or its website, if any, for due inspection by the shareholders at least one
month before the date hereof.

A certificate attesting the deposit of said documents, duly signed by an authorised representative of the Company, has

been given to the notary.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to approve the Joint Merger Proposal and to carry out the merger by way of the absorption of the

Absorbed Company by the Company, in accordance with the conditions detailed in the Joint Merger Proposal. The Meeting
acknowledges (i) the dissolution without liquidation of the Absorbed Company as per the effective date by way of transfer
at book value of all the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Company, all in accordance with the Joint
Merger Proposal and (ii) the cancellation, as a consequence of the merger, of the shares held by the Company in the Absorbed
Company.

The Meeting further acknowledges (i) that from an accounting point of view, the operations of the Absorbed Company

will be treated as having being carried out on behalf of the Company as from the date of this Meeting, (ii) that the merger
takes effect between the Merging Companies on the date of the concurring general meetings of the shareholders of the
Merging Companies approving the merger and is enforceable towards third parties after the publication in the Mémorial
of the minutes of the general meetings of the Merging Companies’ shareholders approving the merger.

32800

L

U X E M B O U R G

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to grant all powers to any member of the Company’s board of directors and to any lawyer and/or

employee of Loyens &amp; Loeff Luxembourg SARL, each acting individually, with full power of substitution, to execute any
documents and perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the
merger.

<i>Declaration

The undersigned notary states, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, having verified and

certifies the existence and the validity of the legal acts and formalities incumbent upon the Company and of the Joint Merger
Proposal.

There being no further business, the Meeting is adjourned.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with the present

deed are estimated at approximately EUR 1,500.-

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the Board of the Meeting,

the present deed is worded in English, followed by a French version and, in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day state above.
The document having been read to the Board of the Meeting, said Board of the Meeting signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille seize, le dix-neuvième jour de février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de B Medical Systems Holding S.A., une société

anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 17, Op der
Hei, L-9809 Hosingen, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 94593 (la Société).

La Société a été constituée le 3 juillet 2001, suivant un acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) N° - 3 du 2
janvier 2002. Depuis, les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et le plus récemment suivant
un acte de Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange sur Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en
remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 1

er

 septembre 2015, publié au Mémorial N° - 2950 du 28 octobre 2015.

L’Assemblée est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Annick Braquet, employée, de résidence professionnelle

à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président nomme Arlette Siebenaler, employée, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Lu-

xembourg comme secrétaire.

L’Assemblée choisit Annick Braquet, employée, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg comme scrutateur.

Le président, le secrétaire et le scrutateur sont ensemble désignés comme le Bureau de l’Assemblée.
Le Bureau de l’Assemblée ayant ainsi été formé, le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
II. L’actionnaire unique de la Société (l’Actionnaire) est représenté en vertu d’une procuration donnée sous seing privé

et le nombre de ses actions est indiqué sur une liste de présence (la Liste de Présence). Cette liste ainsi que la procuration,
après avoir été signées ne varietur par le Bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes
minutes.

III. Qu'il ressort de la Liste de Présence que toutes les actions sont représentées à la présente Assemblée qui est par

conséquent régulièrement constituée et peut délibérer et décider sur les points de l’ordre du jour dont les participants ont
été informés au préalable.

IV. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Prise d’acte du projet commun de fusion prévoyant l’absorption par la Société de sa filiale à 100% B Medical Systems

Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée (la Société Absorbée);

3. Prise d’acte que tous les documents requis par les articles 267 et 278 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été déposés au siège social de la Société ou mis sur son site internet pour que les

32801

L

U X E M B O U R G

actionnaires puissent en prendre connaissance au moins un mois avant la date de l’assemblée générale des actionnaires de
la Société appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion;

4. Approbation du projet commun de fusion et décision d’effectuer la fusion par absorption par la Société de la Société

Absorbée; prise d’acte que, d’un point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée seront traitées comme si
elles avaient été exécutées pour le compte de la Société depuis la date de la présente Assemblée; prise d’acte de la date
d’effet de la fusion entre les parties et de la date de prise d’effet de la fusion envers les tiers;

5. Pouvoir et autorité à tout membre du conseil d’administration de la Société et à tout avocat et/ou employé de Loyens

&amp; Loeff Luxembourg SARL, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, afin d’exécuter tous
documents et d’accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation
avec la fusion; et

6. Divers.
V. Les faits ayant été exposés et reconnus sincères et exacts par l’Assemblée, après discussion et approbation de ce qui

précède par l’Assemblée, l’Assemblée décide de prendre les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de convo-

cation, l’Actionnaire représenté se considérant lui-même comme dûment convoqué et déclarant connaître parfaitement
l’ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée prend acte qu’elle a pris connaissance du projet commun de fusion daté du 23 décembre 2015, publié au

Mémorial, N° - 3474 du 30 décembre 2015 (le Projet Commun de Fusion) conformément à l’article 262 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et prévoyant l’absorption par la Société de B Medical
Systems Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, dont le siège social est établi au 17, Op der Hei, L-9809 Hosingen, Grand-Duché de Luxembourg, immatri-
culée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166303 (la Société Absorbée et ensemble
avec la Société, les Sociétés qui Fusionnent ou individuellement une Société qui Fusionne).

<i>Troisième résolution

L’Assemblée prend acte que le Projet Commun de Fusion et les comptes annuels et, le cas échéant, les rapports de

gestion annuels des trois derniers exercices des Sociétés qui Fusionnent et le bilan intérimaire daté du 30 novembre 2015
des Sociétés qui Fusionnent ont été déposés au siège social de la Société ou, le cas échéant, mis sur son site internet pour
que les actionnaires puissent en prendre connaissance au moins un mois avant la date des présentes.

Un certificat attestant le dépôt de ces documents, dûment signé par un représentant autorisé de la Société, a été remis

au notaire.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’approuver le Projet Commun de Fusion et d’effectuer la fusion par absorption de la Société

Absorbée par la Société, conformément aux conditions détaillées dans le Projet Commun de Fusion. L’Assemblée prend
acte (i) de la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée à la date de prise d’effet par transfert à la valeur comptable
de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société, en conformité avec le Projet Commun de Fusion et (ii) de
l’annulation, en conséquence de la fusion, des actions détenues par la Société dans la Société Absorbée.

L’Assemblée prend par ailleurs acte (i) que d’un point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée seront

traitées comme si elles avaient été exécutées pour le compte de la Société à compter de la date de la présente Assemblée,
(ii) que la fusion prend effet entre les Sociétés qui Fusionnent à la date des assemblées générales concordantes des action-
naires des Sociétés qui Fusionnent décidant de la fusion et prend effet à l’égard des tiers après la publication au Mémorial
des procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires des Sociétés qui Fusionnent approuvant la fusion.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de donner tous les pouvoirs à tout membre du conseil d’administration de la Société et à tout avocat

et/ou employé de Loyens &amp; Loeff Luxembourg SARL, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitu-
tion, afin d’exécuter tous documents et d’accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises
ou souhaitables en relation avec la fusion.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément à l’article 271(2) de la Loi avoir vérifié et certifie l’existence et la légalité

de tous actes et formalités incombant à la Société et du Projet Commun de Fusion.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée est ajournée.

32802

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société relatif au présent acte s’élèvent

approximativement à EUR 1.500.-

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la requête du Bureau de l’Assemblée, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la
version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte au Bureau de l’Assemblée, ledit Bureau de l’Assemblée a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 23 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5822. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 29 février 2016.

Référence de publication: 2016072047/203.
(160036453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

PNR Global (ex-Japan) Aggregate Bond, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 204.195.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen on the twenty-third of February.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Pioneer Asset Management S.A., a société anonyme (public limited company) incorporated and existing under the laws

of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés under number B-57.255, having its registered
office at 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,

here represented by Gwenaël Guillerm, legal advisor, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Luxembourg, on the twenty-second of February 2016.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited company

(société anonyme) which they wish to incorporate and the articles of incorporation of which shall be as follows:

Title I. Name - Registered office - Duration - Purpose - Definitions

Art. 1. Name. There is hereby established by the sole subscriber and all those who may become owners of shares hereafter

issued (the “Shares”) in the future, a public limited company (“société anonyme”) qualifying as an investment company
with  variable  share  capital  (“société  d’investissement  à  capital  variable”)  under  the  name  of  “PNR  Global  (ex-Japan)
Aggregate Bond” (hereinafter the “Company”).

Art. 2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 The board of directors of the Company (the “Board of Directors”) may decide to transfer the registered office of the

Company within the same municipality, or from a municipality to another municipality within the Grand-Duchy of Lu-
xembourg, if and to the extent permitted by Luxembourg law and practice relating to commercial companies.

2.3 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad (but

not, in any event in the United States of America, its territories or possessions) by resolution of the Board of Directors.

2.4 In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic, military or social deve-

lopments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain
a Luxembourg company.

32803

L

U X E M B O U R G

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of holders of the Shares

(the “Shareholders”), adopted in the manner required for an amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 4. Purpose.
4.1 The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in (i) shares in companies and other

securities equivalent to shares in companies, (ii) bonds and other forms of securitised debt, and/or (iii) any other negotiable
securities which carry the right to acquire any such transferable securities by subscription or exchange (“Transferable
Securities”) and (iv) other assets permitted by law, with the purpose of spreading investment risks and affording its Sha-
reholders the results of the management of its assets.

4.2 The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and

development of its purpose to the largest extent permitted by part I of the law of 17 December 2010 on undertakings for
collective investment, as amended (the “2010 Law”).

Title II. Share capital - Shares - Net asset value

Art. 5. Share Capital - Classes of Shares.
5.1 The share capital of the Company shall be represented by fully paid up Shares of no par value and shall at any time

be equal to the total net assets of the Company calculated pursuant to Article 11 hereof (the “Net Asset Value”). The
minimum  capital  shall  be  as  provided  by  the  2010  Law,  i.e.  one  million  two  hundred  and  fifty  thousand  euro  (EUR
1,250,000.-). Such minimum capital must be reached within a period of six (6) months after the date on which the Company
has been authorised as a collective investment undertaking under the 2010 Law.

5.2 The initial issued share capital of the Company is thirty one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into three hundred

and ten (310) Shares of no par value.

5.3 The Shares to be issued pursuant to Articles 6 and 7 hereof may, as the Board of Directors shall determine, be of

different classes (each a “Class” or “Class of Shares”). The proceeds of the issue of each Class of Shares shall be invested
in Transferable Securities of any kind and other assets permitted by the 2010 Law and Luxembourg applicable regulations
pursuant to the investment policy of the Company, subject to the investment restrictions provided by the 2010 Law and
Luxembourg applicable regulations and as determined by the Board of Directors.

5.4 The Board of Directors may create each Class of Shares for an unlimited or limited period of time; in the latter case,

the Board of Directors may, at the expiry of the initial period of time, prorogate the duration of the relevant Class of Shares
once or several times. At expiry of the duration of the Class of Shares, the Company shall redeem all the Shares in the
relevant Class(es) of Shares, in accordance with the provisions of Article 8 below. At each prorogation of a Class of Shares,
the Shareholders shall be duly notified.

5.5 The Board of Directors, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner described in the sales

documents of the Company, that all or part of the assets of the Company be co-managed with assets of one or several other
undertakings for collective investment.

5.6 For the purpose of determining the share capital of the Company, the net assets attributable to each Class of Shares

shall, if not expressed in EUR, be converted into EUR and the capital shall be the total aggregate of the net assets of each
Class of Shares.

Art. 6. Form of Shares.
6.1 The Company shall issue Shares in registered form only.
All issued registered Shares of the Company shall be registered in the register of Shareholders which shall be kept by

the Company or by any entity designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner
of registered Shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company and the number of registered Shares
held by him.

The inscription of the Shareholder’s name in the register of Shareholders evidences his right of ownership on such

registered Shares. Evidence of such inscription shall be delivered upon request to the Shareholder.

The Share certificates shall be signed by two Directors. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile.

The certificates will remain valid even if the list of authorised signatures of the Company is modified. However, one of
such signatures may be made by a person duly authorised thereto by the Board of Directors; in the latter case, it shall be
manual. The Company may issue temporary Share certificates in such form as the Board of Directors may determine.

6.2 Shareholders entitled to receive registered Shares shall provide the Company with an address to which all notices

and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of Shareholders.

In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered

into the register of Shareholders and the Shareholder’s address will be deemed to be at the registered office of the Company,
or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another address shall be provided
to the Company by such Shareholder. A Shareholder may, at any time, change his address as entered into the register of

32804

L

U X E M B O U R G

Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be
set by the Company from time to time.

6.3 If any Shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his Share certificate has been mislaid, mutilated

or destroyed, then, at his request, a duplicate Share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including
but not restricted to a bond issued by an insurance company, as the Company may determine. At the issuance of the new
Share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original Share certificate in replacement of which
the new one has been issued shall become void.

Mutilated Share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.
The Company may, at its election, charge to the Shareholder the costs of a duplicate or of a new Share certificate and

all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection
with the annulment of the original Share certificate.

6.4 The Company recognises only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the ownership

of such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint one single attorney to represent
such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such
Share(s).

6.5 The Company may decide to issue fractional Shares. Such fractional Shares shall not be entitled to vote, unless the

number is so that they represent an entire Share in which case they confer a voting right, but shall be entitled to participate
in the net assets attributable to the relevant Class of Shares on a pro rata basis.

Art. 7. Issue of Shares.
7.1 The Board of Directors is authorised without limitation to issue an unlimited number of fully paid up Shares in one

or more Classes of Shares at any time without reserving to the existing Shareholders a preferential right to subscribe for
the Shares to be issued.

7.2 The Board of Directors may impose restrictions on the frequency at which Shares shall be issued in any Class of

Shares. The Board of Directors may, in particular, decide that Shares of any Class of Shares shall only be issued during
one or more offering periods or at such other periodicity as provided for in the sales documents of the Company.

7.3 Furthermore, the Board of Directors may impose restrictions in relation to the minimum amount of the aggregate

Net Asset Value of Shares to be initially subscribed, the minimum amount of any additional investments and the minimum
of any holding of Shares.

7.4 Whenever the Company offers Shares for subscription, the price per Share at which such Shares are offered after

the initial offer period as described in the sales documents of the Company shall be the Net Asset Value per Share as
determined  in  compliance  with  Article  11  hereof  as  of  such  day  (“Valuation  Day”  as  further  described  in  Article  12
hereinafter) as may be determined in accordance with such policy as the Board of Directors may from time to time determine.
Unless otherwise provided for in the sales documents of the Company, such price may be increased by a percentage estimate
of costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issue and by applicable sales
commissions, as approved from time to time by the Board of Directors.

7.5 The issue price per Share so determined shall be payable within a period as determined by the Board of Directors

as stated in the sales document of the Company and which shall not exceed ten (10) business days as defined in the sales
documents (“Business Day”) after the relevant Valuation Day.

7.6 Different time limits may apply if subscriptions of Shares are made through an agent, provided that the equal treatment

of Shareholders is complied with. In this case, the agent will inform the relevant investor of the procedure relevant to such
investors.

7.7 Where an applicant for Shares fails to pay issue price on subscription, the Board of Directors may cancel the allotment

or, if applicable, redeem the Shares. In this case the applicant may be required to indemnify the Company against any and
all losses, costs or expenses incurred (as conclusively determined by the Board of Directors in its discretion) directly or
indirectly as a result of the applicant’s failure to make timely payment. In computing such loss, account shall be taken,
where appropriate, of any movement in the price of the Shares concerned between allotment and cancellation or redemption
and the costs incurred by the Company in taking proceedings against the applicant.

7.8 No request for conversion or redemption of a Share shall be dealt with unless the issue price for such Share has been

paid and any confirmation delivered in accordance with this Article.

7.9 The Board of Directors may delegate to any director, manager, officer or other duly authorised agent the power to

accept subscriptions, to receive payment of the price of Shares to be issued and to deliver them.

7.10 The Company may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance

with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation, if applicable, to deliver a valuation report
from the independent authorised auditor of the Company (“réviseur d’entreprises agréé”). The securities to be delivered
by way of a contribution in kind must correspond to the investment policy and restrictions of the Company. Any costs
incurred in connection with a contribution in kind of securities shall be borne by the relevant Shareholders.

32805

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 Under the terms and procedures set forth by the Board of Directors in the sales documents of the Company and

within the limits provided by law and these Articles of Incorporation any Shareholder may request the redemption of all
or part of his Shares in the Company.

8.2 Subject to the provisions of Article 12 hereof, the redemption price per Share shall be paid within such period as

may be determined by the Board of Directors in its discretion from time to time, but which shall not, in any event, exceed
ten (10) Business Days from the Valuation Day which next follows receipt of such redemption request, provided that the
Share certificates (if any) and such instruments for redemption as may be required by the Board of Directors have been
received, and are in a form which is satisfactory to the Company.

8.3 However, different time limits may apply where redemptions of Shares are made through an agent, provided that

the principle of equal treatment of Shareholders is complied with. In such cases, the agent will inform the relevant investor
of the procedure relevant to such investor.

8.4.  The  redemption  price  shall  be  equal  to  the  Net  Asset  Value  per  Share  of  the  relevant  Class,  as  determined  in

accordance with the provisions of Article 11 hereof, less such charges and commissions (if any) at the rate provided for in
the sales documents of the Company. Unless otherwise provided for in the sales documents of the Company, such price
may be decreased by a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the Company when disposing of assets
in order to pay the redemption proceeds to redeeming Shareholders. Furthermore, the redemption price may be rounded
up or down as further detailed in the sales documents as the Board of Directors shall determine in its discretion.

8.5 If as a result of any request for redemption, the number, the minimum subscription amount or the aggregate Net

Asset Value of the Shares held by any Shareholder in any Class would fall below these thresholds as set out in the sales
documents of the Company as determined by the Board of Directors in its discretion from time to time, then the Company
may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such Shareholder’s holding of
Shares in such Class.

8.6. The Board of Directors may defer redemptions as of a particular Valuation Day to the next Valuation Day as of

which redemptions are accepted, where the requested redemptions exceed 10% of the Company’s or a Class of Shares’
Net Asset Value. The Board of Directors will ensure the consistent treatment of all Shareholders who have sought to redeem
Shares as of any Valuation Day at which redemptions are deferred. The Board of Directors will pro-rate all such redemption
requests to the stated level (i.e. 10% of the Company’s or the relevant Class of Shares’ Net Asset Value) and will defer the
remainder until the next Valuation Day as of which redemptions are accepted. The Directors will also ensure that all deals
relating to an earlier Valuation Day are completed before those relating to a later Valuation Day as of which redemptions
are accepted are considered.

8.7 The Company shall have the right, if the Board of Directors so determines, and with the express consent of the

relevant Shareholder, to satisfy payment of the redemption price to any Shareholder in specie by allocating to the Share-
holder investments from the portfolio of assets in such Class or Classes of Shares equal in value (as calculated in the manner
described in Article 11 hereof) as of the Valuation Day on which the redemption price is determined to the value of the
Shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and
reasonable basis and without prejudicing the interests of the other Shareholders of the Class or Classes of Shares and the
valuation used shall be confirmed, as applicable, by a special report of the authorised auditor of the Company. The costs
of any such transfers shall be borne by the Shareholder.

The redemption of Shares may be suspended under the terms herein or in other exceptional cases where the circumstances

and the best interests of the Shareholders so require.

8.8 All redeemed Shares shall be cancelled.

Art. 9. Conversion of Shares.
9.1 Unless otherwise determined by the Board of Directors for certain Classes of Shares, any Shareholder is entitled to

request the conversion of whole or part of his Shares in one Share Class into another Share Class, provided that the Board
of Directors may: (i) at its absolute discretion reject any request for the conversion of Shares in whole or in part; (ii) set
restrictions, terms and conditions as to the right to and frequency of conversions between certain Share Classes; (iii) subject
to the payment of such charges and commissions as the Board of Directors shall determine (unless otherwise provided for
in the sales documents of the Company).

9.2 The price for the conversion of Shares shall be computed by reference to the respective Net Asset Values per Share

of the two Share Classes concerned, determined as of the same Valuation Day.

9.3 If as a result of any request for conversion the number or the aggregate Net Asset Value of the Shares held by any

Shareholder in any Class of Shares would fall below such minimum number or value as determined by the Board of
Directors, then the Company may decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such
Shareholder’s holding of Shares in such Class.

9.4 The Shares which have been converted into Shares of another Share Class shall be cancelled.
9.5 The Board of Directors may defer conversion requests as of a particular Valuation Day to the next Valuation Day

as of which conversions are accepted, where the requested conversions exceed 10% of a Class of Shares’ Net Asset Value.
The Board of Directors will ensure the consistent treatment of all Shareholders who have sought to convert Shares as of

32806

L

U X E M B O U R G

any Valuation Day at which conversions are deferred. The Board of Directors will pro-rate all such conversion requests to
the stated level (i.e. 10% of the relevant Class of Shares’ Net Asset Value) and will defer the remainder until the next
Valuation Day as of which conversions are accepted. The Directors will also ensure that all deals relating to an earlier
Valuation Day are completed before those relating to a later Valuation Day as of which conversions are accepted are
considered.

Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares.
10.1 The Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm or corporate

body, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the Company, if it may result in a breach of
any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed to tax
disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise incurred (such person, firm or corporate
body to be determined by the Board of Directors being herein referred to as “Designated Person”).

10.2 Specifically, but without limitation, the Company may restrict the ownership of Shares in the Company by any

restricted U.S. investor as defined in the sales documents of the Company (“Restricted U.S. Investor”) or any Designated
Person, and for such purposes the Company may:

10.2.1 decline to issue any Shares and decline to register any transfer of Shares where it appears to it that such registration

or transfer would or might result in the legal or beneficial ownership of such Shares by a Restricted U.S. Investor or by
any Designated Person; and

10.2.2 at any time require any person whose name is entered in or any person seeking to register the transfer of Shares

on the register of Shareholders, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary
for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such Shareholder’s Shares rests in a Restricted U.S.
Investor or any Designated Person, or whether such entry in the register will result in the beneficial ownership of such
Shares by a Restricted U.S. Investor or any Designated Person; and

10.2.3 decline to accept the vote of any Restricted U.S. Investor or any Designated Person at any meeting of Shareholders

of the Company.

10.3 Where it appears to the Company that: (i) any Restricted U.S. Investor or any Designated Person either alone or in

conjunction with any other person is a beneficial owner of Shares; or that (ii) the aggregate Net Asset Value of Shares or
the number of Shares held by a Shareholder falls below such value or number of Shares respectively as determined by the
Board of Directors of the Company, or (iii) where in exceptional circumstances the Board of Directors determines that a
compulsory redemption is in the interest of the other Shareholders, the Company may compulsorily redeem or cause to be
redeemed from any such Shareholder all Shares held by such Shareholder in the following manner:

10.3.1 The Company shall serve a notice (the “purchase notice”) upon the Shareholder holding such Shares or appearing

in the register of Shareholders as the owner of the Shares to be purchased, specifying the Shares to be purchased, the manner
in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser;

10.3.2 Any such notice may be served upon such Shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope

addressed to such Shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said Shareholder
shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the Share certificate or certificates (if any) representing the
Shares specified in the purchase notice;

10.3.3 Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such Shareholder shall cease

to be the owner of the Shares specified in such notice and his name shall be removed from the register of Shareholders;

10.3.4 The price at which each such Shares is to be purchased (the “purchase price”) shall be an amount based on the

Net Asset Value per Share of the relevant Class as of the Valuation Day next succeeding the date of the purchase notice
or next succeeding the surrender of the Share certificate or certificates (if any) representing the Shares specified in such
notice, all as determined by the Board of Directors, less any service charge provided therein.

10.3.5 Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such Shares normally in the currency

set by the Board of Directors for the payment of the redemption price of the Shares of the relevant Class and will be: (i)
deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere; or (ii) paid by a check
sent to the last known address on the Company’s books (as specified in the purchase notice) upon final determination of
the purchase price following surrender of the Share certificate or certificates (if any) specified in such notice and unmatured
dividend coupons attached thereto;

10.3.6 Upon service of the purchase notice as aforesaid, such former owner shall have no further interest in such Shares

or any of them, nor any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the purchase
price (without interest) from such bank following effective surrender of the Share certificate or certificates (if any) as
aforesaid. Any funds receivable by a Shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five (5) years
from the date specified in the purchase notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the relevant Class or Classes
of Shares. The Board of Directors shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion
and to authorise such action on behalf of the Company;

10.3.7 The exercise by the Company of the power conferred by Article 10 hereof shall not be questioned or invalidated

in any case, on the grounds that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true

32807

L

U X E M B O U R G

ownership of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any purchase notice, provided in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith.

Art. 11. Calculation of the Net Asset Value per Share.
11.1 The Net Asset Value per Share of each Class of Shares shall be expressed in the base or pricing currency of the

relevant Class of Shares concerned (as defined in the sales documents of the Company) and shall be determined as of any
Valuation Day by dividing the net assets of the Company attributable to each Class, being the value of the portion of assets
less the portion of liabilities attributable to such Class, as of any such Valuation Day, by the number of Shares in the relevant
Class then outstanding, in accordance with the valuation rules set forth below. The Net Asset Value per Share may be
rounded to the nearest unit of the base or pricing currency of the relevant Class of Shares or such number of decimal places
as the Directors shall determine. If, since the time of determination of the Net Asset Value, there has been a material change
in the quotations in the markets on which a substantial portion of the investments attributable to the Company are dealt in
or quoted, the Company may, in order to safeguard the interests of the Shareholders and the Company, cancel the first
valuation and carry out a second valuation. In such a case, instructions for subscription, conversion or redemption of Shares
shall be executed on the basis of the second valuation.

11.2 The valuation of the Net Asset Value of the Company shall be made in the following manner:
I. The assets of the Company shall include:
1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
2) all bills and notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
3) all bonds, time notes, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other

securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided that the Company
may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (A) below with regards to fluctuations in the market
value of securities caused by trading exdividends, ex-rights, or by similar practices);

4) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information thereon

is reasonably available to the Company;

5) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Company except to the extent that the same is

included or reflected in the principal amount of such asset;

6) the liquidating value of all forward contracts and all call or put options the Company has an open position in;
7) the preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing Shares of the Company,

insofar as the same have not been written off;

8) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
The valuation of assets of the Company shall be calculated in the following manner:
(A) The value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash

dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof,
unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be arrived at after
making such discount as the Board of Directors may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof.

(B) The value of Transferable Securities, money market instruments and any financial liquid assets and instruments

which are quoted or dealt in on a stock exchange or on a regulated market or any other regulated market is based on their
last available price at the time of valuation of the assets on the relevant stock exchange or market which is normally the
main market for such assets.

(C) In the event that any assets held on the relevant day are not quoted or dealt in on any stock exchange or on any

regulated market, or on any other regulated market or if, with respect of assets quoted or dealt in on any stock exchange
or dealt on any such markets, the last available price as determined pursuant to sub-paragraph (B) is not representative of
the fair market value of the relevant assets, the value of such assets will be based on a reasonably foreseeable sales price
determined prudently and in good faith.

(D) The liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on a stock exchange or on regulated markets,

or on other regulated markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the
Board of Directors, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The value of futures, forward or
options contracts traded on a stock exchange or on regulated markets, or on other regulated markets shall be based upon
the last available settlement or closing prices as applicable to these contracts on a stock exchange or on regulated markets,
or on other regulated markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded on behalf of the
Company; provided that if a futures, forwards or options contract could not be liquidated on the day with respect to which
assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the Board
of Directors may deem fair and reasonable.

(E) Swaps and all other securities and other assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant

to procedures established by the Board of Directors.

(F) Units or shares of open-ended UCIs will be valued at their last determined and available net asset value or, if such

price is not representative of the fair market value of such assets, then the price shall be determined by the Board of Directors
on a fair and equitable basis. Units or shares of a closed-ended UCI will be valued at their last available stock market value.

32808

L

U X E M B O U R G

II. The liabilities of the Company shall include:
1) all loans, bills and accounts payable;
2) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
3) all accrued or payable expenses (including, without limitation, administrative expenses, management fees, including

incentive fees, if any, and depositary fees);

4) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or

property, including the amount of any unpaid distributions declared by the Company;

5) an appropriate provision for future taxes based on capital and income as of the Valuation Day, as determined from

time to time by the Company, and other reserves (if any) authorised and approved by the Board of Directors, as well as
such amount (if any) as the Board of Directors may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent
liabilities of the Company;

6) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted

accounting principles. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all charges and
expenses payable by the Company. The Company may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring
nature based on an estimated amount rateably for yearly or other periods.

The value of all assets and liabilities not expressed in the reference currency of the Company will be converted into the

reference currency of the Company at the rate of exchange determined as of the relevant Valuation Day in good faith by
or under procedures established by the Board of Directors.

The Board of Directors, in its absolute discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers

that such valuation better reflects the fair value of any asset and / or liability of the Company.

In the event that extraordinary circumstances render a valuation in accordance with the foregoing guidelines impracti-

cable or inadequate, the Company will, prudently and in good faith use other criteria in order to achieve what it believes
to be a fair valuation in the circumstances.

To the extent that the Board of Directors considers that it is in the best interests of Shareholders , if on any Valuation

Day the aggregate subscriptions and redemptions in Shares of all Classes of the Company is expected to result in a net
increase or decrease of Shares which exceeds a threshold set by the Board of Directors from time to time, taking into account
factors including the prevailing market conditions, the Net Asset Value of the Company may be adjusted to reflect the
estimated dealing spreads, costs and charges to be incurred by the Company in liquidating or purchasing investments to
satisfy the net transactions for that particular Valuation Day. The adjustment shall not exceed a percentage of the Net Asset
Value on the relevant Valuation Day described in the sales documents of the Company. This adjustment will be made
before the application of any performance fee if applicable.

III. The assets shall be allocated as follows:
The Board of Directors shall allocate the assets and liabilities attributable to each Class of Shares in the following

manner:

1. where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Class of Shares or to any action taken

in connection with an asset of a particular Class of Shares, such liability shall be allocated to the relevant Class of Shares;

2. in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Class

of Shares, such asset or liability shall be allocated to all the pro rata to the Net Asset Values of the relevant Classes of
Shares or in such other manner as determined by the Board of Directors acting in good faith;

3. upon the payment of distributions with respect to any Class of Shares, the Net Asset Value of such Class of Shares

shall be reduced by the amount of such distributions.

The value of the assets and liabilities of the Company is generally determined in accordance with IFRS rules except

where otherwise provided in the sales documents of the Company.

In the absence of fraud, bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value

taken by the Board of Directors or by any bank, company or other organisation which the Board of Directors may appoint
for the purpose of calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company and present, past or future
Shareholders, subject to Article 11.1 hereof.

IV. For the purpose of this Article:
1) Shares of the Company to be redeemed under Article 8 hereof shall be treated as existing and taken into account until

immediately after the time specified by the Board of Directors as of the Valuation Day on which such redemption is made
and from such time and until paid by the Company the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

2) Shares to be issued by the Company shall be treated as being in issue as from the time specified by the Board of

Directors as of the Valuation Day on which such issue is made and from such time and until received by the Company.
The price therefore shall be deemed to be a debt due to the Company;

3)  all  investments,  cash  balances  and  other  assets  expressed  in  currencies  other  than  the  reference  currency  of  the

Company shall be valued after taking into account the rates of exchange as determined by the Board of Directors for
determination of the Net Asset Value of Shares; and

4) where as of any Valuation Day the Company has contracted to:

32809

L

U X E M B O U R G

- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company

and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;

- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company

and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;

provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known as of such Valuation

Day, then its value shall be estimated by the Company.

Art. 12. Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share and of the Issue, Conversion

and Redemption of Shares.

12.1 With respect to each Class of Shares, the Net Asset Value per Share and the price for the issue, conversion and

redemption of Shares shall be calculated from time to time by the Company or any agent appointed thereto by the Company,
at least twice a month at a frequency determined by the Board of Directors and determined in the sales documents of the
Company, such date or time of determination being the Valuation Day.

12.2 The Company may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value per Share of any particular Class

of Shares and the issue and redemption of its Shares to and from its Shareholders as well as the conversion from and to
Shares of each Class of Shares in any of the following events:

12.2.1 when one or more stock exchanges, regulated markets or any other regulated market in a member state of the

European Union or in another state which is the principal market on which a substantial portion of the assets of the Company
is invested, or when one or more foreign exchange markets in the currency in which a substantial portion of the assets of
the Company is denominated, are closed otherwise than for ordinary holidays or if trading thereon is restricted or suspended;
or

12.2.2 when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the responsi-

bility and the control of the Company and its delegates, disposal of the assets of the Company is not reasonably or normally
practicable without being seriously detrimental to the interests of the Shareholders; or

12.2.3 in the event of a breakdown in the normal means of communication used for the valuation of any investment of

the Company or if, for any reason, the value of any asset of the Company may not be determined as rapidly and accurately
as required; or

12.2.4 when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of Shares

or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or payments due on re-
demption of Shares cannot in the opinion of the Board of Directors be effected at normal rates of exchange.

12.3 Any such suspension and termination thereof shall be published, if appropriate, by the Company and may be notified

to Shareholders having made an application for subscription, conversion or redemption of Shares for which the calculation
of the Net Asset Value has been suspended.

12.4 Any request for subscription, conversion or redemption shall be irrevocable except in the event of a suspension of

the calculation of the Net Asset Value per Share.

Title III. Administration and supervision

Art. 13. Board of Directors.
13.1 The Company shall be managed by the Board of Directors composed of not less than three members, who do not

need to be Shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years. They may be re-elected.
The Directors shall be elected by the Shareholders at a general meeting of Shareholders; in particular by the Shareholders
at their annual general meeting for a period ending in principle at the next annual general meeting or until their successors
are elected and qualified, provided however that a Director may be removed with or without cause and/or replaced at any
time by resolution adopted by the Shareholders. The general meeting of Shareholders shall also determine the number of
Directors, their remuneration and the term of their office.

In the event an elected Director is a legal entity, a permanent individual representative thereof should be designated as

member of the Board of Directors. Such individual is submitted to the same obligations than the other Directors.

Such individual may only be revoked upon appointment of a replacement individual.
13.2 Directors shall be elected by the majority of the votes of the Shares validly cast and shall be subject to the approval

of the Luxembourg regulatory authorities in accordance with applicable laws and regulations.

13.3 In the event of a vacancy in the office of Director, the remaining Directors may meet and elect, by majority vote,

a director to temporarily fill such vacancy. The Shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their
next general meeting.

Art. 14. Board Meetings.
14.1 The Board of Directors shall choose from among its members a chairman and may choose one or more vice-

chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary (who does not need to be a director) who shall write and
keep the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the Shareholders. Either the chairman or any two directors
may at any time summon a meeting of the Directors by notice in writing to every director which notice shall set forth the
general nature of the business to be considered and the place at which the meeting is to be convened.

32810

L

U X E M B O U R G

14.2 Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four hours

prior to the date set for such meeting, except in circumstances of an emergency, in which case the nature of such circums-
tances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing by mail, e-mail, facsimile
or any other similar means of communication, or when all Directors are present or represented at the meeting. Separate
notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a resolution adopted by the Board of Directors.

14.3 The chairman shall preside at the meetings of the Directors and of the Shareholders. In his absence, the Shareholders

or the Directors shall decide by a majority vote that another Director, or in the case of a Shareholders’ meeting, that any
other person shall be in the chair of such meetings.

14.4 The Board of Directors may from time to time and at any time by powers of attorney appoint any company, firm,

person or body of persons, with full power of substitution , to be the attorney or attorneys of the Company for such purpose
and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the Board of Directors
under these Articles of Incorporation) and for such period and subject to such conditions as they may think fit, and any
such powers of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing with any such
attorneys as the Board of Directors may think fit and may also authorise any such attorney to delegate all or any of the
powers, authorities and discretions vested in him.

14.5 Any Director may act at any meeting by appointing in writing, by mail, email or facsimile or any other similar

means of communication another director as his proxy. A Director may represent several of his colleagues.

14.6 The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. The Directors may not bind the

Company by their individual signatures, except if specifically authorised thereto by resolution of the Board of Directors.

14.7 The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the Directors are present or

represented.

14.8 Resolutions of the Board of Directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies

of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed where they are signed
by the chairman of the meeting or any two Directors.

14.9 Resolutions are taken by a majority vote of the Directors present or represented. In the event that at any meeting

the numbers of votes for or against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

14.10 Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions voted at the

Board of Directors’ meetings. Each Director shall approve such resolution in writing, by mail, facsimile or any other similar
means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that proves
that such decision has been taken.

14.11 Members of the Board of Directors or of any committee thereof may participate in a meeting of the Board of

Directors or of such committee by means of conference telephone, videoconference, or similar communications equipment
by means of which all persons participating in the meeting can hear each other and participation in a meeting pursuant to
this provision shall constitute presence in person at such meeting.

Art. 15. Powers of the Board of Directors.
15.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration

within the Company’s purpose, in compliance with the investment policy as determined in Article 18 hereof.

15.2 All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of

Shareholders are in the competence of the Board of Directors.

Art. 16. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two

Directors or by the joint or single signature of any officer(s) of the Company or of any other person(s) to whom authority
has been delegated by the Board of Directors.

Art. 17. Delegation of Powers.
17.1 The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company

(including the right to act as authorised signatory for the Company) and its powers to carry out acts in furtherance of the
corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need not be members of the
Board of Directors, who shall have the powers determined by the Board of Directors and who may, if the Board of Directors
so authorises, sub-delegate their powers.

17.2 The Board of Directors may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
17.3 In particular, the Board of Directors will appoint Pioneer Asset Management S.A. as management company in

accordance with chapter 15 of the 2010 Law (the “Management Company”).

In this capacity the Management Company shall perform management functions and shall in particular provide the

Company with advice and recommendations on the Company’s investment policy, as stated in Article 18 of the Articles
of Incorporation and on its sales policy. The Management Company may, under the supervision of the Board of Directors
and on a daily basis, buy and sell at its discretion Transferable Securities and other assets of any kind belonging to the
Company in accordance with the provisions of a written contract.

The designated Management Company shall also be involved in the central administration of the Company and in the

distribution of its shares.

32811

L

U X E M B O U R G

The Management Company shall be authorised to delegate its functions of investment management, central adminis-

tration and distribution mentioned above in accordance with the 2010 Law.

A contract shall be concluded with the Management Company for an unspecified duration and may be terminated by

either of the parties subject to the conditions and modalities specified therein regarding notice periods and compensation
for termination.

Art. 18. Investment Policy and Restrictions.
18.1 The Board of Directors, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine the investment

policy and strategies to be applied in respect of the Company and the course of conduct of the management and business
affairs of the Company, within the restrictions as shall be set forth by the Board of Directors in compliance with applicable
laws and regulations.

18.2 Within those restrictions, the Board of Directors may decide that investments be made in:
18.2.1 Transferable Securities or money market instruments;
18.2.2 shares or units of other UCIs;
18.2.3 deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are

maturing in no more than twelve(12) months;

18.2.4 financial derivative instruments.
18.3 The investment policy of the Company may replicate the composition of an index of securities or debt securities

recognised by the Luxembourg supervisory authority.

18.4 The Company may in particular purchase the above mentioned assets on any Regulated Market of a state of Europe,

being or not member state of the European Union, of America, Africa, Asia, Australia or Oceania.

18.5 The Company may also invest in recently issued Transferable Securities and money market instruments, provided

that the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a regulated
market and that such admission be secured within one year of issue.

18.6 In accordance with the principle of risk spreading, the Company is authorised to invest up to 100% of its net assets

in Transferable Securities or money market instruments issued or guaranteed by (i) a Member State, its local authorities or
a public international body of which one or more Member State(s) are member(s), (ii) any OECD member state or any
member country of the G-20, or (iii) Singapore or Hong Kong or any other public issuer recognised by the Luxembourg
supervisory authority, provided that (i) such securities are part of at least six different issues and (ii) the securities from
any such issue do not account for more than 30% of the total assets of the Company.

18.7 The Board of Directors, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner described in the

sales documents of the Company, that all or part of the assets of the Company be co-managed on a segregated basis with
other assets held by other investors, including other undertakings for collective investment.

18.8 Investments of the Company may be made either directly or indirectly through wholly-owned subsidiaries, as the

Board of Directors may from time to time decide and as described in the sales documents of the Company. Reference in
these Articles to “investments” and “assets” shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially
held directly or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.

18.9 The Company is authorised to employ techniques and instruments relating to Transferable Securities and money

market instruments provided that such techniques and instruments may be used for hedging purposes, for the purpose of
efficient portfolio management or for investment purposes.

Art. 19. Conflict of Interest.
19.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that any one or more of the Board of Directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of, such other company or firm. Any Director or officer of the Company who serves as a
director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting
upon any matters with respect to such contract or other business.

19.2 In the event that any Directors or officers of the Company may have an interest in any transaction of the Company

which conflicts with the interests of the Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors
such conflict of interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or
officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of Shareholders.

19.3 Such conflict of interest as referred to in this Article, shall not include any relationship with or without interest in

any matter, position or transaction involving any affiliated or associated company of any external investment manager
appointed by the Company, or such other person, company or entity as may from time to time be determined by the Board
of Directors in its discretion.

Art. 20. Indemnification of Directors. Every Director, agent, auditor, or officer of the Company and his personal repre-

sentatives shall be indemnified and secured harmless out of the assets of the Company against all actions, proceedings,
costs, charges, expenses, losses, damages or liabilities (“Losses”) incurred or sustained by him in or about the conduct of

32812

L

U X E M B O U R G

the Company business or affairs or in the execution or discharge of his duties, powers, authorities or discretions, including
Losses incurred by him in defending (whether successfully or otherwise) any civil proceedings concerning the Company
in any court whether in Luxembourg or elsewhere. No such person shall be liable: (i) for the acts, receipts, neglects, defaults
or omissions of any other such person; or (ii) by reason of his having joined in any receipt for money not received by him
personally; or (iii) for any loss on account of defect of title to any property of the Company; or (iv) on account of the
insufficiency of any security in or upon which any money of the Company shall be invested; or (v) for any loss incurred
through any bank, broker or other agent; or (vi) for any loss, damage or misfortune whatsoever which may happen in or
arise from the execution or discharge of the duties, powers, authorities, or discretions of his office or in relation thereto,
unless the same shall happen through his own gross negligence or wilful misconduct against the Company.

Art. 21. Auditors.
21.1  The  accounting  data  related  in  the  annual  report  of  the  Company  shall  be  examined  by  an  authorised  auditor

(“réviseur d’entreprises agréé”) appointed by the general meeting of Shareholders and remunerated by the Company.

21.2 The auditor shall fulfil all duties prescribed by the 2010 Law.

Title IV. General meetings - Accounting year - Distributions

Art. 22. General Meetings of Shareholders of the Company.
22.1 The general meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Com-

pany. Its resolutions shall be binding upon all the Shareholders regardless of the Class of Shares held by them. It shall have
the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

22.2 The general meeting of Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors.
22.3 It may also be called upon the request of Shareholders representing at least one tenth of the share capital of the

Company.

22.4 The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office or at a place

specified in the notice of meeting, at 11.30 a.m. (Luxembourg time) on the last Friday of the month of April of each year.

22.5 If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next

following Business Day.

22.6 Other meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices

of meeting.

22.7 The Board of Directors may convene a general meeting of Shareholders pursuant to a notice setting forth the agenda

published to the extent and in the manner required by Luxembourg law and/or sent at least eight (8) days prior to the meeting
to each registered Shareholder at the Shareholder’s address in the register of Shareholders or at such other address indicated
by the relevant Shareholder. No evidence of the giving of such notice to registered Shareholders is required by the meeting.
The agenda shall be prepared by the Board of Directors except in the instance where the meeting is called on the written
demand of the Shareholders in which instance the Board of Directors may prepare a supplementary agenda.

Shareholders representing at least one tenth of the share capital may request the adjunction of one or several items to

the agenda of any general meeting of Shareholders. Such a request must be sent to the registered office of the Company
by registered mail five days at the latest before the relevant meeting.

22.8 If all Shares are in registered form and if no publications are made, notices to Shareholders may be mailed by

registered mail only.

22.9 If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the

agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

22.10 The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders in order to attend

any meeting of Shareholders.

22.11 The business transacted at any meeting of the Shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda

(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

22.12 Each Share of whatever Class is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles of

Incorporation. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing,
by mail or by facsimile transmission, who need not be a Shareholder and who may be a Director.

22.13 Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting of Shareholders are passed by a

simple majority vote of the Shareholders validly cast, regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nihil
vote shall not be taken into account.

22.14 Each Shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail,

facsimile or any other means of communication to the Company’s registered office or to the address specified in the
convening notice. The Shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place,
date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as
for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed
resolution by ticking the appropriate box.

32813

L

U X E M B O U R G

Art. 23. General Meetings of Shareholders of Classes of Shares.
23.1 The Shareholders of the Class or Classes issued may hold, at any time, general meetings to decide on any matters

which relate exclusively to such Class or Classes.

23.2 In addition, the Shareholders of any Class of Shares may hold, at any time, general meetings to decide on any

matters which relate exclusively to such Class.

23.3 The provisions of Article 22, paragraphs 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 shall apply to such general meetings of

Shareholders.

23.4 Unless otherwise provided for by law or herein, resolutions of the general meeting of Shareholders of a Class are

passed by a simple majority of the validly cast votes.

Art. 24. Closure of Classes.
24.1 In the event that for any reason the value of the assets in any Class has not reached or has decreased to an amount

determined by the Board of Directors to be the minimum level for such Class to be operated in an economically efficient
manner, or in case of a substantial modification in the political, economic or monetary situation or as a matter of economic
rationalisation, the Board of Directors may decide to compulsorily redeem all the Shares of the relevant Class or Classes
at the Net Asset Value per Share (taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses),
determined as of the Valuation Day at which such decision shall take effect and therefore close the relevant Class or Classes.
The Company shall serve a notice to the Shareholders of the relevant Class or Classes of Shares prior to the effective date
for the compulsory redemption, which will indicate the reasons for, and the procedure of, the redemption operations. Unless
it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between the Shareholders, the Shareholders of the
Class concerned may continue to request redemption or conversion of their Shares free of charge (but taking into account
actual realisation prices of investments and realisation expenses) prior to the effective date of the compulsory redemption.

24.2 Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by paragraph 24.1 of this Article, the general

meeting of Shareholders of any Class may, upon a proposal from the Board of Directors, redeem all the Shares of the
relevant Class and refund to the Shareholders the Net Asset Value of their Shares (taking into account actual realisation
prices of investments and realisation expenses) determined as of the Valuation Day at which such decision shall take effect.
There shall be no quorum requirements for such general meeting of Shareholders which shall decide by resolution taken
by simple majority of the votes validly cast.

24.3 Assets which may not be distributed to the relevant beneficiaries upon the implementation of the redemption will

be deposited with the Depositary for the period required by Luxembourg law; after such period, the assets will be deposited
with the “Caisse de Consignation” on behalf of the persons entitled thereto.

24.4 All redeemed Shares must be cancelled.

Art. 25. Mergers.
25.1. Mergers decided by the Board of Directors
The Board of Directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of the 2010 Law) where the Company

is the receiving UCITS, with:

- another existing or new Luxembourg or foreign UCITS (the “New UCITS”); or
- a sub-fund thereof,
The Board of Directors may solely decide on the merger and effective date thereof where the Company is the receiving

UCITS (within the meaning of the 2010 Law).

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the 2010 Law, in particular concerning the

merger project and the information to be provided to the Shareholders.

25.2. Mergers decided by the Shareholders
Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding section, a merger (within the meaning

of the 2010 Law) of the Company, either as receiving or absorbed UCITS, with:

- a New UCITS; or
- a sub-fund thereof,
may be decided by a general meeting of the Shareholders for which there shall be no quorum requirement and which

will decide on such a merger and its effective date by a resolution adopted at a simple majority of the votes validly cast at
such meeting.

In the case the Company is the absorbed UCITS (within the meaning of the 2010 Law), and hence ceases to exist, only

the general meeting of the Shareholders may approve and decide on the effective date of such merger by a resolution
adopted with no quorum requirement and at a simple majority of the votes validly cast at such meeting.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the 2010 Law, in particular concerning the

merger project and the information to be provided to the Shareholders.

General
Shareholders will in any case be entitled to request, without any charge other than those retained by the Company to

meet disinvestment costs, the repurchase or redemption of their Shares, or, where possible, to convert them into units or

32814

L

U X E M B O U R G

shares of another UCITS pursuing a similar investment policy and managed by the same management company or by any
other company with which the management company is linked by common management or control, or by substantial direct
or indirect holding, in accordance with the provisions of the 2010 Law.

The Company may also absorb a UCI or a sub-fund thereof in compliance with the applicable law, either by decision

of the Board of Directors or of the general meeting of the Shareholders.

Art. 26. Accounting Year. The accounting year of the Company shall commence on the 1 January of each year and

terminates on the 31 December of the same year.

Art. 27. Distributions.
27.1 The general meeting of Shareholders of the Class or Classes shall, upon proposal from the Board of Directors and

within the limits provided by law, determine how the results shall be disposed of, and may from time to time declare, or
authorise the Board of Directors to declare, distributions.

27.2 For any Class or Classes of Shares entitled to distributions, the Board of Directors may decide to pay interim

dividends in the frequency and amounts determined by the Board of Directors in compliance with the conditions set forth
by law.

27.3 Payments of distributions to holders of registered Shares shall be made to such Shareholders at their addresses in

the register of Shareholders.

27.4 Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the Board of Directors shall in its

discretion determine from time to time.

27.5 For each Class of Shares, the Board of Directors may decide on the payment of interim dividends in compliance

with legal requirements.

27.6 The Board of Directors may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and

conditions as may be set forth by the Board of Directors.

27.7 Any distribution that has not been claimed within five (5) years of its declaration shall be forfeited and revert to

the relevant Class or Classes of Shares.

27.8 No interest shall be payable by the Company on a dividend which has not been claimed by a Shareholder.

Title V. Final provisions

Art. 28. Depositary.
28.1 To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking or savings institution

- a depositary (the “Depositary”) -as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended.

28.2 The Depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the 2010 Law.
28.3 If the Depositary wishes to retire, the Board of Directors shall use its best endeavours to find a successor Depositary

within two (2) months of the effectiveness of such retirement. The Board of Directors may terminate the appointment of
the Depositary but shall not remove the Depositary unless and until a successor Depositary shall have been appointed to
act in the place thereof.

Art. 29. Dissolution of the Company.
29.1 The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting of Shareholders subject to the

quorum and majority requirements referred to in Article 31 hereof.

29.2 Whenever the share capital falls below two-thirds of the minimum capital indicated in Article 5 hereof, the question

of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting of Shareholders by the Board of Directors. The
general meeting of Shareholders, for which no quorum shall be required, shall decide by a simple majority of the validly
cast votes.

29.3 The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting of Shareholders

whenever the share capital falls below one quarter of the minimum capital set by Article 5 hereof; in such an event, the
general meeting of Shareholders shall be held without any quorum requirement and the dissolution may be decided by
Shareholders holding one quarter of the votes of the Shares represented and validly cast at the meeting.

29.4 The general meeting of Shareholders must be convened so that it is held within a period of forty days from ascer-

tainment that the net assets of the Company have fallen below two-thirds or one quarter of the legal minimum, as the case
may be.

Art. 30. Liquidation of the Company. The liquidation of the Company may either be voluntary or compulsory, in the

conditions more duly set out in the sales documents of the Company and the applicable law.

Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed

by the general meeting of Shareholders which shall determine their powers and their compensation.

The liquidation of the Company will be carried out in accordance with the provisions of the 2010 Law. Such law specifies

the steps to be taken to enable the Shareholders to participate in the distribution(s) of the liquidation proceeds and provides
for a deposit in escrow at the Caisse de Consignation at the time of the closure of the liquidation. Liquidation proceeds
available for distribution to Shareholders in the course of the liquidation that are not claimed by Shareholders at the close

32815

L

U X E M B O U R G

of the liquidation be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg, where for a period of 30 years they will be
held at the disposal of the Shareholders entitled thereto.

Art. 31. Amendments to the Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended by a general

meeting of Shareholders subject to the quorum and majority requirements provided by the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended from time to time. For the avoidance of doubt, such quorum and majority requirements
shall be as follows: fifty percent of the share capital issued must be represented at the general meeting and a super-majority
of two thirds of the votes cast is required to adopt a resolution. In the event that the quorum is not reached, the general
meeting must be adjourned and re-convened. There is no quorum requirement for the second meeting but the majority
requirement remains unchanged.

Art. 32. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time, and the 2010 Law, as may be
amended.

<i>Transitory Dispositions

1) The first accounting year will begin on the date of incorporation of the Company and will end on 31 December 2016.
2) The first annual general meeting of Shareholders will be held in 2017.
3) Interim dividends may also be distributed during the Company’s first financial year.

<i>Subscription and Payment

The share capital of the Company is subscribed as follows:
- three hundred and ten (310) shares have been subscribed by Pioneer Asset Management S.A., aforementioned, for the

total price of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-).

Evidence of the above payment totalling thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) was given to the undersigned notary.
The subscriber declared that upon determination by the Board of Directors, pursuant to the Articles of Incorporation,

of the various Classes of Shares which the Company shall have, it will elect the Class or Classes of Shares to which the
Shares subscribed to shall appertain.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26-1,

26-3 and 26-5 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended and expressly states that they have
been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses of the Company as a result of its creation are estimated at approximately EUR 3,000.-.

<i>Resolution of the Shareholders

The incorporating shareholder representing the entire share capital of the Company and considering itself as duly con-

vened has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg (Grand

Duchy of Luxembourg);

2. The following persons are appointed as directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders

to be held in 2017;

- Mr. Enrico Turchi, born in Carrara (Italy) on 20 October 1959, residing professionally at 8-10, rue Jean Monnet, L-2180

Luxembourg (Luxembourg);

- Mr. David Glassey, born in Coleraine (Northern Ireland) on 25 May 1958, residing professionally at 1, George’s Quay

Plaza, George’s Quay, Dublin 2 (Ireland); and

- Mr. Marco Atzeni, born in Milan (Italy) on 8 April 1970, residing professionally at 1 - Tower B, Piazza Gae Aulenti,

20154 Milan (Italy).

3. The following person is appointed as authorised auditor (“réviseur d’entreprises agréé”) until the general meeting of

shareholders convened to approve the Company’s annual accounts for the first financial year:

Deloitte Audit S.à.r.l, a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office

at 560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

WHEREOF this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person known to the notary by name, first name,

and residence, the said proxyholder of the appearing person signed together with the notary this deed.

Signé: G. GUILLERM et H. HELLINCKX.

32816

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 24 févier 2016. Relation: 1LAC/2016/5994. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 26 février 2016.

Référence de publication: 2016072397/782.
(160036195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

B Medical Systems Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-9809 Hosingen, 17, Op der Hei.

R.C.S. Luxembourg B 166.303.

In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth day of February.
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of B Medical Systems Luxembourg S.à r.l., a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 17, Op der Hei, L-9809 Hosingen, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 166303 (the Company). The
Company was incorporated on 22 December 2011, pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-
sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations (the
Mémorial), N° - 578 of 5 March 2012. Since that date, the Company’s articles of association (the Articles) have been
amended several times, for the last time on 1 September 2015, pursuant to a deed of Maître Danielle Kolbach, notary
residing in Redange sur Attert, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial N° - 2954 of 28 October 2015.

THERE APPEARED:

B Medical Systems Holding S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 17, Op der Hei, L-9809 Hosingen, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 94593 (the Sole
Shareholder),

here represented by Annick Braquet, employee, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a power of attorney given under private seal.

After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, this

power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record that:
I. the Sole Shareholder holds all of the shares in the Company;
II. the agenda of the Meeting is as follows.
1. Acknowledgement of the joint merger proposal providing for the absorption of the Company by its 100% mother

company B Medical Systems Holding S.A., a public limited liability company (the Absorbing Company);

2. Acknowledgement that all the documents required by articles 267 and 278 of the law on commercial companies dated

10 August 1915, as amended, have been deposited at the Company’s registered office or its website for due inspection by
the Shareholder at least one month before the date of the general meeting of the Shareholder of the Company resolving on
the joint draft merger terms

3. Approval of the joint merger proposal and decision to carry out the merger by way of the absorption of the Company

by the Absorbing Company; acknowledgment that from an accounting point of view, the operations of the Company will
be treated as having been carried out on behalf of the Absorbing Company as from the date of this Meeting; acknowledgment
of the effective date of the merger between the parties and of the date of enforceability of the merger towards third parties;

4. Granting of all powers to any member of the Company’s board of directors and to any lawyer and/or employee of

Loyens &amp; Loeff Luxembourg SARL, each acting individually, with full power of substitution, to execute any documents
and perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the merger; and

5. Miscellaneous.
III. The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder

considers himself as duly convened and declares to have perfect knowledge of the agenda which was communicated to it
in advance and consequently waives all the rights and formalities it is entitled to for the convening of the Meeting.

IV. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

32817

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge that it has been acquainted with the joint merger proposal dated 23

December 2015, published in the Mémorial, N° - 3474 of 30 December 2015 (the Joint Merger Proposal), in accordance
with article 262 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) and providing for the
absorption of the Company by its 100% mother company B Medical Systems Holding S.A., a public limited liability
company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered
office at 17, Op der Hei, L-9809 Hosingen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 94593 (the Absorbing Company and together with the Company, the Merging
Companies or individually, a Merging Company).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge that the Joint Merger Proposal, the Merging Companies’ annual accounts

and annual reports (if any) of the last three financial years and the Merging Companies interim balance sheet dated 30
November 2015 have been deposited at the Company’s registered office or its website, if any, at least one month before
the date hereof in order to allow it to review them.

A certificate attesting the deposit of said documents, duly signed by an authorised representative of the Company, has

been given to the notary.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the Joint Merger Proposal and to carry out the merger by way of the Company’s

absorption by the Absorbing Company, in accordance with the conditions detailed in the Joint Merger Proposal; The Sole
Shareholder resolves further to acknowledge (i) the Company’s dissolution without liquidation as per the effective date by
way of transfer at book value of all the Company’s assets and liabilities to the Absorbing Company, all in accordance with
the Joint Merger Proposal and (ii) the cancellation of the Company’s shares held by the Absorbing Company as a conse-
quence of the merger.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge that (i) for accounting purposes, the Company’s operations will be treated

as having been carried out on behalf of the Absorbing Company as from the date of the Meeting, (ii) the merger takes effect
between the Merging Companies on the date of the concurring general meetings of the shareholders of the Merging Com-
panies approving the merger and is enforceable towards third parties after the publication in the Mémorial of the minutes
of the general meetings of the Merging Companies’ shareholders approving the merger.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to grant all powers to any member of the Company’s board of managers and to any lawyer

and/or employee of Loyens &amp; Loeff Luxembourg SARL, each acting individually, with full power of substitution, to execute
any documents and perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with
the merger.

<i>Declaration

The undersigned notary states, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and the

validity of the legal acts and formalities required of the Company and of the Joint Merger Proposal.

There being no further business, the Meeting is adjourned.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with the present

deed are estimated at approximately EUR 2,000.-

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, this deed is

drawn up in English, followed by a French version, and in the case of divergences, the English text prevails.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day state above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the sole shareholder’s authorised representative.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille seize, le dix-neuvième jour de février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de B Medical Systems Luxembourg S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège
social est établi au 17, Op der Hei, L-9809 Hosingen, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce

32818

L

U X E M B O U R G

et des Sociétés sous le numéro B 166303 (la Société). La Société a été constituée le 22 décembre 2011, suivant un acte de
Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) N° - 578 du 5 mars 2012. Depuis, les statuts de la Société (les Statuts)
ont été modifiés à plusieurs reprises et le plus récemment le 1 

er

 septembre 2015 suivant un acte de Maître Danielle Kolbach,

notaire de résidence à Redange sur Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri Hel-
linckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial N° - 2954 du 28 octobre
2015.

A COMPARU:

B Medical Systems Holding S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Lu-

xembourg, dont le siège social est établi au 17, Op der Hei, L-9809 Hosingen, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 94593 (l’Associé Unique),

ici représenté par Annick Braquet, employée, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Après signature ne varietur par le représentant autorisé de l’Associé Unique et le notaire instrumentant, cette procuration

restera annexée aux présentes minutes pour être enregistrée avec ce dernier.

L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. L’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans la Société;
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Prise d’acte du projet commun de fusion prévoyant l’absorption de la Société par sa société mère à 100% B Medical

Systems Holding S.A., une société anonyme (la Société Absorbant);

2. Prise d’acte que tous les documents requis par les articles 267 et 278 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été déposés au siège social de la Société ou mis sur son site internet pour que les
actionnaires puissent en prendre connaissance au moins un mois avant la date de l’assemblée générale des actionnaires de
la Société appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion;

3. Approbation du projet commun de fusion et décision d’effectuer la fusion par absorption de la Société par la Société

Absorbante; prise d’acte que, d’un point de vue comptable, les opérations de la Société seront traitées comme si elles avaient
été exécutées pour le compte de la Société Absorbante depuis la date de la présente Assemblée; prise d’acte de la date
d’effet de la fusion entre les parties et de la date de prise d’effet de la fusion envers les tiers;

4. Pouvoir et autorité à tout membre du conseil d’administration de la Société et à tout avocat et/ou employé de Loyens

&amp; Loeff Luxembourg SARL, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, afin d’exécuter tous
documents et d’accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation
avec la fusion; et

5. Divers.
III. L’intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l’Associé Unique, se considère lui-même

comme dûment convoqué et déclare connaître parfaitement l’ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable, et par
conséquent renonce à tous les droits et formalités de convocation de l’Assemblée auxquels il a droit.

IV. l’Assemblée décide de prendre les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de prendre acte qu’il a pris connaissance du projet commun de fusion daté du 23 décembre

2015, publié au Mémorial, N° - 3474 du 30 décembre 2015 (le Projet Commun de Fusion) conformément à l’article 262
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et prévoyant l’absorption de la Société
par sa société mère à 100% B Medical Systems Holding S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 17, Op der Hei, L-9809 Hosingen, Grand-Duché de Lu-
xembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 94593 (la Société Absorbante et
ensemble avec la Société, les Sociétés qui Fusionnent ou individuellement une Société qui Fusionne).

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de prendre acte que le Projet Commun de Fusion et les comptes annuels et, le cas échéant, les

rapports de gestion annuels des trois derniers exercices des Sociétés qui Fusionnent et le bilan intérimaire daté du 30
novembre 2015 des Sociétés qui Fusionnent ont été déposés au siège social de la Société ou, le cas échéant, mis sur son
site internet pour que les actionnaires puissent en prendre connaissance au moins un mois avant la date des présentes.

Un certificat attestant le dépôt de ces documents, dûment signé par un représentant autorisé de la Société, a été remis

au notaire.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide d’approuver le Projet Commun de Fusion et d’effectuer la fusion par absorption de la Société

par la Société Absorbante, conformément aux conditions détaillées dans le Projet Commun de Fusion. L’Associé Unique
décide par ailleurs de prendre acte (i) de la dissolution sans liquidation de la Société à la date de prise d’effet par transfert

32819

L

U X E M B O U R G

à la valeur comptable de tous les actifs et passifs de la Société à la Société Absorbante, en conformité avec le Projet Commun
de Fusion et (ii) de l’annulation, en conséquence de la fusion, des parts sociales de la Société détenues par la Société
Absorbante.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide par ailleurs de prendre acte (i) que d’un point de vue comptable, les opérations de la Société

seront traitées comme si elles avaient été exécutées pour le compte de la Société Absorbante à compter de la date de la
présente Assemblée, (ii) que la fusion prend effet entre les Sociétés qui Fusionnent à la date des assemblées générales
concordantes des actionnaires des Sociétés qui Fusionnent approuvant la fusion et prend effet à l’égard des tiers après la
publication au Mémorial des procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires des Sociétés qui Fusionnent ap-
prouvant la fusion.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de donner tous les pouvoirs à tout membre du conseil de gérance de la Société et à tout avocat et/

ou employé de Loyens &amp; Loeff Luxembourg SARL, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution,
afin d’exécuter tous documents et d’accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou
souhaitables en relation avec la fusion.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément à l’article 271(2) de la Loi avoir vérifié et certifie l’existence et la légalité

de tous actes et formalités incombant à la Société et du Projet Commun de Fusion.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée est ajournée.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société relatif au présent acte s’élèvent

approximativement à EUR 2.000.-

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la
version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le représentant autorisé de l’associé unique.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 23 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5823. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2016.

Référence de publication: 2016073254/191.

(160037542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.

Baumann and Partners - Premium Select, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 143.708.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 1. März 2016.

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2016073260/12.

(160037613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.

32820

L

U X E M B O U R G

Strategie Pro Rendite SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 176.619.

AUFLÖSUNG

Die einzige Aktionärin der White Owl Renewable Energy S.A. SICAV-FIS („Gesellschaft“) hat in der außerordentlichen

Gesellschafterversammlung, welche am 29. Oktober 2015 um 16.00 Uhr in den Geschäftsräumen der LRI INVEST S.A.,
9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach stattgefunden hat, den Abschluss der Liquidation genehmigt.

Der Liquidationserlös beträgt: EUR 803,33
Die Bücher und Schriftstücke der Gesellschaft sind ab dem 29. Oktober 2015 hinterlegt worden und werden für einen

Zeitraum von 5 Jahren am früheren Gesellschaftssitz der Gesellschaft aufbewahrt.

Die Liquidationserlöse sind an die Aktionäre der Gesellschaft verteilt worden, sodass eine Übertragung zur Caisse de

Consignation nicht erforderlich war. Das Liquidationsverfahren ist mithin abgeschlossen.

<i>Der Liquidator

Référence de publication: 2016073679/17.
(160037440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.

1798 US Special Situations Master Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

The board of directors of the management company Lombard Odier Funds (Europe) S.A., a société anonyme which

registered office is at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered on the Registre de commerce et des sociétés under
No. B-152.886, has decided to put the Master Fund into liquidation with effect as of 29 February 2016, at the close of
business in Luxembourg, following the receipt of a full redemption request from the sole unitholder of the Master Fund.

Référence de publication: 2016075087/8.

Brixton 3 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 134.795.

Par résolutions signées en date du 24 décembre 2015, l'associé unique a décidé
- d'acter et d'accepter la démission de Thierry Drinka de son mandat de gérant avec effet au 24 décembre 2015
- de nommer Carl Tash avec adresse professionnelle au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en qualité de

gérant pour une durée indéterminée à compter du 24 décembre 2015

- de modifier l'adresse professionnelle de Julien Petitfrère, Gérant, du 3 rue Mozart, L-2166 Luxembourg au 2-4 rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

- de noter le changement d'adresse de l'associé de la Société du 44 avenue JF Kennedy, L-1855 Kirchberg au 6 rue

Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach avec effet au 24 décembre 2015

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001849/18.
(160000033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Banque de Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 5.310.

La liste des signatures autorisées de la BANQUE DE LUXEMBOURG a été déposée au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Benoît Elvinger
<i>Secrétaire du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2016001854/13.
(150241193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

32821

L

U X E M B O U R G

Bundesverband Investmentkraft S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 80.229.

Le siège social de la société BUNDESVERBAND INVESTMENTKRAFT S.A. au 2 rue Astrid, L-1143 Luxembourg,

inscrite au R.C. Luxembourg, section B numéro 80.229, a été dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Maître Daniel PHONG
<i>Avocat à la Cour

Référence de publication: 2016001874/11.
(160000202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

C.M. Transports S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4710 Pétange, 120, rue d'Athus.

R.C.S. Luxembourg B 54.227.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 02

<i>janvier 2016

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 02 Janvier 2016 que les associés ont décidé de transférer le siège

social de L-4711 PETANGE, 163, rue d'Athus à L-4710 PETANGE, 120, rue d'Athus.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
C.M TRANSPORTS S.à R.L.
163, RUE D’ATHUS
L-4711 PÉTANGE
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016001877/18.
(160000222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

CaixaBank Global SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 179.158.

<i>Extrait de la résolution circulaire datée du 16 décembre 2015

Le Conseil D'Administration décide de nommer par cooptation M. Francisco Javier Estrada Fernández Hontoria, résidant

professionnellement au Paseo Recoletos 37, Madrid, 28004, Espagne, en tant qu'administrateur de la Société à partir du 16
décembre 2015 pour une durée déterminée qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2016 en remplacement de M Guillermo Hermida Lazcano.

Le Conseil D'Administration décide de nommer par cooptation M. Jean-Michel Loehr, résidant professionnellement au

15, Parc Lesigny, L-5753 Frisange, en tant qu'administrateur de la Société à partir du 16 décembre 2015 pour une durée
déterminée qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016 en remplacement de M
William Anthony Jones

Le Conseil D'Administration décide de nommer M. Juan Pedro Bernal Aranda comme président
Référence de publication: 2016001879/17.
(160000330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Cervia GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35F, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 199.596.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions des gérants en date du 12 décembre 2015

Les gérants de la Société ont décidé comme suit, de:
- transférer le siège social de la Société au 35 F, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet immédiat.
- transférer l'adresse professionnelle des gérants suivants au 35 F, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg:

32822

L

U X E M B O U R G

Kenneth MacRae
Aneta Bondar
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Cervia GP S.à r.l.

Référence de publication: 2016001881/17.
(160000592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Citibank International Limited (Luxembourg Branch), Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 78.602.

FERMETURE DE SUCCURSALE

Il est porté à l'attention du public que les activités de Citibank International Limited, Luxembourg Branch ont pris fin

en date du 1 

er

 janvier 2016 suite à la fusion transfrontalière intervenue entre Citibank Europe plc et Citibank International

Limited par voie d'absorption de cette dernière.

Bertrange, le 31 décembre 2015.

<i>Pour le compte de Citibank International Limited, Luxembourg Branch
Alberta Brusi
<i>Citi Country Officer

Référence de publication: 2016001885/15.
(160000672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Clover Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 129.901.

Par résolutions signées en date du 24 décembre 2015, l'associé unique a décidé
- de nommer Carl Tash avec adresse professionnelle au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en qualité de

gérant pour une durée indéterminée à compter du 24 décembre 2015

- de modifier l'adresse professionnelle de Thierry Drinka, Gérant, du 3 rue Mozart, L-2166 Luxembourg au 2-4 rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

- de modifier l'adresse professionnelle de Julien Petitfrère, Gérant, du 3 rue Mozart, L-2166 Luxembourg au 2-4 rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

- de noter la décision des gérants de la Société de transférer le siège social de la Société du 58 rue Chrales Martel, L-2134

Luxembourg au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 24 décembre 2015

- de refléter auprès du RCS le nom actuel de l'associé de la Société à savoir SOF-10 Starlight 18 GBP S.à r.l. devenu

SOF-10 Beagle JVCo Lux S.à r.l. en vertu d'une décision de son associé en date du 17 septembre 2015 publié le 14 novembre
2015 sous le numéro 3109

- de noter le changement d'adresse de l'associé de la Société du 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 2-4 rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 24 décembre 2015

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001888/24.
(160000071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Colt Group S.A, Société Anonyme.

Capital social: EUR 448.416.202,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 115.679.

L'administrateur mentionné ci-dessous a informé le conseil d'administration de Colt Group S.A. (la "Société") qu'il s'est

retiré de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 31 décembre 2015.

- Rakesh Bhasin, 15 St Botolph Street, Beaufort House, London, EC3A 7QN, UK

32823

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

<i>Pour la société Colt Group S.A.
Esmée Chengapen

Référence de publication: 2016001890/15.
(150241229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Colt Lux MP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 160.405.

Le gérant mentionné ci-dessous a informé le conseil d'administration de Colt Lux MP S.à r.l. (la "Société") qu'il s'est

retiré de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2015.

- Rakesh Bhasin, 15 St Botolph Street, Beaufort House, London, EC3A 7QN, Grande Bretagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

<i>Pour la société Colt Lux MP S.à r.l.
Esmée Chengapen

Référence de publication: 2016001891/15.
(150241228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Concrete Investment II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 2.031.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 185.143.

<i>Extrait de la résolution prise par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 29 décembre

<i>2015

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer, en remplacement de Monsieur Antonio Lopes, Monsieur

Alexander Nelke, né le 6 janvier 1978 à Berlin, Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 52-54 avenue du X
Septembre, L-2550 Luxembourg, comme gérant de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale qui se
tiendra en 2016 statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2015.

Par conséquent, le conseil de gérance sera composé des personnes suivantes:
- Petra J.S. Dunselman, gérant;
- Alexander Nelke, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016001896/18.
(150241028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Candle LuxCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 665.525,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 116.474.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Les associés ont décidé de prononcer la clôture de la liquidation de la Société lors de l'assemblée générale extraordinaire

tenue le 31 décembre 2015.

L'Assemblée a décidé que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant une durée

de cinq ans à l'adresse suivante:

46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

32824

L

U X E M B O U R G

FIDES (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2016001910/18.
(160001172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Irma Finances Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.420,00.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 202.542.

STATUTS

L'an deux mil quinze, le seize décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société VENUS, société anonyme de droit français, établie et ayant son siège social au 1, rue Jean Chevolleau,

F-85120 Antigny, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de la Roche-sur-Yon sous le numéro 814 336 871,
ici représenté par Monsieur Loïc PERROT, aux termes d'une procuration lui ayant été expressément accordé par le conseil
d'administration en date du 10 novembre 2015;

2. La société VERDI FINANCES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au

49, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 197.908, ici représenté par son administrateur-délégué Monsieur Luc NEYME, aux termes d'une procuration lui ayant
été expressément accordé par le conseil d'administration en date du 13 novembre 2015;

3. La société PETALE FINANCES S.A. société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au

49, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 197.923, ici représenté par son administrateur-délégué Monsieur Loïc PERROT, aux termes d'une procuration lui ayant
été expressément accordé par le conseil d'administration en date du 13 novembre 2015.

Lesquelles copies des procès-verbaux, après avoir été signées «ne varietur» resteront annexées au présent acte pour être

soumises avec lui aux formalités de l'Enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une

société à responsabilité à constituer.

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est “IRMA FINANCES SARL” (la Société). La Société est une société

à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut

être transféré dans la commune par décision des gérants. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par

décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique
ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à compromettre
les activités normales de la Société au lieu de son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger,
le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures
provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste
une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social. La société aura pour activité le conseil et l'assistance en développement et gestion d'entreprise et

notamment à ce titre, sans que cette liste puisse être considérée comme limitative, des activités de conseil en développement,
de gestion administrative, d'analyse de marché, d'analyse en besoin de développement, en recherche de fournisseurs et
distributeurs.

La société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises

sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La société peut notamment acquérir par souscription,
achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances,
certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par
toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute

32825

L

U X E M B O U R G

société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre, d'obligations

et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous
emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autre sociétés. La Société peut également consentir des garanties
et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir
ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société
ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l'autorisation requise.

La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements

et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société a également pour objet l'acquisition, le développement, la mise en valeur, la commercialisation et la gestion,

pour son compte ou pour le compte de tiers, de marques, brevets, franchises, master franchises royalistes et tous autres
droits de propriété industrielle et intellectuelle.

La  Société  peut  effectuer  toutes  les  opérations  commerciales,  financières  ou  industrielles  et  toutes  les  transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent vingt euros (EUR 12.420,-), représenté par douze mille quatre

cent vingt (12.420) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable

des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-quarts

des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes

à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants peuvent ne pas être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
7.3. L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de Catégorie A et un ou

plusieurs gérants de Catégorie B.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,

qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

32826

L

U X E M B O U R G

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures

à  l'avance,  sauf  en  cas  d'urgence,  auquel  cas  la  nature  et  les  circonstances  de  cette  urgence  sont  mentionnées  dans  la
convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir

parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une
réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions
se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les

décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés sous la condition
que, si l'associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de Catégorie A et un ou plusieurs gérants de
Catégorie B, au moins un (1) gérant A et un (1) gérant B (à chaque fois, soit en personne soit par procuration) votent en
faveur de la résolution. Le Président ne dispose pas d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante.

(vi) Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun

président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) Sous réserve de l'article 8.3 (iii), la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature

individuel d'un gérant.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

(iii) Si l'associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou plusieurs gérants de

Catégorie B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d'un gérant de Catégorie A et d'un gérant
de Catégorie B.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les
associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement
convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

32827

L

U X E M B O U R G

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la

date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans
la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv)  Si  tous  les  associés  sont  présents  ou  représentés  et  se  considèrent  comme  ayant  été  valablement  convoqués  et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute

Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale
ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale
ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des
Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-

quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la

Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés

doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur

des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la

loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la

durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2.  Les  associés  décident  de  l'affectation  du  solde  des  bénéfices  nets  annuels.  Ils  peuvent  allouer  ce  bénéfice  au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants

sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excès à la Société.

32828

L

U X E M B O U R G

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié des associés

détenant les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être
associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des
associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales

pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Résolutions
Circulaires  des  Associés,  selon  le  cas,  sont  apposées  sur  un  original  ou  sur  plusieurs  copies  du  même  document,  qui
ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l'article 13.1 des Statuts, le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le

31 décembre 2015.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les douze mille quatre cent vingt (12.420) parts sociales ont été souscrits

comme suit:

Associés:

Parts-Sociales:

VENUS, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.140 (quatre mille cent quarante)

VERDI FINANCES S.A., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.140 (quatre mille cent quarante)

PETALE FINANCES S.A., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.140 (quatre mille cent quarante)

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.420 (douze mille quatre cent vingt)

Les  douze  mille  quatre  cent  vingt  (12.420)  parts  sociales  ont  été  entièrement  libérées  par  les  souscripteurs  prédits

moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme douze mille quatre cent vingt euros (12.420,- EUR) se trouve
dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation
bancaire, qui le constate expressément.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent

approximativement à mille quatre cents euro (EUR 1.400,-).

<i>Résolutions des associés

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social

souscrit, ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à deux (2). Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société

pour une durée indéterminée:

- Monsieur Luc NEYME, Directeur de Sociétés, né le 12 novembre 1958 à Paris (France), demeurant au 1, rue Jean

Chevolleau, F-85120 Antigny;

- Monsieur Loïc PERROT, Dirigeant de sociétés, né le 28 août 1962 à Paris (France), demeurant au 3, allée des Char-

milles, F-86550 Mignaloux Beauvoir.

2. Le siège social de la Société est établi au 49, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: L. Perrot, L. Neyme et M. Schaeffer.

32829

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 17 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/29117. Reçu soixante-quinze

euros Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 24 décembre 2015.

Référence de publication: 2015210431/271.
(150236195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2015.

GEFIP INVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 52.100.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015208903/10.
(150235108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2015.

e-conomic international MidCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: DKK 86.694.240,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 178.313.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue en date du 30

<i>décembre 2015

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société:
- approuve le rapport du liquidateur et du commissaire à la liquidation;
- donne décharge au commissaire à la liquidation, au liquidateur et aux gérants de la Société;
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 30 décembre

2015;

- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse

suivante: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2016.

e-conomic international MidCo S.àr.l.
En liquidation volontaire
Signature

Référence de publication: 2016001770/23.
(160000745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

AA Iberian Natural Resources &amp; Tourism S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 142.406.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 22 décembre 2015

- La cooptation de Madame Anne-Marie GREGIS, employée privée, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch,

L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Stéphanie COLLEAUX, démissionnaire est
ratifiée.

- La démission de Monsieur Ahcène BOULHAIS, Madame Anne-Marie GREGIS et Monsieur Marc LIMPENS, em-

ployés privés, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg de leurs mandats d’Administrateurs
est acceptée.

32830

L

U X E M B O U R G

- Messieurs Philippe TOUSSAINT, Xavier SOULARD et Patrick WILWERT, employés privés, résidant profession-

nellement  au  24,  Rue  Astrid,  L-1143  Luxembourg  sont  nommés  comme  nouveaux  Administrateurs.  Leurs  mandats
viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2020.

- Le siège social de la société est transféré au 24, Rue Astrid, L-1143 Luxembourg

Fait à Luxembourg, le 22 décembre 2015.

Certifié sincère et conforme
AA-IBERIAN NATURAL RESOURCES &amp; TOURISM S.A.

Référence de publication: 2016001796/21.
(160000321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Agramunt GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35F, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 199.603.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions des gérants en date du 12 décembre 2015

Les gérants de la Société ont décidé comme suit, de:
- transférer le siège social de la Société au 35 F, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet immédiat.
- transférer l'adresse professionnelle des gérants suivants au 35 F, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg:
Kenneth MacRae
Aneta Bondar
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Agramunt GP S.à r.l.

Référence de publication: 2016001777/17.
(160000595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Agramunt SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35F, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 200.361.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions des gérants en date du 12 décembre 2015

Les gérants de la Société ont décidé comme suit, de:
- transférer le siège social de la Société au 35 F, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet immédiat.
- transférer le siège social de son gérant associé commandité et de son associé au 35 F, Avenue John F. Kennedy, L-1855

Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Agramunt SCSp

Référence de publication: 2016001778/15.
(160000591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Agrifinco, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 162.140.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 28 décembre 2015

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2015:

- Monsieur Christian FREY, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à CH-8002 Zurich, Splügens-

trasse 12, Président

- Monsieur Murad IKHTIAR, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2,

avenue Charles de Gaulle,

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1653 Luxem-

bourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

32831

L

U X E M B O U R G

Est nommé commissaire aux comptes, en remplacement de Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision

Comptable, en abrégé CLERC, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2015:

- AUDIEX S.A., 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2016001780/22.
(160000309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

KHM SP Neuhauser Straße 20 Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 150.729.

<i>Auszug aus dem Kauf- und Abtretungsvertrag vom 18. Dezember 2015

Aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrag über Gesellschaftsanteile der Gesellschaft vom 18. Dezember 2015 haben

sich folgende Änderungen in der Teilhaberstruktur der Gesellschaft ergeben:

- CENSI SP S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischem Recht mit Sitz in 5, rue

Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre des Commerce et des Sociétés)
unter der Nummer B 21.630 hält nunmehr an der Gesellschaft:

0 Anteile.
- SIGNA KHM SP Beteiligung S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischem Recht,

mit Sitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre des Commerce
et des Sociétés) unter der Nummer B 164.318 hält nunmehr an der Gesellschaft:

31.000 Anteile.
Référence de publication: 2016003019/18.
(160001013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

King George Holdings Luxembourg IIA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 75.000,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 104.271.

CLÔTURE DE LA LIQUIDATION

<i>Extrait

A l'issue des résolutions prises par l'Associé Unique de la Société lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le

31 décembre 2015 à Luxembourg, il a été résolu ce qui suit:

- de clôturer la liquidation de la Société,
- de conserver les documents légaux et les livres de la Société au siège social de la Société à savoir au 174, route de

Longwy, L-1940 Luxembourg et ceci pour une période de cinq ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016003004/16.
(160001696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Fiducis, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 113.938.

Il résulte d'une lettre adressée à la Société que Monsieur Fred MOLITOR, demeurant à 12, route d'Arlon, Luxembourg

donne sa démission en tant que gérant de la Société avec effet au 1 

er

 janvier 2016.

Luxembourg, le 24 décembre 2015.

Référence de publication: 2016002896/10.
(160001055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

32832


Document Outline

1798 US Special Situations Master Fund

AA Iberian Natural Resources &amp; Tourism S.A.

Agramunt GP S.à r.l.

Agramunt SCSp

Agrifinco

ArcelorMittal Rodange et Schifflange

ArcelorMittal Rodange et Schifflange

ArcelorMittal Rodange et Schifflange

Backstein Finanzgesellschaft A.G.

Banque de Luxembourg

Baumann and Partners - Premium Select

B Medical Systems Holding S.A.

B Medical Systems Luxembourg S.à r.l.

Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch

Brixton 3 Sàrl

Bundesverband Investmentkraft S.A.

CaixaBank Global SICAV

Candle LuxCo 2 S.à r.l.

Cervia GP S.à r.l.

Citibank International Limited (Luxembourg Branch)

Clover Investments Sàrl

C.M. Transports S.à.r.l.

Colt Group S.A

Colt Lux MP S.à r.l.

Concrete Investment II S.C.A.

e-conomic international MidCo S.à r.l.

Fiducis

GEFIP INVEST

Generali European Real Estate Investments S.A.

Global Advantage Funds

Gunco Invest

Irma Finances Sàrl

KHM SP Neuhauser Straße 20 Beteiligung S.à r.l.

King George Holdings Luxembourg IIA S.à r.l.

Konnick Invest S.A.

L'Hautain Chat S.A.

Mateco Location de Nacelles S.A.

PNR Global (ex-Japan) Aggregate Bond

Rue Elisabeth

RUE ELISABETH S.à r.l.

Strategie Pro Rendite SICAV-FIS