This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 503
20 février 2016
SOMMAIRE
Advice S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24137
Aircraft Solutions Lux IX S.à r.l. . . . . . . . . . . .
24127
Aircraft Solutions Lux XV S.à r.l. . . . . . . . . . .
24129
Aircraft Solutions Lux XX S.à r.l. . . . . . . . . . .
24131
Blackwood International Group S.à r.l. . . . . .
24140
Cabinet Comptable Madimba S.à r.l. . . . . . . .
24139
Capesius et Reding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
24137
CASHMERE Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24135
CLSec 1 Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24142
Corestate Turbo FRA HoldCo S.à r.l. . . . . . . .
24138
Emerging Markets Taxi Holding S.à r.l. . . . . .
24104
Garage PIANARO s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
24099
Gärtnerei Sunflower, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
24099
Geimer Services SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24098
Gerim III s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24099
G.I.S.H. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24099
Glofin A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24098
Glofin A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24098
Goodman Europe (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
24099
Goodman Industrial Real Estate Luxembourg
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24099
Goodman Princeton Holdings (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24098
Gubernantia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24100
Hairdress by Tess S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
24133
Herman International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
24100
Hohenzollern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24100
Hotel-Restaurant Lanners Sàrl . . . . . . . . . . . .
24100
I.C.C.Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
24100
I.F.Z. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24100
Immobilière DE LA FONTAINE . . . . . . . . . . .
24104
Immo Gold S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24098
Katone World S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24139
Luxeral Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
24101
Maclean SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24101
Mauritania Gulf S.à. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24101
Michel NEIZEN GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24101
Michel NEIZEN GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24101
Mythos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24103
Nénuphar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24103
Nénuphar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24103
Nénuphar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24103
Nénuphar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24103
Netto-Recycling S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24102
Nexis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24102
Nexis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24102
Nexis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24102
N. Kimmel S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24103
Nouvelle Electricité BASTIAN S.à.r.l. . . . . . . .
24102
Olinda Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24144
Plazza Investments & Properties S.à r.l. . . . . .
24144
24097
L
U X E M B O U R G
Glofin A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 31.335.
Les comptes annuels de la Société au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Glofin A.G.
Signature
Référence de publication: 2016005626/12.
(160004477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Glofin A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 31.335.
Les comptes annuels de la Société au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Glofin A.G. s.a.
Signature
Référence de publication: 2016005627/12.
(160004478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Goodman Princeton Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 153.622.
Dépôt rectificatif du dépôt initial effectué le 27/07/2015 sous le numéro L150135089, concernant le bilan au 31 décembre
2014 qui a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005600/10.
(160003667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Geimer Services SARL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3844 Schifflange, z.i. Letzebuerger Heck.
R.C.S. Luxembourg B 150.915.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016005613/10.
(160004699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Immo Gold S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.
R.C.S. Luxembourg B 153.110.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016005677/10.
(160003992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
24098
L
U X E M B O U R G
Gärtnerei Sunflower, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7712 Colmar-Berg, 24, rue de Bissen.
R.C.S. Luxembourg B 103.799.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005588/9.
(160004758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
G.I.S.H. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-3462 Dudelange, 3, rue Edison.
R.C.S. Luxembourg B 137.523.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005590/9.
(160004598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Garage PIANARO s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 19, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 12.587.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005594/9.
(160004760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Goodman Europe (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 16.880.000,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 105.319.
Le bilan au 30 juin 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005598/9.
(160003703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Goodman Industrial Real Estate Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 114.985.
Les comptes annuels au 30/06/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005599/9.
(160003665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Gerim III s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9016 Ettelbruck, 1, rue de l'Ecole Agricole.
R.C.S. Luxembourg B 39.230.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005615/9.
(160003833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
24099
L
U X E M B O U R G
Gubernantia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8339 Olm, 14, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 113.135.
Les comptes annuels au 31 août 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005641/9.
(160004018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Herman International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 166.404.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005659/9.
(160004541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Hohenzollern, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3462 Dudelange, 3, rue Edison.
R.C.S. Luxembourg B 137.525.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005662/9.
(160004599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Hotel-Restaurant Lanners Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9044 Ettelbruck, 1, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 91.505.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005665/9.
(160004757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
I.C.C.Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9663 Kautenbach, 12, bei der Millen.
R.C.S. Luxembourg B 93.292.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005671/9.
(160004135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
I.F.Z. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8710 Boevange-sur-Attert, 50, Cité Nock.
R.C.S. Luxembourg B 169.650.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005672/9.
(160004532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
24100
L
U X E M B O U R G
Luxeral Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6552 Berdorf, 30, rue Hammhof.
R.C.S. Luxembourg B 135.288.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07/01/2016.
G.T. Experts Comptables S.à r.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2016005795/12.
(160004419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Maclean SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 79.273.
Les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2011 de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2016005836/12.
(160004404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Mauritania Gulf S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 139.997.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005841/10.
(160004994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Michel NEIZEN GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1633 Luxembourg, 25, rue A. Godart.
R.C.S. Luxembourg B 18.611.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016005844/10.
(160004887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Michel NEIZEN GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1633 Luxembourg, 25, rue A. Godart.
R.C.S. Luxembourg B 18.611.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016005845/10.
(160004888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
24101
L
U X E M B O U R G
Netto-Recycling S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1259 Senningerberg, 4, rue Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 52.161.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2016005899/12.
(160005060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Nouvelle Electricité BASTIAN S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5691 Ellange, 50, Z.A.E. le Triangle Vert.
R.C.S. Luxembourg B 95.159.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08/01/2016.
G.T. Experts Comptables S.à r.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2016005888/12.
(160004640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Nexis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1218 Luxembourg, 22, rue Baudouin.
R.C.S. Luxembourg B 78.837.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016005901/10.
(160004346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Nexis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1218 Luxembourg, 22, rue Baudouin.
R.C.S. Luxembourg B 78.837.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016005902/10.
(160004347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Nexis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1218 Luxembourg, 22, rue Baudouin.
R.C.S. Luxembourg B 78.837.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016005903/10.
(160004348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
24102
L
U X E M B O U R G
Mythos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5366 Munsbach, 163, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 89.889.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005884/9.
(160004753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
N. Kimmel S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7636 Ernzen, 77, Montée d'Ernzen.
R.C.S. Luxembourg B 156.227.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005885/9.
(160004759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Nénuphar S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 11.118.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005892/9.
(160003653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Nénuphar S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 11.118.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005893/9.
(160003654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Nénuphar S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 11.118.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005894/9.
(160003655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Nénuphar S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 11.118.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005895/9.
(160003656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
24103
L
U X E M B O U R G
Immobilière DE LA FONTAINE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9521 Wiltz, 9, rue de la Fontaine.
R.C.S. Luxembourg B 105.837.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005679/9.
(160004132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Emerging Markets Taxi Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 184.675.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of November,
before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
1. Asia Internet Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under number B 177.038, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg (“AIH”), and having a share capital of fifty thousand euros (EUR 50,000.00),
being the holder of three thousand two hundred sixty-eight (3,268) common shares and three thousand two hundred
sixty-eight (3,268) series A1 shares and three hundred fifty-five (355) series C shares,
here represented by Julien De Mayer, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on 28 and 30 October 2015;
2. MKC Brillant Services GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated and
existing under the laws of Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Char-
lottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 139778, having its registered office at Johannisstraße
20, 10117 Berlin, Germany (“LIH”),
being the holder of eight thousand one hundred seventy (8,170) common shares, eight thousand one hundred seventy
(8,170) series A2 shares and eight hundred eighty-seven (887) series C shares,
here represented by Julien De Mayer, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on 30 October 2015;
3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under number B 176.544, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand
Duchy of Luxembourg, and having a share capital of forty-three thousand euros (EUR 43,000.00),
being the holder of four hundred eight (408) common shares and four hundred eight (408) series A3 shares,
here represented by Julien De Mayer, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on 29 October 2015
4. TEC Global Invest IX GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated and
existing under the laws of Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Duisburg
(Amtsgericht Duisburg), Germany, under number HRB 26061, having its registered office at Wissollstrasse 5-43, 45478
Mülheim an der Ruhr (“TEC”),
being the holder of six hundred fifty-four (654) common shares, six hundred fifty-four (654) series A4 shares, three
thousand two hundred sixty-eight (3,268) B2 shares and one thousand two hundred forty-two (1,242) series C shares,
here represented by Julien De Mayer, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on 26 October 2015;
5. Phenomen Ventures LP, an exempted Limited Partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman
Islands, registration number OG - 66003, having its registered office at 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman
KY1-9007, Cayman Islands, represented by its general partner, Phenomen Ventures Management, an exempted company
incorporated and existing under the Law of the Cayman Islands, registered with Registry of Companies, Cayman Islands,
under number OG-271195, having its registered address at 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007,
Cayman Islands (“Phenomen”),
being the holder of four thousand nine hundred two (4,902) series B1 shares and seven hundred forty-six (746) series
C shares,
here represented by Julien De Mayer, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
24104
L
U X E M B O U R G
by virtue of a proxy under private seal, given on 26 October 2015;
6. FEC Lux S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 173.487, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
and having a share capital of twenty thousand US dollars (USD 20,000.00),
being the holder of one thousand two hundred nine (1,209) series B3 shares,
here represented by Julien De Mayer, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on 28 October 2015;
7. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) under the laws
of Germany with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the
local court of Munich (Amtsgericht München), Germany, under no. HRA 98863, having its business address at Kaiserstraße
14b, 80801 Munich, Germany (hereinafter “Holtzbrinck”),
being the holder of one thousand six hundred thirty-four (1,634) series B4 shares and one thousand two hundred forty-
two (1,242) series C shares,
here represented by Julien De Mayer, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on 28 October 2015;
8. Leifina GmbH & Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) under the laws of Germany with its statutory
seat in Munich, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Munich (Amts-
gericht München), Germany, under no. HRA 80493, having its business address at Maximilianstr. 21, 80539 Munich,
Germany (“Leifina”),
being the holder of four hundred ninety-seven (497) series C shares,
here represented by Julien De Mayer, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on 22 October 2015; and
9. Radford Corp S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 200.119, having its registered office at 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, and having a share capital of twenty five thousand euros (EUR 25,000.00) (“Radford”), participating and
voting only for purposes of agenda points 3 et seqq.,
becoming the holder of four thousand three hundred eighty-two (4,382) series C shares,
here represented by Mr BEERENS Bernard, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on November 30, 2015.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The parties 1. to 8. (the “Existing Shareholders”) are all the current shareholders of Emerging Markets Taxi Holding
S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 184.675, incorporated pursuant to a deed of notary Henri Hellinckx on 7 February 2014, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1066 on 26 April 2014.
The articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a deed of notary Cosita Delvaux on 11 June
2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2124 on 18 August 2015.
The Existing Shareholders represent the entire share capital and have waived any notice requirement, the general meeting
of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby Radford participates
and votes for purpose of agenda points 3 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Acceptance of Radford Corp S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 200.119, having its registered office at 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, and having a share capital of twenty five thousand euros (EUR 25,000.00), as a new shareholder of the
Company.
2. Increase of the Company’s share capital by an amount of four thousand three hundred eighty-two euros (EUR 4,382.00)
so as to raise it from its current amount of forty thousand nine hundred eighty-two euros (EUR 40,982.00) to forty-five
thousand three hundred sixty-four euros (EUR 45,364.00) by issuing four thousand three hundred eighty-two (4,382) Series
C Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
3. Full restatement of the Company’s articles of association in order to reflect the capital increase as per item 2 above
as well as to reflect several amendments to the articles of association following the entry into the capital of the Company
by Radford Corp S.à r.l-
24105
L
U X E M B O U R G
4. Subsequently, decision to grant power to any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mag-
dalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders’
register of the Company.
5. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders accepts Radford, aforementioned, as new shareholder of the Company.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the Company’s share capital by an amount of four thousand
three hundred eighty-two euros (EUR 4,382.00) so as to raise it from its current amount of forty thousand nine hundred
eighty-two euros (EUR 40,982.00) to forty-five thousand three hundred sixty-four euros (EUR 45,364.00) by issuing four
thousand three hundred eighty-two (4,382) Series C Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
<i>Subscriptioni>
The issued four thousand three hundred eighty-two (4,382) Series C Shares have been duly subscribed by Radford,
aforementioned, for the price of seventeen million six hundred forty-three thousand three hundred thirty-four euros and
twenty-four cents (EUR 17,643,334.24).
<i>Paymenti>
The four thousand three hundred eighty-two (4,382) Series C Shares subscribed by Radford, aforementioned, have been
entirely paid up through a contribution in kind in the aggregate amount of seventeen million six hundred forty-three thousand
three hundred thirty-four euros and twenty-four cents (EUR 17,643,334.24) consisting in a receivable held by Radford,
aforementioned, against the Company, which is valued at least at seventeen million six hundred forty-three thousand three
hundred thirty-four euros and twenty-four cents (EUR 17,643,334.24).
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of seventeen million six hundred forty-three thousand three hundred thirty-four
euros and twenty-four cents (EUR 17,643,334.24) consists of four thousand three hundred eighty-two euros (EUR 4,382.00)
to be allocated to the nominal share capital account of the Company and seventeen million six hundred thirty-eight thousand
nine hundred fifty-two euros and twenty-four cents (EUR 17,638,952.24) to be allocated to the share premium account of
the Company.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to fully restate the Company’s articles of association, in order to reflect
the capital increase as per the second resolution above as well as to reflect several amendments to the articles of association
following the entry into the capital of the Company by Radford, which shall henceforth read as follows:
“ARTICLES OF ASSOCIATION
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Emerging Markets
Taxi Holding S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The object of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such
intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property
rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
24106
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may
be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders, adopted in
the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share Capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at forty five thousand three hundred sixty-four euros (EUR 45,364.00), repre-
sented by (i) twelve thousand five hundred (12,500) common shares (the “Common Shares”), (ii) three thousand two
hundred sixty eight (3,268) series A1 shares (the “Series A1 Shares”), (iii) eight thousand one hundred seventy (8,170)
series A2 shares (the “Series A2 Shares”), (iv) four hundred eight (408) series A3 shares (the “Series A3 Shares”), (v) six
hundred fifty-four (654) series A4 shares (the “Series A4 Shares”), (vi) four thousand nine hundred two (4,902) series B1
shares (the “Series B1 Shares”), (vii) three thousand two hundred sixty-eight (3,268) series B2 shares (the “Series B2
Shares”), (viii) one thousand two hundred nine (1,209) series B3 Shares (the “Series B3 Shares”), (ix) one thousand six
hundred thirty-four (1,634) series B4 shares (the “Series B4 Shares”; the Series B1 Shares, the Series B2 Shares, the Series
B3 and the Series B4 Shares jointly the “Series B Shares”) and nine thousand three hundred fifty-one (9,351) series C
shares (the “Series C Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
5.2 The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent
otherwise provided by these articles of association or by the Law.
5.3 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.4 Each of (i) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”), (ii) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (iii) Aismare Lux
Holdings S.à r.l. (“Aismare”), (iv) TEC Global Invest IX GmbH (“TEC”), (v) Phenomen Ventures LP (“Phenomen”), (vi)
FEC Lux S.à r.l. (“FEC”), (vii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG (“HV”), (viii) Leifina GmbH & Co.
KG (“Leifina”) and (ix) Radford Corp S.à r.l. (“Radford”; LIH, AIH, Aismare, TEC, Phenomen, FEC, HV, Leifina and
Radford together the “Investors” and each an “Investor) shall be entitled to subscribe for such amount of further Shares to
be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder
nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG)
(a “Third Party Investor”) and which has been approved by the Advisory Board (a “Third Party Investment”) - irrespective
whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up to its percentage
ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party
Investment is based on. Each of (i) LIH, (ii) AIH, (iii) Aismare, (iv) TEC, (v) Phenomen, (vi) FEC, (vii) HV, (viii) Leifina
and/or (ix) Radford shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks after it has been notified by
the Company regarding the Third Party Investment if it intends to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of
this article 5.4. This article 5.4 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into Shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The Shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are to
be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
24107
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of Shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that Share until such representative has been appointed.
7.3 The Shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the Shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions of any
shareholders’ agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of preemption,
tag-along rights, or drag-along rights contained in any shareholders’ agreement between the shareholders. To the extent
that such shareholder approval has been granted, an additional consent to the transfer of Shares is not required:
7.4.1 in any case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by an Investor to a company affiliated
to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (each an “Affiliate”);
7.4.2 in case of the transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares of one Investor to a company or entity (x)
which is directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or
more direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or
“Controlled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company or entity by way of (a) managing
the company or entity as managing shareholder, (b) holding the majority of Shares or (c) holding the majority of voting
rights by means of a contractual voting pool, or (y) in which the respective Investor or one or more shareholders of such
Investor has a direct or indirect majority shareholding;
7.4.3 in case of a transfer of Shares from HV to a company which business is conducted by HV Holtzbrinck Ventures
Adviser GmbH. Business conduction within the meaning of the foregoing sentence of this paragraph comprises any form
of administration of business, including any direct or indirect manner of business conduction and/or consulting, based on
the position as shareholder, organ or arising from contractual relationships related thereto; and
7.4.4 in case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by a Shareholder to the Company and/or any
of the Investors pursuant to a call-option under a vesting scheme.
7.5 To the extent a sale, transfer, assignment or any other disposal of Shares requires no additional consent of the
shareholders’ meeting pursuant to article 7.4.1 through article 7.4.4 above, neither duties to offer for sale, nor any rights
of first refusal, nor rights of pre-emption, nor tag-along rights, nor drag-along rights apply in favour of other shareholders.
7.6 Any sale, transfer, assignment or other disposal of Shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification thereof to, or upon the acceptance thereof by the Company in accordance with article 1690
of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the Shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the Shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the Shares are transferred either to parents, des-
cendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.
8.1 In case of (i) any transfer of at least fifty percent (50%) of all Shares in the Company, or a swap or a take-over of
the Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one
another, (ii) transfer of at least 50% of the Company’s assets or business of the Company, in a single or more related
transactions, (iii) transfer of a material part of the Company’s intellectual property rights in a single or more related
transactions, (iv) the liquidation or de facto liquidation of the Company (in particular following an asset deal), or (v) any
sale or transfer of Shares in the Company either to third parties or other shareholders, that would result in either more than
fifty percent (50%) of the share capital or more than fifty percent (50%) of the voting rights being owned by the acquiring
party/parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions, (each of the events described in (i), (ii),
(iii), (iv) or (v) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) - subject to articles 8.2
through 8.4 below - will be distributed in accordance with articles 8.5, 8.6 and 8.7 below to the shareholders pro rata to
their participation in the Liquidity Event.
8.2 On a first level (“First Level”) the holders of Series C Shares shall receive in preference to the remaining shareholders
an amount of EUR 4,026.32 per each Series C Share being subject to the Liquidity Event which equals the amount of their
respective total investment made in the Company per Series C Share (consisting of the nominal amount of the Series C
Shares acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid by that holder
to the Company).
8.3 On a second level (“Second Level”) the holders of Series B Shares shall receive in preference to the remaining
shareholders an amount of EUR 3,060.00 per each Series B Share being subject to the Liquidity Event which equals the
amount of their respective total investment made in the Company per Series B Share (consisting of the nominal amount of
24108
L
U X E M B O U R G
the Series B Shares acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid by
that holder to the Company).
8.4 On a third level (“Third Level”), if and to the extent that the Exit Proceeds exceed the payments (Vorabzahlungen)
to be made under article 8.2, the holders of Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and of the Series A4
Shares shall receive per Share of the respective share class the amount stipulated next to the relevant share class being
subject to the Liquidity Event in the following table:
Share Class
Amount
per Share
in Euro
Series A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.65
Series A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,562.87
Series A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,128.45
Series A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,117.21
8.5 After the payments on the First Level, the Second Level and on the Third Level have been made, the remaining Exit
Proceeds shall be allocated on a common level (“Common Level”) to all shareholders pro rata corresponding to their
participation in the Liquidity Event. Any amounts received by any shareholder on the First Level, Second Level and/or
Third Level shall reduce the amount to be allocated to such shareholder on the Common Level and shall be allocated
subsequently pursuant to this Common Level provided that no shareholder shall be obliged to repay any amount received
on the First Level, Second Level and/or Third Level. The allocation at the Common Level shall be made until all Exit
Proceeds have been distributed to the shareholders.
8.6 The preferred allocation of Exit Proceeds on the First Level, Second Level and on the Third Level applies to each
of the respective Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares, Series A4 Shares, Series B Shares and Series C
Shares as long as the respective Investor has not yet received the full amount that is to be allocated to such Investor according
to the First Level, Second Level and/or Third Level.
8.7 Irrespective of whether or not the transfer of Shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in
one transaction or more transactions, no shareholder shall receive for the transfer of all of its Shares (and shall repay any
exceeding amount to the other shareholders) an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds or
proceeds pro rata to the Shares transferred on a common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such shareholder
on the First Level, Second Level and/or Third Level from a subsequent transfer. All rights related to the liquidity preference
stipulated herein can only be exercised once.
Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own Shares. The voting rights of any of its Shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings is
rejected for lack of assets;
9.2.2 the Share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such Share and
such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the Shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles of association together with the
declaration of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and
the Company hereby acknowledges and accepts the transfer of the Shares in such case and undertakes to register the transfer
in its share register and to proceed with the relevant filings required by law.
9.3 If the Share in question is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect
to one person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform
way through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.
9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).
Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed Shares. The effective date
is the date before the redemption resolution.
10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the Shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding
amounts including interest.
24109
L
U X E M B O U R G
10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an
auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert arbitrator
shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a shareholder or of the Company. The
decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the Company and the
requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the redemption price and
the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs in case the redemption
price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.
Art. 11. Request of Assignment in Lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the Shares to a person
named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or partial
assignment of the Share to the Company or to a person named by the Company.
11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of
association, for the Shares to be assigned is owed by the person acquiring the Shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of Shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
12.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can also
be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by a
shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board of
managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
12.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which must
state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written record must
be sent to each shareholder in writing without undue delay.
12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may be
specified in the respective convening notices of meeting.
13.2 The shareholders’ meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or regis-
tered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period of
notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders’ meetings and at least two (2) weeks for extraordinary share-
holders’ meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’ meeting
is not counted in the calculation of the period of notice.
13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another shareholder
authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of confidentiality.
13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the shareholders’
resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’ meeting (for
purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written record.
24110
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds Shares.
14.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a
higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company’s shareholders are
only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is no
quorum, a new shareholders’ meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with article
13.2. This shareholders’ meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this was
pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.
Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 16. Amendments of the Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority. Any amendment of these articles of
association that materially or adversely affects the rights of the holders of Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3
Shares, Series A4 Shares, Series B Shares and Series C Shares require the consent of all of the holders of such Shares.
Art. 17. Decisions Requiring Specific Majority.
17.1 Resolutions regarding the following subjects must be taken with the consent of Shareholders holding together fifty
per cent (50%) of the share capital of the Company, and require the consent of the Advisory Board:
17.1.1 disposition of all the Company’s assets, of a significant part of the Company’s assets or all or significant part of
assets of any direct or indirect subsidiary of the Company (including, among others, transfer of any and all of the intellectual
property rights), if such disposition is not made on arm`s length terms;
17.1.2 appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such profits
to new accounts; increase or reduction of reserves (including but not limited to share premium and assimilated premium)
as well as capital increase from company funds; and
17.1.3 transfer of industrial property rights or documented know-how by the Company to a third party.
17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and require the consent of the
Advisory Board:
17.2.1 resolution with respect to the liquidation of the Company; and
17.2.2 amendment of these articles of association (including this Article 17) including the resolution with respect to the
merger, separation and transformation of the Company.
17.3 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the consent of all
of the Investors:
17.3.1 exclusion of subscription rights in case of capital increases; and
17.3.2 acquisition of the Company’s own Shares, including redemption of Shares, with the exception of acquisitions in
accordance with article 9.2 and transfers in accordance with article 11.1 of these articles of association.
17.4 Whenever the capital of the Company is divided into different classes of shares the special rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated only with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.
17.5 Any changes in the decision making process (including the competence of meetings of shareholders, Advisory
Board and any specific majority necessary for adoption of some of the decisions) of the Company to the unilateral disad-
vantage of any of the Investors shall not be made without such Investor’s consent. For the avoidance of doubt any decrease
of the number of votes or change of the voting rights of shareholders or managers necessary for adoption of any decision
will bring the unilateral disadvantage of the Investors.
D. Board of managers and advisory board
Art. 18. Powers of the Sole Manager; Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause, by a resolution
of the general meeting of shareholders.
24111
L
U X E M B O U R G
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 21. Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being suf-
ficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in
a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
22.8 The managers shall require the consent of the Advisory Board for legal transactions and measures of the Company
specified below (no consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in
advance been approved by an adopted budget with the consent of the shareholders’ meeting):
22.8.1 assumption of sureties or guarantees in excess of an amount of five hundred thousand euros (EUR 500,000.00)
each;
22.8.2 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other
transactions with derivative financial instruments;
22.8.3 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.4 conclusion, amendment or termination of company collective agreements, works agreements (of substantial
importance) and of general guidelines regarding the company pension scheme;
22.8.5 institution and termination of legal disputes, including arbitration proceedings involving a judicial amount in
controversy of more than five hundred thousand euros (EUR 500,000.00) in the individual case;
24112
L
U X E M B O U R G
22.8.6 conclusion, termination or amendment of silent partnerships and sub-participations in the Company;
22.8.7 conclusion, amendment and termination of intra-group affiliation agreements (Unternehmensverträge) within the
meaning of sections 291 et seqq. of the German Stock Corporation Act (AktG); and
22.8.8 approval of the annual budget for each following year.
22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also required
for the contractual obligation relating thereto. The shareholders’ meeting may by resolution determine further transactions
and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also in advance for
certain groups and kinds of transactions and measures.
22.10 The shareholders may by shareholders’ resolution or by virtue of shareholders’ agreement adopt rules of procedure
for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same
manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in the
future.
Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if
any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).
23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager and
class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company shall have an advisory board (the “Advisory Board”). It shall consist of seven (7) voting members,
with a total of nine (9) votes, and additional non-voting members (the “Observers”). The shareholders may increase or
decrease the number of members of the Advisory Board and the numbers of votes of each member by way of unanimous
shareholders’ consent.
25.2 The shareholders shall only adopt or amend the rules of procedure for the Advisory Board by way of unanimous
shareholders’ consent.
25.3 Each of the Investors shall at all times be entitled to appoint a non-voting Observer to the Advisory Board who
shall be entitled to attend the meetings of the Advisory Board and receive any preparatory documents, meeting notices and
minutes of the Advisory Board at the same time as a voting member.
25.4 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s respective
appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:
25.4.1 two (2) voting members of the Advisory Board, each having one (1) vote, shall be nominated by the Investor
AIH in its sole discretion;
25.4.2 one (1) voting member of the Advisory Board, having three (3) votes, shall be nominated by the Investor LIH in
its sole discretion;
25.4.3 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor Phenomen
in its sole discretion;
25.4.4 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor TEC in
its sole discretion;
25.4.5 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor HV in its
sole discretion; and
25.4.6 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor Radford
in its sole discretion.
25.5 The Advisory Board shall be competent for the granting of consents to any transactions and measures of the
managers which the shareholders’ meeting has made subject to the consent of the Advisory Board either (i) in these articles
24113
L
U X E M B O U R G
of association, (ii) in the rules of procedure of the managers, (iii) by way of shareholders’ resolution or (iv) in any share-
holders’ agreement.
25.6 The remuneration of the members of the Advisory Board, if any, shall be determined by shareholders of the
Company by way of a unanimous shareholders’ resolution.
25.7 In addition to the consent requirements provided for in article 17.1, article 22.8 and article 22.9, the Advisory Board
has a consultative function and will not interfere in the management of the Company.
25.8 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis 11 et seq. of the Law.
E. Audit and Supervision
Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts- Allocation of profits - Interim dividends
Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January o f each year and shall
end on the thirty-first of December of the same year.
Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
28.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of Shares they hold
in the Company.
Art. 29. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and may not exceed realized profits since the
end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried
forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.
29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of
shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise
provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities
of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any
shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
24114
L
U X E M B O U R G
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with the
provisions of any shareholders’ agreement, such shareholders’ agreement shall prevail inter partes and to the extent per-
mitted by Luxembourg law.
31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English
and the German text, the English version shall prevail.”
<i>Fourth Resolutioni>
The general meeting of shareholders hereby grants power to any manager of the Company, regardless of his category,
as well as to Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely,
the shareholders’ register of the Company.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 8,200.-.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the German texts, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreizigsten November,
vor uns, dem unterzeichnenden Notar, Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxem-
burg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Asia Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesellschafts-
register unter der Nummer B 177.038, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg
(„AIH“), und mit einem Gesellschaftskapital von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,00),
Inhaberin von dreitausendzweihundertachtundsechzig (3.268) Stammanteilen, dreitausendzweihundertachtundsechzig
(3.268) Anteilen der Serie A1 und dreihundertfünfundfünfzig (355) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Julien De Mayer, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 28. und 30. Oktober 2015;
2. MKC Brillant Services GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 139778,
mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („LIH“),
Inhaberin von achttausendeinhundertsiebzig (8.170) Stammanteilen, achttausendeinhundertsiebzig (8.170) Anteilen der
Serie A2 und achthundertsiebenundachtzig (887) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Julien De Mayer, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in am 30. Oktober 2015;
3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesellschafts-
register unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von dreiundvierzigtausend Euro (EUR 43.000,00),
Inhaberin von vierhundertacht (408) Stammanteilen und vierhundertacht (408) Anteilen der Serie A3,
hier vertreten durch Julien De Mayer, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 29. Oktober 2015;
4. TEC Global Invest IX GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter der Nummer HRB 26061, mit Sitz in Wissollstraße
5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr („TEC“),
Inhaberin von sechshundertvierundfünfzig (654) Stammanteilen, sechshundertvierundfünfzig (654) Anteilen der Serie
A4, dreitausendzweihundertachtundsechzig (3.268) Anteilen der Serie B2 und eintausendzweihundertzweiundvierzig
(1.242) Anteilen der Serie C.
hier vertreten durch Julien De Mayer, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 26. Oktober 2015;
24115
L
U X E M B O U R G
5. Phenomen Ventures LP, ein exempted Limited Partnership gegründet und bestehend unter dem Recht der Kaiman-
inseln (Cayman Islands), mit der Eintragungsnummer OG - 66003, mit Sitz in 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman
KY1-9007, Cayman Islands, vertreten durch ihren unbeschränkt haftenden Gesellschafter (general partner), Phenomen
Ventures Management, eine Gesellschaft (exempted company) gegründet und bestehend unter dem Recht der Kaimanin-
seln, eingetragen im Registry of Companies, Cayman Islands, unter der Nummer OG-271195, mit Sitz in 89 Nexus Way,
Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands, („Phenomen“),
Inhaberin von viertausendneunhundertzwei (4.902) Anteilen der Serie B1 und siebenhundertsechsundvierzig (746) An-
teilen der Serie C,
hier vertreten durch Julien De Mayer, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 26. Oktober 2015;
6. FEC Lux S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und beste-
hend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
unter der Nummer B 173.487, mit Sitz in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem
Gesellschaftskapital in Höhe von zwanzigtausend US-Dollar (USD 20.000,00),
Inhaberin von eintausendzweihundertneun (1.209) Anteilen der Serie B3,
hier vertreten durch Julien De Mayer, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 28. Oktober 2015;
7. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht, mit sat-
zungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland,
unter der Nummer HRA 98863, mit Geschäftsadresse in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland („Holtzbrinck“),
Inhaberin von eintausendsechshundertvierunddreißig (1.634) Anteilen der Serie B4 und eintausendzweihundertzwei-
undvierzig (1.242) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Julien De Mayer, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 28. Oktober 2015;
8. Leifina GmbH & Co. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht, mit satzungsmäßigem Sitz in Mün-
chen, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Nummer HRA
80493, mit Geschäftsadresse in Maximilianstraße 21, 80539 München, Deutschland („Leifina“),
Inhaberin von vierhundertsiebenundneunzig (497) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Julien De Mayer, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 22. Oktober 2015; und
9. Radford Corp S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und
bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschafts-
register unter der Nummer B 200119, mit Sitz in 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,00) („Radford“),
zukünftige Inhaberin von viertausenddreihundertzweiundachtzig (4.382) Anteilen der Serie C,
ausschließlich für die Punkte 3 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt,
hier vertreten durch Herrn BEERENS Bernard, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 30. November 2015.
Besagte Vollmachten, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur paraphiert
wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die Parteien 1. bis 8. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle derzeitigen Gesellschafter der Emerging Markets
Taxi Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),
mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 184.675, gegründet am 7. Februar 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Henri
Hellinckx, welche am 26. April 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1066 veröffentlicht
wurde.
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 11. Juni 2015 gemäß einer Urkunde des Notars Cosita Delvaux geändert,
welche am 18. August 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2124 veröffentlicht wurde.
Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten
verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die
folgende Tagesordnung verhandeln, wobei Radford ausschließlich für die Punkte 3 ff. der Tagesordnung teilnahme- und
stimmberechtigt ist:
<i>Tagesordnungi>
1. Aufnahme von Radford Corp S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 200119, mit Sitz in 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Groß-
24116
L
U X E M B O U R G
herzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,00), als
neue Gesellschafterin der Gesellschaft.
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von vierzigtausendneunhundert-
zweiundachtzig Euro (EUR 40.982,00) um einen Betrag von viertausenddreihundertzweiundachtzig Euro (EUR 4.382,00)
auf einen Betrag von fünfundvierzigtausenddreihundertvierundsechzig Euro (EUR 45.364,00) durch die Ausgabe von
viertausenddreihundertzweiundachtzig (4.382) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).
3. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, um die Kapitalerhöhung gemäß dem vorgenannten zweiten
Punkt, sowie weitere Änderungen der Satzung nach der Kapitaleinlage durch Radford.
4. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie
Magdalena Staniczek, zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit un-
eingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung, zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
5. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung nimmt Radford, vorbenannt, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft an.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag
von vierzigtausendneunhundertzweiundachtzig Euro (EUR 40.982,00) um einen Betrag von viertausenddreihundertzwei-
undachtzig Euro (EUR 4.382,00) auf einen Betrag von fünfundvierzigtausenddreihundertvierundsechzig Euro (EUR
45.364,00) durch die Ausgabe von viertausenddreihundertzweiundachtzig (4.382) Anteilen der Serie C mit einem Nomi-
nalwert von je einem Euro (EUR 1,00), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die viertausendneunhundertneunundsechzig (4.382) ausgegebenen Anteile der Serie C wurden ordnungsgemäß ganz
von Radford, vorbenannt, für einen Betrag von siebtzehn Millionen sechshundertdreiundvierzigtausenddreihundertvie-
runddreißig Euro und vierundzwanzig Cents (EUR 17.643.334.24,00) vollständig gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die von Radford, vorbenannt, gezeichneten viertausendneunhundertneunundsechzig (4.382) Anteile der Serie C wurden
vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage in einem Gesamtwert von siebtzehn Millionen sechshundertdreiundvierzig-
tausenddreihundertvierunddreißig Euro und vierundzwanzig Cents (EUR 17.643.334,24) bestehend aus einer Forderung
welche Radford, vorbenennt, gegen die Gesellschaft hält und welche auf mindestens siebzehn Millionen sechshundertd-
reiundvierzigtausenddreihundertvierunddreißig Euro und vierundzwanzig Cents (EUR 17.643.334,24) geschätzt wird.
Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar
erbracht.
Die gesamte Einlage in Höhe von siebtzehn Millionen sechshundertdreiundvierzigtausenddreihundertvierunddreißig
Euro und vierundzwanzig Cents (EUR 17.643.334,24) besteht aus viertausendneunhundertneunundsechzig (EUR 4.382)
für das Gesellschaftskapital und siebtzehn Millionen sechshundertachtunddreißigtausendneunhundertzweiundfünfzig Euro
und vierundzwanzig Cents (EUR 17.638.952,24) für das Agio der Gesellschaft.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt eine vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, um die Kapi-
talerhöhung gemäß dem vorgenannten zweiten Beschluss, sowie weitere Änderungen der Satzung nach der Kapitaleinlage
durch Radford wiederzugeben.
Die Satzung der Gesellschaft lautet nunmehr wie folgt:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
„Emerging Markets Taxi Holding S.à r.l.“ (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.
24117
L
U X E M B O U R G
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigem Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke för-
derlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt vierzigtausenddreihundertvierundsechzig Euro (EUR 45.364,-),
bestehend aus (i) zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile“), (ii) dreitausendzweihunder-
tachtundsechzig (3.268) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“), (iii) achttausendeinhundertsiebzig (8.170)
Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“), (iv) vierhundertacht (408) Anteilen der Serie A3 (die „Anteile der Serie
A3“), (v) sechshundertvierundfünfzig (654) Anteilen der Serie A4 (die „Anteile der Serie A4“), (vi) viertausendneunhun-
dertzwei (4.902) Anteilen der Serie B1 (die „Anteile der Serie B1“), (vii) dreitausendzweihundertachtundsechzig (3.268)
Anteilen der Serie B2 (die „Anteile der Serie B2“), (viii) tausendzweihundertneun (1.209) Anteilen der Serie B3 (die
„Anteile der Serie B3“), (ix) tausendsechshundertvierunddreißig (1.634) Anteilen der Serie B4 (die „Anteile der Serie B4“;
die Anteile der Serie B1, die Anteile der Serie B2, die Anteile der Serie B3 und die Anteile der Serie B4 gemeinschaftlich
die „Anteile der Serie B“) und neuntausenddreihunderteinundfünfzig (9.351) Anteilen der Serie C (die „Anteile der Serie
C“), mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
5.2 Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn,
es wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.3 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.4 Jede der Gesellschaften (i) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (ii) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (iii)
Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (iv) TEC Global Invest IX GmbH („TEC“), (v) Phenomen Ventures LP („Phe-
nomen“), (vi) FEC Lux S.à r.l. („FEC“), (vii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG („HV“), (viii) Leifina
GmbH & Co. KG („Leifina“) und ix) Radford Corp S.à r.l. („Radford“; LIH, AIH, Aismare, TEC, Phenomen, FEC, HV,
Leifina und Radford gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer
bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird
(bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne
der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom Beirat zugestimmt wurde (eine
„Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren
Gesellschaftern erfolgte - die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung
24118
L
U X E M B O U R G
erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften (i)
LIH, (ii) AIH, (iii) Aismare, (iv) TEC, (v) Phenomen, (vi) FEC, (vii) HV, (viii) Leifina und/oder (ix) Radford hat die
Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen nach Ankündigung der Investition eines
Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob er sein Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.4
ausüben möchte. Dieser Artikel 5.4 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend
anwendbar.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder die Insol-
venz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals (eine „Qualifizierte Mehrheit“) halten und vorbehaltlich der Bestim-
mungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich
Vorkaufsrechten, Bezugsrechten, Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Ge-
sellschaftern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung der Gesellschafter erteilt wurde, ist eine weitere
Einwilligung zur Übertragung von Anteilen nicht erforderlich:
7.4.1 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen
Investor an eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes
(AktG) (jeweils eine „Verbundene Gesellschaft“);
7.4.2 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen eines In-
vestors an eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, (x) welche/s direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder
mehrere direkte oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kon-
trolliert, von diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte
„Kontrolle“ oder „Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft oder
des Unternehmens bezeichnet, durch (a) die Leitung der Gesellschaft oder des Unternehmens durch einen geschäftsführ-
enden Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine
vertragliche Stimmvereinbarung, oder (y) in welcher/m der betreffende Investor oder ein oder mehrere Gesellschafter dieses
Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
7.4.3 Bei einer Übertragung von Anteilen von HV an eine Gesellschaft, deren Geschäfte von HV Holtzbrinck Ventures
Adviser GmbH geführt werden. Die Geschäftsführung im Sinne des vorstehenden Satzes dieses Paragraphen umfasst jede
Art der Geschäftsverwaltung, einschließlich direkter oder indirekter Arten der Geschäftsführung und/oder Beratung, die
sich aus der Position als Gesellschafter, Gesellschaftsorgan oder aus damit verbundenen vertraglichen Beziehungen erge-
ben; und
7.4.4. Bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen
Gesellschafter an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit
einer Vesting-Regelung.
7.5 Sofern ein Verkauf, eine Übertragung, Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen keiner zusätzlichen
Zustimmung der Gesellschafterversammlung gemäß den Artikeln 7.4.1 bis 7.4.4 bedarf, gelten weder Verpflichtungen zu
Verkaufsangeboten, noch Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Ge-
sellschafter.
24119
L
U X E M B O U R G
7.6 Ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der
Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft darüber in Kenntnis gesetzt
wurde oder diesem/dieser zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zugestimmt hat (wobei die Anteile des verstorbenen Gesell-
schafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist jedoch nicht erforderlich, wenn
die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des
verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) einer Übertragung von mindestens fünfzig Prozent (50%) aller Anteile an der Gesellschaft oder eines
Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren zusam-
mengehörenden Transaktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, (ii) einer Übertragung von mindestens fünfzig Prozent
(50%) des Vermögens oder der Geschäfte der Gesellschaft in einer oder mehreren zusammengehörenden Transaktionen,
(iii) einer Übertragung eines wesentlichen Teils von Rechten in Bezug auf geistiges Eigentum der Gesellschaft in einer
oder mehreren zusammengehörenden Transaktionen, (iv) der Liquidation oder der de facto-Liquidation der Gesellschaft
(insbesondere nach einem Asset Deal), oder (v) eines Verkaufs oder einer Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft
entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde, dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%)
des Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw.
Parteien wären (change of control), als Ergebnis einer oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter
(i), (ii), (iii), (iv) und (v) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse
(„Exiterlöse“) - vorbehaltlich der Artikel 8.2 bis 8.4 - im Einklang mit den Artikeln 8.5, 8.6 und 8.7 auf einer pro rata-Basis
entsprechend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.
8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene“) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie C vorzugsweise im Verhältnis
zu den übrigen Gesellschaftern für jeden vom Liquiditätsereignis betroffenen Anteil der Serie C einen Betrag in Höhe von
EUR 4.026,32, welcher pro Anteil der Serie C dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht
(bestehend aus dem Nominalbetrag der von diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie C und dem Agio und/oder anderen
Kapitaleinlage (Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber an die Gesell-
schaft gezahlt wurde).
8.3 Auf einer zweiten Ebene („Zweite Ebene“) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B vorzugsweise im Verhältnis
zu den übrigen Gesellschaftern für jeden vom Liquiditätsereignis betroffenen Anteil der Serie B einen Betrag in Höhe von
EUR 3.060,00, welcher pro Anteil der Serie B dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht
(bestehend aus dem Nominalbetrag der von diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie B und dem Agio und/oder anderen
Kapitaleinlage (Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber an die Gesell-
schaft gezahlt wurde).
8.4 Auf einer dritten Ebene („Dritte Ebene“), wenn und soweit die Exiterlöse die gemäß den Artikeln 8.2 und 8.3 zu
leistenden Vorabzahlungen übersteigen, erhalten die Inhaber der Anteile der Serie A1, der Anteile der Serie A2, der Anteile
der Serie A3 und der Anteile der Serie A4 pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse den in der folgenden Tabelle neben der
entsprechenden vom Liquiditätsereignis betroffenen Anteilsklasse festgelegten Betrag:
Anteilsklasse
Betrag
pro
Anteil in
Euro
Serie A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,65
Serie A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.562,87
Serie A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.128,45
Serie A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.117,21
8.5 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Ebene, auf der Zweiten Ebene und auf der Dritten Ebene geleistet wurden,
werden die übrigen Exiterlöse auf einer Gemeinsamen Ebene („Gemeinsame Ebene“) an alle Gesellschafter auf einer pro
rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf der Ers-
ten, Zweiten und/oder Dritten Ebene erhaltenen Beträge mindern den von diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag auf
der Gemeinsamen Ebene und werden anschließend entsprechend dieser Gemeinsamen Ebene zugeteilt, mit der Maßgabe,
dass kein Gesellschafter zur Rückzahlung eines auf der Ersten, Zweiten und/oder Dritten Ebene erhaltenen Betrags ver-
pflichtet ist. Die Zuteilung auf der Gemeinsame Ebene erfolgt solange, bis alle Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt
wurden.
8.6 Die bevorzugte Zuteilung der Exiterlöse auf der Ersten Ebene, auf der Zweiten Ebene und auf der Dritten Ebene gilt
für jeden der jeweiligen Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3, Anteile der Serie A4, Anteile
der Serie B und Anteile der Serie C solange, wie der jeweilige Investor den Gesamtbetrag, welcher diesem Investor gemäß
der Ersten, Zweiten und/oder Dritten Ebene zuzuteilen ist, noch nicht erhalten hat.
24120
L
U X E M B O U R G
8.7 Unabhängig davon, ob die Übertragung von Anteilen während eines Liquiditätsereignisses oder danach in einer oder
mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für die Übertragung all seiner Anteile einen Betrag zu
erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der
Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den Anteilen, die auf einer gemeinsamen und gleich-
wertigen Basis übertragen wurden, oder (ii) als der Betrag, der diesem Gesellschafter auf der Ersten, Zweiten und/oder
Dritten Ebene aus einer späteren Übertragung zugeteilt wurde. Sämtliche mit der hierin festgelegten Liquiditätspräferenz
verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.
Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen
Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.
9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil
eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile
automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.
9.3 Wird der besagte Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug
auf eine Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschaf-
terrechte nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach
Eintritt der gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.
9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer im
Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile
entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-
schaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d‘Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.
Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.
11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-
gleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die
Gesellschaft als Garant haftet.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
24121
L
U X E M B O U R G
12.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.
12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich EMail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschrif-
ten des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die
Gesellschafterversammlung in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusam-
menhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleinge-
sellschafter ausgeübt.
Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche in
der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
13.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
13.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei der Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine schrift-
liche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer unter der
Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals
vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 16. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen. Eine Änderung dieser Satzung,
welche wesentliche oder nachteilige Auswirkungen auf die Rechte der Inhaber von Anteilen der Serie A1, Anteilen der
Serie A2, Anteilen der Serie A3, Anteilen der Serie A4, Anteilen der Serie B und Anteilen der Serie C hat, erfordert die
Zustimmung aller Inhaber solcher Anteile.
24122
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Beschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
17.1 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern die Zustimmung der Gesellschafter, die zusam-
men fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals behalten, und erfordern die Zustimmung des Beirats:
17.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens, eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermögens
oder des gesamten oder eines beträchtlichen Anteils des Vermögens direkter oder indirekter Tochtergesellschaften der
Gesellschaft (einschließlich, unter anderem, der Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder der Gesamtheit
der Rechte des geistigen Eigentums), sofern eine solche Veräußerung marktüblichen Bedingungen nicht unterliegt;
17.1.2 Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag solcher
Gewinne auf neue Rechnung; Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven (einschließlich, aber nicht beschränkt auf das
Agio und andere Kapitalreserven), sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; und 17.1.3 Übertragung von gewerb-
lichen Schutzrechten oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesellschaft an Dritte.
17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die Zu-
stimmung des Beirats:
17.2.1 Beschluss hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft; und
17.2.2 Änderung dieser Satzung (Artikel 17 inbegriffen), einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Verschmel-
zung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft;
17.3 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die Zu-
stimmung aller Investoren:
17.3.1 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen; und
17.32 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, einschließlich des Rückkaufs von Anteilen, mit Ausnahme der Erwerbe
gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung.
17.4 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und
Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
17.5 Änderungen im Beschlussfassungsprozess der Gesellschaft (einschließlich der Zuständigkeit der Gesellschafter-
versammlungen, der Sitzungen des Beirats und jeder notwendigen spezifischen Mehrheit zur Annahme einiger Beschlüsse)
zum einseitigen Nachteil eines Investors sind nicht ohne Zustimmung dieses Investors vorzunehmen. Zur Klarstellung wird
darauf hingewiesen, dass ein einseitiger Nachteil der Investoren bei einer Herabsetzung der Stimmanzahl oder bei einer
Änderung der Stimmrechte von Gesellschaftern oder Geschäftsführern besteht, die zur Annahme eines Beschlusses erfor-
derlich sind.
D. Rat der Geschäftsführer und Beirat
Art. 18. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers; Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff alleiniger Ge-
schäftsführer nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den Rat der
Geschäftsführer als Verweis auf den alleinigen Geschäftsführer auszulegen.
18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und ihre
Amtszeit festlegt.
19.2 Die Geschäftsführer können durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung jederzeit und ohne Grund
ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten und
die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterver-
sammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige
Ernennung entscheidet.
20.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
24123
L
U X E M B O U R G
Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des
Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
21.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-
punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-
führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikations-
mittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.
22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
22.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats für die untenstehenden Rechtsgeschäfte und Maßnah-
men der Gesellschaft (eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise
definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung der Gesellschafterversammlung ge-
nehmigt wurden):
22.8.1 Übernahme von Bürgschaften oder Garantien, die einen Betrag von fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,00)
überschreiten;
22.8.2 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Transak-
tionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
22.8.3 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungsverpflichtungen jeglicher Art;
22.8.4 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-
cher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
22.8.5 Einleitung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streit-
wert von über fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,00) im Einzelfall;
22.8.6 Abschluss, Beendigung oder Änderung von stiller Beteiligungen und Unterbeteiligungen in der Gesellschaft;
22.8.7 Abschluss, Änderung und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Ak-
tiengesetzes (AktG)); und
24124
L
U X E M B O U R G
22.8.8 Genehmigung des Jahresplans für jedes folgende Jahr.
Beschlüsse bezüglich der Einführung eines Mitarbeiter-Beteiligungsmodells bedürfen der Zustimmung des Beirats.
22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforderlich,
so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesellschaf-
terversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung des
Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und Maßnah-
men auch im Voraus erteilen.
22.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss oder eine Gesellschaftervereinbarung eine Ge-
schäftsordnung für die Geschäftsführer beschließen.
22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,
auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer Protokoll der Entscheidungen des Alleinigen Ge-
schäftsführers.
23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden),
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Ka-
tegorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie
B), werden Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder
deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige
Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder von zwei
(2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von
Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden
solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie
B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers, oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder
deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat (der „Beirat“). Dieser besteht aus sieben (7) stimmberechtigten Mitgliedern, und
insgesamt neun (9) Stimmen, und zusätzlichen nicht-stimmberechtigten Mitgliedern (die „Beobachter“). Die Gesellschafter
können durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss die Anzahl der Mitglieder des Beirats und die Anzahl der Stim-
men von jeden Mitgliedern erhöhen oder herabsetzen.
25.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einen einstimmigen Gesellschafterbe-
schluss genehmigen oder verändern.
25.3 Jeder der Investoren ist jederzeit dazu berechtigt, einen nichtstimmberechtigten Beobachter des Beirats zu ernennen,
der zur Teilnahme an Sitzungen des Beirats berechtigt ist und zur gleichen Zeit wie die stimmberechtigten Mitglieder alle
vorbereitenden Dokumente, Einladungen zu Sitzungen und Protokolle des Beirats erhält.
25.4 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem entsprechenden ernennenden Gesellschafter jedes
Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:
25.4.1 zwei (2) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats, jeder mit einer (1) Stimme, werden von dem Investor AIH
nach eigenem Ermessen ernannt;
25.4.2 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, mit drei (3) Stimmen, werden von dem Investor LIH nach eigenem
Ermessen ernannt;
25.4.3 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, mit einer (1) Stimme, wird von dem Investor Phenomen nach
eigenem Ermessen ernannt;
25.4.4 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, mit einer (1) Stimme, wird von dem Investor TEC nach eigenem
Ermessen ernannt;
25.4.5 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, mit einer (1) Stimme, wird von dem Investor HV nach eigenem
Ermessen ernannt; und
24125
L
U X E M B O U R G
25.4.6 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, mit einer (1) Stimme, wird von dem Investor Radford nach
eigenem Ermessen ernannt.
Jedes stimmberechtigte Mitglied des Beirats hat eine (1) Stimme.
25.5 Der Beirat ist für die Erteilung von Zustimmungen zu Transaktionen und Maßnahmen der Geschäftsführer zu-
ständig, welche die Gesellschafterversammlung vorbehaltlich der Zustimmung des Beirats (i) in dieser Satzung, (ii) in der
Geschäftsordnung für die Geschäftsführer, (iii) durch einen Gesellschafterbeschluss oder (iv) in einer Gesellschafterver-
einbarung, vorgenommen hat.
25.6 Die Vergütung der Mitglieder des Beirats wird, sofern vorgesehen, von den Gesellschaftern der Gesellschaft durch
einstimmigen Gesellschafterbeschluss festgelegt.
25.7 Neben den Zustimmungserfordernissen gemäß Artikel 17.1, Artikel 22.8 und Artikel 22.9 hat der Beirat eine
beratende Funktion und wird nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.
25.8 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des Artikels 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer (commissaire(s)) beaufsichtigt. Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d‘entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.
26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden
Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-
klang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinnund
Verlustrechnung.
28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
28.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-
falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-
mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-
stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen
an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.
Art. 29. Abschlagsdividenden Agio und Andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 verteilt
und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls
erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Ver-
luste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht
ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-
gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
24126
L
U X E M B O U R G
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die
Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt.
Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der
Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 31. Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den
Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen
den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.
31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.„
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Ka-
tegorie, sowie Magdalena Staniczek, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneinge-
schränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr EUR 8.200,- geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vornamen
und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von dem Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet worden.
Gezeichnet: J. DE MAYER, B. BEERENS, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38133. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 11. Dezember 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015200699/1322.
(150225592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Aircraft Solutions Lux IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 159.659.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of November.
Before Maître Jacques Kesseler, notary established in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CLSec 1 Lux S:à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and existing under
the laws of Luxembourg, with its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 184.304 (the “Sole Sha-
reholder”);
represented here by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at 13, Route de
Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
24127
L
U X E M B O U R G
Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of Aircraft Solutions Lux IX S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) organized and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 15, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under number B 159.659.
II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of the definition of the independent manager as defined under the article 12 of the articles of association
of the Company.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolution has been taken:
<i>Sole resolution:i>
the Sole Shareholder resolves to amend the definition of the independent manager as defined under the article 12 of the
articles of incorporation of the Company as follows:
"Independent Manager" means a person with requisite knowledge of the aviation industry and experience in business
and finance that is not at the time of his or her appointment or at any time when such person is servicing as an Independent
Manager provided, however, that any such person may serve as an independent trustee, independent manager or independent
director of another special purpose vehicle that is an Affiliate of the Issuer, any Transferor, any Investor or Castlelake L.P.,
and has not been for a period of 5 (five) years prior to such appointment (i) an employee, creditor, supplier, manager,
contractor, officer or director of any Transferor, Castlelake, L.P., any Investor or any Affiliate of any such persons, or a
spouse of, or person related to (but not more remotely than first cousins) a person described in this clause (i), (ii) the
beneficial holder (directly or indirectly) of any equity interests (excluding de minimis ownership interests) of any Trans-
feror, Castlelake, L.P., any Investor, any holder of any direct or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate
of any such persons, (iii) a person who Controls (whether directly, indirectly or otherwise) any Transferor, Castlelake, L.P.,
any Investor, any holder of any direct or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate of any such persons or
an employee, officer, director or manager of any such persons or (iv) a person who Controls (whether directly, indirectly
or otherwise) any creditor, supplier or contractor of any Transferor, Castlelake, L.P., any Investor, any holder of any direct
or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate of any such persons, or an employee, officer, director or
manager of any such persons. The terms “Affiliate”, “Control”, “Issuer”, “Transferor” and “Investor” shall have the mean-
ing set forth in the Indenture."
No other amendment is made to the articles of association.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire établi à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg.
A comparu:
CLSec 1 Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie en constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son
siège social à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184.304 (l'«Associé Unique»);
représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privé, résidant professionnellement à 13, Route de Lu-
xembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu du procuration sous seing privé.
Ladite procuration a été signée “ne varietur” par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire
instrumentaire, sera annexée au présent acte pour être déposé avec le présent acte lors des formalités d'enregistrement.
La partie comparante, représentée telle que décrit ci-dessus, a prié le notaire instrumentaire d'enregistrer ce qui suit:
I.- La partie comparante est l'associé unique de Aircraft Solutions Lux IX S.à r.l., une société à responsabilité limitée)
établie en constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
159.659.
II.- L'ordre du jour de la réunion est le suivant:
1. Avenant à la définition de gérant indépendant de l'article 12 des statuts de la Société.
Après avoir approuvé ce qui précède, l'Associé Unique a pris la résolution suivante:
24128
L
U X E M B O U R G
<i>Résolution unique:i>
l'Associé Unique résout de modifier la définition de gérant indépendant tel que défini à l'article 12 des statuts de la
Société comme suit:
"Gérant Indépendant" désigne une personne disposant des connaissances requises de l'industrie aéronautique et de
l'expérience dans les affaires et la finance qui n'est pas au moment de sa nomination, ou à tout moment lorsque cette personne
exerce en tant que Gérant Indépendant (étant entendu que cette personne peut occuper les fonctions de trustee indépendant
ou de dirigeant indépendant d'un autre véhicule d'investissement dédié qui est une Affiliée de l'Emetteur, d'un Cédant, d'un
Investisseur ou de Castlelake L.P.) et n'a pas été pendant une période de 5 (cinq) ans avant cette nomination (i) un employé,
un créancier, fournisseur, gérant, sous-traitant, dirigeant ou administrateur d'un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur ou
une Affiliée de ces personnes, ou un conjoint, ou personne liée à (mais pas d'un degré plus éloigné que cousins germains)
une personne visée au point (i), (ii) le bénéficiaire (directement ou indirectement) de titres de capital (à l'exclusion de
participations de minimis) d'un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un détenteur d'un intérêt bénéficiaire direct ou
indirect dans un investisseur ou d'une Affiliée de chacune de ces personnes, (iii) une personne qui Contrôle (directement,
indirectement ou autrement) un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un titulaire d'un intérêt bénéficiaire direct ou
indirect dans un Investisseur ou dans une Affiliée de ces personnes ou un employé, dirigeant, administrateur ou gérant de
ces personnes ou (iv) une personne qui Contrôle (directement, indirectement ou autre) tout créancier, fournisseur ou en-
trepreneur de tout Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un intérêt bénéficiaire direct ou indirect dans un Investisseur ou
dans une Affiliée de chacune de ces personnes, ou un employé, dirigeant, administrateur ou gérant de ces personnes. Les
termes "Affiliée", "Contrôle", "Emetteur", "Cédant" et "Investisseurs" ont le sens donné dans les Contrats d'Emission.
Aucune autre modification n'est apportée aux statuts.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, à la demande de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais et suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original
du présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 novembre 2015. Relation: EAC/2015/28059. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015200476/104.
(150225960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Aircraft Solutions Lux XV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 91.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 171.863.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of November.
Before Maître Jacques Kesseler, notary established in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CLSec 2 Lux S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and existing under
the laws of Luxembourg, with its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 184.306 (the “Sole Sha-
reholder”);
represented here by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at 13, Route de
Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of Aircraft Solutions Lux XV S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) organized and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 15, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under number B 171.863.
II.- The agenda of the meeting is the following:
24129
L
U X E M B O U R G
1. Amendment of the definition of the independent manager as defined under the article 12 of the articles of association
of the Company.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolution has been taken:
<i>Sole resolution:i>
the Sole Shareholder resolves to amend the definition of the independent manager as defined under the article 12 of the
articles of incorporation of the Company as follows:
"Independent Manager" means a person with requisite knowledge of the aviation industry and experience in business
and finance that is not at the time of his or her appointment or at any time when such person is servicing as an Independent
Manager (provided, however, that any such person may serve as an independent trustee, independent manager or inde-
pendent director of another special purpose vehicle that is an Affiliate of the Issuer, any Transferor, any Investor or
Castlelake L.P.), and has not been for a period of 5 (five) years prior to such appointment (i) an employee, creditor, supplier,
manager, contractor, officer or director of any Transferor, Castlelake, L.P., any Investor or any Affiliate of any such persons,
or a spouse of, or person related to (but not more remotely than first cousins) a person described in this clause (i), (ii) the
beneficial holder (directly or indirectly) of any equity interests (excluding de minimis ownership interests) of any Trans-
feror, Castlelake, L.P., any Investor, any holder of any direct or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate
of any such persons, (iii) a person who Controls (whether directly, indirectly or otherwise) any Transferor, Castlelake, L.P.,
any Investor, any holder of any direct or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate of any such persons or
an employee, officer, director or manager of any such persons or (iv) a person who Controls (whether directly, indirectly
or otherwise) any creditor, supplier or contractor of any Transferor, Castlelake, L.P., any Investor, any holder of any direct
or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate of any such persons, or an employee, officer, director or
manager of any such persons. The terms “Affiliate”, “Control”, “Issuer”, “Transferor” and “Investor” shall have the mean-
ing set forth in the Indenture."
No other amendment is made to the articles of association.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois de novembre.
Pardevant Maître Jacques Kesseler, notaire établi à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg.
A comparu:
CLSec 2 Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie en constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son
siège social à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184.306 (l'“Associé Unique”);
représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privé, résidant professionnellement à 13, Route de Lu-
xembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu du procuration sous seing privé.
Ladite procuration a été signée “ne varietur” par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire
instrumentaire, sera annexée au présent acte pour être déposé avec le présent acte lors des formalités d'enregistrement.
La partie comparante, représentée telle que décrit ci-dessus, a prié le notaire instrumentaire de prendre que:
I.- La partie comparante est l'associé unique de Aircraft Solutions Lux XV S.à r.l.,, une société à responsabilité limitée
établie en constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
171.863.
II.- L'agenda de la réunion est le suivant:
1. Avenant à la définition de gérant indépendant à l'article 12 des statuts de la Société.
Après avoir approuvé ce qui précède, l'Associé Unique a pris la résolution suivante:
<i>Résolution unique:i>
l'Associé Unique résout de modifier la définition de gérant Indépendant tel que définit à l'article 12 des statuts de la
Société comme suit:
"Gérant Indépendant" désigne une personne disposant des connaissances requises de l'industrie de l'aviation et de l'ex-
périence dans les affaires et la finance qui n'est pas au moment de sa nomination, ou à tout moment lorsque cette personne
sert en tant que Gérant Indépendant (étant entendu que cette personne peut occuper les fonctions de trustee indépendant or
dirigeant indépendant d'un autre véhicule d'investissement dédié qui est une Affiliée de l'Emetteur, d'un Cédant, d'un
24130
L
U X E M B O U R G
Investisseur ou de Castlelake L.P.) et n'a pas été pendant une période de 5 (cinq) ans avant cette nomination (i) un employé,
un créancier, prestataire, gérant, sous-traitant, dirigeant ou administrateur d'un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur ou
une Affiliée de ces personnes, ou un conjoint, ou personne liée à (mais pas d'un degré plus éloigné que cousins germains)
une personne visée au point (i), (ii) le bénéficiaire (directement ou indirectement) de titres de capital (à l'exclusion de
participations de minimis) d'un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un détenteur d'un intérêt bénéficiaire direct ou
indirect dans un investisseur ou d'une Affiliée de chacune de ces personnes, (iii) une personne qui Contrôle (directement,
indirectement ou autrement) un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un titulaire d'un intérêt bénéficiaire direct ou
indirect dans un Investisseur ou dans une Affiliée de ces personnes ou un employé, dirigeant, administrateur ou gérant de
ces personnes ou (iv) une personne qui Contrôle (directement, indirectement ou autre) tout créancier, fournisseur ou en-
trepreneur de tout Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un intérêt bénéficiaire direct ou indirect dans un Investisseur ou
dans une Affiliée de chacune de ces personnes, ou un employé, dirigeant, administrateur ou gérant de ces personnes. Les
termes "Affiliée", "Contrôle", "Emetteur", "Cédant" et "Investisseurs" ont le sens donné dans les Contrats d'Emission.
Aucune autre modification n'est apportée aux statuts.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original
du présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 novembre 2015. Relation: EAC/2015/28067. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015200483/104.
(150225968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Aircraft Solutions Lux XX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 186.862.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of November.
Before Maître Jacques Kesseler, notary established in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CLSec 1 Lux S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and existing under
the laws of Luxembourg, with its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 184.304 (the “Sole Sha-
reholder”);
represented here by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at 13, Route de
Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of Aircraft Solutions Lux XX S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) organized and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 15, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under number B 186.862.
II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of the definition of the independent manager as defined under the article 12 of the articles of association
of the Company.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolution has been taken:
<i>Sole resolution:i>
the Sole Shareholder resolves to amend the definition of the independent manager as defined under the article 12 of the
articles of incorporation of the Company as follows:
24131
L
U X E M B O U R G
"Independent Manager" means a person with requisite knowledge of the aviation industry and experience in business
and finance that is not at the time of his or her appointment or at any time when such person is servicing as an Independent
Manager (provided, however, that any such person may serve as an independent trustee, independent manager or inde-
pendent director of another special purpose vehicle that is an Affiliate of the Issuer, any Transferor, any Investor or
Castlelake L.P.), and has not been for a period of 5 (five) years prior to such appointment (i) an employee, creditor, supplier,
manager, contractor, officer or director of any Transferor, Castlelake, L.P., any Investor or any Affiliate of any such persons,
or a spouse of, or person related to (but not more remotely than first cousins) a person described in this clause (i), (ii) the
beneficial holder (directly or indirectly) of any equity interests (excluding de minimis ownership interests) of any Trans-
feror, Castlelake, L.P., any Investor, any holder of any direct or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate
of any such persons, (iii) a person who Controls (whether directly, indirectly or otherwise) any Transferor, Castlelake, L.P.,
any Investor, any holder of any direct or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate of any such persons or
an employee, officer, director or manager of any such persons or (iv) a person who Controls (whether directly, indirectly
or otherwise) any creditor, supplier or contractor of any Transferor, Castlelake, L.P., any Investor, any holder of any direct
or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate of any such persons, or an employee, officer, director or
manager of any such persons. The terms “Affiliate”, “Control”, “Issuer”, “Transferor” and “Investor” shall have the mean-
ing set forth in the Indenture."
No other amendment is made to the articles of association.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire établi à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg.
A comparu:
CLSec 1 Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie en constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son
siège social à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184.304 (l'«Associé Unique»);
représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privé, résidant professionnellement à 13, Route de Lu-
xembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu du procuration sous seing privé.
Ladite procuration a été signée “ne varietur” par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire
instrumentaire, sera annexée au présent acte pour être déposé avec le présent acte lors des formalités d'enregistrement.
La partie comparante, représentée telle que décrit ci-dessus, a prié le notaire instrumentaire d'enregistrer ce qui suit:
I.- La partie comparante est l'associé unique de Aircraft Solutions Lux XX S.à r.l., une société à responsabilité limitée)
établie en constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
186.862.
II.- L'ordre du jour de la réunion est le suivant:
1. Avenant à la définition de gérant indépendant de l'article 12 des statuts de la Société.
Après avoir approuvé ce qui précède, l'Associé Unique a pris la résolution suivante:
<i>Résolution unique:i>
l'Associé Unique résout de modifier la définition de gérant indépendant tel que défini à l'article 12 des statuts de la
Société comme suit:
"Gérant Indépendant" désigne une personne disposant des connaissances requises de l'industrie aéronautique et de
l'expérience dans les affaires et la finance qui n'est pas au moment de sa nomination, ou à tout moment lorsque cette personne
exerce en tant que Gérant Indépendant (étant entendu que cette personne peut occuper les fonctions de trustee indépendant
ou de dirigeant indépendant d'un autre véhicule d'investissement dédié qui est une Affiliée de l'Emetteur, d'un Cédant, d'un
Investisseur ou de Castlelake L.P.) et n'a pas été pendant une période de 5 (cinq) ans avant cette nomination (i) un employé,
un créancier, fournisseur, gérant, sous-traitant, dirigeant ou administrateur d'un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur ou
une Affiliée de ces personnes, ou un conjoint, ou personne liée à (mais pas d'un degré plus éloigné que cousins germains)
une personne visée au point (i), (ii) le bénéficiaire (directement ou indirectement) de titres de capital (à l'exclusion de
participations de minimis) d'un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un détenteur d'un intérêt bénéficiaire direct ou
indirect dans un investisseur ou d'une Affiliée de chacune de ces personnes, (iii) une personne qui Contrôle (directement,
indirectement ou autrement) un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un titulaire d'un intérêt bénéficiaire direct ou
indirect dans un Investisseur ou dans une Affiliée de ces personnes ou un employé, dirigeant, administrateur ou gérant de
24132
L
U X E M B O U R G
ces personnes ou (iv) une personne qui Contrôle (directement, indirectement ou autre) tout créancier, fournisseur ou en-
trepreneur de tout Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un intérêt bénéficiaire direct ou indirect dans un Investisseur ou
dans une Affiliée de chacune de ces personnes, ou un employé, dirigeant, administrateur ou gérant de ces personnes. Les
termes "Affiliée", "Contrôle", "Emetteur", "Cédant" et "Investisseurs" ont le sens donné dans les Contrats d'Emission.
Aucune autre modification n'est apportée aux statuts.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, à la demande de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais et suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original
du présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 novembre 2015. Relation: EAC/2015/28069. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015200484/104.
(150225966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Hairdress by Tess S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3850 Schifflange, 17-19, avenue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 202.163.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le trois décembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
A COMPARU:
Madame Tessy CATTAZZO, coiffeuse, née à Luxembourg le 15 juillet 1987, demeurant à L-5752 Frisange, 7, Um Hau.
Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle va
constituer.
Titre I
er
. Raison sociale, objet, siège, durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi que
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure pour dames et hommes avec vente des articles ou
produits de la branche.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.
La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobi-
lières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.
Art. 3. La société prend la dénomination de "HAIRDRESS by Tess s.à r.l.".
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Schifflange.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II. Capital social, apports, parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales d'une
valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera
considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés
qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
24133
L
U X E M B O U R G
Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à
l'article 1690 du Code Civil.
Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les
associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.
L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur
les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour
l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Titre III. Gérance
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du
capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes,
ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation
toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un
délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour
faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit
d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.
Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et
registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Titre IV. Décisions et assemblées générales
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des réso-
lutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception
du texte de la résolution proposée.
Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement
prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum
n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une
seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du
capital représenté.
Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Titre V. Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices
Art. 16. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social
communication desdits inventaire et bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts
sociales.
24134
L
U X E M B O U R G
Titre VI. Dissolution, liquidation
Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18
septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associée unique Madame Tessy CATTAZZO, préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(€ 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate
expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis
à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La comparante ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Madame Tessy CATTAZZO, préqualifiée, est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée.
2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.
3.- Le siège social est établi à L-3850 Schifflange, 17-19, avenue de la Libération.
La comparante déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le
bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et agir pour son propre compte et certifie que les fonds servant
à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à
l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
Le notaire instrumentant a rendu attentive la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: CATTAZZO, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 8 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38912. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.
Bascharage, le 14 décembre 2015.
Référence de publication: 2015200810/126.
(150226084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
CASHMERE Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 42.640.
L'an deux mille quinze, le vingt-six novembre.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de gestion de patrimoine familial dénommée
"CASHMERE Spf S.A.", avec siège social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par
Maître Frank BADEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 29 décembre
1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 160 du 14 avril 1993. Les statuts ont été modifiés
à plusieurs reprises, et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentaire en date du 15 septembre 2008, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2459 du 8 octobre 2008.
24135
L
U X E M B O U R G
La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42 640.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle
au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, avec la même adresse
professionnelle.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Corinne PETIT, prénommée.
Madame le président déclare et requiert le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l'enregistrement.
II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Décision sur la dissolution et la mise en liquidation de la Société;
2) Décharge aux organes de la société;
3) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs; et
4) Divers.
L'Assemblée après avoir approuvé l'exposé de Madame le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée,
a abordé l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et adopter comme actes de la Société les actes passés par les
administrateurs et par les commissaires aux comptes de la Société, pour la période débutant à la constitution de la Société
et jusqu'à la date du présent acte, de renoncer à toute action que la Société pourrait intenter à l'égard des administrateurs
ou des commissaires aux comptes de la Société en conséquence de l'exécution de leur mandat respectif, et de leur Page 3
accorder décharge pour l'accomplissement de leur mandat respectif jusqu'à la date du présent acte.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée désigne comme liquidateur la société anonyme «C.G. Consulting», ayant son siège social à L-2163 Lu-
xembourg, 40, avenue Monterey, enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 102.188 (le «Liquidateur») auquel sont conférés les pouvoirs prévus par les dispositions légales en vigueur.
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 à 148 bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi»). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans
devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Le Liquidateur a le droit de distribuer les actifs en espèces et également de verser aux actionnaires dans l'intérêt de la
société des avances sur le produit de la liquidation. Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer
aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle
partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de
liquidation, aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à mille quatre cents euros (1.400.- EUR) sont à charge
de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous
ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Petit, L. Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 07 décembre 2015. 2LAC/2015/27903. Reçu douze euros EUR 12,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
24136
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2015.
Référence de publication: 2015200649/73.
(150225827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Advice S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Capesius et Reding S.à r.l.).
Siège social: L-5852 Hesperange, 10, rue d'Itzig.
R.C.S. Luxembourg B 27.368.
L'an deux mil quinze, le dix novembre.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange,
Ont comparu:
1.- Monsieur Joseph REDING, maître-menuisier, demeurant à L-5852 Hesperange, 46, rue d'Itzig;
2.- Madame Irme REDING-TAMELLINI, commerçante, demeurant à L-5852 Hesperange, 46, rue d'Itzig;
3.- Madame Karin REDING, commerçante, demeurant à L-3397 Roeser, 1A, rue Hoehl;
4.- Madame Marie-Antoinette dite Toiny REDING, architecte d'intérieur, demeurant à L-3397 Roeser, 6, rue d'Alzingen.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant:
Que la société «CAPESIUS ET REDING S.à r.l.», ayant son siège social à L-5852 Hesperange, 10, rue d'Itzig, (ci-après
la «Société») a été constituée suivant acte reçu par Maître Tom METZLER, alors notaire de résidence à Luxembourg-
Bonnevoie, en date du 29 janvier 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 105 de l'année
1988, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 29 avril 1988, publié audit Mémorial C, Numéro 186 de
l'année 1988, modifiée suivant décision de l'assemblée générale des associés sous seing privée en date du 15 janvier 2002,
portant conversion du capital social en euros, publiée audit Mémorial C numéro 899 du 13 juin 2002, et en dernier lieu
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 mars 2015, publié audit Mémorial C numéro 1388 du 1
er
juin
2015.
Qu'elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 27368;
Qu'elle a un capital social de trente-deux mille cinq cents euros (EUR 32.500,-), divisé en mille trois cents (1.300) parts
sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune;
Que les comparants sont les seuls et uniques associés (les "Associés") en vertu des statuts publiés comme prédit.
Sur ce, les comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de changer la dénomination de «CAPESIUS ET REDING S.à r.l.» en «Advive S.à r.l.» et de
modifier en conséquence l'article 2 des statuts comme suit:
« Art. 2. La société prend la dénomination de «Advive S.à r.l.».
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de changer l'objet social de la Société et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts, comme
suit:
« Art. 4. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'administration, la
gestion, le contrôle et le développement des sociétés ou entreprises qui font partie du même groupe de sociétés qu'elle.
La société pourra participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir de toute manière,
tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, accorder
aux sociétés ou entreprises dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés
qu'elle, tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle peut notamment contracter tous prêts ou crédits et se porter caution solidaire.
D'une façon générale, elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rap-
portant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.».
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés acceptent la démission de la gérante commerciale Madame Irme TAMELLINI, et lui accordent pleine et
entière décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
24137
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident de nommer gérant unique pour une durée indéterminée: Monsieur Joseph REDING, jusqu'alors
gérant technique.
La société est engagée et représentée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour le présent procès-verbal est clos.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Reding, I. Reding-Tamellini, K. Reding, T. Reding, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 13 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/35949. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 10 décembre 2015.
Référence de publication: 2015200643/61.
(150225685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Corestate Turbo FRA HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 180.016.
EXTRAIT
Il résulte d'un acte de cession sous seing privé signé en date du 9 décembre 2015 que:
1. CORESTATE CAPITAL AG, une société de droit suisse, avec siège social à Baarerstrasse 135, CH-6300 Zug, Suisse,
immatriculée auprès du registre de commerce du canton Zug sous le numéro CHE-113.002.233, a cédé 168.954 parts
sociales de catégorie A, 168.954 parts sociales de catégorie B, 168.954 parts sociales de catégorie C, 168.954 parts sociales
de catégorie D, 168.954 parts sociales de catégorie E, 168.954 parts sociales de catégorie F, 168.954 parts sociales de
catégorie G, 168.954 parts sociales de catégorie H, 168.954 parts sociales de catégorie I et 168.954 parts sociales de catégorie
J à CHINAWHITE S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Trinity Chambers, P.O.
Box 4301, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, immatriculée auprès du registre de commerce des Iles Vierges
Britanniques, immatriculée auprès du registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1657007;
2. CORESTATE CAPITAL AG, une société de droit suisse, avec siège social à Baarerstrasse 135, CH-6300 Zug, Suisse,
immatriculée auprès du registre de commerce du canton Zug sous le numéro CHE-113.002.233, a cédé 25.848 parts sociales
de catégorie A, 25.848 parts sociales de catégorie B, 25.848 parts sociales de catégorie C, 25.848 parts sociales de catégorie
D, 25.848 parts sociales de catégorie E, 25.848 parts sociales de catégorie F, 25.848 parts sociales de catégorie G, 25.848
parts sociales de catégorie H, 25.848 parts sociales de catégorie I et 25.848 parts sociales de catégorie J à Townhouse
Services Limited, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Trinity Chambers, P.O. Box 4301,
Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, immatriculée auprès du registre de commerce des Iles Vierges Britanniques
sous le numéro 1655078;
3. CORESTATE CAPITAL AG, une société de droit suisse, avec siège social à Baarerstrasse 135, CH-6300 Zug, Suisse,
immatriculée auprès du registre de commerce du canton Zug sous le numéro CHE-113.002.233, a cédé 11.078 parts sociales
de catégorie A, 11.078 parts sociales de catégorie B, 11.078 parts sociales de catégorie C, 11.078 parts sociales de catégorie
D, 11.078 parts sociales de catégorie E, 11.078 parts sociales de catégorie F, 11.078 parts sociales de catégorie G, 11.078
parts sociales de catégorie H, 11.078 parts sociales de catégorie I et 11.078 parts sociales de catégorie J à M06 Limited,
une société de droit de l'Île de Man, avec siège social à 4
th
Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas,
Île de Man, IM1 2LF, immatriculée auprès du registre de commerce de l'Île de Man sous le numéro 011288V.
Partant, les parts sociales de la Société sont réparties comme suit:
24138
L
U X E M B O U R G
CHINAWHITE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463.074 parts sociales de catégorie A
463.074 parts sociales de catégorie B
463.074 parts sociales de catégorie C
463.074 parts sociales de catégorie D
463.074 parts sociales de catégorie E
463.074 parts sociales de catégorie F
463.074 parts sociales de catégorie G
463.074 parts sociales de catégorie H
463.074 parts sociales de catégorie I
463.074 parts sociales de catégorie J
Townhouse Services Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.848 parts sociales de catégorie A
25.848 parts sociales de catégorie B
25.848 parts sociales de catégorie C
25.848 parts sociales de catégorie D
25.848 parts sociales de catégorie E
25.848 parts sociales de catégorie F
25.848 parts sociales de catégorie G
25.848 parts sociales de catégorie H
25.848 parts sociales de catégorie I
25.848 parts sociales de catégorie J
M06 Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.078 parts sociales de catégorie A
11.078 parts sociales de catégorie B
11.078 parts sociales de catégorie C
11.078 parts sociales de catégorie D
11.078 parts sociales de catégorie E
11.078 parts sociales de catégorie F
11.078 parts sociales de catégorie G
11.078 parts sociales de catégorie H
11.078 parts sociales de catégorie I
11.078 parts sociales de catégorie J
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015200630/66.
(150225309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Katone World S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Cabinet Comptable Madimba S.à r.l.).
Siège social: L-1470 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 161.263.
L'an deux mille quinze, le trois décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Monsieur Kinzonzi MWEKATONE, gérant, né à Kinshasa (République démocratique du Congo), le 8 décembre 1986,
demeurant à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- que le comparant est l’associé unique de «Cabinet Comptable MADIMBA SARL», une société à responsabilité limitée,
ayant son siège social à L-3223 Bettembourg, 20, rue Dicks, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro B 161.263, constituée suivant acte reçu par Maître Roger ARRENSDORFF, notaire, alors
de résidence à Mondorf-les-Bains en date du 19 avril 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1778 du 4 août 2011 et
- qu'il a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale constate qu'en vertu d’une cession de parts sociales sous seing privé daté du 27 novembre 2015,
approuvée par l’associé conformément à l'article six (6) des statuts et considérée comme dûment signifiée à la société,
conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, Monsieur Naeem
AKHTAR, demeurant à L-8084 Bertrange, 6, rue de la Petrusse, a cédé ses cent (100) parts sociales à Monsieur Kinzonzi
MWEKATONE, prénommé.
24139
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en KATONE WORLD S.à.r.l. et de donner en conséquence
à l'article 1
er
des statuts la teneur suivante:
« Art. 1
er
. La société prend la dénomination de «KATONE WORLD S.à r.l.».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société vers L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich, et de
modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de changer l’objet social et de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 3. La Société a pour objet l’importation et l’exportation de textiles en tous genres ainsi que des opérations d’achat
et de vente en relation avec cette activité. En outre elle pourra exploiter un restaurant, bar, discothèque, avec débit de
boissons alcoolisées et non-alcoolisées.
La société a également pour objet toutes activités commerciales, en accord avec les dispositions de la loi du 9 juillet
2004, modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement et réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution
pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer le gérant actuel et en lui accordant décharge et décide de nommer au poste de gérant
unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Kinzonzi MWEKATONE, gérant, né à Kinshasa (République démocratique du Congo), le 8 décembre 1986,
demeurant à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de mille euros, sont à charge de la société, et les associés
s'y engagent personnellement.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Kinzonzi MWEKATONE, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 07 décembre 2015. Relation GAC/2015/10704. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015200612/61.
(150225452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Blackwood International Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 170.590.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of November.
Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand-duchy of Luxembourg,
There appeared:
Blackwood International Holdings Limited, a company incorporated under the laws of Cyprus, having its registered
office at Themistokli Dervi, 3, Julia House, 1066 Nicosia, Cyprus, registered with the Cyprus Trade and Companies Register
under number HE 248549 (the “Sole Member”),
24140
L
U X E M B O U R G
duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, professionally residing professionally in
Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal,
The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,
Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:
- the Sole Member holds all the shares in Blackwood International Group S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) constituted and existing under the laws of Luxembourg, having its registered address at
7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 170 590, incorporated pursuant to a
notarial deed of Maître Francis Kesseler, then notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
on July 18, 2012, published in the Official gazette, (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), number 2210 of
September 5, 2012 (the “Company”);
- the Company's capital is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000), represented by thirty-one thousand (31,000)
corporate units in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up;
- the Sole Member hereby resolves to proceed with the dissolution of the Company with effect as from today;
- the Sole Member assumes the role of liquidator of the Company;
- the Sole Member as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the known
liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Member is vested with all the assets and
hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular
those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;
- the Sole Member waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation) and to
hear a report of an auditor to the liquidation;
- consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed;
- the Sole Member has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the financial
situation of the Company;
- the Sole Member grants full discharge to the managers of the Company for their mandates from the date of their
respective appointments up to the date of the present meeting; and
- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting
at the registered office of the Company.
Whereof, the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary this
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le seize novembre.
Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Blackwood International Holdings Limited, une société constituée sous les lois de Chypre, ayant son siège social à
Themistokli Dervi, 3, Julia House, 1066 Nicosia, Chypre, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Chypre
sous le numéro HE 248549 (l'«Associé Unique»),
ici dûment représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant professionnellement à
Pétange, ou tout employé résidant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au
présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement,
Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
- l'Associé Unique détient toutes les parts sociales de Blackwood International Group S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 170590, constituée suivant un acte
notarié de Maître Francis Kesseler, alors notaire résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 18 juillet
2012 et publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2210 du 5 septembre 2012 (la «Société»);
- le capital social de la Société est fixé à trente et un mille Euros (31.000 EUR), représenté par trente et un mille (31.000)
parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (1 EUR) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées;
- par la présente l'Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
24141
L
U X E M B O U R G
- l'Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;
- l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif
connu de la Société a été payé ou provisionné, qu'il est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa
charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour
avant tout paiement à sa personne;
- l'Associé Unique renonce à la formalité de la nomination d'un commissaire à la liquidation et à la préparation d'un
rapport du commissaire à la liquidation;
- partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- la comparante a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;
- la comparante donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour leur mandat à compter de la date de
leurs nominations respectives jusqu'à la date de la présente assemblée; et
- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la
présente assemblée au siège de la Société.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été établi
en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les
versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27093. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015200572/94.
(150225877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
CLSec 1 Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 797.004,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 184.304.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of November.
Before Maître Jacques Kesseler, notary established in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CLSec Holdings 1 Limited, a limited company formed and existing under the laws of Bermuda, registered with the
Registrar of Companies of Bermuda under number 48609, and having its registered office at Codan Dervices Limited of
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda (the “Sole Shareholder”);
represented here by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at 13, Route de
Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of CLSec 1 Lux S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) organized and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under number B 184.304.
II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of the definition of the independent manager as defined under the article 12 of the articles of association
of the Company.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolution has been taken:
<i>Sole resolution:i>
the Sole Shareholder resolves to amend the definition of the independent manager as defined under the article 12 of the
articles of incorporation of the Company as follows:
"Independent Manager" means a person with requisite knowledge of the aviation industry and experience in business
and finance that is not at the time of his or her appointment or at any time when such person is servicing as an Independent
24142
L
U X E M B O U R G
Manager (provided, however, that any such person may serve as an independent trustee, independent manager or inde-
pendent director of another special purpose vehicle that is an Affiliate of the Issuer, any Transferor, any Investor or
Castlelake L.P.), and has not been for a period of 5 (five) years prior to such appointment (i) an employee, creditor, supplier,
manager, contractor, officer or director of any Transferor, Castlelake, L.P., any Investor or any Affiliate of any such persons,
or a spouse of, or person related to (but not more remotely than first cousins) a person described in this clause (i), (ii) the
beneficial holder (directly or indirectly) of any equity interests (excluding de minimis ownership interests) of any Trans-
feror, Castlelake, L.P., any Investor, any holder of any direct or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate
of any such persons, (iii) a person who Controls (whether directly, indirectly or otherwise) any Transferor, Castlelake, L.P.,
any Investor, any holder of any direct or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate of any such persons or
an employee, officer, director or manager of any such persons or (iv) a person who Controls (whether directly, indirectly
or otherwise) any creditor, supplier or contractor of any Transferor, Castlelake, L.P., any Investor, any holder of any direct
or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate of any such persons, or an employee, officer, director or
manager of any such persons. The terms “Affiliate”, “Control”, “Issuer”, “Transferor” and “Investor” shall have the mean-
ing set forth in the Indenture."
No other amendment is made to the articles of association.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois de novembre.
Par devant Maître Jacques Kesseler, notaire établi à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg.
A comparu:
CLSec Holdings 1 Limited, une société à responsabilité limitée établie en constituée selon les lois des Bermudes, ayant
son siège social à Codan Dervices Limited of Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermudes, immatriculée
du registre de commerce des Bermudes sous le numéro 48609 (l' “Associé Unique”);
représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privé, résidant professionnellement à 13, Route de Lu-
xembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu du procuration sous seing privé.
Ladite procuration a été signée “ne varietur” par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire
instrumentaire, sera annexée au présent acte pour être déposé avec le présent acte lors des formalités d'enregistrement.
La partie comparante, représentée telle que décrit ci-dessus, a prié le notaire instrumentaire de prendre que:
I.- La partie comparante est l'associé unique de CLSec 1 Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie en
constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-
Duché du Luxembourg, immatriculée du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184.304.
II.- L'agenda de la réunion est le suivant:
1. Avenant à la définition de gérant indépendant à l'article 12 des statuts de la Société.
Après avoir approuvé ce qui précède, l'Associé Unique a pris la résolution suivante:
<i>Résolution unique:i>
l'Associé Unique résout de modifier la définition de gérant Independent tel que définit à l'article 12 des statuts de la
Société comme suit:
"Gérant Indépendant" désigne une personne disposant des connaissances requises de l'industrie de l'aviation et de l'ex-
périence dans les affaires et la finance qui n'est pas au moment de sa nomination, ou à tout moment lorsque cette personne
sert en tant que Gérant Indépendant (étant entendu que cette personne peut occuper les fonctions de trustee indépendant or
dirigeant indépendant d'un autre véhicule d'investissement dédié qui est une Affiliée de l'Emetteur, d'un Cédant, d'un
Investisseur ou de Castlelake L.P.) et n'a pas été pendant une période de 5 (cinq) ans avant cette nomination (i) un employé,
un créancier, prestataire, gérant, sous-traitant, dirigeant ou administrateur d'un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur ou
une Affiliée de ces personnes, ou un conjoint, ou personne liée à (mais pas d'un degré plus éloigné que cousins germains)
une personne visée au point (i), (ii) le bénéficiaire (directement ou indirectement) de titres de capital (à l'exclusion de
participations de minimis) d'un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un détenteur d'un intérêt bénéficiaire direct ou
indirect dans un investisseur ou d'une Affiliée de chacune de ces personnes, (iii) une personne qui Contrôle (directement,
indirectement ou autrement) un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un titulaire d'un intérêt bénéficiaire direct ou
indirect dans un Investisseur ou dans une Affiliée de ces personnes ou un employé, dirigeant, administrateur ou gérant de
ces personnes ou (iv) une personne qui Contrôle (directement, indirectement ou autre) tout créancier, fournisseur ou en-
trepreneur de tout Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un intérêt bénéficiaire direct ou indirect dans un Investisseur ou
24143
L
U X E M B O U R G
dans une Affiliée de chacune de ces personnes, ou un employé, dirigeant, administrateur ou gérant de ces personnes. Les
termes "Affiliée", "Contrôle", "Emetteur", "Cédant" et "Investisseurs" ont le sens donné dans les Contrats d'Emission.
Aucune autre modification n'est apportée aux statuts.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original
du présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 novembre 2015. Relation: EAC/2015/28048. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015200666/102.
(150225938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Plazza Investments & Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1429 Luxembourg, 30, rue Tony Dutreux.
R.C.S. Luxembourg B 100.540.
En date du 14 décembre 2015, il a été a décidé de transférer la totalité des parts sociales de la Société détenue par l'associé
unique G & P Properties S.à r.l. (en liquidation), à Calista Capital SPF, une société anonyme de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 30, rue Tony Dutreux à L-1429 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Société de Luxembourg sous le numéro B 157.975.
De telle sorte que Calista Capital SPF est désormais l'associé unique de la Société et détient 124 parts sociales sur un
total de 124 de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour Plazza Investments & Properties S.à.r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015201939/17.
(150226809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Olinda Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3313 Bergem, 76, Grand Rue.
R.C.S. Luxembourg B 15.538.
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Schifflange, le 05/12/2014i>
Suite à la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des
actions nominatives et du registre des actions au porteur, le conseil d'administration s'est réuni.
La séance est présidée par son administrateur unique Monsieur Jean-Christophe PONSSON et ouverte à 14h30 pour
prendre la décision suivante:
1. Nommer comme dépositaire des actions au porteur: Fiduciaire Euro Conseil Entreprise S.A., dont le siège social se
situe à L.3313 BERGEM, 76 Grand Rue, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B90.331.
Plus aucun point ne figurant ni à l'ordre du jour, le Président lève la séance.
Schifflange, le 05 décembre 2014.
Jean-Christophe PONSSON
<i>Le présidenti>
Référence de publication: 2015201908/18.
(150227454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
24144
Advice S.à r.l.
Aircraft Solutions Lux IX S.à r.l.
Aircraft Solutions Lux XV S.à r.l.
Aircraft Solutions Lux XX S.à r.l.
Blackwood International Group S.à r.l.
Cabinet Comptable Madimba S.à r.l.
Capesius et Reding S.à r.l.
CASHMERE Spf S.A.
CLSec 1 Lux S.à r.l.
Corestate Turbo FRA HoldCo S.à r.l.
Emerging Markets Taxi Holding S.à r.l.
Garage PIANARO s.à.r.l.
Gärtnerei Sunflower, S.à r.l.
Geimer Services SARL
Gerim III s.à r.l.
G.I.S.H. SPF
Glofin A.G.
Glofin A.G.
Goodman Europe (Lux) S.à r.l.
Goodman Industrial Real Estate Luxembourg S.à r.l.
Goodman Princeton Holdings (Lux) S.à r.l.
Gubernantia S.à r.l.
Hairdress by Tess S.à r.l.
Herman International S.A.
Hohenzollern
Hotel-Restaurant Lanners Sàrl
I.C.C.Luxembourg S.à r.l.
I.F.Z. S.A.
Immobilière DE LA FONTAINE
Immo Gold S.à r.l.
Katone World S.à r.l.
Luxeral Investments S.à r.l.
Maclean SPF S.A.
Mauritania Gulf S.à. r.l.
Michel NEIZEN GmbH
Michel NEIZEN GmbH
Mythos S.à r.l.
Nénuphar S.A.
Nénuphar S.A.
Nénuphar S.A.
Nénuphar S.A.
Netto-Recycling S.A.
Nexis S.A.
Nexis S.A.
Nexis S.A.
N. Kimmel S.à.r.l.
Nouvelle Electricité BASTIAN S.à.r.l.
Olinda Finance S.A.
Plazza Investments & Properties S.à r.l.