logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 467

18 février 2016

SOMMAIRE

21A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22372

Actis Morocco Energy Holdings Limited  . . . .

22370

AGI Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22373

Agri-Center S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22370

AJR Participations II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

22373

AJR Participations II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

22373

AJR Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22373

AJR Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22373

Albatros Participations Industrielles S.A. . . . .

22373

Alexandros S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22374

Alexandros S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22374

All Consulting Company S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

22374

ALLIANCE SICAV-SIF S.A. . . . . . . . . . . . . . .

22377

Amigo Investments Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

22370

Apache International Finance  . . . . . . . . . . . . .

22412

Arkus Partners G.I.E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22395

Artic Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22416

BAUTEC Rénovations & Energie S.A.  . . . . . .

22406

Beaconinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22408

Beobank Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22390

Black Quantum Private Equity S.A.  . . . . . . . .

22409

Boga S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22372

Café Academica S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22376

Capital Project S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22371

CFC Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22371

Charger Lux HoldCo II (Offshore) S.à r.l.  . . .

22386

Charger Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l.  . . .

22391

Chauffage & Sanitaire Heinen Steve S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22371

Cleaning Management Services S.à r.l.  . . . . . .

22372

CNOOC Luxembourg Holding S.à r.l.  . . . . . .

22374

CNOOC Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

22374

Codex Events S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22374

COLUMBIA International Consulting sàrl  . .

22376

Compagnie Sud-Express S.A. . . . . . . . . . . . . . .

22375

CTC-Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22376

Dania Presents S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22375

Decapterus Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

22375

Dimensions 3 Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

22376

DJ IMMO S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22406

Findus Manco S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22376

manatee consilium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22370

Wahl & May S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22372

Wanda S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22375

Warlander Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22375

Wharf Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22371

Wood Trade Center S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22416

XEMXIJA S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22370

YM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22372

Zuang Distribution S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22371

22369

L

U X E M B O U R G

XEMXIJA S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 193.347.

Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2015.

<i>Pour: XEMXIJA S.A. SPF
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2016001758/14.
(150239727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Agri-Center S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 15, Op der Haart.

R.C.S. Luxembourg B 94.107.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2016001809/10.
(160000322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Amigo Investments Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 179.792.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001783/10.
(160000338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Actis Morocco Energy Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 174.803.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001774/10.
(150241084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

manatee consilium, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 92.879.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016001772/10.
(150241243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

22370

L

U X E M B O U R G

Wharf Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 109.459.

Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 Décembre 2015.

WHARF PROPERTIES S.à r.l.
Robert McCorduck
<i>Gérant

Référence de publication: 2016001741/14.
(150239746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Capital Project S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 147.408.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CAPITAL PROJECT S.A.

Référence de publication: 2016001915/10.
(160000307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

CFC Reinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 1A, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 73.304.

Les comptes annuels au 31 octobre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CFC REINSURANCE S.A.

Référence de publication: 2016001922/10.
(160000411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Chauffage &amp; Sanitaire Heinen Steve S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 32A, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 86.533.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016001923/10.
(160000333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Zuang Distribution S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, 5, rue du Château d'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 67.860.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016001763/10.
(150240724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

22371

L

U X E M B O U R G

Cleaning Management Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 170.688.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Cleaning Management Services Sàrl
Constantin ROMAS
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2016001887/13.
(150241026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Boga S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9250 Diekirch, 50, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 95.749.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BOGA S.A.
Signature

Référence de publication: 2016001867/11.
(150240965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Wahl &amp; May S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 429, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 67.208.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016001746/10.
(150240582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

21A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 153.385.

Le bilan approuvé au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001764/10.
(150241137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

YM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3347 Leudelange, 2, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 177.621.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016001762/10.
(150240053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

22372

L

U X E M B O U R G

AGI Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 28.173.

Les comptes annuels au 31 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016001807/9.
(160000479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

AJR Participations II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 104.450.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016001812/9.
(160000514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

AJR Participations II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 104.450.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016001813/9.
(160000527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

AJR Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 103.578.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016001814/9.
(160000397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

AJR Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 103.578.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016001815/9.
(160000413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Albatros Participations Industrielles S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 44.929.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016001817/9.
(160000721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

22373

L

U X E M B O U R G

Alexandros S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 76.098.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016001818/9.
(160000499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Alexandros S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 76.098.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016001819/9.
(160000500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

All Consulting Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 108.275.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016001820/9.
(150240981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

CNOOC Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 181.323.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016001924/9.
(160000114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

CNOOC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 161.327.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016001925/9.
(160000115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Codex Events S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5411 Canach, 36, rue d'Oetrange.

R.C.S. Luxembourg B 74.399.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016001926/9.
(150240956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

22374

L

U X E M B O U R G

Warlander Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 166.203.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

<i>Pour Warlander Sàrl
SS&amp;C GlobeOp (Luxembourg)

Référence de publication: 2016001740/12.
(150240611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Wanda S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 189.526.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30/12/2015.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2016001747/12.
(150240414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Dania Presents S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6623 Wasserbillig, 2, Am Haerewengert.

R.C.S. Luxembourg B 91.588.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2016001957/10.
(150240932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Decapterus Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 145.528.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016001946/10.
(150241083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Compagnie Sud-Express S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op der Schmett.

R.C.S. Luxembourg B 102.696.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2016001931/10.
(160000252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

22375

L

U X E M B O U R G

Findus Manco S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 188.296.

Les comptes annuels audités pour la période du 25 juin 2014 au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2015.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2016002016/13.
(150241060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Dimensions 3 Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 21, rue des Muguets.

R.C.S. Luxembourg B 106.151.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2016001964/11.
(150240964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

COLUMBIA International Consulting sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 94.306.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016001928/10.
(150241056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

CTC-Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 13, Stawelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 149.635.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2016001937/10.
(160000259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Café Academica S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 27, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 67.263.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016001906/10.
(150241249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

22376

L

U X E M B O U R G

ALLIANCE SICAV-SIF S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, Boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 203.458.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-first day of January.
Before Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing at Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

- Martin Charles SCHMITT, company director, born on 21 September 1956 in Mulhouse (France) and residing at 22,

rue du torrent, 1815 Clarens (Switzerland),

here represented by Maxime Alfredo FERRETTI, Practice Leader PE/RE, Luxembourg Fund Partners S.A., having his

professional address at 2, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy
given under private seal, dated 14 January 2016.

Hereinafter referred to as the “Party”.
The above mentioned proxy, being initialed ne varietur by the appearing party, and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has, in the capacity of which it acts, requested the notary to draw up the following articles of

association (the “Articles of Association”) of a public limited company (“société anonyme”) (the “Company”), the incor-
poration of which such party has approved.

Art. 1. Form. There is hereby formed among the subscriber(s) and all persons who may become holder of shares hereafter

issued, a company in the form of a public limited company (“société anonyme”), formed as an investment company with
variable capital (“SICAV”) and Specialized Investment Fund, governed by the present articles of association (the “Articles”
or “Articles of Association”) and by current Luxembourg laws, and notably by the Law on Commercial Companies of 10
August 1915 (the “1915 Law”),the Law on Specialized Investment Funds of 13 February 2007 (the “2007 Law”) and the
Law of 12 July 2013 related to Alternative Investment Fund Managers (the “2013 Law”).

Art. 2. Name. The Company's name is ALLIANCE SICAV-SIF S.A..

Art. 3. Purpose. The Company's exclusive object is the collective investment of its funds in assets in order to spread the

investment risks and to ensure for the investors the benefit of the results of the management of these assets according to
its investment objectives and policies in accordance with the provisions of the 2007 Law, of the 2013 Law and applicable
Luxembourg Supervisory Authority's (the “CSSF”) circulars.

The investment objectives and strategy of the Company are more fully described in the Company's Issuing Document.
The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and in

particular, without limitation, grant any assistance, loans, advances or guarantees and raise money in any manner and secure
the repayment of any money borrowed from third parties or from its shareholders.

In addition, the Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly

to all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the
2007 Law and the 2013 Law.

Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, in the Grand

Duchy of Luxembourg. If and to extent permitted by law, the board of directors of the Company (the “Board”) may decide
to transfer the registered office of the Company within the municipality by a resolution of the Board. The Board shall further
have the right to set up branches, offices, administrative centers and agencies wherever it shall deem fit, either within or
outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

Where the Board determines that extraordinary political, economic or social developments or events have occurred or

are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. Duration. The Company is constituted for an unlimited duration.
The Company may be terminated at any time by a decision of the general meeting of shareholders in the manner required

for the amendment of these Articles of Association.

The life of the Company does not come to an end upon the death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any of its shareholders or members of the Board of Directors.

22377

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Share Capital. The initial share capital of the Company is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided

into thirty-one (31) fully paid up Shares, with no par value. The Company's share capital shall at any time be equal to its
net asset value, as determined in accordance with Article twelve (12) hereafter.

The minimum subscribed capital of the Company, which must be achieved within 12 (twelve) months as from the date

on which the Company has been authorized as a Specialized Investment Fund by the CSSF, shall be one million two hundred
fifty thousand Euros (EUR 1,250,000.-) as required by the 2007 Law.

Art. 7. The sub-funds and classes of shares. The Company is a multi-compartment structure consisting of one or several

sub-funds, each one representing a specific portfolio of assets and liabilities. There is no cross liability between sub-funds.
Each sub-fund is invested in accordance with the investment objective and policy applicable to it. The investment objective
and policy as well as other specific features of each sub-fund, including their related duration, will be set forth in the
Company's Issuing Document. The Board of Directors may decide to create at any time additional sub-funds or to close
an existing sub-fund. in accordance with Article thirty (30) hereafter

The Company including all of its sub-funds is regarded as a single legal entity. However, each sub-fund shall be liable

for its own debts and obligations. In addition, for the purpose of the relations between the shareholders, each sub-fund will
be deemed to be a separate entity having its own contributions, capital gains, losses, charges and expenses.

The Board of Directors may decide to issue, within each sub-fund, separate classes of shares, which may carry different

rights and obligations, inter alia with regard to their distribution policy and right to revenues, their fee structure, their
minimum initial subscription and holding amounts or their target investors. The specific features of the classes within each
sub-fund will be set forth in the Company's Issuing Document. The Board of Directors may create at any time additional
classes or to close an existing class.

Art. 8. Form of shares. The Board of Directors of the Company shall determine whether the Company shall issue shares

in registered form and/or in dematerialized form.

All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by

the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of
each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered
shares held by him and the amounts paid.

The  inscription  of  the  shareholder's  name  in  the  register  of  shareholders  evidences  his  right  of  ownership  on  such

registered shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the shareholder
or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.

The share certificates shall be signed by two Directors of the Company. Such signatures shall be either manual, or

printed, or in facsimile. However, one of such signatures may be made by a person duly authorised thereto by the Board
of Directors; in the latter case, it shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the
Board of Directors may determine.

Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Company with an address to which all notices and

announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered

into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company,
or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another address shall be provided
to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as entered into the register of
shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be
set by the Company from time to time.

If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been mislaid, mutilated or

destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including
but not restricted to a bond issued by an insurance company, as the Company may determine. At the issuance of the new
share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in replacement of which
the new one has been issued shall become void.

Mutilated share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.
The Company may, at its election, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new share certificate and all

reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection with
the annulment of the original share certificate.

Dematerialized shares may be held through collective depositories. In such cases, shareholders shall receive a confir-

mation in relation to their shares from the depository of their choice (for example, their bank or broker), or shares may be
held by shareholders directly in a registered account kept for the Company and its shareholders by the Company's central
administration. These shareholders will be registered by the central administration. Shares held by a depository may be
transferred to an account of the shareholder with the central administration or to an account with other depositories approved
by the Company or with an institution participating in the securities and fund clearing systems. Conversely, shares held in
a shareholder's account kept by the central administration may at any time be transferred to an account with a depository.

The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership

of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such

22378

L

U X E M B O U R G

share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise of all rights attached
to such shares.

The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be

entitled to participate in the net assets attributable to the relevant class of shares on a pro rata basis. In the case of bearer
shares, only certificates evidencing full shares will be issued.

Fractions of shares may be issued, up to 6 (six) decimal places set forth in the Company's Issuing Document.

Art. 9. Shareholders. The holding of shares is exclusively restricted to «Well-Informed Investors» as defined in the 2007

Law.

The Board of Directors shall have the power to impose such restrictions or prevent the ownership of shares of the

Company or compulsory redeem part or all shares of the Company as it may think necessary for the purpose notably of
ensuring that no shares in the Company are acquired or held by (a) any person in breach of these Articles of Association,
the Issuing Document of the Company, the law or requirement of any country or governmental authority, or (b) any person
in circumstances which in the opinion of the Board of Directors might result in the Company incurring any liability to
taxation or suffering any other disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered.

Art. 10. Issue of shares. Whenever shares of the Company shall be offered by the Company for subscription, potentially

through a commitment process, the price per share at which such shares shall be issued shall be the net asset value thereof
as determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof or any other price as set forth in the Company's Issuing
Document if the investment strategy and liquidity of any Company's sub-fund so require. The Board of Directors may also
decide that an issue commission has to be paid as more described in the Issuing Document. The allotment of shares is
conditional upon payment and if timely payment has not been received within the settlement period, the subscription may
lapse and be cancelled at the cost of the investor or the investor's financial intermediary. If payment is not received in full,
the relevant allotment of shares may be reduced accordingly. The Board of Directors may in its discretion determine the
minimum amount of any subscription in any class of share of any sub-fund.

Subscriptions received before a certain hour (“cut-off time”) on a specific date (which does not need to be the valuation

date) as determined by the Board of Directors from time to time shall be processed at the net asset value or price determined
for the applicable valuation date. If subscriptions are received after that cut-off time as determined by the Board of Directors
from time to time, they shall be processed at the net asset value or price determined for the following valuation date. The
investor will bear any taxes or other expenses attaching to the application.

The Board of Directors may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of assets by any shareholder

who agrees to comply with any conditions set forth by the Board of Directors from time to time including, but not limited
to, the obligation to deliver a valuation report from the auditor of the Company which shall be available for inspection, and
provided that such assets comply with the investment restrictions and policies of the relevant sub-fund, as set forth in the
Company's Issuing Document. Any costs incurred in connection with a contribution in kind of assets, including the auditor's
costs for preparing any valuation report required, shall be borne by the shareholder making such contribution.

The Board of Directors reserves the right to accept or refuse any application of subscription for shares in whole or in

part.

Art. 11. Transfer and conversion of shares. Any transfer of shares to the existing shareholders or to any third party shall

require the prior written approval of the Board of Directors and the Board of Directors may in its discretion and without
indicating any reason decline to approve such transfer.

The Board shall not accept any transfer of shares to any transferee who may not be considered as an eligible investor

within the meaning of the 2007 Law.

The shareholder wishing to transfer its shares in the Company will be responsible for all costs associated with any

attempted or realized transfer.

Unless otherwise provided for within the Company's Issuing Document, (i) shares of a sub-fund may not be converted

for shares in another sub-fund and (ii) shares of a sub-fund may be converted for shares in another class of shares of the
same sub-fund, subject to the prior written approval of the Board of Directors.

Art. 12. Net asset value. The net asset value of the Company shall be determined on the basis of the fair value principle

as often as the Board of Directors may think useful, but in no event less than once a year.

The net asset value will be expressed in Euro and shall be determined by the administrative agent of the Company, under

the responsibility of the Board of Directors and, if applicable, the alternative investment fund manager (the “AIFM”), acting
in its own name and on behalf of the Company, as more described in the Issuing Document of the Company.

The net asset value per Share of each class within each sub-fund shall be equal to the value of the net assets of the sub-

fund attributable to such class of shares less the liabilities (including the fees, costs, charges and expenses set out in this
prospectus and any other provisions considered by the Board of Directors to be necessary or prudent) of the sub-fund
attributable to such class of shares by the total number of shares outstanding in the relevant class at the time of the deter-
mination of the net asset value on the relevant valuation day.

The value of the assets of each sub-fund shall be determined as follows:

22379

L

U X E M B O U R G

1. The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash

dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof, unless
in any case the same is reasonably considered unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall
be determined after making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof;

2. Equity and debt securities are valued on the basis of dealer-supplied quotations or by pricing services. The prices

derived by a pricing agent reflect broker/dealer-supplied valuations and electronic data processing techniques;

3. Securities for which no price quotation is available or for which the price referred to in the previous indent is not

representative of the fair market value, will be valued prudently, and in good faith on the basis of their reasonably foreseeable
sales prices pursuant to the policies established in good faith;

4. The value of money market instruments not listed or dealt in on any stock exchange or other Regulated Market (as

defined in the Luxembourg Law of 16 July 2007 concerning markets in financial instruments) and with remaining maturity
of less than 12 months and of more than 90 days is deemed to be the nominal value thereof, increased by any interest
accrued thereon. Money market instruments with a remaining maturity of 90 days or less will be valued by the amortised
cost method;

5. Real estate and private equity investments registered in the name of the Company or on account of such sub-fund or

a subsidiary of the Company will be valued at least annually by one (1) or more independent valuer(s).

6. The securities of real estate companies which are listed on a stock exchange or dealt in on another Regulated Market

will be valued on the basis of the last available publicised stock exchange or market value. If the same security is listed on
several stock exchanges, the last available price on the stock exchange that represents the major market for this security
will apply.

7. The securities of real estate and private equity companies which are not listed on a stock exchange nor dealt in on

another Regulated Market will be valued on the basis of the probable net realisation value (excluding any deferred taxation)
estimated with prudence and in good faith, as far as is reasonably practicable, the value of real estate assets as determined
in accordance with paragraph 5. above.

8. The liquidating value of futures, forward and options contracts not traded on a stock exchange or other Regulated

Market shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established in good faith, on a basis
consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward and options contracts
traded on stock exchanges or other Regulated Markets, shall be based upon the last available settlement prices of these
contracts on stock exchanges or other Regulated Markets on which the particular futures, forward or options contracts are
traded by the Company; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the day with
respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be
such value as the Board of Directors may deem fair and reasonable.

9. Values expressed in a currency other than the reference currency of a sub-fund shall be converted on the basis of the

rate of exchange prevailing on the relevant valuation day or such other exchange rate as may be determined to provide a
fair market value.

In the event that extraordinary circumstances render valuations as aforesaid impracticable or inadequate, the Board of

Directors or the AIFM are authorised, prudently and in good faith, to follow other rules in order to achieve a fair valuation
of the assets of the Company.

If since the time of determination of the Net Asset Value per Share of any Class in a particular sub-fund there has been

a material change in the quotations in the markets on which a substantial portion of the investments of such sub-fund are
dealt in or quoted, the Board of Directors may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the Company,
cancel the first valuation of the net asset value per Share and carry out a second valuation. All the subscription, redemption
and exchange orders to be dealt with on such day will be dealt with at the second net asset value per Share.

Each sub-fund shall be valued so that all agreements to purchase or sell assets are reflected as of the date of execution,

and all dividends receivable and distributions receivable in respect of such securities are accrued as of the relevant ex-
dividend dates in respect of such securities.

The Board of Directors or the AIFM may permit some other method of valuation to be used, if it considers that such

valuation better reflects the fair value of any asset of the Company on account of such sub-fund and if the application of
the aforementioned valuation criteria appears impossible or inappropriate due to extraordinary circumstances or events.

The Board of Directors may decide to invest and manage all or any part of the pool of assets of its sub-funds (hereafter

referred to as "Participating Funds") on a pooled basis where it is appropriate with regard to their respective investment
sectors to do so. As more described in and in compliance with the provisions of the Issuing Document, any such asset pool
("Asset Pool") shall first be formed by transferring to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets
from each of the Participating Funds. Thereafter the Board of Directors may from time to time make further transfers to
the Asset Pool. It may also transfer assets from the Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the participation
of the Participating Fund concerned. Assets other than cash may be contributed to an Asset Pool only where they are
appropriate to the investment sector of the Asset Pool concerned.

22380

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Suspension. The Board of Directors may temporarily suspend the calculation of the net asset value:
a) In the event of the closure, for periods other than normal holidays, of a stock exchange or other regulated market that

operates regularly, is recognised and open to the public and provides the listings for a significant portion of the assets of
one or more sub-funds, or in the event that transactions on such markets are suspended, subject to restrictions or impossible
to execute in the required quantities;

b) Where there is a breakdown in the methods of communication normally used to determine the value of investments

of the Company or the current value on any investment exchange or when, for any reason whatsoever, the value of invest-
ments cannot be promptly and accurately ascertained;

c) Where exchange or capital transfer restrictions prevent the execution of transactions on behalf of one or more sub-

funds or where purchases and sales made on its behalf cannot be executed at normal exchange rates;

d) Where factors relating inter alia to the political, economic, military or monetary situation, and which are beyond the

control, responsibility and operational ability of the Company, prevent it from disposing of its assets and determining their
net asset value in a normal or reasonable way;

e) Following any decision to dissolve one, several or all sub-funds of the Company;
f) Where the market of a currency in which a significant portion of the assets of one or more sub-funds is expressed is

closed for periods other than normal holidays, or where trading on such a market is either suspended or subject to restrictions;

g) To establish exchange parities in the context of a merger, contribution of assets, split or any restructuring operation,

within or by one or more sub-funds. Furthermore, in order to prevent market timing opportunities arising when a net asset
value is calculated on the basis of prices which are no longer up-to-date or reliable, the Board of Directors is authorised to
temporarily suspend the issue, redemption and conversion of shares of one or several sub-funds.

In exceptional circumstances which may have an adverse effect on the interests of shareholders, in the event of large

volumes of subscription, redemption or conversion requests or in the event of a lack of liquidity on the markets, the Board
of Directors reserves the right to set the net asset value of the shares of the Company only after carrying out the required
purchases and sales of assets on behalf of the Company. In this case, any subscriptions, redemptions and conversions
simultaneously pending will be executed on the basis of a single net asset value. The suspension of the calculation of the
net asset value and/or the issue, redemption or conversion of shares of one or more sub-funds will be announced by any
appropriate means, unless the Board of Directors feels that such an announcement is not useful in view of the short duration
of the suspension. Such a suspension decision will be notified to any shareholders requesting the subscription, redemption
or conversion of shares.

Art. 14. Redemption of shares. The Company is an open-ended investment company. However, the Board of Directors

may decide, depending on the investment strategy and objectives of each sub-fund, to launch closed-ended sub-funds.

Redemptions will be made in accordance with the principles set forth in the Issuing Document of the Company for each

sub-fund.

Redemption of shares shall be made at a price per share, which is determined by the Board of Directors in accordance

with the provisions of the Issuing Document of the Company. The Board of Directors may also decide that redemption
commission has to be paid as more described in the Issuing Document.

The payment of the redemption price shall be made for cash or consideration in kind at the discretion of the Board of

Directors. The allotment of Company's assets in respect of redemption for consideration in kind shall be fair and not
detrimental to the interests of the other shareholders of the Company. In compliance with the provisions of the 2007 and
1915 Laws, any redemption for consideration in kind shall be subject to the confirmation by an auditor's special report of
the valuation of the Company of the Company's assets to be allocated, the costs of which shall be borne by the Company.

The Company may decide to compulsorily redeem in accordance with the provisions of Article 9 of these Articles and

the provisions of the Issuing Document.

To face potential liquidity risks, the Board of Director or the AIFM, subject to the prior approval of the CSSF, may,

under exceptional circumstances and in the interest of the relevant sub-fund or of the shareholders of the relevant sub-fund,
apply gates and/or side pockets. All redeemed shares or fractions thereof shall be automatically cancelled.

Art. 15. Board of Directors. The Company will be managed by the Board of Directors of the Company, composed of

not less than three (3) members. The members of the Board of Directors need not be shareholders of the Company.

The Directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period not exceeding six (6)

years and shall hold office until their successor are elected. A Director may be removed with or without cause and replaced
at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors

may meet and elect, by majority of vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of the shareholders.

Art. 16. Chairman. The Board of Directors shall elect from among its members a Chairman and may choose from among

its members one or more Vice-Chairmen. It may also choose a secretary, who needs not to be a Director, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors
shall meet upon call by the Chairman, or two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.

22381

L

U X E M B O U R G

The Chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the Vice-Chairman or

another Director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore, or in their absence or inability
to act, the shareholders may appoint another Director or an officer of the Company as chairman pro tempore by vote of the
majority of shares present or represented at any such meeting.

The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors, or in his absence or inability to act, the Vice-

Chairman or another Director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore.

The Board of Directors shall from time to time appoint any officer or agent of the Company considered necessary for

the operation and management of the Company, who need not be Directors or shareholders of the Company. The officers
appointed unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the power and duties granted to them by the Board of
Directors.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors in advance of the hour set for

such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice
of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by email, telefax or any other similar or electronic
communication means from each Director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places set
out in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy, which

appointment shall be in writing or by email, telefax or any other similar or electronic communication means.

Directors may also assist at board meetings and board meetings may be held by video conference or telephone conference

or any other means of telecommunication permitting the identification of such Directors, provided that the vote is confirmed
in writing or by email, telefax or any other similar or electronic communication means. The Directors may only act at duly
convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Company by their individual acts, except as
specifically permitted by resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors can deliberate or act with due authority if at least a majority of the Directors is present or

represented at such meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at
such meeting, the Chairman having a casting vote.

Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may
be evidenced by facsimile or any other similar or electronic communication means.

Art. 17. Minutes. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman or, in his

absence, by the chairman pro-tempore who presided at such meeting or by two (2) Directors.

Copies or extracts of such minutes which are to be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the

Chairman or by the chairman pro-tempore of that meeting, or by two (2) Directors or the secretary or an assistant secretary.

Art. 18. Power. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration, dispo-

sition and execution in the Company's interest. All powers not expressly restricted by law or by the present Articles of
Association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 19. Delegation of Power. The Board of the Company may delegate its powers to conduct the daily management

and affairs of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers to carry out
acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need
not be Directors, who shall have the powers determined by the Board of Directors and who may, if the Board of Directors
so authorizes, sub-delegate their powers.

The Board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
The Board may further decide to create either at the level of the Company or for a specific sub-fund any committee the

members of which need not be Directors. The Board shall organize such committee functioning and determine the powers
of their members as further described in the Issuing Document of the Company.

The Company may also designate an AIFM in compliance with the provisions of the 2013 Law.

Art. 20. Conflicts of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers or agent or daily manager or
employee of the Company is interested in, or is a director, associate, officer, agent, daily manager or employee of such
other company or firm. Any Director, officer, agent, daily manager or employee of the Company who serves as a director,
officer, agent, daily manager or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any Director, officer, agent, daily manager or employee of the Company may have, in any transaction

of the Company, an interest opposite to the interests of the Company, such Director, officer, agent, daily manager or
employee shall make known to the Board of Directors such opposite interest and shall not consider or vote on any such
transaction, and such transaction and such Director's, officer's, agent's, daily manager's or employee's interest therein shall
be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.

22382

L

U X E M B O U R G

The term “opposite interest”, as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any

matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be determined by the
Board of Directors in its discretion.

Art. 21. Signature. The Company shall be bound by the joint signature of any two (2) Directors or by the individual

signature(s) of any duly authorized Director or officer, or agent or daily manager of the Company or by the individual
signature of the Chairman or any other person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

Art. 22. Indemnification. The Company may indemnify any member of the Board of Directors or officer, and his heirs,

executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding
to which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at his
request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to
be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to
be liable for gross negligence or willful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only
in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.

Art. 23. General meetings of shareholders. The general meeting of shareholders of the Company shall represent the

entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders of the Company. It
shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of the

agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the Board of Directors. It may also be called upon the

written request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.

Upon request of shareholders representing at least one tenth of the share capital, one or more new items shall be added

to the agenda of any general meeting of shareholders. Such demand shall be addressed to the registered office of the
Company by registered mail at least five (5) days before such meeting.

The annual meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company (or

elsewhere as may be specified in the convening notice), on the third Friday of April each year at the time indicated in the
convening notice. The first annual meeting shall be held in 2017.

If such day is a legal or bank holiday in Luxembourg, the annual meeting shall be held on the next banking day.
Other meetings of shareholders, including meetings of shareholders of one specific sub-fund or class of shares, may be

held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time-limits provided by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of

shareholders of the Company unless otherwise provided herein.

Any shareholder may participate in a general meeting of shareholders by video conference, or by conference call or

similar means of communication equipment which enables his/her identification and participating in a meeting by such
means shall constitute presence in person at such meeting. The means of communication used must allow all the persons
taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an effective participation of all such
persons in the meeting. The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to
attend any meeting of shareholders.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which

shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each whole share of the Company is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles of

Association. A shareholder may act at any meeting of shareholders by giving a proxy to another person in writing or by
facsimile transmission or any other similar or electronic communication means, who need not be a shareholder and who
may be a Director of the Company.

Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the

votes validly cast, unless the item to be resolved upon relates to an amendment of the Articles, in which case the resolution
will be passed with a majority of the two thirds of the votes validly cast.

Art. 24. Financial Year. The Company's financial year begins on 1 

st

 January and closes on 31 

st

 December of the same

year and for the first time in 2016.

Art. 25. Accounts. Each year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the Company. The annual

accounts shall be approved by the annual general meeting of shareholders upon proposal of the Board of Directors. The
accounts shall be expressed in Euro.

Art. 26. Supervision. The operations of the Company and its financial situation shall be supervised by one independent

auditor qualifying as a «réviseur d'entreprises agréé» who shall be appointed in accordance with the provisions of the 2007
Law.  The  independent  auditor  shall  be  remunerated  by  the  Company  and  shall  remain  in  office  until  its  successor  is
appointed. The independent auditor shall fulfill all duties prescribed by the 2007 Law.

22383

L

U X E M B O U R G

Art. 27. Distribution. Subject to permitted reinvestments, and the requirements of Luxembourg law, distributions may

be payable by the Company on its shares upon decision by the Board of Directors in accordance with the Company's Issuing
Document.

No distribution may be made if after the declaration of such distribution the net asset value of the Company would fall

below EUR 1,250,000.- (one million two hundred fifty thousand Euros). Dividends not claimed within five years of their
due date will lapse and revert to the relevant class of shares.

Art. 28. Depositary. The Company shall enter into a depositary agreement with a financial institution, which shall satisfy

the requirements of the 2007 Law and the 2013 Law. The depositary shall assume towards the Company and the shareholders
the responsibilities set out in the 2007 Law (notably in article 16 of the 2007 Law) and the 2013 Law, the depositary
agreement and any other law applicable.

In the event of termination of the depositary agreement or the resignation of the depositary, the Board of Directors shall

use its best endeavors to find a financial institution to act as depositary and upon doing so the Board of Directors shall
appoint such financial institution to be depositary in place of the former depositary.

Art. 29. Liquidation. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several

liquidators (whether natural persons or legal entities approved by the CSSF) named pursuant to a general meeting effecting
such dissolution and at which meeting the liquidators' powers and compensation shall be determined. The operations of
liquidation will be carried out pursuant to the 1915 Law.

The net proceeds of liquidation in respect of each sub-fund or, as the case may be, of each class within each sub-fund,

shall be distributed by the liquidators to the holders of shares of the relevant class in proportion to their holding of such
shares in such sub-fund or class, and whether such proceeds shall be distributed in cash or kind.

If the Company's share capital (i.e. the aggregate of all sub-funds) falls below two-thirds of the minimum capital (EUR

1,250,000.-), the Board of Directors must submit a proposal for the Company's termination to a general meeting for deli-
beration. No quorum requirements will be applied; winding-up may be pronounced by a simple majority of the validly cast
votes.

If the Company's share capital falls below one quarter of the minimum capital increased by the share premium (EUR

1,250,000.-), the Board of Directors must submit a proposal for the Company's termination to the general meeting for
deliberation. No quorum requirements will be applied; winding-up may be pronounced by the shareholders owning one
quarter of the validly cast votes.

The aforesaid meetings shall be convened within forty days of the date at which it was ascertained that the net assets

fell below two-thirds or one quarter of the minimum capital, respectively. Moreover, the Company may be terminated by
resolution of the general meeting in accordance with the pertinent provisions of these Articles of Association.

The resolutions of the general meeting of shareholders or of a court of law pronouncing the termination and winding-

up of the Company are to be published in compliance with applicable laws. The choice of which newspapers are to carry
the publication is made at the discretion of the liquidator(s).

The amounts that have not been claimed by the shareholders or their beneficiaries at the close of liquidation of the

Company shall be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg.

Art. 30. Termination, liquidation and merger of sub-funds or classes of shares. The Board of Directors may decide to

close one or more sub-funds (having or not a limited duration) in the best interests of the shareholders, if there has been a
substantial modification in the political, economic, regulatory or monetary situation pertinent to sub-fund, which, in the
opinion of the Board of Directors renders this decision necessary, or where such action is required in order to protect the
interests of shareholders, or if for any reason whatsoever, the value of the net assets of a sub-fund falls below an amount
determined in the Company's Issuing Document and the Board of Directors determines that the interests of the shareholders
of that same sub-fund demand such action to be taken.

The Board of Directors may decide to close one or more classes in the best interests of the shareholders, The Company

shall serve a notice in writing to the shareholders of the relevant class or sub-fund, which will indicate the reasons and the
procedure for the redemption operations.

The Company shall base these redemptions on the net asset value taking into account liquidation or closing expenses.
The amounts that have not been claimed by the shareholders or their beneficiaries at the close of liquidation of a class

or sub-fund shall be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg.

All redeemed Shares may be cancelled.
A termination contemplated above may be combined with a contribution to one or several sub-fund(s) or class(es) within

the Company or to one or several other sub-fund(s) or class(es) of another undertaking for collective investment (under the
corporate or the contractual type form) in the best interests of the shareholders.

A  sub-fund  may  exclusively  be  contributed  to  a  foreign  undertaking  for  collective  investment  with  the  unanimous

approval of the shareholders of the relevant sub-fund or under the condition that only the assets of the consenting share-
holders shall be so contributed.

22384

L

U X E M B O U R G

Art. 31. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the 1915 Law, the 2007 Law and the 2013 Law for

which no specific provision is made in these Articles of Association.

Art. 32. Definitions and Interpretation. References to articles are to the Articles of these Articles of Association. Words

importing gender include each gender. References to persons include bodies corporate, firms and unincorporated associa-
tions. The singular includes the plural and vice versa. Headings of articles are included for convenience only and do not
affect their interpretation. References to all or any part of any statute or statutory instrument include any statutory amend-
ment, modification or re-enactment in force from time to time and references to any statute include any statutory instrument
or regulations made under it. Any reference to the Company, the Board of Directors, agents, etc, includes a reference to its
or their duly authorized agents or delegates.

<i>Transitional measures

Exceptionally, the first financial year shall begin on the date hereof and end on 31 

st

 December 2016.

The first annual general meeting shall be held in 2017.

<i>Subscription and Payment

The initial capital of the Company amounts to thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) and has been subscribed as

follows:

Martin Charles SCHMITT, prenamed: thirty-one (31) shares.
The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the

sum of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in the 1915 Law, and

confirms that these conditions have been observed.

<i>Estimate of formation expenses

The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be paid

by the Company as a result of its incorporation amount approximately to one thousand five hundred Euro.

<i>General meeting of shareholders

The  appearing  party,  representing  the  entire  subscribed  share  capital  and  considering  himself  as  having  been  duly

convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company.

Having first verified that it was regularly constituted, the appearing party has passed the following resolutions with the

approval of the Board of Directors:

<i>First resolution:

The following persons are elected as member of the Board of Directors for a period ending at the annual general meeting

of shareholders to be held in 2017:

- Didier CORDELLE, born on 12 September 1964 in Hirson (France), having his professional address at 22, Rue de la

Chapelle, F-59130 Lambersart;

- Martin SCHMITT, born on 21 September 1956 in Mulhouse (France), having his professional address at 22, Rue du

Torrent, CH-1815 Clarens;

-  Stefan  GUSTAFSSON,  born  on  27  September  1978  in  Nykyrga  (Sweden),  having  his  professional  address  at  2,

Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

- Luigi TEMPORINI, born on 30 May 1946 in Pozzuolo del Friulu (Italy), having his professional address at 12, rue de

l'Espen, F-68640 Riespach;

- Peter HUANG, born on 17 January 1985 in Luxembourg, having his professional address at 2, Boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg.

<i>Second resolution

The address of the registered office of the Company is set at 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

Has been elected as approved statutory auditor (réviseur d'entreprise agréé) until the annual general meeting of share-

holders to be held in 2017:

PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, having its registered office at L-1014 Luxembourg, 2 rue Gerhard Mer-

cator, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 65.477.

22385

L

U X E M B O U R G

<i>Power

The above appearing party(ies) hereby give(s) power to any agent and / or employee of the office of the signing notary,

acting individually to proceed as the case may be with the registration, listing, modification, deletion, publication or any
other useful or necessary operations following this deed and possibly to draw, correct and sign any amendment or modi-
fication as requested or any error, lapse or typo in this deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English only.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by surname, name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Signé: M. A. Ferretti, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 janvier 2016. Relation: EAC/2016/2121. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé): Amédé SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 25 janvier 2016.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2016059370/523.
(160020495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

Charger Lux HoldCo II (Offshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 158.706,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.298.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-sixth day of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public having his professional address at Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg.

Is held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of “Charger LuxHoldCo II (Offshore) S.à r.l.”, a Luxembourg

société à responsabilité limitée, having its registered office at 5 C, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 138.298 (the “Com-
pany”), incorporated as a société à responsabilité limitée by a deed enacted by Maître Joseph Elvinger dated 14 April 2008
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1333 dated 30 May 2008 and lastly amended
by a notarial deed enacted by the undersigned notary, dated 31 December 2013, published in Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations under number 1151, dated 7 May 2014.

There appeared:

The sole shareholder of the Company, Charger Lux HoldCo (Offshore) S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité

limitée, having its registered office at 5 C, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 138.248 (the “Shareholder”), holder of
68,500 (sixty-eight thousand five hundred) shares of the Company, duly represented by Mr. Régis Galiotto, notary clerk,
with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal on 18 September 2014.

The above-mentioned proxy, being initialled “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the notary to record as follows:
I. - That the 68,500 (sixty-eight thousand five hundred) shares of the Company, representing the whole share capital of

the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole
Shareholder states as having been duly informed beforehand.

II. - The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 90,206 (ninety thousand two hundred six Euro)

by the issue of 90,206 (ninety thousand two hundred six) new shares of the Company, with a nominal value of EUR 1 (one

22386

L

U X E M B O U R G

Euro) each, so as to raise it from its amount of EUR 68,500 (sixty-eight thousand five hundred Euro) to EUR 158,706 (one
hundred fifty-eight thousand seven hundred six Euro);

3. Subscription and payment by Charger Lux HoldCo (Offshore) S.à r.l. of 90,206 (ninety thousand two hundred six)

new shares, by way of a contribution in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the new share

capital pursuant to the resolutions above; and

6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put
at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each
document.

<i>Second resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 90,206 (ninety thousand two hundred

six Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 68,500 (sixty-eight thousand five hundred Euro) to EUR 158,706
(one hundred fifty-eight thousand seven hundred six Euro) by the issuance of 90,206 (ninety thousand two hundred six)
new shares of the Company with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the “New Shares”), the whole to be fully paid
up through a contribution in kind by the Sole Shareholder, consisting of claims held by the Sole Shareholder towards the
Company amounting to EUR 90,206 (ninety thousand two hundred six Euro) (the “Contribution”).

<i>Third resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares by means of the

Contribution.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the Contributor, here represented by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private

seal, and declares to subscribe to the New Shares in the Company and to pay them up entirely through the Contribution.

<i>Description of the Contribution

The Contribution made by the Sole Shareholder, in exchange for the issuance of the New Shares is composed of claims

held by the Sole Shareholder towards the Company and having an aggregate amount of EUR 90,206 (ninety thousand two
hundred six Euro).

<i>Valuation

The total net value of the Contribution amounts to EUR 90,206 (ninety thousand two hundred six Euro).
Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated

as of 18 September 2014, which shall remain annexed to this deed and be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the contribution' existence

A proof of each of the Contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, the

shareholding of the Company is now composed of:

- Charger Lux HoldCo (Offshore) S.à r.l.: holder of the 158,706 (one hundred fifty-eight thousand seven hundred six)

shares.

The notary acts that the 158,706 (one hundred fifty-eight thousand seven hundred six) shares representing the whole

share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution described above having been fully

carried out, it is resolved to amend article 6 of the Company's articles of association so as to read as follows:

“ Art. 6. The Company's share capital is set at EUR 158,706 (one hundred fifty-eight thousand seven hundred six Euro),

represented by 158,706 (one hundred fifty-eight thousand seven hundred six) shares with a par value of one Euro (EUR 1)
each.”

22387

L

U X E M B O U R G

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this deed, have been estimated at about two thousand Euros (2,000.- Euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn-up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour de septembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de «Charger Lux HoldCo II (Offshore) S.à r.l.», une société

à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5 C, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 138.298 (la «Société»), constituée suivant acte notarié par Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 14 Avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1333 le 30 mai 2008 et dernièrement modifié suivant acte notarié en date du 31 décembre 2013 par le notaire
soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1151 le 7 mai 2014.

A comparu:

L'associé unique de la Société, Charger Lux HoldCo (Offshore) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 5C, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.248 (l'«Associé
Unique»), détenteur de 68.500 (soixante-huit mille cinq cents) parts sociales de la Société, dûment représenté par Monsieur
Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé le 18 septembre 2014.

La procuration susmentionnée, après avoir été signée “ne varietur” par la partie comparante et par le notaire instrumen-

taire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique représenté comme indiqué ci-dessus, a requis au notaire d'enregistrer comme suit:
I.- Que les 68.500 (soixante-huit mille cinq cents) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale d'1 EUR (un Euro)

chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut
valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été dûment et préalablement informé.

II.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 90.206 EUR (quatre-vingt-dix mille deux cent six Euros)

par l'émission de 90.206 (quatre-vingt-dix mille deux cent six) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale d'1 EUR
(un Euro) chacune, afin de porter son montant actuel de 68.500 EUR (soixante-huit mille cinq cents Euros) à 158.706 EUR
(cent cinquante-huit mille sept cent six Euros);

3. Souscription et paiement par Charger Lux HoldCo (Offshore) S.à r.l. de 90.206 EUR (quatre-vingt-dix mille deux

cent six Euros) par l'émission de 90.206 (quatre-vingt-dix mille deux cent six) parts sociales, au moyen d'un apport en
nature;

4. Nouvelle composition du capital social de la Société;
5. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital social suivant

l'augmentation de capital suivant les résolutions ci-dessus; et

6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée;

l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué
et accepte en conséquence de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la

22388

L

U X E M B O U R G

documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps
suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 90.206 EUR (quatre-vingt-dix mille deux cent

six Euros) afin de porter son montant actuel de 68.500 EUR (soixante-huit mille cinq cents Euros) à 158.706 EUR (cent
cinquante-huit mille sept cent six Euros) par l'émission de 90.206 (quatre-vingt-dix mille deux cent six) parts sociales d'une
valeur nominale d'1 EUR (un Euro) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), l'intégralité devant être libérée par l'Associé
Unique par un apport en nature consistant en des créances détenues par l'Associé Unique à l'égard de la Société s'élevant
à un montant de 90.206 EUR (quatre-vingt-dix mille deux cent six Euros) (l'«Apport»).

<i>Troisième résolution

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales au moyen de

l'Apport.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Monsieur Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé, et déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales dans la Société et les libère entièrement au moyen
de l'Apport.

<i>Description de l'apport

L'Apport réalisé par l'Associé Unique, en contrepartie de l'émission des Nouvelles Parts Sociales, consiste en des créan-

ces détenues par l'Associé Unique à l'égard de la Société et s'élevant à un montant total de 90.206 EUR (quatre-vingt-dix
mille deux cent six Euros).

<i>Evaluation

La valeur nette totale de l'Apport s'élève à un total de 90.206 EUR (quatre-vingt-dix mille deux cent six Euros).
Une telle évaluation a reçu l'approbation de l'ensemble des gérants de la Société, aux termes d'une déclaration de valeur

de l'apport en date du 18 septembre 2014, qui demeure annexée au présent acte afin d'être soumise avec ce dernier aux
formalités d'enregistrement.

<i>Preuve de l'existence de l'Apport

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire instrumentaire.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport décrit ci-dessus ayant été intégralement réalisé,

le capital social de la Société est maintenant détenu par:

- Charger Lux HoldCo (Offshore) S. à r.l.: détentrice de 158.706 (cent cinquante-huit mille sept cent six) parts sociales

de la Société.

Le notaire établit que les 158.706 (cent cinquante-huit mille sept cent six) parts sociales représentant l'intégralité du

capital social de la Société sont représentées, de telle sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur la résolution
suivantes.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport décrit ci-dessus ayant été totalement réalisé, il

est décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à 158.706 EUR (cent cinquante-huit mille sept cent six Euros), représentées

par 158.706 (cent cinquante-huit mille sept cent six) parts sociales, d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune.»

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée.

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec l'augmentation de son capital social, ont été estimés à deux mille Euros (2.000.-Euro).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne comparante, le présent acte

est établi en anglais suivi d'une traduction en français. A la requête de la même personne comparante, en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, le présent acte a été rédigé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

22389

L

U X E M B O U R G

Après avoir lu le présent acte au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec nous, notaire, le présent

acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 octobre 2014. Relation: LAC/2014/46509. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 13 janvier 2016.

Référence de publication: 2016051091/197.
(160010141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.

Beobank Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 192.081.

L’an deux mille seize, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable «BEOBANK

FUNDS», ayant son siège social à L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 192.081, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en
date du 14 novembre 2014, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 3626 du 29 novembre 2014.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Valérie Letellier, employée, résidant professionnellement à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Vinciane Alexandre, employée, résidant professionnellement à Lu-

xembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Aline Biej, employée, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour publiés au Mémorial C, au Lu-

xemburger Wort et au Tageblatt le 11 décembre 2015 et le 29 décembre 2015 ainsi que dans De Tijd et l’Echo le 11
décembre 2015.

Les convocations ont été envoyées aux actionnaires par courrier simple en date du 11 décembre 2015.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence et
le cas échéant les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

III.- Qu’il appert de cette liste de présence que une action est présente ou représentée à la présente assemblée générale

extraordinaire.

IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de la Société, avec effet au premier janvier 2016 (ou toute autre date ultérieure fixée par le

conseil d’administration au cas où le déménagement de l’agent domiciliataire de la Société prendrait du retard), du 33, rue
de Gasperich, L-5826 Hesperange au 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Modification subséquente de l’article n° 2 premier alinéa des Statuts avec effet à la date effective du transfert du siège

social; octroi au conseil d’administration du pouvoir d’accomplir toutes les formalités nécessaires à la constatation ou, le
cas échéant, la modification de la date de prise d’effet du transfert du siège social de la Société au cas où le déménagement
de l’agent domiciliataire de la société prendrait du retard.

Modification  subséquente  de  l’article  2  deuxième  alinéa  des  Statuts;  octroi  au  conseil  d’administration  de  pouvoir

transférer le siège social de la Société au sein de la même commune.

2. Modification du deuxième paragraphe de l’article n° 25 se référant à l’Assemblée Générale annuelle. Le deuxième

paragraphe sera reformulé comme suit:

«L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social de la Société ou à l'endroit indiqué dans la

convocation, (…)»

Le Président informe l'Assemblée qu'une première assemblée générale extraordinaire s’est tenue en date du 27 novembre

2015 et que les conditions de quorum pour voter les points à l'ordre du jour n'étaient pas remplies.

La présente Assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée conformément

à l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Ces faits ayant été approuvés par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

22390

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution:

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la Société, avec effet au premier janvier 2016 du 33, rue de Gasperich,

L-5826 Hesperange au 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution:

L’Assemblée décide de modifier l’article deux des statuts avec effet au 1 

er

 janvier comme suit:

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. La Société

peut établir, par simple décision du conseil d'administration (le «Conseil d’Administration»), des succursales, des filiales
ou des bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du Conseil d'Administration. Un transfert

du siège social dans une autre commune du Grand-Duché de Luxembourg requiert une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires de la Société («l’Assemblée Générale») statuant comme en matière de modification des statuts (les «Sta-
tuts»).

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire, de

nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger,
jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales;  cette  mesure  provisoire  n'aura  toutefois  aucun  effet  sur  la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

<i>Troisième résolution:

L’Assemblée décide de modifier le deuxième paragraphe de l’article 25 se référant à l’Assemblée Générale annuelle.

Le deuxième paragraphe sera reformulé comme suit:

«L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social de la Société ou à l'endroit indiqué dans la

convocation, le troisième jeudi du mois de mai de chaque année à 14h30, à l’exception de la première assemblée générale
annuelle qui se tiendra le deuxième jeudi du mois de mai en 2016. Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se réunira le
premier jour ouvrable bancaire suivant. L'Assemblée Générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Admi-
nistration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instru-

mentant le présent procès-verbal.

Signé: V. LETELLIER, V. ALEXANDRE, A. BIEJ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 21 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/1971. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 29 janvier 2016.

Référence de publication: 2016058482/83.
(160019018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2016.

Charger Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 130.020,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.274.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-sixth day of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public having his professional address at Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg.

Is held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of “Charger LuxHoldCo II (Onshore) S.à r.l.”, a Luxembourg

société à responsabilité limitée, having its registered office at 5 C, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 138.274 (the “Com-
pany”), incorporated as a société à responsabilité limitée by a deed enacted by Maître Joseph Elvinger dated 14 April 2008
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1328 dated 30 May 2008 and lastly amended
by a notarial deed enacted by the undersigned notary, dated 31 December 2013, published in Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations under number 1151, dated 7 May 2014.

22391

L

U X E M B O U R G

There appeared:

The sole shareholder of the Company, Charger Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité

limitée, having its registered office at 5 C, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 138.249 (the “Shareholder”), holder of
68,500 (sixty-eight thousand five hundred) shares of the Company, duly represented by Mr. Régis Galiotto, notary clerk,
with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal on 18 September 2014.

The above-mentioned proxy, being initialled “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the notary to record as follows:
I. - That the 68,500 (sixty-eight thousand five hundred) shares of the Company, representing the whole share capital of

the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole
Shareholder states as having been duly informed beforehand.

II. - The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 61,520 (sixty-one thousand five hundred twenty

Euro) by the issue of 61,520 (sixty-one thousand five hundred twenty) new shares of the Company, with a nominal value

of EUR 1 (one Euro) each, so as to raise it from its amount of EUR 68,500 (sixty-eight thousand five hundred Euro) to

EUR 130,020 (one hundred thirty thousand twenty Euro);

3. Subscription and payment by Charger Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l. of 61,520 (sixty-one thousand five hundred

twenty) new shares, by way of a contribution in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the new share

capital pursuant to the resolutions above; and

6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put
at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each
document.

<i>Second resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 61,520 (sixty-one thousand five hundred

twenty Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 68,500 (sixty-eight thousand five hundred Euro) to EUR
130,020 (one hundred thirty thousand twenty Euro) by the issuance of 61,520 (sixty-one thousand five hundred twenty)
new shares of the Company with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the “New Shares”), the whole to be fully paid
up through a contribution in kind by the Sole Shareholder, consisting of claims held by the Sole Shareholder towards the
Company amounting to EUR 61,520 (sixty-one thousand five hundred twenty Euro) (the “Contribution”).

<i>Third resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares by means of the

Contribution.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the Contributor, here represented by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private

seal, and declares to subscribe to the New Shares in the Company and to pay them up entirely through the Contribution.

<i>Description of the Contribution

The Contribution made by the Sole Shareholder, in exchange for the issuance of the New Shares is composed of claims

held by the Sole Shareholder towards the Company and having an aggregate amount of EUR 61,520 (sixty-one thousand
five hundred twenty Euro).

<i>Valuation

The total net value of the Contribution amounts to EUR 61,520 (sixty-one thousand five hundred twenty Euro).

22392

L

U X E M B O U R G

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated

18 September 2014, which shall remain annexed to this deed and be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the contribution' existence

A proof of each of the Contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, the

shareholding of the Company is now composed of:

- Charger Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l.: holder of 130,020 (one hundred thirty thousand twenty) shares.
The notary acts that the 130,020 (one hundred thirty thousand twenty) shares representing the whole share capital of the

Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution described above having been fully

carried out, it is resolved to amend article 6 of the Company's articles of association so as to read as follows:

“ Art. 6. The Company's share capital is set at EUR 130,020 (one hundred thirty thousand twenty Euro), represented by

130,020 (one hundred thirty thousand twenty) shares with a par value of one Euro (EUR 1) each.”

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this deed, have been estimated at about two thousand Euros (2,000.- Euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn-up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour de septembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de «Charger Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l.», une société

à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5 C, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 138.274 (la «Société»), constituée suivant acte notarié par Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 14 Avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1328 le 30 mai 2008 et dernièrement modifié suivant acte notarié en date du 31 décembre 2013 par le notaire
soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1151 le 7 mai 2014.

A comparu:

L'associé unique de la Société, Charger Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 5C, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.249 (l'«Associé
Unique»), détenteur de 68.500 (soixante-huit mille cinq cents) parts sociales de la Société, dûment représenté par Monsieur
Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé le 18 septembre 2014.

La procuration susmentionnée, après avoir été signée “ne varietur” par la partie comparante et par le notaire instrumen-

taire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique représenté comme indiqué ci-dessus, a requis au notaire d'enregistrer comme suit:
I.- Que les 68.500 (soixante-huit mille cinq cents) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale d'1 EUR (un Euro)

chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut
valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été dûment et préalablement informé.

II.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

22393

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 61.520 EUR (soixante-et-un mille cinq cent vingt Euros)

par l'émission de 61.520 (soixante-et-un mille cinq cent vingt) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale d'1 EUR
(un Euro) chacune, afin de porter son montant actuel de 68.500 EUR (soixante-huit mille cinq cents Euros) à 130.020 EUR
(cent trente mille vingt Euros);

3. Souscription et paiement par Charger Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l. de 61.520 EUR (soixante-et-un mille cinq cent

vingt Euros) par l'émission de 61.520 (soixante-et-un mille cinq cent vingt) parts sociales, au moyen d'un apport en nature;

4. Nouvelle composition du capital social de la Société;
5. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital social suivant

l'augmentation de capital suivant les résolutions ci-dessus; et

6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée;

l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué
et accepte en conséquence de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la
documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps
suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 61.520 EUR (soixante-et-un mille cinq cent

vingt Euros) afin de porter son montant actuel de 68.500 EUR (soixante-huit mille cinq cents Euros) à 130.020 EUR (cent
trente mille vingt Euros) par l'émission de 61.520 (soixante-et-un mille cinq cent vingt) parts sociales d'une valeur nominale
d'1 EUR (un Euro) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), l'intégralité devant être libérée par l'Associé Unique par un
apport en nature consistant en des créances détenues par l'Associé Unique à l'égard de la Société s'élevant à un montant de
61.520 EUR (soixante-et-un mille cinq cent vingt Euros) (l'«Apport»).

<i>Troisième résolution

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales au moyen de

l'Apport.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Monsieur Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé, et déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales dans la Société et les libère entièrement au moyen
de l'Apport.

<i>Description de l'apport

L'Apport réalisé par l'Associé Unique, en contrepartie de l'émission des Nouvelles Parts Sociales, consiste en des créan-

ces détenues par l'Associé Unique à l'égard de la Société et s'élevant à un montant total de 61.520 EUR (soixante-et-un
mille cinq cent vingt Euros).

<i>Evaluation

La valeur nette totale de l'Apport s'élève à un total de 61.520 EUR (soixante-et-un mille cinq cent vingt Euros).
Une telle évaluation a reçu l'approbation de l'ensemble des gérants de la Société, aux termes d'une déclaration de valeur

de l'apport en date du 18 septembre 2014, qui demeure annexée au présent acte afin d'être soumise avec ce dernier aux
formalités d'enregistrement.

<i>Preuve de l'existence de l'Apport

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire instrumentaire.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport décrit ci-dessus ayant été intégralement réalisé,

le capital social de la Société est maintenant détenu par:

- Charger Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l.: détentrice de 130.020 (cent trente mille vingt) parts sociales de la Société.
Le notaire établit que les 130.020 (cent trente mille vingt) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la

Société sont représentées, de telle sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur la résolution suivantes.

22394

L

U X E M B O U R G

<i>Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport décrit ci-dessus ayant été totalement réalisé, il

est décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à 130.020 EUR (cent trente mille vingt Euros), représentées par 130.020

(cent trente mille vingt) parts sociales, d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune.»

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée.

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec l'augmentation de son capital social, ont été estimés à deux mille Euros (2.000.-Euro).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne comparante, le présent acte

est établi en anglais suivi d'une traduction en français. A la requête de la même personne comparante, en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, le présent acte a été rédigé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec nous, notaire, le présent

acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 octobre 2014. Relation: LAC/2014/46510. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Référence de publication: 2016053486/192.
(160012328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Arkus Partners G.I.E., Groupement d'Intérêt Economique.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg C 123.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the second day of December, 2015.
Among:
1. Arkus Financial Services, a public limited liability company (société anonyme”), registered with the Register of

commerce and companies of Luxembourg under number B 132014, and having its registered office at L-2633 Senninger-
berg, 6B, route de Trêves, Grand Duchy of Luxembourg, having the following corporate purpose:

“The corporate purpose of the Company is to offer any kind of administrative services and to provide any kind of services

in relation to: assessment and definition of risk management processes; risk profiling and risk parameters and thresholds
specification of the investment schemes and portfolios; evaluation of appropriate risk measurement systems; implemen-
tation of the risk measurement; analysis of the risk measures and of the deviations versus the set thresholds and risk profile;
similar related activities. The Company may also offer advice in relation to the above services. The Company may provide
its services to undertakings of collective investments, pension funds, banks, insurance companies and similar legal entities
in Luxembourg and abroad and to this extend establish subsidiaries and representation offices. It may establish companies,
participate in existing companies and finance such companies. The purpose of the Company is further the holding of
participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the
acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of
securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio. Furthermore, the Company may
undertake all activities and take all actions which are appropriate to directly or indirectly promote the purpose of the
Company and which it may deem useful for the fulfillment and development of its purpose to the largest extent permitted
under the law dated 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended (the «Companies' Act»)”;

2. Mr. Yves Jacobé de Naurois, with professional address at IRML, 6B route de Trêves, L-2633 Senningerberg, Lu-

xembourg;

3. Mr. Nicolaus Bocklandt, residing at 7, Clos Andre Rappe, B-1200 Brussels, Belgium;
4. Mr. Jean-Christoph Arntz, residing at 3, an der Flurscheid, D-61352 Bad Homburg, Germany;
5. Mr. Benoît Paquay, residing at 52, Rue Cyprien Merjai, L-2145 Beggen, Luxembourg;

22395

L

U X E M B O U R G

(hereinafter collectively referred to as the «Founding Members» and individually as a «Founding Member», the Members

mentioned under point 2. to 5. being also referred to as the “Individual Members”).

Whereas Arkus Financial Services (hereafter “Arkus”) is a Luxembourg regulated PFS (Professional of the Financial

Sector) and provides flexible and independent risk management services including the delegation of risk management
functions, conducting officers and independent directors' mandates and related support, governance systems to regulated
and non-regulated entities (hereafter the “Services”).

Whereas Arkus proposes from time to time to the Individual Members to act as independent directors, conducting officers

or risk officer for various companies including regulated entities supervised in Luxembourg or in other jurisdictions.

Whereas the Individual Members also act directly as directors or conducting officers or provide management services

to companies based in Luxembourg or other jurisdictions.

Whereas the Founding Members must be of sufficiently good repute and be sufficiently experienced in relation to the

services they provide.

Whereas in order to ensure to their clients the highest standard of professional and ethical behavior, and to adopt rules

and guidelines to frame their activities, the Individual Members have adopted a code of conduct (hereafter the “Code of
Conduct”) as well as a governance policy (hereafter the “Governance Policy”) and have set up a committee (hereafter the
“Governance Committee”) with the purpose to monitor the compliance of its members with the Code of Conduct and to
report to the Grouping any breach to the Code of Conduct.

Whereas the Individual Members have a strategic interest in the Services and Arkus has a strategic interest in identifying

and supporting conducting officers and/or directors who share the same approach on strong governance and can help respond
to the needs of management and investment companies in this respect.

Whereas the Founding Members have decided to join their forces and capabilities in order to develop and expand their

activities, and in order to set up common resources and equipment such as to facilitate or develop their activities.

Whereas the Founding Members wish to establish the following agreement for the establishment of an economic interest

grouping (groupement d'intérêt économique).

Now, therefore, in consideration of the covenants herein contained and other good and valuable consideration, the receipt

and sufficiency of which are hereby acknowledged, the Founding Members hereto agree as follows:

A. Name - Corporate object - Duration - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the Founding Members and all those who may become parties to the present

Agreement (hereinafter collectively referred to as the «Members» and individually as a «Member»), an economic interest
grouping (groupement d'intérêt économique) under the name of Arkus Partners G.I.E- (hereinafter the «Grouping»).

Art. 2. The Grouping is established for an unlimited duration.

Art. 3. The purpose of the Grouping is:
-  to  enhance  the  provision,  through  its  Members,  of  services  of  the  highest  quality,  in  order  to  make  sure  that  the

denomination Arkus Partners G.I.E. be considered as a guarantee for the quality of services rendered by firms and indivi-
duals exercising their activities under this denomination;

- to arrange on an exclusive basis for shared services to its Members, directly or through other Members, necessary to

the performance of their activities, notably their activities of director or conducting officer, including providing employees
or equipment, recruitment, management and remuneration of employees, legal assistance, management and maintenance
of professional premises and installations, accounting, finance, marketing and information technology services but ex-
cluding  any  activity  which  could  give  the  grouping  access  to  information  of  Members  covered  by  any  applicable
professional secrecy rules;

- to strengthen the name and professional reputation of all its constituent organizations within the marketplace, profes-

sional circles and, most importantly, with the existing clients and the personnel within the Members.

The Grouping may furthermore perform other functions incidental to the purpose set out herein or necessary to make

the Grouping effective, as well as carry out any operations, which it may deem useful in accomplishment of its purpose
and which remain within the limits laid down in articles 1 (1) and 2 of the amended law of 25 March 1991 on economic
interest groupings (the «Law of 1991»).

Art. 4. The registered office of the Grouping is established at L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trêves.
The registered office may be transferred within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision adopted by a simple

majority vote of the board of managers or by a decision of the sole manager.

B. Financing of the Grouping

Art. 5. The Grouping is established without equity contribution.
Each Member has the same interest in the Grouping.
A contribution may, at the sole discretion of the board of managers or of the sole manager, be required from new Members

who are not Founding Members.

22396

L

U X E M B O U R G

Art. 6. For each mandate assumed by each of the Members, the general meeting of Members shall agree at the beginning

of each year or upon the admission of a new Member or following the acceptance of a new mandate by a Member (hereafter
the “General Meeting”) on the percentage of the annual governance fees to be paid by the relevant Member to the Grouping
(hereafter the “Annual Fees”) for the current year in relation to this mandate, for the administrative support on mandate
and for the shared resources and services to be provided by the Grouping to the relevant Member.

For the needs of the calculation of the Annual Fees, each Member shall disclose to the General Meeting, to be held at

the beginning of each year, the number of mandates he assumes, as well as the contact details of his/her clients, the annual
fees invoiced for each mandate to the clients, and an appraisal of the amount of services to be provided by the Grouping
in relation to each mandate. Each Member shall also, without delay, communicate the same information to the General
Meeting about any new mandate he receives during the year.

In addition to the administrative support and shared resources provided by the Grouping to its Members, they may also

benefit from optional services to be specified by the General Meeting.

Art. 7. If at any time it appears that the funds of the Grouping are not sufficient to cover the expenses or the foreseeable

expenses relating to the operations and functioning of the Grouping, each Member shall be liable for the payment of a
percentage in these expenses (hereafter the “Percentage”), corresponding to:

the aggregate amount of the Annual Fees paid by this Member X 100 / the aggregate amount of the Annual Fees paid

by all the Members

The board of managers or the sole manager may request at any time Members to participate to the payment of the

expenses of the Grouping according to this article 7 upon delivery of a breakdown of expenses.

The Members may also decide to pay advances to the Grouping to cover future expenses on the basis of the same

Percentage (hereafter the “Advances”).

Advances will be regularized quarterly upon delivery by the sole manager or the board of managers of a breakdown of

expenses to the Members (the “Quarterly Breakdown”). Any positive or negative difference between the advance paid by
a Member and its actual Percentage in the expenses of the Grouping during the corresponding period shall, as the case may
be, be reimbursed to said Member or to the Grouping. Advances may never exceed the total expenses incurred by the
Grouping during the period elapsed between the establishment of two breakdowns.

C. Members - General meetings - Members' liability

Art. 8. No Member may transfer his/her interests in the Grouping.
Admission of a new Member is subject to the prior consent of the other Members given in a general meeting and held

in  accordance  with  article  10.,  being  specified  that  only  the  candidates  having  received  a  favorable  opinion  from  the
Governance Committee and having approved the present Agreement, the Code of Conduct and the Governance Policy may
be admitted as Member of the Grouping.

A new Member, upon his admission to the Grouping, shall pay to the Grouping the Annual Fees, and shall participate

in the expenses of the Grouping on the basis of the same criteria as the existing Members. In case of the new member
entering the Grouping after January, the payment of the Annual Fees will be time prorated.

Existing Members may determine from time to time any other financial condition to be fulfilled by new member.

Art. 9. Any regularly constituted general meeting of Members shall represent the entire body of Members of the Group-

ing. Save as otherwise provided in this Agreement, it shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts, which
may be useful in accomplishment of the purpose of the Grouping.

Art. 10. The general meeting of Members shall not validly deliberate on:
(i) any amendment of the Agreement of the Grouping,
(ii) the dissolution of the Grouping and the appointment of the liquidator(s),
(iii) the admission of a new member,
(iv) the exclusion of (a) Member(s),
(v) the appointment and removal of the board of managers or of the sole manager,
unless at least all the Members are present or represented to the general meeting. Resolutions relating to these matters

shall be unanimously adopted by the Members present or represented at such meeting, being specified that for resolutions
regarding the exclusion of a Member, the Member to be excluded may not be included in the quorum and he may not vote
on this matter.

The general meeting of Members shall not validly deliberate on:
(i) the remuneration to be granted to the board of managers or to the sole manager,
(ii) the amount of the Annual Fees to be paid by the Members for each of their mandates,
(iii) the payment by Members of Advances,
(iv) the approval of the annual accounts of the Grouping,
(v) the appointment of one or more statutory auditor(s) to verify these accounts,
(vi) any other decision or issue concerning the operations and functioning of the Grouping,

22397

L

U X E M B O U R G

unless at least the majority of the Members are present or represented to the general meeting. Resolutions relating to

these matters shall be taken by a majority vote of the Members present or represented at such meeting.

Art. 11. General meeting of Members shall be held at least twice a year (at the beginning of the year for the General

Meeting and at the latest six months after the end of the financial year for the general meeting regarding the approval of
its accounts), and at any time at the individual request of any Member.

General meeting of Members is convened by the board of managers or by the sole manager who shall prepare, make

approve and keep the records of the minutes of the meetings, or appoint someone else to do so.

Convening notices for a meeting of Members shall contain the agenda and shall be sent by registered letters and by e-

mail at least eight days before the meeting to the Members.

If all the Members are present or represented at a meeting of Members, and if they state that they have been duly informed

of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice. Participations via video conference may be
allowed.

A Member may act at any meeting of Members by appointing another person as his proxy in writing, cable, telex or

facsimile.

Each Member shall have one (1) vote.

Art. 12. The Members may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing their approval in writing,

by facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes
giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 13. The Members shall be jointly and severally liable for all Grouping's liabilities.
The liability of a new Member shall however not include the payment of debts contracted by the Grouping or debts

originated from the Grouping's activities before the date of the new Member's admission.

The Member who ceases to belong to the Grouping shall remain liable for the debts and other liabilities arising out of

the Grouping's activities up to the date of the publication of the departure of the Member.

Art. 14. A Member of the Grouping shall cease to be a Member upon:
- his resignation from the Grouping;
- his exclusion from the Grouping.

Art. 15. A Member may resign from the Grouping by giving three months prior notice by registered mail addressed to

the board of managers or to the sole manager indicating the reasons of its resignation.

At the expiration of the relevant prior notice period, the board of managers or the sole manager shall establish a break-

down including (hereafter the “Final Breakdown”):

i) on the one hand, the outstanding Annual Fees and the Percentage of the expenses, to be paid by this Member to the

Grouping upon request of the board of managers or the sole manager, and,

ii) on the other hand, the amount of the Advances paid by this Member to the Grouping since the last Quarterly Break-

down.

The balance between i) and ii) (hereafter the “Compensation”) shall be paid by the Member to the Grouping, or, to the

extent that the amount under ii) is higher than the amount i), by the Grouping to the Member, within one month following
the expiration of the relevant prior notice period.

Art. 16. A Member may be excluded for just cause, including notably:
- the non-compliance with the provisions of the present Agreement,
- the continued failure to execute its obligations towards the Grouping,
- the commission of any act, that was intended to or that has materially harmed the functioning of the Grouping, or such

as to infringe the good reputation of the Grouping or of its Members,

- the breach of any provision of the Code of Conduct or of the Governance Policy, or the non-compliance with any

recommendation made by the Governance Committee, as reported by the Governance Committee.

According to above article 10., decision regarding the exclusion of a Member shall be adopted by unanimous decision

of the general meeting of Members. The latter shall not be entitled to participate at such vote.

As from the exclusion of a Member, the board of managers or the sole manager shall establish and send the Final

Breakdown to the Member. The Member or, as the case may be, the Grouping, shall pay the Compensation within 90 days
following the sending of the Final Breakdown to the resigning or excluded Member.

The decision of exclusion entails an automatic exclusion from the board of managers as the case may be, and may also

involve the cancelation of the excluded member's office lease and other support services.

Art. 17. The resignation, exclusion, bankruptcy or insolvency, dissolution or merger of one of the Members, others than

Arkus, will not cause the dissolution of the Grouping.

The resignation, exclusion, bankruptcy or insolvency, dissolution or merger of Arkus, will cause the dissolution of the

Grouping.

22398

L

U X E M B O U R G

D. Management of the Grouping

Art. 18. The Grouping is managed by one or several managers.
If several managers are appointed, the Grouping is managed by a board of managers.
The sole manager or the board of managers coordinates and organizes the activities of the Grouping and is also entrusted

with:

- the day to day management of the Grouping;
- the establishment any breakdown of expenses including the Quarterly Breakdown and the Final Breakdown;
- the request to the Members to participate to the payment of the expenses of the Grouping according to above article

7.;

- the convening of the general meeting of Members;
- the appraisal of the quality of the services provided to the Grouping by Arkus, or by any other provider.
The Grouping is only validly engaged by two signatures of the board of managers. In the case of a sole manager, a

second signature will be requested from another Member.

The sole manager or board of managers reports his activities to the Members on a quarterly basis.
A manager may be a legal entity or a physical person.
In case the manager is a legal entity, upon its appointment, the latter shall inform the Grouping, by registered letter, on

the identity of its permanent representative, which shall be a physical person. Without prejudice to the joint and several
liability of the manager, the permanent representative shall be subject to the same civil and criminal liability as the manager
(s) of the Grouping.

The permanent representative of a manager shall be appointed for the same period of time as the manager. Such repre-

sentation shall be confirmed upon each renewal of the mandate of the manager.

Upon the resignation, the dismissal, the death or the incapacity of its permanent representative, the manager shall inform

the Grouping, by registered letter, about this event and about the identity of its new permanent representative.

The Manager(s) is (are) appointed by a unanimous decision of all the Members taken in accordance with above article

10., which also set the term of his/her/their office as well as his/her/their remuneration.

Any manager may be removed with or without cause by a unanimous decision of all the Members taken in accordance

with above article 10. If the manager is a Member, this Member to be excluded shall not be entitled to participate in such
vote.

The board of managers or the sole manager may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private

instrument.

Art. 19. The board of managers shall meet upon call by any two members of the board of managers, at the place indicated

in the notice of meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the members of the board of managers by e-

mail and by letter twenty-four hours at least in advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency,
in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in
case of assent of each manager in writing, by cable, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A
special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution
adopted by the board of managers.

A manager or a permanent representative of a manager being a legal entity, may act at any meeting of the board of board

of managers by appointing in writing or by cable, telex or facsimile another manager or permanent representative of a
manager as his proxy.

A manager or a permanent representative of a manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate
or act validly only if at least a majority of managers is present or represented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile, or other means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving
evidence of the resolution.

Art. 20. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the managers present to this meeting.

Copies or extracts of the resolutions of the sole manager or of minutes of the board of managers, shall be circulated to the
Members.

Art. 21. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Grouping.

22399

L

U X E M B O U R G

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 22. The Grouping's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 23. Each year on the thirty-first of December, the annual accounts (the balance sheet, the profits and losses account

and annexes) are closed and the manager(s) prepare an inventory including an indication of the value of the Grouping's
assets and liabilities. Each Member may inspect the above inventory and annual accounts at the Grouping's registered
office.

The general meeting of Members shall approve the above inventory and annual accounts within a period of six months

after the closing.

The general meeting of Members may decide to appoint one or several statutory auditor(s) in order to verify the annual

accounts.

The Grouping is not itself involved in the distribution of profits or the allocation of profits or losses. Profits may be

assigned partially or in full to the reserve accounts.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. The Grouping will be dissolved by:
- the resignation, exclusion, bankruptcy or insolvency, dissolution or merger of Arkus,
- a resolution of its general meeting of Members taken in accordance with the first paragraph of the above article 10.

Art. 25. In the event of a dissolution of the Grouping, the Grouping shall be liquidated by one or more liquidators, which

do not need to be Members, and which are appointed by the general meeting of Members, which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets
and payment of the liabilities of the Grouping, in accordance with article 22 (3), (4), (5) of the Law of 1991.

In the absence of a decision designating a specific person as liquidator, the board of managers or the sole manager will

act as liquidator(s).

The surplus resulting from the realization of the assets of the Grouping and the payment of the liabilities of the Grouping

shall be distributed among the Members proportionally to their contribution part in the Grouping.

G. General provisions

Art. 26. All matters not governed by the present Agreement shall be determined in accordance with the Law of 1991

and with the amended law of 10 August 1915 on Commercial Companies.

Art. 27. This Agreement shall be binding upon and enforceable by the Members hereto.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Grouping and shall terminate on the 31 

st

 of

December 2016.

<i>General meeting of Members

Upon the signature of the present Agreement, the undersigned Members representing all the Members of the Grouping

and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to a General Meeting.

After the verification of the due constitution of the meeting, the meeting has adopted the following resolutions by

unanimous vote:

1) The number of managers is fixed at one.
4) Mr. Yves Jacobé de Naurois, born on the 7 

th

 of July 1948 at Talence (France), with professional address at 6B route

de Trêves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as sole manager of the Grouping for an
unlimited duration.

The Members state herewith that the present Agreement is worded in English followed by a French translation; the

English version will prevail in case of differences between the English and French text.

In witness whereof, the Founding Members have duly executed this Agreement or have caused it to be duly executed

as of the date first set forth above.

Done in Luxembourg in six originals, one of which has been filed with the Luxembourg trade and companies' register,

and each Founding Member acknowledging receipt of one original.

Arkus Financial Services / Mr. Yves Jacobé de Naurois / Mr. Nicolaus Bocklandt / Mr. Jean-Christoph Arntz /

Mr. Benoît Paquay.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le deux décembre 2015.
Entre les soussignés:

22400

L

U X E M B O U R G

1. Arkus Financial Services, une société anonyme, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro B 132014 et ayant son siège social au 6B, route de Trêves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg,
ayant l'objet social suivant:

«La Société a pour objet d'offrir toutes sorte de services administratifs ainsi que toute sorte de services concernant:

l'évaluation et la mise en place de procédures de gestion de risques; la classification en profiles de risques et paramétrages
de risques et spécification de limites de produits et portefeuilles d'investissement; l'évaluation de systèmes de mesures
appropriés; l'implémentation de mesures de risque; l'analyse de mesures de risques et déviations vis-à-vis des limites fixées
et profiles de risque; des activités connexes comparables. La Société pourra aussi offrir de la consultation concernant les
services susmentionnés. La Société pourra prester ses services à des organismes de placement collectifs, fonds de pension,
banques, sociétés d'assurance ainsi que toute société comparable au Luxembourg et à l'Etranger et à ce but établir des filiales
et  bureau  de  représentation.  Elle  pourra  constituer  des  sociétés,  participer  dans  des  sociétés  existantes  et  financer  ces
sociétés. La Société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La Société peut par ailleurs effecteur toute activité et réaliser
toutes les opérations qui seraient directement ou indirectement utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social de
manière plus la large permis par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»)»;

2. Mr Yves Jacobé de Naurois, demeurant professionnellement à IRML, 6B route de Trêves, L-2633 Senningerberg,

Grand-Duché de Luxembourg;

3. Mr Nicolaus Bocklandt, demeurant à 7, Clos Andre Rappe, B-1200 Bruxelles, Belgique;
4. Mr Jean-Christoph Arntz, demeurant à 3, an der Flurscheid, D-61352 Bad Homburg, Allemagne;
5. Mr Benoît Paquay, demeurant à 52, Rue Cyprien Merjai, L-2145 Beggen, Grand-Duché de Luxembourg;
(ci-après, désignés collectivement comme «Membres Fondateurs» et individuellement comme un «Membre Fondateur»,

les Membres mentionnées sous les points 2. à 5. Etant également désignés comme «Membres Individuels»),

Attendu que Arkus Financial Services (ci-après «Arkus») est un PSF luxembourgeois (Professionnel du Secteur Finan-

cier) réglementé qui fournit des services flexibles et indépendants de gestion des risques, y compris la délégation des
fonctions de gestion des risques, la fourniture de mandats de dirigeants indépendants et de «conducting officers» ainsi que
le support nécessaire, et la fourniture de systèmes de gouvernance aux entités réglementées et non réglementées (ci-après
les «Services»).

Attendu  qu'Arkus  propose  de  temps  à  autre  aux  Membres  Individuels  d'agir  comme  administrateurs  indépendants,

«conducting officers» ou agents à la gestion des risques pour diverses sociétés, y compris pour des entités réglementées au
Luxembourg ou dans d'autres juridictions.

Attendu que les Membres Individuels agissent également directement comme administrateur ou «conducting officers»

ou fournissent des services de gestion aux sociétés établies au Luxembourg ou dans d'autres juridictions.

Attendu que les Membres Fondateurs doivent présenter un niveau d'honorabilité et d'expérience professionnelle suffisant

en relation avec les services qu'ils fournissent.

Attendu que, afin de procurer à leurs clients le plus haut niveau de conduite éthique et, afin d'adopter des règles et des

lignes directrices encadrant leurs activités, les Membres Individuels ont adoptés un code de conduite (ci-après le «Code de
Conduite») ainsi qu'une politique de gouvernance (ci-après la «Politique de Gouvernance») et ont mis en place un comité
(ci-après le «Comité de Gouvernance») afin de lui confier le contrôle du respect du Code de Conduite par ses Membres et
de le charger de rapporter au Groupement tout manquement au Code de Conduite.

Attendu que les Membres Individuels ont un intérêt stratégique à bénéficier des Services et qu'Arkus a un intérêt stra-

tégique à identifier et soutenir les dirigeants et/ou «conducting officers» qui partagent la même approche d'une gouvernance
forte et peuvent aider à répondre aux besoins des sociétés de gestion et d'investissement à cet égard.

Attendu que les Membres Fondateurs ont décidé d'unir leurs forces et leurs capacités afin de développer et de diversifier

leurs activités, et ce, dans le but de mettre en place les ressources et les équipements nécessaires afin de faciliter ou de
développer leurs activités communes.

Attendu que les Membres souhaitent conclure entre eux le présent contrat de groupement d'intérêt économique;
Par conséquent, eu égard aux engagements contenus dans la présente et moyennant une contrepartie valable, accusant

la bonne réception et la suffisance de celle-ci, les Membres Fondateurs ici présents, conviennent de ce qui suit:

A. Dénomination - Objet - Durée - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les Membre Fondateurs et tous ceux qui pourront devenir partie au présent

Contrat par la suite (ci-après désignés collectivement les «Membres» et individuellement le «Membre»), un groupement
d'intérêt économique sous la dénomination de Arkus Partners G.I.E. (ci-après, le «Groupement»).

Art. 2. Le Groupement est constitué pour une durée illimitée.

22401

L

U X E M B O U R G

Art. 3. Le Groupement a pour objet:
- d'améliorer la fourniture, au travers de ses Membres, de services de la plus haute qualité, afin de s'assurer que la

dénomination Arkus Partners G.I.E. soit considérée comme une garantie de la qualité des services rendus par les sociétés
ainsi que par les individus qui exercent leurs activités sous cette dénomination;

- de mettre en place sur une base exclusive des services communs, au bénéfice de ses Membres, directement ou au travers

d'autres Membres, nécessaires à l'exercice de leurs activités, notamment leurs activités d'administrateur ou de «conducting
officers», y compris la mise à disposition d'employés ou d'équipement, le recrutement, la gestion et la rémunération des
employés, l'assistance juridique, la gestion et l'entretien des locaux et des installations professionnelles, la comptabilité,
les finances, le marketing et les services technologiques d'information, mais à l'exclusion de toute activité qui pourrait
donner au Groupement l'accès aux informations de Membres, couvertes par le secret professionnel;

- de renforcer le nom et la réputation professionnelle de toutes ses organisations constituantes au sein du marché, des

milieux professionnels et, surtout envers leurs clients existants et envers le personnel engagé par ses Membres.

Le Groupement pourra également exercer toute opération qu'il jugera utile à l'accomplissement de son objet en restant

dans les limites tracées par les articles 1 (1) et 2 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupement d'intérêt économique (la «Loi
de 1991»).

Art. 4. Le siège social du Groupement est établi à L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trêves.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision adoptée par un

vote à la majorité simple du conseil de gérance ou en vertu d'une décision du gérant unique.

B. Financement du groupement

Art. 5. Le Groupement est établi sans apports.
Chaque Membre a le même intérêt dans le Groupement.
Une contribution peut, à la seule discrétion du conseil de gérance ou du gérant unique, être réclamée aux nouveaux

Membres qui ne sont pas des Membres Fondateurs.

Art. 6. Pour chaque mandat assumé par chacun des Membres, l'assemblée générale des Membres (ci-après l'«Assemblée

Générale») devra convenir, au début de chaque année ou lors de l'admission d'un nouveau Membre ou à la suite de l'ac-
ceptation d'un nouveau mandat par un Membre, du pourcentage des frais de gouvernance annuels à payer par le Membre
concerné au Groupement (ci-après les «Frais Annuels») pour l'année en cours en relation avec ce mandat, pour le soutien
administratif attaché au mandat ainsi que pour les ressources et services communs qui seront fournis par le Groupement
au Membre concerné.

Pour les besoins du calcul des Frais Annuels, chaque Membre devra fournir à l'assemblée générale, qui se tiendra au

début de chaque année, le nombre de mandats qu'il assume, ainsi que les informations relatives à son/ses clients, le frais
annuels facturés aux clients pour chaque mandat, ainsi qu'une évaluation de la quantité de services qui seront fournis par
le Groupement en relation avec chaque mandat. Chaque Membre devra également, sans délai, communiquer les mêmes
informations à l'Assemblée Générale à propos de tout nouveau mandat qu'il reçoit en cours d'année.

En plus du support administratif et des ressources fournies par le Groupement à ses Membres, ceux-ci pourront également

bénéficier de services optionnels à préciser par l'Assemblée Générale.

Art. 7. Si, à tout moment, il apparaît que les fonds du Groupement ne sont pas suffisants pour couvrir les dépenses ou

les  dépenses  prévisibles,  relatives  aux  opérations  et  au  fonctionnement  du  Groupement,  chaque  Membre  sera  tenu  au
paiement d'un pourcentage de ces dépenses (ci-après le "Pourcentage"), correspondant à:

le montant total des Frais Annuels payés par ce Membre X 100 / le montant total des Frais Annuels payés par tous les

Membres

Le conseil de gérance ou le gérant unique peut demander à tout moment aux Membres de participer au paiement des

frais du Groupement conformément au présent article 7 sur base de l'émission d'un décompte de dépenses.

Les Membres peuvent également décider de payer des avances au Groupement pour couvrir les dépenses futures sur

base du même Pourcentage (ci-après les "Avances").

Les Avances seront régularisées trimestriellement sur base de l'émission par le gérant unique ou par le conseil de gérance

d'un décompte de dépenses aux Membres (le "Décompte Trimestriel"). Toute différence positive ou négative entre l'avance
versée par un Membre et son Pourcentage effectif dans les dépenses du Groupement au cours de la période correspondante
doit, le cas échéant, être remboursée au Membre visé ou au Groupement. Les Avances ne peuvent jamais dépasser le total
des dépenses engagées par le Groupement au cours de la période écoulée entre l'établissement de deux décomptes.

C. Membres - Assemblées générales - Responsabilité des Membres

Art. 8. Aucun Membre ne peut transférer ses intérêts dans le Groupement.
L'admission d'un nouveau Membre est soumise à l'accord préalable des autres Membres donné au cours d'une assemblée

générale tenue conformément à l'article 10., étant précisé que seuls les candidats ayant reçu un avis favorable du Comité
de Gouvernance et ayant approuvé le présent Contrat, le Code de Conduite et de la Politique de Gouvernance peuvent être
admis en tant que Membres du Groupement.

22402

L

U X E M B O U R G

Tout nouveau Membre, lors de son admission au Groupement, versera au groupement les Frais Annuels, et participera

aux frais du Groupement sur base des mêmes critères que les Membres existants. Dans le cas où un nouveau Membre
intègre le Groupement après le mois de janvier, le paiement des Frais Annuels sera calculé au prorata du temps restant.

Les Membres existants peuvent fixer à n'importe quel moment toute autre condition financière à remplir par le nouveau

Membre.

Art. 9. L'assemblée générale des Membres régulièrement constituée représente l'intégralité des Membres du Groupe-

ment. Sauf disposition contraire du présent Contrat, elle a les pouvoirs les plus étendus pour arrêter, exécuter ou ratifier
des actes, qui peuvent s'avérer utiles à l'accomplissement de l'objet du Groupement.

Art. 10. L'assemblé générale des Membres ne peut valablement délibérer sur:
(i) tout amendement du présent Contrat de Groupement
(ii) la dissolution du Groupement,
(iii) l'admission d'un nouveau Membre,
(iv) l'exclusion d'un ou plusieurs Membre(s),
(v) la nomination et la révocation du conseil de gérance ou du gérant unique,
que si tous les Membres au moins sont présents ou représentés à l'assemblée générale. Les résolutions relatives à ces

questions doivent être adoptées à l'unanimité par les membres présents ou représentés à cette assemblée, étant précisé que
pour les résolutions relatives à l'exclusion d'un Membre, le Membre à exclure ne peut être inclus dans le quorum et ne peut
voter sur cette matière.

L'assemblé générale des Membres ne peut valablement délibérer sur:
(i) la rémunération à accorder au conseil de gérance ou au gérant unique,
(ii) le montant des Frais Annuels à payer par les Membres pour chacun de leurs mandats,
(iii) le paiement d'Avances par les Membres,
(iv) l'approbation des comptes annuels du Groupement,
(v) la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises,
(vi) toute autre décision ou question concernant les opérations et le fonctionnement du Groupement,
que si la majorité des Membres au moins sont présents ou représentes à l'assemblée générale. Les résolutions relatives

à ces questions devront être adoptées à la majorité des voix des Membres présents ou représentés à cette assemblée.

Art. 11. Une assemblée générale des Membres doit être tenue au moins deux fois par an (au début de l'année pour

l'Assemblée Générale et au plus tard six mois après la fin de l'année comptable pour l'assemblée générale relative à l'ap-
probation des comptes), et à tout moment à la demande individuelle d'un Membre.

L'assemblée générale des Membres est convoquée par le conseil de gérance ou par le gérant unique, qui doit préparer,

faire approuver et tenir les registres des procès-verbaux des assemblées, ou nommer quelqu'un d'autre pour le faire.

Les convocations aux assemblées des Membres devront contenir l'ordre du jour et seront envoyées par courrier à chaque

Membre huit jours au moins avant l'assemblée.

Si tous les Membres sont présents ou représentés à une assemblée, et s'ils déclarent qu'ils ont été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable. Les participations via vidéo confé-
rences pourront être autorisées.

Un Membre peut se faire représenter à toute assemblée des Membres en désignant par écrit, par câble, télégramme ou

télécopie toute autre personne comme son mandataire.

Chaque membre dispose d'une (1) voix.

Art. 12. Les Membres peuvent, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en exprimant leur approbation

par écrit, par télégramme, ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le tout ensemble con-
stituera le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les Membres sont conjointement et solidairement responsables des dettes du Groupement.
Toutefois, un nouveau Membre ne sera pas responsable du paiement des dettes contractées par le Groupement ou des

dettes générées par les activités du Groupement avant la date d'admission du nouveau Membre.

Le Membre qui cesse d'appartenir au Groupement reste responsable des dettes ou autres obligations résultant des activités

du Groupement jusqu'à la date de publication du départ de ce Membre.

Art. 14. Tout Membre du Groupement cessera d'être Membre des suites de:
- sa démission du Groupement;
- son exclusion du Groupement.

Art. 15. Un Membre peut démissionner du Groupement moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recom-

mandée au conseil de gérance ou au gérant unique indiquant les motifs de sa démission.

22403

L

U X E M B O U R G

A l'expiration de la période de préavis applicable, le conseil de gérance ou le gérant unique établira un décompte (ci-

après le «Décompte Final») comprenant:

i) d'une part, les Frais Annuels impayés et le Pourcentage des dépenses à payer par ce Membre au Groupement à la

demande du conseil de gérance ou du gérant unique, et,

ii) d'autre part, le montant des Avances versées par ce Membre au Groupement depuis le dernier Décompte Trimestriel.
La différence entre i) et ii) (ci-après la «Compensation») sera payé par le Membre au Groupement, ou, dans la mesure

où le montant sous ii) est plus élevé que le montant sous i), par le Groupement au Membre, dans le mois qui suit l'expiration
de la période de préavis applicable.

Art. 16. Tout Membre peut être exclu pour des justes motifs, notamment en cas de:
- non-respect des dispositions du présent Contrat,
- défaut persistant d'exécuter ses obligations envers le Groupement,
- commission de tout acte, de nature à nuire ou qui a matériellement porté atteinte au fonctionnement du Groupement,

ou qui est de nature à porter atteinte à la bonne réputation du Groupement ou de ses Membres,

- la violation d'une des dispositions du Code de Conduite ou de la Politique de Gouvernance, ou le non-respect d'une

recommandation formulée par le Comité de Gouvernance, tels que rapportés par le Comité de Gouvernance.

Conformément à l'article 10. qui précède, la décision relative à l'exclusion d'un Membre doit être adopté à l'unanimité

lors de l'assemblée générale des Membres. Le Membre à exclure ne sera pas autorisé à participer à un tel vote.

A partir de l'exclusion d'un Membre, le conseil de gérance ou le gérant unique devra établir et transmettre à ce Membre

le Décompte Final. Le Membre ou, le cas échéant, le Groupement, devra payer la Compensation endéans les 90 jours qui
suivent l'envoi du Décompte Final au Membre démissionnaire ou exclu.

La décision d'exclusion entraîne, le cas échéant, une exclusion automatique du conseil de gérance, et peut également

entraîner l'annulation du bail portant sur le bureau du Membre exclu ainsi que des autres services de support.

Art. 17.  La  démission,  l'exclusion,  la  faillite  ou  l'insolvabilité,  la  dissolution  ou  la  fusion  d'un  des  Membres,  autre

qu'Arkus, n'engendrera pas la dissolution du Groupement.

La démission, l'exclusion, la faillite ou l'insolvabilité, la dissolution ou la fusion d'Arkus, provoquera la dissolution du

Groupement.

D. Gérance du Groupement

Art. 18. Le Groupement est géré par un ou plusieurs gérants.
Si plusieurs gérants sont nommés, le Groupement est géré par un conseil de gérance.
Le gérant unique ou le conseil de gérance coordonne et organise les activités du Groupement et il est également en

charge de:

- la gestion journalière du Groupement;
- l'établissement de tous les décomptes de dépenses, y compris le Décompte Trimestriel et le Décompte Final;
- demander aux Membres de participer au paiement des dépenses du Groupement conformément à l'article 7. qui précède;
- la convocation de l'assemblée générale des Membres;
- l'évaluation de la qualité des services fournis au Groupement par Arkus, ou par tout autre prestataire.
Le Groupement est valablement engagé par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Dans le cas

d'un gérant unique, la seconde signature d'un autre Membre sera requise.

Le gérant unique ou conseil de gérance adressent un rapport d'activité aux Membres sur une base trimestrielle.
Un gérant peut être une personne morale ou une personne physique.
Si le gérant est une personne morale, à sa désignation, celle-ci informera le Groupement, par lettre recommandée, de

l'identité de son représentant permanent, qui devra être une personne physique.

Sans préjudice de la responsabilité solidaire qui incombe au gérant, le représentant permanent sera soumis à la même

responsabilité civile et pénale que celle applicable au(x) Gérant(s) du Groupement.

Le représentant permanent d'un gérant sera désigné pour la même durée que le gérant. Une telle représentation sera

confirmée à chaque renouvellement du mandat du gérant.

En cas de démission, de destitution, de mort ou d'incapacité de son représentant permanent, le gérant informera le

Groupement, par lettre recommandée, de cet événement et de l'identité de son nouveau représentant permanent.

Le(s) Gérant(s) est (sont) désigné(s) par une décision prise à l'unanimité des Membres conformément à l'article 10. qui

précède, laquelle fixe également la durée de son/leur mandat ainsi que sa/leur rémunération.

Tout gérant peut être révoqué avec ou sans motif par une décision unanime de tous les Membres prise conformément à

l'article 10. qui précède. Si le gérant est un Membre, ce Membre à exclure ne sera pas autorisé à participer au vote.

Le conseil de gérance ou le gérant unique peut concéder des pouvoirs spéciaux par procuration authentique ou sous

seing privé.

22404

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Le conseil de gérance se réunit sur convocation de deux Membres du conseil de gérance, à l'endroit indiqué

dans l'avis de convocation.

Une convocation écrite à toute réunion du conseil de gérance sera adressée par e-mail ou par courrier à tous les membres

du conseil de gérance au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas
la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette
convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme ou télécopieur, ou tout autre
moyen de communication similaire. Une telle convocation ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se
tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Un gérant ou un représentant permanent d'un gérant personne morale, pourra se faire représenter à toute réunion du

conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme ou télécopie un autre gérant ou représentant permanent
d'un gérant comme son mandataire.

Un gérant ou un représentant permanent d'un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou

par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par télécopieur ou tout autre moyen de communication, à confirmer par écrit. Le tout ensemble constituant le
procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 20. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par les gérants présents à cette réunion.

Les copies ou extraits des résolutions du gérant unique ou des procès-verbaux du conseil de gérance seront communiquées
aux Membres.

Art. 21. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution du Groupement.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 22. L'année sociale du Groupement commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 23. Chaque année, au 31 décembre, les comptes annuels (le bilan, le compte de profits et pertes et les annexes) sont

arrêtés et le ou les gérant(s) dresse(nt) un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives du Groupement.
Tout Membre peut prendre communication au siège social du Groupement de l'inventaire et du bilan.

L'assemblée générale des Membres approuve ledit inventaire et ledit bilan dans les six mois de la clôture de l'exercice

auquel ils se rapportent.

L'assemblée générale des Membres peut désigner un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises aux fins de vérifier les comptes

annuels.

Le Groupement n'est pas lui-même impliqué dans la distribution de bénéfices ou dans la répartition des bénéfices ou

des pertes. Les bénéfices peuvent être attribués en partie ou en totalité aux comptes de réserves.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. Le Groupement sera dissout par:
- la démission, l'exclusion, la faillite ou l'insolvabilité, la dissolution ou la fusion d'Arkus,
- une résolution prise par l'assemblée générale des Membres, en conformité avec le premier paragraphe de l'article 10.

qui précède.

Art. 25. En cas de dissolution du Groupement, le Groupement sera liquidé par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont

pas besoin d'être des Membres, et qui seront nommés par l'assemblée générale des Membres, laquelle fixera leurs pouvoirs
et leur rémunération. Sauf disposition contraire, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs
et payer les dettes du Groupement, conformément aux articles 22 (3), (4), (5) de la Loi de 1991.

En l'absence d'une décision désignant une personne spécifique en tant que liquidateur, le conseil de gérance ou le gérant

unique agira comme liquidateur(s).

L'excédent résultant de la réalisation des actifs du Groupement et le paiement des dettes du Groupement sera partagé

entre les Membres en proportion de leurs parts dans le Groupement.

G. Dispositions générales

Art. 26. Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent Contrat, les Membres s'en réfèrent aux dispositions de la Loi de

1991 et de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 27. Ce Contrat est obligatoire et exécutoire pour ses Membres.

22405

L

U X E M B O U R G

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale débutera à la date de la formation du Groupement et se terminera le 31 décembre 2016.

<i>Assemblée générale des Membres

Aussitôt après à la signature du présent Contrat, les Membres soussignés représentant l'intégralité des Membres du

Groupement et se considérant comme dûment convoqués, se sont immédiatement réunis afin de procéder à l'Assemblée
Générale.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, les Membres ont pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1) Le nombre de gérants est fixé à un.
2) Mr Yves Jacobé de Naurois, né le 7 juillet 1948 à Talence (France), demeurant professionnellement à 6B route de

Trêves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé au poste de gérant unique du Groupement pour
une durée illimitée.

Les Membres déclarent que le présent Contrat est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; le texte anglais

fera foi en cas de divergences entre les deux.

Les Membres Fondateurs ont dûment signé ce Contrat ou l'on fait dûment signer, même date qu'en tête.

Fait à Luxembourg en six originaux, l'un ayant été déposé auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

et chaque Membre Fondateur accusant réception d'un original.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015199077/592.
(150224016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2015.

DJ IMMO S.A., Société Anonyme,

(anc. BAUTEC Rénovations &amp; Energie S.A.).

Siège social: L-9227 Diekirch, 20, Esplande.

R.C.S. Luxembourg B 95.950.

L'an deux mille quinze, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

S'est réunie:

l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme «BAUTEC Rénovations &amp; Energie S.A.», (matr. 2006 2209

845), avec siège social à L-9415 Vianden, 3, route de Bettel,

constituée originairement sous la dénomination de LES ARTIFICIERS suivant un acte reçu par le notaire Marc Cravatte,

de résidence à Ettelbruck, en date du 17 novembre 1987, publié au Mémorial C numéro 36 du 11 février 1988 et dont les
statuts ont été modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois suivant un acte reçu par Maître Urbain Tholl, notaire
de résidence à Mersch, en date du 20 juillet 2007, publié au Mémorial C numéro 2051 du 21 septembre 2007, modifiée,
en adoptant la dénomination actuelle, suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 mai 2010, publié au
Mémorial C numéro 1380 du 6 juillet 2010, ayant changé ses statuts pour la dernière fois le 30 août 2013, publié au Mémorial
C numéro 2701 du 29 octobre 2013,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 95.950.
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur José FERNANDES DOS SANTOS, retraité,

demeurant à L-8360 Goetzingen, 3C, rue des Champs;

L'assemblée décide à l'unanimité de renoncer à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.
Le Président de l'assemblée expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que le présent acte a pour objet de:
1. Changement de l’objet social et modification de l’article 2 des statuts.
2. Changement de la dénomination sociale et du siège social
3. Réorganisation du Conseil d’administration
4. Divers
I..-  Que  les  actionnaires  présents  ou  représentés,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés,  ainsi  que  le  nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur»
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été

signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

22406

L

U X E M B O U R G

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-

tration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer l’objet social de la société et de modifier par conséquent l’article 2 des statuts

qui aura la teneur suivante:

« Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la promotion et la mise en valeur de tous projets immobiliers sur le

territoire luxembourgeois.

Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou

réelle, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société exercera son activité au Grand-Duché de Luxembourg.
De façon générale, la société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobi-

lières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou favoriser la réalisation.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société et de changer le siège social de la société

pour le transférer à L-9227 Diekirch, 20 Esplanade;

En conséquence l'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  II est formé une société anonyme sous la dénomination de DJ IMMO S.A.

Cette société aura son siège social à Diekirch.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la localité

du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale des
actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait
obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d’Admi-
nistration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social dans
un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de Monsieur Jean-Paul NAGEL en tant qu'administrateur et ad-

ministrateur-délégué de la société avec décharge pour l’exercice de ses fonctions selon les termes de la convention sous
seing privé datée du 21 mai 2015, dont copie est annexée aux présentes, après avoir été signée «ne varietur» par les parties
comparantes et le notaire instrumentaire, et de Monsieur Percy RAUCHS de son mandat de directeur.

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
1) Monsieur Dominique BOUTAY, ingénieur, né le 24 janvier 1955 à Rocourt (B) demeurant à L-8351 Goeblange,

19A, rue de Windhof;

2) Madame Adelia Maria LOPES SIMOES, employée, née le 14 octobre 1981 à Soure (P) demeurant à L-8360 Goe-

tzingen, 3C, rue des Champs

3) Monsieur Sérgio FERNANDES DOS SANTOS, né le 20 octobre 1972 à Luxembourg-ville, demeurant à L-3326

Crauthem, 18, rue de Bettembourg, qui est également nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société
pour les affaires journalières avec sa signature et la signature conjointe d’un administrateur.

Monsieur Carlos SARAIVA, comptable, né le 10 février 1981 à Albergaria (P), demeurant professionnellement à L-9227

Diekirch, 20, Esplanade, est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans, en remplacement de la société
C.F.N. GESTION S.A., avec siège à L-9227 Diekirch, 20, Esplanade, RCS B 143.390.

22407

L

U X E M B O U R G

<i>Loi anti blanchiment

En application de la loi du 12 novembre 2004, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels de cette opération et

déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du
code pénal luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à environ 900,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: José FERNANDES DOS SANTOS, Dominique BOUTAY, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 27 novembre 2015. Relation: DAC/2015/20330. Reçu soixante-quinze euros

75,00.-€.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 9 décembre 2015.

Référence de publication: 2015199156/103.
(150223539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2015.

Beaconinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 101.312.

L'an deux mille quinze, le trente novembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BEACONINVEST S.A.", ayant son siège social à L-2453

Luxembourg, 6 rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg section B numéro 101312, constituée suivant acte reçu par Maître
Léon Thomas dit Tom METZLER, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de Luxembourg),
en date du 15 juin 2004, publié au Mémorial C numéro 828 du 12 août 2004, et dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois par acte reçu par Maître Francis KESSELER, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de
Luxembourg), en date du 5 juin 2014, publié au Mémorial C numéro 2200 du 19 août 2014.

Le capital social est fixé à dix-neuf millions neuf cent cinquante mille euros (EUR 19.950.000) représenté par treize

mille six cent cinquante et une (13.651) actions sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Jun-

glinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster,

3, route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution de la société et liquidation de ses avoirs.
2. Nomination de la société à responsabilité limitée "I.L.L. Services S.à r.l.", ayant son siège social à L-2453 Luxem-

bourg, 6 rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg B 153141, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus
par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats.
4. Divers.
II Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée
"ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, sera gardée à l’étude de celui-ci.

22408

L

U X E M B O U R G

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur de la société, la société à responsabilité limitée "I.L.L. Services S.à r.l.", ayant

son siège social à L-2453 Luxembourg, 6 rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg B 153141.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi pour exécuter son mandat, et notamment par

les articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de
l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

<i>Troisième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la société, à savoir Monsieur Sébastien ANDRE,

président du conseil d’administration, Madame Astrid BETZ, administrateur et Madame Monique JUNCKER, adminis-
trateur,  ainsi  qu'au  commissaire  de  la  société,  à  savoir  la  société  à  responsabilité  limitée  COMCOLUX  S.à  r.l.,  pour
l'exécution de leurs mandats respectifs.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à 2.100,- EUR.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bob PLEIN, Henri DA CRUZ, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 02 décembre 2015. Relation GAC/2015/10498. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015199157/66.
(150223358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2015.

Black Quantum Private Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 183.300.

In the year two thousand fifteen, on the fifteenth of October,
before the undersigned Maître Martine Schaeffer notary, residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders of “Black Quantum Private Equity S.A.” (hereafter, referred to as the

“Company”), a public limited liability company ("société anonyme" or “S.A.”), governed by the laws of the Grand-Duchy
of Luxembourg, in particular, the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time, having
its registered office at 23, route d’Arlon, L-8009 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register (the “R.C.S.”) under number B 183.300 (the “Company”), incorporated by a deed
of the undersigned notary dated December 13 

th

 , 2013, published in the Mémorial C, number 455 of February 19 

th

 , 2014.

Which Articles of Incorporation have not been amended since.

The meeting is presided by Mr Gianpiero SADDI, private employee, professionally residing in Luxembourg;
who appoints as secretary Mrs Alexandra FUENTES, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Gianpiero SADDI, prenamed.
The Chairman declares and the Meeting agrees that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by the shareholders are shown on an attendance

list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the
proxies “ne varietur” will be registered with this deed.

22409

L

U X E M B O U R G

II.  It  appears  from  the  attendance  list,  that  all  the  shares,  representing  the  entirety  of  the  subscribed  capital  of  the

Company, are represented in this extraordinary general assembly.

III. The shareholders declare that they have been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all

convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide
on the agenda of the meeting.

IV. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Decision to appoint until the general annual shareholders’ meeting which will be held in 2017:
- Mr Giovanni PATRI, category A director, as Chairman of the board of directors of the Company, and
- Mrs Marine SCHRUB, born on 28 October 1986 in Chalons en Champagne (France), residing in 86, rue Général de

Gaulle, F-57330 Hettange-Grande (France), as new member of the board of directors (Category A) as of the present date;

- Mr Raphaël BONFIGLIOLI, as a new member of the board of directors (Category) as of the present date;
2. Decision to change the registered office of the company from 23, route d’Arlon, L-8009 Strassen to 127, rue de

Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

3. Decision to acknowledge and to accept the resignation of Mrs Milena Radulovic, residing in 12, rue André Duchscher,

L-1424 Luxembourg, as a member of the board of directors as of the present date and to fully grant discharge for the
execution and performance of her mandate until that date.

After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

<i>First resolution

The Meeting resolves to appoint, until the general annual shareholders’ meeting which will be held in 2017:
- Mr Giovanni PATRI, category A director, as Chairman of the board of directors of the Company.
- Mrs Marine SCHRUB, born on 28 October 1986 in Chalons en Champagne (France), residing in 86, rue Général de

Gaulle, F-57330 Hettange-Grande (France), as new member of the board of directors (Category A director) as of date of
the present deed,;

- Mr Raphaël BONFIGLIOLI, born on 8 November 1975 in Tubize (Belgique), residing in 13, Boucle des Hirondelles,

F-57970 Koenigsmacker (France) as new member of the board of directors (Category B director) as of the date of the
present deed.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to transfer the registered office from 23, route d’Arlon, L-8009 Strassen to 127, rue de Mühlenbach,

L-2168 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and accordingly to amend article 2. «Registered office» as follows:

“ 2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2.2. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the

sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its
shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3. The board of directors of the Company (the "Board of Directors" or the "Board") is authorized to change the address

of the Company inside the municipality of the Company’s registered office.

2.4. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely

to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be
provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will
not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company. The
decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.

2.5. The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.”

<i>Third resolution

The Meeting resolves to acknowledge and to accept the resignation of Mrs Milena Radulovic, residing in 12, rue André

Duchscher, L-1424 Luxembourg, as a member of the board of directors as of the present date and to fully grant discharge
for the execution and performance of her mandate until the date of the present deed.

<i>Expenses

The expenses, costs, earnings or loads in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this

act amount to approximately one thousand two hundred euro (EUR 1.200.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

22410

L

U X E M B O U R G

The notary who understands and speaks English states that demand the present deed is worded in English followed by

a French translation. At the request of these people and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le quinze octobre.
Par devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signé;

S'est réunie

l’assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  Black  Quantum  Private  Equity  S.A.,  une  société  anonyme,

établie selon les lois applicables au Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée de temps à autres (la «Loi de 1915»), ayant son siège social au 23, route d’Arlon, L-8008
Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 183.300 (la «Société»), constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 13 décembre 2013, publié au
Mémorial C, numéro 455 du 19 février 2014. Dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg;
Le président désigne comme secrétaire Madame Alexandra FUENTES, employée privée, résidant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, prénommé.
Ensuite Monsieur le président prie le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée générale extraordinaire, les procurations des actionnaires re-

présentés et le nombre d’actions qu'ils détiennent sont renseignées sur une liste de présence. Cette liste et les procurations,
après avoir été signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour
être enregistrées avec lui.

II. Il ressort de la liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont représentées à

la présente assemblée.

III. Les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l’ordre du jour de l'assemblée et renoncent à toutes

les exigences de convocation et à toutes les formalités. L’assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Agenda

1. Décision de nommer:
- Mr Giovanni PATRI, administrateur de catégorie A, en tant que Président du Conseil d’administration, et
- Mme Marine SCHRUB, née le 28 Octobre 1986 à Chalons en Champagne (France), demeurant au 86, rue Général de

Gaulle, F-57330 Hettange-Grande (France), en tant que nouveau membre du Conseil d’administration (Catégorie A) à
partir du present acte;

- Mr Raphaël BONFIGLIOLI, en tant que nouveau membre du Conseil d’administration (Catégorie B) à partir du present

acte;

2. Décision de transférer le siège social de la société du 23, route d’Arlon, L-8009 Strassen au 127, rue de Mühlenbach,

L-2168 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

3. Décision de reconnaître et d'accepter la démission de Mme Milena Radulovic, demeurant à 12, rue André Duchscher,

L-1424 Luxembourg, en tant que membre du conseil d'administration à compter de la présente date et à accorder pleine
décharge pour l'exécution et la performance de son mandat jusqu'à cette date.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de nommer, jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017:
- Mr Giovanni PATRI, administrateur de catégorie A, en tant que Président du Conseil d’administration, et
- Mme Marine SCHRUB, née le 28 Octobre 1986 à Chalons en Champagne (France), demeurant au 86, rue Général de

Gaulle, F-57330 Hettange-Grande (France), en tant que nouveau membre du Conseil d’administration (administrateur de
Catégorie A) à partir du présent acte;

- Mr Raphaël BONFIGLIOLI, né le 8 novembre 1975 à Tubize (Belgique), demeurant au 13, Boucle des Hirondelles,

F-57970 Koenigsmacker (France), en tant que nouveau membre du Conseil d’administration (administrateur de Catégorie
B) à partir du présent acte.

22411

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société du 23, route d’Arlon, L-8009 Strassen au 127, rue

de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et, par conséquent de modifier l’article 2 «Siège
Social» des statuts comme suit:

“ 2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2. Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une réso-

lution de l’actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de
ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3. Le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration" ou le "Conseil") est autorisé à changer

l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.4. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produisent ou sont imminents, le siège social
peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois
cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité
luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Administration.

2.5. La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.”

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide reconnaître et d'accepter la démission de Mme Milena Radulovic, demeurant à 12, rue

André Duchscher, L-1424 Luxembourg, en tant que membre du conseil d'administration à compter de la date du présent
acte et à accorder pleine et entière décharge pour l'exécution et la performance de son mandat jusqu'à cette date.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents
euros (EUR 1.200.-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande des comparants le présent acte

est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi, A. Fuentes et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 26 octobre 2015. Relation: 2LAC/2015/23981. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Référence de publication: 2015199145/167.
(150224223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2015.

Apache International Finance, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 92.676.

In the year two thousand and fifteen, on the first day of December,
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Was held

an extraordinary general meeting of Apache International Finance, a société à responsabilité limitée (private limited

liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with regis-
tered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD
20,000 and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Register of Trade and Companies)
under number B 92.676 (the “Company”).

22412

L

U X E M B O U R G

There appeared,

Apache International Holdings, a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated

and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 6, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 20,000 and registered with the Luxem-
bourg Registre de Commerce et des Sociétés (Register of Trade and Companies) under number B 173.614 (the “Sole
Shareholder”).

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg,

by virtue of power of attorney.

The said power of attorney, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The 20,000 (twenty thousand) shares representing the whole share capital of the Company were represented so that the

meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the Shareholders have been duly informed.

The Sole Shareholder, through its proxy holder, requested the notary to enact that the agenda of the meeting was the

following:

<i>Agenda

1) Increase of the share capital of the Company by the creation and the issuance of new shares with a nominal value of

USD 1 each;

2) Subscription and payment of the new shares by way of a contribution in kind by the sole shareholder of the Company;

and

3) Decrease of the share capital of the Company;
4) Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, represented as stated hereinabove, the following resolutions

have been taken:

<i>First resolution

It was resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 4,790,986,054 (four billion seven

hundred ninety million nine hundred eighty-six thousand fifty-four US Dollars) so as to raise it from its current amount of
USD  20,000  (twenty  thousand  US  Dollars)  to  USD  4,791,006,054  (four  billion  seven  hundred  ninety-one  million  six
thousand fifty-four US Dollars) by the issuance of 4,790,986,054 (four billion seven hundred ninety million nine hundred
eighty-six thousand fifty-four) new shares with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each.

<i>Second resolution

It was resolved to accept that all the 4,790,986,054 (four billion seven hundred ninety million nine hundred eighty-six

thousand fifty-four) new shares of the Company with a nominal value of USD 1 be fully subscribed by the Sole Shareholder
by the conversion of a receivable it holds against the Company for an amount of USD 4,790,986,054 (four billion seven
hundred ninety million nine hundred eighty-six thousand fifty-four US Dollars) (the “Receivable”) into share capital of the
Company by way of contributing the Receivable to the Company in exchange for 4,790,986,054 (four billion seven hundred
ninety million nine hundred eighty-six thousand fifty-four) new shares of the Company with a nominal value of USD 1
(one US Dollar) each (the “Contribution”).

<i>Subscription - Payment

Apache International Holdings, through its proxy holder, declared to fully subscribe to the above mentioned increase

of capital of USD 4,790,986,054 (four billion seven hundred ninety million nine hundred eighty-six thousand fifty-four
US Dollars) by subscribing to all the 4,790,986,054 (four billion seven hundred ninety million nine hundred eighty-six
thousand fifty-four) new shares of the Company with a nominal value of USD 1, the whole being fully paid up by the
Contribution.

<i>Evaluation

The value of the Receivable is set at USD 4,790,986,054 (four billion seven hundred ninety million nine hundred eighty-

six thousand fifty-four US Dollars).

Such contribution has been valued by all the managers of the Company, pursuant to a statement of contribution value,

which has been produced to the notary.

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary.

<i>Effective implementation of the contribution

Apache International Holdings, contributor represented as stated here-above, expressly declared that:
(i) the Receivable is certain, liquid and payable;
(ii) it is the sole legal owner and holder of all rights, title and interest in and to the Receivable;

22413

L

U X E M B O U R G

(iii) the Receivable is free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
(iv) the Receivable is not the object of a dispute or claim;
(v) the Receivable is freely transferable, with all the rights attached thereto; and
(vi) all formalities subsequent to the transfer of the Receivable required under any applicable law have or will be carried

out in order for the contribution to be valid anywhere and towards any third party.

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervened:
- Mr. Jon W. Sauer, type A manager of the Company; and
- Mr. Emmanuel Natale and Mrs. Marjorie Allo, type B managers of the Company,
each of them represented here by Mr Max Mayer, by virtue of a power of attorney.
Acknowledging having been previously informed of the extent of their liabilities, engaged as managers of the Company

by reason of the contribution in kind described above, expressly agreed with the description of the contribution in kind,
with its valuation, with the effective transfer of the Apache International Holdings Receivable, and confirmed the validity
of the subscription and payment.

<i>Third resolution

It was resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of USD 4,790,986,054 (four billion seven

hundred ninety million nine hundred eighty-six thousand fifty-four US Dollars) so as to reduce it from the amount of USD
4,791,006,054 (four billion seven hundred ninety-one million six thousand fifty-four US Dollars) to USD 20,000 (twenty
thousand US Dollars) by way of redemption of 4,790,986,054 (four billion seven hundred ninety million nine hundred
eighty-six thousand fifty-four) shares of the Company with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each and subsequent
cancellation thereof.

It was noted that the Company will pay the redemption price, amounting to USD 4,790,986,054 (four billion seven

hundred ninety million nine hundred eighty-six thousand fifty-four US Dollars) to the Sole Shareholder by way of a payment
in kind and cash.

It was noted that further to this resolution, the amount of the share capital of the Company is of USD 20,000 (twenty

thousand US Dollars) represented by 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 each.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 8,300.-.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le premier jour du mois de décembre,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie

une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de Apache International Finance, société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, ayant un capital social de 20.000 USD et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 92.676 (la «Société»).

A comparu,

Apache International Holdings, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6 rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 20.000 USD et immatri-
culée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173.614 (l’«Associé Unique»);

ici représentée par M. Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce

dernier.

22414

L

U X E M B O U R G

Le président prie le notaire d'acter que les 20.000 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société

étaient représentées, de sorte que l'assemblée a pu décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont
l’Associé Unique, a été préalablement informé.

L’Associé Unique, représenté par son mandataire, a prié le notaire d’acter que l’ordre du jour de l'assemblée est le

suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la Société par la création et l’émission de nouvelles parts sociales d’une valeur

nominale de 1 USD chacune;

2) Souscription et paiement des nouvelles parts sociales par un apport en nature de l’associé unique de la Société;
3) Réduction du capital social de la Société; et
4) Divers.
Après que l’agenda a été approuvé par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il a été décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 4.790.986.054 USD (quatre milliards sept

cent quatre-vingt-dix millions neuf cent quatre-vingt-six mille cinquante-quatre US Dollars) ) pour le porter de son montant
actuel de 20.000 USD (vingt mille US Dollars) à 4.791.006.054 USD (quatre milliards sept cent quatre-vingt-onze millions
six mille cinquante-quatre US Dollars) par l’émission de 4.790.986.054 (quatre milliards sept cent quatre-vingt-dix millions
neuf cent quatre-vingt-six mille cinquante-quatre) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un US Dollar)
chacune.

<i>Deuxième résolution

Il a été décidé d’accepter que les 4.790.986.054 (quatre milliards sept cent quatre-vingt-dix millions neuf cent quatre-

vingt-six mille cinquante-quatre) nouvelles parts sociales de la Société d’une valeur nominale de 1 USD (un US Dollar)
chacune soient souscrites par l’Associé Unique par la conversion d’une créance détenue à l’encontre de la Société d’un
montant de 4.790.986.054 USD (quatre milliards sept cent quatre-vingt-dix millions neuf cent quatre-vingt-six mille cin-
quante-quatre US Dollars) (la «Créance») en capital de la Société par contribution de la Créance par l’Associé Unique à
la Société en échange de 4.790.986.054 (quatre milliards sept cent quatre-vingt-dix millions neuf cent quatre-vingt-six
mille cinquante-quatre) nouvelles parts sociales de la Société d’une valeur nominale de 1 USD (un US Dollar) chacune (la
«Contribution»).

<i>Souscription - Paiement

L’Associé Unique, représenté par son mandataire, nommé ci-dessus, a déclaré souscrire à l’augmentation de capital

susmentionnée d’un montant de 4.790.986.054 USD (quatre milliards sept cent quatre-vingt-dix millions neuf cent quatre-
vingt-six mille cinquante-quatre US Dollars) en souscrivant à l’ensemble des 4.790.986.054 (quatre milliards sept cent
quatre-vingt-dix millions neuf cent quatre-vingt-six mille cinquante-quatre) nouvelles parts sociales de la Société d’une
valeur nominale de 1 USD (un US Dollar) chacune, la totalité devant être entièrement libérée par la Contribution.

<i>Evaluation

La valeur de la Créance a été fixée à 4.790.986.054 USD (quatre milliards sept cent quatre-vingt-dix millions neuf cent

quatre-vingt-six mille cinquante-quatre US Dollars).

Cet apport a été évalué par tous les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l’apport qui

a été fournie au notaire.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Mise en oeuvre effective de l’apport

L’Associé Unique, apporteur représenté comme indiqué ci-dessus, a déclaré expressément que:
(i) la Créance est certaine, liquide et exigible;
(ii) il est seul propriétaire, et le seul détenteur, des droits, titres et intérêts attachés à la Créance;
(iii) la Créance est libre de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;
(iv) la Créance ne fait l’objet d’aucune contestation ou action en justice;
(v) la Créance est librement transférable, avec tous les droits y attachés; et
(vi) l’ensemble des formalités subséquentes au transfert de la Créance requise en vertu de loi applicable seront accomplies

afin que la contribution soit valable en tout lieu et à l’égard de tout tiers.

<i>Intervention des gérants

Ci-après sont intervenus:

22415

L

U X E M B O U R G

- M Jon W. Sauer, gérant de type A de la Société;
- M Emmanuel Natale et Mme Marjorie Allo, gérants de type B de la Société,
chacun étant représenté par M. Max Mayer, préqualifié, en vertu d’une procuration.
Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité de gérants de la Société engagée en

raison de l’apport en nature décrit ci-dessus, chacun d’eux ont accepté expressément la description de l’apport en nature,
son évaluation, et le transfert effectif de la Créance, et a confirmé la validité de la souscription et du paiement.

<i>Troisième résolution

Il a été décidé de réduire le capital social de la Société d’un montant de 4.790.986.054 USD (quatre milliards sept cent

quatre-vingt-dix millions neuf cent quatre-vingt-six mille cinquante-quatre US Dollars) afin de le réduire de son montant
de 4.791.006.054 USD (quatre milliards sept cent quatre-vingt-onze millions six mille cinquante-quatre US Dollars) à un
montant de 20.000 USD (vingt mille US Dollars) par le rachat de 4.790.986.054 (quatre milliards sept cent quatre-vingt-
dix millions neuf cent quatre-vingt-six mille cinquante-quatre) parts sociale de la Société d’une valeur nominale de 1 USD
(un US Dollar) et leur annulation subséquente.

Il a été noté que la Société paiera le prix de rachat s’élevant à 4.790.986.054 USD (quatre milliards sept cent quatre-

vingt-dix  millions  neuf  cent  quatre-vingt-six  mille  cinquante-quatre  US  Dollars)  à  l’Associé  Unique,  au  moyen  d’un
paiement en nature et en numéraire.

Il a été noté que, suite à cette résolution, le capital social de la Société est d’un montant de 20.000 USD (vingt mille US

Dollars) divisé en 20.000 (vingt mille) parts sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un US Dollar) chacune.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en raison

des présentes ou qui pourrait être dû au regard de cette augmentation de capital est évalué à environ 8.300,-EUR.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'entête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 décembre 2015. Relation GAC/2015/10581. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015199065/203.
(150224219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2015.

Artic Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 147.289.

Le bilan approuvé au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001826/10.
(150241275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Wood Trade Center S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 4, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 66.421.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016001753/10.
(150239831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

22416


Document Outline

21A S.à r.l.

Actis Morocco Energy Holdings Limited

AGI Holding S.A.

Agri-Center S.A.

AJR Participations II S.A.

AJR Participations II S.A.

AJR Participations S.A.

AJR Participations S.A.

Albatros Participations Industrielles S.A.

Alexandros S.à r.l.

Alexandros S.à r.l.

All Consulting Company S.à r.l.

ALLIANCE SICAV-SIF S.A.

Amigo Investments Lux S.à r.l.

Apache International Finance

Arkus Partners G.I.E.

Artic Holding S.A.

BAUTEC Rénovations &amp; Energie S.A.

Beaconinvest S.A.

Beobank Funds

Black Quantum Private Equity S.A.

Boga S.A.

Café Academica S.à r.l.

Capital Project S.A.

CFC Reinsurance S.A.

Charger Lux HoldCo II (Offshore) S.à r.l.

Charger Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l.

Chauffage &amp; Sanitaire Heinen Steve S.à r.l.

Cleaning Management Services S.à r.l.

CNOOC Luxembourg Holding S.à r.l.

CNOOC Luxembourg S.à r.l.

Codex Events S.A.

COLUMBIA International Consulting sàrl

Compagnie Sud-Express S.A.

CTC-Invest S.A.

Dania Presents S.à r.l.

Decapterus Holding S.à r.l.

Dimensions 3 Soparfi S.A.

DJ IMMO S.A.

Findus Manco S.C.A.

manatee consilium

Wahl &amp; May S.A.

Wanda S.A., SPF

Warlander Sàrl

Wharf Properties S.à r.l.

Wood Trade Center S.A.

XEMXIJA S.A. SPF

YM S.A.

Zuang Distribution S.A.