This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 450
16 février 2016
SOMMAIRE
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.
3) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21568
Balham Holding S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21554
Baltar Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21555
Baurora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21556
BBTPS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21554
Bears & Sons S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21556
Bilfinger FRB S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21556
Biosystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21557
Black Quantum Global Ventures S.A. . . . . . . .
21555
Blue Star Shipping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21558
Breitlecker S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21599
Bridgepoint Europe V Investments (2) S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21554
CaixaBank Global SICAV . . . . . . . . . . . . . . . .
21600
Caladan SPF, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21560
Caliorne 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21560
Camac Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
21554
Camberra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21558
Camper & Nicholsons International S.A. . . . .
21561
Cantillon Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
21559
Carpemundi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21561
Casino Developpement Europe Sàrl . . . . . . . .
21559
CDC Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21562
Cergrafhold S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21562
C. & M. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21558
Concord Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
21560
Cure S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21563
Delos ManCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21564
Demap S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21563
Easy Tabac Alcool S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21564
ECF Cardiff Office S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
21565
Estate Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21565
European Finance Corporation . . . . . . . . . . . .
21565
Experta Corporate and Trust Services S.a., Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21564
F.07 Peintures et Façades . . . . . . . . . . . . . . . . .
21566
F&C Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21566
Fonciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21567
Foretag S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21567
Fourteen Yaw S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21568
GerPoLux Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
21596
Global Fashion Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
21585
Goodman Celadon Logistics (Lux) S.à r.l. . . .
21576
GreenOak European Secured Lending GP S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21593
GreenOak Europe Secured Lending GP S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21593
Hickante S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21590
Iolita Corp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21598
PETOSEVIC Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21560
21553
L
U X E M B O U R G
Bridgepoint Europe V Investments (2) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 193.144.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Référence de publication: 2015197569/10.
(150222295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Balham Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.312.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 135.525.
Suite à la cession de parts intervenue en date du 30 octobre 2015 entre Klenix Limited et Monsieur Anupam Suryakant
Kothari, né à Mumbai, Inde, le 22 juin 1967, résidant au 6, Lacets Saint Léon, 98000 Monaco, les 331.250.000 parts d'une
valeur nominale de EUR 0,01 sont transférées à Monsieur Anupam Suryakant Kothari.
- Monsieur Anupam Suryakant Kothari, détient les 331.250.000 parts sociales de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant Uniquei>
Référence de publication: 2015197575/15.
(150221821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
BBTPS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 152.023.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Référence de publication: 2015197578/10.
(150222254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Camac Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 175.590.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 2 décembre 2015i>
Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 2 décembre 2015 que:
1. La démission de Monsieur Pierre-Siffrein Guillet, administrateur de catégorie B, demeurant professionnellement au
412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg avec effet immédiat est acceptée;
2. La cooptation de Monsieur Philippe Stock, né le 10 septembre 1960 à Gosselies, en Belgique, de nationalité belge,
employé privé, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, au poste d'administrateur de
catégorie B et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur Monsieur Pierre-Siffrein Guillet, adminis-
trateur démissionnaire, avec effet immédiat est acceptée. Le mandat de Monsieur Philippe Stock viendra à échéance lors
de l'assemblée générale statutaire de l'an 2020. La ratification de la cooptation de Monsieur Philippe Stock sera soumise à
la délibération de la prochaine assemblée.
Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2015197607/19.
(150221570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
21554
L
U X E M B O U R G
Black Quantum Global Ventures S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-8008 Strassen, 23, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 183.733.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société en date du 12 novembre 2015i>
L'Assemblée a unanimement pris les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
L'Assemblée décide de prendre acte et d'accepter la démission de:
- Georges Emmanuel ROSMADE, de son mandat d'administrateur de catégorie A,
- Milena RADULOVIC, de son mandat d'administrateur de catégorie B.
<i>Deuxième Résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer jusqu'à la prochaine assemblée annuelle statutaire qui se tiendra en 2016:
- Marine Capucine SCHRUB, née le 28 Octobre 1986 à Châlons-en-Champagne (France), demeurant au 86, rue du
Général de Gaulle, F-57330 Hettange-Grande (France), en tant qu'Administrateur de catégorie B; et
- Raphael Antonio Enrico BONFIGLIOLI, né le 8 Novembre 1975 à Tubize (Belgique), demeurant au 13, Boucle des
Hirondelles, F-57970 Koenigsmacker (France), en tant qu'Administrateur de catégorie B.
<i>Troisième Résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer Giovanni PATRI, né le 18 Août 1975 à Lobbes (Belgique), résidant professionnellement
au 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Administrateur de catégorie A, en tant que Président du Conseil d'adminis-
tration de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle statutaire qui se tiendra en 2016.
Référence de publication: 2015197561/24.
(150222461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Baltar Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 70.748.
EXTRAIT
Il résulte de l'acte de cession du 4 décembre 2015 entre la société PARTS INVEST, société anonyme de droit luxem-
bourgeois, inscrite au Registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 88712, ayant son siège social au 18, rue
Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, ici représentée par son administrateur, Monsieur Frédéric CIPOLLETTI
Et Monsieur Paul ALLEGRINI, né le 29 avril 1970 à Bastia, domicilié au 8, boulevard Paul Eyschen, L-1480 Luxem-
bourg
- Que la société PARTS INVEST prénommée, cède par la présente sa participation qu'elle détient dans la société BAL-
TAR INVEST S.à r.l., prénommée, à savoir 100 parts sociales représentant 100% du capital à Monsieur Paul ALLEGRINI,
prénommé.
Suite à cette cession, les parts sociales de la société BALTAR INVEST sont détenue par:
- Paul ALLEGRINI: 100 parts sociales
Fait à Luxembourg, le 4 décembre 2015.
BALTAR INVEST
Frédéric CIPOLLETTI
Référence de publication: 2015197576/21.
(150221501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
21555
L
U X E M B O U R G
Baurora S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 58.758.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 26 novembre 2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, a en vertu de l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société:
- société BAURORA SA, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, Boulevard Royal, de fait inconnue à cette
adresse
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Laurent LUCAS, juge au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, et liquidateur Maître Cécilia COUSQUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et ordonne aux
créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe du Tribunal de commerce de et à Luxembourg avant le 17
décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Me Cécilia COUSQUER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015197577/22.
(150221733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Bears & Sons S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 54.468.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 4 décembre 2015i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme "BEARS & SONS S.A." tenue
en date du 4 décembre 2015:
que Madame Corinne Marquart Ott a été révoqué de sa fonction d'administrateur,
que Ott&Co SA a été révoqué de sa fonction d'administrateur.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2015197583/15.
(150222318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Bilfinger FRB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstross.
R.C.S. Luxembourg B 62.299.
Im Jahre zweitausendvierzehn,
Den dreiundzwanzigsten November,
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo GOEDERT, mit dem Amtswohnsitz in Düdelingen.
Ist erschienen:
Die Europäische Aktiengesellschaft Bilfinger SE, mit Sitz in D- 68165 Mannheim, Carl-Reiß-Platz 1-5, eingetragen im
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim unter der Nummer 710 296,
hier vertreten durch Herrn Frank Olaf WEGERMANN, Geschäftsführer, wohnhaft in L-6718 Grevenmacher, 19, rue
des Caves, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, Welche Vollmacht gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt um
mit ihr formalisiert zu werden.
Welche Komparentin, hier vertreten wie oben erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:
Bilfinger SE, vorgenannt, ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BILFINGER FRB
S.à r.l., mit Sitz in L-6921 Roodt-sur-Syre, 4A, Banzelt, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister Luxemburg unter
der Nummer B 62299, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den damals in Grevenmacher residierenden Notar
21556
L
U X E M B O U R G
Joseph GLODEN, am 9. Dezember 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
Nummer 209 vom 3. April 1998,
zuletzt abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 19. November 2013, veröffentlicht
im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 3239 vom 19. Dezember 2013.
Die Gesellschafterin erklärt eine Generalversammlung der Gesellschaft abzuhalten und ersucht den amtierenden Notar
folgenden Beschluss zu beurkunden:
<i>Einziger Beschlussi>
Die Gesellschaftsversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von L-6921 Roodt-sur-Syre, 4A, Banzelt, nach L-6868
Wecker, 18, Duchscherstross, zu verlegen und Artikel fünf - Absatz eins der Satzung abzuändern, zwecks Anpassung der
Satzung an diesen Beschluss, um dieser Bestimmung folgenden Wortlaut zu geben:
“ Art. 5. Absatz eins. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wecker.“
Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde in Düdelingen, Datum wie eingangs erwähnt,
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort
bekannten Bevollmächtigten der Komparentin, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.
Signé: F. WEGERMANN, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27822. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): A. SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 04 décembre 2015.
C. GOEDERT.
Référence de publication: 2015197585/42.
(150222413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Biosystem, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 60.867.
<i>Extrait de cession de parts socialesi>
Il résulte d'une convention de cession de parts sous seing privé entre la société International Business Services & Partners
S.A. (en abrégé IBS & Partners S.A.), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A boulevard Royal, enregistrée au
RCS Luxembourg sous le N° B 35973, la société Goudsmit & Tang Management Company, ayant son siège social à L-2449
Luxembourg, 25A boulevard Royal, enregistrée au RCS Luxembourg sous le N° B 41 819 et la société IBOS II Luxembourg
S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A boulevard Royal, enregistrée au RCS Luxembourg sous le N° B
92926
Depuis le 23/11/2015, les associés de la société BIOSYSTEM Sàrl sont composés comme suit:
- IBOS II Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25A boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
RCS Luxembourg: B 92926
70 parts sociales
- Goudsmit &Tang Management Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25A boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
RCS Luxembourg: B 41 819
30 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
(100 parts sociales d'une valeur nominale de 125,00€ chacune soit un capital de 12.500,- €.)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015197586/26.
(150222258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
21557
L
U X E M B O U R G
Blue Star Shipping, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 185.901.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 8 décembre 2015 à Luxembourgi>
<i>Résolution:i>
Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée en date de ce jour par Monsieur Patrick
Haller de sa fonction d'Administrateur de la Société.
Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Antonio Quaratino,
employé privé, demeurant professionnellement au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Mon-
sieur Patrick Haller, démissionnaire.
L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'Assemblée Générale de l'an 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Blue Star Shipping S.A.
Signatures
Référence de publication: 2015197588/18.
(150222273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
C. & M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.
R.C.S. Luxembourg B 45.391.
<i>Résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 3 juillet 2015:i>
Le mandat des administrateurs étant arrivé à son terme, l'assemblée a décidé de nommer jusqu'à l'assemblée statuant sur
les comptes de l'exercice clôturant au 31/12/2020:
- Monsieur Pierre Choquet, domicilié 18, rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, en qualité d'administrateur;
- Madame Christine Laurent, domiciliée 18, rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, en qualité d'administrateur;
- Management Sàrl, dont le siège social est situé 20, avenue Pasteur, L 2310 Luxembourg, en qualité d'administrateur.
Le mandat du commissaire-aux-comptes étant arrivé à son terme, l'assemblée a décidé de nommer jusqu'à l'assemblée
statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31/12/2020:
- Luxfiducia Sàrl, une société ayant son siège social au 20, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 3 juillet 2015:i>
- Le conseil d'administration a nommé Monsieur Pierre Choquet, domicilié 18, rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, en
qualité d'Administrateur-Délégué. Mr Pierre Choquet est également nommé Président du Conseil d'Administration, et ce
jusqu'à l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31/12/2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015197603/21.
(150222253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Camberra S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.300.000,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 141.965.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 7 décembre 2015 à 11.00 heuresi>
<i>Résolution uniquei>
Le conseil d'administration décide de coopter administrateur en remplacement de Monsieur Sabrie Soualmia, Monsieur
Pierre Thielen, né le 28 Septembre 1947 à Ettelbruck, Luxembourg et résident professionnellement au 5, Avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg.
L'élection définitive de Monsieur Thielen sera soumise à la plus proche assemblée générale des actionnaires.
21558
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 7 Décembre 2015.
Pour copie conforme
<i>Pour le conseil d'administration
i>Xavier Mangiullo
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2015197608/18.
(150222233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Cantillon Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 158.523.
EXTRAIT
En date du 7 décembre 2015, l'associé de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de Charlotte Lahaije-Hultman comme gérant B de la société avec effet au 1
er
décembre
2015;
- Nomination au poste de gérant B de Nadine Gloesener, née le 12 janvier 1973 à Esch/Alzette (Luxembourg) et avec
adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet au 1
er
décembre 2015 et pour une
durée indéterminée;
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 07.12.2015.
Référence de publication: 2015197611/16.
(150221829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Casino Developpement Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 11.198.491,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 140.408.
EXTRAIT
1. En date du 1
er
décembre 2015, BSEPEF 1B FCPR, représenté par la société de gestion Bridgepoint SAS; société par
actions simplifié, ayant son siège social au 82, rue de Courcelles F-75008 Paris, France et immatriculée au registre des
sociétés de France sous le numéro 380223313, associé de la Société a cédé la totalité de ses parts, à savoir 2.060.053 parts
sociales à Bridgepoint Capital (Nominees) Limited, ayant son siège social au 95 Wigmore Street,W1U 1FB Londres,
Royaume-Uni et immatriculée au registre des sociétés du Royaume-Uni sous le numéro 3139614.
2. En date du 1
er
décembre 2015, BSEPEF 2 FCPR, représenté par la société de gestion Bridgepoint SAS; société par
actions simplifié, ayant son siège social au 82, rue de Courcelles F-75008 Paris, France et immatriculée au registre des
sociétés de France sous le numéro 380223313, associé de la Société a cédé la totalité de ses parts, à savoir 3.512.413 parts
sociales à Bridgepoint Capital (Nominees) Limited, ayant son siège social au 95 Wigmore Street,W1U 1FB Londres,
Royaume-Uni et immatriculée au registre des sociétés du Royaume-Uni sous le numéro 3139614.
3. En date du 1
er
décembre 2015, BSEPEF 3, représenté par la société de gestion Bridgepoint SAS; société par actions
simplifié, ayant son siège social au 82, rue de Courcelles F-75008 Paris, France et immatriculée au registre des sociétés de
France sous le numéro 380223313, associé de la Société a cédé la totalité de ses parts, à savoir 72.967 parts sociales à
Bridgepoint Capital (Nominees) Limited, ayant son siège social au 95 Wigmore Street,W1U 1FB Londres, Royaume-Uni
et immatriculée au registre des sociétés du Royaume-Uni sous le numéro 3139614.
En conséquence de ce qui précède, BSEPEF 1B FCPR, BSEPEF 2 FCPR et BSEPEF 3 ne détiennent plus de parts
sociales dans la Société et Bridgepoint Capital (Nominees) Limited détient désormais 7.013.519 de parts sociales dans la
Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015197618/28.
(150221841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
21559
L
U X E M B O U R G
Concord Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 187.498.364,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.709.
En date du 3 décembre 2015, l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Démission de Mme. Andrea Smekalova, du poste de gérant de catégorie B avec effet au 30 novembre 2015;
- Nomination de Mme. Katalin Oroszki, née le 30 septembre 1976 à Vàc, Hongrie, ayant pour adresse professionnelle
46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au poste de gérant de catégorie B pour une durée indéterminée et avec
effet au 1
er
décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Concord Luxembourg S.à r.l.
Christiaan F. van Arkel
<i>Gérant de catégorie Bi>
Référence de publication: 2015197632/17.
(150222599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Caladan SPF, S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
R.C.S. Luxembourg B 161.389.
La convention de Domiciliation concernant la société CALADAN SPF, S.A. ayant son siège social au 50, route d'Esch,
L-1470 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 161.389, a été dé-
noncée, avec effet en date du 02/12/2015, par la société International Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l., ayant son
siège social au 50, route d'Esch, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 107.093.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
International Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
50, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
M. Rutledge
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015197640/17.
(150222109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
PETOSEVIC Group, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 149.107.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016000537/9.
(150239158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.
Caliorne 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 160.639.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 1 i>
<i>eri>
<i> décembre 2015.i>
Acceptation de la démission de Madame Tazia BENAMEUR, et des sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVI-
CES S.A. en tant qu'Administrateurs.
Acceptation de la nomination comme nouveaux Administrateurs, à partir de ce jour, de:
- Monsieur Daniel BOONE, né le 28/01/1965 à Lille (France), demeurant professionnellement au 66, boulevard Napo-
léon 1
er
, L-2210 Luxembourg
- Monsieur Christophe LAGUERRE, né le 26/05/1964 à Saint Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 115,
rue du Kiem, L-8030 Strassen
21560
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Francesco Carlo GIORCELLI, né le 14/04/1970 à Milan (Italie), demeurant professionnellement au 5, via
Nassa, CH-6900 Lugano
Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2016.
Acceptation de la démission de Monsieur Eric HERREMANS en tant que Commissaire aux Comptes.
Acceptation de la nomination de la société A3T S.A. dont le siège est au 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1330 Luxembourg comme nouveau Commissaire aux Comptes à partir de ce jour.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2016.
Le siège social est transféré au 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.
<i>Pour la société
i>CALIORNE 2 S.A.
Référence de publication: 2015197642/25.
(150221803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Camper & Nicholsons International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 38.428.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration de la Société tenue en date du 19 décembrei>
<i>2014i>
En date du 19 décembre 2014, le conseil d'administration de la Société a pris la résolution de nommer M. Gualtiero
Tomaso GIORI, actuellement administrateur de la Société, en tant que président du conseil d'administration de la Société,
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue en date du 18 novembrei>
<i>2015i>
En date du 18 novembre 2015, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- de révoquer Monsieur Luca FRACASSI de son mandat d'administrateur de la Société avec effet immédiat;
- de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux administrateurs de la Société avec effet immédiat et ce pour
une durée détermine de trois (3) ans jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra en l'année
2018:
- Monsieur Paolo CASANI, né le 1
er
septembre 1957 à La Spezia, Italie, résidant professionnellement à l'adresse suivante
68, rue du Rhône, 1204 Genève, Suisse; et
- Monsieur Nicola DI GIOVANNI, né le 9 avril 1976 à Paris, France, résidant professionnellement à l'adresse suivante
116, avenue des Champs Élysées, 75008 Paris, France.
Le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Riccardo BONALUMI, administrateur
- Monsieur Gualtiero Tomaso GIORI, administrateur et président du conseil d'administration;
- Monsieur Marco Francesco MAZZU', administrateur
- Monsieur Paolo CASANI, administrateur
- Monsieur Nicola DI GIOVANNI, administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2015.
CAMPER & NICHOLSONS INTERNATIONAL S.A.
Signature
Référence de publication: 2015197645/32.
(150222370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Carpemundi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zare Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 133.801.
Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires du 20.10.2015 que les mandats d'administrateur suivant sont renou-
velés pour une durée indéterminée:
- Madame Fabienne Henrion;
- Monsieur Frédéric Senet,
- Madame Danielle Folliet;
21561
L
U X E M B O U R G
L'assemblée générale constate par ailleurs la modification des qualifications de Madame Fabienne Henrion d'économiste
à responsable administrative et de Madame Danielle Folliet d'employée à retraitée. Le reste des informations en relation
avec les administrateurs reste inchangé.
Il résulte également de cette assemblée la nomination au poste d'administrateur délégué à la gestion journalière de
Monsieur Frédéric Senet résidant 9 ruelle Hustin, B-6887 HERBEUMONT, BELGIQUE pour une durée indéterminé.
Monsieur Frédéric Senet pourra dans le cadre de son mandat d'administrateur délégué engagé valablement par sa seule
signature la société CARPEMUNDI SA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CARPEMUNDI S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015197649/22.
(150222148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
CDC Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 102.048.
<i>Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 juillet 2015i>
Les actionnaires de la société CDC Luxembourg S.A. réunis en Assemblée Générale ordinaire annuelle du 24 juillet,
ont décidé à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
L'assemblée générale constatant que les mandats des administrateurs de:
- Monsieur Jean-Paul LAURENT, gérant de sociétés, demeurant à F-67540 Ostwald, 2A, rue du Docteur Albert Schwei-
tzer (Président du conseil d'administration + administrateur-délégué)
- Madame Edith VERMEULEN, agent administratif, demeurant à F-67540 Ostwald, 2A, rue du Docteur Albert Schwei-
tzer, (administrateur)
- Madame Aurélie SPAHN-LAURENT, sans profession, demeurant à F-04100 Digne-les-Bains, 13, rue Maldonat,
(administrateur)
sont venus à échéance, décide de renouveler leur mandat pour une nouvelle période de six années, c'est-à-dire jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021.
D'autre part, l'assemblée générale constatant que le mandat du commissaire aux comptes de:
- Monsieur René REMY,
est venu échéance, décide de renouveler son mandat pour une nouvelle période de six années, c'est-à-dire jusqu'à l'as-
semblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 24 juillet 2015.
Référence de publication: 2015197654/25.
(150222134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Cergrafhold S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 49.272.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 28 Septembre 2015i>
- L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 2 Place de
Strasbourg L-2562 Luxembourg, avec effet immédiat.
- L'assemblée prend acte de la démission de trois administrateurs de catégorie «B» et un administrateur de catégorie
«A.»:
* Mme Marina Padalino, Administrateur de catégorie «B»
* Mme Manuela D'Amore, Administrateur de catégorie «B»
* CL Management S.A., Administrateur de catégorie «B»
* Mme Mariella Cerutti, Administrateur de catégorie «A»
- L'assemblée décide de réduire le nombre des administrateurs de la Société de 5 à 3 et par conséquent décide de nommer,
avec effet immédiat, deux nouveaux administrateurs de catégorie «B»:
* Monsieur Dominique Audia, demeurant professionnellement au 2, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, Admi-
nistrateur de catégorie «B»;
21562
L
U X E M B O U R G
* Mr Frank Jacopucci, résidant professionnellement au 8 rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, Administrateur de
catégorie «B»;
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.
- L'assemblée constate que le mandat de Monsieur Giancarlo Cerutti, Administrateur de catégorie «A» et Président, a
pour échéance la date de l'assemblée générale qui se tiendra en 2015 et décide alors de prolonger sa date d'échéance jusqu'à
l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.
- L'assemblée prend acte de la démission de l'actuel Commissaire aux comptes, à savoir H.R.T. Révision S.A., 163 rue
du Kiem, L-8030 Strassen.
- L'assemblée décide de pourvoir, avec effet immédiat, à son remplacement en appelant à la fonction de Commissaire
aux comptes la société FCS Services, ayant son siège social 2 Place de Strasbourg L-2562 Luxembourg
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Citco C&T (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2015197659/33.
(150222027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Cure S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, op der Heckmill.
R.C.S. Luxembourg B 146.531.
<i>Niederschrift über die Hauptversammlung der Firma Cure S.A.i>
Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten wir zu einer Versammlung zusammen und beschließen
folgendes:
1. Das Mandat des Herrn Marco Feiten als Verwaltungsratsmitglied wird bis zur nächsten Generalversammlung, die im
Jahre 2016 stattfindet, verlängert.
2. Das Mandat des Herrn Gerd Büttner als Verwaltungsratsmitglied wird bis zur nächsten Generalversammlung, die im
Jahre 2016 stattfindet, verlängert.
3. Das Mandat des Herrn Christian Kistler als Vorsitzender des Verwaltungsrates wird bis zur nächsten Generalver-
sammlung, die im Jahre 2016 stattfindet, verlängert.
4. Das Mandat des Herrn Marco Feiten als Geschäftsführer wird bis zur nächsten Generalversammlung, die im Jahre
2016 stattfindet, verlängert.
5. Das Mandat des Herrn Gerd Büttner als Delegierter des Verwaltungsrates wird bis zur nächsten Generalversammlung,
die im Jahre 2016 stattfindet, verlängert.
6. Das Mandat der Zimmer & Schulz Lux-International SARL-Fiduciaire-Expert Comptable als Rechnungskommissar
wird bis zur nächsten Generalversammlung, die im Jahre 2016 stattfindet, verlängert.
Grevenmacher, den 27. November 2015.
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
Référence de publication: 2015197673/25.
(150221758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Demap S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 103.778.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises à Luxembourg lors de l'assemblée général extraordinaire des actionnairesi>
<i>de la société tenue en date du 4 décembre 2015i>
L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs de la Société suivants:
- Monsieur Sébastien FRANCOIS, Administrateur de catégorie B,
- Madame Anne MAILLARD, Administrateur de catégorie B,
- Monsieur Laurent POLLINA, Administrateur de catégorie A,
- Monsieur Stéphane POLLINA, Administrateur de catégorie A,
- Monsieur Paul POLLINA, Administrateur de catégorie A,
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
clos au 31 décembre 2019.
21563
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue à Luxembourg extraordinairement le 16 no-i>
<i>vembre 2015i>
L'Assemblée décide de nommer MAYFAIR AUDIT S.à r.l., une société à responsabilité limitée, au capital social de
EUR 12,400,-, établie et ayant son siège social à L-7257 Walferdange, 2, Millewee, R.C.S. Luxembourg B 189.753, en
qualité de commissaire aux comptes de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires devant
statuer sur les comptes de l'exercice social clos au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015197696/25.
(150222453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Delos ManCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.797,55.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 199.130.
<i>Extrait des résolutions prises par les Associés en date du 3 décembre 2015i>
- Madame Chantal MATHU, née le 8 mai 1968 à Aye (Belgique), employée privée, résidant professionnellement au
412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), est nommée comme nouveau gérant de catégorie
B, avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.
- Monsieur Daniel FISCHER, né le 13 août 1977 à Francfort (Allemagne), employé privé, résidant professionnellement
au 22/24 Junghofstrasse, D- 60311 Francfort (Allemagne), est nommé comme nouveau gérant de catégorie A, avec effet
immédiat, pour une durée indéterminée.
Fait à Luxembourg, le 7 décembre 2015.
Certifié sincère et conforme
Delos ManCo S.à r.l.
Référence de publication: 2015197684/18.
(150222176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Easy Tabac Alcool S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 147.507.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1 i>
<i>eri>
<i> décembre 2015i>
L'associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Résolution 1:i>
Monsieur Jean-François DELTGEN, demeurant à L-3347 Leudelange, 1b, rue de Cessange, est nommé délégué à la
gestion journalière pour une période indéterminée.
<i>Résolution 2:i>
Monsieur Jean François DELTGEN a le pouvoir d'engager valablement la société à l'égard des tiers, et ce en toutes
circonstances y compris toutes opérations bancaires, par sa signature individuelle.
Rodange, le 1
er
décembre 2015.
Pour extrait conforme
<i>L'associé uniquei>
Référence de publication: 2015197739/18.
(150222244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Experta Luxembourg, Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 29.597.
<i>Extrait de la résolution prise lors de la résolution circulaire du conseil d'administration en date du 7 décembre 2015i>
Démission de Monsieur Adrian LEUENBERGER, de ses fonctions d'administrateur et Président du conseil d'adminis-
tration, avec effet au 5 novembre 2015.
21564
L
U X E M B O U R G
Nomination sous réserve de l'agrément par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) de:
- Monsieur Hans-Peter BORGH, né le 22/06/1973 à De Bilt (Pays-Bas), et demeurant professionnellement au 69, route
d'Esch, L-2953 Luxembourg, au poste d'administrateur et Président du conseil d'administration, avec effet au 5 novembre
2015. son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle de 2020.
La ratification de la cooptation de Monsieur Hans-Peter BORG au poste d'administrateur de la Société sera soumise lors
de la prochaine assemblée générale.
<i>Pour: Experta Corporate and Trust Services S.A., Luxembourg
i>En abrégé Experta Luxembourg Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015197738/20.
(150222005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
ECF Cardiff Office S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 141.114.
EXTRAIT
En date du 20 Novembre 2015, les associés ont pris les résolutions suivantes:
- Le mandat de Audit & Consulting Services S.à r.l., avec siège social au 9-11, rue Louvigny; L-1946 Luxembourg, en
qualité de Réviseur d'entreprise agréé a pris fin avec effet au 20 novembre 2015;
- La société AUMEA Partner S.à r.l., avec siège social au 26-28 rue Edward Steichen; L-2540 Luxembourg, RCS
Luxembourg B 180.716, est nommée nouveau Réviseur d'entreprise agréé pour une période déterminée d'un an qui prendra
fin avec l'assemblée générale des associés qui se tiendra en 2016, avec effet au 20 novembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Walferdange.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015197742/18.
(150222407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Estate Communication, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 146.437.
L'assemblée approuve la cession des parts sociales avec effet 1
er
décembre 2015:
Abc Import-Export Sarl 25A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg: B24112 transfère 27 parts
sociales vers
ROUX Stéphane Né le 20/04/1956 à Paris (France) Domicilié au 41, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg (Luxem-
bourg)
Abc Import-Export Sarl 25A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg: B24112 transfère 60 part so-
ciales vers Life Concept Multispeciality Center Financial S.A. 29 avenue Monterey L-2163 Luxembourg enrégistre
B144531
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 1
er
Décembre 2015.
Référence de publication: 2015197758/17.
(150221804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
European Finance Corporation, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 21.097.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 novembre 2015 qu'il a été procédé à une reconstitution
entière des organes sociaux et qu'ont été:
21565
L
U X E M B O U R G
a) renommé administrateur
- Monsieur Saeed Abbas Ebraheem Yousif AL YOUSIF, né le 1
er
janvier 1980 à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis),
demeurant à 376 Al Barsha Second, 24673, Dubai (Emirats Arabes Unis)
b) nommés nouveaux administrateurs
- Madame Gabriele SCHNEIDER, née le 31 octobre 1966 à Birkenfeld/Nahe (Allemagne), avec adresse professionnelle
à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont
- Madame Dina Abbas Ebraheem Yousef AL YOUSEF, née le 21/09/1981 à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), de-
meurant à Villa 104, Street 4A, Opposite Zoo, Jumeira 1, 24673 Dubai (Emirats Arabes Unis)
pour terminer le mandat des Messieurs Jacques Merkt et Cyril Abecassis.
c) nommé commissaire aux comptes
- Monsieur Jérôme Domange, né le 12 août 1977 à Thionville (France), directeur de société, avec adresse professionnelle
à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, en remplacement de SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE S.A..
Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se
tiendra en l'an 2020.
Luxembourg, le 26 novembre 2015.
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2015197764/28.
(150222332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
F.07 Peintures et Façades, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 7, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 122.896.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2015i>
L'assemblée a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Révocation de Monsieur Paulo APOLINARIO DA SILVA, 8 rue des Eglantines L-57330 ROUSSY-LE-VILLAGE,
de son mandat de gérant administratif.
2. Nomination de Monsieur Gilles CLAUDON, demeurant 2 route d'Audun-le-Tiche F-54190 VILLERUPT, en qualité
de gérant administratif pour une durée indéterminée.
La société préqualifiée est valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
Luxembourg, le 7 décembre 2015.
<i>Pour F.07 Peintures et Façades
i>Fiduciaire des PME
Société anonyme
Signatures
Référence de publication: 2015197768/19.
(150221568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
F&C Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 82.782.
Suite à l'assemblée générale ordinaire du 02 Décembre 2015, les actionnaires de la société F&C FUND, ont pris les
résolutions suivantes:
- Réélection des membres du conseil d'administration de la société, composé comme suit jusqu'à la prochaine assemblée
générale qui se tiendra en 2016:
- Jacques Elvinger
2, Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Luxembourg.
- Hugh Cameron Moir
Pimrose Street, Exchange House, EC2A 2NY Londres, Royaume-Uni.
- Enrico Turchi
4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.
- Patrick Johns
21566
L
U X E M B O U R G
Wheatacre House, Wheatacre, Nr. Beccles, NR34 0AR Norfolk, Royaume-Uni.
- Bernd Kalis
5, Sederanger, 80538 Munich, Allemagne.
- Ernst Hagen
Jachthavenweg 109 E, 1081KM Amsterdam, Pays-Bas
- Réélection de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative: 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Luxembourg,
en tant que réviseur agréée de la société, jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 Décembre 2015.
State Street Bank Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2015197769/28.
(150221922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Fonciem, Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 156.311.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2015i>
Il résulte de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société en date du 14 octobre 2015 une résolution
unique:
1. L'Assemblée prend acte du changement d'adresse de l'administrateur unique, Monsieur Sébastien FÈVE, né le 19
décembre 1978 à Saint-Dié (France) demeurant désormais à L -1740 Luxembourg, 20, Rue de Hollerich.
2. L'Assemblée prend acte du changement d'adresse du commissaire aux comptes, la Société à responsabilité limitée
L'Ex N'Co, inscrite auprès du R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B85931, sise à L-1740 Luxembourg, 20, Rue de
Hollerich.
Luxembourg, le 14 octobre 2015.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015197778/19.
(150221412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Foretag S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 201.489.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 3 décembre 2015, que l'associé unique, AIM Services
S.à r.l., a transféré la totalité des 12.500 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:
- Saturn Grafton S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, ayant son siège
social à l'adresse suivante: 22, Grand Rue, 3
rd
Floor, L-1660 Luxembourg.
En conséquence, la totalité des 12.500 parts sociales de la Société sont désormais détenues par le nouvel associé unique,
Saturn Grafton S.à r.l..
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Foretag S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015197780/19.
(150221380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
21567
L
U X E M B O U R G
Fourteen Yaw S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 181.911.
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 3 décembre 2015, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg de son mandat d'administrateur, avec immédiat;
2. Acceptation de la démission de Christophe Davezac, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg de son mandat d'administrateur, avec immédiat;
3. Acceptation de la démission de José Correia, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg de son mandat d'administrateur, avec immédiat;
4. Nomination d'Isabel de Aquino Ribeiro da Fonseca, avec adresse professionnelle au 3067, Avenida da Boavista,
4100-136 Porto, Portugal, au mandat d'administrateur de classe A, avec effet immédiat et pour une période venant à
échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre
2020 et qui se tiendra en 2021;
5. Nomination de José Correia, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
d'administrateur de classe B, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2020 et qui se tiendra en 2021;
6. Nomination de Paulo Lopes, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
d'administrateur de classe B, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2020 et qui se tiendra en 2021;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Référence de publication: 2015197782/26.
(150222150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.000,00.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 202.039.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the second day of December.
Before the undersigned Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains.
There appeared:
AMP capital Investors (Angel Trains UK. No. 2) S.à r.l., a company incorporated and organized under the laws of
Luxembourg, with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 140.473,
here represented by Mrs. Khadigea Klingele, lawyer, with professional address at Mondorf les Bains,
by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on 30 November 2015.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company ("Société à Responsabilité Limitée") under the name
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.3) S.à.r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of
Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law),
as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case
may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in
21568
L
U X E M B O U R G
the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager
or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations
of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or
otherwise create security over all or over some of its assets. For the avoidance of doubt, the Company shall not carry out
any regulated activities of the financial sector.
3.3 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against currency ex-
change and interest rate risks as well as other risks.
3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at twenty thousand British pounds (GBP 20,000) represented by twenty
thousand (20,000) shares in registered form, each with a par value of GBP 1.-, all subscribed for and fully paid-up.
5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the
general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A share register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law
and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
21569
L
U X E M B O U R G
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general
meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute
a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
7.2 The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.
8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or
not, by the manager, or if there is more than one manager, by any two managers of the Company.
Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the
place indicated in the convening notice.
9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any
two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been
validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
21570
L
U X E M B O U R G
13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of
December.
14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an
indication of the value of the Company's assets and liabilities.
14.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2 The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting and may be distributed to the shareholder(s)
in proportion to her/his/their shareholding in the Company.
15.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased
by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by
each shareholder in the Company.
VII. General provision
Art. 17. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2016.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l., prenamed and represented as stated here-above,
declare to have subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all twenty thousand (20,000)
shares by contribution in cash, so that the amount of twenty thousand British pounds (GBP 20,000) is at the disposal of the
Company, as has been proved to the undersigned notary.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred (EUR 1,300.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as manager of the Company for an indefinite period:
21571
L
U X E M B O U R G
- Adam Petrie, manager, born on 8 February 1985 at Christchurch (New Zealand), with professional address at Level
4, Berkeley Square House, Berkeley Square, London W1J6BX, United Kingdom
- Wim Ritz, manager, born on 14 June 1970 in Merksem (Belgium), with professional address at 15, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
- Fionnuala Doyle, manager, born on 21 April 1978 in Cork (Ireland), with professional address at 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French texts, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day
named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the Notary by name, first name,
civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le deux décembre.
Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.
A COMPARU:
AMP Capital Investors (Angel Trains UK. No.2) S.à r.l., une société constituée et régie selon le droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 15 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 141.473,
ici représentée par Madame Khadigea Klingele, juriste, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 30 Novembre 2015, à elle délivrée.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le représentant de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle partie comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination AMP Capital Investors
(Angel Trains UK No.3) S.à.r.l. («la Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré
dans les limites de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il
peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales,
filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par
souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.
Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra
en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de
quelque nature ou origine que ce soit.
3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/
ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations,
21572
L
U X E M B O U R G
à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit
de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs. En tout état de cause, la Société ne devra pas effectuer une
activité réglementée du secteur financier.
3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de
taux d'intérêt et autres risques.
3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts
de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y
rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à vingt mille livres (GBP 20.000), représenté par vingt mille (20.000) parts sociales sous
forme nominative d’une valeur nominale d’une livre chacun (GBP 1.-), toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé
unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des parts sociales sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
6.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat.
Dans la mesure où plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas néces-
sairement un/des associé(s).
7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.
8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par le gérant, ou s'il y a plusieurs gérants, par deux gérants de la Société.
Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
21573
L
U X E M B O U R G
9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou
représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être
renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme,
télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée.
Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre
moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre
et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme
si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées
sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de
deux gérants ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature
ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit,
soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax
ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés
apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société
seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même
année.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
15.3 Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à
la réserve légale;
21574
L
U X E M B O U R G
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération.
Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est
fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2016.
<i>Souscription - Libérationi>
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S. à r.l., représentée comme sus-indiqué, déclare avoir souscrit à
l'intégralité du capital social de la Société et avoir entièrement libéré les vingt milles (20.000) parts sociales par versement
en espèces, de sorte que la somme de vingt mille livres (GBP 20.000) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé
au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
La partie comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR
1.300.-).
<i>Décision de l'associée uniquei>
Et aussitôt, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- Adam Petrie, gérant, né le 08 février 1985, à Christchurch (Nouvelle Zélande), avec adresse professionnelle au 4
ème
étage, Berkeley Square House, Berkeley Square, London W1J6BX, Royaume Uni;
- Wim Ritz, gérant, né le 14 Juin 1970, à Merksem (Belgique), avec adresse professionnelle au 15 Rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg;
- Fionnuala Doyle, gérant, née le 21 avril 1978, à Cork (Irlande), avec adresse professionnelle au 15 Rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg;
2. Le siège social de la Société est établi au 15 Rue Edward Steichen Luxembourg L-2540.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par nom, prénom, qualité et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Klingele, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 4 décembre 2015. GAC/2015/10612. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 9 décembre 2015.
Référence de publication: 2015198435/401.
(150223596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
21575
L
U X E M B O U R G
Goodman Celadon Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 191.028.
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FIFTEEN, ON THE FIRST DAY OF THE MONTH OF DECEMBER.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
(1) Shine Investment Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and being registered with the Registre de
Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 196.932; and
(2) Logistics Holdings Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and being registered with the Registre de
Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 196.959
(the “Shareholders”),
each represented by Maître Perrine Reinhart, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to two
proxies dated 30
th
November 2015 which proxy shall be registered together with the present deed,
being the Shareholders of Goodman Celadon Logistics (Lux) S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited
liability company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B191.028 (the "Company"),
incorporated on 22 September 2014 pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) of 17 No-
vember 2014, number 3421.
The articles of association of the Company have never been amended since the incorporation of the Company.
The appearing parties, acting in the above mentioned capacity, declared and requested the notary to record as follows:
1. The Shareholders hold all the 12,500 shares in issue in the Company so that the total share capital is represented and
resolutions can be validly taken by the Shareholders.
2. The items on which resolutions are to be taken are as follows:
1. Change of the corporate denomination of the Company to Logicor (Shine) Walsrode S.à r.l. and amendment of article
1 of the articles of association of the Company which shall read as follows:
“ Art. 1. Form- Corporate Name. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Logicor
(Shine) Walsrode S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become
shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.”
2. Amendment and restatement of the articles of association of the Company in their entirety so that they shall read as
set forth in the second resolution and in particular the corporate object of the Company (article 2) which shall be amended
as follows:
“ Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.
The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
21576
L
U X E M B O U R G
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.”
Thereafter the following resolutions were passed by the Shareholders of the Company:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to amend Article 1 of the articles of association of the Company so that Article 1 of the
articles of association of the Company reads as set out in item 1. of the above agenda.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolved to fully amend and re-state the Company's articles of association and in particular the cor-
porate object of the Company so that such articles of association shall read as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Logicor (Shine)
Walsrode S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.
The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case
may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,
economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
21577
L
U X E M B O U R G
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)
represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its own shares
upon resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%)
of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business
of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to
act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
21578
L
U X E M B O U R G
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the
board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of
the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal
to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed
by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in
the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
21579
L
U X E M B O U R G
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th! August 1915 on commercial companies;
in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 2,000.-.
The undersigned notary who understands and speaks German and English states herewith that on request of the above
appearing party the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing
party and in case of divergences between the German and the English texts, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by its name, first name,
civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
IM JAHRE ZWEITAUSENDFÜNFZEHN, AM ERSTEN TAG DES MONATS DEZEMBER.
Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
(1) Shine Investment Holdco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) lu-
xemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesellschaftskapital zwölftau-
sendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg
unter der Nummer B196.932; und
(2) Logistics Holdings Holdco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesellschaftskapital zwölftau-
sendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg
unter der Nummer B196.959
(die „Gesellschafter“),
hier vertreten durch Maître Perrine Reinhart, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund von zwei
privatschriftlichen Vollmachten, ausgestellt am 30. November 2015, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit
dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden,
als Gesellschafter der Goodman Celadon Logistics (Lux) S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesell-
schaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des
Sociétés in Luxemburg, unter der Nummer B191.028 (die «Gesellschaft»), gegründet am 22. September 2014 gemäß
Urkunde aufgenommen durch Maître Carlo Wersandt, Notar wohnhaft in Luxemburg, Großherzogtum Luxembourg, ver-
öffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial») am 17. November 2014, Nummer 3421.
Die Satzung der Gesellschaft wurde nie abgeändert seit der Gründung der Gesellschaft.
Die Erschienenen geben, in Ausübung ihres obenerwähnten Amtes, folgende Erklärungen ab und ersuchen den amtie-
renden Notar folgendes zu beurkunden:
1. Die Gesellschafter halten alle 12.500 von der Gesellschaft ausgegebenen Gesellschaftsanteile, so dass das gesamte
Gesellschaftskapital vertreten ist und die Gesellschafter wirksam über alle Punkte der Tagesordnung entscheiden können.
2. Die Punkte über die ein Beschluss getroffen werden soll sind die folgenden:
1. Änderung des Gesellschaftsnamen der Gesellschaft in „Logicor (Shine) Walsrode S.à r.l.“ und Abänderung von
Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft, sodass dieser wie folgt lautet:
„ Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem
Namen "Logicor (Shine) Walsrode S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Per-
sonen, die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende
Satzung und durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt."
21580
L
U X E M B O U R G
2. Änderung und Neuformulierung der kompletten Satzung der Gesellschaft, sodass diese wie im zweiten Beschluss
beschrieben lautet, und besonders des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft (Artikel 2) der wie folgt lautet:
„ Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Ver-
waltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen
die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Ge-
sellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-
geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-
liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und
alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-
denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen."
Danach wurden folgende Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter haben beschlossen Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern so dass Artikel 1 der Satzung
der Gesellschaft den Wortlaut hat wie im ersten Punkt der Tagesordnung beschrieben.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter haben beschlossen die komplette Satzung der Gesellschaft zu ändern und umzuformulieren und
besonders der Gesellschaftszweck der Gesellschaft, sodass die Satzung der Gesellschaft wie folgt lautet:
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
"Logicor (Shine) Walsrode S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die
gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und
durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Ver-
waltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen
die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Ge-
sellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-
geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
21581
L
U X E M B O U R G
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-
liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und
alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-
denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende
solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung
auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünf-
hundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von
je ein Euro (EUR 1).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung
vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine eigenen Gesellschaftsanteile
durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht
anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die
keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
21582
L
U X E M B O U R G
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen
Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder
einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“
und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder
(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder
von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
21583
L
U X E M B O U R G
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-
schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich
nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
21584
L
U X E M B O U R G
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Akte
entstehen, werden ungefähr abgeschätzt auf EUR 2.000,-.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen und deutschen Sprache kundig ist, bestätigt hiermit, dass auf Anfrage
der erschienenen Partei vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Überset-
zung, und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung
maßgebend ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer der erschienenen Partei der dem
amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist, hat derselbe zusammen mit dem Notar
die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. REINHART, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38143. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 08. Dezember 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015198663/527.
(150222994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Global Fashion Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Seningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 190.907.
In the year two thousand and fifteen, on the first day of December.
Before the undersigned, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of
Global Fashion Group S.A. (hereinafter the “Company”), a société anonyme, incorporated and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B
190.907, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated
pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 1 October
2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 11 November 2014 under N° 3333, pursuant
to a resolution of the meeting of the board of directors of the Company (the “Board”) held on 23 November 2015 (the
“Resolutions”). The articles of association were last amended by deed of the undersigned notary on 11 November 2015,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 28 November 2015 under number 3224.
An excerpt of the aforementioned Resolutions, initialed ne varietur by the appearing person and the notary, will remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The appearing person, acting in
the aforementioned capacity, has requested the undersigned notary to state his declarations as follows:
1) According to article 5.1 of the articles of association, the Company has an issued share capital of sixty-nine million
one hundred eighty-four thousand eight hundred thirty-seven euro (EUR 69,184,837), represented by sixty-seven million
three hundred seventy-five thousand four hundred ten (67,375,410) common shares with a nominal value of one Euro (EUR
1) each and by one million eight hundred nine thousand four hundred twenty-seven (1,809,427) convertible preference
shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.
2) Pursuant to article 6.1 of the articles of association, the Company's authorized capital, excluding the issued share
capital, is set at eighteen million five hundred fifteen thousand four hundred sixty-six euro (EUR 18,515,466), which is
split in (i) six million five hundred eighty-six thousand six hundred fifty-three euro (EUR 6,586,653), consisting of six
million five hundred eighty-six thousand six hundred fifty-three (6,586,653) common shares with a nominal value of one
Euro (EUR 1) each (the “ESOP Common Shares Authorized Capital”), (ii) nine million one hundred nineteen thousand
six hundred fifty euro (EUR 9,119,650), consisting of (a) one million eight hundred twenty-three thousand nine hundred
thirty (1,823,930) convertible preference shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each and (b) seven million two
hundred ninety-five thousand seven hundred twenty (7,295,720) common shares with a nominal value of one Euro (EUR
1) each (the “Convertible Preference Shares Authorized Capital”), (iii) eight hundred fifty-five thousand six hundred eighty-
five euro (EUR 855,685) consisting of eight hundred fifty-five thousand six hundred eighty-five (855,685) common shares
with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “Kanui/Tricae Shares Authorized Capital”), and (iv) one million nine
hundred fifty-three thousand four hundred seventy-eight euro (EUR 1,953,478) consisting of one million nine hundred
21585
L
U X E M B O U R G
fiftythree thousand four hundred seventy-eight (1,953,478) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each
(the “Management Roll-up Authorized Capital”, and together with the ESOP Common Shares Authorized Capital, the
Convertible Preference Shares Authorized Capital and the Kanui/Tricae Shares Authorized Capital, the “Authorized Ca-
pital”).
3) Under the Convertible Preference Shares Authorized Capital, the Board is authorized, among others, to issue up to
one million eight hundred twenty-three thousand nine hundred thirty (1,823,930) convertible preference shares with a
nominal value of one Euro (EUR 1) each, without reserving a preferential subscription right for the existing shareholders,
during a period of time of five (5) years from 18 September 2015.
4) In the Resolutions, the Board has resolved to increase the Company’s share capital by one million eight hundred nine
thousand four hundred twenty-seven euro (EUR 1,809,427) so as to raise it from its current amount of sixty-nine million
one hundred eighty-four thousand eight hundred thirty-seven euro (EUR 69,184,837) up to seventy million nine hundred
ninety-four thousand two hundred sixty-four euro (EUR 70,994,264) through the issue of one million eight hundred nine
thousand four hundred twenty-seven (1,809,427) convertible preference shares for a price of forty-one euro and twelve
cents (EUR 41.12) per convertible preference share with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “New Shares”)
subject to the fulfillment of the conditions precedent mentioned under point 5) below.
5) Pursuant to the Resolutions, the issuance of the New Shares shall be effective upon execution of this notarial deed
and conditional on (i) the receipt of the total subscription price of seventy-four million four hundred three thousand six
hundred thirty-eight euro and twenty-four cents (EUR 74,403,638.24) by the Company, and (ii) the receipt of a subscription
form executed by each of the Subscribers (as defined below) for the number of convertible preference shares as mentioned
in the Resolutions (the “Conditions Precedent”).
6) Proof of satisfaction of the Conditions Precedent has been produced to the undersigned notary, and the appearing
person, acting in the aforesaid capacity, hereby confirms the fulfillment of the Conditions Precedent.
7) The New Shares have been subscribed as follows:
i. Seven hundred twenty thousand eight hundred eighty-four (720,884) newly issued convertible preference shares have
been subscribed by Kinnevik Online AB, a limited liability company (aktiebolag), incorporated and existing under the laws
of Sweden, registered with the company registrar in Sweden (Bolagsverket), under no. 556815-4958, with registered seat
in Stockholm, Sweden, having its business address at Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Sweden (“Kinnevik”), for a price
of twenty-nine million six hundred forty-two thousand seven hundred fifty euro and eight cents (EUR 29,642,750.08);
ii. Six hundred thousand seven hundred two (600,702) convertible preference shares have been subscribed by Rocket
Internet SE, a European stock corporation (Societas Europaea) existing under the laws of Germany with its registered office
in Berlin, registered with commercial register of the local court of Charlottenburg, Germany, under HRB 165662 B, having
its business address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany, (“Rocket Internet”), for the price of twenty-four million
seven hundred thousand eight hundred sixty-six euro and twenty-four cents (EUR 24,700,866.24);
iii. One hundred eighty-eight thousand nine hundred forty-five (188,945) convertible preference shares have been sub-
scribed by Al European Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under no. B 168.122, having its registered address at 33, rue du Puits Romain,
L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, (“Al European Holdings”), for the price of seven million seven hundred
sixty-nine thousand four hundred eighteen euro and forty cents (EUR 7,769,418.40);
iv. One hundred twenty-one thousand five hundred ninety-five (121,595) convertible preference shares have been sub-
scribed by TEC Global Invest I GmbH, a limited liability company existing under the laws of Germany, registered with
the commercial register of the local court of Duisburg, Germany, under number HRB 24965 with registered address in
Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany, (“TEC Global Invest”), for the price of four million nine
hundred ninety-nine thousand nine hundred eighty-six euro and forty cents (EUR 4,999,986.40);
v. Seventy-five thousand six hundred fifty-four (75,654) convertible preference shares have been subscribed by Ver-
linvest SA, a stock corporation existing under the laws of Belgium, registered with the register of Legal Entities in Brussels,
Belgium under number 0455.030.364, registered address in Place Flagey 18, 1050 Brussels, Belgium, (“Verlinvest”), for
the price of three million one hundred ten thousand eight hundred ninety-two euro and forty-eight cents (EUR 3,110,892.48).
vi. Twenty-four thousand three hundred nineteen (24,319) convertible preference shares have been subscribed by In-
ternational Finance Corporation, an international organization established by articles of agreement between its member
countries, with registered address at 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington D.C, 20433, United States of America,
(“IFC”), for the price of nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-seven euro and twenty-eight cents (EUR
999,997.28);
vii. Fifty-two thousand one hundred twenty-four (52,124) convertible preference shares have been subscribed by
2369335 Ontario Limited, a corporation incorporated under the laws of the Province of Ontario, under Ontario Corporation
number 2369335, with registered address at 5650 Yonge Street, Toronto, Ontario Canada M2M 4H5, Canada, (“Ontario”),
for the price of two million one hundred forty-three thousand three hundred thirty-eight euro and eighty-eight cents (EUR
2,143,338.88);
viii. Seven thousand one hundred sixty-one (7,161) convertible preference shares have been subscribed by L’Arche
B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under the laws of the Netherlands, registered with the com-
21586
L
U X E M B O U R G
mercial register of the Dutch Trade Register under number 59430982, with registered address at Tweede Weteringplantsoen
5, 1017 ZD Amsterdam, the Netherlands, (“L’Arche”), for the price of two hundred ninety-four thousand four hundred
sixty euro and thirty-two cents (EUR 294,460.32);
ix. Eighteen thousand forty-three (18,043) convertible preference shares have been subscribed by York Global Finance
II S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilitée limitée) incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et
des Sociétés) under number B 120.097, with its registered address at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg (“York”, together with Kinnevik, Rocket Internet, Al European Holdings, TEC Global Invest,
Verlinvest, IFC, Ontario and L’Arche, the “Subscribers”), for the price of seven hundred forty-one thousand nine hundred
twenty-eight euro and sixteen cents (EUR 741,928.16).
8) The convertible preference shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash consisting of
seventy-four million four hundred three thousand six hundred thirty-eight euro and twenty-four cents (EUR 74,403,638.24);
so that the amount of seventy-four million four hundred three thousand six hundred thirty-eight euro and twenty-four cents
(EUR 74,403,638.24) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of seventy-four million four hundred three thousand six hundred thirty-eight euro
and twenty-four cents (EUR 74,403,638.24) consists of one million eight hundred nine thousand four hundred twenty-
seven euro (EUR 1,809,427) for the share capital and seventy-two million five hundred ninety-four thousand two hundred
eleven euro and twenty-four cents (EUR 72,594,211.24) for the share premium.
9) As a consequence of the aforementioned issuance of New Shares, article 5.1 of the articles of association shall be
amended as follows:
“ 5.1. The Company has an issued share capital of seventy million nine hundred ninety-four thousand two hundred sixty-
four euro (EUR 70,994,264), represented by sixty-seven million three hundred seventy-five thousand four hundred ten
(67,375,410) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each and by three million six hundred eighteen
thousand eight hundred fifty-four (3,618,854) convertible preference shares with a nominal value of one Euro (EUR 1)
each.
Any reference in these articles of association to the concept of “shares” shall refer to the common shares and the
convertible preference shares, as applicable.”
10) As a consequence of the aforementioned issuance of the New Shares, article 6.1 of the articles of association shall
be amended as follows:
“ 6.1. The Company's authorized capital, excluding the issued share capital, is set at is set at sixteen million seven
hundred-six thousand thirty-nine euro (EUR 16,706,039), which is split in (i) six million five hundred eighty-six thousand
six hundred fifty-three euro (EUR 6,586,653), consisting of six million five hundred eighty-six thousand six hundred fifty-
three (6,586,653) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “ESOP Common Shares Authorized
Capital”), (ii) seven million three hundred ten thousand two hundred twenty-three euro (EUR 7,310,223), consisting of (a)
fourteen thousand five hundred three (14,503) convertible preference shares with a nominal value of one Euro (EUR 1)
each and (b) seven million two hundred ninety-five thousand seven hundred twenty (7,295,720) common shares with a
nominal value of one Euro (EUR 1) (the “Convertible Preference Shares Authorized Capital”), (iii) eight hundred fifty-
five thousand six hundred eighty-five euro (EUR 855,685) consisting of eight hundred fifty-five thousand six hundred
eighty-five (855,685) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “Kanui/Tricae Shares Authorized
Capital”), and (iv) one million nine hundred fifty-three thousand four hundred seventy-eight euro (EUR 1,953,478) con-
sisting of one million nine hundred fifty-three thousand four hundred seventy-eight (1,953,478) common shares with a
nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “Management Rollup Authorized Capital”, and together with the ESOP
Common Shares Authorized Capital, the Convertible Preference Shares Authorized Capital and the Kanui/Tricae Shares
Authorized Capital, the “Authorized Capital).”
11) All Conditions Precedent being fulfilled as of the date of this deed, the issuance of the New Shares is hereby effective.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are assessed to EUR 7,500.-.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing person and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by name, first name and residence, the
said appearing person signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am ersten Dezember.
Vor der unterzeichnenden Notarin, Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
21587
L
U X E M B O U R G
Ist erschienen:
Herr Alexander Olliges, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, als Vertreter des Verwaltungsrats der Global Fashion
Group S.A. (im Folgenden die „Gesellschaft“), einer Aktiengesellschaft (société anonyme), gegründet und bestehend nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der
Nummer B 190.907, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet am 1. Oktober
2014 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
welche am 11. November 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 3333, veröffentlicht wurde,
gemäß einem Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) vom 23. November 2015 (die „Be-
schlüsse“). Die Satzung wurde zuletzt am 11. November 2015 gemäß einer Urkunde der unterzeichnenden Notarin geändert,
welche am 28. November 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 3224, veröffentlicht wurde.
Ein Auszug der vorgenannten Beschlüsse wird nach Paraphierung „ne varietur“ durch den Erschienenen und die Notarin
der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben bei den Registrierungsbehörden hinterlegt zu werden.
Der Erschienene, der mit den vorgenannten Befugnissen handelt, hat die unterzeichnende Notarin ersucht, folgende Er-
klärungen festzuhalten:
1) Gemäß Artikel 5.1 der Satzung beträgt das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft neunundsechzig Mil-
lionen einhundertvierundachtzigtausendachthundertsiebenunddreißig Euro (EUR 69.184.837), aufgeteilt in siebenund-
sechzig Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausendvierhundertzehn (67.375.410) Aktien mit einem Nominalwert von je
einem Euro (EUR 1) und eine Million achthundertneuntausendvierhundertsiebenundzwanzig (1.809.427) wandelbare
Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
2) Gemäß Artikel 6.1 der Satzung beträgt das genehmigte Kapital der Gesellschaft, ausschließlich des ausgegebenen
Gesellschaftskapitals, achtzehn Millionen fünfhundertfünfzehntausendvierhundertsechsundsechzig Euro (EUR
18.515.466), aufgeteilt in (i) sechs Millionen fünfhundertsechsundachtzigtausendsechshundertdreiundfünfzig Euro (EUR
6.586.653), bestehend aus sechs Millionen fünfhundertsechsundachtzigtausendsechshundertdreiundfünfzig (6.586.653)
Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital der ESOP-Aktien“), (ii) neun
Millionen einhundertneunzehntausendsechshundertfünfzig Euro (EUR 9.119.650), bestehend aus (a) einer Million acht-
hundertdreiundzwanzigtausendneunhundert dreißig (1.823.930) wandelbaren Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von
je einem Euro (EUR 1) und (b) sieben Millionen zweihundertfünfundneunzigtausendsiebenhundertzwanzig (7.295.720)
Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital der Wandelbaren Vorzugsaktien“),
(iii) achthundertfünfundfünfzigtausendsechshu ndertfünfundachtzig Euro (EUR 855.685), bestehend aus achthundertfün-
fundfünfzigtausendsechshundertfünfundachtzig (855.685) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das
„Genehmigte Kapital der Kanui/Tricae-Aktien“), und (iv) eine Million neunhundertdreiundfünfzigtausendvierhundertach-
tundsiebzig Euro (EUR 1.953.478), bestehend aus einer Million neunhundertdreiundfünfzigtausendvierhundertachtund-
siebzig (1.953.478) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital des Management
Roll-ups“, und zusammen mit dem Genehmigten Kapital der ESOP-Aktien, dem Genehmigten Kapital der Wandelbaren
Vorzugsaktien und dem Genehmigten Kapital der Kanui/Tricae-Aktien, das „Genehmigte Kapital“).
3) Im Rahmen des Genehmigten Kapitals der Wandelbaren Vorzugsaktien ist der Verwaltungsrat innerhalb eines Zeit-
raums von fünf (5) Jahren ab dem 18. September 2015 unter anderem zur Ausgabe von bis zu einer Million achthundertd-
reiundzwanzigtausendneunhundertdreißig (1.823.930) wandelbaren Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1) ermächtigt, ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht zur Zeichnung zu gewähren.
4) In den Beschlüssen hat der Verwaltungsrat die Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem
derzeitigen Betrag von neunundsechzig Millionen einhundertvierundachtzigtausendachthundertsiebenun ddreißig Euro
(EUR 69.184.837) um einen Betrag von einer Million achthundertneuntausendvierhundertsiebenundzwanzig Euro (EUR
1.809.427) auf einen Betrag von siebzig Millionen neunhundertvierundneunzigtausendzweihundertvierundsechzig Euro
(EUR 70.994.264) durch die Ausgabe von einer Million achthundertneuntausendvierhundertsiebenundzwanzig (1.809.427)
wandelbaren Vorzugsaktien zu einem Preis von einundvierzig Euro und zwölf Cent (EUR 41,12) pro wandelbarer Vor-
zugsaktie mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die „Neuen Aktien“), vorbehaltlich der Erfüllung der unter
Punkt 5) unten genannten aufschiebenden Bedingungen, beschlossen.
5) Gemäß den Beschlüssen wird die Ausgabe der Neuen Aktien mit der Ausstellung dieser notariellen Urkunde und
vorbehaltlich (i) des Erhalts durch die Gesellschaft des vollständigen Bezugspreises in Höhe von vierundsiebzig Millionen
vierhundertdreitausendsechshundertachtunddreißig Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 74.403.638,24) und (ii) des Er-
halts eines von jedem der Zeichner (wie unten definiert) unterzeichneten Zeichnungsscheins für die in den Beschlüssen
genannte Anzahl an wandelbaren Vorzugsaktien (die „Aufschiebenden Bedingungen“), wirksam.
6) Der Nachweis über die Erfüllung der Aufschiebenden Bedingungen wurde der unterzeichnenden Notarin erbracht
und der Erschienene, der mit den vorgenannten Befugnissen handelt, bestätigt hiermit die Erfüllung der Aufschiebenden
Bedingungen.
7) Die Neuen Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
i. siebenhundertzwanzigtausendachthundertvierundachtzig (720.884) neu ausgegebene wandelbare Vorzugsaktien wur-
den von Kinnevik Online AB, einer Gesellschaft (aktiebolag), gegründet und bestehend nach dem Recht Schwedens,
eingetragen im Handelsregister Schwedens (Bolagsverket) unter der Nummer 556815-4958, mit Sitz in Stockholm, Schwe-
21588
L
U X E M B O U R G
den, mit Geschäftssitz in Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Schweden („Kinnevik“), zum Preis von neunundzwanzig
Millionen sechshundertzweiundvierzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro und acht Cent (EUR 29.642.750,08) gezeichnet;
ii. sechshundertausendsiebenhundertzwei (600.702) wandelbare Vorzugsaktien wurden von Rocket Internet SE, einer
Europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea) bestehend nach deutschem Recht, mit Sitz in Berlin, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 165662 B, mit Geschäftssitz in
Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket Internet“), zum Preis von vierundzwanzig Millionen siebenhun-
derttausendachthundertsechsundsechzig Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 24.700.866,24) gezeichnet;
iii. einhundertachtundachtzigtausendneunhundertfünfundvierzig (188.945) wandelbare Vorzugsaktien wurden von Al
European Holdings S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und
bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxem-
burg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 168.122, mit Sitz in 33, rue du Puits Romain, L-8070
Bertrange, Großherzogtum Luxemburg („Al European Holdings“), zum Preis von sieben Millionen siebenhundertneu-
nundsechzigtausendvierhundertachtzehn Euro und vierzig Cent (EUR 7.769.418,40) gezeichnet;
iv. einhunderteinundzwanzigtausendfünfhundertfünfundneunzig (121.595) wandelbare Vorzugsaktien wurden von
TEC Global Invest I GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend nach deutschem Recht, eingetragen
im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 24965, mit Sitz in Wissollstraße
5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland („TEC Global Invest“), zum Preis von vier Millionen neunhundertneu-
nundneunzigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro und vierzig Cent (EUR 4.999.986,40) gezeichnet;
v. fünfundsiebzigtausendsechshundertvierundfünfzig (75.654) wandelbare Vorzugsaktien wurden von Verlinvest SA,
einer Aktiengesellschaft bestehend nach dem Recht Belgiens, eingetragen im Register Juristischer Personen in Brüssel,
Belgien, unter der Nummer 0455.030.364, mit Sitz in Place Flagey 18, 1050 Brüssel, Belgien („Verlinvest“), zum Preis
von drei Millionen einhundertzehntausendachthundertzweiundneunzig Euro und achtundvierzig Cent (EUR 3.110.892,48)
gezeichnet;
vi. vierundzwanzigtausenddreihundertneunzehn (24.319) wandelbare Vorzugsaktien wurden von International Finance
Corporation, einer internationalen Organisation gegründet durch einen Vertrag (articles of agreement) zwischen ihren
Mitgliedstaaten, mit Sitz in 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington D.C., 20433, Vereinigte Staaten von Amerika
(„IFC“), zum Preis von neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertsiebenundneunzig Euro und achtundzwanzig
Cent (EUR 999.997,28) gezeichnet;
vii. zweiundfünfzigtausendeinhundertvierundzwanzig (52.124) wandelbare Vorzugsaktien wurden von 2369335 Onta-
rio Limited, einer Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Provinz Ontario, unter der Nummer 2369335, mit Sitz in
5650 Yonge Street, Toronto, Ontario Canada M2M 4H5, Canada („Ontario“), zum Preis von zwei Millionen einhundertd-
reiundvierzigtausenddreihundertachtunddreißig Euro und achtundachtzig Cent (EUR 2.143.338,88) gezeichnet;
viii. siebentausendeinhunderteinundsechzig (7.161) wandelbare Vorzugsaktien wurden von L’Arche B.V., einer Ge-
sellschaft (Besloten Vennootschap) nach dem Recht der Niederlande, eingetragen im Handelsregister des Dutch Trade
Register unter der Nummer 59430982, mit Sitz in Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam, Niederlande
(„L’Arche“), zum Preis von zweihundertvierundneunzigtausendvierhundertsechzig Euro und zweiunddreißig Cent (EUR
294.460,32) gezeichnet;
ix. achtzehntausenddreiundvierzig (18.043) wandelbare Vorzugsaktien wurden von York Global Finance II S.à r.l., einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et
des Sociétés) unter der Nummer B 120.097, mit Sitz in 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg („York“, zusammen mit Kinnevik, Rocket Internet, Al European Holdings, TEC Global Invest, Verlinvest, IFC,
Ontario und L’Arche, die „Zeichner“), zum Preis von siebenhunderteinundvierzigtausendneunhundertachtundzwanzig
Euro und sechzehn Cent (EUR 741.928,16) gezeichnet.
8) Die so gezeichneten wandelbaren Vorzugsaktien wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage bestehend aus
vierundsiebzig Millionen vierhundertdreitausendsechshundertachtunddreißig Euro und vierundzwanzig Cent (EUR
74.403.638,24); sodass der Betrag von vierundsiebzig Millionen vierhundertdreitausendsechshundertachtunddreißig Euro
und vierundzwanzig Cent (EUR 74.403.638,24) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was der unterzeichnenden
Notarin nachgewiesen wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von vierundsiebzig Millionen vierhundertdreitausendsechshundertachtunddreißig Euro
und vierundzwanzig Cent (EUR 74.403.638,24) besteht aus einer Million achthundertneuntausendvierhundertsiebenund-
zwanzig Euro (EUR 1.809.427) für das Gesellschaftskapital und zweiundsiebzig Millionen fünfhundertvierundneunzig-
tausendzweihundertelf Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 72.594.211,24) für das Agio.
9) Infolge der obengenannten Ausgabe Neuer Aktien wird Artikel 5.1 der Satzung wie folgt geändert:
„ 5.1. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt siebzig Millionen neunhundertvierundneunzig-
tausendzweihundertvierundsechzig Euro (EUR 70.994.264), bestehend aus siebenundsechzig Millionen dreihundertfün-
fundsiebzigtausendvierhundertzehn (67.375.410) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) und drei
Millionen sechshundertachtzehntausendachthundertvierundfünfzig (3.618.854) wandelbar en Vorzugsaktien mit einem
Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
21589
L
U X E M B O U R G
Jeder Bezug in dieser Satzung auf „Aktien“ bezieht sich, je nach Fall, auf die Aktien und die wandelbaren Vorzugaktien.“
10) Infolge der obengenannten Ausgabe der Neuen Aktien wird Artikel 6.1 der Satzung wie folgt geändert:
„ 6.1. Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt, ausschließlich des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, sechzehn
Millionen siebenhundertsechstausendneununddreißig Euro (EUR 16.706.039), aufgeteilt in (i) sechs Millionen fünfhun-
dertsechsundachtzigtausendsechshundertdreiundfünf zig Euro (EUR 6.586.653), bestehend aus sechs Millionen fünfhun-
dertsechsundachtzigtausendsechshundertdreiundfünfzig (6.586.653) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1) (das „Genehmigte Kapital der ESOP-Aktien“), (ii) sieben Millionen dreihundertzehntausendzweihundertdrei-
undzwanzig Euro (EUR 7.310.223), bestehend aus (a) vierzehntausendfünfhundertdrei (14.503) wandelbaren Vorzugsak-
tien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) und (b) sieben Millionen zweihundertfünfundneunzigtausend-
siebenhundertzwanzig (7.295.720) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital
der Wandelbaren Vorzugsaktien“), (iii) achthundertfünfundfünfzigtausendsechshundertfünfundachtzig Euro (EUR
855.685), bestehend aus achthundertfünfundfünfzigtausendsechshundertfünfun dachtzig (855.685) Aktien mit einem No-
minalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital der Kanui/Tricae-Aktien“), und (iv) eine Million
neunhundertdreiundfünfzigtausendvierhundertachtundsiebzig Euro (EUR 1.953.478) bestehend aus einer Million neun-
hundertdreiundfünfzigtausendvierhundertachtundsiebzig (1.953.478) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1) (das „Genehmigte Kapital des Management Roll-ups“, und gemeinsam mit dem Genehmigten Kapital der ESOP-
Aktien, dem Genehmigten Kapital der Wandelbaren Vorzugsaktien und dem Genehmigten Kapital der Kanui/Tricae-
Aktien, das „Genehmigte Kapital“).“
11) Da alle Aufschiebenden Bedingungen zum Datum dieser Urkunde erfüllt sind, ist die Ausgabe der Neuen Aktien
hiermit wirksam geworden.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare oder Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde zu
tragen sind, werden auf ungefähr EUR 7.500,- geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen des Erschienenen auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf
Verlangen des besagten Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung,
ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist dem Erschienenen, welcher der Notarin mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist,
verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Erschienenen unterzeichnet worden.
Gezeichnet: A. OLLIGES, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38142. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 08. Dezember 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015198662/311.
(150222951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Hickante S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 9, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 202.042.
STATUTS
L'an deux mille quinze,
Le premier décembre,
Par-devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange,
Ont comparu:
1) Monsieur Raymond John HICKEY, employé, né à Dublin (Irlande) le 14 août 1972, demeurant à L-3270 Bettembourg,
42, route de Peppange;
2) Monsieur Thomas James HICKEY, employé, né à Dublin (Irlande) le 14 février 1978, demeurant à L-6111 Junglinster,
31, rue Tun Deutsch;
3) Monsieur Gabriel BOISANTE, employé, né à Paris (France) le 8 octobre 1977, demeurant à L-2440 Luxembourg,
20, rue de Rollingergrund.
21590
L
U X E M B O U R G
Lesquels comparants étant tous ici représentés par Maître Safouane JAOUID, avocat à la Cour, demeurant profession-
nellement à Dudelange, en vertu de une procuration sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée «ne
varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes afin d'être soumise ensemble avec
elles à la formalité de l'enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les
statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les lois y relatives
ainsi que par les présents statuts.
La Société comporte initialement plusieurs associés; elle peut, à toute époque, devenir société unipersonnelle par la
réunion de toutes les parts sociales en une seule main, puis redevenir une société à plusieurs associés par suite de cession
ou de transmission totale ou partielle des parts sociales ou de création de parts nouvelles.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet social, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre
ou pour compte de tiers:
toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l'exploitation d’un commerce de brasserie-restaurant avec
débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
D’une façon générale, la Société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières
et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en
faciliter l'accomplissement.
La Société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser ou à le développer.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société prend la dénomination de «HICKANTE S.à r.l.».
Art. 5. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé ou des associés, selon le cas. Il peut être transféré à l'intérieur de
la commune par une décision du gérant ou conseil de gérance.
Des succursales ou bureaux pourront être établis partout, au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- €) représenté par cent (100) parts
sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- €) chacune.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues
par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans
les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social.
L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés; en cas
de pluralité d'associés toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou
de la collectivité des associés.
Les créanciers, ayants-droits ou héritiers de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte
que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire
judiciaire des valeurs sociales; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.
Au cas où une part est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par
l'usufruitier.
Art. 10. Cession et transmission des parts.
1. Cessions et transmissions en cas d'associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
2. Cessions et transmissions en cas de pluralité d'associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l'agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.
21591
L
U X E M B O U R G
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des descendants
soit au conjoint survivant.
Dans les cas où la cession ou transmission de parts est soumise à l'agrément des associés restants, ces derniers ont un
droit de préférence pour le rachat des parts à céder, en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent au moment de la
cession. En cas de l'exercice de leur droit de préférence par les associés restants et en cas de désaccord sur le prix de rachat,
le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte
pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
Art. 11. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture de l'associé ou de l'un des associés. Le décès, l'incapacité, la mise en
tutelle ou en curatelle, la faillite, la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés, n'entraîne pas la dissolution de
la Société.
Art. 12. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non-associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition
intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet de
la Société. Le ou les gérants représentent, de même, la Société en justice soit en demandant, soit en défendant.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique ou par
l'assemblée générale des associés.
Dans ce dernier cas, l'associé unique ou l'assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur nombre,
la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.
L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu'il
soit besoin d'une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes,
mais encore pour toutes raisons, quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine de l'associé unique ou des
associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L'associé unique ou les associés décideront de la ré-
munération du gérant.
Art. 13. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent
pas la dissolution de la Société.
Les créanciers, héritiers et ayants-cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 14. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société. Simple mandataire il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 15. Décisions de l'associé ou des associés.
1. Lorsque la Société ne compte qu'un associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité
des associés.
Les décisions de l'associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
2. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été
adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, à moins que la loi ou les présents statuts n'en
disposent autrement.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il possède.
Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Art. 17. Inventaire - Bilan. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un
inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. Tout associé peut prendre au siège social communication
de l'inventaire et des comptes annuels.
Art. 18. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux,
amortissements et provisions, résultant des comptes annuels constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou l'assemblée générale des associés.
Art. 19. Dissolution - Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce
soit, la liquidation sera faite pour un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts l'associé unique ou les associés,
selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente-et-un décembre 2016.
21592
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription et paiementi>
Les cent parts sociales (100) ont été souscrites comme suit par:
1. Monsieur Raymond John HICKEY,
prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 parts
2. Monsieur Thomas James HICKEY,
prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 parts
3. Monsieur Gabriel BOISANTE,
prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (12.500.- €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales se trouvent remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à mille cent euros (1.100.- €).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant, les comparants, représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis
en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Est appelé aux fonctions de gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Raymond John HICKEY, employé, né à Dublin (Irlande) le 14 août 1972, demeurant à L-3270 Bettembourg,
42, route de Peppange;
La Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la Société est fixé à L-1212 Luxembourg, 9, rue des Bains.
<i>Avertissementi>
Avant la clôture du présent acte, le notaire instrumentaire soussigné a attiré l'attention des constituants sur la nécessité
d'obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l'objet social.
DONT ACTE, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au mandataire des constituants, connu du
notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. JAOUID, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 décembre 2015. Relation: EAC/2015/28684. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 08 décembre 2015.
C. GOEDERT.
Référence de publication: 2015198695/165.
(150223721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
GreenOak Europe Secured Lending GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GreenOak European Secured Lending GP S.à r.l.).
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 200.487.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth day of November.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
21593
L
U X E M B O U R G
THERE APPEARED:
“GreenOak Partners LLC; a limited liability company, incorporated under the laws of the United States pursuant to the
Delaware Limited Liability Company Act. 6 Del. C. §§ 18-101, et seq., as amended from time to time by the filing of the
Certificate with Secretary of State of the State of Delaware on May 24, 2010, having its registered office at 285 Madison
Avenue, Suite 1800, New York, NY 10017, USA, acting in its capacity as the general partner of GO Europe Secured
Lending GP Holdings, LP, an exempt limited partnership, incorporated under the laws of the Cayman Islands on August
14, 2015, having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand
Cayman, KY1-1104,
here represented by Mrs Lara FORTE, employee, residing professionally in Luxembourg, (the “Proxy-holder”), by
virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the
officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, represented as said before, declares and requests the officiating notary to act the following:
The appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of “GreenOak European Secured Lending GP S.à
r.l.”, a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg (Grand Duchy of
Luxembourg), with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 200.487, (the “Company”),
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on September 25, 2015, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
The Sole Shareholder then reviewed the following agenda (the “Agenda”):
<i>Agendai>
1. Change of name of the Company from “GreenOak European Secured Lending GP S.à r.l.” to “GreenOak Europe
Secured Lending GP S.à r.l.”;
2. Amendment of the article 1 of the Company's article of association to reflect the change of the name of the Company
as per item 1 above;
3. Powers and authorizations.
Further to the review of the different items composing the Agenda, the Sole Shareholder, representing the entire share
capital of the Company, requested the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from “GreenOak European Secured Lending GP
S.à r.l.” to “GreenOak Europe Secured Lending GP S.à r.l.”
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Company's articles
of association in order to give it henceforth the following wording:
“ Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of
“GreenOak Europe Secured Lending GP S.à r.l.” (the “Company”), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, and, in particular, the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “1915 Law”), and these
articles of association (the “Articles”)”.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to empower and authorize any manager of the Company, each acting individually, to
amend the books and records of the Company in order to reflect the above amendment.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with us the notary the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois de novembre;
21594
L
U X E M B O U R G
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
A COMPARU:
“GreenOak Partners LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon le droit des Etats-Unis et conformément
aux lois de l'Etat de Delaware sur les sociétés à responsabilité limitée, 6 Del. C., §§ 18-101, et seq., telle que modifiée par
le certificat enregistré auprès du secrétaire de l'Etat de Delaware en date du 24 mai 2010, ayant son siège social à 285
Madison Avenue, Suite 1800, New York, NY 10017, Etats-Unis d'Amérique, agissant en sa qualité d'associé commandité
de GO Europe Secured Lending GP Holdings, LP, un exempt limited partnership, constitué sous les lois des Iles Cayman
le 14 août 2015, ayant son siège social à c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand
Cayman, KY1-1104,
ici représentée par Mademoiselle Lara FORTE, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, (le “Manda-
taire”), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur”
par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui
suit:
La partie comparante est l'associée unique (l'“Associé Unique”) de “GreenOak European Secured Lending GP S.à r.l.”,
une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 200.487 (la “Société”), constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 25 septembre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'Associé Unique a ensuite considéré l'ordre du jour suivant (l'“Ordre du jour”):
<i>Ordre du jouri>
1. Changement de la dénomination sociale de la Société qui passe de “GreenOak European Secured Lending GP S.à
r.l.” à “GreenOak Europe Secured Lending GP S.à r.l.”;
2. Modification subséquente de l'article 1 des Statuts afin de refléter le changement du nom de la Société mentionnée
au point 1 ci-dessus;
3. Pouvoir et autorisation.
Après considération des différents points portés à l'Ordre du Jour, l'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital
social de la Société, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société en la faisant passer de “GreenOak European
Secured Lending GP S.à r.l.” à “GreenOak Europe Secured Lending GP S.à r.l.”.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la précédente résolution, l'Associé Unique décide de modifier l'article 1 des statuts de la Société afin
de lui donner la teneur suivante:
“ Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous le nom de “GreenOak Europe Secured
Lending GP S.à r.l.” (la «Société»), régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg et, en particulier, par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»)”.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associe Unique décide d'habiliter et d'autoriser n'importe lequel des gérants de la Société, chacun pouvant agir indi-
viduellement, à modifier les livres de la Sociétés afin de refléter la modification ci-dessus.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. FORTE, C. WERSANDT.
21595
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 1
er
décembre 2015. 2LAC/2015/27263. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Yvette THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 08 décembre 2015.
Référence de publication: 2015198665/118.
(150223072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
GerPoLux Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5447 Schwebsange, 111, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 202.032.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am sechsundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1) Herr Janusz BIELECKI, Manager, wohnhaft in Piastowska 9/1, 30-211 Krakow (Polen);
2) Herr Wojciech OBERWAN, Manager, wohnhaft in Praska 28A/4, 30-328 Krakow (Polen);
3) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Eifelwerk Holding S.à r.l. mit Gesellschaftssitz in L-5447 Schwebsingen,
111, route du Vin und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B201257,
hier vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer Herr Sebastian Horst KLEIFGES, Student, wohnhaft in D-54655
Malbergweich, 1, Eifelwerkstrasse.
Vorgenannte Parteien haben den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft
mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche
Gesetzgebung zu Grunde liegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Un-
ternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf,
Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von
Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen (Beteiligungen an Perso-
nengesellschaften sind ausgeschlossen) insbesondere auch die Verwaltung von Patenten, Geschmacksmustern und Lizen-
zen.
Die Gesellschaft kann auch in Immobilien für den eigenen Bedarf investieren.
Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit
anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften,
deren Interessen sie vertritt, führen.
Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur
Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.
Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck
verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt
oder indirekt auf dem Hauptzweck Bezug haben.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen „GerPoLux Holding S.à r.l.“.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schengen.
Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung kann der Gesellschaftssitz innerhalb derselben Gemeinde verlegt
werden.
Die Geschäftsführung kann Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative Büros sowohl im Großher-
zogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendsechshundert EURO (12.600.- EUR) eingeteilt in ein-
hundertsechsundzwanzig (126) Anteile von je einhundert EURO (100.- EUR).
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes
über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
21596
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung unter Lebenden von Gesellschaft-
santeilen an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der Gesellschafterversammlung und mindestens fünfundsiebzig
Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften verwiesen.
Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der
Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.
Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer die weitest gehenden
Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu
verwalten.
Der oder die Geschäftsführer der Gesellschaft können zu jeder Zeit und auch ohne rechtmäßigen Grund von der Gene-
ralversammlung der oder des Gesellschafters abberufen werden.
Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.
Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen
kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember
desselben Jahres.
Art. 16. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stamm-
kapitals erreicht hat.
Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.
Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversamm-
lung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn
von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bes-
timmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Zeichnung der Anteilei>
Alle einhundertsechsundzwanzig (126) Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
1) Herr Janusz BIELECKI, vorgenannt, zweiundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
2) Herr Wojciech OBERWAN, vorgenannt, zweiundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
3) Die Gesellschaft Eifelwerk Holding S.à r.l., vorgenannt, zweiundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
TOTAL: Einhundertsechsundzwanzig (126) Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Dieselben Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendsechshundert EURO (12.600.-
EUR) der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise
eintausend einhundert Euro (1.100.- EUR).
21597
L
U X E M B O U R G
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Sodann sind die Komparenten, handelnd wie erwähnt, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zu einer Gene-
ralversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt auf unbestimmte Dauer:
Herr Sebastian Horst KLEIFGES, Student, wohnhaft in D-54655 Malbergweich, 1, Eifelwerkstrasse (Deutschland).
Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäfts-
führers.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5447 Schwebsange, 111, route deu Vin.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: J. BIELECKI, W. OBERWAN, S. KLEIFGES, Patrick SERRES.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 novembre 2015. Relation: GAC/2015/10331. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, erteilt.
Remich, den 9. Dezember 2015.
Référence de publication: 2015198661/117.
(150223483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Iolita Corp, Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 182.642.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le treize Novembre.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
SWISS LIFE (Luxembourg)S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8009 Strassen,
25, route d’Arlon, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 22.663,
ici représentée par Monsieur Vincent DIDIER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration signée le 12 novembre, 2015.
Laquelle procuration, après signature «ne varietur», par le notaire instrumentant et le mandataire, restera annexée aux
présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société IOLITA CORP, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais, a été
constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 4 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 300 du 3 février 2014;
- que les statuts n’ont pas été modifiés depuis cette date;
- que le capital social de la société IOLITA S.A. s'élève actuellement à QUATRE MILLIONS DEUX CENT QUATRE
VINGT DIX MILLE EUROS (EUR 4.290.000,-) représenté par QUARANTE DEUX MILLE NEUF CENTS (42.900)
actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées;
- que la société SWISS LIFE (Luxembourg)S.A., précitée, est la seule propriétaire de toutes les actions;
- que la partie comparante, en sa qualité d’actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée
et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- que l’actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 06 novembre 2015
ci annexé aux présentes, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est
réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l’activité de la Société a cessé;
21598
L
U X E M B O U R G
- l’actionnaire unique est investi de l’entièreté de l’actif de la Société et déclare prendre à sa charge l’entièreté du passif
de la Société qu’il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 06 novembre 2015 étant seulement un
des éléments d’information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et réviseur d’entreprises de la Société;
- il y a lieu de procéder à l’annulation de toutes les actions et/ ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-2535 Luxembourg,
16, boulevard Emmanuel Servais.
Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre l’actionnaire unique et l’avoir social de, ou remboursement à, l’ac-
tionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à
compter de la publication du présent acte et sous réserve qu’aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée
n’aura exigé la constitution de sûretés.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille sept cent cinquante euros (EUR 1.750,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: V. DIDIER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/36331. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 EUR
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Référence de publication: 2015198722/57.
(150223239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Breitlecker S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6131 Junglinster, 12, rue Nicolas Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 135.177.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le vingt-sept novembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Lucien GABBANA, maître-installateur, né à ICessalto, le 25 septembre 1940, (numéro d’identification
national 1940 09 25 014 44), demeurant à L-6180 Gonderange, 18, rue de Bourglinster, et
2.- Madame Fernande WEIMERSKIRCH, sans profession, épouse de Monsieur Lucien Gabbana, née à Luxembourg,
le 14 janvier 1948, (numéro d’identification national 1948 01 14 240 89, demeurant à L-6180 Gonderange, 18, rue de
Bourglinster
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
a.- Que la société à responsabilité limitée "Breitlecker S. à r.l.", (numéro d’identification national: 2007 24 64 320),
avec siège social à L-6131 Junglinster, 12, rue Nicolas Glesener, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 135.177), été
constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Francis KESSELER, alors notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du
19 décembre 2007, publié au Mémorial C numéro 317 du 7 février 2008, que les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises
et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, alors notaire de résidence à Esch/Alzette, en date
du 9 octobre 2014, publié au Mémorial C numéro 3691 du 3 décembre 2014.
b.- Que le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales d'une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
c.- Que la société " Breitlecker S. à r.l." détient encore le bien immobilier suivant:
- la parcelle de terrain sises dans le lotissement «BREITLECKER» à Gonderange, inscrite au cadastre de la commune
de Junglinster, section RB de Gonderange, comme suit:
- numéro 760/4134, au lieu-dit: «Breitlecker», comme place, contenant 74 centiares,
21599
L
U X E M B O U R G
<i>Origine de propriétéi>
La Société est devenue propriétaire de la parcelle par apport en nature réalisé dans l’acte de constitution reçu par Maître
Francis KESSELER, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 19 décembre 2007, transcrit au premier
bureau des hypothèques à Luxembourg, le 4 février 2008, volume 2110, numéro 92.
d.- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de ladite société.
e.- Que l’activité de la société ayant cessé et que les comparants, en tant qu'associés uniques, siégeant en assemblée
générale extraordinaire modificative des statuts de la société, prononcent la dissolution anticipée de la prédite société, avec
effet immédiat, et sa mise en liquidation.
f.- Que les associés se désignent comme liquidateurs de la société, mission qu'ils acceptent.
g.- Que les liquidateurs requièrent le notaire instrumentant d’acter qu'ils déclarent avoir réglé tout le passif de la société
dissoute, moyennant reprise par les associés de l'intégralité de l'actif et du passif, et avoir transféré tous les actifs au profit
des associés.
h.- Dans le cadre de la transmission des actifs, les liquidateurs attribuent à chacun des associés la moitié (1/2) indivise
du susdit terrain, et évoluent cette même parcelle à cinq cents euros (500,- EUR.).
i.- Que les comparants sont investis de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement de tout le
passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.
j.- Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
k- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société pour l'exécution de leurs mandats.
l.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l’ancienne adresse
du siège savoir L-6131 Junglinster, 12, rue Nicolas Glesener.
CHARGES ET CONDITIONS DE L’ATTRIBUTION DES IMMEUBLES suivantes:
1.- L'entrée en jouissance a eu lieu aujourd'hui.
2.- Tous les impôts et charges grevant les éléments immobiliers attribués sont à charge des associés à partir de l'entrée
en jouissance.
3.- Les associés prendront les éléments immobiliers ci-avant décrits dans l'état dans lequel ils se trouvent actuellement,
avec toutes les servitudes actives et passives, occultes et apparentes, hypothèques charges et privilèges, qui pourraient y
être attachées. Il fera valoir les unes et se défendra des autres, le tout à ses risques et périls et sans aucun recours contre la
société civile.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille cinq cents euros, sont à la charge de la société.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte, et le notaire a certifié l'état civil sus-indiqué des
parties dans le cadre et conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 53, d'après leurs cartes d’identité respectives.
Signé: Lucien GABBANA, Fernande WEIMERSKIRCH, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 01 décembre 2015. Relation GAC/2015/10440. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015197598/67.
(150222003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
CaixaBank Global SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 179.158.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Référence de publication: 2015197606/10.
(150222284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
21600
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.3) S.à r.l.
Balham Holding S. à r.l.
Baltar Invest S.à r.l.
Baurora S.A.
BBTPS S.à r.l.
Bears & Sons S.A.
Bilfinger FRB S.à r.l.
Biosystem
Black Quantum Global Ventures S.A.
Blue Star Shipping
Breitlecker S. à r.l.
Bridgepoint Europe V Investments (2) S.à.r.l.
CaixaBank Global SICAV
Caladan SPF, S.A.
Caliorne 2 S.A.
Camac Investissement S.A.
Camberra S.A.
Camper & Nicholsons International S.A.
Cantillon Luxembourg S.à r.l.
Carpemundi S.A.
Casino Developpement Europe Sàrl
CDC Luxembourg S.A.
Cergrafhold S.A.
C. & M. S.A.
Concord Luxembourg S.à r.l.
Cure S.A.
Delos ManCo S.à r.l.
Demap S.A.
Easy Tabac Alcool S.A.
ECF Cardiff Office S.à r.l.
Estate Communication
European Finance Corporation
Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg
F.07 Peintures et Façades
F&C Fund
Fonciem
Foretag S.à r.l.
Fourteen Yaw S.A.
GerPoLux Holding S.à r.l.
Global Fashion Group S.A.
Goodman Celadon Logistics (Lux) S.à r.l.
GreenOak European Secured Lending GP S.à r.l.
GreenOak Europe Secured Lending GP S.à r.l.
Hickante S.à r.l.
Iolita Corp
PETOSEVIC Group