This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 397
11 février 2016
SOMMAIRE
Artico Dynamic SIF-SICAV . . . . . . . . . . . . . . .
19013
Axantus Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19056
BBJJ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19035
Boavista Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19046
CKIF ALA Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
19049
Claessens Company SPF S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .
19013
Cofimin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19010
Copadent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19010
Dalia Air Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19010
Davco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19010
Diana Properties S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19054
Digital Services XXXV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
19016
Diversified Holding Company S.à r.l. . . . . . . .
19052
Domaine de la Couronne de Chêne S.A. . . . . .
19011
Endurance Office II Asset S.à r.l. . . . . . . . . . .
19043
Golden Spirits Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19013
Graas-Lavie et Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19014
Great Northern HK S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
19041
Herblux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19014
ICO S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19011
Imagina International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19011
Immo JO S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19012
Immo JO S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19012
Immo JO S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19012
Imondial S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19012
Indeff S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19012
Interact-iv.com Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19011
International Engineering & Construction S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19011
International Security Consulting (I.S.C)
S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19011
Investissements Immobiliers Kirchberg S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19012
IPC Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19013
Isna Car Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19013
JDBS Entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19013
Labeo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19014
LHP Clima S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19014
Luxmicrokine S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19014
Luxury Sofas S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19043
Marguerite Autoroutes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
19010
Mars Propco 13 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19014
Mondial Cash Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
19010
Ravento S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19043
Schou S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19015
Sirta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19015
Tordell S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19015
Tournesol Investissements S.A. . . . . . . . . . . . .
19015
Transports Huberty S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19015
Twoforone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19015
19009
L
U X E M B O U R G
Marguerite Autoroutes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 165.719.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015195546/9.
(150219307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Mondial Cash Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 4, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 191.282.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015195583/9.
(150219196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Cofimin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 90.803.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206440/9.
(150233219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Copadent, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8557 Petit Nobressart, 3 apt B, Noutemerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 133.650.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206469/9.
(150231896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Dalia Air Line, Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 111.757.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206491/9.
(150233339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Davco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 168.448.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206493/9.
(150232142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
19010
L
U X E M B O U R G
Domaine de la Couronne de Chêne S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 94.008.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206514/9.
(150232752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Interact-iv.com Lux, Société Anonyme.
Siège social: L-4364 Esch-sur-Alzette, 3, avenue de la Fonte.
R.C.S. Luxembourg B 179.536.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206768/9.
(150233459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
International Engineering & Construction S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2222 Luxembourg, 36, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 133.019.
Les comptes annuels au 31-12-2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206770/9.
(150233104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
International Security Consulting (I.S.C) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 234, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 149.267.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206771/9.
(150232341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
ICO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 173A, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 99.530.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206781/9.
(150232699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Imagina International, Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 224, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 99.803.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206785/9.
(150233152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
19011
L
U X E M B O U R G
Immo JO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8313 Capellen, 1A, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 111.235.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206788/9.
(150232826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Immo JO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8313 Capellen, 1A, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 111.235.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206789/9.
(150232827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Immo JO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8313 Capellen, 1A, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 111.235.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206790/9.
(150232828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Imondial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 21A, avenue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 101.233.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206801/9.
(150232518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Indeff S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Hiereboesch.
R.C.S. Luxembourg B 96.166.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206802/9.
(150233259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Investissements Immobiliers Kirchberg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 35.533.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206817/9.
(150233281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
19012
L
U X E M B O U R G
IPC Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1541 Luxembourg, 42, boulevard de la Fraternité.
R.C.S. Luxembourg B 154.471.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206824/9.
(150233434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Isna Car Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clemency, 9bis, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 131.661.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206827/9.
(150233169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
JDBS Entreprise, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8552 Oberpallen, 8, rue de la Platinerie.
R.C.S. Luxembourg B 171.237.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206852/9.
(150233058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Artico Dynamic SIF-SICAV, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 161.968.
Les comptes annuels au 30 Juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015204296/9.
(150229723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Claessens Company SPF S.à.r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 175.343.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015204391/9.
(150230231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Golden Spirits Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5555 Remich, 7, place du Marché.
R.C.S. Luxembourg B 174.304.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015204559/9.
(150229600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
19013
L
U X E M B O U R G
Graas-Lavie et Cie, Société en Commandite simple.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 13, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 44.115.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015204562/9.
(150229971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Herblux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 185.856.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015204598/9.
(150230251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Labeo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 87.032.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015204686/9.
(150230022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
LHP Clima S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 4, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 170.697.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015204698/9.
(150230135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Luxmicrokine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 186.398.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015204716/9.
(150229424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Mars Propco 13 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 122.304.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015205688/9.
(150230419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.
19014
L
U X E M B O U R G
Schou S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9357 Bettendorf, 24, Cité Pierre Strauss.
R.C.S. Luxembourg B 93.573.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015205959/9.
(150230776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Sirta S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 193.117.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015205973/9.
(150230611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Tournesol Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 173.496.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206013/9.
(150231230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Tordell S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 112.909.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206035/9.
(150231321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Transports Huberty S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4831 Rodange, 325, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 18.182.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206041/9.
(150230801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Twoforone S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 127.823.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206043/9.
(150230602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.
19015
L
U X E M B O U R G
Digital Services XXXV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.841,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 194.409.
In the year two thousand and fifteen, on the twentieth day of November,
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacement
of his prevented colleague Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg, the
latter named shall remain depositary of the present deed;
THERE APPEARED:
1. Asia Internet Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered address at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg trade
and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B177038 (“Asia Internet Holding”),
being the holder of fifteen thousand (15,000) shares, and becoming the holder of seven hundred ten (710) series A shares,
here represented by Mrs Magdalena Staniczek, professionally residing in Senningerberg,
by virtue of a proxy under private seal given in Berlin (Germany), on 16 November 2015;
2. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered address at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg trade
and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B191426 (“HV Holtzbrinck Ventures Fund
VI”),
becoming the holder of two thousand one hundred thirty one (2,131) series A shares,
here represented by Mrs Magdalena Staniczek, professionally residing in Senningerberg,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on 16 November 2015;
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Asia Internet Holding is the current sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Digital Services XXXV S.à r.l. (the
“Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B194409 and incorporated pursuant to a deed of the notary
Cosita Delvaux, residing in Luxembourg, on 7 January 2015, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations number 758 dated 19 March 2015. The articles of association have never been amended since.
The Sole Shareholder representing the entire share capital declares having waived any notice requirement, the general
meeting of the shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda
whereby HV Holtzbrinck Ventures Fund VI participates and votes for purpose of agenda points 4 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Decision to create two (2) classes of shares in the share capital of the Company, so that the Company will hence have
two (2) classes of shares, represented by common shares (hereinafter the “Common Shares”) and series A shares (hereinafter
the “Series A Shares”).
2. Decision to convert the existing fifteen thousand (15,000) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each,
into fifteen thousand (15,000) Common Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, without cancellation of
shares.
3. Acceptance of HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the
Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B191426, as new sha-
reholder of the Company.
4. Increase of the Company’s share capital by an amount of two thousand eight hundred forty one euros (EUR 2,841.-)
so as to raise it from its current amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) up to seventeen thousand eight hundred
forty one euros (EUR 17,841.-) by issuing two thousand eight hundred forty one (2,841) Series A Shares with a nominal
value of one euro (EUR 1) each.
5. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as
follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at seventeen thousand eight hundred forty-one euros (EUR 17,841.00), repre-
sented by
5.1.1 fifteen thousand (15,000) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, and
19016
L
U X E M B O U R G
5.1.2 two thousand eight hundred forty-one (2,841) series A shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”
6. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:
“A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Digital Services
XXXV S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such
intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property
rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may
be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting
of the shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at seventeen thousand eight hundred forty-one euros (EUR 17,841.00), repre-
sented by
5.1.1 fifteen thousand (15,000) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, and
5.1.2 two thousand eight hundred forty-one (2,841) series A shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
19017
L
U X E M B O U R G
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are to
be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions of
any shareholders’ agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of preemption
or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders’ agreement between the shareholders. To the extent
that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:
7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Asia Internet Holding S.à
r.l. (“Asia Internet Holding”) and the shareholder HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS (“Holtzbrinck”, and together
with Asia Internet Holding the “Investors” and each also an “Investor”) to a company affiliated to such Investor within the
meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);
7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is
directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more direct
or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Controlled” or
“Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company as managing
shareholder or partner, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a con-
tractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and policies
of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective Investor or one
or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;
7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under a simplified
employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme;
7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation proce-
dures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the Company,
if the shareholders of the Company hold more than 50% in any surviving legal entity after such transformation procedure.
7.5 In the cases provided for in Article 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of
first refusal, rights of preemption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.
7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased
shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, if:
8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings is
rejected for lack of assets;
8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and such
enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration of
redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its share
register and to proceed with the relevant filings required by law.
19018
L
U X E M B O U R G
8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one person;
independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform way through
one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement arises.
8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of Article
8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).
Art. 9. Compensation for Redemption.
9.1 Redemption is made against compensation.
9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date
is the date before the redemption resolution.
9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding amounts
including interest.
9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an
auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert arbitrator
shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a shareholder or of the Company. The
decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the Company and the
requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the redemption price and
the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs in case the redemption
price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.
Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.
10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a person
named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or partial
assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.
10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of
association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 11. Collective decisions of the shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
11.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
11.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
11.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can also
be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by a
shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board of
managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
11.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which must
state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written record must
be sent to each shareholder in writing without undue delay.
11.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 12. General meetings of shareholders.
12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may be
specified in the respective convening notices of meeting.
19019
L
U X E M B O U R G
12.2 The shareholders’ meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or regis-
tered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period of
notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders’ meetings and at least two (2) weeks for extraordinary share-
holders’ meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’ meeting
is not counted in the calculation of the period of notice.
12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another shareholder
authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of confidentiality.
12.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the shareholders’
resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’ meeting (for
purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written record.
Art. 13. Quorum and vote.
13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
13.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a
higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company’s shareholders are
only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is no
quorum, a new shareholders’ meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with Article
12.2. This shareholders’ meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this was
pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.
Art. 14. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 15. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority.
Art. 16. Shareholders’ resolutions requiring specific majority.
16.1 Shareholders’ Resolutions regarding the following subjects must be taken by (i) a majority in number of share-
holders (ii) who also constitute a Super Majority:
16.1.1 disposition of all Company’s assets or of a significant part of the Company’s assets including the resolution with
respect to the liquidation of the Company; and
16.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company.
16.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
16.2.1 conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq. German
Stock Corporation Act (AktG));
16.2.2 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of
any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation in
the Company’s profit or any payment that is dependent on the amount of the Company’s profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners;
16.2.3 exclusion of subscription rights in case of capital increases; and
16.2.4 acquisition of the Company’s own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 8.2 and
transfers in accordance with Article 10.1 of these articles of association.
16.3 Whenever the capital of the company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold all
the issued shares of that class.
D. Board of managers - Advisory board
Art. 17. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
17.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
17.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
17.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfill the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or
by these articles of association to the general meeting of shareholders.
19020
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Election, removal and term of office of managers.
18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 19. Vacancy in the office of a manager.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 20. Convening meetings of the board of managers.
20.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
20.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being suf-
ficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in
a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 21. Management.
21.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
21.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
21.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
21.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
21.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
21.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
21.8 The managers shall require the consent of the Advisory Board (as defined below) for the legal transactions and
measures specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and
have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board (as defined below):
21.8.1 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euros
(EUR 200,000.00) in aggregate;
21.8.2 future transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other trans-
actions with derivative financial instruments;
21.8.3 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
19021
L
U X E M B O U R G
21.8.4 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial
importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;
21.8.5 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in
controversy of more than two hundred thousand euros (EUR 200,000.00) in the individual case;
21.8.6 transfer of industrial property rights or documented know-how by the Company to a third party, excluding,
however, such dispositions (i) in the ordinary course of business and (ii) between the Company and direct and indirect
subsidiaries of the Company;
21.8.7 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such
shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company, affiliated companies pursuant to sections 15 et seqq.
German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct or
indirect shareholders, as far as the latter - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The consent
requirement pursuant to this Article 21.8.7 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of business of
the Company and is at arm’s length;
21.8.8 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options) outside
the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in any shareholders’ agreement, if
any.
21.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also required
for the contractual obligation relating thereto. The shareholders’ meeting may by resolution determine further transactions
and measures requiring the consent of the Advisory Board (as defined below). The Advisory Board (as defined below) may
give its consent also in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.
21.10 The shareholders may by shareholders’ resolution adopt rules of procedure for the managers.
21.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 21 apply in the same
manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in the
future.
Art. 22. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if
any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).
22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 23. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager and
class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
Art. 24. Advisory board.
24.1 The Company shall have an advisory board (“Advisory Board”). It shall consist of three (3) voting members. The
shareholders may by way of unanimous shareholders’ consent increase or decrease the number of voting members of the
Advisory Board.
24.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of a unanimous
shareholders’ consent.
24.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s respective
appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:
24.3.1 two (2) voting members of the Advisory Board, each having two (2) votes, shall be nominated by Asia Internet
Holding in its sole discretion; and
24.3.2 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by Holtzbrinck in its sole
discretion.
24.4 Each member of the Advisory Board may be represented by another member of the Advisory Board or any other
representative of the respective party. In this case a written proxy must be presented at the respective Advisory Board
meeting. For this purpose, Asia Internet Holding and Holtzbrinck are entitled to appoint one substitute member for each
Advisory Board member.
19022
L
U X E M B O U R G
24.5 The Advisory Board may have non-voting members of the Advisory Board as observers.
24.6 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Asia Internet
Holding shall be the chairman of the Advisory Board. The rules of procedure of the Advisory Board, if any, may provide
for further provisions in particular on the selforganization of the Advisory Board. The Advisory Board shall adopt reso-
lutions with the simple majority of votes cast. The Advisory Board shall hold meetings on a regular basis, at least once
every calendar quarter.
24.7 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.
E. Audit and supervision
Art. 25. Auditor(s).
25.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
25.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
25.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
25.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
25.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 26. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 27. Annual accounts and allocation of profits.
27.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
27.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
27.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
27.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
27.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
27.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 28. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
28.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a
reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.
28.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 29. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of
shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise
provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities
of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 30. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law and any shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the
Company, and which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles
19023
L
U X E M B O U R G
conflicts with the provisions of any shareholders’ agreement, such shareholders’ agreement shall prevail inter parties and
to the extent permitted by Luxembourg law.
These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English and
the German text, the English version shall prevail.”
7. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, regardless of his category, as well as Ms. Magdalena
Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders register
of the Company.
8. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to create two (2) classes of shares in the share capital of the Company, so
that the Company will hence have two (2) classes of shares, represented by common shares (hereinafter the “Common
Shares”) and series A shares (hereinafter the “Series A Shares”).
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to convert the existing fifteen thousand (15,000) shares, with a nominal
value of one euro (EUR 1) each, into fifteen thousand (15,000) Common Shares, with a nominal value of one euro (EUR
1) each, without cancellation of shares.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to accept HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, aforementioned, as
new shareholder of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two thousand
eight hundred forty one euros (EUR 2,841) so as to raise it from its current amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000)
up to seventeen thousand eight hundred forty one euros (EUR 17,841) by issuing two thousand eight hundred forty one
(2,841) Series A Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
<i>Subscriptioni>
The two thousand eight hundred forty one (2,841) Series A Shares have been entirely subscribed as follows:
- seven hundred ten (710) Series A Shares have been subscribed by Asia Internet Holding, aforementioned, for the price
of seven hundred ten euros (EUR 710.-); and
- two thousand one hundred thirty one (2,131) Series A Shares have been subscribed by HV Holtzbrinck Ventures Fund
VI, aforementioned, for the price of two thousand one hundred thirty one euros (EUR 2,131.-).
<i>Paymenti>
The two thousand eight hundred forty one (2,841) Series A Shares so subscribed have been entirely paid up through
contributions in cash so that an amount of two thousand eight hundred forty one euros (EUR 2,841.-) has been paid and is
as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of two thousand eight hundred forty one euros (EUR 2,841.-) is entirely allocated
to the share capital of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company so that it
shall henceforth read as stated in the agenda.
<i>Sixth resolutioni>
Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders decides to fully restate the articles of association
of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well
as Ms. Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the
shareholders register of the Company.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 1,600.-
19024
L
U X E M B O U R G
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the German texts, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by her name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zwanzigsten November,
Vor Uns, Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in Sanem, Großherzogtum Luxemburg, handelnd in Ver-
tretung seines verhinderten Kollegen Maître Cosita DELVAUX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, der letztgenannte soll der Verwahrer der vorliegenden Urkunde bleiben;
SIND ERSCHIENEN:
1. Asia Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) bestehend
nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B177038 („Asia Internet
Holding“),
Inhaberin von fünfzehntausend (15.000) Anteilen und zukünftige Inhaberin von siebenhundertzehn (710) Anteilen der
Serie A,
hier vertreten durch Frau Magdalena Staniczek, geschäftsansässig in Senningerberg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 16. November 2015, ausgestellt in Berlin (Deutschland);
2. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, eine Gesellschaft (société en commandite simple) bestehend nach dem Recht
des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handels- und Gesell-
schaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B191426 („HV Holtzbrinck Ventures
Fund VI“),
zukünftige Inhaberin von zweitausendeinhunderteinunddreißig (2.131) Anteilen der Serie A,
hier vertreten durch Frau Magdalena Staniczek, geschäftsansässig in Senningerberg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 16. November 2015, ausgestellt in Luxemburg.
Besagte Vollmachten, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur paraphiert
wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Asia Internet Holding ist die derzeitige alleinige Gesellschafterin (die „Alleinige Gesellschafterin“) der Digital Services
XXXV S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz
in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
Luxemburg unter der Nummer B 194409, gegründet am 7. Januar 2015 gemäß einer Urkunde der Notarin Cosita Delvaux,
mit Amtssitz in Luxemburg, welche am 19. März 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
758, veröffentlicht wurde. Die Satzung wurde seitdem nicht geändert.
Da die Alleinige Gesellschafterin das gesamte Gesellschaftskapital vertritt und erklärt, auf jegliche Ladungsformalitäten
verzichtet zu haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über alle
Punkte der folgenden Tagesordnung verhandeln, wobei HV Holtzbrinck Ventures Fund VI ausschließlich für die Punkte
4 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt ist:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschluss bezüglich der Schaffung von zwei (2) Anteilsklassen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft, sodass die
Gesellschaft nunmehr zwei (2) Anteilsklassen hat, bestehend aus Stammanteilen (im Folgenden die „Stammanteile“) und
Anteilen der Serie A (im Folgenden die „Anteile der Serie A“).
2. Beschluss bezüglich der Umwandlung ohne Einziehung von Anteilen der bestehenden fünfzehntausend (15.000)
Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in fünfzehntausend (15.000) Stammanteile mit einem Nomi-
nalwert von je einem Euro (EUR 1).
3. Aufnahme der HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, einer Gesellschaft (société en commandite simple) bestehend
nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B191426, als neue
Gesellschafterin der Gesellschaft.
4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünfzehntausend Euro (EUR
15.000) um einen Betrag von zweitausendachthunderteinundvierzig Euro (EUR 2.841) auf einen Betrag von siebzehntau-
sendachthunderteinundvierzig Euro (EUR 17.841) durch die Ausgabe von zweitausendachthunderteinundvierzig (2.841)
Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
5. Dementsprechende Änderung des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
19025
L
U X E M B O U R G
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt siebzehntausendachthunderteinundvierzig Euro (EUR 17.841,00),
bestehend aus
5.1.1 fünfzehntausend (15.000) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), und
5.1.2 zweitausendachthunderteinundvierzig (2.841) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch
das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“
6. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Digital Services XXXV S.à r.l. (im Folgenden die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw.Wertpapieren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sons-
tige Art.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
19026
L
U X E M B O U R G
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt siebzehntausendachthunderteinundvierzig Euro (EUR 17.841,00),
bestehend aus
5.1.1 fünfzehntausend (15.000) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), und
5.1.2 zweitausendachthunderteinundvierzig (2.841) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch
das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-
gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten, (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestimmungen von
Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrech-
ten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten oder -pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaf-
tern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung von
Anteilen nicht erforderlich:
7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter
Asia Internet Holding S.à r.l. („Asia Internet Holding“) und den Gesellschafter HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS
(„Holtzbrinck“, und zusammen mit Asia Internet Holding die „Investoren“ und jeweils einzeln ein „Investor“) an eine mit
diesem Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);
7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen
Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte oder
indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von diesem
Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder „Kontrolliert
Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnen, durch (a) die Leitung der
Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter oder Partner, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten
der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, direkt oder
indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten stimmberech-
tigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor oder einer oder mehrere
Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
7.4.3 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen (i) an einen Dritten, welcher
Anteile unter einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen
Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;
7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Umwand-
lungsvorgängen gemäß des Umwandlungsrechts Luxemburgs, insbesondere (jedoch nicht beschränkt auf) eine Verschmel-
19027
L
U X E M B O U R G
zung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang mehr als
fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.
7.5 In den in den Artikel 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch
Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte oder -pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.
7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten
gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschafters
für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist jedoch nicht erforderlich, wenn die Anteile
an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen
Gesellschafters übertragen werden.
Art. 8. Rückkauf von Anteilen.
8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen
Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.
8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
8.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil
eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile
automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.
8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine
Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.
8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer im
Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 9. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
9.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile ent-
spricht. Als Stichtag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
9.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-
schaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
ersuchenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.
Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.
10.1 Die Gesellschaft kann verlangen, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters der Gesellschaft) zu übertragen hat,
auch im Falle eines Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft
benannte Person.
10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-
gleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die
Gesellschaft als Garant haftet.
19028
L
U X E M B O U R G
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 11. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
11.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
11.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
11.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß dem vorstehenden Satz eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
11.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
11.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschrif-
ten von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschaf-
terversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 12. Gesellschafterversammlung.
12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in der
entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
12.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4) Wochen für ordentliche Gesellschafterversamm-
lungen und mindestens zwei (2) Wochen für außerordentliche Gesellschafterversammlungen einzuhalten ist. Die Ankün-
digungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung wird bei der Berechnung der
Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
12.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine
schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter, oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Rechnungsprüfer/
Wirtschaftsprüfer mit einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
12.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 13. Quorum und Abstimmung.
13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals
vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
12.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
19029
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.
Art. 16. Gesellschafterbeschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
16.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern (i) eine zahlenmäßige Mehrheit
der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden:
16.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-
gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Auflösung der Gesellschaft; und 16.1.2 Beschluss hinsichtlich der
Verschmelzung, Teilung und Umwandlung der Gesellschaft.
16.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
16.2.1 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
16.2.2 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (zur Klarstellung, nicht durch die Veräußerung von Anteilen) jegli-
cher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei eine
Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft abhängig
ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge, welche im
Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie Verträge
mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbepartnern;
16.2.3 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen; und
16.2.4 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme von Erwerben gemäß Artikel 8.2 und Übertragungen
gemäß Artikel 10.1 dieser Satzung.
16.3 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und
Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
D. Rat der Geschäftsführer - Beirat
Art. 17. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
17.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 18. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
18.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
18.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und
die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
19.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterver-
sammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige
Ernennung entscheidet.
19.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
20.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-
punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abge-
geben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des
19030
L
U X E M B O U R G
Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der
Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 21. Geschäftsführung.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-
führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Geschäftsführer sein muss und der für die
Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
21.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
21.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich, oder per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel
bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
21.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln oder abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
21.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats (wie unten definiert) für die unten genannten Rechts-
geschäfte und Maßnahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise
definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats (wie unten definiert) ge-
nehmigt wurden:
21.8.1 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-
hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;
21.8.2 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Transak-
tionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
21.8.3 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
21.8.4 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-
cher Bedeutung) und allgemeinen Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
21.8.5 Einleitung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streitwert
von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;
21.8.6 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesellschaft
an einen Dritten, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen (i) im gewöhnlichen Geschäftsgang und (ii) zwischen der
Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
21.8.7 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investmentgesellschaften mit verbundenen juristischen und natürlichen
Personen. Als solche werden direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft, verbundene Gesellschaften gemäß §§
15 ff. des deutschen Akteingesetztes (AktG) sowie Angehörige gemäß Abschnitt 15 der deutschen Abgabenordnung (AO)
direkter oder indirekter Gesellschafter angesehen, soweit letztere - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine
Mehrheitsbeteiligung halten. Die Zustimmung gemäß diesem Artikel 21.8.7 ist nicht erforderlich, wenn die Transaktion
zum gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;
19031
L
U X E M B O U R G
21.8.8 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung
jeglicher Anteils- oder Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den
Gesellschaftern in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.
21.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforderlich,
so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesellschaf-
terversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung des
Beirats (wie unten definiert) erfordern. Der Beirat (wie unten definiert) kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen
und Arten von Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.
21.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer
beschließen.
21.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 21, soweit gesetzlich möglich,
auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, an welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Art. 22. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls
vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsame Unterschrift
mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Ver-
treter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine
Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, im Rahmen dieser Übertragung wirksam
verpflichtet.
Art. 24. Beirat.
24.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat („Beirat“). Dieser besteht aus drei (3) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Ge-
sellschafter können durch einstimmige Zustimmung der Gesellschafter die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des
Beirats erhöhen oder herabsetzen.
24.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einstimmige Zustimmung der Gesell-
schafter festlegen und/oder verändern.
24.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden
Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:
24.3.1 zwei (2) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats mit jeweils zwei (2) Stimmen werden von Asia Internet Holding
nach eigenem Ermessen ernannt; und
24.3.2 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von Holtzbrinck nach eigenem Ermessen
ernannt.
24.4 Jedes Mitglied des Beirats kann von einem anderen Mitglied des Beirats oder einem anderen Vertreter der jeweiligen
Partei vertreten werden. In diesem Fall muss bei der betreffenden Sitzung des Beirats eine schriftliche Vollmacht vorgelegt
werden. Zu diesem Zweck sind Asia Internet Holding und Holtzbrinck berechtigt, ein Ersatzmitglied für jedes Beiratsmit-
glied zu ernennen.
24.5 Der Beirat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder des Beirats als Beobachter haben.
24.6 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Asia Internet Holding er-
nanntes stimmberechtigtes Mitglied ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats kann, sofern
vorhanden, weitere Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst
19032
L
U X E M B O U R G
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal
pro Kalenderquartal.
24.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 25. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
25.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
25.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
25.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte der
Gesellschaft.
25.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.
25.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 27. Jahresabschluss und Gewinne.
27.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-
klang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
27.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
27.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-
falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
27.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
27.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-
stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
27.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 28. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
28.1 Der Rat der Geschäftsführer kann beschließen, Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zu
zahlen, welche vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlags-
dividende zur Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls verteilt und darf nicht die Summe der seit
dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne
und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die nach dem Gesetz
von 1915 oder dieser Satzung einer Rücklage zugeführt werden müssen, übersteigen.
28.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-
gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 29. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die
Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt.
Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Andwendbares recht
Art. 30. Anwendbares Recht. Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestim-
mungen des Gesetzes von 1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter mitunter mit der Gesellschaft
19033
L
U X E M B O U R G
eingehen und durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung
mit den Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung
zwischen den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.
Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“
7. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie Frau
Magdalena Staniczek zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit un-
eingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
8. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, zwei (2) Anteilsklassen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft zu schaf-
fen, sodass die Gesellschaft nunmehr zwei (2) Anteilsklassen hat, bestehend aus Stammanteilen (im Folgenden die
„Stammanteile“) und Anteilen der Serie A (im Folgenden die „Anteile der Serie A“).
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, die bestehenden fünfzehntausend (15.000) Anteile mit einem Nominalwert
von je einem Euro (EUR 1) ohne Einziehung von Anteilen in fünfzehntausend (15.000) Stammanteile mit einem Nomi-
nalwert von je einem Euro (EUR 1) umzuwandeln.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, vorbenannt, als neue Gesellschaf-
terin der Gesellschaft anzunehmen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag
von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) um einen Betrag von zweitausendachthunderteinundvierzig Euro (EUR 2.841)
auf einen Betrag von siebzehntausendachthunderteinundvierzig Euro (EUR 17.841) durch die Ausgabe von zweitausen-
dachthunderteinundvierzig (2.841) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die zweitausendachthunderteinundvierzig (2.841) Anteile der Serie A wurden vollständig wie folgt gezeichnet:
- siebenhundertzehn (710) Anteile der Serie A wurden von Asia Internet Holding, vorbenannt, zum Preis von sieben-
hundertzehn Euro (EUR 710) gezeichnet; und
- zweitausendeinhunderteinunddreißig (2.131) Anteile der Serie A wurden von HV Holtzbrinck Ventures Fund VI,
vorbenannt, zum Preis von zweitausendeinhunderteinunddreißig Euro (EUR 2.131) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die so gezeichneten zweitausendachthunderteinundvierzig (2.841) Anteile der Serie A wurden vollständig durch Bar-
einlagen eingezahlt, sodass ein Betrag in Höhe von zweitausendachthunderteinundvierzig Euro (EUR 2.841) gezahlt wurde
und der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was der unterzeichnenden Notarin nachgewiesen wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von zweitausendachthunderteinundvierzig Euro (EUR 2.841) wird vollständig dem Ge-
sellschaftskapital der Gesellschaft zugeführt.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in
der Tagesordnung dargestellt lautet.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der
Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Ka-
tegorie, sowie Frau Magdalena Staniczek, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit
uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
19034
L
U X E M B O U R G
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare oder Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr EUR 1.600,- geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche der Notarin mit Namen, Vornamen
und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten unterzeichnet worden.
Gezeichnet: M. STANICZEK, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37034. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 03. Dezember 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015195957/1068.
(150219730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
BBJJ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 201.934.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-six November.
Before Us Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
Mr. Gerardus Cornelis LANGELAAR, financial advisor, born on 17
th
January 1963, in Amsterdam, Netherlands,
residing at IJweg 973, 2131 LV Hoofddorp, the Netherlands,
here represented by Mrs Cristiana VALENT, employee, residing professionally at Junglinster, by virtue of a proxy given
under private seal.
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, requests the undersigned notary to draw up the Constitutive
Deed of a limited liability company, ("société à responsabilité limitée"), as follows:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated 10th August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the articles of association (hereafter the “Articles”),
which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any
form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever.
2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct or
indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any affiliated
company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the “Connected Companies”). It may also
give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its Connected
Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its
assets
19035
L
U X E M B O U R G
2.3 The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual
property rights of any nature or origin whatsoever.
2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.
2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect invest-
ments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting,
dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging,
pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The private limited liability Company will have the name “BBJJ S.à r.l.”.
Art. 5. The registered office is established in the municipality of Schuttrange.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in
case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12.500.- EUR) divided into twelve thousand five hundred
(12,500) share quotas of one euro (1.- EUR) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’ meeting,
in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements
of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers who need not to be shareholders.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers (“conseil de gérance”).
The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority
of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
single signature of any of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or more ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine any such agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place
will be taken by election among managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by any manager.
The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented
by proxies and provided that at least two managers are physically present. Any decisions by the board of managers shall
be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.
19036
L
U X E M B O U R G
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of commu-
nication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.
The board of managers may pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving
evidence of the resolution. Such resolutions can be documented in a single document or in several separate documents
having the same content signed by all the members of the board of managers.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares
which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly
taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning
at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December.
Art. 16. Each year, with reference to 31
st
of December, the Company’s accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company’s assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their shareholding in the Com-
pany.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim
dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that
the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried
forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in
accordance with the Law or these Articles.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners
or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transistory dispositioni>
The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31
st
of December 2016.
<i>Subscription and payment of the sharequotasi>
The Articles thus having been established, the twelve thousand five hundred (12,500) sharequotas have been subscribed
by the sole shareholder Mr. Gerardus Cornelis LANGELAAR, prenamed, and fully paid up up by the aforesaid subscriber
by payment in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), is from this day on at the
free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.
<i>Costsi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at three thousand euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder, representing the entire corporate capital, has immediately proceeded to an extraordinary general
meeting and has taken the following resolutions:
1.- The registered office is established in Munsbach L-5365, 6C, rue Gabriel Lippmann
19037
L
U X E M B O U R G
2.- The meeting appoints as manager:
Mr. Gerardus Cornelis LANGELAAR, financial advisor, born on 17
th
January 1963, in Amsterdam, Netherlands,
residing at IJweg 973, 2131 LV Hoofddorp, the Netherlands.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the French version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, known to the notary, by surname, Christian name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-six novembre.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Monsieur Gerardus Cornelis LANGELAAR, conseiller financier, né le 17 janvier 1963 à Amsterdam, Pays-Bas, résidant
à IJweg 973, 2131 LV Hoofddorp, Pays-Bas,
ici représenté par Madame Cristiana VALENT, employée, résidant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une
procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les
statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après
“La Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après “La
Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après “les Statuts”), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les
règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2.
2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, sous quelque forme que ce
soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange
ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et
autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée.
2.2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d’octroi de
garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci ne
soit substantiel, ou à toute société qui serait actionnaire direct ou indirect de la Société, ou encore à toute société appartenant
au même groupe que la Société (ci-après reprise comme les «Sociétés Apparentées»). La Société pourra accorder toute
garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou
charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces méthodes, pour l’exécution de tout
contrat ou obligation de la Société ou de Sociétés Apparentées
2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.
2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des
investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la
construction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.
2.6. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société à responsabilité limitée aura la dénomination "BBJJ S.à r.l.”.
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Schuttrange.
19038
L
U X E M B O U R G
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège sociale peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales d’un euro (1.- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée
générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-
sibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la
faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires
de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et
approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la
compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par
la signature individuelle de l’un des membres du conseil de gérance.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
quelconques (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.
Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu
parmi les membres présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.
Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou repré-
sentés.
Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par
procurations et qu'à tout le moins deux de ses membres soient physiquement présents. Toute décision du conseil de gérance
doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la réunion seront signées par tous les gérants présents à la réunion.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens
de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simul-
tanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d’une réunion. Cette décision pourra
être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants
y ayant participé.
Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de commu-
nication similaire. L’ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Ces résolutions pourront
être documentées par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les
membres du conseil de gérance.
19039
L
U X E M B O U R G
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 16. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité
de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la
Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds
de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes de
la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libération des parts socialesi>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par
l'associé unique Monsieur Gerardus Cornelis LANGELAAR, prénommé, et libérées entièrement moyennant un versement
en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre
disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate
expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ mille trois cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, l’associé unique, représentant l'intégralité du capital social, s’est réuni en assemblée générale extraordinaire
et a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann
2.- L'assemblée désigne comme gérant de la société:
Monsieur Gerardus Cornelis LANGELAAR, conseiller financier, né le 17 janvier 1963 à Amsterdam, Pays-Bas, résidant
à IJweg 973, 2131 LV Hoofddorp, Pays-Bas.
19040
L
U X E M B O U R G
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et français, la version française fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par noms prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 01 décembre 2015. Relation GAC/2015/10437. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015195873/311.
(150219846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Great Northern HK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 180.424.
DISSOLUTION
In the year two thousand fifteen, on the twenty-seventh day of November.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appeared:
Peterson (Manchester) Company Limited, a Limited Company, registered at the Companies Registry of Hong Kong
under number 1942097, with registered office at 22/F South China Building, 1-3 Wyndham Street, Central, Hong Kong
(The Sole Shareholder),
Here represented by Mrs Rachida El Farhane, employee, with professional address in Luxembourg ("the proxy") by
virtue of a proxy under private seal given on 23 November 2015 which, after having been signed ne varietur by the appearing
party and the undersigned notary, will be registered with this minute.
The proxy declared and requested the notary to act:
I.- That the société à responsabilité limitée Great Northern HK S.àr.l., having its head office at L-1840 Luxembourg,
28, boulevard Joseph II, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number
180.424, has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on the 18
th
of September 2013, published in the Memorial C, Receuil des Sociétés et Associations number 3113 dated 16 November
2015. The articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing
in Luxembourg, on the 24
th
of October 2013, published in the Memorial C, Receuil des Sociétés et Associations, number
3168 of the 12
th
of December 2013.
II.- That the corporate share capital is presently set at one hundred fifty-six thousand one hundred and twenty British
Pounds (GBP 156,120.-), represented by one thousand and three hundred (1,300) class A shares and one (1) class B share
fully paid up with a par value of one hundred and twenty GBP (GBP 120.-) each.
III.- That the Sole Shareholder, has become the owner of all the shares of the Company, and declares to have full
knowledge of the articles of association and is fully aware of the financial situation of the Company.
IV.- that the Sole Shareholder has resolved to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the company;
V.- that the Sole Shareholder, as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the Company as at
31
st
of October 2015 declares that the known liabilities of the said company have been paid or fully funded, that the sole
shareholder takes over all assets, liabilities and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the
liquidation of the company is terminated without prejudice as he assumes personally all its liabilities.
The appearing party furthermore declares that:
VI. the Company's activities has ceased and following the above resolutions, the Company's liquidation is to be consi-
dered as accomplished and closed;
VII.- That the Sole Shareholder grants full discharge to the managers of the Company for their mandate up to this date.
VIII.- That the books and records of the company will be kept for a period of five years at the former registered office
of the Company (28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
19041
L
U X E M B O U R G
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by
reason of the present deed are estimated approximately at one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-sept novembre.
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Peterson (Manchester) Company Limited, une société à responsabilité limitée, enregistrée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Hong Kong, sous le numéro 1942097 dont le siège social se situe au 22/F South China Building,
1-3 Wyndham Street, Central Hong Kong (L'Associé Unique),
ici représentée par Madame Rachida El Farhane, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg ("le manda-
taire"), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 23 novembre 2015, laquelle, après avoir été signée ne
varietur par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée
avec lui.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses décla-
rations et constatations:
I.- Que la société à responsabilité limitée Great Northern HK S.àr.l.", ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 28,
boulevard Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro B 180.424,
a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 Septembre
2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3113 du 16 novembre 2015. Les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois par acte reçu par Maître Henri Hellinckx en date du 24 octobre 2013 et publié au Mémorial
C numéro 3168 du 12 décembre 2013.
II.- Que le capital social s'élève actuellement à cent cinquante-six mille et cent-vingt livres sterling (156.120,- GBP)
représenté par mille trois cents (1.300) parts sociales de classe A et une (1) part sociale de classe B d'une valeur nominale
de cent vingt livres sterling (120,- GBP) chacune et intégralement libérée.
III.- Que l'Associé Unique est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'il déclare avoir
parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société.
IV.- que la partie comparante, en sa qualité d'associé unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée
et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
V.- que l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 31 octobre 2015,
déclare que toutes les dettes connues ont été payées ou provisionnées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs,
passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée
sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
VI.- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats
jusqu'à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant la période légale de cinq ans à l'ancien
siège social de la Société (c'est-à-dire 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire par ses noms, prénom
usuels, état et demeure, ladite comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: El Farhane, GRETHEN.
19042
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 01 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37833. Reçu soixante-quinze
euros (75,00 €)
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Référence de publication: 2015196049/102.
(150220849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Luxury Sofas S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 122.559.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015203816/9.
(150228624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.
Ravento S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Endurance Office II Asset S.à r.l.).
Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 129.061.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of the month of November;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
The joint-stock company “SIDOTI a.s.”, established and existing under the laws of the Czech Republic, having its
registered office at Vladislavova 1390/17, Nové Mesto, 110 00 Prague 1, Czech Republic (previously Prague 1, Václavské
námestí 1601/47, Postal Code 110 00, Czech Republic), Business ID No. 281 81 204, registered in the Commercial Register
maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File No 12581, (the “Principal”),
represented by its director with sole power of signature, Mr Martin NEMECEK.
The appearing party, has declared and requested the officiating notary to state:
- That the address of “SIDOTI a.s.”, prequalified, has changed and it is now set at Vladislavova 1390/17, Nové Mesto,
110 00 Prague 1,
- That the private limited liability company “ENDURANCE OFFICE II ASSET S.à r.l.”, established and having its
registered office in L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register, section B, under number 129061 , (the “Company”), has been incorporated on May 4, 2007, pursuant to a deed
of Me Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 1613 of the August 1, 2007,
and that the articles of association (the “Articles”) have been amended several times and for the last time on April 14,
2015, pursuant to a deed of the officiating notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1490 of June 12, 2015;
- That the Principal is the sole actual partner (the “Sole Partner”) of the Company and that it has taken, through its Proxy-
holder, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Partner decides to change the denomination of the Company from “ENDURANCE OFFICE II ASSET S.à
r.l.” into “Ravento S.à r.l.”.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Partner decides to amend article 1 of the Articles in order to read
as follows:
“ Art. 1. Form, Corporate Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under
the name of Ravento S.à r.l. (hereafter the «Company»), which will be governed by the laws pertaining to such an entity,
and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as
by the present articles of association (hereafter the «Articles»).”
19043
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
The Sole Partner decides to amend the representation of the Company and signature regime and to amend subsequently
articles 10 (two first paragraphs), 11 (first paragraph) and 12 of the Articles in order to read as follows:
Art. 10. (two first paragraphs).
“ Art. 10. Management. The Company is managed by at least one manager who need not to member and who is appointed
by the general meeting of members. The Company shall have “class A” managers and/or “class B” managers, whereby the
classes of managers are set by a resolution of the members. The managers may be removed at any time, with or without
cause, by a resolution of members holding a majority of votes.
The managers have the same rights to participate and vote at any meeting of the board of managers, regardless of their
class. However, to be valid, a resolution of the board of managers shall be adopted by the majority of “class A” managers.”
Art. 11. (first paragraph).
“ Art. 11. Powers of the managers. In dealing with third parties and subject to the limitations set in article 12, the managers
will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.”
Art. 12.
“ Art. 12. Representation of the Company. The Company shall be bound by the joint signatures of two “class A”
managers. In the event there is only one “class A” manager in the office, the Company shall be bound by an individual
signature of one “class A” manager. The Company shall be also bound by the joint signatures of one “class A” manager
together with one “class B” manager. A “Class B” manager shall only sign jointly together with a “class A” manager.”
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Partner decide to dismiss the current managers, Mr Martin NEMECEK and Mr Zdenek HAVELKA, with
immediate effect, and to appoint, for an unlimited period of time, two new managers:
- Mr Radovan VÍTEK, born on January 22, 1971 in Mesto na Morave, Czech Republic, residing at Résidence des Pierres,
Route de la Moubra 21, 3963 Crans-Montana, Switzerland, and
- Mr Marek GALVAS, born on April 17, 1975 in Brno, Czech Republic, residing at Bĕly Pažoutové 686/16, Komin,
624 00 Brno, Czech Republic,
as “class A” managers.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the representative of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said representative has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-cinq novembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
A COMPARU:
La société anonyme “SIDOTI a.s.”, établie et existant sous les lois de la République Tchèque, ayant son siège social à
Vladislavova 1390/17, Nové Mesto, 110 00 Prague 1, République Tchèque (anciennement Prague 1, Václavské námestí
1601/47, Postal Code 110 00, Czech Republic), Business ID No. 281 81 204, inscrite au Commercial Register conservé au
Municipal Court de Prague, section B, numéro document 12581, (la «Comparante»),
représentée par son administrateur avec pouvoir de signature individuel, Monsieur Martin NEMECEK.
La comparante, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que l'adresse de “SIDOTI a.s.”, préqualifiée, a changée et qu'elle est domiciliée à Vladislavova 1390/17, Nové Mesto,
110 00 Prague 1,
- Que la société à responsabilité limitée “ENDURANCE OFFICE II ASSET S.à r.l.”, établie et ayant son siège social
à L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
19044
L
U X E M B O U R G
sous le numéro 129061, (la “Société”), a été constituée en date du 4 mai 2007, suivant acte reçu par Maître Henri HEL-
LINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1613 du 1er août 2007,
et que les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 14 avril 2015 suivant acte
reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1490 du 12 juin
2015;
- Que la comparante est la seule associée actuelle (l'“Associé Unique”) de la Société et qu'elle a pris, par son Mandataire,
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société de “ENDURANCE OFFICE II ASSET S.à r.l.” en
“Ravento S.à r.l.”.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 1 des Statuts afin de lui donner la teneur
suivante:
“ Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Ravento S.à
r.l. (ci-après «la Société»), qui sera régie par les lois relatives à une telle entité, et en particulier la loi du 10 août 1915
relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (ci-après les
«Statuts»).”
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier la représentation de la Société et le régime de signature et de modifier par consé-
quent les articles 10 (deux premiers paragraphes), 11 (premier paragraphe) et 12 des Statuts, afin de leur donner la teneur
suivante:
Art. 10. (deux premiers paragraphes).
“ Art. 10. Gérance. La Société est gérée par au moins un gérant qui ne doit pas obligatoirement être associé et qui est
nommé par l' assemblée générale des associés. La Société aura des gérants de “classe A” et/ou des gérants de “classe B”,
de telles classes de gérants étant instaurées suivant décision des associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Les gérants ont les mêmes droits de participer et voter à toute reunion du conseil de gérance, indépendamment de leur
classe. Cependant, pour être valable, une résolution du conseil de gérance devra être adoptée par la majorité des gérants
de “classe A”.”
Art. 11. (premier paragraphe).
“ Art. 11. Pouvoirs des gérants. Dans les rapports avec les tiers, et sous réserve des restrictions énoncées à l'article 12,
les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tout acte et opération
conformément à l' objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.”
Art. 12.
“ Art. 12. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par les signatures conjointes de deux gérants
de “classe A”. Au cas où il n'y aurait qu'un gérant de “classe A” en fonction, la Société sera valablement engagée par la
signature individuelle d' un gérant de “classe A”. La Société sera également valablement engagée par les signatures con-
jointes d' un gérant de “classe A” et d' un gérant de “classe B”. Un gérant de “classe B” ne pourra signer que conjointement
avec un gérant de “classe A”.”
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de révoquer les gérants actuels, Monsieur Martin NEMECEK et Monsieur Zdenek HAVELKA,
avec effet immédiat, et de nommer, pour une durée indéterminée, deux nouveaux gérants:
- Monsieur Radovan VITEK, né le 22 janvier 1971 à Nové Mesto na Morave, République Tchèque, demeurant Résidence
des Pierres, Route de la Moubra 21, 3963 Crans-Montana, Suisse, et
- Monsieur Marek GALVAS., né le 17 avril 1975 à Brno, République Tchèque, demeurant Bĕly Pažoutové 686/16,
Komin, 624 00 Brno, République Tchèque,
comme gérants de “classe A”.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.
19045
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au représentant de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant connu du notaire par
nom, prénom, état civil et domicile, ledit représentant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. NEMECEK, C. WERSANDT
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 27 novembre 2015. 2LAC/2015/27049. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Référence de publication: 2015195996/153.
(150219752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Boavista Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 164.302.
In the year two thousand and fifteen, on the twentieth day of November.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the shareholder of “BOAVISTA FINANCE S.A-. (the “Company”, a société
anonyme, having its registered office in L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, registered at the Trade Register of
Luxembourg section B under number 164.302, incorporated by deed dated 24
th
of October, 2011, enacted by Maître Emile
SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, "Recueil des Sociétés et Associations", on
the 9
th
of December, 2011, number 3030, page 145428 and whose articles of association (the “Articles”) have not been
amended since.
The meeting is presided by Mr. Mustafa NEZAR, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The Chairman appoints, as secretary, Ms Rachida EL FARHANE, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Ms Monique DRAUTH, employee, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting (the “Board”) having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the
officiating notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. to transfer the registered office, administrative and effective management seat with effect as of today from the Grand
Duchy of Luxembourg to the Republic of Panama and to change the Company's nationality into Panamanian without
however that such change in nationality and transfer of the registered office will imply from a legal and tax point of view
the incorporation of a new legal entity, the whole under the suspensive condition of the Company's registration in Panama
(Public registry of Panama);
2. to approve the interim balance sheet of the Company.
3. to fix the address of the new registered office of the Company at Humboldt Tower, Piso 2, Calle 53 Este Marbella,
ciudad de Panamá, República de Panamá;
4. to accept the resignation of the sole director and of the statutory auditor of the Company and to give full discharge;
5. to appoint Aleman, Cordero & Lee Trust (Panama) SA as registered agent and grant all powers to any employee, in
order to handle all administrative formalities relating to the registration of the Company in Panama, to sign all acts and
documents and take all the necessary steps, do all necessary requisitions, declarations and delegations relating to this;
6. to grant to any employee of the company VISTRA (Luxembourg) S.à r.l.”, with registered office in L-2540 Luxem-
bourg, 15, rue Edward Steichen, the widest and all necessary powers to proceed to the deregistration of the Company at
the Luxembourg Trade and Companies Registry;
7. miscellaneous.
B) That the sole shareholder, present or represented, as well as the number of the shares held by him, are shown on an
attendance list; this attendance list is signed by the proxyholder of the represented shareholder, the members of the Board
of the meeting and the officiating notary.
19046
L
U X E M B O U R G
C) That the proxy of the represented shareholder, signed “ne varietur” by the members of the Board of the meeting and
the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that the sole shareholder
declares having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving to the usual formalities
of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
The sole shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to transfer the registered office, administrative and effective management seat with effect
as of today from the Grand Duchy of Luxembourg to the Republic of Panama and to change the Company's nationality
into Panamanian without however that such change in nationality and transfer of the registered office will imply from a
legal and tax point of view the incorporation of a new legal entity, the whole under the suspensive condition of the Company's
registration in Panama.
The sole shareholder resolves to approve the interim balance sheet of the Company as of 12 November 2015.
A copy of such interim balance sheet, after being signed “ne varietur” by the members of the Board and the officiating
notary, will remain annexed to the present deed for registration purposes.
The sole shareholder decides to confirm that all the assets and all the liabilities of the Company previously of Luxembourg
nationality, without limitation, will remain the ownership in their entirety of the Panamanian Company maintained without
discontinuance, which will continue to own all the assets and will continue to be obliged by all the liabilities and commit-
ments of the Company previously of Luxembourg nationality.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder accepts the resignation of the sole director of the Company with immediate effect and fully dis-
charges the sole director for the mandate up to this date.
The sole shareholder accepts the resignation of the statutory auditor of the Company with immediate effect and fully
discharges the statutory auditor for the mandate up to this date.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolves that the address of its registered office in Panama shall be fixed at Humbolt Tower, East
53
rd
Street, Urb. Marbella, Panama City, Republic of Panama.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder resolves to elect Aleman, Cordero & Lee Trust (Panama) SA as registered agent and grant all
powers to any employee, in order:
- to handle all administrative formalities relating to the registration of the Company in Panama
- to sign all acts and documents and take all the necessary steps, do all necessary requisitions, declarations and delegations
relating to this.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder resolves to grant all powers to Vistra (Luxembourg) S.à r.l. in order to carry out the radiation of
the company in Luxembourg.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, they signed together with us, the notary, the present original deed.
Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text
will prevail:
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de novembre.
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.
Se réunit
19047
L
U X E M B O U R G
une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «BOAVISTA FINANCE S.A.», une société anonyme,
dont le siège social est établi à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.302, constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 24 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en
date du 9 décembre 2011, numéro 3030, page 145428 et dont les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Rachida EL FARHANE, salariée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’Assemblée élit comme scrutateur Madame Monique DRAUTH, salarié, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le bureau de l’assemblée (le “Bureau”) ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant
d'acter:
A) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. de transférer le siège social, administratif et le siège de direction effective avec effet à la date de ce jour du Grand-
Duché de Luxembourg vers la République de Panama, et en conséquence pour la Société, d'adopter la nationalité
panaméenne, le transfert du siège et le changement de nationalité ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement à la
dissolution ni à la constitution d'une nouvelle société, le tout sous condition suspensive de l’inscription de la société au
Public Registry of Panama;
2. d'approuver le bilan intérimaire de la Société.
3. de fixer le nouveau siège de la Société à Humbolt Tower, East 53
rd
Street, Urb. Marbella, Panama City, République
de Panama;
4. d'accepter la démission de l’administrateur unique et du commissaire aux comptes de la Société avec décharge.
5. de nommer comme agent représentatif Aleman, Cordera, Galindo & Lee Trust Panama SA et d'accorder tous pouvoirs
généralement quelconques à l’effet d'accomplir toutes les formalités administratives nécessaires à l’inscription de la société
au Panama, d'accomplir toutes formalités administratives afin d'enregistrer la Société au Panama, de signer tous actes et
documents y afférents et de faire toutes les démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives
6. de conférer à tout salarié de la société VISTRA (Luxembourg) S.à r.l., avec siège social à L-2540 Luxembourg, 15,
rue Edward Steichen, tous les pouvoirs nécessaires et étendus pour opérer la radiation de la Société au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg.
7. divers.
B) Que l’actionnaire présent ou représenté, ainsi que le nombre de actions qu’il détient, est porté sur une liste de présence;
cette liste de présence est signée par le mandataire, les membres du Bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que la procuration de l’actionnaire représenté, signée “ne varietur” par les membres du Bureau de l’Assemblée et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisées avec lui.
D) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée et que l’actionnaire unique, déclare avoir été dûment
notifié et avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renonce aux formalités de convocation
d'usage, aucune autre convocation n'étant nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.
Ensuite l’actionnaire unique prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’actionnaire unique décide de transférer le siège social, administratif et le siège de direction effective avec effet à la
date de ce jour du Grand-Duché de Luxembourg vers la République de Panama, et de faire adopter par la Société la
nationalité panaméenne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement,
ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle, et le tout sous la condition suspensive de l’inscription
de la Société au Panama (au Public Registry of Panama).
L’actionnaire unique décide d’approuver, sans restriction, ni réserve le bilan intérimaire de la Société, arrêté au 12
novembre 2015.
Une copie de ce bilan intérimaire, après avoir été signée “ne varietur” par tous les membres du Bureau et par le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
L’actionnaire unique décide de confirmer que tous les actifs et passifs de la société, précédemment de nationalité lu-
xembourgeoise, sans limitation, resteront la propriété de la Société panaméenne, maintenue sans discontinuité, laquelle
continuera à être propriétaire et à être obligée par tous les passifs et engagements de la Société, anciennement de nationalité
luxembourgeoise.
19048
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L’actionnaire unique accepte la démission de l’administrateur unique de la société avec effet immédiat et lui donne
quitus, pleine et entière décharge.
L’actionnaire unique accepte la démission du commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat et lui donne
quitus, pleine et entière décharge.
<i>Troisième résolutioni>
L'actionnaire unique décide de fixer l’adresse du nouveau siège social de la Société au Panama à Humbolt Tower, East
53
rd
Street, Urb. Marbella, Panama City, République de Panama.
<i>Quatrième résolutioni>
L’actionnaire unique décide de nommer comme agent représentatif Aleman, Cordera, Galindo & Lee Trust Panama SA
et d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à l’effet:
- d'accomplir toutes les formalités administratives nécessaires à l’inscription de la société au Panama;
- d'accomplir toutes formalités administratives afin d'enregistrer la Société au Panama;
- de signer tous actes et documents y afférents et de faire toutes les démarches, réquisitions, déclarations et délégations
y relatives.
<i>Cinquième résolutioni>
L’actionnaire unique décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à l’effet de radier l’inscription de la
Société au Luxembourg à tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l.
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et do-
miciles, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Nezar, El Farhane, Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37020. Reçu soixante-quinze
euros (75,00 €)
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Référence de publication: 2015195882/178.
(150219873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
CKIF ALA Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 200.704.
In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of the month of November;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
CITIC KAZYNA GP Ltd., a company incorporated and existing under the laws of Cayman Islands, having its registered
office at Offices of Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman
Islands, registered with Registrar of Companies of the Cayman Islands under number MC-219121,
here represented by Mrs Candice DE BONI, employee, residing professionally in Luxembourg,
(the “Proxy-holder”), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne varietur”
by the Proxy-holder of the appearing party and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to
be recorded with it.
Such appearing party, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to state:
- That the private limited liability company “CKIF ALA INVESTMENT S.à r.l.”, established and having its registered
office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d’Esch, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section
B, under number 200704, (the “Company”), has been incorporated on October 2, 2015 pursuant to a deed of the officiating
notary, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
19049
L
U X E M B O U R G
and that its articles of association (the “Articles”) have not been amended since then;
- That the appearing party is the sole actual partner (the “Sole Partner”) of the Company and that it has taken, through
its Proxy-holder, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Partner decides to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred eighty thousand
US Dollars (180,000.- USD) in order to raise it from its present amount of twenty thousand US Dollars (20,000.- USD) to
two hundred thousand US Dollars (200,000.- USD), by the creation and issue of:
- nine (9) class A shares;
- nineteen thousand nine hundred ninety-nine (19,999) class B shares;
- nineteen thousand nine hundred ninety-nine (19,999) class C shares;
- nineteen thousand nine hundred ninety-nine (19,999) class D shares;
- nineteen thousand nine hundred ninety-nine (19,999) class E shares;
- nineteen thousand nine hundred ninety-nine (19,999) class F shares;
- nineteen thousand nine hundred ninety-nine (19,999) class G shares;
- nineteen thousand nine hundred ninety-nine (19,999) class H shares;
- nineteen thousand nine hundred ninety-nine (19,999) class I shares; and
- nineteen thousand nine hundred ninety-nine (19,999) class J shares;
(the “New Shares”), with a nominal value of one US Dollar (1.- USD) each, benefiting of the same rights and advantages
as the presently issued shares, to be issued with a share premium of an aggregate amount of nine million eight hundred
thousand US Dollars (9,800,000.- USD),
and to allocate to the legal reserve an amount of twenty thousand US Dollars (20,000.- USD).
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Partner, represented as stated here before, declares to subscribe to the New Shares and to fully pay
them up, together with the related share premium and the amount to be allocated to the legal reserve, by a contribution in
cash, so that the amount of ten million US Dollars (10,000,000.- USD) is from now on at the free disposal of the Company,
as it has been proved to the notary by a bank certificate, who states it expressly.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above taken resolution, the Sole Partner resolves to amend article 5.1 of the Articles in order
to give it the following wording:
“ 5.1. The Company's corporate capital is fixed at two hundred thousand US Dollars (USD 200,000) represented by two
hundred thousand (200,000) shares (each a “Share” and together the “Shares”) divided into classes of shares (each a "Class
of Shares" and together the "Classes of Shares") as follows:
- 20,000 class A shares (the "Class A Shares");
- 20,000 class B shares (the "Class B Shares ");
- 20,000 class C shares (the "Class C Shares ");
- 20,000 class D shares (the "Class D Shares ");
- 20,000 class E shares (the "Class E Shares ");
- 20,000 class F shares (the "Class F Shares ");
- 20,000 class G shares (the "Class G Shares ");
- 20,000 class H shares (the "Class H Shares ");
- 20,000 class I shares (the "Class I Shares "); and
- 20,000 class J shares (the "Class J Shares "),
in registered form, each share with a par value of one US Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up.”
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is estimated at approximately four thousand six hundred
Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of discrepancies between
the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of this document.
19050
L
U X E M B O U R G
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du mois de novembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
A COMPARU:
CITIC KAZYNA GP LTD, une société constituée et existant suivant les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à
Offices of Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands,
et enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro MC-219121,
ici représentée par Madame Candice DE BONI, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
(le “Mandataire”), en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé; laquelle procuration, après avoir été signée
“ne varietur” par le Mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin
d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société à responsabilité limitée “CKIF ALA INVESTMENT S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-2086
Luxembourg, 412F, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 200704, (la “Société”), a été constituée le 2 octobre 2015 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
et que ses statuts (les “Statuts”) n'ont pas été modifiés depuis lors;
- Que la partie comparante est la seule associée actuelle (l'“Associé Unique”) de la Société et qu'elle a pris, par son
Mandataire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de cent quatre-vingt
mille dollars américains (180.000,- USD) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille dollars américains (20.000,-
USD) à deux cent mille dollars américains (200.000,- USD), par la création et l’émission de:
- neuf (9) parts sociales de catégorie A;
- dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (19.999) parts sociales de catégorie B;
- dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (19.999) parts sociales de catégorie C;
- dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (19.999) parts sociales de catégorie D;
- dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (19.999) parts sociales de catégorie E;
- dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (19.999) parts sociales de catégorie F;
- dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (19.999) parts sociales de catégorie G;
- dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (19.999) parts sociales de catégorie H;
- dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (19.999) parts sociales de catégorie I; et
- dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (19.999) parts sociales de catégorie J;
(les “Nouvelles Parts Sociales”), d'une valeur nominale de un dollar américain (1,- USD) chacune, bénéficiant des mêmes
droits et avantages que les parts sociales existantes, assorties d’une prime d’émission d’un montant total de neuf millions
huit cent mille dollars américains (9.800.000,- USD),
et d’allouer une somme de vingt mille dollars américains (20.000,- USD) à la réserve légale.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite, l'Associé Unique, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales les libérer
intégralement, ensemble avec la prime d’émission y relative et le montant à allouer à la réserve légale, moyennant apport
en numéraire, de sorte que la somme de dix millions de dollars américains (10.000.000,- USD) se trouve dès à présent à la
libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution prise ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l’article 5.1 des Statuts afin de lui
donner la teneur suivante:
“ 5.1. Le capital social est fixé à deux cent mille dollars américains (USD 200.000) représenté par deux cent mille
(200.000) parts sociales (individuellement «part sociale» et collectivement «parts sociales») réparties en catégories de parts
sociales (individuellement «Catégorie de Parts Sociales» et collectivement «Catégories de Parts Sociales») comme suit:
- 20.000 Parts Sociales de catégorie A (les "Parts Sociales De Catégorie A");
19051
L
U X E M B O U R G
- 20.000 Parts Sociales de catégorie B (les "Parts Sociales De Catégorie B");
- 20.000 Parts Sociales de catégorie C (les "Parts Sociales De Catégorie C");
- 20.000 Parts Sociales de catégorie D (les "Parts Sociales De Catégorie D");
- 20.000 Parts Sociales de catégorie E (les "Parts Sociales De Catégorie E");
- 20.000 Parts Sociales de catégorie F (les "Parts Sociales De Catégorie F");
- 20.000 Parts Sociales de catégorie G (les "Parts Sociales De Catégorie G");
- 20.000 Parts Sociales de catégorie H (les "Parts Sociales De Catégorie H");
- 20.000 Parts Sociales de catégorie I (les "Parts Sociales De Catégorie I"); et
- 20.000 Parts Sociales de catégorie J (les "Parts Sociales De Catégorie J");
sous forme nominative d'une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.”
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de quatre mille six cents
euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par
nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous, le notaire, la présente minute.
Signé: C. DE BONI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 24 novembre 2015. 2LAC/2015/26658. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 30 novembre 2015.
Référence de publication: 2015195935/154.
(150219942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Diversified Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 50.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 161.054.
In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of November.
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.
Was held
the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public liability company "DIVERSIFIED HOLDING
COMPANY S.à r.l..", a "société à responsabilité limitée" established under Luxembourg law, having its registered office
in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch (the “Company”),incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
on 19 May 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1813 of 9 August 2011, filed
in the Companies and Trade Register of Luxembourg under section B 161054.
The meeting was presided by Mr Ahcène Boulhais, employee, professionally residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Mrs Solange Wolter-Schieres, employee, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Laurence Petit, employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held and to be held by them is shown on an attendance
list. That list and the proxies signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.
II. As it appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the Company, are represented
so that the sole shareholder exercising the powers devolved to the meeting can validly decide on all items of the agenda of
which the shareholders have been beforehand informed.
19052
L
U X E M B O U R G
III.- The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to proceed with the anticipated dissolution of the company with immediate effect and to put it into liquidation.
2. Appointment of one Liquidator and specification of his powers.
3. Discharge of the Managers for the period of January 1
st
2015 until the date of the present Meeting.
4. Miscellaneous
Having taken knowledge of the agenda, the General Meeting adopts the following resolutions by a unanimous vote of
the shareholders present or represented.
<i>First resolutioni>
The meeting resolves that the Company be, and hereby is, dissolved and put into liquidation, with immediate effect, in
accordance the Luxembourg company law on the commercial companies.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the meeting decides to appoint Minerva Middle East DMCC, Office 2102,
21
st
Floor, Saba Tower 1, Jumeira Lakes Towers, PO Box 24075, Dubai, United Arab Emirates, as liquidator of the
Company (the “Liquidator”).
The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the Law.
The Liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the Law without requesting the authorization
of the general meeting in the cases in which it is requested.
The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all
in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of all
the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.
The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such
part of its powers it determines and for the period it will fix.
<i>Third resolutioni>
The meeting gives discharge to the Managers for the period of January 1
st
2015 until the date of the present Meeting.
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby declares that at the request of the persons appearing,
named above, this deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same persons appearing,
in case of divergences between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated to persons appearing known to the undersigned notary by their names,
usual surnames, civil status and residences, the said persons appearing have signed with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction en français.
L'an deux mil quinze, le treize novembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des associés de "DIVERSIFIED HOLDING COMPANY S. à r.l.", une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch (ci-après
la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 mai 2011, publié au Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations numéro 1813 du 9 août 2011, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 161054.
L'assemblée générale extraordinaire est présidée par Monsieur Ahcène Boulhais, employé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le Président nomme comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Laurence Petit, employée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent et vont détenir sont renseignés sur une
liste de présence. Cette liste et les procurations(une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.
19053
L
U X E M B O U R G
II. Ainsi qu'il résulte de ladite liste de présence, toutes les parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l'associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à
l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont préalablement été
informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Décision de procéder à la dissolution anticipée de la société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.
2. Nomination d'un Liquidateur et détermination de ses pouvoirs
3. Décharge aux Gérants pour la période du 1
er
janvier 2015 jusqu'à la date de cette assemblée.
4. Divers
Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, l'Assemblée Générale adopte les résolutions suivantes à l'unanimité
des votes des actionnaires présents ou représentés.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide la dissolution de la Société et sa mise en liquidation avec effet immédiat, conformément aux dis-
positions de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution ci-dessus, l'assemblée décide de nommer Minerva Middle East DMCC, Office 2102,
21
st
Floor, Saba Tower 1, Jumeira Lakes Towers, PO Box 24075, Dubai, Emirats Arabes Unis, en qualité de liquidateur
de la Société (le “Liquidateur”).
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus tels que prévu aux articles 144 à 148 bis de la Loi.
Le Liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi sans demander l'autorisation de l'assemblée
générale dans les cas où cette autorisation serait requise.
Le Liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les droits
réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les
inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.
Le Liquidateur n'a pas à faire l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le Liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs
mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée donne décharge aux gérants pour la période du 1
er
janvier 2015 jusqu'à la date de cette assemblée.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent
procès verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant, sur demande
des mêmes comparants, faire foi en cas de divergence avec la version française.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par noms, prénoms
usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. BOULHAIS, L. PETIT, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/36295. Reçu douze euros (12.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Référence de publication: 2015195967/120.
(150219663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Diana Properties S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 110.077.
DISSOLUTION
L'AN DEUX MILLE QUINZE, LE VINGT-SIX NOVEMBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.
19054
L
U X E M B O U R G
A comparu:
Société Immobilière Civile TROIZA, une société immobilière civile de droit monégasque ayant son siège social au 25,
Boulevard Albert 1
er
, MC-98000 Montecarlo, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Montecarlo
sous le numéro 06SC12384,
ici représentée par Madame Stéphanie RAGNI, employée privée, demeurant professionnellement au 23, rue Jean Jaurès,
L-1836 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 18 novembre 2015, laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par
le mandataire de la comparante et la notaire soussignée, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée,
ci-après nommée «l’associée unique».
Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- que la société à responsabilité limitée DIANA PROPERTIES S.à r.l., ayant son siège social à L-1836 Luxembourg,
23 rue Jean Jaurès, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B, sous le
numéro 110.077, ci-après dénommée «la Société», a été constituée par Maître Alphone LENTZ, notaire de résidence à
Remich, en date du 12 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°1483 du 31 décembre
2005;
- que le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 125 (cent
vingt-cinq) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes entièrement libérées;
- que l’associé unique s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société;
- que l’activité de la Société ayant cessé, l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme associé unique
en assemblée générale extraordinaire prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
- que l’associé unique se désigne lui-même comme liquidateur de la Société, et en cette qualité il a rédigé son rapport
de liquidation, lequel reste annexé au présent acte. L’associé unique tel que représenté déclare que tout le passif a été payé.
L’actionnaire unique déclare reprendre tout l’actif de la société et il déclare encore que par rapport à d’éventuels passifs
de la Société actuellement inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout
ce passif éventuel, qu’en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;
- que l’actif restant est réparti à l’associé unique;
- que les déclarations du liquidateur ont été vérifiées par la société CHESTER & JONES S.à.r.l., une société à respon-
sabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 14, rue Bernard Haal L-1711 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120602, désignée comme «commissaire
à la liquidation» par l’associé unique de la Société; lequel confirme l’exactitude du rapport du liquidateur;
- que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la Société pour l’exercice de leurs mandats respectifs, depuis
la constitution de la société jusqu'à ce jour;
- que décharge pleine et entière est donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l’exercice de leurs
mandats respectifs;
- que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la Société
au 23, rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg;
Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités
à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accomplir toutes
les formalités.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à
raison des présentes est évalué à environ EUR 1.300,-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue française au mandataire de la comparante, connu du notaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. RAGNI, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 01 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37929. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 décembre 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015195956/64.
(150220050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
19055
L
U X E M B O U R G
Axantus Capital, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 159.163.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le vingt-cinq novembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A COMPARU:
M. Bernard ROUSSELOT, administrateur, né le 26 septembre 1949 à Molsheim (France), ayant son adresse profes-
sionnelle à L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, 75, Parc d'Activités, associé unique de la société, (le
«comparant»),
ici dûment représenté par M. Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglisnter, en vertu d'une
procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte
avec lequel elle sera enregistrée.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:
I.- Que la société à responsabilité limitée «AXANTUS CAPITAL», ayant son siège social à L-8308 Capellen, Grand-
Duché de Luxembourg, 75, Parc d'Activités, R.C.S. Luxembourg numéro B 159163 (la «Société»), a été constituée suivant
acte reçu par Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg en date du 10 février 2011,
publié au Mémorial C numéro 1072 du 20 mai 2011.
II.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq-cents euros (EUR 12.500,-) représenté
par douze mille cinq-cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.
III.- Que le comparant est l'associé unique de la Société.
IV.- Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la Société qui a interrompu ses activités.
V.- Que le comparant se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter
et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre
en exécution les dispositions du présent acte.
VI.- Que le comparant, en sa qualité de liquidateur de la Société, au vu des comptes de liquidation (bilan, compte de
profits et pertes et annexe) pour la période se clôturant au 19 novembre 2015 (annexe 1), déclare de manière irrévocable
reprendre tout le passif présent et futur de la Société dissoute.
VII.- Que le comparant déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la société
indiqué au point VI.
VIII.- Que la liquidation de la Société est achevée et que celle-ci est à considérer comme définitivement close.
IX.- Que décharge pleine et entière est donnée au gérant unique de la Société dissoute pour l'exécution de son mandat
jusqu'à ce jour («quitus»), à savoir:
- Seren S.à r.l., ayant son siège social à L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, 75, Parc d'Activités.
X.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la Société.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 décembre 2015. Relation GAC/2015/10350. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015195860/50.
(150220661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
19056
Artico Dynamic SIF-SICAV
Axantus Capital
BBJJ S.à r.l.
Boavista Finance S.A.
CKIF ALA Investment S.à r.l.
Claessens Company SPF S.à.r.l.
Cofimin S.A.
Copadent
Dalia Air Line
Davco S.A.
Diana Properties S. à r.l.
Digital Services XXXV S.à r.l.
Diversified Holding Company S.à r.l.
Domaine de la Couronne de Chêne S.A.
Endurance Office II Asset S.à r.l.
Golden Spirits Sàrl
Graas-Lavie et Cie
Great Northern HK S.à r.l.
Herblux
ICO S.à r.l.
Imagina International
Immo JO S.à r.l.
Immo JO S.à r.l.
Immo JO S.à r.l.
Imondial S.à r.l.
Indeff S.A.
Interact-iv.com Lux
International Engineering & Construction S.A.
International Security Consulting (I.S.C) S.àr.l.
Investissements Immobiliers Kirchberg S.A.
IPC Group S.A.
Isna Car Invest S.A.
JDBS Entreprise
Labeo S.A.
LHP Clima S.A.
Luxmicrokine S.à r.l.
Luxury Sofas S.A. - SPF
Marguerite Autoroutes S.à r.l.
Mars Propco 13 S.à r.l.
Mondial Cash Luxembourg S.A.
Ravento S.à r.l.
Schou S.à.r.l.
Sirta S.A.
Tordell S.A.
Tournesol Investissements S.A.
Transports Huberty S.A.
Twoforone S.A.