logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 352

9 février 2016

SOMMAIRE

Attert 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16878

Baltic Ventures S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16867

BGL BNP Paribas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16850

Briantea & Eurasian S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

16850

Bristol Ventures S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16867

Credit Suisse (Lux) Energy GP S.à r.l.  . . . . . .

16886

CTDX S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16852

Data Trust Holding S.A  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16872

Deltaline S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16850

Dialogiques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16895

Energylux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16877

Erre Nove S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16877

ESA plus S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16877

Euphonie Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16877

Fidji Luxembourg (BC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16866

Fidji Luxembourg (BC3) S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

16866

Gant International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

16872

Georges & Theis Architectes Associés Sàrl . . .

16872

GFM (CE) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16896

Hogan S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16874

Honey S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16873

Hotepar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16875

I.C.E. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16873

I.C.E. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16873

I.C.E. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16873

I.C.E. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16873

Instacom International S.A. SPF  . . . . . . . . . . .

16874

Instacom International S.A. SPF  . . . . . . . . . . .

16874

Instacom International S.A. SPF  . . . . . . . . . . .

16873

Insurance, Consulting, Investment Group Lu-

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16875

Interleasing Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . .

16875

Inter Metals S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16875

International Safety Hard Alloy Corporation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16874

International University of Health, Exercise &

Sports S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16876

Intrepid Aviation Luxembourg Borrower II

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16874

Investa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16876

I.T. & Management Associates S.A.  . . . . . . . .

16875

Jessan Participations S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

16876

Jetamo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16876

KC Esther S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16876

Le Chat Potte s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16852

Le Chat Potte s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16852

Majestic Ventures S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

16869

Mandarin Capital Partners II S.C.A. SICAR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16872

Mersey Ventures S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16869

Olympic Ventures S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

16870

Osprey Ventures S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16870

Sarasino Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16877

Swiss Alpha, SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16851

16849

L

U X E M B O U R G

Briantea & Eurasian S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 71.769.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à :

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le jeudi <i>25 février 2016 à 14.00 heures au siège social

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et attribution du résultat au 31 décembre 2014.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision de continuer la société en conformité avec l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016060772/16.

Deltaline S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5447 Schwebsingen, 53, Wäistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 155.868.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Aktionaere der Deltaline S.A., welche am <i>25. Februar 2016 um 14.00 Uhr in Ahn, 7, route du Vin, mit der nach-

folgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

<i>Tagesordnung:

1. Verlesung der Jahresberichte zum 31. Dezember 2014 des Verwaltungsrates sowie des Aufsichtskommissars;
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014;
3. Beschlussfassung über das Jahresergebnis;
4. Tilgung Darlehen;
5. Entlastung für die Verwaltungsratsmitglieder und den Aufsichtskommissar;
6. Verschiedenes

- Mandate Verwaltungsrat

<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates

Référence de publication: 2016060775/19.

BGL BNP Paribas, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 6.481.

Nous prions Mesdames et Messieurs les actionnaires de BGL BNP Paribas S.A. de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, le vendredi <i>19 février 2016 à 14h00, pour délibérer

sur l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. annulation des actions au porteur non immobilisées, réduction du capital social et modification des statuts en con-

séquence (modification de l'article 5 des statuts), le tout conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014
relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,

2. adoption de la seule forme nominative pour toutes les actions actuelles (non annulées conformément aux dispositions

de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur) et futures de la société (modi-
fication des articles 7 et 10 des statuts),

3. fixation  de  nouvelles  modalités  de  convocation  de  l'Assemblée  générale  (modification  des  articles  27  et  29  des

statuts),

4. introduction d'une modalité supplémentaire de réunion et de prise de décision du Conseil d'administration (modifi-

cation de l'article 18 des statuts),

5. autres modifications des statuts (modification des articles 8, 16 et 23 des statuts).

16850

L

U X E M B O U R G

En vertu des dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, le Conseil

d'administration de la Société a nommé Fidupar S.A. comme dépositaire des actions au porteur émises par la Société.

En application des dispositions légales et réglementaires applicables, les droits de vote et les droits financiers attachés

aux actions au porteur encore en circulation qui n'ont pas été immobilisées auprès de Fidupar S.A., déposées auprès des
systèmes de règlement des opérations sur titres Clearstream Banking S.A. ou Euroclear Bank S.A. ou converties en actions
nominatives sont suspendus jusqu'à leur immobilisation auprès du dépositaire ou leur conversion en actions nominatives
auprès de la Société devant intervenir au plus tard le 18 février 2016.

La Société rappelle à ses actionnaires détenteurs d'actions au porteur qu'en application de la loi du 28 juillet 2014 relative

à l'immobilisation des actions et parts au porteur, les actions au porteur qui, au 18 février 2016, n'auront pas été immobilisées
auprès de Fidupar S.A., déposées dans les systèmes de règlement des opérations sur titres Clearstream Banking S.A. ou
Euroclear Bank S.A. ou converties en actions nominatives seront obligatoirement annulées.

Nous prions donc les propriétaires d'actions au porteur de contacter dans les meilleurs délais :
- la Société afin de convertir leurs actions au porteur en actions nominatives ou,
- Fidupar S.A. afin de faire procéder à l'immobilisation de leurs actions au porteur,
- ou de s'assurer auprès de leurs établissements bancaires que leurs actions au porteur sont bien déposées auprès des

systèmes de règlement des opérations sur titres Clearstream Banking S.A. ou Euroclear Bank S.A.

En application de l'article 27 des statuts de la Société, les actionnaires (nominatifs ou au porteur) qui désirent prendre

part à l'Assemblée générale extraordinaire doivent demander une carte d'entrée à la Société, moyennant blocage de leurs
actions auprès de la Société, (actions nominatives), de Fidupar S.A. ou des systèmes de règlement des opérations sur titres
Clearstream Banking S.A. ou Euroclear Bank S.A., (actions au porteur), au plus tard pour le vendredi 12 février 2016.

Il est rappelé aux actionnaires qu'en vertu de l'article 28 des statuts " tout actionnaire peut se faire représenter par un

mandataire ayant lui-même le droit de vote et ayant rempli les conditions " énumérées pour être admis à l'assemblée.

Les procurations éventuelles devront être déposées auprès de la Société au plus tard le vendredi 12 février 2016 et seront

acceptées sous réserve du blocage des actions du mandant auprès de la Société, de Fidupar S.A. ou des systèmes de règlement
des opérations sur titres Clearstream Banking S.A. ou Euroclear Bank S.A.

<i>Le Conseil d'administration

BGL BNP Paribas
Société anonyme
Siège social : L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy
R.C.S. Luxembourg B 6481
Contact : Secrétariat Général - (+352) 42 42 - 39 29 / 42 42 - 21 27
www.bgl.lu

Fidupar
Société anonyme
Siège social : 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 74296
Contact : (+352) 26 26 - 38 26
www.fidupar.eu
Référence de publication: 2016055594/60.

Swiss Alpha, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6B, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 148.588.

Die am 5. Februar 2016 am Sitz der Gesellschaft abgehaltene außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre des

Swiss Alpha, SICAV konnte nicht wirksam über die Punkte der Tagesordnung beschließen, da das erforderliche Quorum
gemäß Artikel 67-1 (2) des Luxemburger Gesetzes über die Handelsgesellschaften nicht erreicht wurde.

Hiermit wird allen Aktionären des Swiss Alpha, SICAV mitgeteilt, dass eine

2. AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

am <i>15. März 2016 um 10.30 Uhr, in den Geschäftsräumen der BayernInvest Luxembourg, 6B, rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Munsbach stattfinden wird.

<i>Tagesordnung:

1. Beschluss die Gesellschaft Swiss Alpha, SICAV in Liquidation zu setzen.
2. Benennung der Liquidatoren Herr Thorsten Eiglmeier (für die Swiss Alpha AG) und Frau Katja Mertes-Tegebauer

(für die BayernInvest Luxembourg S.A.), vorbehaltlich der Genehmigung der CSSF.

16851

L

U X E M B O U R G

3. Festlegung der Befugnisse der Liquidatoren.
4. Annahme der Rücktrittsgesuche der Mitglieder des Verwaltungsrates.
5. Sonstiges

Zur  Teilnahme  an  der  außerordentlichen  Generalversammlung  und  zur  Ausübung  des  Stimmrechts  sind  diejenigen

Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 11. März 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft
einreichen aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden.
Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die Punkte der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum und

werden durch Zwei-Drittel Mehrheit der anwesenden oder vertretenden Aktien beschlossen.

Munsbach, den 05. Februar 2016

<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2016060774/10183/27.

Le Chat Potte s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3315 Bergem, 65, rue de Noertzange.

R.C.S. Luxembourg B 161.522.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des Sociétés.
Pour mention aux fins de publications au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Signature:
Référence de publication: 2015210498/10.
(150236280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2015.

Le Chat Potte s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3315 Bergem, 65, rue de Noertzange.

R.C.S. Luxembourg B 161.522.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des Sociétés.
Pour mention aux fins de publications au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Signature:
Référence de publication: 2016006755/10.
(160005815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

CTDX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: DKK 501.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 203.445.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of December,
Before the undersigned, Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Chevron Philippines Ltd., a limited liability company organized under the laws of Bermuda, having its registered office

at 11, Church Street, HM 11 Hamilton, Bermuda and registered with the Registrar of Companies of Bermuda under number
32241,

here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under

private seal, which, after signature “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the un-
dersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purposes of registration.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the appearing party is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of CTDX ApS, a private limited liability company

incorporated under the laws of Denmark with registered office located at Øster Allé 48, 2100 Copenhagen, Denmark, a
nominal share capital of DKK 501,000.- and registered with the Danish Business Authority under CVR number 21 59 99
80 (the Company);

II. that the Sole Shareholder wishes to migrate the Company to the Grand Duchy of Luxembourg and for it to assume

the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended;

16852

L

U X E M B O U R G

III. that it results from a balance sheet of the Company that, as at 30 November 2015, the Company's net assets correspond,

at least, to the nominal value of the Company's share capital and any share premium. After signature ne varietur by the
proxyholder of the Sole Shareholder and the notary, a copy of the Company's balance sheet will remain attached to this
deed to be registered with it;

IV. that pursuant to resolutions of the Company's Sole Shareholder adopted in Denmark, a copy of which will remain

attached to this notarial deed, it has been resolved to transfer the Company's registered office, principal establishment,
central administration and place of effective management from Denmark to Luxembourg City, Grand Duchy of Luxem-
bourg (the Migration), effective as from the date of this deed, without the Company being dissolved but, on the contrary,
with full corporate and legal continuance pursuant to the terms of the migration plan published by the Danish Business
Authority on 18 November 2011 (the Migration Plan);

V. that all formalities required under the laws of Denmark to give effect to that transfer have been or will be duly carried-

out;

VI. that the agenda of this meeting is as follows:
1. Transfer of the Company's registered office, principal establishment, central administration and place of effective

management from Denmark to the Grand Duchy of Luxembourg, with effect as from the date of the notarial meeting,
without the Company being dissolved but, on the contrary, with full corporate and legal continuance;

2. Adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée)

under the name CTDX S.à r.l. and acceptance of Luxembourg nationality arising from the transfer of the Company's
registered office, principal establishment, central administration and place of effective management to the Grand Duchy
of Luxembourg;

3. Acknowledgement of the Company's opening balance sheet and confirmation of the description and consistency of

all its assets and liabilities;

4. Amendment and complete restatement of the Company's articles of association to conform them to the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, as a consequence of the Company becoming a Luxembourg law governed company subject
to the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended;

5. Acknowledgment of the resignation of the Company's current directors, consisting of Lars Philip Comerford and

Melanie Nicola Abrahams, from their office as directors of the Company under the laws of Denmark;

6. Acknowledgment of the resignation of the Company's current executive director, consisting of Lars Philip Comerford,

from his office as executive director of the Company under the laws of Denmark;

7. Appointment, effective as of the date of the notarial meeting, of the following persons as managers:
- Jeffrey John Allison, born on 20 April 1963 in Pennsylvania, USA and residing professionally at Chevron House, 11

Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda;

- Cornelis Johannes van Klink, born on 22 October 1953 in Rotterdam, the Netherlands and residing professionally at

32 Petroleumweg, 3196 KD, Vondelingenplaat, the Netherlands;

- Virginia Strelen, born on 30 May 1977 in Bergisch, Gladbach, Germany and residing professionally at 15, rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Salvatore Rosato, born on 6 October 1979 in Avellino, Italy and residing professionally at 15, rue Edward Steichen,

L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

8. Establishment, as of the date of the notarial meeting, of the registered office, principal establishment, central admi-

nistration and place of effective management of the Company at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg;

9. Conversion, effective as of the date of the notarial meeting, of: (i) the currency of the share capital of the Company

from Danish Krone (DKK) to United States Dollars (USD); (ii) the currency of the nominal value of the Company's shares
from Danish Krone (DKK) to United States Dollars (USD); and (iii) all accounts in the books of the Company from Danish
Krone (DKK) to United States Dollars (USD);

10. Subsequent amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the change of

currency, as specified under item 8 above;

11. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company, each individually, to record, on behalf of the Company, the conversion
of the functional currency of the Company, the new number of shares in issue and the new par value of the shares in the
register of shareholders of the Company; and

12. Any other business.
VII. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to transfer the Company's registered office, principal establishment, central administration

and place of effective management from Denmark to the Grand Duchy of Luxembourg with effect as from the date of this
notarial deed, without the Company being dissolved but, on the contrary, with full corporate and legal continuance.

16853

L

U X E M B O U R G

The Sole Shareholder further declares that all formalities required under the laws of Denmark to give effect to this

transfer have been or will be duly performed, and evidence of this has been provided to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves that the Company will adopt the form of a private limited liability company (société à

responsabilité limitée) under the name CTDX S.à r.l., assume Luxembourg nationality and, as from the date of this notarial
deed, be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge the Company's balance sheet dated 30 November 2015 (the Closing

Accounts).

The Sole Shareholder notes that the Company's Closing Accounts show that, as at 30 November 2015, the Company's

net assets correspond, at least, to the nominal value of the Company's share capital and share premium.

The valuation of the Company's assets and liabilities is further evidenced to the undersigned notary by a valuation

certificate issued by the directors of the Company dated 18 December 2015. Such certificate, after signature ne varietur by
the proxyholder of the Sole Shareholder and the notary, will remain attached to the deed for the purposes of registration.

The Sole Shareholder confirms that the description, consistency and allocation of all the Company's assets and liabilities

are derived from the Closing Accounts.

The Sole Shareholder resolves to acknowledge the Company's opening balance sheet and mirroring the Company's

Closing Accounts, which reflect the Company's financial situation before the transfer from Denmark to Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg and a copy of which will remain attached to this deed.

The Sole Shareholder states that the Company continues to own all its assets and is still bound by all its liabilities and

commitments.

<i>Fourth resolution

As a result of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend and completely restate, effective as of

the date of this notarial deed, the Company's articles of association under the laws of Denmark so as to conform them to
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

The restated articles of association of the Company will read as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “CTDX S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law
of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered Office.
2.1 The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1 The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises

in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription,  purchase  and  exchange  or  in  any  other  manner,  any  stock,  shares  and  other  participation  securities,  bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.

3.2 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance

16854

L

U X E M B O U R G

of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.

3.3 The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect

itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to

real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1 The share capital is set at five hundred one thousand Danish Krone (DKK 501,000-) represented by five hundred

one thousand (501,000) shares in registered form, having a nominal value of one Danish Krone (DKK 1.-), each.

5.2 The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance

with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1 The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2 The shares are freely transferable between shareholders.
6.3 When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties
6.4 When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5 A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6 A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.7 The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1 The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2 The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).

The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or
several class B managers.

8.1 Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2 Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle

shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except

in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have

full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the
meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v)  The  Board  may  only  validly  deliberate  and  act  if  a  majority  of  its  members  are  present  or  represented.  Board

resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the
shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A

16855

L

U X E M B O U R G

manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes
signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

8.3 Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager and

any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person[s] to whom special powers

have been delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the

managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any

commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholders

Art. 11. General meetings of the shareholders and shareholders' written resolution.
11.1 Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at

a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may

be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2 Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting

following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders.

The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each
manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda

of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to

be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the

share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the
votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least

three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company

shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall

bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

Art. 12. Sole shareholder. , When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is

to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

16856

L

U X E M B O U R G

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1 The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2 Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
owed by its manager(s) and shareholders to the Company.

13.3 Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4 The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the

end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders'
Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
13.5 If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held

at the registered office or at any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice, on
the second Monday of May of each year at 10.00 a.m.. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual General
Meeting shall be held on the following business day.

Art. 14. Auditors.
14.1 When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors

(réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their
number and remuneration and the term of their office.

14.2 If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be su-

pervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more approved
external auditors (réviseurs d'entreprises agrees). The commissaires are subject to re-appointment at the annual General
Meeting. They may or may not be shareholders.

Art. 15. Allocation of profits
15.1 Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal

Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2 The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

15.3 Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;

and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the

distribution of an interim dividend.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to

claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16.
16.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Com-
pany's assets and pay its liabilities.

16.2 The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

16857

L

U X E M B O U R G

VII. General provisions

Art. 17.
17.1 Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders

Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2 Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one
original  or  several  counterparts  of  the  same  document,  all  of  which  taken  together  shall  constitute  one  and  the  same
document.

All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation, effective as from the date of this notarial deed, of the

members of the board of directors of the Company consisting of Lars Philip Comerford and Melanie Nicola Abrahams
from their position as directors of the Company under the laws of Denmark.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation, effective as from the date of this notarial deed, of Lars

Philip Comerford from his position as executive director of the Company under the laws of Denmark.

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder further resolves to appoint, with effect from the date of this notarial deed for an unlimited duration,

the following persons:

- Jeffrey John Allison, born on 20 April 1963 in Pennsylvania, USA and residing professionally at Chevron House, 11

Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda;

- Cornelis Johannes van Klink, born on 22 October 1953 in Rotterdam, the Netherlands and residing professionally at

32 Petroleumweg, 3196 KD, Vondelingenplaat, the Netherlands;

- Virginia Strelen, born on 30 May 1977 in Bergisch, Gladbach, Germany and residing professionally at 15, rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Salvatore Rosato, born on 6 October 1979 in Avellino, Italy and residing professionally at 15, rue Edward Steichen,

L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Eight resolution

The Sole Shareholder resolves to establish the registered office, principal establishment, central administration and place

of effective management of the Company at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
effective as of the date of this notarial deed.

<i>Ninth resolution

The Sole Shareholder resolves to convert, effective as of this notarial deed, the functional currency of the Company

from Danish Krone (DKK) to United States Dollars (USD).

The Sole Shareholder resolves to convert, effective as of this notarial deed, the share capital of the Company currently

amounting to nominally five hundred one thousand Danish Krone (DKK 501,000-) to seventy-two thousand six hundred
forty-five United States Dollars (USD 72,645.-) based on the closing exchange rate of 0.1450- DKK/USD, as published
by Bloomberg on 18 December 2015 at 11.02 a.m. CET.

The Sole Shareholder further resolves to convert, effective as of this notarial deed, the par value of the shares of the

Company currently amounting to one Danish Krone each, to zero point one four five zero United States Dollars (USD
0.1450) each ,based on the same above mentioned exchange rate.

The Sole Shareholder acknowledges that proof of the above exchange rate has been given to the notary and will remain

attached to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxyholder representing the Sole Shareholder
and the undersigned notary.

The Sole Shareholder further resolves to convert, effective as of this notarial deed, all accounts in the books of the

Company from Danish Krone (DKK) into United States Dollars (USD).

<i>Tenth resolution

As a result of the above conversion, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the articles of association of

the Company which shall henceforth read as follows:

16858

L

U X E M B O U R G

“  5.1.  The  share  capital  is  set  at  seventy-two  thousand  six  hundred  forty-five  United  States  Dollars  (USD  72,645)

represented by five hundred one thousand (501,000) shares in registered form, having a nominal value of zero point one
four five zero United States Dollars (USD 0.1450-), each.”

<i>Eleventh resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

with power and authority given to any manager of the Company, each individually, to record, on behalf of the Company,
the conversion of the currency of the share capital of the Company, the new number of shares in issue and the new par
value of the shares in the register of shareholders of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this

notarial deed are estimated at approximately five thousand six hundred Euros (EUR 5,600.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed

is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.

This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the appearing party.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le dix-huitième jour de décembre,
Pardevant le soussigné, Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Chevron Philippines Ltd., une société à responsabilité limitée régie par les lois des Bermudes, dont le siège social est

établi à 11, Church Street, HM 11 Hamilton, les Bermudes et immatriculée au registre des sociétés des Bermudes sous le
numéro 32241,

ici représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé, qui après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui auprès de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que la partie comparante est l'associé unique (l'Associé Unique) de CTDX ApS, une société à responsabilité limitée

constituée selon le droit du Danemark, dont le siège social est établi à Øster Allé 48, 2100 Copenhague, Danemark, disposant
d'un capital social de DKK 501.000 et immatriculée auprès des autorités commerciales du Danemark (Danish Business
Authority) sous le numéro CVR 21 59 99 80 (la Société);

II. que l'Associé Unique souhaite migrer la Société vers le Grand-Duché de Luxembourg et qu'elle adoptera la forme

d'une société à responsabilité limitée existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, conformément à la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;

III. qu'il résulte d'un bilan de la Société qu'au 30 Novembre 2015, la valeur de l'actif net de la Société est estimée, au

moins, à la valeur nominale du capital social de la Société et de la prime d'émission. Une copie du bilan de la Société, après
avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire de l'Associé Unique, restera annexée au présent
acte et sera soumise avec lui auprès de l'enregistrement;

IV. qu'en vertu de résolutions de l'Associé Unique adoptées au Danemark, à la date des présentes, dont une copie restera

annexée au présent acte, il a été décidé de transférer le siège social, le principal établissement, l'administration centrale et
lieu de gestion effective de la Société du Danemark à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg (la Migration),
portant effet à compter de la date du présent acte, sans dissolution de la Société mais au contraire avec la pleine continuité
de sa personnalité juridique en vertu des conditions du plan de migration publié par les autorités commerciales du Danemark
(Danish Business Authority) le 18 novembre 2011 (le Plan de Migration);

V. que toutes les formalités requises par les lois danoises afin de rendre effectif ce transfert ont été ou seront valablement

réalisées;

VI. que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. transfert du siège social, de l'établissement principal, de l'administration centrale et du lieu de gestion effective de la

Société du Danemark vers le Grand-Duché de Luxembourg avec effet à compter de la présente assemblée, sans dissolution
de la Société mais au contraire avec pleine continuité de sa personnalité juridique et morale;

2. adoption par la Société de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée avec pour raison sociale CTDX

S.à r.l., et acceptation de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert du siège social, principal établissement,
administration centrale et lieu de gestion effective de la Société vers le Grand-Duché de Luxembourg;

3. prise d'acte du bilan d'ouverture de la Société et confirmation de la description et de la cohérence de l'intégralité de

l'actif et du passif de la Société;

16859

L

U X E M B O U R G

4. modification et refonte complète des statuts de la Société afin de les rendre conformes aux lois du Grand-Duché de

Luxembourg, du fait que la Société devienne une société régie par le droit luxembourgeois et soumise à la loi luxembour-
geoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée;

5. prise d'acte de la démission des actuels administrateurs de la Société, à savoir Lars Philip Comerford et Melanie Nicola

Abrahams, de leurs postes d'administrateurs de la Société sous le droit danois;

6. prise d'acte de la démission de l'actuel administrateur exécutif de la Société, à savoir Lars Philip Comerford, de son

poste d'administrateur exécutif de la Société sous le droit danois;

7. nomination à compter de la date de la présente assemblée, des personnes suivantes en qualité de gérants:
- Jeffrey John Allison, né le 20 avril 1963 en Pennsylvanie, USA et résidant professionnellement à Chevron House, 11

Church Street, Hamilton, HM 11, les Bermudes;

- Cornelis Johannes van Klink, né le 22 octobre 1953 à Rotterdam, les Pays-Bas et résidant professionnellement à 32

Petroleumweg, 3196 KD, Vondelingenplaat, les Pays-Bas;

- Virginia Strelen, née le 30 mai 1977 à Bergisch, Gladbach, Allemagne et résidant professionnellement au 15, rue

Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Salvatore Rosato, né le 6 octobre 1979 à Avellino, Italie et résidant professionnellement au 15, rue Edward Steichen,

L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

8. établissement, à compter de la date des présentes, du siège social, principal établissement, administration centrale et

lieu de gestion effective de la Société au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

9. conversion à compter de la date des présentes, de (i) la devise du capital social de la Société de couronnes danoises

(DKK) en dollars américains (USD); (ii) de la devise de la valeur nominale des parts sociales de la Société de couronnes
danoises (DKK) en dollars américains (USD) et (iii) des comptes dans les livres de la Société de couronnes danoises (DKK)
en dollars américains (USD), à compter de la date de la présente assemblée;

10. modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter le changement de devise, tel que

mentionné au point 8 ci-dessus;

11. modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et pouvoir et autorité

accordés à tout gérant de la Société, chacun individuellement, afin d'enregistrer, au nom de la Société, la conversion de la
devise du capital social de la Société, le nouveau nombre de parts sociales en circulation et la nouvelle valeur nominale
des parts sociales dans le registre des associés de la Société; et

12. divers.
VII. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social, établissement principal, administration centrale et lieu de gestion

effective de la Société du Danemark vers le Grand-Duché de Luxembourg, avec effet à la date de la présente assemblée,
sans dissolution de la Société mais au contraire avec la pleine continuité de sa personnalité juridique et morale.

L'Associé Unique déclare en outre que toutes les formalités requises en vertu des lois du Danemark à l'effet de rendre

effectif ledit transfert ont été ou seront dûment accomplies, preuve en a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide que la Société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée avec pour raison sociale

CTDX S.à r.l., accepte la nationalité luxembourgeoise et sera, à partir de la date du présent acte, soumise au droit du Grand-
Duché de Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de prendre acte du bilan de la Société en date du 30 novembre 2015 (les Comptes de Clôture).
L'Associé Unique note que les Comptes de Clôture de la Société montrent que, en date du 30 novembre 2015, l'actif net

de la Société correspond, au moins, à la valeur nominale du capital social de la Société et de la prime d'émission.

L'évaluation de l'actif et du passif de la Société est en outre certifiée au notaire instrumentant par un certificat émis par

les administrateurs de la Société en date du 18 décembre 2015. Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire
de l'Associé Unique et le notaire, restera annexé au présent acte aux fins de l'enregistrement.

L'Associé Unique confirme que la description, la cohérence et l'affectation de l'actif et du passif de la Société proviennent

des Comptes de Clôture.

L'Associé Unique décide de prendre acte du bilan d'ouverture de la Société et correspondant aux Comptes de Clôture

de la Société, et reflétant la situation financière de la Société avant son transfert du Danemark vers le Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg dont une copie restera annexée au présent acte.

L'Associé Unique confirme que la Société continue à détenir tous ses actifs et passifs et continue d'être responsable à

l'égard de toutes ses obligations et engagements.

16860

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier et de reformuler complètement à

compter de la date des présentes, les statuts de la Société conformes au droit danois, afin de les rendre conformes au droit
du Grand-Duché de Luxembourg.

Les statuts reformulés de la Société auront la teneur suivante:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est «CTDX S.à r.l.» (la Société). La Société est une société à responsabilité

limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de
Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par

une décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraor-
dinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont
de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège
social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circons-
tances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société, qui, nonobstant le transfert provisoire de
son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  et  la  gestion  de  ces  participations.  La  Société  peut  en  outre  acquérir,  par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière dans tous titres, actions et autres valeurs de participation, obliga-
tions,  créances,  certificats  de  dépôt  et  autres  instruments  de  dette,  et  plus  généralement,  toutes  valeurs  mobilières  et
instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la
gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. En outre, elle peut investir dans l'acquisition et la gestion d'un porte-
feuille de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. Elle peut prêter des fonds, y compris, sans limitation, les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. Elle peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation
requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques, moyens juridiques et instruments nécessaires à une gestion efficace

de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux
d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à cinq cent un mille couronnes danoises (DKK 501.000,-) représenté par cinq cent un mille

(501.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une couronne danoise (DKK 1.-), chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

16861

L

U X E M B O U R G

6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'après avoir été notifiée à la

Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que:
(i) elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) le rachat résulte d'une réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par une résolution des associés, qui fixe la durée de

leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils composent le conseil (le Conseil). Les Associés peuvent

décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs
gérants de classe B.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,

qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant, au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe sera

au Grand-Duché de Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures

à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la
convocation.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux

déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les

décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, sous réserve
que si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un (1)
gérant de classe A et un (1) gérant de classe B votent en faveur de ladite résolution. Les décisions du Conseil sont consignées
dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants
présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence, ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un gérant de classe

A et d'un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs

spéciaux ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil, aux gérants

ou à tout gérant doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne peuvent être tenus personnellement responsables pour les engage-

ments valablement pris par eux au nom de la Société dans le cadre de leur mandat, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

16862

L

U X E M B O U R G

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont adoptées

en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être

adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(v) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer

une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la

date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans
la convocation à ladite assemblée.

(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les

associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés

de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne (associé ou non) afin de le représenter à toute

Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par la seconde Assemblée Générale à la majorité des voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au

moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Les Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.

Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale, ou aux Résolutions Ecrites des Associés doit

être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et les comptes de résultats, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des

actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants
de la Société et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et les comptes de résultats sont approuvés de la manière suivante:
(i) si la Société ne compte pas plus de vingt-cinq (25) associés, dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice

social concerné, soit (a) lors de l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou

(ii) si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, lors de l'Assemblée Générale annuelle.
13.5. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, l'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège

social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du
mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvré au Grand-Duché de Luxembourg, l'Assemblée
Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

16863

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Réviseurs d'entreprises/Commissaires.
14.1 Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus

par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et
la durée de leur mandat.

14.2. Si le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlées par un

ou plusieurs commissaires, sauf si la loi exige la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commis-
saires peuvent être réélus par l'Assemblée Générale annuelle. Ils ne doivent pas nécessairement être associés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve

Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2.  Les  associés  décident  de  l'affectation  du  solde  des  bénéfices  nets  annuels.  Ils  peuvent  allouer  ce  bénéfice  au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (y compris la prime d'émission) suffisants

sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la Réserve
Légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires; et

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le

Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement réalisés et les
associés doivent immédiatement reverser l'excédent à la Société à la demande du Conseil.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16.
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, le cas échéant, est distribué aux

associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

Art. 17.
17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout autre
moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales

pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi applicable et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de prendre acte de la démission, avec effet à la date des présentes, des membres du conseil

d'administration de la Société, à savoir Lars Philip Comerford et Melanie Nicola Abrahams, de leurs fonctions d'adminis-
trateurs de la Société sous les lois du Danemark.

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique décide de prendre acte de la démission, avec effet à la date des présentes, de Lars Philip Comerford

de son poste d'administrateur exécutif de la Société sous les lois du Danemark.

16864

L

U X E M B O U R G

<i>Septième résolution

L'Associé Unique décide de nommer, à compter de la date des présentes et pour une durée indéterminée, les personnes

suivantes:

- Jeffrey John Allison, né le 20 avril 1963 en Pennsylvanie, USA et résidant professionnellement à Chevron House, 11

Church Street, Hamilton, HM 11, les Bermudes;

- Cornelis Johannes van Klink, né le 22 octobre 1953 à Rotterdam, les Pays-Bas et résidant professionnellement à 32

Petroleumweg, 3196 KD, Vondelingenplaat, les Pays-Bas;

- Virginia Strelen, née le 30 mai 1977 à Bergisch, Gladbach, Allemagne et résidant professionnellement au 15, rue

Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Salvatore Rosato, né le 6 octobre 1979 à Avellino, Italie et résidant professionnellement au 15, rue Edward Steichen,

L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Huitième résolution

L'Associé Unique décide d'établir le siège social, le principal établissement, l'administration centrale et le lieu de gestion

effective de la Société au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à compter de la
date des présentes.

<i>Neuvième résolution

L'Associé Unique décide de convertir, à compter de la date des présentes, la devise fonctionnelle de la Société de la

couronne danoise (DKK) en dollars américains (USD).

L'Associé Unique décide de convertir, à compter de la date des présentes, le capital social de la Société, d'un montant

actuel de cinq cent un mille (501.000) couronnes danoises (DKK 501.000) à soixante-douze mille six cent quarante-cinq
dollars américains (USD 72.645,-) sur base du taux de change de DKK 1= USD 0.1450, tel que publié par Bloomberg le
18 décembre 2015 à 11.02 CET.

L'Associé Unique décide en outre de convertir, à compter de la date des présentes, la valeur nominale des parts sociales

de la Société, s'élevant actuellement à une couronne danoise (DKK 1) chacune à zéro point un quatre cinq zéro dollars
américains (USD 0.1450,-) chacune, sur base du taux de change mentionné ci-dessus.

L'Associé Unique prend acte que la preuve du taux de change susmentionné a été apportée au notaire instrumentant et

qu'elle restera annexée au présent acte, après avoir été signée ne varietur par le mandataire représentant l'Associé Unique
et le notaire instrumentant.

L'Associé Unique décide en outre de convertir, à compter de la date des présentes, tous les comptes dans les livres de

la Société de couronnes danoises (DKK) en dollars américains (USD).

<i>Dixième résolution

En conséquence de la conversion ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société

qui aura dès lors la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social est fixé à soixante-douze mille six cent quarante-cinq dollars américains (USD 72.645,-), repré-

senté par cinq cent un mille (501.000,-) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de zéro point un quatre
cinq zéro dollars américains (USD 0.1450,-) chacune.»

<i>Onzième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus

avec pouvoir et autorité accordés à tout gérant de la Société, chacun individuellement, afin d'enregistrer, au nom de la
Société, la conversion de la devise du capital social de la Société, le nouveau nombre de parts sociales en circulation et la
nouvelle valeur nominale des parts sociales dans le registre des associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent

acte notarié sont estimés à environ cinq mille six cents Euros (5.600.- EUR).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une version française, et en cas de divergences, le texte anglais prévaut.

Dont Acte, le présent acte notarié est passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu l'acte, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 28 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41903. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

16865

L

U X E M B O U R G

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Référence de publication: 2016059529/734.
(160020039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

Fidji Luxembourg (BC), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 110.918.

Fidji Luxembourg (BC3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 182.720.

I, Jacques KESSELER, Notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, hereby attest and certify that:
Pursuant to a merger proposal (the “Merger Proposal”) enacted by a notarial deed drawn up by the aforementioned

notary, on 18 November 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number
3189 of 25 November 2015, Fidji Luxembourg (BC) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à
responsabilité limitée) whose registered office is at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 110.918 (the “Com-
pany”) has planned to merged with Fidji Luxembourg (BC 3) S.à r.l. a Luxembourg private limited liability company
(société à responsabilité limitée) whose registered office is at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 182.720
(the “Absorbed Company”) by way of absorption of the Absorbed Company by the Company and without liquidation of
the Absorbed Company.

The conditions precedent to the effectiveness of the Merger set forth in the Merger Proposal have been fulfilled on 8

January 2016 (the “Effective Date”), as acknowledged and confirmed to the undersigned by the Company on 19 January
2016 and that Merger (as defined below) is accordingly effective as of the Effective Date.

The simplified merger by absorption between the Company and the Absorbed Company has been operated in accordance

with the provisions of Sub-Section III of Section XIV of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies,
as amended (the “Luxembourg Company Law”), (the “Merger”).

All the formalities required under the Luxembourg Company Law in relation to the Merger have been accomplished

and, in particular, the conditions as provided for under Article 279 of the Luxembourg Company Law were observed as
follows:

- the publication of the Merger Proposal in the Mémorial was made at least one (1) month before the Merger took effect

between the parties;

- the documents specified in Article 267, paragraph 1) a), b) and c) were made available to the shareholders of the

Company at least one (1) month before the Merger took effect between the parties;

- no shareholder of the Company, holding at least 5% of the shares in the subscribed capital of the Company, required,

during the period of one (1) month following the publication of the Merger Proposal in the Mémorial, the convening of an
extraordinary general meeting of shareholders of the Company in order to decide whether to approve the Merger.From an
accounting point of view, the operations of the Absorbed Company are considered as accomplished for the account of the
Company as from the Effective Date.

Therefore the Merger, already effective among the merging companies on the Effective Date , will become effective

vis-à-vis third parties with the publication of this certificate in the Mémorial, with the following consequences:

- the universal transfer of all of the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Company;
- the dissolution of the Absorbed Company without liquidation;
- the cancellation of shares of the Absorbed Company;
- all other consequences, as listed in the Merger Proposal.

Certified in Pétange, on the 22 

nd

 day of January 2016.

Suit la traduction française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergences, la version anglaise fera

foi.

Le soussigné, Maître Jacques KESSELER, Notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg certifie que:
Suivant un projet de fusion (le «Projet de Fusion») établi par acte du notaire instrumentant, en date du 18 Novembre

2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 3189 du 25 novembre 2015,
Fidji Luxembourg (BC) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social est au 4,
rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le B 110918 («la Société») a projeté de fusionner avec Fidji Luxembourg (BC3)

16866

L

U X E M B O U R G

S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social est au 4, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg  sous  le  B  182720  («la  Société  Absorbée»)  par  absorption  de  la  Société  Absorbée  par  la  Société  et  sans
liquidation de la Société Absorbée.

Les conditions suspensives à la prise d'effet de la Fusion exposées dans le Projet de Fusion ont été remplies le 8 janvier

2016 (la «Date d'Effet»), tel que constaté et confirmé au notaire instrumentant par la Société le 19 Janvier 2016, la Fusion
(telle que définie ci-dessous) prenant donc effet à la Date d'Effet.

La fusion simplifiée par voie d'absorption entre la Société et la Société Absorbée a été opérée suivant les dispositions

des de la Sous-section III de la Section XIV de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la «Loi sur les Sociétés»), (la «Fusion»).

Toutes les formalités requises par la Loi sur les Sociétés par rapport à la Fusion ont été accomplies et, en particulier les

conditions prévues à l'Article 279 de la Loi sur les Sociétés ont été respectées de manière suivante:

- la publication du Projet de Fusion au Mémorial a été faite au moins un (1) mois avant que la Fusion ait pris effet entre

les parties;

- les documents indiqués à l'Article 267, paragraphe 1) a), b) et c) ont été mis à disposition des actionnaires de la Société

au moins un (1) mois avant que la Fusion ait pris effet entre les parties;

- aucun associé de la Société détenant au moins 5% des actions du capital de la Société, n'a requis pendant le délai d'un

(1) mois après la publication du Projet de Fusion au Mémorial, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des
associés de la Société à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

Du point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée sont considérées comme accomplies pour le compte

de la Société à la Date d'Effet.

Ainsi, la Fusion, déjà effective entre les sociétés fusionnantes à la Date d'Effet, prendra effet à l'égard des tiers le jour

de la publication au Mémorial du présent certificat, avec les conséquences suivantes:

- le transfert universel de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société;
- la dissolution de la Société Absorbée sans liquidation;
- l'annulation des parts sociales de la Société Absorbée;
- toutes les autres conséquences, telles qu'énumérées dans le Projet de Fusion.

Ainsi certifié à Pétange, le 22 janvier 2016.

Référence de publication: 2016055879/82.
(160015118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Baltic Ventures S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 35.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 165.038.

Bristol Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 37.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 164.986.

In the year two thousand and sixteen, on the third day of February,
the undersigned Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, certifies in accordance with article 273 of

the law of 10 August 1915 on the commercial companies, as amended (the “Law of 1915”):

1. that the joint merger plan between Baltic Ventures S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing

under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 165.038, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg (the “Absorbing Company”),
and Bristol Ventures S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 164.986, having its
registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg (the “Absorbed Company“ and together with the Absorbing
Company,  the  “Merging  Companies“)  signed  in  the  form  of  a  notarial  deed  in  front  of  the  undersigned  notary  on  11
December 2015, has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3474 of 30 December
2015 (the “Merger Plan“);

2. that in accordance with paragraph 2 of article 267 (1) of the Law of 1915, the sole shareholders of the Merging

Companies have expressly waived their rights to be provided with interim accounting statements of the Merging Companies;

3. that the documents listed in article 267 paragraph (1) a) and b), of the Law of 1915 have been made available to the

shareholders of the Absorbing Company at the registered office of the latter as of 11 December 2015;

16867

L

U X E M B O U R G

4. that article 2 of said Merger Plan provides that the merger shall be realized and take effect between the Merging

Companies one month and one day after the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the
Merger Plan;

5. that no shareholder holding over five percent (5%) of the subscribed share capital of the Absorbing Company has

requested, within one month after the publication of the Merger Plan in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
the convening of a general meeting of the Absorbing Company;

6. that as from 1 January 2015, all operations and transactions of the Absorbed Company are considered for accounting

and tax purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company;

7. that the merger will be effective towards third parties at the date of the publication in the Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations of this certificate according to article 273 (1) of the Law of 1915;

8. that the Absorbed Company may therefore be struck off of the Trade and Companies' Register;
9. that the conditions provided for by article 279 of the Law of 1915 have been observed.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, upon request of the Merging Com-

panies, this certificate is worded in English, followed by a French version; and upon request of the same Merging Companies
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le troisième jour du mois de février,
le soussigné Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, certifie conformément à l'article 273 de la

loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»):

1. que le projet commun de fusion entre Baltic Ventures S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante

conformément aux lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165.038 (la «Société Absorbante»),
et Bristol Ventures S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante conformément aux lois du Grand-
duché  de  Luxembourg,  ayant  son  siège  social  au  19,  rue  de  Bitbourg,  L-1273  Luxembourg,  inscrite  au  Registre  de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.986 (la «Société Absorbée» et ensemble avec la Société
Absorbante, les «Sociétés Fusionnantes») signé en la forme notariée par devant le notaire soussigné en date du 11 décembre
2015, a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3474 du 30 décembre 2015 (le «Projet de
Fusion»);

2. qu'en application du paragraphe 2 de l'article 267 (1) de la Loi, les associés uniques des Sociétés Fusionnantes ont

expressément renoncé à leurs droits d'obtenir des comptes intérimaires des Sociétés Fusionnantes.

3. que les documents repris à l'article 267 paragraphe (1) a) et b) de la Loi de 1915 ont été mis à la disposition des

associés de la Société Absorbante au siège social de cette dernière à partir du 11 décembre 2015;

4. que l'article 2 du Projet de Fusion prévoit que la fusion sera considérée comme définitivement réalisée et prendra effet

entre les Sociétés Fusionnantes un mois et un jour après la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
du Projet de Fusion;

5. qu'aucun associé de la Société Absorbante détenant une participation au-delà de cinq pourcent (5%) du capital souscrit

de la Société Absorbante, n'a dans le délai d'un mois à partir de la publication du Projet de Fusion au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, demandé la convocation d'une assemblée générale;

6. qu'à compter du 1 

er

 janvier 2015, l'ensemble des opérations ainsi que des transactions réalisées par la Société Absorbée

sont considérées, d'un point de vue fiscal et comptable, comme ayant été accomplies au nom et pour le compte de la Société
Absorbante;

7. que la fusion prendra effet vis-à-vis des tiers à la date de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations du présent certificat conformément à article 273 (1) de la Loi de 1915;

8. que la Société Absorbée peut dès lors être rayée du Registre de commerce et des sociétés;
9. que les conditions exigées par l'article 279 de la Loi de 1915 ont été accomplies.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente que sur demande des Sociétés Fusionnantes,

le présent certificat est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes Sociétés Fusion-
nantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Mondorf-les-Bains, le 3 février 2016.

Maître Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2016060843/81.
(160022376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.

16868

L

U X E M B O U R G

Majestic Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 35.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 164.987.

Mersey Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 40.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 164.985.

In the year two thousand and sixteen, on the third day of February,
the undersigned Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, certifies in accordance with article 273 of

the law of 10 August 1915 on the commercial companies, as amended (the “Law of 1915”):

1. that the joint merger plan between Majestic Ventures S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and

existing  under  the  laws  of  the  Grand-Duchy  of  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies'
Register under number B 164.987, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg (the “Absorbing
Company”), and Mersey Ventures S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 164.985,
having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg (the “Absorbed Company“ and together with the
Absorbing Company, the “Merging Companies“) signed in the form of a notarial deed in front of the undersigned notary
on 11 December 2015, has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3473 of 30
December 2015 (the “Merger Plan“);

2. that in accordance with paragraph 2 of article 267 (1) of the Law of 1915, the sole shareholders of the Merging

Companies have expressly waived their rights to be provided with interim accounting statements of the Merging Companies;

3. that the documents listed in article 267 paragraph (1) a) and b), of the Law of 1915 have been made available to the

shareholders of the Absorbing Company at the registered office of the latter as of 11 December 2015;

4. that article 2 of said Merger Plan provides that the merger shall be realized and take effect between the Merging

Companies one month and one day after the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the
Merger Plan;

5. that no shareholder holding over five percent (5%) of the subscribed share capital of the Absorbing Company has

requested, within one month after the publication of the Merger Plan in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
the convening of a general meeting of the Absorbing Company;

6. that as from 1 January 2015, all operations and transactions of the Absorbed Company are considered for accounting

and tax purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company;

7. that the merger will be effective towards third parties at the date of the publication in the Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations of this certificate according to article 273 (1) of the Law of 1915;

8. that the Absorbed Company may therefore be struck off of the Trade and Companies' Register;
9. that the conditions provided for by article 279 of the Law of 1915 have been observed.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, upon request of the Merging Com-

panies, this certificate is worded in English, followed by a French version; and upon request of the same Merging Companies
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le troisième jour du mois de février,
le soussigné Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains certifie conformément à l'article 273 de la

loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»):

1. que le projet commun de fusion entre Majestic Ventures S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et

existante conformément aux lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.987 (la «Société
Absorbante»), et Mersey Ventures S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante conformément aux
lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.985 (la «Société Absorbée» et ensemble avec
la Société Absorbante, les «Sociétés Fusionnantes») signé en la forme notariée par devant le notaire soussigné en date du
11 décembre 2015, a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3473 du 30 décembre 2015
(le «Projet de Fusion»);

16869

L

U X E M B O U R G

2. qu'en application du paragraphe 2 de l'article 267 (1) de la Loi, les associés uniques des Sociétés Fusionnantes ont

expressément renoncé à leurs droits d'obtenir des comptes intérimaires des Sociétés Fusionnantes.

3. que les documents repris à l'article 267 paragraphe (1) a) et b) de la Loi de 1915 ont été mis à la disposition des

associés de la Société Absorbante au siège social de cette dernière à partir du 11 décembre 2015;

4. que l'article 2 du Projet de Fusion prévoit que la fusion sera considérée comme définitivement réalisée et prendra effet

entre les Sociétés Fusionnantes un mois et un jour après la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
du Projet de Fusion;

5. qu'aucun associé de la Société Absorbante détenant une participation au-delà de cinq pourcent (5%) du capital souscrit

de la Société Absorbante, n'a dans le délai d'un mois à partir de la publication du Projet de Fusion au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, demandé la convocation d'une assemblée générale;

6. qu'à compter du 1 

er

 janvier 2015, l'ensemble des opérations ainsi que des transactions réalisées par la Société Absorbée

sont considérées, d'un point de vue fiscal et comptable, comme ayant été accomplies au nom et pour le compte de la Société
Absorbante;

7. que la fusion prendra effet vis-à-vis des tiers à la date de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations du présent certificat conformément à article 273 (1) de la Loi de 1915;

8. que la Société Absorbée peut dès lors être rayée du Registre de commerce et des sociétés;
9. que les conditions exigées par l'article 279 de la Loi de 1915 ont été accomplies.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente que sur demande des Sociétés Fusionnantes,

le présent certificat est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes Sociétés Fusion-
nantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Mondorf-les-Bains, le 3 février 2016.

Maître Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2016061107/81.
(160022384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.

Olympic Ventures S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 35.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 165.037.

Osprey Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 38.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 164.988.

In the year two thousand and sixteen, on the third day of February,
the undersigned Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, certifies in accordance with article 273 of

the law of 10 August 1915 on the commercial companies, as amended (the “Law of 1915”):

1. that the joint merger plan between Olympic Ventures S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and

existing  under  the  laws  of  the  Grand-Duchy  of  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies'
Register under number B 165.037, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg (the “Absorbing
Company”), and Osprey Ventures S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 164.988,
having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg (the “Absorbed Company“ and together with the
Absorbing Company, the “Merging Companies“) signed in the form of a notarial deed in front of the undersigned notary
on 11 December 2015, has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3473 of 30
December 2015 (the “Merger Plan“);

2. that in accordance with paragraph 2 of article 267 (1) of the Law of 1915, the sole shareholders of the Merging

Companies have expressly waived their rights to be provided with interim accounting statements of the Merging Companies;

3. that the documents listed in article 267 paragraph (1) a) and b), of the Law of 1915 have been made available to the

shareholders of the Absorbing Company at the registered office of the latter as of 11 December 2015;

4. that article 2 of said Merger Plan provides that the merger shall be realized and take effect between the Merging

Companies one month and one day after the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the
Merger Plan;

16870

L

U X E M B O U R G

5. that no shareholder holding over five percent (5%) of the subscribed share capital of the Absorbing Company has

requested, within one month after the publication of the Merger Plan in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
the convening of a general meeting of the Absorbing Company;

6. that as from 1 January 2015, all operations and transactions of the Absorbed Company are considered for accounting

and tax purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company;

7. that the merger will be effective towards third parties at the date of the publication in the Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations of this certificate according to article 273 (1) of the Law of 1915;

8. that the Absorbed Company may therefore be struck off of the Trade and Companies' Register.
9. that the conditions provided for by article 279 of the Law of 1915 have been observed.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, upon request of the Merging Com-

panies, this certificate is worded in English, followed by a French version; and upon request of the same Merging Companies
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le troisième jour du mois de février,
le soussigné Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains certifie conformément à l'article 273 de la

loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»):

1. que le projet commun de fusion entre Olympic Ventures S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et

existante conformément aux lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165.037 (la «Société
Absorbante»), et Osprey Ventures S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante conformément aux
lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.988 (la «Société Absorbée» et ensemble avec
la Société Absorbante, les «Sociétés Fusionnantes») signé en la forme notariée par-devant le notaire soussigné en date du
11 décembre 2015, a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3473 du 30 décembre 2015
(le «Projet de Fusion»);

2. qu'en application du paragraphe 2 de l'article 267 (1) de la Loi, les associés uniques des Sociétés Fusionnantes ont

expressément renoncé à leurs droits d'obtenir des comptes intérimaires des Sociétés Fusionnantes.

3. que les documents repris à l'article 267 paragraphe (1) a) et b) de la Loi de 1915 ont été mis à la disposition des

associés de la Société Absorbante au siège social de cette dernière à partir du 11 décembre 2015;

4. que l'article 2 du Projet de Fusion prévoit que la fusion sera considérée comme définitivement réalisée et prendra effet

entre les Sociétés Fusionnantes un mois et un jour après la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
du Projet de Fusion;

5. qu'aucun associé de la Société Absorbante détenant une participation au-delà de cinq pourcent (5%) du capital souscrit

de la Société Absorbante, n'a dans le délai d'un mois à partir de la publication du Projet de Fusion au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, demandé la convocation d'une assemblée générale;

6. qu'à compter du 1 

er

 janvier 2015, l'ensemble des opérations ainsi que des transactions réalisées par la Société Absorbée

sont considérées, d'un point de vue fiscal et comptable, comme ayant été accomplies au nom et pour le compte de la Société
Absorbante;

7. que la fusion prendra effet vis-à-vis des tiers à la date de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations du présent certificat conformément à article 273 (1) de la Loi de 1915;

8. que la Société Absorbée peut dès lors être rayée du Registre de commerce et des sociétés;
9. que les conditions exigées par l'article 279 de la Loi de 1915 ont été accomplies.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente que sur demande des Sociétés Fusionnantes,

le présent certificat est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes Sociétés Fusion-
nantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Mondorf-les-Bains, le 3 février 2016.

Maître Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2016061170/81.
(160022382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.

16871

L

U X E M B O U R G

Gant International S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

R.C.S. Luxembourg B 130.003.

EXTRAIT

En date du 24 novembre 2015, la société domiciliataire Cofidom-Gestman Sàrl, a dénoncé avec effet immédiat le siège

social de la société

Nom de la Société: GANT INTERNATIONAL S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 23, Rue Aldringen L - 1118 LUXEMBOURG
N° du Registre de Commerce: B 130.003

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015191911/15.
(150215389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

Data Trust Holding S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 198.576.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2015.

Référence de publication: 2015191793/10.
(150215130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

Georges &amp; Theis Architectes Associés Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 84, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 98.045.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2015

A l'unanimité, l'Assemblée générale approuve la cession de cinquante parts sociales de M. GEORGES Benoit à M.

THEIS Georges.

A l'unanimité, l'Assemblée générale décide de transférer le siège social au 1, Reimerwee L9681 ROULLINGEN à partir

du 12 novembre 2015.

A l'unanimité, l'Assemblée générale accepte la démission du gérant M. GEORGES Benoit à partir du 12 novembre 2015

et confirme M. THEIS Georges entant que gérant unique.

THEIS Georges
<i>Le Gérant

Référence de publication: 2015191916/16.
(150215122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

Mandarin Capital Partners II S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société

d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 178.903.

Les statuts coordonnés au 11/11/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/11/2015.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2015192103/13.
(150214990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

16872

L

U X E M B O U R G

I.C.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 142.545.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015203664/9.
(150229387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

I.C.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 142.545.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015203665/9.
(150229388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

I.C.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 142.545.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015203666/9.
(150229389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

I.C.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 142.545.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015203667/9.
(150229390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Honey S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 16, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 138.078.

Les comptes annuels au 31. Dezember 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015203657/9.
(150228388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Instacom International S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 21.072.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2015203680/11.
(150229455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

16873

L

U X E M B O U R G

Instacom International S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 21.072.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2015203681/11.
(150229456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Instacom International S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 21.072.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2015203682/11.
(150229457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

International Safety Hard Alloy Corporation, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 1.957.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015203683/10.
(150228760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Intrepid Aviation Luxembourg Borrower II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 183.545.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Intrepid Aviation Luxembourg Borrower II S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015203687/11.
(150228538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Hogan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 162.902.

Le bilan de la société au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015203638/12.
(150228509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

16874

L

U X E M B O U R G

Hotepar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 124.125.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
HOTEPAR S.A.
Signature

Référence de publication: 2015203659/12.
(150228957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Insurance, Consulting, Investment Group Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Wilwerdange.

R.C.S. Luxembourg B 118.815.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Troisvierges, le 16/12/2015.

Référence de publication: 2015203711/10.
(150228568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Inter Metals S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 182.586.

Les comptes annuels au 31 MARS 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015203712/10.
(150229166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Interleasing Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 22, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 37.717.

Les comptes annuels au 01/01/2014 du 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015203713/10.
(150229009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

I.T. &amp; Management Associates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 66, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 55.125.

Date de clôture des comptes annuels 31/12/2014 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Derenbach, le 16/12/2015.

FRL SA
Signature

Référence de publication: 2015203669/12.
(150228948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

16875

L

U X E M B O U R G

International University of Health, Exercise &amp; Sports S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4671 Differdange, 50, avenue du Parc des Sports.

R.C.S. Luxembourg B 190.186.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16/12/2015.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2015203685/12.
(150229177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Investa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3360 Leudelange, 28, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 154.337.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PINHEIRO Samantha.

Référence de publication: 2015203715/10.
(150228422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Jessan Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 165.457.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2015.

Référence de publication: 2015203723/10.
(150229237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Jetamo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4988 Sanem, 6, rue de la Fontaine.

R.C.S. Luxembourg B 157.101.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015203729/10.
(150228921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

KC Esther S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 174.450.

<i>Rectificatif du dépôt enregistré et déposé au RCS le 08/09/2015 à Luxembourg sous la référence L150165010 du bilan au

<i>31 décembre 2014

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015203759/12.
(150229143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

16876

L

U X E M B O U R G

Energylux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9690 Watrange, 17B, rue Abbé Welter.

R.C.S. Luxembourg B 159.745.

Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2014 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Derenbach, le 16/12/2015.

FRL SA
Signature

Référence de publication: 2015203538/12.
(150228914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Erre Nove S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 31, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 55.550.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2015.

Référence de publication: 2015203544/10.
(150228996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

ESA plus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6475 Echternach, 20, rue Rabatt.

R.C.S. Luxembourg B 150.751.

Les comptes annuels du 01/01/2014 au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015203545/10.
(150229024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Euphonie Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 79.740.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015203550/10.
(150229179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Sarasino Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7651 Heffingen, 8, Hannert der Kiirch.

R.C.S. Luxembourg B 129.744.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09/12/2015.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2015199817/12.
(150223709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2015.

16877

L

U X E M B O U R G

Attert 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 201.861.

STATUTES

In the year two thousand five, on the 26 

th

 day of October,

Before Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg-City, to whom remains the present deed,

THERE APPEARED:

Schengen SCS 1, a Luxembourg common limited partnership, with registered office at L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel

Lippmann, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 201.821,

Represented by Mrs. Esbelta De Freitas, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The said proxy, after having been signed “ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the here above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

private limited liability company (société à responsabilité limitée), which it intends to organize as unitholder or with any
person who may become unitholder of this company in the future.

Title I. Name - Duration - Registered office - Object

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée), under the name of

“Attert 2 S.à r.l.”, governed by the present articles of association and the laws of Luxembourg pertaining to such an entity
(hereinafter the “Company”), and in particular the law dated 10 

th

 of August, 1915, on commercial companies, as amended

(hereafter the “Law”).

Art. 2. Object.
2.1 The object of the Company is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of participations, in

Luxembourg or abroad, in any form whatsoever. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, ex-
change or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit
and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private
entity whatsoever.

2.2 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities.

2.3 The Company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies,

in which it has a direct or indirect participation or to any other affiliated companies. It may also give guarantees and grant
securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or
any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of
its assets.

2.4 The Company may hold interests in partnerships. It may also acquire, enhance, licence and sub-licence and dispose

of patents, licences, and all other intangible property, as well as rights deriving there from or supplementing them. In
addition, the Company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad, and
may lease or dispose of moveable property.

2.5 In general, the Company may carry out all commercial and financial operations, whether in the area of securities or

of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purpose.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of members adopted in the manner

required for the amendment of these articles of association.

The life of the Company does not come to an end by the incapacity, bankruptcy, insolvency of or any other similar event

affecting, one or several members.

Art. 4. Registered office. The registered office is established in the city of Luxembourg. The registered office may be

transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the sole manager or the board of managers of the Com-
pany. It may further be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of its members adopted in the manner required for the amendment of these articles of association.

The Company may establish offices and branches, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of

the sole manager or the board of managers.

In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent, that would interfere

with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office; the
registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances.

16878

L

U X E M B O U R G

Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

Title II. Capital - Units

Art. 5. Capital - Units. The Company’s corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,-)

represented by twelve thousand five hundred (12.500) units in registered form with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

All the units are fully paid up.

Art. 6. Increase and reduction of corporate capital. The corporate capital of the Company may be increased or reduced

in one or several times, by a resolution of the general meeting of member(s), adopted in the manner required for the
amendment of these articles of association.

Art. 7. Transfer of units. Units are freely transferable among members.
In case of a sole member, the units are freely transferable to nonmembers. In case of plurality of members, units may

be transferred to non-members, within the limits of the Law. Indeed, units may not be transferred inter-vivo to non-members,
unless members representing at least three-quarters (3/4) of the corporate capital shall have agreed thereto in a general
meeting.

The transfer of units will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance

by the Company, as provided in article 1690 of the civil code.

The Company may purchase its own units.

Art. 8. Form of units - Members’ register. Units are in registered form.
A members’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law

and may be examined by the member(s) if he or they require.

The ownership of the registered units will result from the registration in the members’ register.

Title III. Administration - Management - Representation

Art. 9. Management. The Company shall be managed by a sole manager or a board of managers composed, at least, of

two (2) managers, who do not need to be members and who will be appointed pursuant to a resolution of the general meeting
of member(s).

The managers are appointed and removed ad nutum pursuant to a decision of the general meeting of member(s), which

determines  their  powers,  compensation  and  duration  of  their  mandates  reserved  the  faculty  attributed  to  the  board  of
managers to proceed by way of cooptation in order to replace resigning or deceased board members.

Art. 10. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or the present articles of association to

the general meeting of members fall within the competence of the sole manager or the board of managers, which shall have
all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object of the Company.

To the extent permitted by the Law, the sole manager or the board of managers may sub-delegate powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents. The sole manager or the board of managers will determine the agent’s responsibilities
and remunerations (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The agent so appointed shall in any case be revocable ad nutum.

Art. 11. Board of managers - Procedure.
11.1 In case of a plurality of managers the board of managers shall meet in Luxembourg as often as the Company’s

interest so requires or upon call of any manager. The board of managers shall meet at least annually in Luxembourg. The
board of managers may choose among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a
manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

11.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least two (2) working

days in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing by telefax
or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers. No such notice is required if all the managers of
the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have full
knowledge of the agenda of the meeting.

11.3 Any manager may exceptionally attend the board of managers’ meeting by means of telephone conference or

videoconference. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

11.4 Any manager may exceptionally act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax,

or by email another manager as his proxy. In case there is only one manager present at the board meeting, this manager is
allowed to appoint a secretary, who needs not to be manager, in order to assist him by holding the board meeting. Votes
may also be cast in writing or by cable, telegram, or telefax, or by email.

16879

L

U X E M B O U R G

11.5 In case of a plurality of managers the board of managers can validly deliberate and act only if the majority of the

managers are present or represented. Decisions shall be taken by a majority vote composed at least by one vote of each
class of managers present or represented at such meeting.

11.6 Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the

managers' meetings. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter or telefax. The date of the resolution shall be the date of the last signature of the resolution.

11.7 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

chairman pro tempore who presided at such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial
proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, the chairman pro tempore or by two managers.

Art. 12. Representation. The Company shall be bound by the signature of the sole manager or, in case of a plurality of

managers by the joint signature of two managers or by the sole or joint signature of any person or persons to whom such
signatory power shall have been delegated by the board of managers.

Art. 13. Liability of the managers. In the execution of their mandates, the managers are not held personally responsible

for the obligations of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their
duties.

Title IV. General meetings of members

Art. 14. Powers and voting rights.
14.1 Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of the

Company. It shall have the power to ratify all acts relating to the operations of the Company.

14.2 Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a

simple majority of those present and voting.

14.3 The corporate capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by a sole

member or majority of members representing at least three quarters (3/4) of the corporate capital. The members may change
the nationality of the Company by an unanimous vote. If all of the members are present or represented at a meeting of
members, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without
prior notice or publication.

14.4 Each unit entitles its holder to one vote in ordinary and extraordinary general meeting of member(s).
14.5 The Company will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as the sole owner
in relation to the Company.

14.6 Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to its relationship

with the number of units in existence. If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of
the general meeting.

14.7 The decisions of the member(s) are recorded in minutes or drawn-up in writing.
14.8 Also, contracts entered into between the member(s) and the Company represented by him or them, are recorded

on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into
under normal conditions.

Art.15. Annual general meeting. An annual general meeting of members approving the annual accounts shall be held

annually within six months after the closing of the accounting year at the registered office of the Company or at such other
place as may be specified in the notice of the annual general meeting.

Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall

terminate on the thirty-first of December, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of
the incorporation of the Company and shall terminate on the thirty-first of December, of the year two thousand sixteen.

Art. 17. Annual accounts and allocation of profits.
17.1 The annual accounts are drawn up by the sole manager or the board of managers as at the end of each accounting

year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Company.

17.2 Out of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve account.

This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve has reached an amount to ten per cent (10%) of the corporate
capital of the Company.

This allocation should again become compulsory if the legal reserve falls below ten (10%) per cent of the corporate

capital of the Company.

17.3 The general meeting of member(s), upon recommendation of the sole manager or the board of managers, will

determine the allocation of the annual net profits.

17.4 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) Interim accounts are established by the sole manager or the board of managers of the Company,

16880

L

U X E M B O U R G

(ii) These accounts show a profit, including profits carried forward,
(iii) The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members, or the sole

manager or the board of managers,

(iv) The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the significant creditors of

the Company are not threatened.

Title V. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation.
18.1 In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may

be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of the member(s) in charge of such dissolution and
which shall determine their powers and their compensations.

18.2 The power to amend the articles of association, if so justified by the needs of the liquidation, remains with the

general meeting of the member(s).

18.3 The power of the sole manager or the board of managers will end upon the appointment of the liquidator(s). After

the payment of all debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the remaining available amount
will be paid to the member, or in case of a plurality of members, the members in proportion to the units held by each member
in the Corporation.

Art. 19. General provision. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Subscription - Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party, represented

as stated here above, declare to subscribe for the twelve thousand five hundred (12,500.-) units and to have fully paid up
in cash these units for an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article

183 of the Law have been observed.

<i>Statement

The undersigned notary herewith declares having checked the existence of the conditions listed in article 183 of the Law

and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result

of its incorporation, are estimated at approximately nine hundred fifty euro (EUR 950.-).

<i>Resolution of the sole member

The prenamed member, representing the entire subscribed capital, has immediately taken the following resolutions:
1 The registered office of the Company is at L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
2 The number of manager is fixed at three (3).
3 The following persons are appointed as managers for an unlimited period of time:
- Mr. Eirik Holtedahl, Chief Financial Officer, born on 19 January 1968, in Oslo, Norway, residing professionally at

L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann;

- Mr. Marc Hentgen, Chief Executive Officer, born on 12 February 1960, in Dudelange, Luxembourg, residing profes-

sionally at L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann;

- Mr. Stephan Maus, Chief Accountant, born on 28 February 1976, in Worms, Germany, residing professionally at

L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le vingt-six octobre,
Par devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, lequel dernier restera dépositaire de la

présente minute,

16881

L

U X E M B O U R G

A COMPARU:

Schengen SCS 1, une société en commandite simple, établie et ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel

Lippmann, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201.821,

Ici représentée par Maître Esbelta De freitas, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Lequel comparant, agissant ès-qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée que la

partie prémentionnée va constituer en tant qu’associée ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de la société
par la suite.

Titre I 

er

 . Nom - Durée - Siège social - Objet

Art. 1 

er

 . Nom.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination “Attert 2 S.à r.l.”, (ci-après la

“Société”), qui sera régie par les présents statuts et les lois relatives à une telle entité, et en particulier la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»).

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, le développement et la cession de prise de participations dans toute

entreprise luxembourgeoise ou étrangère, sous quelque forme que ce soit. La Société pourra en particulier acquérir par
souscription, achat, échange ou de toute autre manière, toutes sortes d'actions cotées, actions simples et autres titres parti-
cipatifs, obligations, certificats de dépôt ou autres instruments de crédit et plus généralement tous titres et instruments
financiers émis par des entités privées ou publiques.

2.2 La Société pourra emprunter sous toutes les formes, sauf par voie d'émission publique. Elle pourra émettre par voie

d'émission privée seulement, effets, obligations et titres de créances et tout autre type de dette et/ou de titre de participation.

2.3 La Société pourra aussi contracter des prêts et accorder toute sorte de support, prêts, avances et garanties à d'autres

sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect et tout autre société affiliée. Elle pourra aussi donner des garanties
et accorder des garanties à l'égard de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées
ou toutes autres sociétés. La Société pourra de plus gager, transférer, grever ou créer d'autres types de garanties sur des
parties de ses actifs.

2.4 La Société pourra détenir des participations dans des associations. Elle pourra également acquérir, développer et

céder  des  brevets,  licences  ou  tout  autre  droit  intellectuel,  propriété  intangible,  ainsi  que  les  droits  en  dérivant  ou  les
complétant. De plus, la Société pourra acquérir, gérer, développer et céder des propriétés immobilières situées au Luxem-
bourg ou à l'étranger, et elle pourra louer ou disposer de bien meuble.

2.5 De manière générale, la Société pourra procéder à toutes opérations commerciales et financières dans les domaines

de l'acquisition de titres ou de biens immobiliers, qui sont de nature à développer et compléter l'objet social ci-dessus.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée d'associés adoptée dans les conditions

requises pour modifier les présents statuts.

L'existence de la Société ne prend pas fin par l'incapacité, la banqueroute, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire

affectant un ou plusieurs associés.

Art. 4. Siège social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la

ville de Luxembourg par décision du gérant unique ou du conseil de gérance de la société. Il pourra également être transféré
en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée générale des associés délibérant
comme en matière de modification des statuts.

La Société pourra établir des bureaux et des succursales tant au Grand- Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, par

décision du gérant unique ou du conseil de gérance.

Dans l'hypothèse d’événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'ac-

tivité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont
produits ou sont imminents, il pourra être procédé au transfert provisoire du siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales, ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle nonobstant ce transfert du siège social statutaire, restera luxembourgeoise.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille

cinq cents (12.500) parts sociales nominatives d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées.

16882

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Augmentation et réduction du capital. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à une ou

plusieurs reprises, par résolution de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 7. Transfert des parts. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
En cas d'associé unique, les parts sociales sont librement cessibles à des non-associés. En cas de pluralité d'associés, le

transfert de parts sociales peut-être effectué envers des non-associés à condition que ce transfert respecte les règles de la
Loi, c'est à dire qu'il a été autorisé au préalable par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts
(3/4) du capital social.

Le transfert de parts sociales ne sera opposable à la Société ou aux tiers que suite à la notification à la Société ou

l'acceptation par la Société telles que prévue par l'article 1690 du code civil.

La société pourra acquérir ses propres parts sociales.

Art. 8. Forme des parts sociales - Registre des associés. Les parts sociales sont nominatives.
Un registre des associés sera détenu au siège social de la Société conformément à la Loi et pourra être examiné par tout

associé qui le demande.

La propriété des parts nominatives résultera de l'inscription dans le registre des associés.

Titre III. Administration - Gérance - Représentation

Art. 9. Gérance. La Société est gérée par un gérant unique ou par un conseil de gérance, composé, au moins, de deux

(2) gérants, qui n’ont pas besoin d’être des associés et qui seront nommés par résolution de l’assemblée générale des
associés.

Les gérants sont nommés et révoqués ad nutum par une décision de l'assemblée générale des associés, qui détermine

également leurs pouvoirs, rémunération ainsi que la durée de leur mandat, sous réserve du pouvoir accordé au conseil de
gérance de procéder au remplacement des gérants démissionnaires ou décédés par voie de cooptation.

Art. 10. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à la

décision des associés, relèvent de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, qui est investi des pouvoirs
les plus larges pour passer tous actes et effectuer les opérations conformément à l'objet social.

Dans les limites permises par la Loi, le gérant unique ou le conseil de gérance est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le gérant unique ou le conseil de gérance déterminera les respon-
sabilités et la rémunération (si c'est le cas), la durée de la représentation et toute autre condition appropriée de la fonction
d'agent.

L'agent nommé sera dans tous les cas révocable ad nutum.

Art. 11. Conseil de gérance - Procédure.
11.1 En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance se réunira à Luxembourg aussi souvent que l'intérêt de la Société

le requière ou sur convocation d’un gérant. Le conseil de gérance se réunira au moins une fois par an à Luxembourg. Le
conseil de gérance pourra choisir en son sein un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être
gérant et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des
associés.

11.2 Tout gérant doit être convoqué par une convocation écrite au moins deux (2) jours avant la tenue du conseil de

gérance, à moins qu'un délai de convocation plus bref ne soit imposé par le caractère d'urgence des affaires en cause, lequel
sera dans ce cas décrit dans la convocation. Il peut être passé outre cette convocation avec l'accord écrit, par télécopieur
ou par courriel de chaque gérant. Aucune convocation spéciale n'est requise pour les réunions se tenant à une date, à une
heure et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement prise par le conseil de gérance. Une telle convocation
n'est pas requise si tous les gérants sont présents ou représentés lors de la réunion et qu'ils constatent qu'ils ont été bien
informés et qu'ils ont pleine connaissance de l'ordre du jour de la réunion.

11.3 Tout gérant pourra participer au conseil de gérance exceptionnellement par voie de téléconférence ou vidéocon-

férence. La participation à une réunion par ces moyens sera équivalente à une participation en personne.

11.4 Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax

ou par email un autre gérant. Pour le cas où un seul gérant serait présent à une réunion du conseil de gérance, ce gérant est
autorisé à nommer un secrétaire, qui peut ne pas être un gérant, pour l'assister dans la tenue de la réunion du conseil de
gérance. Les votes peuvent également être exprimés par écrit, par télécopieur ou par e-mail.

11.5 En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et agir que si la majorité des

gérants est présente ou représentée. Les décisions seront prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés
à une telle réunion, composés au moins par une voix de chaque catégorie de gérant.

11.6 Les résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants ont les mêmes effets que les résolutions votées

lors d'une réunion du conseil de gérance. De telles signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs
copies de la même résolution et peuvent être prouvées par des lettres ou des téléfax. La date des résolutions sera la date de
la dernière signature des résolutions.

16883

L

U X E M B O U R G

11.7 Les minutes de chacune des réunions du conseil de gérance doivent être signées par le président ou en son absence

par le président qui préside une telle réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou
ailleurs seront signés par le président, le président ad hoc, ou par deux gérants.

Art. 12. Représentation. La Société est engagée par la signature du gérant unique ou par la signature conjointe de deux

gérants ou la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le
conseil de gérance.

Art. 13. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont respon-
sables que de l'exécution de leur mandat.

Titre IV. Assemblée générale des associés

Art. 14. Pouvoirs et droits de votes.
14.1 Toute assemblée d'associés de la Société valablement constituée représentera l'ensemble des associés de la Société.

Elle aura le pouvoir de ratifier tous les actes en relation avec les opérations de la Société.

14.2 Sauf exception légale, les décisions des assemblées des associés valablement convoquées seront prises à la majorité

simple des associés présents et votants.

14.3 Le capital social et les autres dispositions de ces statuts pourront être modifiés à tout moment par l'associé unique

ou par une majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité
de la société requiert l’unanimité des voix des associés. Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée
des associés et s'ils précisent qu'ils ont tous été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans
convocation ou publication préalable.

14.4 Chaque part sociale donne droit à une voix au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
14.5 La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par part sociale; dans l'hypothèse où une part sociale est détenue par

plusieurs personnes, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne
ait été désignée comme le seul propriétaire de cette part sociale vis-à-vis de la Société.

14.6 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et des bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre de parts sociales en circulation. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs
de l'assemblée générale des associés.

14.7 Les décisions de l’associé unique sont établies sous la forme de minutes ou dressées par écrit.
14.8 De plus, les contrats passés entre les associés et la société représentée par les associés, seront établis sous la forme

de minutes ou dressées par écrit. Cependant, cette dernière hypothèse n'est pas applicable aux opérations courantes passées
à des conditions normales.

Art. 15. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour

l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra dans les six mois de la clôture de l'exercice social au siège de la Société
ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 16. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre

de la même année, à l'exception du premier exercice social qui débutera à la date de création de la Société et se terminera
le trente et un décembre deux mille seize.

Art. 17. Comptes annuels et allocation des bénéfices.
17. Les comptes annuels sont préparés par le gérant unique ou par le conseil de gérance à l'issue de chaque exercice

social et sont tenus à la disposition des associés au siège social de la Société.

17.2 Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice annuel net de la Société pour la constitution d’une réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant des réserves atteint dix pour cent (10%) du capital social de la
société.

Le prélèvement redevient obligatoire lorsque la réserve légale tombe en dessous de dix pour cent (10%) du capital social

de la société.

17.3 L'assemblée générale des associés, sur recommandation du gérant unique ou du conseil de gérance, déterminera

l'allocation des bénéfices annuels nets.

17.4 Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment sous les conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires seront établis par le gérant unique ou par le conseil de gérance,
(ii) ces comptes feront état d'un bénéfice incluant les bénéfices reportés,
(iii) la décision de payer un dividende intérimaire sera prise par une assemblée extraordinaire des associés, ou par le

gérant unique ou les gérants,

(iv) le paiement sera effectué après que la Société aura obtenu la garantie que les droits des créanciers importants de la

Société ne sont pas menacés.

16884

L

U X E M B O U R G

Titre V. Dissolution et Liquidation

Art. 18. Dissolution et liquidation.
18.1 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront

être des personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée des associés qui déterminera leurs pouvoirs et rému-
nérations.

18.2 Le pouvoir de modifier les statuts, si nécessaire pour les besoins de la liquidation, reste une prérogative de l'as-

semblée générale des associé(s).

18.3 Les pouvoirs du gérant unique ou des gérants cesseront par la nomination du(es) liquidateur(s). Après le paiement

de toutes les dettes et tout le passif de la Société ou du dépôt des fonds nécessaires à cela, le surplus sera versé à l'associé
unique ou en cas de pluralité d'associé le surplus sera versé à chaque associé en proportion du nombre de ses parts.

Art. 19. Dispositions générales. Tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents statuts sera

régi par la Loi.

<i>Souscription et Libération

La partie comparante, ici représentée comme indiqué ci-dessus, ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a déclaré

souscrire aux douze mille cinq cent (12.500) parts sociales et a déclaré les avoir libérées en espèces pour un montant de
douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-).

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183

de la Loi, ont été respectées.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié que les conditions prévues par l’article 183 de la Loi se trouvent accomplies

et déclare expressément que celles-ci sont remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ neuf cent cinquante euros

(EUR 950.-).

<i>Résolutions de l’associé unique

Et aussitôt, le comparant représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1 Le siège social de la Société est fixé à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
2 Le nombre de gérant est fixé à trois (3).
3 Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée illimitée:
- Mr. Eirik Holtedahl, Chief Financial Officer, né le 19 janvier 1968, à Oslo, Norway, demeurant professionnellement

à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann;

- Mr. Marc Hentgen, Chief Executive Officer, né le 12 février 1960, à Dudelange, Luxembourg, demeurant profession-

nellement à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann;

- Mr. Stephan Maus, Chief Accountant, né le 28 février 1976, à Worms, Germany, demeurant professionnellement à

L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: DE FREITAS, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 3 novembre 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 34817. Reçu soixante-quinze

euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Référence de publication: 2015194760/429.
(150218127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

16885

L

U X E M B O U R G

Credit Suisse (Lux) Energy GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 201.856.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen,
on the twenty-fourth day of the month of November.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Credit Suisse Holding Europe (Luxembourg) S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated

and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and
Companies under number B 45.630 and having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg,

represented  by  Mr  Alexander  WAGNER,  Rechstanwalt,  professionally  residing  at  10,  Boulevard  Grand-Duchesse

Charlotte, L-1330 Luxembourg,

by virtue of a proxy given to him under private seal in Luxembourg, on 23 November 2015.
Said proxy given, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of incor-

poration of a société à responsabilité limitée governed by the relevant laws and the present articles of incorporation.

<i>Definitions

The following terms shall have the meaning as set out hereafter whenever used herein with initial capital letters:
"1915 Law" means the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to

time;

"Articles" means the present articles of incorporation;
"Board" means in case of plurality of Managers the board of Managers of the Company;
"Business Day" means any day, other than a Saturday or Sunday, when banks in Luxembourg are open for the transaction

of normal business;

"Euro" or "EUR" means the lawful currency of the European Union member states that have adopted the single currency

in accordance with the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union;

"Manager" means a manager appointed to the Board in accordance with these Articles or as the case may be a member

of the Board;

"Share(s)" means the shares issued by the Company and any share issued in exchange for those shares or by way of

conversion or reclassification, and any shares representing or deriving from those shares as a result of any increases in or
reorganization or variation of the capital of the Company; and

"Shareholder" means a holder of Shares.

Title I. Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by the present and all persons and entities who may become Shareholders in the future

a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of Credit Suisse (Lux) Energy GP S.à r.l.
(hereinafter referred to as the "Company").

Art. 2. The Company’s corporate object is to act as general partner (associé gérant commandité) of a common limited

partnership (société en commandite simple), incorporated under the name "Credit Suisse (Lux) Wind Power Central Norway
SCS".

The Company shall carry out any activities connected with its status of general partner of the aforementioned entity.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly with all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The Manager or in case of plurality of Managers, the Board is authorised to change the address of the Company inside

the municipality of the statutory registered office.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary

general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

16886

L

U X E M B O U R G

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect
on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Lu-
xembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The Company’s capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred

(100) Shares of one hundred and twenty- five Euro (EUR 125.-) each.

The one hundred (100) Shares have all been fully paid in cash.
The capital may be increased or reduced by a resolution of the single Shareholder or by resolution of the Shareholders

of the Company adopted in accordance with Article 19 hereof.

Shares will only be issued in registered form and will be inscribed in the register of Shares, which is held by the Company

or by one or more persons on behalf of the Company. Such register of Shares shall set forth the name of each Shareholder,
his residence or elected domicile, the number and class of Shares held by him.

In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the 1915 Law.

Title III. Shareholder meetings

Art. 6. Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company shall represent the entire body of Sha-

reholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of
the Company.

Art. 7. In case of a single Shareholder, the single Shareholder assumes all powers conferred to the Shareholders’ meeting.

Any resolutions to be taken by the single Shareholder may be taken in writing.

In case of plurality of Shareholders, the provisions of Article 8 will apply to any resolution to be taken by a meeting of

Shareholders.

Each Share is entitled to one vote.
A Shareholder may be represented at any meeting of Shareholders by another person, which does not need to be a

Shareholder and which may be a Manager. The proxy established to this effect may be in writing or by cable, telegram,
facsimile or e-mail transmission.

Art. 8. If legally required or if not so required upon the decision of the Board, annual general meetings of Shareholders

of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law, in the City of Luxembourg at the registered office of
the Company, or such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting. Such annual general
meetings may be held abroad if, in the judgement of the Board, exceptional circumstances so require.

The Board may convene other meetings of Shareholders to be held at such place and time as may be specified in the

respective notices of meetings.

The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of Shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Except as otherwise required by law or provided herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly convened will

be passed by simple majority of the votes cast by those Shareholders present and voting.

The general meeting of Shareholders shall be called by the Board, by notices containing the agenda and which will be

published as required by law.

The Board will prepare the agenda, except if the meeting takes place due to the written request of Shareholders provided

for by law; in such case the Board may prepare an additional agenda.

If all of the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

The matters dealt with by the meeting of Shareholders are limited to the issues contained in the agenda which must

contain all issues prescribed by law as well as to issues related thereto, except if all the Shareholders agree to another
agenda. In case the agenda should contain the nomination of Managers or of the auditor, the names of the eligible Managers
or of the auditors will be inserted in the agenda.

Title IV. Administration

Art. 9. The Company shall be managed by one or more Manager(s). If several Managers have been appointed they will

constitute a Board.

The Manager(s) need not be Shareholders of the Company.

16887

L

U X E M B O U R G

The Manager(s) shall be elected by the general meeting of Shareholders for a period as determined by such general

meeting of Shareholders and until their successors are elected and take up their functions. Upon expiry of its mandate, a
Manager may seek reappointment.

The Manager(s) mandate may be revoked at any time with or without a reason by the general meeting of Shareholders.
In case of plurality of Managers and in the event of a vacancy in the office of a Manager because of death, retirement

or otherwise, the remaining Managers may meet and may elect, by majority vote, a Manager to fill such vacancy until the
next general meeting of Shareholders.

Art. 10. In case of plurality of Managers, the Board may choose from among its members a chairman, and may choose

from among its members one or more vice-chairmen.

The Manager or in case of plurality of Managers, the Board may also choose a secretary, who need not be a Manager

and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the Shareholders.

The Manager or in case of plurality of Managers, the Board may from time to time appoint officers of the Company,

including a managing director, a general manager and any assistant managers or other officers considered necessary for
the operation and management of the Company. Officers need not be Managers or Shareholders of the Company. The
officers appointed, unless otherwise stipulated herein, shall have the powers and duties given to them by the Manager or
in case of plurality of Managers, the Board.

The Board shall meet upon call by the chairman, or any two Managers, at the place indicated in the notice of meeting.
Notice of any meeting of the Board shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, telefax or by other electronic

means of transmission to all Manager at least twenty four hours in advance of the day set for the meeting. The notice shall
specify the purposes of and each item of business to be transacted at the meeting, and no business other than that referred
to in such notice may be conducted at any such meeting nor shall any action taken by the Board not referred to in such
notice be valid. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or telex or telefax or by other
electronic means of transmission of each Manager and shall be deemed to be waived by any Manager who is present in
person or represented by proxy at the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times
and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any Manager may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable or telegram, telex or telefax

another Manager as his proxy. Any Manager may attend a meeting of the Board using teleconference, video means or any
other audible or visual means of communication. A Board member attending a meeting of the Board by using such means
of communication is deemed to be present in person at this meeting.

A meeting of the Board held by teleconference or videoconference or any other audible or visual means of communi-

cation, in which a quorum of Managers participate shall be as valid and effectual as if physically held, provided that a
minute of the meeting is made and signed by the chairman of the meeting.

The Board can deliberate or act validly only if at least a majority of the Managers is present or represented at a meeting

of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
Managers who are not present in person or represented by proxy may vote in writing or by cable or telegram or telex or
telefax or by other electronic means of communication.

In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have

a casting vote.

Circular resolutions signed by all Managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and

held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced
by letters or telefaxes. Such resolutions shall enter into force on the date of the circular resolution as mentioned therein. In
case no specific date is mentioned, the circular resolution shall become effective on the day on which the last signature of
a Board member is affixed.

Resolutions taken by any other electronic means of communication e.g. e-mail, cables, telegrams or telexes shall be

formalized by subsequent circular resolution. The date of effectiveness of the then taken circular resolution shall be the
one of the latest approval received by the Company via electronic means of communication. Such approvals received from
all Board Members shall remain attached to and form an integral part of the circular resolution endorsing the decisions
formerly approved by electronic means of communication.

Any circular resolutions may only be taken by unanimous consent of all the members of the Board.
The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman of the meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

chairman of the board or chairman pro tempore of that meeting, or by two Managers.

Art. 11. The Manager or in case of plurality of Managers, the Board, shall have power to determine the course and

conduct of the management and business affairs of the Company.

It is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the interests of the Company.

All  powers  not  expressly  reserved  by  law  or  by  these  Articles  to  the  general  meeting  of  Shareholders  fall  within  the
competence of the Board.

16888

L

U X E M B O U R G

Art. 12. The Company shall be bound by the sole signature of its single Manager, or in case of plurality of Managers,

by the joint signature of any two Managers of the Company, or by the signature of any person(s) to whom such signatory
authority has been delegated by the Manager or in case of plurality of Managers, by the Board or by any two Managers
acting jointly.

Art. 13. The Manager or in case of plurality of Managers, the Board, may delegate its powers to conduct the daily

management and affairs of the Company, including the right to sign on behalf of the Company, and its powers to carry out
acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to officers of the Company or to other persons, which at their turn
may delegate their powers if they are authorised to do so by the Manager or in case of plurality of Managers, the Board.

Art. 14. No contract or other transaction which the Company and any other company or firm might enter into shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or officers of the Company is interested in such
other company or firm by a relation, or is a director, officer or employee of such other company or legal entity.

In the event that any Manager or officer of the Company may have any personal interest in any contract or transaction

of the Company other than that arising out of the fact that he is a Manager, officer or employee or holder of securities or
other interests in the counter-party, such Manager or officer shall, in case of plurality of Managers, make known to the
Board such personal interest and shall not consider or vote upon any such contract or transaction. Such contract or trans-
action,  and  such  Manager’s  or  officer’s  personal  interest  therein,  shall  be  reported  to  the  next  succeeding  meeting  of
Shareholders.

Art. 15. The Company may indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against

expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Manager or officer of the Company or, at its request, of any other company of
which the Company is a unitholder or a creditor and which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct;
in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement
as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty.
The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Title V. Accounting, Distributions

Art. 16. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall terminate on 31 December of each year.

Art. 17. From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital
of the Company as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to time in accordance with Article 5
hereof.

The general meeting of Shareholders shall decide each year how the remainder of the annual net profit shall be allocated

and may declare dividends from time to time or instruct the Manager or in case of Board to do so.

The Board may within the conditions set out by law unanimously resolve to pay out interim dividends.

Title VI. Winding up, Liquidation

Art. 18. In the event of a winding-up of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators.

Liquidators may be physical persons or legal entities and are named by the meeting of Shareholders deciding such winding-
up and which shall determine their powers and their compensation.

Title VII. Amendments

Art. 19. These Articles may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the respect of the

quorum and majority requirements provided by Luxembourg law.

Art. 20. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law.

<i>Transitory disposition

The  first  accounting  year  shall  commence  on  the  date  of  incorporation  of  the  Company  and  shall  terminate  on  31

December 2016.

<i>Subscription and Payment

The capital of the Company is subscribed as follows:
Credit Suisse Holding Europe (Luxembourg) S.A., specified above, subscribes for one hundred (100) Shares, resulting

in a total payment in cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

Evidence of the above payment in cash was given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately

thousand euro.

16889

L

U X E M B O U R G

<i>General Meeting of Shareholders

The above named person representing the entire subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting,

passed the following resolutions:

(i) The following are elected as Managers for an undetermined period:
- Rudolf Kömen, Director, Credit Suisse Fund Management S.A., born on 01 January 1967 in Trier, Germany, having

its professional address at 5, rue Jean- Monnet, L-2180 Luxembourg;

- Fernand Schaus, Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxembourg born on 26 April 1967 in Sandweiler,

Luxembourg, having its professional address at 5, rue Jean-Monnet, L-2180 Luxembourg; and

- Dominik Bollier, Managing Partner, Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG, Zurich, born on 24 July 1976,

in Horgen, Switzerland, having its professional address at Kalanderplatz 5, 8070 Zurich, Switzerland.

(ii) The following is elected as independent auditor for a term to expire at the close of the annual general meeting of

Shareholders which shall deliberate on the annual accounts as at 31 December 2016:

“KPMG, Luxembourg”, Société Coopérative, 39 Avenue Kennedy, L-1855 Luxembourg (RCS Luxembourg, section

B number 149 133).

(iii) The registered office of the Company is set at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the above named

person, this deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing person, in case
of divergence between the English and the German versions, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, surname, status

and residence, said proxyholder signed together with Us notary the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden englischen Textes.

Im Jahre zweitausendfünfzehn,
am vierundzwanzigsten Tag des Monats November.
Vor Uns Maître Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz in SASSENHEIM Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

Credit Suisse Holding Europe (Luxembourg) S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und organisiert

nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter
der Nummer B 45.630, mit Sitz in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

hier vertreten durch Herrn Alexander WAGNER, Rechtsanwalt, berufsansässig in 10, Boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1330 Luxemburg,

aufgrund einer ihm am 23. November 2015 in Luxemburg erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
Diese Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichnenden Notar

der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Die wie vorstehend beschrieben vertretene Erschienene hat den Notar gebeten, die nachstehende Satzung (articles of

incorporation) einer den einschlägigen Gesetzen sowie den Bestimmungen dieser Satzung unterliegenden Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu Protokoll zu nehmen.

<i>Definitionen

Die folgenden Begriffe haben, wenn sie mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben sind, die ihnen jeweils zugeordnete

Bedeutung:

"Euro" oder "EUR" ist die gesetzliche Währung derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die gemäß dem

Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union die gemeinsame
Währung eingeführt haben;

"Geschäftsführer"  ist  einer  der  gemäß  dieser  Satzung  zum  Mitglied  des  Rates  der  Geschäftsführung  bestellten  Ge-

schäftsführer bzw. im Falle einer Mehrheit von Geschäftsführern ein Mitglied des Rates der Geschäftsführung;

"Geschäftstag" ist ein Tag, außer Samstag und Sonntag, an dem die Banken in Luxemburg für die üblichen Geschäfte

geöffnet sind;

"Gesellschafter" ist ein Inhaber von Gesellschaftsanteilen;
"Gesellschaftsanteil(e)" sind die von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile sowie im Tausch gegen solche Anteile oder

aufgrund einer Umwandlung oder Reklassifizierung ausgegebene Anteile sowie Anteile, die aufgrund von Kapitalerhö-
hungen, Umwandlungen oder Reklassifizierung für diese Anteile stehen oder aus ihnen hervorgehen;

"Gesetz von 1915" ist das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils

geltenden Fassung;

16890

L

U X E M B O U R G

"Rat der Geschäftsführung" ist der Rat der Geschäftsführung der Gesellschaft; und
"Satzung" ist die vorliegende Satzung.

Abschnitt I. Name, Zweck, Dauer, Sitz

Art. 1. Hiermit wird durch die gegenwärtigen und künftigen Gesellschafter eine Gesellschaft in der Rechtsform einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Namen Credit Suisse (Lux) Energy GP S.à r.l.
(nachstehend "Gesellschaft" genannt) gegründet.

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist es, als Komplementärin (associé gérant commandité) einer Kommanditgesell-

schaft (société en commandite simple) zu fungieren, welche unter dem Namen " Credit Suisse (Lux) Wind Power Central
Norway SCS" gegründet wurde.

Die Gesellschaft soll alle Tätigkeiten ausführen, die mit ihrer Stellung als Komplementärin der vorbezeichneten Ge-

sellschaft zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann alle gewerblichen, technischen oder finanziellen Tätigkeiten ausführen, die direkt oder indirekt

mit allen oben beschriebenen Bereichen verbunden sind, um die Erfüllung ihres Zweckes zu fördern.

Art. 3. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
Der Alleingeschäftsführer oder, im Falle einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Rat der Geschäftsführung, berechtigt

den Gesellschaftssitz innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes zu verlegen.

Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß dem für Satzungsän-

derungen geltenden Verfahren an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Sofern außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur eintreten oder vor-

hersehbar  sind,  die  die  Gesellschaft  in  ihrer  Tätigkeit  am  Gesellschaftssitz  behindern,  kann  der  Sitz  der  Gesellschaft
vorübergehend bis zur Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden; eine solche vorübergehende
Maßnahme berührt die Nationalität der Gesellschaft nicht. Der Beschluss zur Verlegung des Gesellschaftssitzes in ein
anderes Land wir vom Alleingeschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, von dem Rat der Ge-
schäftsführung gefasst.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen oder Büros gründen, in Luxemburg sowie im Ausland.

Abschnitt II. Kapital, Gesellschaftsanteile

Art. 5. Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgelegt und in einhundert

(100) Gesellschaftsanteile mit einem Wert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) je Anteil aufgeteilt.

Die einhundert (100) Gesellschaftsanteile sind vollständig eingezahlt.
Das Kapital kann aufgrund eines gemäß Artikel 19 dieser Satzung getroffenen Beschlusses des Alleingesellschafters

oder der Gesellschafter der Gesellschaft erhöht oder herabgesetzt werden.

Gesellschaftsanteile werden nur als Namensanteile ausgegeben und sind ins Anteilsregister einzutragen, das von der

Gesellschaft oder von einer oder mehreren Personen im Namen der Gesellschaft geführt wird. In diesem Anteilsregister
wird der Name des Gesellschafters, sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort, die Nummer und die Klasse der von
ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile vermerkt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, sind die von dem Alleingesellschafter gehaltenen Gesellschafts-

anteile frei übertragbar.

Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, können die von jedem Gesellschafter gehaltenen Gesellschaftsan-

teile gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes von 1915 übertragen werden.

Abschnitt III. Gesellschafterversammlungen

Art. 6. Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Gesellschafter der Gesellschaft gilt als Vertretung sämtlicher

Gesellschafter der Gesellschaft. Sie verfügt über größtmögliche Befugnisse, mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft
verbundene Handlungen anzuordnen, durchzuführen oder zu bewilligen.

Art. 7. Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, stehen diesem sämtliche der Gesellschafterversammlung

übertragenen Befugnisse zu. Von dem Alleingesellschafter zu fassende Beschlüsse können schriftlich gefasst werden.

Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, gelten die Bestimmungen von Artikel 8 für sämtliche von einer

Gesellschafterversammlung zu fassenden Beschlüsse.

Jeder Gesellschaftsanteil gewährt eine Stimme.
Ein Gesellschafter kann sich auf Gesellschafterversammlungen von einer anderen Person vertreten lassen, die kein

Gesellschafter sein muss und ein Geschäftsführer sein kann. Eine zu diesem Zweck gewährte Vollmacht kann schriftlich,
per Telegramm, per Fernschreiben, per Fax oder E-Mail erteilt werden.

Art. 8. Sofern kraft Gesetz erforderlich oder, andernfalls, aufgrund einer Entscheidung des Rates der Geschäftsführung,

werden die jährlichen Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft gemäß luxemburgischem Recht am Sitz der Gesell-

16891

L

U X E M B O U R G

schaft in Luxemburg oder einem anderen, in der Einladung zur Versammlung genannten Ort abgehalten. Solche jährlichen
Gesellschafterversammlungen können im Ausland abgehalten werden, wenn der Rat der Geschäftsführung dies aufgrund
des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände für erforderlich hält.

Der Rat der Geschäftsführung kann weitere Gesellschafterversammlungen einberufen, die an den in den jeweiligen

Einladungen genannten Orten und zu den darin ebenfalls genannten Zeiten abgehalten werden.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in dieser Satzung gelten im Hinblick auf die Fristen für Einladungen zu

Gesellschafterversammlungen und deren Beschlussfähigkeit die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

Vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen oder Bestimmungen dieser Satzung sind auf einer ordnungs-

gemäß einberufenen Gesellschafterversammlung zu fassende Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen der anwesenden und sich an der jeweiligen Abstimmung beteiligenden Gesellschafter zu fassen.

Die jährlichen Gesellschafterversammlungen sind von dem Rat der Geschäftsführung durch Versendung von Einla-

dungen einzuberufen, die die Tagesordnung enthalten und die gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu
veröffentlichen sind.

Der Rat der Geschäftsführung wird die Tagesordnung erstellen, es sei denn, eine Versammlung findet auf schriftliches

Verlangen der Gesellschafter gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen statt; in einem solchen Fall kann der
Rat der Geschäftsführung eine weitere Tagesordnung erstellen.

Sofern bei einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie

über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann eine Versammlung ohne vorherige Einladung oder
Veröffentlichung abgehalten werden.

Die Angelegenheiten, die von einer Gesellschafterversammlung behandelt werden, sind auf die in der Tagesordnung

genannten Punkte zu beschränken, wobei alle gesetzlich vorgeschriebenen und mit diesen zusammenhängende Punkte zu
behandeln sind, es sei denn, alle Gesellschafter einigen sich auf eine andere Tagesordnung. Sofern die Bestellung von
Geschäftsführern oder eines Abschlussprüfers auf der Tagesordnung steht, sind die Namen der zur Wahl stehenden Ge-
schäftsführer oder Abschlussprüfer in die Tagesordnung aufzunehmen.

Abschnitt IV. Verwaltung

Art. 9. Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Geschäftsführern geführt. Sofern mehrere

Geschäftsführer bestellt worden sind, bilden sie einen Rat der Geschäftsführung.

Der bzw. die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.
Der bzw. die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung für einen von dieser bestimmten Zeitraum

gewählt,  bis  ihre  Nachfolger  gewählt  sind  und  ihr  Amt  übernehmen.  Nach  Ablauf  seiner  Amtszeit  kann  sich  ein  Ge-
schäftsführer wieder zur Wahl stellen.

Der bzw. die Geschäftsführer können jederzeit von der Gesellschafterversammlung mit oder ohne die Angabe von

Gründen ihres Amtes enthoben werden.

Sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, sowie für den Fall, dass der Posten eines Geschäftsführers aufgrund des

Todes, des Eintritts in den Ruhestand eines Geschäftsführers oder aus anderen Gründen vakant wird, können sich die
verbleibenden Geschäftsführer versammeln und mit einfacher Mehrheit einen Geschäftsführer wählen, der eine solche
Vakanz bis zur nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung ausfüllt.

Art. 10. Im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, ernennt der Rat der Geschäftsführung aus seiner Mitte einen

Vorsitzenden und kann einen oder mehrere stellvertretende Vize-Vorsitzenden ernennen.

Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung kann einen Sek-

retär ernennen, der kein Geschäftsführer sein muss und für die Führung des Protokolls von Versammlungen des Rates der
Geschäftsführung und von Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.

Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung kann jeweils

Bevollmächtigte ("Officers") der Gesellschaft ernennen, einschließlich eines Managing Directors, eines General Managers,
eines Assistant Managers oder sonstiger Bevollmächtigte, die im Hinblick auf den Betrieb und die Verwaltung der Ge-
sellschaft  für  erforderlich  gehalten  werden.  Bevollmächtigte  müssen  keine  Geschäftsführer  oder  Gesellschafter  der
Gesellschaft sein. Die ernannten Bevollmächtigten haben die ihnen von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Ge-
schäftsführer bestellt sind, vom Rat der Geschäftsführung zugewiesenen Befugnisse und Pflichten.

Der Rat der Geschäftsführung versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern an dem

in der jeweiligen Einladung genannten Ort.

Die Einladung zu einer Versammlung der Geschäftsführung erfolgt schriftlich bzw. per Kabel, Telegramm, Telex, Fax

oder auf elektronischem Wege und soll mindestens vierundzwanzig Stunden vor der Versammlung zugestellt werden. Die
Einladung beinhaltet die Tagesordnung der Versammlung. Ein nicht in der Tagesordnung enthaltener Agenda-Punkt kann
nicht rechtsgültig in der Versammlung beraten werden. Auf die Einberufung zur Versammlung der Geschäftsführer kann
verzichtet werden mittels schriftlicher Einwilligung bzw. mittels einer Zustellung der Mitteilung per Kabel, Telegramm,
Telex, Fax oder elektronischer Mittel. Das Erfordernis der Einberufung gilt als verzichtet für alle in der Versammlung
anwesenden oder durch Vollmacht vertretenen Geschäftsführer. Für die Versammlungen, die gemäß einem durch Beschluss

16892

L

U X E M B O U R G

der Geschäftsführer festgesetzten Zeitplan abgehalten werden, ist keine zusätzliche Einladung zur Versammlung erfor-
derlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich in der Versammlung der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer vertreten

lassen, in dem er schriftlich bzw. per Kabel, Telefax, Telegramm, Telex, einen anderen Geschäftsführer als seinen Be-
vollmächtigten ernennt.

Die Teilnahme der Geschäftsführer an der Geschäftsführungssitzung kann per Telefon, Video-Konferenzschaltung oder

anderen ähnlichen Kommunikationsmittel, die es allen an der Geschäftsführungssitzung teilnehmenden Personen erlaubt,
sich gegenseitig zu hören, erfolgen. Ein Geschäftsführer, der durch die Kommunikationsmittel an einer Geschäftsfüh-
rungssitzung teilnimmt, gilt als persönlich Anwesender dieser Sitzung.

Eine Versammlung der Geschäftsführer per Telefon oder Video-Konferenzschaltung oder jeder anderen Art von Audio-

oder Videokommunikation, an der ein Quorum von Geschäftsführern teilnimmt, ist genauso bindend als ob alle Geschäfts-
führer  persönlich  anwesend  gewesen  wären,  vorausgesetzt,  ein  Protokoll  wurde  erstellt  und  vom  Vorsitzenden  der
Geschäftsführungssitzung unterzeichnet.

Die Geschäftsführung kann rechtsgültig Beschlüsse fassen, wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder anwesend

oder vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Geschäftsführer gefasst, welche
bei der Sitzung anwesend oder vertreten sind. Nicht persönlich anwesende oder nicht vertretene Geschäftsführer können
schriftlich bzw. durch Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder durch Einsatz anderer elektronischer Mittel an der Abstimmung
teilnehmen.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden auschlaggebend.
Umlaufbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurden, sind genauso rechtswirksam und bindend, als

ob die Sitzung ordnungsgemäß einberufen und abgehalten worden wäre. Die Unterschrift der Geschäftsführer kann auf
einer einzelnen Ausfertigung bzw. auf mehreren Ausfertigungen eines jeden Beschlusses vermerkt sein, und auch per Brief,
Telefax oder Telex bestätigt werden. Diese Beschlüsse treten in Kraft am Tage des im Umlaufbeschluss vermerkten Datums.
Sollte dort kein spezielles Datum vermerkt sein, wird der Umlaufbeschluss gültig an dem Tag, an dem die letzte Unterschrift
getätigt wird.

Beschlüsse, die durch elektronische Mittel wie z.B. per E-Mail, ein Telegramm oder ein Telex gefasst werden, müssen

anschließend durch einen Zirkularbeschluss formalisiert werden. Das Inkrafttreten des Zirkularbeschlusses erfolgt am Tage
der letzten Zustimmungserklärung, welche die Gesellschaft in elektronischer Form erhielt. Die Zustimmungen von allen
Mitgliedern der Geschäftsführung werden dem Umlaufbeschluss beigefügt und bilden dabei einen integralen Bestandteil
derselben, wobei der Umlaufbeschluss die zuvor in elektronischer Form gefassten Beschlüsse bestätigt.

Umlaufbeschlüsse können nur durch einstimmigen Beschluss aller Geschäftsführer gefasst werden.
Die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung müssen durch den Vorsitzenden der Sitzung unterzeichnet werden.
Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, welche für die Zwecke von juristischen Verfahren oder andersweitig erstellt

werden, sind vom Vorsitzenden der Geschäftsführung oder seinem zeitweisen Vertreter in dieser Sitzung oder von zwei
Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Art. 11. Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung ist befugt,

die Richtung und Art der Geschäftsführung und der Geschäfte der Gesellschaft festzulegen.

Der Geschäftsführer bzw. der Rat der Geschäftsführung ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um sämt-

liche im Interesse der Gesellschaft stehenden Verwaltungshandlungen und -verfügungen vorzunehmen. Sämtliche Befug-
nisse,  die  nicht  kraft  Gesetzes  oder  gemäß  dieser  Satzung  ausdrücklich  der  jährlichen  Gesellschafterversammlung
zugewiesen sind, werden vom Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat der Geschäfts-
führung ausgeübt.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers verpflichtet oder, sofern

mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern der Gesellschaft,
oder durch die Unterschrift einer Person oder mehrerer Personen, auf die ein solches Zeichnungsrecht durch den Ge-
schäftsführer,  oder,  sofern  mehrere  Geschäftsführer  bestellt  sind,  durch  den  Rat  der  Geschäftsführung  oder  durch  die
gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern übertragen worden ist.

Art. 13. Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung kann

seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich des Rechts, für die Gesellschaft zu
zeichnen, sowie seine Befugnisse, Handlungen zur Förderung der Unternehmenspolitik und des Gesellschaftszwecks vor-
zunehmen, an Bevollmächtigte der Gesellschaft oder andere Personen übertragen, die wiederum berechtigt sind, Unter-
vollmachten zu erteilen, sofern sie von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat
der Geschäftsführung hierzu ermächtigt worden sind.

Art. 14. Verträge oder andere Transaktionen der Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder einem anderen Un-

ternehmen bleiben unberührt und werden nicht unwirksam, wenn einer oder mehrere der Geschäftsführer oder Bevoll-
mächtigte der Gesellschaft aufgrund persönlicher Beziehungen ein Interesse an dieser anderen Gesellschaft oder diesem
anderen Unternehmen hat oder haben oder dort Geschäftsführer oder Bevollmächtigter oder Mitarbeiter ist oder sind.

16893

L

U X E M B O U R G

Falls ein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Gesellschaft möglicherweise aus anderen Gründen als aufgrund

des Umstands, dass er Geschäftsführer, Bevollmächtigter, Mitarbeiter oder Inhaber von Wertpapieren oder sonstigen Be-
teiligungen  des  anderen  Unternehmens  ist,  ein  persönliches  Interesse  an  einem  Vertrag  oder  einer  Transaktion  der
Gesellschaft hat, wird der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, den Rat der
Geschäftsführung von diesem persönlichen Interesse in Kenntnis setzen und von einer Beteiligung an Beschlussfassungen
hinsichtlich eines solchen Vertrags oder einer solchen Transaktion absehen. Die jeweils nächste Gesellschafterversamm-
lung  ist  von  einem  solchen  Vertrag  oder  einer  solchen  Transaktion  und  dem  persönlichen  Interesse  des  betreffenden
Geschäftsführers oder Bevollmächtigten zu unterrichten.

Art. 15. Die Gesellschaft kann einen Geschäftsführer oder Bevollmächtigten, seine Erben, Testamentsvollstrecker oder

Nachlassverwalter für angemessene Kosten schadlos halten, die diesem oder diesen in Zusammenhang mit einem Anspruch,
einer Klage oder einem Verfahren entstanden sind, die möglicherweise auf der jetzigen oder früheren Tätigkeit des Be-
treffenden als Geschäftsführer oder Bevollmächtigte für die Gesellschaft oder für eine andere Gesellschaft beruhen, sofern
dies verlangt wird, deren Anteilinhaber oder Gläubiger die Gesellschaft ist, wenn der Betreffende insoweit keinen anderen
Schadloshaltungsanspruch hat; dies gilt nicht, wenn der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte wegen grober Fahrlässigkeit
oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird; wird ein Vergleich geschlossen, erfolgt die Schadloshaltung nur bezüglich sol-
cher vom Vergleich erfassten Punkte, bezüglich derer - laut Auskunft eines Rechtsberaters gegenüber der Gesellschaft -
keine Pflichtverletzung der schadlos zu haltenden Person vorliegt. Das vorstehende Recht auf Schadloshaltung schließt
andere, dem Geschäftsführer oder Bevollmächtigten möglicherweise zustehende Rechte nicht aus.

Abschnitt V. Buchhaltung, Ausschüttung von Dividenden

Art. 16. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Von dem Jahresüberschuss der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die gesetzlich vorgeschriebenen

Reserven eingestellt. Diese Zuführung von Geldern endet, sobald und solange die Reserven bei zehn Prozent (10 %) des
Kapitals der Gesellschaft gemäß Artikel 5 dieser Satzung oder dem gegebenenfalls gemäß Artikel 5 dieser Satzung herauf-
oder herabgesetzten Betrag liegen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt jährlich über die Verwendung des Jahresüberschusses; sie kann ggf. Divid-

enden festsetzen oder den Alleingeschäftsführer oder im Fall eines Rats der Geschäftsführung, diesen anweisen, dies zu
tun.

Der Rat der Geschäftsführung kann im gesetzlich vorgesehenen Rahmen einstimmig die Ausschüttung von Interimdi-

videnden beschließen.

Abschnitt VI. Auflösung, Liquidation

Art. 18. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren. Bei

den Liquidatoren kann es sich um natürliche oder juristische Personen handeln, die von der Gesellschafterversammlung
bestellt werden, die über die Auflösung entscheidet und die Befugnisse und die Vergütung der Liquidatoren bestimmt.

Abschnitt VII. Änderungen

Art. 19. Diese Satzung kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung geändert werden, wenn diese beschlussfähig

ist und die nach luxemburgischem Recht erforderlichen Mehrheiten erreicht werden.

Art. 20. Alle Fragen, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, sind gemäß dem Gesetz von 1915 zu lösen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2016.

<i>Zeichnung und Zahlung

Das Kapital der Gesellschaft wird folgendermaßen gezeichnet:
Die oben genannte Credit Suisse Holding Europe (Luxembourg) S.A. zeichnet einhundert (100) Gesellschaftsanteile

gegen eine Bareinzahlung von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-).

Der Nachweis über diese Bareinzahlung wurde gegenüber dem unterzeichneten Notar erbracht.

<i>Kosten

Die von der Gesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf tausend Euro.

<i>Gesellschafterversammlung

Als Inhaberin des gesamten gezeichneten Kapitals der Gesellschaft fasst die oben genannte Person in Ausübung der der

Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse die folgenden Beschlüsse:

(i) Die folgenden Personen werden für unbestimmte Dauer als Geschäftsführer bestellt:
- Rudolf Kömen, Verwaltungsrat, Credit Suisse Fund Management S.A., geboren am 01 Januar 1967 in Trier, Deutsch-

land, mit beruflicher Anschrift 5, rue Jean-Monnet, L-2180 Luxembourg;

16894

L

U X E M B O U R G

- Fernand Schaus, Verwaltungsrat, Credit Suisse Fund Management S.A., geboren am 26 April 1967 in Sandweiler,

Luxemburg, mit beruflicher Anschrift 5, rue JeanMonnet, L2180 Luxembourg; und

- Dominik Bollier, Managing Partner, Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG, Zurich, geboren am 24. Juli

1976, in Horgen, Schweiz, mit beruflicher Anschrift in Kalanderplatz 5, 8070 Zürich, Schweiz.

(ii) Als unabhängiger Abschlussprüfer wird bestellt für die Dauer eines Zeitraums bis zum Ende der jährlichen Gesell-

schafterversammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 berät:

“KPMG, Luxembourg”, Société Coopérative, 39 Avenue Kennedy, L1855 Luxembourg (RCS Luxemburg, Sektion B

Nummer 149 133).

(iii) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der vorstehend

genannten Person die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung;
auf Wunsch der vorstehend genannten Person ist bei Widersprüchen zwischen der englischen und der deutschen Fassung
die englische Fassung maßgeblich.

WORÜBER, die vorliegende Urkunde in Luxemburg am eingangs des vorliegenden Dokuments angegebenen Datum

aufgesetzt wurde.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden gegenüber dem erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer

mit Uns, dem amtierenden Notar, gemeinsam die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. WAGNER, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 25. November 2015. Relation: EAC/2015/27846. Erhalten fünfundsiebzig Euro

(75. EUR).

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2015194852/515.
(150218067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Dialogiques, Société Anonyme.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 59.514.

L'an deux mille quinze, le vingt novembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie

l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  “Dialogiques”,  ayant  son  siège  social  à

L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 59.514, constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg-
Eich, en date du 3 juin 1997, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 598 du 13 septembre
1997,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange,

agissant en remplacement de confrère empêché Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4
novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2930 du 9 décembre 2008

ayant un capital de trente-et-un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) actions ayant une valeur

nominale de deux cent quarante-huit euros (248,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri DA CRUZ, employé, ayant son domicile professionnel à

Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Bob PLEIN, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster,

3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster,

3, route de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Elargissement de l’objet social et modification afférente de l’article 4 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

16895

L

U X E M B O U R G

« Art. 4. La Société a pour objet:
- d’exercer des fonctions de contrôle et agir à titre de commissaire aux comptes ou de liquidateur dans d’autres sociétés

et prestataires de service pour des sociétés.

- la réalisation de toutes opérations concernant le commerce ainsi que l'exportation et l'importation de produits de toutes

sortes et la direction d'une agence commerciale.

- l'achat, la vente, la mise en valeur et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles tant au Grand-Duché de Luxembourg

qu'à l'étranger, pour son compte propre.

- l'acceptation de mandats sociaux dans d'autres sociétés établies au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger. La

Société a également pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un porte-feuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de
négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la Société
pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques,

sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société pourra encore effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières,

susceptibles de favoriser l'accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus.»

2.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L'assemblée décide d’élargir l’objet social de la Société et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts, tel que

détaille dans l’ordre du jour.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à huit cent euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Henri DA CRUZ, Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 novembre 2015. Relation GAC/2015/10357. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015194914/75.
(150218212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

GFM (CE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 101.245.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2015.

Référence de publication: 2015191918/10.
(150215305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

16896


Document Outline

Attert 2 S.à r.l.

Baltic Ventures S. à r.l.

BGL BNP Paribas

Briantea &amp; Eurasian S.A.

Bristol Ventures S.à r.l.

Credit Suisse (Lux) Energy GP S.à r.l.

CTDX S.à r.l.

Data Trust Holding S.A

Deltaline S.A.

Dialogiques

Energylux

Erre Nove S.A.

ESA plus S.à r.l.

Euphonie Invest S.A.

Fidji Luxembourg (BC)

Fidji Luxembourg (BC3) S.à r.l.

Gant International S.à r.l.

Georges &amp; Theis Architectes Associés Sàrl

GFM (CE) S.A.

Hogan S.à r.l.

Honey S.à r.l.

Hotepar S.A.

I.C.E. S.A.

I.C.E. S.A.

I.C.E. S.A.

I.C.E. S.A.

Instacom International S.A. SPF

Instacom International S.A. SPF

Instacom International S.A. SPF

Insurance, Consulting, Investment Group Luxembourg

Interleasing Luxembourg S.A.

Inter Metals S.A.

International Safety Hard Alloy Corporation

International University of Health, Exercise &amp; Sports S.A.

Intrepid Aviation Luxembourg Borrower II S.à r.l.

Investa S.à r.l.

I.T. &amp; Management Associates S.A.

Jessan Participations S.à r.l.

Jetamo S.à r.l.

KC Esther S.à r.l.

Le Chat Potte s.à r.l.

Le Chat Potte s.à r.l.

Majestic Ventures S.à r.l.

Mandarin Capital Partners II S.C.A. SICAR

Mersey Ventures S.à r.l.

Olympic Ventures S. à r.l.

Osprey Ventures S.à r.l.

Sarasino Soparfi S.A.

Swiss Alpha, SICAV