This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 236
29 janvier 2016
SOMMAIRE
Argano Overseas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11295
Entreprise de Toiture J. Zender & Cie s.àr.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11323
Entreprise de Toiture J. Zender & Cie s.àr.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11326
Feedo A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11327
Fercol S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11321
Firth Improvement S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
11328
Immo Centre Promotion S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
11299
Immo-Wallux S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11303
Logamo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11299
Medical Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11328
MH Concept S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11328
Oregonian Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11320
OUTLET.lu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11319
Paramedicus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11321
Pasarela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11322
Patricia International S.A., SPF . . . . . . . . . . . .
11321
Patrizia Real Estate 32 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
11322
PATRIZIA Wohnmodul I Zwischenholding
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11322
PBA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11322
PHARMA/wHEALTH Management Compa-
ny S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11323
Phisolina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11323
P.H.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11320
Pixys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11323
Pratzen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11313
Praxair Holding Latinoamérica . . . . . . . . . . . .
11320
Pro-Mère S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11324
Quod Bonum S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11324
RDC Holdings Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .
11328
Realkapital Partners Luxembourg S.A. . . . . .
11324
Repco 18 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11325
Rowan California S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11325
Rowan Finanz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11325
Rowan Holdings Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
11326
Rowan Offshore Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
11326
Rowan Relentless Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
11326
Rowan Reliance Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
11327
Rowan Renaissance Luxembourg S.à r.l. . . . .
11327
Rowan Resolute Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
11327
RP Residential Assembly S.à r.l. . . . . . . . . . . .
11304
Selmar Investments, S.à r.l., SPF . . . . . . . . . . .
11304
Skol Development Africa S.A. . . . . . . . . . . . . .
11313
The Independent UCITS Platform (Luxem-
bourg) II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11282
TOCQUEVILLE FINANCE S.A., société de
gestion de patrimoine familial, SPF . . . . . . . .
11324
United Depositary Services S.A. . . . . . . . . . . . .
11314
11281
L
U X E M B O U R G
The Independent UCITS Platform (Luxembourg) II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 203.107.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of the month of January;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
There appeared:
Prodigy Capital Partners LLP, with registered office at 17-20 Ironmonger Lane, London, EC2V 8EP,
here represented by Julien DEMELIER-MOERENHOUT, lawyer, residing professionally in Luxembourg, (the “Proxy-
holder”), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne varietur” by the Proxy-
holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, represented as stated before, has requested the notary to state as follows the articles of incorporation
of a public limited company (société anonyme):
Art. 1. Denomination.
1.1 There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued,
a company in the form of a société anonyme qualifying as société d’investissement à capital variable under the name of
“The Independent UCITS Platform (Luxembourg) II” (hereinafter the “Company”).
Art. 2. Duration.
2.1 The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 3. Object.
3.1 The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities, money market
instruments and other permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the
results of the management of its portfolio.
3.2 The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by Part I of the law of 17 December 2010 on undertakings for
collective investment, as amended (the “Law of 2010”).
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, in the Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 The registered office of the Company may be transferred within the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of
the board of directors of the Company (the “Board of Directors”). For the purpose of transferring the registered office of
the Company within the Grand Duchy of Luxembourg, the Board of Directors is empowered and instructed to take any
requisite action, including amending these Articles of Incorporation, it being understood that, for the avoidance of doubt,
no resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles will be required.
4.3 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board
of Directors.
4.4 In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political or military events have occurred or
are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until
the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality
of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.
Art. 5. Capital - Shares - Classes and Sub-Funds.
5.1 The capital of the Company shall be represented by shares of no par value (the “Shares” and each a “Share”) and
shall at any time be equal to the total net assets of the Company as defined in Article 22 hereof.
5.2 The initial share capital of the Company amounts to thirty one thousand euro (EUR 31,000) divided into 310 fully
paid Shares of no par value.
5.3 The minimum capital of the Company shall be the minimum prescribed by Luxembourg law.
5.4 The Board of Directors is authorised without limitation to issue fully paid Shares at any time in accordance with
Article 6 at a price based on the Net Asset Value (as defined in Article 22) per Share without reserving to the existing
shareholders a preferential right to subscription of the Shares to be issued.
5.5 The Board of Directors may delegate to any of its members (collectively, the “Directors” and each individually, a
“Director”) or to any officer of the Company or to any duly authorised person, the duty to accept subscriptions and receive
payment for such new Shares and to deliver these, remaining always within the provisions of the Law of 2010.
11282
L
U X E M B O U R G
5.6 The capital of the Company, which has an umbrella structure as provided for in article 181 of the Law of 2010, may,
as the Board of Directors shall determine, be divided into different portfolios of securities and other assets permitted by
law with specific investment objectives and various risk or other characteristics (the “Sub-Funds” and each a “Sub-Fund”).
The Sub-Funds may be denominated in different currencies as the Board of Directors shall determine. With regard to third
parties, there is no cross liability between Sub-Funds and each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities
reasonably attributable to it. The assets of a specific Sub-Fund are exclusively available to satisfy the rights of creditors
whose claims have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of that Sub-Fund.
5.7 Within each Sub-Fund, the Board of Directors may decide to issue different classes of Shares (the “Classes” and
each a “Class”) which may differ, inter alia, with respect to their charging structure, dividend policies, hedging policies,
investment minima, currency of denomination or other specific features, as the Board of Directors may decide to issue.
The Board of Directors may decide if and from what date Shares of any such Classes shall be offered for sale, those Shares
to be issued on the terms and conditions as shall be decided by the Board of Directors. Where the context so requires,
references in these Articles of Incorporation to “Sub-Fund(s)” shall be references to “Class(es)”.
5.8 For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if not
denominated in Euro, be converted into Euro and the capital shall be the aggregate of the net assets of all the Sub-Funds.
The Company shall prepare consolidated accounts in Euro.
Art. 6. Issue of Shares.
6.1 The Company will issue Shares in registered form only. The Company shall issue statements of account to certify
holdings of shareholders, which shall constitute extracts of the register of shareholders (the “Register”).
6.2 Unless otherwise provided for in the prospectus of the Company as the same may be amended from time to time
(the “Prospectus”), Shares may be issued only upon acceptance of the subscription and after receipt of the purchase price.
The subscriber will, without undue delay, receive title to the Shares purchased by him and upon application obtain delivery
of a confirmation of his shareholding.
6.3 Payments of dividends will be made by bank transfer or by check to shareholders, in respect of registered Shares,
at their address in the Register or to designated signature.
6.4 A dividend declared but not paid on a Share for five years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share,
shall be forfeited by the holder of such Share, and shall revert to the Company. All issued Shares of the Company shall be
inscribed in the Register, which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefor by the Company
and such Register shall contain the name of each holder of registered Shares, his residence or elected domicile and the
number of Shares held by him. Every transfer of a registered Share shall be entered in the Register.
6.5 Transfer of registered Shares shall be effected by written declaration of transfer to be inscribed in the Register, dated
and signed by the transferor and if so requested by the Company, at its discretion, also signed by the transferee, or by
persons holding suitable powers of attorney to act therefor.
6.6 Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements
from the Company may be sent. Such address will also be entered in the Register.
6.7 In the event that a shareholder identified in paragraph 6.6 does not provide such an address, the Company may permit
a notice to that effect to be entered in the Register and the shareholder’s address will be deemed to be at the registered
office of the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address
shall be provided to the Company by such shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered
in the Register by means of a written notification to the Company at the Company’s registered office, or at such other
address as may be set by the Company from time to time.
6.8 If payment made by any subscriber results in the issue of a Share fraction, the person entitled to such fraction shall
not be entitled to vote but shall, to the extent the Company shall determine, in its sole discretion, as to the calculation of
fractions, be entitled to dividends or other distributions on a pro rata basis.
6.9 The Company will recognise only one holder in respect of a Share in the Company unless otherwise determined by
the Board of Directors and disclosed in the Prospectus. In the event of joint ownership or bare ownership and usufruct, the
Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant Share or Shares until one person shall have
been designated to represent the joint owners or bare owners and usufructaries vis-à-vis the Company.
6.10 In the case of joint shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or
other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint
holders, or to all joint shareholders together, at its absolute discretion.
Art. 7. Lost and Damaged Certificates.
7.1 If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his Share certificate has been mislaid or
destroyed, then, at his request, a duplicate Share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including
a bond delivered by an insurance company but without restriction thereto, as the Company may determine. At the issuance
of the new Share certificate, which shall indicate that it is a duplicate, the original Share certificate replaced by the duplicate
certificate shall become void.
11283
L
U X E M B O U R G
7.2 Mutilated Share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company. The mutilated certificates
shall be delivered to the Company and shall be annulled immediately.
7.3 The Company may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate Share certificate and all
reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in connection
with the annulment of the original Share certificate(s).
Art. 8. Restrictions on Shareholding.
8.1 The Board of Directors shall have power to impose or relax such restrictions on any Shares or Sub-Fund, but not
necessarily on all Shares within the same Sub-Fund, as it may think necessary for the purpose of ensuring that no Shares
in the Company or no Shares of any Sub-Fund in the Company are acquired or held by or on behalf of:
(A) any person in breach of the law or requirements of any country or governmental or regulatory authority, if the Board
of Directors determines that any Director, the Company, any manager of the Company’s assets, any of the Company’s
investment managers or advisers or any Connected Person (as defined in Article 16) would suffer any disadvantage as a
result of such breach;
(B) any person in circumstances which in the opinion of the Board of Directors might result in the Company or its
shareholders incurring any liability to taxation or suffering any other pecuniary disadvantage which they might not other-
wise have incurred or suffered, including a requirement to register under any securities or investment or similar laws or
requirements of any country or authority, or market timing and/or late trading practices.
8.2 Without limiting the generality of the foregoing, the Company may restrict or prevent the ownership of Shares in
the Company by any person, firm or corporate body, and, without limitation, by any U.S. Person (as defined in the Pros-
pectus).
8.3 In order to restrict or prevent the ownership of Shares pursuant to the authority granted in paragraph 8.2, the Company
may:
(A) decline to issue any Share where it appears to it that such registration would or might result in such Share being
directly or beneficially owned by a person who is precluded from holding Shares in the Company (a “Precluded Person”);
(B) at any time require any person whose name is entered in the Register to furnish it with any information, supported
by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such
shareholder’s Shares rests in a Precluded Person; and
(C) where it appears to the Company that any person who is a Precluded Person, either alone or in conjunction with any
other person is a beneficial or registered owner of Shares, the Company may compulsorily redeem from any such share-
holder all Shares held by such shareholder in the following manner:
(i) the Company shall serve a notice (hereinafter called the “Redemption Notice”) upon the shareholder bearing such
Shares or appearing in the Register as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares to be redeemed as
aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the Redemption Price (as hereafter defined) in respect
of such Shares is payable. Any such Redemption Notice may be served upon such shareholder by posting the same in a
prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the
Company. Upon posting of such Redemption Notice, the said shareholder shall be obliged to deliver to the Company the
Share certificate or certificates (if issued) representing the Shares specified in the Redemption Notice. Immediately after
the close of business on the date specified in the Redemption Notice, such shareholder shall cease to be a shareholder and
the Shares previously held by him shall be cancelled;
(ii) the price at which the Shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed (the “Redemption Price”) shall
be an amount equal to the Net Asset Value of Shares of the relevant Sub-Fund and Classes, determined in accordance with
Article 22, less any redemption charge payable in respect thereof;
(iii) payment of the Redemption Price will be made to the shareholder appearing as the owner thereof in the currency
of denomination of the relevant Sub-Fund or Class and will be deposited by the Company in Luxembourg or elsewhere (as
specified in the Redemption Notice) for payment to such person, but if a Share certificate shall have been issued, then only
upon surrender of the Share certificate or certificates representing the Shares specified in such notice. The Redemption
Price which may not be distributed to the shareholders upon the implementation of the redemption will be deposited with
the Custodian (as defined in Article 26 hereof) for a period of six months and after such period, the Redemption Price will
be deposited in escrow with the Caisse de Consignation on behalf of the shareholders entitled thereto. Upon deposit of such
price as aforesaid no person interested in the Shares specified in such Redemption Notice shall have any further interest in
such Shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the
shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest);
(iv) the exercise by the Company of the powers conferred by this Article 8 shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Redemption Notice; provided, that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith; and
(v) the Company declines to accept the vote of any Precluded Person at any general meeting of shareholders of the
Company.
11284
L
U X E M B O U R G
8.4 In addition to the foregoing, the Board of Directors may restrict the issue and transfer of Shares of a Sub-Fund to
institutional investors within the meaning of articles 174, 175 and 176 of the Law of 2010 (“Institutional Investor(s)”). The
Board of Directors may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for Shares of a Sub-Fund
reserved for Institutional Investors until such time as the Company has received sufficient evidence that the applicant
qualifies as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of Shares of a Sub-Fund reserved for Institutional
Investors is not an Institutional Investor, the Board of Directors will switch the relevant Shares into Shares of a Sub-Fund
which is not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a Sub-Fund with similar characteristics) or
compulsorily redeem the relevant Shares in accordance with the provisions set forth above in this Article 8. The Board of
Directors will refuse to give effect to any transfer of Shares and consequently refuse to enter any transfer of Shares into
the Register in circumstances where such transfer would result in a situation where Shares of a Sub-Fund restricted to
Institutional Investors would, upon such transfer, be held by a person not qualifying as an Institutional Investor. In addition
to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Institutional Investor, and who holds
Shares in a Sub-Fund restricted to Institutional Investors, shall hold harmless and indemnify the Company, the Board of
Directors, the other shareholders of the relevant Sub-Fund and the Company’s agents for any damages, losses and expenses
resulting from or connected to such holding circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or
untrue documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Institutional
Investor or has failed to notify the Company of its loss of such status.
8.5 The Company may further cause Shares to be redeemed if such Shares are held by/or for the account and/or on behalf
of (i) a person that does not provide the necessary information requested by the Company in order to comply with legal
and regulatory rules such as but not limited to the FATCA provisions or (ii) a person who is deemed to cause potential
financial risk for the Company.
Art. 9. Powers of the General Meeting of Shareholders.
9.1 Any regularly constituted general meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of
shareholders of the Company. Resolutions passed at such general meeting(s) shall be binding upon all shareholders of the
Company regardless of the Sub-Fund and Classes of Shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry
out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 10. General Meetings.
10.1 The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at
the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the notice of meeting, at 2.00 p.m. Luxembourg time on the third Thursday of the month of April or, if such day is not
a bank business day in Luxembourg, on the next bank business day in Luxembourg thereafter. The annual general meeting
may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.
10.2 If permitted by and on the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of
shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph, that date, time or
place to be decided by the Board of Directors.
10.3 Other general meetings of shareholders or Sub-Fund or Class meetings may be held at such place and time as may
be specified in the respective notices of meeting. Sub-Fund or Class meetings may be held to decide on any matters which
relate exclusively to such Sub-Fund or Class. Two or more Sub-Funds or Classes may be treated as one single Sub-Fund
or Class if such Sub-Funds or Classes, as applicable, are affected in the same way by the proposals requiring the approval
of shareholders of the relevant Sub-Funds or Classes.
Art. 11. Notices, Quorum and Votes.
11.1 The quorum and notice periods required by law shall govern meetings of shareholders of the Company in all
respects, including, without limitation, the procedures for convening and conducting such meetings, unless otherwise
provided herein.
11.2 Each Share of a Sub-Fund, regardless of the Net Asset Value per Share within its Class, is entitled to one vote
subject to the restrictions contained in these Articles of Incorporation. A shareholder may act at any meeting of shareholders
by appointing another person as his proxy in writing, by fax or by email. Such proxy shall be deemed valid, provided that
it is not revoked, for any reconvened shareholders’ meeting.
11.3 Shareholders may also vote by means of a dated and duly completed form which must include the information as
set out herein. The Board of Directors may in its absolute discretion indicate in the convening notice that the form must
include information in addition to the following information: the name of the Company; the name of the shareholder as it
appears in the Register; the place, date and time of the meeting; the agenda of the meeting; and an indication as to how the
shareholder has voted.
11.4 In order for the votes expressed by such form to be taken into consideration for the determination of the quorum,
the form must be received by the Company or its appointed agent at least three (3) Business Days before the meeting or
any other period as may be indicated in the convening notice by the Board of Directors.
11.5 If so decided by the Board of Directors at its discretion and disclosed in the convening notice for the relevant
meeting, shareholders may take part in a meeting by way of videoconference or by any other means of telecommunication
11285
L
U X E M B O U R G
which allow them to be properly identified and in such case will be considered as present for the quorum and majority
determination.
11.6 Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly
convened will be passed by a simple majority of those present and voting.
11.7 The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
Art. 12. The Board of Directors.
12.1 Directors are nominated out of a list of candidates proposed by Prodigy Capital Partners LLP and, as the case may
be, a list of candidates proposed by the shareholder(s) of the Company.
12.2 The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members, provided that
at least two (2) directors and not less than half of all directors (including the chairman) are selected out of the list of
candidates proposed by Prodigy Capital Partners LLP. The remaining directors, if any, are selected out of the list of
candidates proposed by the Shareholders. Members of the Board of Directors need not be shareholders of the Company.
12.3 If the shareholders of the Company do not propose a sufficient number of candidates on their list or do not propose
any candidate, the remaining offices or, as the case may be, all offices will be filled-in by candidates proposed by Prodigy
Capital Partners LLP.
12.4 In the event of a vacancy in the office of a candidate proposed by Prodigy Capital Partners LLP, the Board of
Directors may temporarily fill the office by a director selected out of the list of candidates proposed by Prodigy Capital
Partners LLP. If no candidate is available on this list, Prodigy Capital Partners LLP must propose a new list of candidates
to the Board of Directors within a reasonable period of time indicated by the Board of Directors.
12.5 In the event of a vacancy in the office of a candidate proposed by the shareholders of the Company, the Board of
Directors may temporarily fill the office by a director selected out of the list of candidates proposed by the shareholders
of the Company. If no candidate is available on this list, the shareholders of the Company must propose a new list of
candidates to the Board of Directors within a reasonable period of time indicated by the Board of Directors. If the share-
holders of the Company do not submit a list of candidates within a reasonable period of time indicated by the Board of
Directors, the Board of Directors is entitled to temporarily fill the office by a candidate proposed by Prodigy Capital Partners
LLP.
12.6 The Directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period which may not exceed
6 (six) years and until their successors are elected and qualify; provided, however, that a Director may be removed with or
without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
12.7 In the event of a vacancy in the office of a Director appointed by a meeting of shareholders because of death,
retirement or otherwise, the remaining Directors so appointed may meet and may elect, by majority vote, a Director to fill
such vacancy on a provisional basis until the next meeting of shareholders which shall make the final appointment.
Art. 13. Proceedings of the Board of Directors.
13.1 The Board of Directors shall choose from among its members a chairman and may choose from among its members
one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors shall meet upon
request by the chairman or any two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.
13.2 The chairman shall preside at all meetings of shareholders and at the Board of Directors. In his absence, the
shareholders or the Board of Directors shall appoint any person as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
13.3 Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four (24)
hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of
circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing, by fax or
by email of each Director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
13.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or by email another
Director as his proxy. Directors may also cast their vote in writing, by fax or by email.
13.5 Meetings of the Board of Directors may be held by way of conference call, video conference or by any similar
means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
13.6 Any meeting held by means of communication described in paragraph 13.5 shall be deemed to have taken place
at the registered office of the Company.
13.7 The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the
Company by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.
13.8 The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least two Directors are present at a meeting of the
Board of Directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such
11286
L
U X E M B O U R G
meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman or,
in his absence, the chairman pro tempore shall have a deciding vote.
13.9 Resolutions of the Board of Directors may also be passed in the form of a circular resolution in identical terms
which may be signed on one or more counterparts by all the Directors.
13.10 The Board of Directors from time to time may appoint the officers of the Company, including a general manager,
a secretary, and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation
and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of Directors. Officers
need not be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles
of Incorporation, shall have the powers and duties given them by the Board of Directors.
13.11 The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company
and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities
which need not be members of the Board of Directors. The Board of Directors may also delegate any of its powers,
authorities and discretions to any committee, consisting of such person or persons (whether such person(s) is a member of
the Board of Directors or not) as the Board of Directors thinks fit.
Art. 14. Minutes of Board of Directors Meetings.
14.1 The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
chairman pro tempore who presided at such meeting.
14.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, the secretary or by any two Directors.
Art. 15. Determination of the Investment Policies.
15.1 The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate
and investment policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Company.
15.2 The Board of Directors shall also determine any restrictions which shall, from time to time, be applicable to the
investments of the Company, in accordance with part I of the Law of 2010 including, without limitation, restrictions in
respect of:
(A) the borrowings of the Company and the pledging of its assets, and
(B) the maximum percentage of assets which the Company may invest in any form or class of security and the maximum
percentage of any form or class of security which it may acquire.
15.3 The Board of Directors may decide that investments of the Company be made:
(A) in transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by
the Law of 2010;
(B) in transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a member state of the European
Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public;
(C) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in any other
country in Europe, Asia, Oceania (including Australia), the American continents and Africa, or dealt in on another market
in the countries referred to above; provided, that such market is regulated, operates regularly and is recognised and open
to the public;
(D) in recently issued transferable securities, and money market instruments; provided, that the terms of the issue provide
that application be made for admission to official listing in any of the stock exchanges or other regulated markets referred
to above and provided that such admission is secured within one year of issue; and
(E) in any other transferable securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the
Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the sales documents of the Company.
15.4 The Board of Directors of the Company may decide to invest up to one hundred percent (100%) of the net assets
of each Class and/or Sub-Fund of the Company in different transferable securities and money market instruments issued
or guaranteed by any member state of the European Union; its local authorities; a non-member state of the European Union,
as acceptable by the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the Prospectus; public international bodies of
which one or more of such member states are members; or by any other member state of the Organisation for Economic
Cooperation and Development, provided, that in the case where the Company decides to make use of this provision it must
hold, on behalf of the Class and/or Sub-Fund concerned, securities from at least six different issues and securities from any
one issue may not account for more than thirty percent (30%) of the total net assets of such Class.
15.5 The Board of Directors may decide that investments of the Company be made in financial derivative instruments,
including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the Law of 2010 and/or
financial derivative instruments dealt in over-the-counter markets; provided, that, among others, the underlying instrument
consists of instruments covered by Article 41 (1) of the Law of 2010, financial indices, interest rates, foreign exchange
rates or currencies, in which the Company may invest according to its investment objectives as disclosed in the sales
documents of the Company.
15.6 The Board of Directors may decide that investments of a Sub-Fund of the Company be made so as to replicate
stock indices and/or debt securities indices to the extent permitted by the Law of 2010 provided that the relevant index is
11287
L
U X E M B O U R G
recognised as having a sufficiently diversified composition, is an adequate benchmark and is published in any appropriate
manner.
15.7 The Company may invest up 10% of the net assets of any Sub-Fund in undertakings for collective investment as
defined in article 41 (1) (e) of the Law of 2010.
15.8 The Board of Directors may invest and manage all or any part of the assets of two or more Classes or Sub-Funds
on a pooled basis, where it is appropriate with regard to their respective investment sectors to do so.
15.9 When investments of the Company are made in the capital of subsidiary companies which, exclusively on the
Company’s behalf carry on only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is
located, with regard to the redemption of Shares at the request of shareholders, paragraphs (1) and (2) of Article 48 of the
Law of 2010 do not apply.
15.10 The Board of Directors can decide that a Sub-Fund may subscribe, acquire and/or hold Shares to be issued or
issued by one or more other Sub-Funds without the Company being subject to the requirements of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended, with respect to the subscription, acquisition and/or the holding of its own
Shares, under the conditions set out under article 181 (8) of the Law of 2010.
Art. 16. Director’s Interest.
16.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-
dated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate
officer or employee of such other company or firm (a “Connected Person”). Any Director or officer of the Company who
serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such an affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business, subject to paragraphs 16.2 and 16.3,
below.
16.2 In the event that any Director or officer of the Company has a personal interest in any transaction of the Company,
such Director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest, shall not consider or vote on
any such transactions, and such Director’s or officer’s interest shall be reported to the next succeeding meeting of share-
holders.
16.3 The term “personal interest”, as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest
in any matter, position or transaction involving Prodigy Capital Partners LLP or any affiliate thereof or such other corpo-
ration or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors on their discretion unless such “personal
interest” is considered to be a conflicting interest by applicable laws and regulations.
Art. 17. Indemnity.
17.1 Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been a Director or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding in which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such Director or officer and against amounts paid or
incurred by him in the settlement thereof.
17.2 The words “claim”, “actions”, “suit”, or “proceeding”, shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil,
criminal or other including appeals), actual or threatened, and the words “liability” and “expenses” shall include, without
limitation, attorney’s fees, costs, judgments, amounts paid in settlement, fines, penalties and other liabilities.
17.3 No indemnification shall be provided hereunder to a Director or officer:
(A) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, negligence or
reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(B) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated not to have acted in good faith and in
the reasonable belief that his action was in the best interests of the Company; or
(C) in the event of a settlement, unless there has been a determination that such Director or officer did not engage in
wilful misfeasance, bad faith, negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office:
(i) by a court or other body approving the settlement; or
(ii) by vote of two thirds (2/3) of those members of the Board of Directors of the Company constituting at least a majority
of such Board of Directors who are not themselves involved in the claim, action, suit or proceeding; or
(iii) by written opinion of independent counsel.
17.4 The right of indemnification provided by this Article 17 may be insured against by policies maintained by the
Company, shall be severable, shall not affect any other rights to which any Director or officer may now or hereafter be
entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such Director or officer and shall inure to the benefit of the
heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to
which corporate personnel other than Directors and officers may be entitled by contract or otherwise under law.
17.5 Expenses in connection with the preparation and presentation of a defense to any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this Article 17 may be advanced by the Company, prior to final disposition thereof upon receipt
11288
L
U X E M B O U R G
of any undertaking by or on behalf of the officer or Director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is
not entitled to indemnification under this Article.
Art. 18. Administration.
18.1 The Company will be bound by the joint signature of any two Directors to whom authority has been delegated by
the Board of Directors or by the joint or single signature of any Director or officer to whom authority has been delegated
by the Board of Directors.
18.2 All powers not expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders
are in the competence of the Board of Directors.
Art. 19. Auditor.
19.1 The Company shall appoint an independent auditor who shall carry out the duties prescribed by the Law of 2010.
The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders and serve until its successor shall
have been elected.
Art. 20. Redemption and Switching of Shares.
20.1 Without limiting the provisions provided in this Article 20, the Company has the power to redeem its own Shares
at any time within the sole limitations set forth by law.
20.2 Any shareholder may request the redemption of all or part of his Shares by the Company; provided, that:
(A) in the case of a request for redemption of part of his Shares, the Company may redeem all of the remaining Shares
held by such Shareholder, if compliance with such redemption request would result in the aggregate Net Asset Value of
the outstanding Shares of any one Sub-Fund being less than such amount or number of Shares as determined by the Board
of Directors and disclosed in the Prospectus from time to time; and
(B) the Company may limit the total number of Shares of any Sub-Fund which may be redeemed on a dealing day to a
number representing a percentage (as set out in the Prospectus) of the net assets or number of Shares of a same Sub-Fund
or a percentage (as set out in the Prospectus) of the net assets or number of Shares of a Class.
20.3 If redemption is deferred pursuant to paragraph 20.2, the relevant Shares shall be redeemed at the Share price based
on the Net Asset Value per Share prevailing at the date on which the redemption is effected, less any redemption charge
in respect thereof.
20.4 The redemption price shall be paid normally, within a period as determined by the Board of Directors and disclosed
in the Prospectus and shall be based on the Share price for the relevant Class of the relevant Sub-Fund as determined in
accordance with the provisions of Article 22 hereof, less any redemption charge in respect thereof. If in exceptional cir-
cumstances the liquidity of the portfolio of assets maintained in respect of the Shares being redeemed is not sufficient to
enable the payment to be made within such a period, such payment shall be made as soon as reasonably practicable thereafter
but without interest.
20.5 Any such request must be filed or confirmed by such shareholder in written form at the registered office of the
Company in Luxembourg or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of
Shares. The certificate or certificates for such Shares in proper form and accompanied by proper evidence of transfer or
assignment must be received by the Company or its agent appointed for that purpose before the redemption price may be
paid.
20.6 The Company shall have the right, if the Board of Directors so determines, to satisfy payment of the redemption
price to any shareholder requesting redemption of any of his Shares (but subject to the consent of the shareholder) in specie
by allocating to the holder investments from the portfolio of the relevant Sub-Fund equal in value (calculated in the manner
described in Article 22 hereof) to the value of the holding to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred
in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders of
Shares in the relevant Sub-Fund and the valuation used shall be confirmed by a special report by the Company’s auditor.
The specific costs for such redemptions in specie will be borne by the redeeming shareholder.
20.7 Shares of the capital stock of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.
20.8 Unless otherwise determined by the Board of Directors and disclosed in the Prospectus, any shareholder may request
switching of the whole or part of his Shares of one Class of a Sub-Fund into Shares of a Class of another Sub-Fund or in
another Class of the same Sub-Fund based on a switching formula as determined from time to time by the Board of Directors
and disclosed in the Prospectus provided that the Board of Directors may impose such restrictions as to, inter alia, frequency
of switching, and may make switching subject to payment of such charge, as it shall determine and disclose in the current
Prospectus.
Art. 21. Valuations and Suspension of Valuations.
21.1 For the purpose of determining the issue, switching, and redemption on price thereof, the Net Asset Value of Shares
in the Company shall be determined as to the Shares of each Class of each Sub-Fund by the Company from time to time,
but in no instance less than two (2) times per month, as the Board of Directors may direct (every such day or time for
determination of Net Asset Value being referred to herein as a “Valuation Day”).
11289
L
U X E M B O U R G
21.2 The Company may suspend the determination of the Net Asset Value of Shares of one or more Sub-Funds and/or
the issue, redemption and/or switching of Shares in the following cases:
(A) during any period when any market or stock exchange, which is the principal market or stock exchange on which
a material part of the investments of the relevant Sub-Fund for the time being are quoted, is closed, other than for legal
holidays or during which dealings are substantially restricted or suspended; provided, that such restriction or suspension
affects the valuation of the investments of the Sub-Fund attributable to such Sub-Fund;
(B) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency, in the opinion of the Board of Directors,
as a result of which disposal or valuation of investments of the relevant Sub-Fund by the Company is not possible;
(C) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any
of the relevant Sub-Fund’s investments or the current price or value on any market or stock exchange;
(D) if the Company is being (or is proposed to be) wound up or merged, from the date on which notice is given of a
general meeting of shareholders at which a resolution to wind up or merge the Company is to be proposed or if a Sub-Fund
is being liquidated or merged, from the date on which the relevant notice is given;
(E) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company attributable to a Sub-Fund cannot
promptly or accurately be ascertained (including the suspension of the calculation of the net asset value of an underlying
undertaking for collective investment);
(F) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the
redemption of Shares of a Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of
investments or payments due on redemption of Shares cannot, in the opinion of the Board of Directors, be effected at normal
rates of exchange; or
(G) any other circumstances beyond the control of the Board of Directors.
21.3 The Board of Directors may, in any of the circumstances listed above, suspend the issue, redemption and/or
switching of Shares without suspending the calculation of the Net Asset Value.
21.4 A notice of the beginning and of the end of any period of suspension pursuant to paragraph 21.2 will be published
in a Luxembourg newspaper and in any other newspaper(s) selected by the Board of Directors, if, in the opinion of the
Board of Directors, it is likely to exceed such period as determined by the Board of Directors and disclosed in the Prospectus.
Shareholders will be promptly informed by mail of any such suspension and of the termination thereof.
21.5 Notice will likewise be given to any applicant or shareholder, as applicable, applying for purchase, redemption, or
switching of Shares in the Sub-Fund(s) concerned. Such shareholders may give notice that they wish to withdraw their
application for subscription, redemption and switching of Shares. If no such notice is received by the Company such
application for redemption or switching as well as any application for subscription will be dealt with on the first Valuation
Day following the end of the period of suspension.
21.6 The suspension of the Net Asset Value calculation of a Sub-Fund shall have no effect on the calculation of the Net
Asset Value, the issue, sale, redemption and switching of Shares of any other Sub-Fund for which the Net Asset Value
calculation is not suspended.
Art. 22. Determination of Net Asset Value.
22.1 The net asset value (the “Net Asset Value”) of Shares of each Sub-Fund shall be expressed as a per Share figure
in the currency of the relevant Sub-Fund as determined by the Board of Directors and shall be determined in respect of any
Valuation Day by dividing the net assets of the Company corresponding to each Sub-Fund, being the value of the assets
of the Company corresponding to such Sub-Fund less any liabilities attributable to such Sub-Fund at such time or times as
the Directors may determine at the place where the Net Asset Value is calculated, by the number of Shares of the relevant
Sub-Fund then outstanding adjusted to reflect any dealing charges, dilution levies or fiscal charges which the Board of
Directors feels it is appropriate to take into account in respect of that Sub-Fund and by rounding the resulting sum as
provided in the sales documents of the Company.
22.2 The Net Asset Value of the Company is expressed in Euro.
(A) The assets of the Company shall be deemed to include:
(i) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
(ii) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
(iii) all bonds, time notes, shares, stock, debenture stocks, units/shares in undertakings for collective investment, sub-
scription rights, warrants, options and other investments and securities owned or contracted for by the Company;
(iv) all stock, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company (provided that the
Company may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-divi-
dends, ex-rights or similar practices);
(v) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Company except to the extent that the same is
included or reflected in the principal amount of such security;
(vi) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off; and
(vii) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
(B) The value of the assets of the Company shall be determined as follows:
11290
L
U X E M B O U R G
(i) the value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash
dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof,
unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be arrived at after
making such discount as the Directors may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;
(ii) the value of securities and/or financial derivative instruments which are quoted or dealt in on any stock exchange
shall be based, except as defined in (iii) below, in respect of each security on the latest available dealing prices or the latest
available mid-market quotation (being the mid point between the latest quoted bid and offer prices) on the stock exchange
which is normally the principal market for such security;
(iii) where investments of the Company are both listed on a stock exchange and dealt in by market-makers outside the
stock exchange on which the investments are listed then the Board of Directors will determine the principal market for the
investments in question and they will be valued at the latest available price in that market;
(iv) securities dealt in on another regulated market are valued in a manner as near as possible to that described in paragraph
(ii);
(v) in the event that any of the securities held in the Company’s portfolio on the Valuation Day are not quoted or dealt
in on a stock exchange or another regulated market, or for which no price quotation is available, or if the price as determined
pursuant to sub-paragraphs (ii) and/or (iv) is not in the opinion of the Board of Directors representative of the fair market
value of the relevant securities, the value of such securities shall be determined prudently and in good faith, based on the
reasonably foreseeable sales or any other appropriate valuation principles;
(vi) the financial derivative instruments which are not listed on any official stock exchange or traded on any other
organised market will be valued in a reliable and verifiable manner on a daily basis and verified by a competent professional
appointed by the Board of Directors;
(vii) units or shares in underlying open-ended investment funds shall be valued at their last available net asset value
reduced by any applicable charges;
(viii) liquid assets and money market instruments are valued at their market price, at their nominal value plus accrued
interest or on an amortised cost basis in accordance with the European Securities and Markets Authority’s guidelines on a
common definition of European money market funds. If the Company considers that an amortization method can be used
to assess the value of a money market instrument, it will ensure that this will not result in a material discrepancy between
the value of the money market instrument and the value calculated according to the amortization method;
(ix) in the event that the above mentioned calculation methods are inappropriate or misleading, the Board of Directors
may adjust the value of any investment or permit some other method of valuation to be used for the assets of the Company
if it considers that the circumstances justify that such adjustment or other method of valuation should be adopted to reflect
more fairly the value of such investments.
22.3 The Board of Directors may, in its absolute discretion, use different valuation methods than those set out above.
In any case, the valuation methods will be disclosed in the Prospectus.
22.4 The liabilities of the Company shall be deemed to include:
(A) all loans, bills and accounts payable;
(B) all accrued or payable administrative expenses (including but not limited to investment advisory fee, performance
or management fee, custody fees and corporate agents’ fees);
(C) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company where the Valuation Day falls on the
record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;
(D) an appropriate provision for future taxes based on capital and income on the Valuation Day, as determined from
time to time by the Company, and other provisions if any authorized and approved by the Board of Directors covering
among others liquidation expenses; and
(E) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by Shares in the
Company. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the
Company comprising formation expenses, the remuneration and expenses of its Directors, conducting persons and officers,
including their insurance cover, fees payable to its investment advisers or investment managers, fees and expenses payable
to its service providers and officers, accountants, custodian and its correspondents, domiciliary, registrar and transfer agents,
any paying agent and permanent representatives in places of registration, any other agent employed by the Company, fees
and expenses incurred in connection with the listing of the Shares of the Company at any stock exchange or to obtain a
quotation or another regulated market, fees and expenses in respect of premises and information technology costs for the
Conducting Persons, fees for legal and tax advisers in Luxembourg and abroad, fees for auditing services, printing, reporting
and publishing expenses, including the cost of preparing, translating, distributing and printing of the prospectuses, notices,
rating agencies, explanatory memoranda, registration statements, or of interim and annual reports taxes or governmental
charges, shareholders servicing fees and distribution fees payable to distributors of Shares in the Company, currency
conversion costs, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges
and brokerage, postage, telephone and telex. The Company may calculate administrative and other expenses of a regular
11291
L
U X E M B O U R G
or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal
proportions over any such period.
22.5 The Board of Directors shall establish a portfolio of assets for each Sub-Fund, and if applicable, for each Class in
the following manner:
(A) the proceeds from the allotment and issue of each Sub-Fund or Class shall be applied in the books of the Company
to the portfolio of assets established for that Sub-Fund or Class, and the assets and liabilities and income and expenditure
attributable thereto shall be applied to such portfolio subject to the provisions of this Article;
(B) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same portfolio as the assets from which it was derived and on each re-evaluation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant portfolio;
(C) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Class or Sub-Fund or to any action
taken in connection with an asset of a particular Class or Sub-Fund, such liability shall be allocated to the relevant Class
or Sub-Fund;
(D) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
Class or Sub-Fund, such asset or liability shall be allocated to all the Classes or Sub-Funds pro rata based on the Net Asset
Values of each portfolio; provided, that all liabilities attributable to a Class or Sub-Fund shall be binding on that Class or
Sub-Fund; and
(E) upon the record date for the determination of the person entitled to any dividend declared on any Class or Sub-Fund,
the Net Asset Value of such Class or Sub-Fund shall be reduced by the amount of such dividends.
22.6 For the purposes of this Article:
(A) Shares for which a subscription request has been accepted but payment has not yet been received shall be deemed
to be existing as from the close of business on the Valuation Day on which they have been allotted and the price therefor,
until received by the Company, shall be deemed a debt due to the Company;
(B) Shares to be redeemed under Article 20 hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately
after the close of business on the Valuation Day referred to in this Article, and from such time and until paid the price
therefor shall be deemed to be a liability of the Company;
(C) all investments, cash balances and other assets of the Company not expressed in the currency in which the Net Asset
Value of any Sub-Fund is denominated, shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in
force at the date and time for determination of the asset value of Shares; and
(D) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Company
on such Valuation Day, to the extent practicable.
22.7 If the Board of Directors so determines, the Net Asset Value of the Shares of each Sub-Fund may be converted at
the middle market rate into such other currencies than the currency of denomination of the relevant class, referred to above,
and in such case the issue and redemption price per Share of such Sub-Fund may also be determined in such currency based
upon the result of such conversion.
Art. 23. Issue of Shares.
23.1 Whenever the Company shall offer Shares for subscription, the price per Share at which such Shares shall be offered
and sold, shall be based on the Share price for the relevant Class of the relevant Sub-Fund plus an initial sales charge of
up to 3% of the Net Asset Value per Share. The price so determined shall be payable within a period as determined by the
Board of Directors and disclosed in the Prospectus.
23.2 The Board of Directors may elect in their absolute discretion to accept subscription payments from investors, either
in whole or in part, in specie rather than in cash. In exercising their discretion, the Board of Directors will take into account
the investment objective, investment policy and investment restrictions of the Sub-Fund and whether the proposed in specie
assets comply with those criteria. The auditor of the Company must prepare a special audit report confirming the value of
any assets contributed in specie. The subscriber will be responsible for all custody and other costs (including the cost of
the special audit report by the auditor of the Company) involved in the transfer of the relevant assets, unless the Board of
Directors otherwise agree.
Art. 24. Distributors.
24.1 The Board of Directors may permit any company or other person appointed for the purpose of distributing Shares
of the Company to charge any applicant for Shares a sales commission of such amount as such company or other person
may determine but not exceeding 5% of the amount which the relevant applicant may decide to invest in Shares and such
company may differentiate between applicants as to the amount of such sales commission (within the permitted limit).
Art. 25. Accounting Year.
25.1 The accounting year of the Company shall begin on 1 January of each year and shall terminate on 31 December of
the same year. The accounts of the Company shall be expressed in Euro or such other currency as the Board of Directors
may determine. Where there shall be different Sub-Funds as provided for in Article 5 hereof, and if the accounts within
such Sub-Funds are expressed in different currencies, such accounts shall be converted into Euro and aggregated for the
purpose of determining the accounts of the Company.
11292
L
U X E M B O U R G
Art. 26. Custodian.
26.1 The Company shall enter into a custodian agreement with an entity which shall satisfy the requirements of the Law
of 2010 (the “Custodian”). All securities, cash and other assets of the Company are to be held by or to the order of the
Custodian who shall assume, in its role as custodian to the Company and its shareholders, the responsibilities provided by
law.
Art. 27. Term, Liquidation, Merger and Division.
27.1 The Board of Directors may at any time move to dissolve the Company at an extraordinary general meeting of
shareholders.
27.2 Unless otherwise provided for in the Prospectus, each Sub-Fund will be set up for a continuous and unlimited term
of years.
27.3 If the Company’s share capital falls below two-thirds of the minimum capital required by law, the Board of Directors
must refer the matter of the dissolution to a general meeting of Shareholders, deliberating without any quorum and deciding
by a simple majority of the Shares represented at the meeting. If the Company’s share capital is less than a quarter of the
minimum capital required by law, the Board of Directors must refer the matter of dissolution of the Company to a general
meeting of Shareholders, deliberating without any quorum; the dissolution may be decided by Shareholders holding a
quarter of the Shares represented at the meeting. In the event of a dissolution of the Company, liquidation must be carried
out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders
effecting such dissolution and which shall determine the liquidator(s)’s powers and their compensation. The net proceeds
of liquidation corresponding to each Class (within each Sub-Fund) will be distributed by the liquidators to the holders of
Shares of each Class of each Sub-Fund in proportion to the number of Shares held by each the holder in such category of
such Class.
27.4 The liquidation must be completed, in principle, within a period of nine (9) months from the date of the decision
relating to the liquidation. Where the liquidation of the Company cannot be fully completed within nine (9) months, a
written request for exemption shall be submitted to the Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) de-
tailing the reasons why the liquidation cannot be completed.
27.5 As soon as it has been determined that the liquidation of the Company is complete, whether this decision is taken
before the nine (9) month period has expired or at a later date, any residual funds not claimed by shareholders prior to the
completion of the liquidation shall be deposited as soon as possible at the Caisse de Consignation.
27.6 A Sub-Fund or a Class may be terminated by resolution of the Board of Directors if (i) the Net Asset Value of a
Sub-Fund or a Class is below such amount as determined by the Board of Directors; (ii) in the event of special circumstances
beyond its control, such as political, economic, or military emergencies; or (iii) if the Board of Directors should conclude,
in light of prevailing market or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a Sub-Fund
or a Class to operate in an economically efficient manner, and with due regard to the best interests of shareholders, that a
Sub-Fund or a Class should be terminated. In such event, the assets of the Sub-Fund will be realized, the liabilities discharged
and the net proceeds of realization distributed to shareholders in proportion to their holding of Shares in that Sub-Fund or
Class against such evidence of discharge as the Board of Directors may reasonably require. Shareholders shall be notified
of any decision made pursuant to this paragraph as required. No Shares shall be redeemed after the date of the decision to
liquidate the Sub-Fund or a Class.
27.7 The liquidation of a Sub-Fund or a Class must be completed, in principle, within a period of nine (9) months from
the date of decision of the Board of Directors relating to the liquidation. Where the liquidation of a Sub-Fund or a Class
cannot be fully completed within a period of nine (9) months, a written request for exemption shall be submitted to the
CSSF detailing the reasons why the liquidation cannot be completed.
27.8 As soon as it has been determined that the liquidation of the Company is complete, whether this decision is taken
before the nine (9) month period has expired or at a later date, any residual funds not claimed by shareholders prior to the
completion of the liquidation shall be deposited as soon as possible at the Caisse de Consignation.
27.9 The Company may be merged in accordance with the provisions of the Law of 2010. In the event the Company is
involved in a merger as the surviving undertaking for collective investment in transferable securities (“UCITS”), the Board
of Directors, in its sole discretion, will decide on the merger and the effective date thereof; in the event the Company is
involved in a merger as the absorbed UCITS and thereafter ceases to exist, a general meeting of shareholders will be required
to approve and decide on the effective date of such merger by a resolution adopted with no quorum requirement and at the
simple majority of the votes validly cast at such meeting. Any applicable contingent deferred sales charges are not to be
considered as redemption charges and shall therefore be due.
27.10 The Board of Directors may resolve to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 2010) of any
Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with (i) another existing Sub-Fund within the Company or another
sub-fund within another Luxembourg or foreign UCITS; or (ii) a new Luxembourg or foreign UCITS, and as appropriate,
to re-designate the Shares of the Sub-Fund concerned as Shares of the new Sub-Fund or of the new UCITS as applicable.
Any applicable contingent deferred sales charges are not to be considered as redemption charges and shall therefore be
due.
11293
L
U X E M B O U R G
27.11 A Class may merge with one or more other Classes by resolution of the Board of Directors if the Net Asset Value
of a Class is below such amount as determined by the Board of Directors or in the event of special circumstances beyond
its control, such as political, economic, or military emergencies, or if the Board of Directors should conclude, in light of
prevailing market or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a Class to operate in an
economically efficient manner, and with due regard to the best interests of shareholders, that a Class should be merged.
Shareholders shall be notified of any decision made pursuant to this paragraph as required. Each shareholder of the
relevant Class shall be given the option, within a period to be determined by the Board of Directors (but not being less than
one (1) month, unless otherwise authorised by the regulatory authorities, and specified in said notice), to request free of
any redemption charge either the repurchase of its Shares or the exchange of its Shares against Shares of any Class not
concerned by the merger. Any applicable contingent deferred sales charges are not to be considered as redemption charges
and shall therefore be due.
27.12 A Class may be contributed to another investment fund by resolution of the Board of Directors in the event of
special circumstances beyond its control, such as political, economic, or military emergencies, or if the Board of Directors
should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability
of a Class to operate in an economically efficient manner, and with due regard to the best interests of shareholders, that a
Class should be contributed to another fund. Shareholders shall be notified of any decision made pursuant to this paragraph
as required. Each shareholder of the relevant Class shall be given the option within a period to be determined by the Board
of Directors (but not being less than one month, unless otherwise authorised by the regulatory authorities, and specified in
said notice) and specified in said notices, to request, free of any redemption charge, the repurchase of its Shares. Any
applicable contingent deferred sales charges are not to be considered as redemption charges and shall therefore be due.
Where the holding of units in another undertaking for collective investment does not confer voting rights, the contribution
will be binding only on shareholders of the relevant Class who expressly agree to the contribution.
27.13 If the Board of Directors determines that it is in the interests of the shareholders of the relevant Sub-Fund or Class
or that a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund or Class concerned has occurred which
would justify it, the reorganisation of one Sub-Fund or Class, by means of a division into two or more Sub-Funds or Classes,
may take place. Shareholders shall be notified of any decision made pursuant to this paragraph as required. The notification
will also contain information regarding the new Sub-Funds or Classes. The notification will be made at least one month
before the date on which the reorganization becomes effective in order to enable the shareholders to request the sale of
their Shares, free of charge, before the operation involving division into two or more Sub-Funds or Classes becomes
effective. Any applicable contingent deferred sales charges are not to be considered as redemption charges and shall
therefore be due.
Art. 28. Amendment of Articles of Incorporation.
28.1 These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the
quorum and majority requirements provided by the laws of Luxembourg. Any amendment affecting the rights of the holders
of Shares of any Class or Sub-Fund vis-à-vis those of any other Class or Sub-Fund shall be subject, to the said quorum and
majority requirements in respect of each such relevant Class or Sub-Fund.
Art. 29. General.
29.1 All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended, and the Law of 2010.
<i>Transitory provisionsi>
(1) The first accounting year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2016.
(2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2017.
<i>Subscription and paymenti>
(1) The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party
has subscribed and entirely paid up in cash the following Shares:
Shareholder
Subscribed
Capital
Number of Shares
Prodigy Capital Partners LLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000.- 310 shares in Class A2 (EUR) acc.
of The Independent UCITS Platform
(Luxembourg) II - InvestQuest
Global Bond Fund
(2) Proof of such payment in cash has been given to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.
11294
L
U X E M B O U R G
<i>Expensesi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately two thousand four hundred
Euros (EUR 2.400.-).
<i>Resolutions taken by the sole shareholderi>
The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following
resolutions as sole shareholder:
<i>First resolution:i>
The following persons are appointed Directors:
(a) Hugh Hunter, born in Jersey, UK on 12 September 1959, with professional address at Suite 3A, 17-20 Ironmonger
Lane, London EC2V 8EP, United Kingdom for a period ending on the date of the annual general meeting to be held in
2022;
(b) David Robinson, born in New York, USA on 12 February 1960, with professional address at 17-20 Suite 3A,
Ironmonger Lane, London EC2V 8EP, United Kingdom for a period ending on the date of the annual general meeting to
be held in 2022;
(c) Lorcan Murphy, born in Limerick, Ireland on 14 June 1967, with professional address at 52 Berkeley Square, London,
W1J 5BT, United Kingdom for a period ending on the date of the annual general meeting to be held in 2017.
<i>Second resolution:i>
The following party has been appointed licensed registered auditor (“réviseur d’entreprises agréé”) of the Company for
a period ending on the date of the annual general meeting to be held in 2016:
Mazars Luxembourg, a société anonyme, established and having its registered office at 10A, rue Henri M. Schnadt,
L-2530 Luxembourg, and registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number
15.9962
<i>Third resolution:i>
The registered office of the Company is fixed at 11, rue Aldringen, L- 1118 Luxembourg Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in English
with no need of further translation in accordance with article 189(2) of the Law of December 17, 2010 on undertakings for
collective investments
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with the notary the present deed.
Signé: J. DEMELIER-MOERENHOUT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 12 janvier 2016. 2LAC/2016/697. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 18 janvier 2016.
Référence de publication: 2016052565/784.
(160011066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Argano Overseas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 122.575.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of the month of December;
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary (the “Notary”) residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
undersigned;
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of ARGANO OVERSEAS S.A., a Luxembourg
public company limited by shares (société anonyme), having its registered office at 1, Place du Théâtre, L - 2613 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number
11295
L
U X E M B O U R G
B 122.575, incorporated pursuant to a deed of Maître Blanche Mourtier, notary residing in Esch-sur-Alzette, on 14 De-
cember 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 158 on 10 February 2007.
The Meeting elected as chairman, Mrs Alexia UHL, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the Meeting elected as scrutineer Mr Julien DEMELIER-MOERENHOUT,
lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The office of the Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list signed by the members of the bureau, the shareholders present and the proxies of the shareholders represented. The
said list initialled “ne varietur” by the members of the bureau will be annexed to and be registered with this deed.
II. The entire share capital being present or represented at the Meeting, no convening notices were sent, the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and received knowledge of the agenda prior to this Meeting.
III. As appears from the said attendance list, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on
the items of the agenda.
IV. The agenda of the Meeting is as follows:
1. To acknowledge and confirm compliance with (and, to the extent applicable and necessary, to waive) the formalities
of article 267 (1) a), b) and c) of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended (Luxem-
bourg documents to be made available to shareholders).
2. To waive the shareholders’ rights to receive the explanatory report on the merger from the management boards of the
Company and GUADIANA 1977 INVERSIONES Y ESTUDIOS, S.L..
3. To waive the requirements for an examination of, and a report on, the Common Merger Project dated 16 October
2013 by independent experts.
4. To examine the Common Merger Project dated 16 October 2013, acknowledge its filing and publication in Luxem-
bourg and in Spain and approve the merger and its effective date for accounting purposes.
5. To approve the effects of the merger generally and specifically on ARGANO OVERSEAS S.A. and to delegate to
the board of directors of GUADIANA 1977 INVERSIONES Y ESTUDIOS, S.L. the power to take the necessary actions
to give effect to the merger and other related actions.
6. To attend to any other necessary actions in order to ensure that the merger is completed effectively.
7. Miscellaneous.
The Shareholders, acting in their capacity of shareholders of the Company, hereby unanimously pass the following
resolutions before the undersigned Notary:
<i>First resolutioni>
The Shareholders acknowledge that the documents as set out in article 267 (1) a), b) and c) of the Luxembourg law on
commercial companies of 10 August 1915, as amended (the "Companies Law") have been made available to them within
the timeframe as required by the Companies Law (and, to the extent applicable and necessary, confirm their waiver of such
a requirement).
<i>Second resolutioni>
The Shareholders declare that, in accordance with article 265 (3) of the Companies Law and with the provisions of the
Spanish Law 3/2009, of 3 April, on structural changes in corporate enterprises (the “Law 3/2009”), they have duly waived
their rights to receive the explanatory report on the merger to be drawn up by the management boards of the Company and
GUADIANA 1977 INVERSIONES Y ESTUDIOS, S.L., a private limited liability company, having its registered office
at calle Àlvarez de Baena 4, Madrid, Spain registered with the Spanish Register of Commerce and Companies of Madrid
at Tome 21.980, Book 0, Folio 111, 8
ème
Section, Page M- ("GUADIANA").
<i>Third resolutioni>
The Shareholders declare that, in accordance with article 266 (5) of the Companies Law and with the Law 3/2009 they
have duly waived the requirements for an examination of, and a report on, the Common Merger Project dated 16 October
2013 by independent experts.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders declare to have examined the Common Merger Project dated 16 October 2013 drawn up by the
management boards of the Company and GUADIANA (the "Common Merger Project").
The Shareholders acknowledge that, pursuant to the Law 3/2009, the Common Merger Project was filed in Spain on 19
November 2013 with the Spanish Register of Commerce and Companies of Madrid. The Shareholders further acknowledge
that in Luxembourg, the Common Merger Project was filed on 23 December 2013 with the Luxembourg register of com-
merce and companies and was published on 29 January 2014 in the Mémorial number 254 page 12151 in accordance with
article 262 and article 9 of the Companies Law.
11296
L
U X E M B O U R G
The Shareholders approve the merger of the Company and GUADIANA whereby GUADIANA will absorb the Company
in accordance with the Law 3/2009 as well as the articles 261 and following of the Companies Law, as set out in the
Common Merger Project which the Shareholders approve in all its provisions and in its entirety, without exception and
reserve (the "Merger"). The Shareholders especially approve that the Merger will be deemed to take effect, only for ac-
counting purposes, on 1 January 2014 (the "Economic Effective Date").
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders acknowledge and approve that as a consequence of the Merger, the Company shall cease to exist and
all assets and liabilities of the Company will be transferred to GUADIANA by way of universal transfer in accordance
with the Companies Law with effect as of the Economic Effective Date. The Shareholders further resolve to delegate to
the board of directors of GUADIANA the power to take the necessary actions to give effect to the present resolutions. The
Shareholders acknowledge that towards third parties, the Merger shall become effective on the date of the publication of
the present minutes in the Mémorial pursuant to the Companies Law.
The Shareholders acknowledge that in accordance with article 268 (1) of the Companies Law, creditors of the merging
companies, whose claims predate the date of the publication of the present minutes in the Mémorial, may, notwithstanding
any agreement to the contrary, within two months of such publication, apply to the judge presiding over the chamber of
the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters in the district in which the registered office of the Company
is located and sitting as in urgent matters, for the constitution of security for matured or unmatured claims if the Merger
would jeopardise the general lien of such creditors or impede the enforcement of their claims.
<i>Notarial verification and certificationi>
In accordance with article 271 (2) of the Companies Law, the Notary (i) declares to have verified and certifies the
existence and the legality of the legal acts and formalities required by the Company and of the Common Merger Project
and attests the proper completion of the pre-merger acts and formalities in relation to the Company and (ii) declares to have
verified and to certify the legality of the completion of the Merger.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1.000.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by name, first name, civil status and
residence, they signed with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le trentième jour du mois de décembre;
Par devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire (le «Notaire» de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Lu-
xembourg), soussigné;
S’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’»Assemblée») des actionnaires de la société ARGANO OVERSEAS S.A., une
société anonyme ayant son siège social au 1, Place du Théâtre, L - 2613 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B122.575 et constituée selon
un acte de Maître Blanche Mourtier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 2006, publiée au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 158, le 10 dévier 2007;
L'Assemblée a élu comme président, Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le
président a nommé en tant que secrétaire et l'Assemblée a élu en tant que scrutateur Monsieur Julien DEMELIERMOE-
RENHOUT, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire de prendre acte que:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par les membres du bureau, les actionnaires présents et les représentants des actionnaires représentés.
Ladite liste signée “ne varietur” par les membres du bureau restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
II. Que l’entièreté du capital social étant représentée à l’Assemblée, aucune convocation préalable n’a été effectuée, les
actionnaires présents ou représentés déclarant avoir dûment reçu avis et pris connaissance de l’ordre du jour avant l’As-
semblée.
11297
L
U X E M B O U R G
III. Qu'il appert de ladite liste de présence que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur les points à l'ordre du jour.
IV. Que l'ordre du jour de l’Assemblée est conçu comme suit:
1. De reconnaître et confirmer conformité avec (et, dans la mesure ou cela est applicable et nécessaire, d’y renoncer)
les formalités de l’article 267(1) a), b) et c) de la loi Luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales en date du 10
août 1915, telle que modifiée (documents Luxembourgeois de mettre à disposition aux associés).
2. De renoncer aux droits des associés to recevoir le report explicatif, concernant la fusion, du conseil de gérance de la
Société et GUADIANA 1977 INVERSIONES Y ESTUDIOS, S.L..
3. De renoncer à la nécessité de faire examiner et établir un rapport sur le Projet Commun de Fusion daté du 16 octobre
2013 par des experts indépendants.
4. D’examiner de Projet Commun de Fusion en date du 16 Février 2013, de reconnaître l’enregistrement de l’acte et la
publication au Luxembourg et en Espagne et d’approuver la fusion et sa date effective pour des fins de la comptabilité.
5. D’approuver les effets de la fusion généralement et spécifiquement vis-à-vis ARGANO OVERSEAS S.A. et de
déléguer au conseil d’administration de GUADIANA 1977 INVERSIONES Y ESTUDIOS, S.L. le pouvoir de prendre les
mesures nécessaires afin de donner effet à la fusion et d’autres actions liés.
5. De faire toute autre action nécessaire afin d’assurer que la fusion soit complétée effectivement.
6. Divers.
Les Associés, agissant en leur capacité d’associé de la Société, adoptent les résolutions suivantes par devant le notaire
soussigné:
<i>Première résolutioni>
Les Associés reconnaissent que les documents tels que prévus à l'article 267 (1) a), b) et c) de la loi Luxembourgeoise
sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés») ont été mis à leur disposition
au siège social de la Société et ce pendant le délai requis par la Loi sur les Sociétés (et, dans la mesure où cela est applicable
et nécessaire, confirment leur renonciation à cette exigence).
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés déclarent que, conformément à l'article 265 (3) de la Loi sur les Sociétés et les provisions de la loi espagnole
3/2009, du 3 avril sur les changements structurels des sociétés (la «Loi 3/2009») qu'ils ont dûment renoncé au droit de
recevoir un rapport explicatif sur la fusion devant être émis par les conseils de gérance de la Société et de GUADIANA
1977 INVERSIONES Y ESTUDIOS, S.L., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social statutaire à calle
Àlvarez de Baena 4, Madrid, Espagne, enregistrée auprès du registre de commerce et des société de Madrid au Tome 21.980,
Livre 0, Folio 111, 8
ème
Section, Page M- ("GUADIANA").
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés déclarent que, conformément à l'article 266 (5) de la Loi sur les Sociétés et de la loi 3/2009 ils ont dûment
renoncé à la nécessité de faire examiner et établir un rapport sur le Projet Commun de Fusion daté du 16 octobre 2013 par
des experts indépendants.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés déclarent avoir examiné le Projet Commun de Fusion en date du 16 octobre 2013 rédigé par les conseils
de gérance de la Société et de GUADIANA (le «Projet Commun de Fusion»).
Les Associés reconnaissent que, conformément à la Loi 3/2009, le Projet Commun de Fusion a été enregistré en Espagne
le 19 novembre 2013 auprès du registre de commerce et des sociétés de Madrid. Les Associés reconnaissent également
qu'à Luxembourg, le Projet Commun de Fusion a été enregistré le 23 décembre 2013 auprès du Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg et publié le 29 janvier 2014 au Mémorial numéro 254 page 12151 conformément aux articles
262 et 9 de la Loi sur les Sociétés.
Les Associés approuvent la fusion de la Société et GUADIANA dans laquelle GUADIANA absorbe la Société confor-
mément à la Loi 3/2009 ainsi qu'aux articles 261 et suivants de la Loi sur les Sociétés, telle qu'établie dans le Projet Commun
de Fusion que les Associés approuvent dans toutes ses dispositions et dans son ensemble, sans exception et réserve (la
«Fusion»). Les Associés approuvent plus précisément que la Fusion sera réputée prendre effet, seulement à des fins comp-
tables, au 1
er
janvier 2014 (la «Date Economique Effective»).
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés reconnaissent et approuvent qu'en conséquence de la Fusion, la Société cessera d'exister et l'ensemble des
actifs et passifs de la Société seront transférés à GUADIANA par le biais d'une transmission universelle conformément à
l'article 274 de la Loi sur les Sociétés avec effet à la Date Economique Effective. Les Associés décident également de
déléguer au conseil de gérance de GUADIANA le pouvoir de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à la
présente résolution. Les Associés reconnaissent qu'entre les sociétés qui fusionnent et vis-à-vis des tiers, la Fusion deviendra
effective à la date de publication des présentes au Mémorial conformément à la Loi sur les Sociétés.
11298
L
U X E M B O U R G
Les Associés reconnaissent conformément à l'article 268 (1) de la Loi sur les Sociétés, que les créanciers des sociétés
qui fusionnent, dont la créance est antérieure à la date de publication des présentes au Mémorial, pourraient, nonobstant
toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du Tribunal
d'Arrondissement dans le ressort duquel le siège social de la Société est situé, siégeant en matière commerciale comme en
matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues si la Fusion mettrait en péril le privilège
général desdits créanciers ou empêcherait la réalisation de leurs créances.
<i>Vérification notariale et certificationi>
Conformément à l'article 271 (2) de la Loi sur les Sociétés, le notaire soussigné (i) déclare avoir vérifié et certifie
l'existence et la légalité des actes légaux et des formalités requises par la Société et du Projet Commun de Fusion et atteste
la parfaite réalisation des actes préalables à la fusion et les formalités relatives à la Société, (ii) déclare avoir vérifié et
certifier la légalité de la réalisation de la Fusion.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ mille Euro (EUR 1.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais et le français, déclare par les présentes que, sur demande des
comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et domicile, ils ont
signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.
Signé: A. UHL, J. DEMELIER-MOERENHOUT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 04 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/86. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 08 janvier 2016.
Référence de publication: 2016053434/203.
(160012630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.
Logamo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 145, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 77.874.
Immo Centre Promotion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 114, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 24.378.
PROJET COMMUN DE FUSION PAR ABSORPTION
A. Concernant la société absorbée:
1) L'administrateur délégué de la société «Logamo s.a.», définie ci-dessous, Monsieur Emile Faber, demeurant à L-4914
Bascharage, 14 rue des Champs
Ainsi que les actionnaires:
2) Monsieur Emile FABER, agent immobilier, demeurant à L-4914 Bascharage, 14 rue des Champs
3) Madame Sonja LAZZARA, épouse d'Emile FABER, demeurant à L-4914 Bascharage, 14 rue des Champs
agissant en leurs qualités de seuls actionnaires de la société anonyme
«LOGAMO s.a.»,
ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 145, avenue de la Faïencerie, Registre de commerce Luxembourg B-77874,
constituée suivant acte reçu en date du 14 septembre 2000 par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Lu-
xembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no 160 du 2 mars 2001
dont ils détiennent l'intégralité du capital social de 31.000,00 €.
Conformément à l'article 261 et ss. de la Loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales
prennent les résolutions suivantes
11299
L
U X E M B O U R G
<i>1 i>
<i>èrei>
<i> Résolution: Fusioni>
Les actionnaires décident de fusionner la société anonyme «Logamo s.a.» (société absorbée) avec la société à respon-
sabilité limitée «Immo Centre Promotion sàrl» (société absorbante), inscrite au registre de commerce sous le numéro
B-24378, avec siège social à L-1511 Luxembourg, 145, avenue de la Faïencerie, qualifié ci-après.
Cette fusion sera faite dans les conditions suivantes:
La société «Logamo s.a.» apportera à la société «Immo Centre Promotion sàrl», tout son actif net, à charge par cette
dernière de reprendre et d'exécuter tous les engagements de la Société apporteuse et de supporter tout son passif, le tout
sur base des inventaires dressés après répartition, constatés par le bilan établi au 31.12.2015, avec les changements survenus
depuis cette date par l'exercice normalement continué de l'exploitation, comme si cette exploitation avait eu lieu au profit
et pour compte de la société à responsabilité limitée «Immo Centre Promotion sàrl»,
Cet apport sera rémunéré aux actuels actionnaires de la société «Logamo s.a.» au prorata de leur actuelle participation
dans la prédite société, par l'attribution d'un nombre de 47.000 parts nouvelles de 25 € (VINGT-CINQ Euros) chacune,
valeur nominale, à créer par la société «Immo Centre Promotion sàrl», par voie d'augmentation de capital. Le montant
correspondant aux fractions de parts résultant des calculs effectués seront remboursées aux actionnaires actuels de la société
«Logamo s.a.» au prorata de leurs participation dans la prédite société, en tant que soulte. Ces parts nouvelles seront du
même type que les parts actuellement existantes de la société absorbante; elles jouiront des mêmes droits et avantages
qu'elles, et donneront droit à la participation aux bénéfices sociaux de la société «Immo Centre Promotion sàrl», à partir
du 01.01.2016.
<i>2 i>
<i>emei>
<i> Résolution: Dissolution.i>
Les actionnaires décident que la société «Logamo s.a.» sera dissoute sous la condition de la réalisation de la fusion
projetée avec effet à la date du 31.12.2015, date à laquelle la fusion est présumée réalisée dans les conditions ci-dessus
déterminées.
Elle désigne en qualité de mandataire spécial Monsieur Emile FABER, prénommé, à qui elle confère les pouvoirs ci-
après
Réaliser la fusion projetée en observant la résolution qui précède et notamment faire apport à la société «Immo Centre
Promotion sàrl», de tout l'actif net de la société dissoute dans les conditions précisées ci-dessus; faire toutes les opérations
et constatations y relatives; prendre toutes mesures d'exécution nécessaires; arrêter les termes et conditions accessoires du
contrat de fusion; remettre ou retirer tous titres et pièces; donner et retirer toutes décharges.
Le mandataire spécial reçoit en outre et de façon générale, sans qu'il ait besoin de recourir à une nouvelle autorisation
de l'assemblée générale, tous les pouvoirs et notamment ceux de donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes in-
scriptions d'office ou autres, prises ou à prendre, avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et à l'action
résolutoire, de donner mainlevée de toutes transcriptions, mentions marginales, saisies, oppositions et autres empêchements,
et enfin de dispenser tous Conservateurs des hypothèques compétents de prendre inscription d'office pour quelque cause
que ce soit.
Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés et seront conservés pendant dix ans au moins au siège
de la société absorbante, la société «Immo Centre Promotion sàrl».
B. Concernant la société absorbante:
1. Le gérant et l'associé unique de la société «Immo Centre Promotion sàrl», définie ci-dessous, Monsieur Emile FABER,
demeurant à L-4914 Bascharage, 14 rue des Champs,
agissant en sa qualité d'associé unique de la société à responsabilité limitée
IMMO CENTRE PROMOTION S.à r.l.
établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 114 avenue de la Faïencerie, inscrite au registre de commerce
sous le numéro B-24378, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse BIEL, alors notaire de résidence à Differdange,
en date du 5 juin 1986, publié au Mémorial C numéro 230 du 12 août 1986, dont les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 1
er
août 2003, publié au Mémorial C numéro
942, du 12 septembre 2003 et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Karine REUTER, alors notaire de résidence à
Pétange, en date du 20 mars 2013, publié au Mémorial C numéro 1206 du 23 mai 2013,
déclarant qu'il est le seul associé de la prédite société, correspondant à l'intégralité du capital social de VINGT-QUATRE-
MILLE-SEPT-CENT-QUATRE-VINGT-NEUF EUROS, TRENTE-CINQ CENTS (EUR 24.789.35€).
Conformément à l'article 261 et suivants de la Loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales
a pris les résolutions suivantes:
<i>Première Résolution: Fusion et augmentation du capital social.i>
L'associé unique décide d'accepter la fusion par absorption avec la société anonyme «Logamo s.a.» préqualifiée, société
absorbée, par l'apport qui sera fait par ladite société préalablement dissoute de tout son actif et de tout son passif.
Aux fins de réaliser ladite fusion, l'associé unique décide
11300
L
U X E M B O U R G
1 ° d'augmenter le capital social de 210,65 Euros (DEUX-CENT-DIX Euros SOIXANTE-CINQ Cents, pour le porter
ainsi de VINGT-QUATRE-MILLE-SEPT-CENT-QUATRE-VINGT-NEUF EUROS, TRENTE-CINQ CENTS (EUR
24.789.35€) à 25.000,00 € (VINGT-CINQ-MILLE EUROS), sans création et émission de parts nouvelles. La valeur de
chaque part sociale est ainsi portée à 25,00 € (VINGT-CINQ EUROS) chacune.
2° d'augmenter le capital social de 1.175.000,00 € (UN-MILLION-CENT-SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS) pour
le porter ainsi de 25.000,00 € (VINGT-CINQ-MILLE EUROS) à 1.200.000,00 € (UN-MILLION-DEUX-CENT-MILLE
EUROS), par la création et l'émission de 47.000 (QUARANTE-SEPT MILLE) parts nouvelles de 25,00 Euros (VINGT-
CINQ EUROS) chacune, valeur nominale, entièrement libérées, du même type que les parts de capital actuellement
existantes, jouissant des mêmes droits et avantages que celles-ci, avec droit aux bénéfices sociaux à partir du 01.01.2016.
Les 47.000 (QUARANTE-SEPT MILLE) parts nouvelles seront attribuées aux actuels actionnaires de la société ab-
sorbée «Logamo s.a.», dissoute, en rémunération de l'apport de tout l'actif net de ladite société à charge de reprendre et
exécuter tous les engagements de la absorbée «Logamo s.a.» et de supporter tout son passif, le tout sur base des inventaires
dressés après répartition, constatés par le bilan établi au 31.12.2015, avec les changements survenus depuis cette date par
l'exercice normalement continué de l'exploitation, comme si cette exploitation avait eu lieu au profit et pour compte de la
société à responsabilité limitée «Immo Centre Promotions sàrl.».
<i>Deuxième Résolution: Apport des actifs et passifs dans le patrimoine de la société absorbante.i>
L'actif de la société dissoute et absorbée «Logamo s.a.» consiste notamment: en biens immeubles, créances commerciales
et diverses, avoirs en caisse, en banque et au Compte de Chèques Postaux et les bénéfices des contrats en cours, s'élève à
la somme de 1.176.493,91 Euros.
Et spécialement les immeubles de la Société absorbée «Logamo s.a.» consistent en:
Commune de Garnich, section B de Garnich, numéros cadastraux, lieu-dit, nature et contenance:
N° cadastre
Lieu-dit
Nature
Contenance
1 / 4826
An der Menzel
place
0a40ca
2/ 4827
An der Menzel
place verte
2a93ca
2 / 4828
An der Menzel
place
0a08ca
2/ 4833
An der Menzel
place voirie
62a30ca
2/ 4834
An der Menzel
aire de loisirs
6a52ca
5 / 4835
An der Menzel
place
0a33ca
5 / 4836
An der Menzel
sentier
0a82ca
8 / 4830
An der Merzel
place
0a29ca
8/ 4831
An der Merzel
place
0a03ca
9/ 4832
An der Merzel
sentier
1a56ca
1942/ 4829
An der Merzel
place verte
32a98ca
<i>Titre de propriétéi>
La société «Logamo s.a.» a acquis l'objet de vente prédécrit sous une plus grande contenance aux termes d'un acte de
vente reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 15 septembre 2003, transcrit au deuxième
bureau des hypothèques de et à Luxembourg, le 2 octobre 2003, volume 1399, numéro 2.
<i>Conventioni>
Les terrains énumérés ci-dessus font partie d'un lotissement dit «In der Merzel» à Gamich, pour lequel une convention
relative au lotissement a été dressée entre l'administration communale de Garnich et la société «Logamo s.a.» en date du
10 mars 2003, régissant les dispositions à respecter lors de la réalisation du lotissement. Les terrains énumérés ci-dessus
et visés par l'article 17 de la prédite convention seront cédés à titre gratuit à la Commune de Garnich lors de la réception
définitive du lotissement.
La société absorbante «Immo Centre Promotion sàrl» se substituera, sans aucune exception, à partir du 01.01.2016 dans
tous les droits et obligations découlant de la prédite convention.
valeur d'apport des immeubles correspondant à la valeur comptable bilantaire: . . . . . . . . . . . . . . . . .
1000,01 €
Valeurs actives mobilières:
Avoir en banques:
BIL LU45 0023 1504 0088 0400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
814,56 €
BIL LU48 0023 2504 0086 5500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
373.729,56 €
Autres créances:
Créances actionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65.075,44 €
Prêt Immo Centre Promotions sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
740.246,07 €
Total Actif: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.180.865.64 €
Le passif de la société absorbée «Logamo s.a.»
11301
L
U X E M B O U R G
Autres dettes et provisions:
- Provisions pour impôts 2015 (montant brut): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.258,00 €
- (à déduire paiement impôts 2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 1.585,80 €
- Dettes fiscales (IRC, ICC et IsF) Imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.699,53 €
Total Passif: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.371.73 €
Solde net des apporte: (actifs - passifs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.176.493,91 €
<i>Réalisation de la fusioni>
Monsieur Emile Faber, prénommé agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme «Logamo», dis-
soute, préqualifiée, conformément aux résolutions prises par les actionnaires de la société «Logamo s.a.», constate la
réalisation des opérations décidées et précisées en l'exposé qui précède.
A. Dissolution, Augmentation de capital - souscription.
Monsieur Emile Faber confirme la dissolution de la société absorbée Logamo s.a» et décide de souscrire, l'augmentation
de capital de 1.175.000,00 € Euros décidée par l'associé unique de la société absorbante «IMMO CENTRE PROMOTION
sàrl.», au nom et pour compte des actionnaires de la société dissoute «Logamo s.a», comme suit:
1) Monsieur Emile FABER prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.500 parts
2) Madame Sonja LAZZARA, épouse d'Emile FABER, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.500 parts
TOTAL CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.000 parts
La création et l'émission de 47.000 parts nouvelles de 25 € chacune de la société absorbante «IMMO CENTRE PRO-
MOTION sàrl.» sont du même type que celles actuellement existantes, jouissant des mêmes droits et avantages que celles-
ci, et donneront droit à la participation aux bénéfices sociaux de la société «IMMO CENTRE PROMOTION sàrl.» à partir
du 01.01.2016.
Les 47.000 parts nouvelles ainsi créées et émises ont été entièrement libérées par la rémunération de l'apport de l'actif
social de la dissoute «Logamo s.a.», qui a été fait lors de la fusion de la société prémommée «IMMO CENTRE PROMO-
TION sàrl.», à charge en outre de reprendre et d'exécuter tous ses engagements et de supporter tout son passif.
La différence entre l'actif social net apporté fixé à 1.176.493,91 € et la valeur des nouvelles parts allouées aux associés
de la société dissoute «Logamo s.a.» fixée à 1.175.000,00 € est constituée d'une soulte de 1.493,91 € qui sera virée au
compte des actionnaires de la société dissoute «Logamo s.a..»
B. Apports. Fusion.
Monsieur Emile Faber, prénommé, agissant comme il est dit en qualité de mandataire spécial de la société «Logamo
s.a.» et en vertu des pouvoirs qui lui ont été expressément conférés ainsi qu'il est exposé ci-dessus, déclare par les présentes
avoir fait l'apport de l'actif social de la dissoute «Logamo s.a.» à la société «IMMO CENTRE PROMOTION sàrl.» et à
l'instant déclare dès lors les anciennes actions de la société «Logamo s.a.» annulées et détruites et que la fusion a été réalisée.
Suite à la déclaration du mandataire spécial de la société absorbée «Logamo s.a.» l'associé unique de la société absorbante
«IMMO CENTRE PROMOTION sàrl.» prend les résolutions suivantes:
<i>3 i>
<i>emei>
<i> résolution: Acceptation des apportsi>
L'associé unique de la société absorbante «IMMO CENTRE PROMOTION sàrl.» accepte l'apport qui a été fait à l'instant
par la société «Logamo s.a.» à la société «IMMO CENTRE PROMOTION sàrl.» moyennant attribution des 47.000 parts
nouvelles entièrement libérées et avec charge en outre de reprendre et exécuter tous les engagements de la société apporteuse
«Logamo s.a.» et de supporter tout son passif.
<i>4 i>
<i>emei>
<i> résolution: Modification du capital social et de l'article 7 des statutsi>
Suite à l'intégration des valeurs actives et passives de la société dissoute «Logamo s.a.» dans le patrimoine de la société
«IMMO CENTRE PROMOTION sàrl.» et suite à l'attribution de 47.000 parts nouvelles aux actionnaires de la société
dissoute «Logamo s.a.», l'article 7 des statuts de la société «IMMO CENTRE PROMOTION sàrl.» sera modifié et aura la
teneur suivante:
« Art. 7. Le capital social est fixé à 1.200.000,00 € (UN-MILLION-DEUX-CENTS-MILLE EUROS), représenté par
48.000 (QUARANTE-HUIT-MILLE) parts sociales de 25 € (VINGT-CINQ EUROS) chacune, intégralement libérées.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.»
Les 48.000 (QUARANTE-HUIT-MILLE) parts sociales sont réparties entre les associés comme suit:
1) Monsieur Emile FABER prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.500 parts
2) Madame Sonja LAZZARA, épouse d'Emile FABER, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.500 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.000 parts
11302
L
U X E M B O U R G
<i>Dispositions finales:i>
1) Sous réserve d'absence de contestation du présent projet de fusion par absorption, les soussignés chargent le notaire
Maître Karine REUTER, de résidence à Luxembourg, de formaliser le présent projet dans les délais légaux, par la réception
d'un acte constatant l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbée «LOGAMO S.A.» et d'un
acte constatant la fusion par la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société absorbante
«IMMO CENTRE PROMOTION sàrl». L'étude du notaire sera également mandatée à l'effet de faire dresser et signer tous
actes complémentaires, rectificatifs ou modtfîcatifs des présentes, pour mettre celles-ci en concordance avec les documents
hypothécaires, cadastraux et avec ceux du Registre de Commerce et en général prendre toutes mesures d'exécution, arrêter
les termes et conditions accessoires du présent acte de fusion.
2) La présente fusion est régie en matière de l'impôt sur le revenu par l'article 170 LIR, respectivement par l'article 22
bis LIR, ainsi qu'en matière de perception des taxes d'enregistrement par l'article 4 de la loi du 19 décembre 2008 et la
circulaire n° 739 du 31 décembre 2008 du Directeur de l'Administration de l'Enregistrement.
3) Pour les besoins de l'enregistrement les immeubles apportés ont été évalués à leur valeur marchande actuelle de
1000,01 €.
4) Conformément à l'article 266, alinéa 5 de la Loi modifiée du 15 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tous
les associés de la société absorbée et de la société absorbante décident de renoncer à un examen du présent projet de fusion
par un expert indépendant, ainsi qu'à un rapport par un expert indépendant. («Ni un examen du projet commun de fusion
par des experts indépendants ni un rapport d'expert ne sont requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant
un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont ainsi décidé.»)
Ainsi établi à Luxembourg, le 22 janvier 2016, sous seing privé, en triple exemplaires.
Monsieur Emile Faber
<i>L'administrateur délégué de la société à absorber «LOGAMO s.a»
i>Monsieur Emile Faber / Madame Sonja Lazzara, épouse de Emile Faber
<i>Les actionnaires de la société à absorber, «LOGAMO s.a.»
i>Monsieur Emile Faber
<i>Le gérant et l'associé unique de la société absorbante «IMMO CENTRE PROMOTION sàrl»i>
Référence de publication: 2016055187/213.
(160015262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Immo-Wallux S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1918 Luxembourg, 37A, rue de Laroche.
R.C.S. Luxembourg E 3.909.
EXTRAIT
Cession de parts et assemblée générale extraordinaire reçu par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence
à Niederanven en date du 17 décembre 2015, sous son numéro de répertoire 52.398, enregistré le 22 décembre 2015 sous
la relation LAC/2015/41250 de la société IMMO-WALUX S.C.I., Société Civile Immobilière, RCS LUXEMBOURG E
numéro 3909:
<i>Première résolutioni>
Les associés constatent que les parts de la Société sont dorénavant réparties comme suit:
1.- Monsieur Henri STEINER, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 parts
2.-Monsieur Mathieu STEINER, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts
3.- Monsieur Philippe STEINER, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), représenté par cent (100)
parts d’intérêts de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacun.»
Pour extrait conforme
Paul Bettingen
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2016055191/24.
(160014421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
11303
L
U X E M B O U R G
RP Residential Assembly S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 138.036.
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 20 novembre 2015 que:
- Monsieur Patrick Fox a démissionné de ses fonctions de Gérant catégorie B de la Société avec effet au 26 octobre
2015;
- Monsieur Spencer Raymond, né le 20 septembre 1981 au New Jersey, États-Unis d'Amérique et résidant profession-
nellement au 500 Boylston, Suite 1880, Boston, MA 02116, États-Unis d'Amérique, a été nommé Gérant catégorie B de
la Société avec effet au 26 octobre 2015 pour une durée indéterminée.
Il est également à noter que Hermann-Günter Schommarz, Gérant de catégorie A de la Société, se prénommera Herman
Schommarz avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 23 novembre 2015.
Référence de publication: 2015190531/18.
(150212786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Selmar Investments, S.à r.l., SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Capital social: EUR 5.000.000,00.
Siège social: L-2311 Luxemburg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 201.570.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the twenty-eight of October.
Before Us Maître Jacques KESSELER, notary residing at Pétange (Grand-Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED
Mr. Enrique SELFA MARQUES, born on 30/07/1938 in Valencia (Spain), residing at Cerro De Alfeição, 8100-280
Loule (Portugal),
Mme. Eliane PERDON JUMEAU, born on 10/01/1936 in Paris (France) residing at Urb. Guadalmina Baja Calle 5, n°
173 Bis, 29679 Marbella, Málaga, (Spain),
here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, professionally residing at 13, route de
Luxembourg, L-4701 Pétange, by virtue of a proxy given under private seal,
Mr. Ricardo SELFA PERDON born on 12/05/1966 in Madrid (Spain) residing at Cerro De Alfeição, 8100-280 Loule
(Portugal),
here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk,, professionally residing at 13, route de
Luxembourg, L-4701 Pétange, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxies, signed “ne varietur” by the proxyholders of the appearing parties and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed in order to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in their here above stated capacities, have required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a Société à reponsabilité limitée which it declares organized and the articles of incorporation of which
shall be as follows:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (Société à responsabilité limitée) under the name
"SELMAR INVESTMENTS, S.à.r.l., SPF" (hereafter the Company), which will be governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, in particular by the law dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter
the Law), and by the law dated 11 May 2007 regarding the incorporation of a Société de gestion de patrimoine familial, as
well as by the present articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy
of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
11304
L
U X E M B O U R G
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager
or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object. The object of the Company, to the exclusion of any commercial activity, is the acquisition, the holding,
the management and the disposal of (i) financial instruments within the meaning of the law dated August 5
th
, 2005 on
financial guarantee contracts, and of (ii) cash and assets of any nature whatsoever held on an account.
It may acquire by means of contribution, subscription, purchase option and any other means financial instruments of
any nature and sell them by means of sale, exchange or any other way.
The Company will not have any business activity or industrial activity and will not keep a commercial establishment
opened to the public.
The Company may not hold intellectual property rights.
Generally speaking, the Company may implement any measure of surveillance or control and carry out any operation
or transaction which it deems necessary or useful for the accomplishment and the development of its Company object in
the broadest manner possible, provided that the Company does not interfere in the management of the companies in which
it holds participations, within the limits established by the law dated 11 May 2007.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's issued share capital is set at five million Euro (EUR 5,000,000.-), represented by five thousand
(5,000.-) shares with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval
of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of
the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the
general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to be shareholder(s). In case
of plurality of managers, the managers will form a board of managers.
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
11305
L
U X E M B O U R G
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or by two managers
acting jointly.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the
place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circums-
tances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
9.7. In case of emergency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner
as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of the
sole manager or, in case of plurality of managers, by the individual signature of any manager of the Company or, as the
case may be, by the joint or single signature(s) of any persons to whom such signatory power has been validly delegated
in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The sole manager or, as the case may be, the managers assume, by reason of their
mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/ them in the name of the Company,
provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of
December.
11306
L
U X E M B O U R G
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the board of managers must prepare the balance sheet
and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the managers, the
statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be authorized and distributed, at any time, by the sole manager or, as the case may be, the
board of managers under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the sole manager or the board of managers of the
Company;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased
by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
the statutory reserve; and
(iii) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by
each shareholder in the Company.
VII. General provisions
17. Reference is made to the provisions of the Law and of the law of 11 May 2007 regarding the incorporation of a
Société de gestion de patrimoine familial for all matters for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
Exceptionally the first financial year shall begin on the date of the incorporation of the corporation and shall terminate
on the 31 December 2015.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as
follows:
M. Enrique SELFA MARQUES, prenamed, declares to subscribe four thousand six hundred forty one (4,641) shares
by a contribution in kind consisting of nineteen thousand five hundred and thirty four (19,534) shares of “GLENCOVE
LUXEMBOURG S.à.r.l.”, a company having its registered office in L-2311 Luxembourg 3, Avenue Pasteur, registered at
the RCS Luxembourg under the number B182364. (Hereafter the “Contribution” or "GLENCOVE LUXEMBOURG
S.àr.l.”).
Mrs. Eliane PERDON JUMEAU, prenamed, declares to subscribe two hundred and seventy six (276) shares by a
contribution in kind consisting of one thousand hundred sixty one (1,161) shares of GLENCOVE LUXEMBOURG S.à.r.l.
M. Ricardo SELFA PERDON, prenamed, declares to subscribe eighty three (83) shares by a contribution in kind con-
sisting of three hundred and fifty (350) shares of GLENCOVE LUXEMBOURG S.à.r.l.
These contributions represent 12.24 % of the share capital of GLENCOVE LUXEMBOURG S.à.r.l.
<i>Valuation - Statementi>
It results from a certificate issued by the managers of GLENCOVE LUXEMBOURG S.à.r.l. as of the date of the
certificate that:
a) M. Enrique SELFA MARQUES, prenamed, is the owner of at one hundred seventy thousand four hundred and eighty-
four (170.484) shares of GLENCOVE LUXEMBOURG S.à.r.l.;
11307
L
U X E M B O U R G
Mrs. Eliane PERDON JUMEAU, prenamed, is the owner of at one thousand hundred sixty one (1.161) shares of
GLENCOVE LUXEMBOURG S.à.r.l.;
M. Ricardo SELFA PERDON, prenamed, is the owner of at three hundred and fifty (350) shares of GLENCOVE
LUXEMBOURG S.à.r.l.;
b) on the date hereof, the Contribution is valued at least five millions Euro (EUR 5,000,000.-), this estimation being
based on generally accepted accountancy principles;
c) the shares are not encumbered with any pledge or any other right, the shares are not subject to any seizure or opposition
and that the transfer of these shares is not contrary to any provision of the articles of association of GLENCOVE LU-
XEMBOURG S.à.r.l., so that nothing can hinder the contribution and transcription of these shares in favor of the company
“SELMAR INVESTMENTS, S.à.r.l., SPF”;
d) all formalities in order to duly formalize the transfer of the shares to the Company have been made or will be, by his
care.
The value of the Contribution shall entirely be allocated to the nominal share capital account of the Company for an
amount of five million Euro (EUR 5.000.000.-).
Such certificate and after signature “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately 4,000.- euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the Shareholders, representing the entirety of the subscribed share
capital have passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period of time:
- FMS SERVICES S.A., with registered office 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 101240
- S.G.A. SERVICES S.A., with registered office 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 76118
- Mrs. Tazia BENAMEUR with professional address 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
2. The registered office will be fixed at 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to appearing persons, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil quinze, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
Monsieur Enrique SELFA MARQUES., né le 30 juillet 1938 à Valence (Espagne), domicilié à Cerro De Alfeição - CX
Postal 330-Z, 8100-280 Loule, Portugal,
Madame Eliane PERDON JUMEAU., née le 10 janvier 1936 à Paris (France), domiciliée à Urb. Guadalmina Baja Calle
5, n° 173 Bis, 29679 Marbella, Málaga, Espagne,
ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement au 13,
route de Luxembourg, L- 4761 Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
Monsieur Ricardo SELFA PERDON., né le 12 mai 1966 à Madrid (Espagne), domicilié au Cerro De Alfeição - CX
Postal 330-Z, 8100-280 Loule, Portugal,
ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement au 13,
route de Luxembourg, L- 4761 Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, signées «ne varietur» par les mandataires des parties comparantes et le notaire resteront annexées
au présent acte pour être enregistrés avec ce dernier.
Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
d'une Société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
11308
L
U X E M B O U R G
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une Société à responsabilité limitée sous la dénomination «SELMAR INVEST-
MENTS, S.à.r.l., SPF» (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi), et par la loi du 11 mai
2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, ainsi que par les présents statuts (ci-après les
Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'as-
semblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou
bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que
des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces événements
seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit
du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social. La Société a pour objet à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la
gestion et la réalisation (i) d'instruments financiers tels que définis par la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie
financière et (ii) d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs
mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La Société ne pourra pas exercer d'activité commerciale, n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun
établissement commercial ouvert au public.
La Société ne pourra pas détenir des droits de propriété intellectuelle.
D'une manière générale, la Société pourra prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-
ration ou transaction qu'elle estime utile à l'accomplissement, au développement de son objet social et à la sauvegarde de
ses droits, à condition qu'elle ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, en restant toujours cepen-
dant, dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.
4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,- ), représenté par cinq mille (5.000,-) parts sociales
d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé
unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code Civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la
Loi.
11309
L
U X E M B O U R G
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale
des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s). En cas
de pluralité de gérants, les gérants forment un conseil de gérance.
7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous
pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par le gérant, ou s'il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou par deux gérants agissant
conjointement.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de la
Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre
du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société
donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les procès-verbaux
des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre
moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre
et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
9.7. En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement
adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la seule signature du
gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de deux gérants de la Société, ou, le cas échéant,
par la/les signature(s) individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement
délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Le gérant unique ou, le cas échéant, les gérants ne contractent à raison de leur
fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société,
dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs - Droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque
associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit,
soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax
ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés
apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
11310
L
U X E M B O U R G
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société
seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le conseil de gérance, doit préparer le bilan et les comptes
de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société,
avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel
est le cas), et associés envers la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être autorisés et distribués à tout moment, par le gérant unique ou, le cas
échéant, le conseil de gérance, dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à
la réserve légale; et
(iii) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération.
Sauf disposition contraire prévue dans la résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés ou par la
loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de
la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.
VII. Dispositions générales
17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi
et à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social qui commence le jour de la constitution de la société et se terminera le
31 décembre 2015.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les parts sociales comme
suit:
Monsieur Enrique SELFA MARQUES, prénommé, déclare souscrire quatre mille six cent quarante et un (4.641) nou-
velles parts sociales et de les libérer par un apport en nature consistant en l'apport de dix-neuf mille cinq cent trente-quatre
(19.534) parts sociales de «GLENCOVE LUXEMBOURG S.à r.l.», une société à responsabilité limité, ayant son siège
social à L-2311 Luxembourg, 3, Avenue Pasteur, enregistré auprès du RCS Luxembourg sous le numéro B182364. (Ci-
après l'«Apport» ou «GLENCOVE LUXEMBOURG S.à.r.l.»).
Madame Eliane PERDON JUMEAU, prénommée, déclare souscrire deux cent soixante-seize (276) nouvelles parts
sociales et de les libérer par un apport en nature consistant en l'apport de mille cent soixante et une (1.161) parts sociales
de GLENCOVE LUXEMBOURG S.à.r.l..
Monsieur Ricardo SELFA PERDON, prénommé, déclare souscrire quatre-vingt-trois (83) nouvelles parts sociales et
de les libérer par un apport en nature consistant en l'apport de trois cent cinquante (350) parts sociales de GLENCOVE
LUXEMBOURG S.à.r.l..
Ces apports représentant 12,24 % du capital social de GLENCOVE LUXEMBOURG S.à.r.l.
11311
L
U X E M B O U R G
<i>Evaluations - Déclarationsi>
Il résulte d'un certificat délivré par les gérants de la société GLENCOVE LUXEMBOURG S.à.r.l. en date de ce jour
que:
a) Monsieur Enrique SELFA MARQUES, prénommé, est le propriétaire des cent soixante-dix mille quatre cent quatre-
vingt-quatre (170.484) parts sociales de GLENCOVE LUXEMBOURG S.à.r.l.;
Madame Eliane PERDON JUMEAU, prénommée, est la propriétaire des mille cent soixante et une (1.161) parts sociales
de GLENCOVE LUXEMBOURG S.à.r.l.;
Monsieur Ricardo SELFA PERDON, prénommé, est le propriétaire des trois cent cinquante (350) parts sociales de
GLENCOVE LUXEMBOURG S.à.r.l.;
b) en date de ce jour, l'Apport est évalué au moins à cinq millions euros (EUR 5.000.000,-) cette estimation étant basée
sur les principes comptables généralement acceptés;
c) les parts ne sont ni grevées d'aucun gage, ni d'aucun autre droit quelconque, qu'elles ne font l'objet d'aucune saisie ou
opposition, que le transfert de ces parts n'est contraire à aucune disposition du règlement de la GLENCOVE LUXEM-
BOURG S.à.r.l. et qu'en conséquence rien ne peut faire obstacle à l’apport et à la transcription de ces parts en faveur de la
société «SELMAR INVESTMENTS, S.à.r.l., SPF»;
d) que toutes les formalités dans le but de formaliser le transfert des parts à l’égard de la Société ont été effectuées ou
seront effectuées de par ses soins.
La valeur de l’Apport sera affectée pour un montant de cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-) au compte de capital
social de la Société.
Ledit certificat après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera
annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Coûtsi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à 4.000,- euro.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social se considérant comme réunis en assemblée générale
ont pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des gérants de la Société est fixé à trois, pour une durée indéterminée:
- FMS SERVICES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est au 3, avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg, RCS Luxembourg B 101240
- S.G.A. SERVICES S.A. société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est au 39, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, RCS Luxembourg B 76118
- Madame Tazia BENAMEUR, domiciliée professionnellement au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
2. Le siège social de la Société est établi au 3, avenue Pasteur, L- 2311 Luxembourg
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Selfa Marques, Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 octobre 2015. Relation: EAC/2015/25227. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015188105/460.
(150210035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
11312
L
U X E M B O U R G
Pratzen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 188.243.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 novembre 2015i>
<i>1 i>
<i>èrei>
<i> Résolution:i>
M. Alain Geurts, né le 13 septembre 1962 à Nioki (RDC), employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et Mme. Frédérique Mignon, née le 19 janvier 1973 à Bastogne (Belgique), employée
privée, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg sont nommés, avec effet immédiat,
nouveaux Administrateurs en remplacement de M. Serge HIRSCH et Mme Catherine SEVELLE démissionnaires. Leurs
mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2019.
<i>2 i>
<i>èmei>
<i> Résolution:i>
La société Fiduciaire Wotan SA., R.C.S Luxembourg B 198 446, ayant siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820
Luxembourg, est nommée, avec effet immédiat, nouveau Commissaire en remplacement de la société anonyme H.R. T
Révision S.A. démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2019.
<i>3 i>
<i>èmei>
<i> Résolution:i>
Le siège social est transféré avec effet immédiat au 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour Pratzen SA.
i>Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015190459/26.
(150213398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Skol Development Africa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 139.315.
Remplacement du représentant permanent
Nous vous prions de bien vouloir noter que la Société CIPARI SA, immatriculée B 7518, domiciliée 50, route d'Esch,
L-1470 Luxembourg, dans le cadre de son mandat d'administrateur au sein de la société SKOL DEVELOPMENT AFRICA
S.A. désigne à partir du 10 novembre 2015 en tant que représentant permanent Monsieur Thomas HOCHREITER
<i>Ancien représentant permanent:i>
DURANTON HERVE
Né le 1
er
janvier 1965 à Thiers (France) et domicilié
124, rue de Livourne
B-1000 Bruxelles
<i>Nouveau représentant permanent:i>
HOCHREITER THOMAS
Né le 20 octobre 1973 à Windhuk (Allemagne) et domicilié
c/o HOSSBACH
Herrenstrasse 50 a
D-76133 Karlsruhe
Référence de publication: 2015190587/22.
(150213080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
11313
L
U X E M B O U R G
United Depositary Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 201.589.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the thirteenth day of November
Before us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
United International Holdings (Netherlands) B.V., having its registered office in Strawinskylaan 411,WTC Toren A,
1077XX Amsterdam, The Netherlands, registered with the Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register under
the number 821788036,
here represented by Mr. Edgar SCHÖPF, employee, company director, residing professionally in Luxembourg, by virtue
of a proxy given in Amsterdam on the 9
th
of November 2015.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the
present deed in order to be registered with it.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to inscribe as follows the articles of
association of a société anonyme:
Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of “United Depositary Services S.A.” (“Compa-
ny”).
Art. 2. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the city of Luxembourg by a decision of the board of directors (“Board”).
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to
have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The Company is established for an unlimited period of time.
Art. 4. The purpose of the Company is to pursue, as professional of the financial sector, the activities of a professional
depositary of assets other than financial instruments in accordance with article 26-1 of the Luxembourg law of 5 April 1993
on the financial sector, as amended (“Law of 1993”).
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital of the Company is set at seven hundred fifty thousand Euro (EUR 750,000.-) divided into
seven hundred fifty (750) shares with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.
The shares are and will remain in registered form.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the requirements under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg (“Luxembourg Law”).
The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership
of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent
such share(s) towards the company.
The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).
Title III. - Management, Board of directors, Daily managers
Art. 6. The Company is managed by its Board composed of at least three directors, either shareholders or not, who are
appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders (“General Meeting”) which may at
any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the General Meeting.
In case the Company is incorporated by a sole shareholder, or if, at a General Meeting, it is noted that the Company
only has one shareholder the composition of the Board may be limited to one member until the next annual General Meeting
at which it is noted that the Company has (again) more than one shareholder. In this case, the sole director exercises the
powers devolving on the Board.
11314
L
U X E M B O U R G
Art. 7. The Board will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced by the eldest
director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary General Meeting following the incorporation of the
Company.
The Board convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented, as often as
the interest of the Company so requires. It must be convened each time two directors so request.
Resolutions can also be adopted by the Board by way of circular letter where the signatures of the different Directors
may be apposed on several exemplars of the resolution in writing. Any director may also participate in any meeting of the
Board by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking
part in the meeting to hear one another.
Art. 8. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance
with the corporate object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles of incorporation (“Articles”)
to the General Meeting fall within the competence of the Board. The Board may pay interim dividends, in compliance with
the legal requirements.
Art. 9. Toward third parties the Company will be validly bound by (i) the joint signatures of any two directors, or (ii)
by the sole signature of the sole director, or (iii) by the sole signature of any person to whom a special signatory power has
been delegated by the Board, or (iv) by the sole signature of a Daily Manager (As defined below), within the limit of his/
her mandate.
Art. 10. The daily management of the Company, as well as the representation of the Company in relation with this
management shall be delegated to at least two directors, officers or other agents, shareholders or not (the “Daily Managers”).
Daily Managers must possess adequate professional experience by virtue of their having previously carried on similar
activities at a high level of responsibility and autonomy. Their appointment, revocation and powers shall be determined by
a resolution of the Board. They must be empowered to determine the direction taken by the business of the Company and
shall have closely equal powers.
The Board may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more
managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the Board, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Art. 12. Directors incur, by reason of their position, no personal liability for any undertaking validly given by them on
behalf of the company as long as this undertaking is consistent with the articles and the applicable provisions of the law of
1915 on commercial companies (the “Law of 1915”).
Title IV. - Approved statutory auditor
Art. 13. The accounts of the Company shall be revised by one or more approved statutory auditors (réviseurs d'entreprises
agréés) who possess adequate professional experience and which are appointed, revoked and replaced by the Board in
accordance with the Law of 1993.
Title V. - General meeting
Art. 14. The General Meeting represents all the shareholders of the Company. It has the broadest powers to order, carry
out or ratify acts relating to the operations of the Company, unless the present Articles provide otherwise.
The annual General Meeting will be held in the city of Luxembourg at the place specified in the convening notices on
the 15
th
of May at 12:00 p.m.
If such day is a legal holiday, the General Meeting will be held on the next following day which is not a legal holiday.
Other General Meetings may be held at such places and dates as may be specified in the respective notices of General
Meeting.
Each share entitles one vote. Each shareholder may participate to the General Meetings by appointing in writing, by
telecopy, email or any other similar means of communication, another person as his proxy-holder.
If all shareholders are present or represented at a General Meeting, and if they declare knowing the agenda, the General
Meeting may be held without convening notice or prior publication.
If the Company only has one sole shareholder, the latter exercises the powers devolving on the General Meeting.
Title VI. - Accounting year, Allocation of profits
Art. 15. The accounting year of the company shall begin on January 1
st
and shall terminate on December 31
st
of each
year.
Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the company and the amortizations, the credit balance represents
the net profits of the company. Of the net profits, five percent (5,00 %) shall be appropriated for the legal reserve; this
11315
L
U X E M B O U R G
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00 %) of the capital of the Company, but
it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.
The balance is at the disposal of the General Meeting.
Title VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 17. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators,
physical or legal persons, appointed by the General Meeting which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII. - General provisions
Art. 18. All matters not governed by these Articles are to be construed in accordance with the Law of 1915.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31
st
of December
2016.
The first annual General Meeting shall be held in 2017.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid up
in cash the shares issued by the Company.
Proof of such payment in cash has been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever shall be borne by the Company and amount to
one thousand four hundred and fifty euro.
<i>Statementsi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26, 26-3 and 26-5 of the Law of 1915
have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that
these Articles comply with the provisions of article 27 of the Law of 1915.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The above named person representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed Directors of the Company for a period ending on the date of the annual general
meeting to be held in 2020:
- Mr Gérard MATHEIS, employee, born on 4
th
of December 1962 in Luxembourg with professional address at 7, avenue
Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg;
- Mr Jean FELL, employee, born on 9
th
of April 1956 in Echternach with professional address at 7, avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg; and
- Mr Edgar SCHÖPF, employee, born on 3
rd
of September 1969 in Ellwangen (Germany) with professional address at
7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The limited liability company KPMG Luxembourg, with registered office at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register number B 149133 is appointed as statutory auditor of the
Company for a period ending on the date of the annual general meeting to be held in 2020.
<i>Third resolutioni>
The registered office of the Company is fixed at 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze le treize novembre.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
11316
L
U X E M B O U R G
United International Holdings (Netherlands) B.V, avec siège social à 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 411, WTC
Toren A, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 821788036;
ici représentée par Monsieur Edgar SCHÖPF, employé, ayant son domicile professionnel à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à Amsterdam le 9 Novembre 2015.
Cette procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte
pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les
statuts d'une société anonyme.
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de "United Depositary Services
S.A.".
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg ville.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale
au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. L'objectif de la Société est de poursuivre, en tant que professionnel du secteur financier, les activités d'un dépo-
sitaire professionnel d'actifs autres que les instruments financiers conformément à l'article 26-1 de la loi luxembourgeoise
du 5 Avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée ("loi de 1993").
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à sept cent cinquante mille Euros (EUR 750.000,-) représenté par sept cent cinquante
(750) actions d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.
Les actions sont et resteront nominatives.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues con-
jointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs actions font l'objet d'un contentieux, l'ensemble des personnes
revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l'égard de la
société.
L'absence de la désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.
Titre III. - Administration, Conseil d'administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associés ou non,
nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par
elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale
de la société.
Lorsque la société est constituée par un associé unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté
que celle-ci n'a plus qu'un associé unique la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé. Dans ce cas, le membre unique
exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par
l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui
se tiendra après la constitution de la société.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'admi-
nistrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents
administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration. Tout
administrateur peut en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéo-
11317
L
U X E M B O U R G
conférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres.
Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de
disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par
la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. Vis-à-vis des tiers, la société sera valablement engagée par (i) les signatures conjointes de deux administrateurs
quelconques, ou (ii) par la signature unique de l'administrateur unique ou (iii) par la seule signature de toute(s) autre(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) un pouvoir spécial de signature a été délégué par le conseil d'administration ou (iv) par
la seule signature de toute personne en charge de la gestion journalière, dans la limite de la gestion journalière de la Société.
Art. 10. La gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion doit être déléguée
à une ou plusieurs administrateurs, agents ou autres mandataires, associés ou non. Leur nomination, révocation et leurs
pouvoirs seront déterminés par une résolution du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires
sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés
de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
Art. 12. Les membres du conseil d'administration ne contractent, en raison de leur mandat, aucune responsabilité per-
sonnelle pour un engagement valablement pris par eux au nom de la société, aussi longtemps que cet engagement est
conforme aux statuts et aux dispositions applicables de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales.
Titre IV. - Revision des comptes
Art. 13. Les comptes de la société seront vérifiés par un plusieurs réviseurs d'entreprises agrées.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose
des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en oeuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la société,
à moins que les statuts n'en disposent autrement.
L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le 15
mai à 12 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires
en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme
mandataire.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connaissance
de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.
Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d'«associé» et exerce les pouvoirs dévolus
à l'assemblée générale des actionnaires.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
11318
L
U X E M B O U R G
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2016.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2017.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante pré-qualifiée, dûment représentée, déclare souscrire toutes
les sept cent cinquante (750) actions d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.
Toutes les sept cents cinquante (750) actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de sept
cent cinquante mille Euros (EUR 750.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, a été évalué à environ mille quatre cent cinquante Euros.
<i>Décisions de l'associée uniquei>
La comparante pré-qualifiée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant
qu'associé unique:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société pour une période se terminant à la date de l'as-
semblée générale annuelle qui se tiendra en 2020:
- Monsieur Gérard MATHEIS, employé, né le 04 décembre 1962 à Luxembourg et demeurant professionnellement à 7,
avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
- Monsieur Jean FELL, employé, né le 09 avril 1956 à Echternach et demeurant professionnellement à 7, avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg.
- Monsieur Edgar SCHÖPF, employé, né le 03 septembre 1969 à Ellwangen (Allemagne) et demeurant professionnel-
lement à 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
La société à responsabilité limitée KPMG Luxembourg avec siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg numéro B 149133 est nommé réviseur d'entreprises de
la Société pour une période se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est établi à L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande du mandataire, le
présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande du même mandataire et en cas de
divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Edgar SCHÖPF, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 17 novembre 2015. Relation GAC/2015/9864. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015188157/302.
(150210583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
OUTLET.lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 14, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 107.441.
<i>Feststellung von Anteilsübertragungeni>
Gemäß privatschriftlichen Anteilsübertragungen, die von der Geschäftsführung genehmigt worden ist, setzt sich das
Gesellschaftskapital der OUTLET.LU S.à.r.l. nun wie folgt zusammen:
11319
L
U X E M B O U R G
Herr Steven PITMAN, wohnhaft in L-6661 Born, 11, Wangertswee: siebenhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . 700
Total:siebenhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Des Weiteren wird Dritten mitgeteilt dass die Adresse von Herrn Steven PITMAN folgendermassen lautet: in L-6661
Born, 11, Wangertswee
Luxemburg, den 3. November 2015.
Référence de publication: 2015190447/15.
(150212893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Oregonian Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 94.582.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg, le 27 octobrei>
<i>2015i>
Le siège social de la société est fixé au 10 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Monsieur Robert REGGIORI, expert-comptable, né le 15 novembre 1966 à METZ (France), et Monsieur Louis VEGAS-
PIERONI, expert-comptable, né le 26 septembre 1967 à Fameck (France), et Madame Mariagrazia RINALDI, comptable,
née le 27.02.1976 à MONOPOLI (Italie) et, demeurant tous professionnellement au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,
sont nommés nouveaux administrateurs de la société. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Sta-
tutaire de l'an 2018.
La société CUSTOM S.A., RCS Luxembourg N B124470, avec siège social au 10 boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, est nommée commissaire aux comptes pour une période de deux ans. Son mandat viendra à échéance lors de
l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2018.
Pour extrait sincère et conforme
OREGONIAN INVEST S.A.
Référence de publication: 2015190445/20.
(150212713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
P.H.S., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 9.124.197,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 180.067.
EXTRAIT
L'un des gérants de la société, à savoir Monsieur Philippe SIMON, a désormais comme adresse:
- Domaine d'Ampagnito, 207, Nosy be, Madagascar.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
<i>Pour P.H.S.
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2015190448/14.
(150213088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Praxair Holding Latinoamérica, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 133.277.795,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 174.199.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 03 Novembre 2015 que:
- La démission de Madame Ann Heidinger en tant que gérant de catégorie A de la Société a été acceptée avec effet au
06 Novembre 2015; et
- Madame Rosanne Culina, née le 17 octobre 1972 à Sault Ste Marie, Canada, demeurant professionnellement au 1 City
Centre Drive, Suite 1200, Mississauga, ON L5B 1M2, Canada a été nommée, avec effet au 06 Novembre 2015, gérant de
catégorie A, et ce pour une durée indéterminée.
11320
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Référence de publication: 2015190460/17.
(150212988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Fercol S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4577 Differdange, 77, Cité Henri Grey.
R.C.S. Luxembourg B 124.144.
Les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015190966/10.
(150213943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Paramedicus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 2, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 170.802.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire réunie en date du 28 octobre 2015i>
L'an deux mille quinze, le vingt-huit octobre, à seize heures, les actionnaires de la société PARAMEDICUS S.A.,
susvisée, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, tenue au siège social, et ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Roland François KOHL, né le 23/06/1953 à Esch-sur-Alzette, et de-
meurant à L-4396 Pontpierre, 13, Huelgaass, de son mandat d'administrateur de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée nomme comme administrateur de la société en remplacement de Monsieur Roland François KOHL, dé-
missionnaire, Monsieur Laurent MEUNIER, né le 10/05/1976 à Besançon (France), et demeurant à L-3876, Schifflange,
10, rue Caspar Mathias Spoo.
Son mandat est valable jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle devant se tenir le 01/08/2018.
Pour extrait conforme
<i>Les membres du bureaui>
Référence de publication: 2015190465/20.
(150213250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Patricia International S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 34.377.
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 15 octobre 2015, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Wolfgang Glanzner, administrateur de type B, avec adresse au 22, Seilerstätte, 1010 Vienne, Autriche
- Christian Ullrich, administrateur de type A, avec adresse au 34, Unterer Schreiberweg, 1190 Wien, Autriche
- Irmgard Ullrich, administrateur de type B, avec adresse au 5, Hornigweg, 1190 Wien, Autriche
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social
se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;
2. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes Susanne Neumann-Ullrich, avec adresse au 3A, Sichelgrund,
3443 Sieghartskirchen, Autriche, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur
les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Référence de publication: 2015190468/19.
(150213253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
11321
L
U X E M B O U R G
Pasarela, Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 125.060.
<i>Procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration tenue le 18 novembre 2015i>
Le 18 novembre 2015, le conseil d'administration a pris la résolution suivante:
1. de nommer MMS avocats, 14a, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, en tant que dépositaire des actions au porteur de
la société.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015190467/13.
(150212878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Patrizia Real Estate 32 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 165.544.
Wir teilen mit, dass Herr Arwed Fischer sein Mandat als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf des
13 November 2015 niedergelegt hat.
Wir teilen mit, das der Alleinige Anteilsinhaber am 13 November 2015 beschlossen hat Herrn Klaus Schmitt, geboren
am 21.09.1965 in Pegnitz, geschäftsansässig in Fuggerstraße, 26, D-86150 Augsburg, mit sofortiger Wirkung, als Ge-
schäftsführer der Gesellschaft zu bestellen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 25.11. 2015.
<i>Für die Gesellschaft
Ein Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2015190471/16.
(150213486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
PATRIZIA Wohnmodul I Zwischenholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 163.333.
Wir teilen mit, dass Herr Arwed Fischer sein Mandat als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf des
13 November 2015 niedergelegt hat.
Wir teilen mit, das der Alleinige Anteilsinhaber am 13 November 2015 beschlossen hat Herrn Klaus Schmitt, geboren
am 21.09.1965 in Pegnitz, geschäftsansässig in Fuggerstraße, 26, D-86150 Augsburg, mit sofortiger Wirkung, als Ge-
schäftsführer der Gesellschaft zu bestellen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 25.11.2015.
<i>Für die Gesellschaft
Ein Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2015190472/16.
(150213491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
PBA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 157.225.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 20 novembre 2015 lors de la réunion du conseil d'administration de la Sociétéi>
- La démission de M. Jérémy LEQUEUX de ses fonctions d'administrateur de la Société a été acceptée avec effet au 15
octobre 2015.
- La cooptation de Mme Alexandra DALLÜGE, employée privée, née à Siegburg (Allemagne), le 21 juin 1989, résidant
professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg avec effet au 15 octobre 2015 en tant qu'adminis-
trateur de la Société jusqu'au 29 juin 2018 a été décidée.
11322
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PBA S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015190473/16.
(150213507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
PHARMA/wHEALTH Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 45.176.
Diese Dokument dient dazu die bisher eingeschriebenen Informationen beim Luxemburger Gesellschafts- und Han-
delsregister zu aktualiseren.
- Die berufliche Adresse von Herrn Claude KREMER, Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, lautet wie folgt:
- 41A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 24. November 2015.
PHARMA/wEALTH MANAGEMENT COMPANY S.A.
Claude Kremer
<i>Director / Administrateuri>
Référence de publication: 2015190474/16.
(150212927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Entreprise de Toiture J. Zender & Cie s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 58.174.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015190928/9.
(150213259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Phisolina S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 40.391.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 4 novembre 2015 que, le professionnel du secteur
financier, la société INTERCORP S.A., 23, rue Beaumont, -1219 Luxembourg, a été nommée dépositaire des titres au
porteur émis par la société.
Luxembourg, le 4 novembre 2015.
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2015190475/15.
(150213265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Pixys S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 168.186.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 23 juillet 2015i>
L'assemblée a pris acte de la démission de la société FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A. de son mandat de commissaire
aux comptes et a décidé de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes la société SIRIUS FINANCE LIMI-
TED, avec siège social au 788¬790, Finchley Road, Londres NW11 7TJ, Royaume-Uni, immatriculée auprès du Registre
des Sociétés d'Angleterre et des Pays de Galles sous le numéro 4251093, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée
générale annuelle de 2020.
11323
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015190476/14.
(150213139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Pro-Mère S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 85.855.
<i>Extrait de la décision du conseil d'administration du 24 novembre 2015i>
Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Romain POULLES, né le 25/08/1969 à Luxembourg, résidant au 9
rue de Keispelt, L-8282 Kehlen, a été reconduit, avec effet au 13 décembre 2013, et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
PRO-MERE S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015190485/14.
(150212871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
TOCQUEVILLE FINANCE S.A., société de gestion de patrimoine familial, SPF, Société Anonyme - Société de
Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 40.783.
Le Bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015191520/11.
(150213770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Quod Bonum S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 203.004.883,00.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 193.688.
<i>Beschluss der Gesellschaft vom 14. April 2015i>
Mette Garby, 142, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg, geboren am 21. März 1962 in Hørsholm, Dänemark ernannt
wurde als ,Administrateur délégué‘. Mette Garby ist berechtigt, die Gesellschaft für das laufende Tagesgeschäft durch ihre
alleinige Unterschrift zu vertreten, und kann somit auch jegliche Bankgeschäfte in Bezug auf die Luxemburger Bankkonten
unter alleiniger Unterschrift tätigen. Dauer des Mandats: unbegrenzt.
Luxemburg, den 19. November 2015.
Référence de publication: 2015190490/14.
(150213087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Realkapital Partners Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 140.414.
Il résulte de sa lettre de démission en date du 17 février 2015 que M. Morten Kampli a démissionné en tant qu'admi-
nistrateur de la Société avec effet à compter du 28 février 2015.
Dorénavant, le conseil d'administration de la Société est constitué de:
- M. Roald Albrigtsen
- M. Marcus Kruus
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Référence de publication: 2015190494/14.
(150212659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
11324
L
U X E M B O U R G
Repco 18 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 2.396.530,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 112.979.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 5 mai 2015 ap-i>
<i>prouvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014i>
1 - Le mandat des administrateurs:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, adminis-
trateur;
3. Monsieur David BANNERMAN, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg,
administrateur
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en
décembre 2015.
2 - L'Assemblée Générale a confirmé le mandat de Monsieur David BANNERMAN statuant sur les comptes clos en 31
décembre 2014 et a pris acte de la démission de Monsieur David BANNERMAN de ses fonctions de commissaires aux
comptes de la Société.
3 - L'Assemblé Générale nomme Monsieur Johannes Raschke, né le 8 avril 1981 à Berlin (Allemagne), demeurant
professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité de commissaire aux comptes de la Société
pour l'exercice statuant sur les comptes clos en 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2015.
Référence de publication: 2015190517/26.
(150213463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Rowan California S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.025.000,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 178.266.
Il est notifié qu'en date du 03 novembre 2015, la Société a pris la décision suivante:
- transfert du siège social de la Société du 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, au 48 Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rowan California S.à r.l.
Martinus C.J. Weijermans
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2015190502/15.
(150212739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Rowan Finanz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 312.154.110,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 180.891.
Il est notifié qu'en date du 03 novembre 2015, la Société a pris la décision suivante:
- transfert du siège social de la Société du 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, au 48 Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
11325
L
U X E M B O U R G
Rowan Finanz S.à r.l.
Martinus C.J. Weijermans
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2015190503/15.
(150212738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Rowan Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 249.357.426,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 167.846.
Il est notifié qu'en date du 03 novembre 2015, la Société a pris la décision suivante:
- transfert du siège social de la Société du 46A, Avenue J.F. Kennedy L- 1855 Luxembourg, au 48 Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rowan Holdings Luxembourg S.à r.l.
Martinus C.J. Weijermans
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2015190504/15.
(150212737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Entreprise de Toiture J. Zender & Cie s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 58.174.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015190930/9.
(150213261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Rowan Offshore Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 6.025.000,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 162.526.
Il est notifié qu'en date du 03 novembre 2015, la Société a pris la décision suivante:
- transfert du siège social de la Société du 46A, Avenue J.F. Kennedy L- 1855 Luxembourg, au 48 Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rowan Offshore Luxembourg S.à r.l.
Martinus C.J. Weijermans
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2015190506/15.
(150212758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Rowan Relentless Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.025.000,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 180.893.
Il est notifié qu'en date du 03 novembre 2015, la Société a pris la décision suivante:
- transfert du siège social de la Société du 46A, Avenue J.F. Kennedy L- 1855 Luxembourg, au 48 Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
11326
L
U X E M B O U R G
Rowan Relentless Luxembourg S.à r.l.
Martinus C.J. Weijermans
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2015190507/15.
(150212675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Rowan Reliance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.025.000,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 189.379.
Il est notifié qu'en date du 03 novembre 2015, la Société a pris la décision suivante:
- transfert du siège social de la Société du 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, au 48 Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rowan Reliance Luxembourg S.à r.l.
Martinus C.J. Weijermans
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2015190508/15.
(150212744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Feedo A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 153.503.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015190965/9.
(150214316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Rowan Renaissance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.025.000,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 182.876.
Il est notifié qu'en date du 03 novembre 2015, la Société a pris la décision suivante:
- transfert du siège social de la Société du 46A, Avenue J.F. Kennedy L- 1855 Luxembourg, au 48 Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rowan Renaissance Luxembourg S.à r.l.
Martinus C.J. Weijermans
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2015190509/15.
(150212743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Rowan Resolute Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.025.000,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 189.381.
Il est notifié qu'en date du 03 novembre 2015, la Société a pris la décision suivante:
- transfert du siège social de la Société du 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, au 48 Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
11327
L
U X E M B O U R G
Rowan Resolute Luxembourg S.à r.l.
Martinus C.J. Weijermans
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2015190510/15.
(150212757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
RDC Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 430.934.923,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 167.417.
Il est notifié qu'en date du 03 novembre 2015, la Société a pris la décision suivante:
- transfert du siège social de la Société du 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, au 48 Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
RDC Holdings Luxembourg S.à r.l.
Martinus C.J. Weijermans
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2015190513/15.
(150213481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Firth Improvement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 186.829.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015190972/9.
(150213755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Medical Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 41.657.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015192115/10.
(150215353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
MH Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6190 Gonderange, 4, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 141.720.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 27/11/2015.
Référence de publication: 2015192117/10.
(150215408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
11328
Argano Overseas S.A.
Entreprise de Toiture J. Zender & Cie s.àr.l.
Entreprise de Toiture J. Zender & Cie s.àr.l.
Feedo A.G.
Fercol S.à r.l.
Firth Improvement S.à r.l.
Immo Centre Promotion S.à r.l.
Immo-Wallux S.C.I.
Logamo S.A.
Medical Soparfi S.A.
MH Concept S.à r.l.
Oregonian Invest S.A.
OUTLET.lu S.à r.l.
Paramedicus S.A.
Pasarela
Patricia International S.A., SPF
Patrizia Real Estate 32 S.à r.l.
PATRIZIA Wohnmodul I Zwischenholding S.à r.l.
PBA S.A.
PHARMA/wHEALTH Management Company S.A.
Phisolina S.A.
P.H.S.
Pixys S.A.
Pratzen S.A.
Praxair Holding Latinoamérica
Pro-Mère S.A.
Quod Bonum S.A.
RDC Holdings Luxembourg S.à r.l.
Realkapital Partners Luxembourg S.A.
Repco 18 S.A.
Rowan California S.à r.l.
Rowan Finanz S.à r.l.
Rowan Holdings Luxembourg S.à r.l.
Rowan Offshore Luxembourg S.à r.l.
Rowan Relentless Luxembourg S.à r.l.
Rowan Reliance Luxembourg S.à r.l.
Rowan Renaissance Luxembourg S.à r.l.
Rowan Resolute Luxembourg S.à r.l.
RP Residential Assembly S.à r.l.
Selmar Investments, S.à r.l., SPF
Skol Development Africa S.A.
The Independent UCITS Platform (Luxembourg) II
TOCQUEVILLE FINANCE S.A., société de gestion de patrimoine familial, SPF
United Depositary Services S.A.