logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 232

28 janvier 2016

SOMMAIRE

BFIT Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11107

Fineos International (Luxembourg) S.A.  . . . .

11090

Fineos International (Luxembourg) S.à r.l.  . .

11090

Flexitech Management S.à r.l. & Partners

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11130

Graycliff Private Equity Partners III GP S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11115

Group Money Investment Holding SA  . . . . . .

11128

Immo Invest Lux Holdco S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

11101

Mberp II (Luxembourg) 17 S.à r.l.  . . . . . . . . .

11111

Mberp II (Luxembourg) 18 S.à r.l.  . . . . . . . . .

11112

Newton Partners  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11112

NH VI Daled Management S.à r.l. & Partners

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11130

Norden Wynde S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11113

Opaline Investissements S.A. SPF  . . . . . . . . . .

11112

Opportunity Two  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11113

Pape Construction S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

11114

PCO Holdco II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11136

PCO HoldCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11136

Porto Conte S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11113

Prince & Princess S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

11128

Private Bank Funds I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11128

Pulcinella S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11129

Punto d'Oro S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11114

Pyro-Protection S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11129

Queensberry S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11129

Rapego S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11115

Rebecorp S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11129

Reskina S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11130

RoCo Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11130

Rom7 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11113

Sabadell BS Select Fund of Hedge Funds SI-

CAV (Luxembourg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11123

Sabadell Select Fund of Hedge Funds SICAV

(Luxembourg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11123

Vansan Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11114

11089

L

U X E M B O U R G

Fineos International (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Fineos International (Luxembourg) S.A.).

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 189.389.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of October.
Before us, Maître Paul BETTINGEN, notary, residing in Niederanven (Grand-Duchy of Luxembourg),

There appeared:

Mr. Marino GAROSI, Industrial, born on 6 June 1949 in Castel Goffredo (Italy), residing in Castel Goffredo, Italy,

I-46042, Strada Casaloldo, 52,

here represented by Mr. Giorgio BIANCHI, private employee, residing professionally at 26, Boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the person appearing and by the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that Mr. Marino GAROSI, prenamed is the sole current shareholder (the “Sole Shareholder”) of FINEOS INTERNA-

TIONAL (LUXEMBOURG) S.A., a public limited liability company, incorporated and existing under the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 50 route d'Esch, L - 1470 Luxembourg and registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 189389 (the “Company”), incorporated pursuant to a
deed of the undersigned notary on 31 July 2014 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2812
of 8 October 2014;

- that the Company' share capital is set at EUR 50,000 (fifty thousand Euros) divided into five thousand (5,000) shares

each with a nominal value of EUR 10 (ten Euros) per share; and

- that the agenda is as follows:
1. Conversion of the Company from a Luxembourg public limited company (Société anonyme) into a Luxembourg

private limited liability company (Société à responsabilité limitée);

2. Change of the name of the Company from “FINEOS INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.” into “FINEOS

INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l.”;

3. Allocation of the shares of the Company further to the conversion into a Société à responsabilité limitée;
4. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company including the cancellation of the

authorised capital;

5. Acknowledgement and acceptance of the resignation by the current members of the board of directors of the Company

with effect as of the date of the conversion and discharge for the exercise of their mandate;

6. Acknowledgement and acceptance of the resignation of the current internal auditor, with effect as of the date of the

conversion and discharge for the exercise of his mandate;

7. Appointment of Mr. Marino Garosi, Mr. Denis Callonego and Mrs. Audrey Petrini as managers of the Company with

effect as of the date of the conversion and for an unlimited term;

8. Miscellaneous.
Then the Sole Shareholder, exercising the power of the general meeting and declaring having previously got knowledge

of the agenda took following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to convert the Company from its original form of a Luxembourg public limited company

(société anonyme) into the form of a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), in
accordance with article 3, paragraph 5 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,
with effect as of the date hereof.

The Sole Shareholder further resolves that from an accounting and tax perspective, this conversion will be considered

as effective on the date hereof.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from “FINEOS INTERNATIONAL (LUXEM-

BOURG) S.A.” into “FINEOS INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l.”

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to convert the current five thousand (5,000) shares with a nominal value of EUR 10 (ten

Euros) per share, representing the Company‘s share capital of EUR 50,000 (fifty thousand Euros) divided into five thousand
(5,000) shares each with a nominal value of EUR 10 (ten Euros) per share.

11090

L

U X E M B O U R G

All of the new shares will be held by Mr. Marino GAROSI, prenamed.
The value of the net asset of the Company has been confirmed to the notary by an interim balance sheet of the Company

as at 30 September 2015 and a confirmation dated 27 October 2015.

This interim balance sheet and the confirmation will remain annexed to the present deed to be filed at the same time

with registration authorities.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and fully restate the articles of association of the Company in order to adapt

them to the provisions of section XII of the Luxembourg law of 10 August 1915, as amended, regarding limited liability
companies (société à responsabilité limitée), so that they shall henceforth read as follows:

“A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

“FINEOS INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l.” (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the
law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of
association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The object of the Company is (i) the holding of participations and interests in any form whatsoever in Luxembourg

and foreign companies, partnerships or other entities, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and (iii) the acquisition, ownership, administration, development, management and disposal of its portfolio. The Company
may enter into any agreements relating to the acquisition, subscription or management of the aforementioned instruments
and the financing thereof.

2.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, debentures, notes and other instruments

convertible or not.

2.3 The Company may grant assistance and lend funds to its subsidiaries, affiliated companies, to any other group

company as well as to other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which would
be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. It may also give guarantees and grant security
in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
group company as well as other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which
would be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. The Company may further mortgage,
pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

2.4 The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including the entry into any forward transactions as well as techniques and instru-
ments designed to protect the Company against credit risk, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

2.5 In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures

and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

2.6 The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to movable

or immovable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

11091

L

U X E M B O U R G

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at EUR 50,000 (fifty thousand Euros) divided into five thousand (5,000) shares

each with a nominal value of EUR 10 (ten Euros) per share.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same accounting par value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by

the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the

transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by the
surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, des-
cendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. Meetings of shareholders may be held at such place and time as may be

specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general
meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or
publication.

In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least one general meeting of shareholders shall be

held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg at the registered office of the Company or at
such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.

11092

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

shall form a board of managers.

13.2 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any

convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means

of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote.

17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.

11093

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager. The minutes

of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by the chairman pro
tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced
in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

joint signature of any two (2) managers, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such
signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20 Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))

in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the

Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators  shall  have  the  most  extensive  powers  for  the  realisation  of  the  assets  and  payment  of  the  liabilities  of  the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

11094

L

U X E M B O U R G

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the Law.”

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge and accept the resignation of the current directors of the Company, with

effect as of the date hereof.

The Sole Shareholder further resolves to grant discharge to the current directors for the exercise of their mandate as

directors of the Company until the date hereof.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge and accept the resignation of the current internal auditor of the Company

and resolves to grant discharge to it for the exercise of its mandate as internal auditor of the Company until the date hereof.

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint the following persons as managers with effect as of the date hereof and for an

unlimited period of time:

- Mr. Marino GAROSI, Industrial, born on 6 June 1949 in Castel Goffredo (Italy), residing in Castel Goffredo (Italy),

I-46042, Strada Casaloldo, 52, Italy;

-  Mr.  Denis  CALLONEGO,  Private  Employee,  born  on  4  April  1959  in  Briey  (France),  residing  professionally  in

Luxembourg, 26, Boulevard Royal (L-2449);

- Mrs. Audrey PETRINI, Private Employee, born on 22 June 1986 in Thionville (France), residing professionally in

Luxembourg, 26 Boulevard Royal (L-2449).

There being no further business, the meeting was closed.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

<i>Powers

The appearing person, acting in the same interest, does hereby grant power to any clerc and / or employee of the firm

of the undersigned notary, acting individually, in order to document and sign any deed of amendment (typing error(s)) to
the present deed.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this

deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the mandatory of the appearing party acting in the above stated capacity, known to

the notary by name, first name and residence, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Marino GAROSI, industriel, né le 6 juin 1949 à Castel Goffredo (Italie), demeurant à Castel Goffredo, Italie,

I-46042, Strada Casaloldo, 52,

ici représenté par Monsieur Giorgio BIANCHI, employé privé, demeurant au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- que Monsieur Marino GAROSI, précité est le seul associé actuel (l'«Associé Unique») de FINEOS INTERNATIONAL

(LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme existant et régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social établi
au 50 route d'Esch, L - 1470 Luxembourg immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous la section B et le numéro 189389 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 31 juillet
2014, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2812 du 8 octobre 2014;

11095

L

U X E M B O U R G

- que le capital social de la Société s'élève à EUR 50.000 (cinquante mille Euros) divisé en 5.000 (cinq mille) actions

ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros) chacune.

- que l'agenda est conçu comme suit;
1. Transformation de la Société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée
2. Changement de la dénomination sociale de la Société de “FINEOS INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.” en

“FINEOS INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l.”;

3. Allocation des parts sociales de la Société après la conversion;
4. Modification et refonte complète des statuts de la Société en ce inclus la suppression du capital autorisé;
5. Prise d'acte et acceptation de la démission des administrateurs actuels, à compter de la date de la transformation et

décharge pour l'exercice de leur mandat;

6. Prise d'acte et acceptation de la démission du commissaire aux comptes actuel de la Société, à compter de la date de

la transformation et décharge pour l'exercice de son mandat;

7. Nomination de Mr Marino Garosi, Mr Denis Callonego et Mme Audrey Petrini en tant que gérants de la Société, à

compter de la date de la transformation et pour une durée illimitée;

8. Divers.
Ensuite, l'Associé Unique, exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale et déclarant avoir eu connaissance préalable-

ment de l'ordre du jour a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de transformer la Société de sa forme d'origine de société anonyme de droit luxembourgeois

en une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe
5 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, à compter de la date de la présente.

L'Associé Unique décide ensuite que la transformation sera effective d'un point de vue comptable et fiscal à la date du

présent acte.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de changer la dénomination sociale de la Société de “FINEOS INTERNATIONAL (LU-

XEMBOURG) S.A.” en “FINEOS INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de convertir les cinq mille (5.000) actions de la Société, de valeur nominale de EUR 10 (dix

Euros) chacune et représentant le capital social de la Société de cinquante mille Euros (EUR 50.000), en cinq mille (5.000)
parts sociales de la Société, de valeur nominale de EUR 10 (dix Euros) chacune. Les nouvelles parts sociales sont détenues
intégralement par Mr. Marino GAROSI, précité.

L'actif net de la Société a été confirmé au notaire sur présentation d'un bilan intermédiaire de la Société en date du 30

septembre 2015 ainsi que d'une confirmation datée du 27 octobre 2015.

Ce bilan intermédiaire et la confirmation resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de

l'enregistrement.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de la modification et de la refonte complète des statuts de la Société pour les adapter aux

dispositions de la section XII de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés à
responsabilité limitée, pour qu'ils aient désormais la teneur suivante:

«A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom - Forme.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «FINEOS INTERNATIONAL

(LUXEMBOURG) S.à r.l» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.
2.1 L'objet de la Société est (i) la prise de participations et d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères, des partenariats (partnerships) ou d'autres entités, (ii) l'acquisition par l'achat, la souscri-
ption ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances
de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et (iii) l'acquisition, la propriété, l'administration, le déve-
loppement, la gestion et la disposition de son portefeuille. La Société peut conclure tout contrat relatif à l'acquisition, la
souscription ou la gestion des instruments précités et au financement y relatif.

2.2 La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes, de

notes et d'autres instruments convertibles ou non.

2.3 La Société peut accorder une assistance et prêter des fonds à ses filiales, sociétés affiliées, à toute autre société du

groupe ainsi qu'à toutes autres entités ou personnes, étant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui serait

11096

L

U X E M B O U R G

considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. Elle pourra également fournir des garanties
et octroyer des sûretés en faveur de parties tierces afin de garantir ses propres obligations ou bien les obligations de ses
filiales, sociétés affiliées ou toute autre société du groupe, ainsi qu'à toute autre entité ou personne pourvu que la Société
ne conclut pas une transaction qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. La
Société pourra également hypothéquer, gager, transférer, grever ou autrement hypothéquer tout ou partie de ses avoirs.

2.4 La Société peut généralement employer toute technique et utiliser tout instrument relatif à ses investissements en

vue de leur gestion efficace, y compris la conclusion de toute transaction à terme ainsi que des techniques et instruments
destinés à protéger la Société contre le risque de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et tout
autre risque.

2.5 De manière générale, elle peut accorder son assistance à des sociétés affiliées, prendre toute mesure de contrôle ou

de surveillance et mener toute opération qu'elle jugerait utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.

2.6 La Société pourra en outre réaliser toute opération commerciale ou financière, ainsi que toute transaction concernant

des biens mobiliers ou immobiliers, qui sont en rapport direct ou indirect avec son objet social.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée

selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être

transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision

du conseil de gérance.

4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique

ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale
de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à EUR 50.000 (cinquante mille Euros) divisé en 5.000 (cinq mille) actions

ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés

de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur comptable.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre

événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour

consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent être émis
sur demande et aux frais de l'associé demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant

unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à
cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession

ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après

l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

11097

L

U X E M B O U R G

7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous

réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants représentant les trois quarts des droits des survivants.
Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants,
descendants ou au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l'associé décédé.

C. Décisions des associés

Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les

présents statuts.

8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il

détient.

8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui

relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.

8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des

dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et
les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

Art. 9. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures

indiquées dans les convocations aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés
à l'assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convo-
cation ou publication préalable.

Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale des associés devra être

tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au Luxembourg au siège social de la Société ou
à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée générale.

Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés

de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital social.

Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement

unanime des associés.

Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social.

D. Gérance

Art. 13. Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société est gérée un ou plusieurs gérants. Dans l'hypothèse où la Société est gérée par plusieurs gérants, ces

gérants forment un conseil de gérance.

13.2 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute

mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par
la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.

Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine leur rémunération et la durée de leur

mandat.

14.2 Les gérants sont nommés et peuvent être librement révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une décision

des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Art. 15. Vacance d'un poste de gérant.
15.1 Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la

démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne pouvant
excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des associés
appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.

15.2 Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est

comblée sans délai par l'assemblée générale des associés.

11098

L

U X E M B O U R G

Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au

siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures

à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une
telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé
constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance
dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée
à tous les membres du conseil de gérance.

16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés

à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées
par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner

un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance.

17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,

le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.

17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme

son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du
mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres
du conseil de gérance.

17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout

autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans
discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue
au siège social de la Société.

17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente

ou représentée à une réunion du conseil de gérance.

17.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de

gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d'une voix prépondérante.

17.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera
la date de la dernière signature.

Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique. Les procès-

verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou, en son absence, par
le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux
qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par deux (2) gérants.

Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par

la signature conjointe de deux (2) gérants, ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à
laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délé-
gation.

E. Audit et surveillance

Art. 20. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
20.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront

surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la
durée de leurs fonctions.

20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.
20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69

de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.

20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif

ou avec son accord.

11099

L

U X E M B O U R G

F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le

trente-et-un décembre de la même année.

Art. 22 Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif

et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.

22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve

légale, si cet associé consent à cette affectation.

22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bé-

néfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

22.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la

Société.

Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable

intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées
à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-

formément à la Loi et aux présents statuts.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée

par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera
les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

24.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre

de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.»

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique prend acte et accepte la démission des administrateurs actuels de la Société, à compter de la date de

la présente.

L'Associé Unique décide en outre d'accorder décharge aux administrateurs actuels de la Société pour l'exercice de leur

mandat d'administrateurs de la Société jusqu'à la date de la présente.

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique décide de prendre acte et d'accepter la démission du commissaire aux comptes actuel de la Société,

à compter de la date de la présente.

L'Associé Unique décide en outre d'accorder décharge au commissaire aux comptes actuel de la Société, pour l'exercice

de son mandat de commissaire aux comptes de la Société jusqu'à la date de la présente.

<i>Septième résolution

L'Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes comme gérants de la Société, à compter de la date des

présentes et pour une durée illimitée:

- Monsieur Marino GAROSI, industriel, né le 6 juin 1949 à Castel Goffredo (Italie), demeurant à Castel Goffredo (Italie

- I-46042), Strada Casaloldo, 52, Italie;

- Monsieur Denis CALLONEGO, employé privé, né le 4 avril 1959 à Briey (France), avec adresse professionnelle à

Luxembourg, 26, Boulevard Royal (L-2449);

11100

L

U X E M B O U R G

- Madame Audrey PETRINI, employée privée, née le 22 juin 1986 à Thionville (France), avec adresse professionnelle

à Luxembourg, 26 Boulevard Royal (L-2449).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est

évalué à environ mille quatre cents Euros (EUR 1.400).

<i>Pouvoirs

La personne comparante, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé

de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de
frappe(s)) au présent acte.

Dont acte, passé à Senningerberg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande de la même partie comparante et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante es qualité qu'il agit, connu du notaire instrumentant par nom,

prénom, et résidence, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Giorgio Bianchi, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 9 novembre 2015 1LAC / 2015 / 35320. Reçu 75.-€

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 18 novembre 2015.

Référence de publication: 2015187003/611.
(150209269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Immo Invest Lux Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 186.778.

In the year two thousand fifteen, on the ninth of November.
Before the undersigned, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

OPCIMMO, a professional open-ended real estate investment fund (société de placement à preponderance immobilière

à capital variable) established under the laws of France, having its registered office at 91-93 boulevard Pasteur, 75015
Paris, France, registered with the register of commerce and companies of Paris under number 533 506 234 (the "Sole
Shareholder"),

here represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, with professional address in Junglinster, by virtue of a proxy given

on 30 October 2015.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of IMMO INVEST LUX HOLDCO S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
address at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies ("RCS") under number B 186778 and incorporated pursuant to a deed of the un-
dersigned notary, dated 16 April 2014, whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1800, page 86372, on 10 July 2014 (the "Company").
The Articles of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 27
May 2015, published in the Mémorial number 1989, page 95439, on 6 August 2015.

The appearing party representing the whole share capital requires the notary to act the following resolutions taken in

accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as
amended, pursuant to which a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general
meeting of shareholders of the company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in
writing:

11101

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Sole Shareholder decides to amend the definitions of the Class B Investment (as defined in the Articles) and the

Class C Investment (as defined in the Articles) contained in article 5.1 of the Articles, in order to amend the addresses of
the registered offices of the underlying investments, which shall now read as follows:

- "two hundred five thousand three hundred forty (205,340) class B shares (the "Class B Shares") which are entitled to

track the direct or indirect investment of the Company in Square 41 S.à r.l. (formerly RPTRE I S.à r.l.), a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg and being registered with the Luxembourg register of commerce and
companies under number B 140024 (the "Class B Investment") with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each;

- six million four hundred thousand (6,400,000) class C shares (the "Class C Shares") which are entitled to track the

direct or indirect investment of the Company in 88north I S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société
à responsabilité limitée) having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of
Luxembourg, and being registered with the RCS under number B 196840 and in 88north II S.à r.l., a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  and  being  registered  with  the  RCS  under  number  B  196839  (the  "Class  C
Investment") with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each;"

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to create one new class of shares in the share capital of the Company:
- the class D shares which are entitled to track the direct or indirect investment of the Company in ENNIS S.à r.l., a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg with its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the RCS under number B 122836.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of two million one

hundred and five thousand five hundred fifty-eight Euro (EUR 2,105,558.-) so as to bring it from its current amount of six
million eight hundred forty-eight thousand six hundred ninety Euro (EUR 6,848,690.-) to eight million nine hundred fifty-
four thousand two hundred forty-eight Euro (EUR 8,954,248.-) by creating and issuing two million one hundred and five
thousand five hundred fifty-eight (2,105,558) new class D shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the
"New Class D Shares"), each of such New Class D Shares having such rights and obligations as set forth in the Articles
and being issued with a share premium of a total amount of eighteen million two hundred forty-eight thousand one hundred
and seventy-five Euro (EUR 18,248,175.-).

<i>Subscription and payment

All the New Class D Shares are subscribed by the Sole Shareholder and fully paid up by a contribution in kind consisting

of an unquestioned and freely transferrable claim of a total amount of twenty million three hundred fifty three thousand
seven hundred thirty three Euro (EUR 20,353,733.-) (the " Contribution") out of which two million one hundred and five
thousand five hundred fifty-eight Euro (EUR 2,105,558.-) are allocated to the share capital of the Company and eighteen
million two hundred forty-eight thousand one hundred and seventy-five Euro (EUR 18,248,175.-) are allocated to the share
premium account.

The proof of the existence and of the value of the Contribution has been produced to the undersigned notary.
Further thereto, the Company's share capital of eight million nine hundred fifty-four thousand two hundred forty-eight

Euro (EUR 8,954,248.-) is represented as follows:

- twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares held by the Sole Shareholder (the "Ordinary Shares");
- two hundred thirty thousand eight hundred fifty (230,850) class A shares held by the Sole Shareholder (the "Class A

Shares");

- two hundred five thousand three hundred forty (205,340) class B shares held by the Sole Shareholder (the "Class B

Shares");

- six million four hundred thousand (6,400,000) class C shares held by the Sole Shareholder (the "Class C Shares"); and,
- two million one hundred and five thousand five hundred fifty-eight (2,105,558) class D shares held by the Sole Sha-

reholder (the "Class D Shares");

each with a nominal value of one Euro (EUR 1.-).

<i>Fourth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder decides to amend (i) article 5.1 of the Articles and (ii)

article 15 of the Articles, which shall now read as follows:

11102

L

U X E M B O U R G

5.1. The issued share capital of the Company is eight million nine hundred fifty-four thousand two hundred forty-eight

Euro (EUR 8,954,248.-) divided into:

- twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares (the "Ordinary Shares") with a nominal value of one Euro (EUR

1.-) each;

- two hundred thirty thousand eight hundred fifty (230,850) class A shares (the "Class A Shares") which are entitled to

track the direct or indirect investment of the Company in Silizium Propco S.à r.l., a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
and being registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 186795 (the "Class A
Investment") with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each;

- two hundred five thousand three hundred forty (205,340) class B shares (the "Class B Shares") which are entitled to

track the direct or indirect investment of the Company in Square 41 S.à r.l. (formerly RPTRE I S.à r.l.), a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg and being registered with the Luxembourg register of commerce and
companies under number B 140024 (the "Class B Investment") with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each;

- six million four hundred thousand (6,400,000) class C shares (the "Class C Shares") which are entitled to track the

direct or indirect investment of the Company in 88north I S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société
à responsabilité limitée) having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of
Luxembourg, and being registered with the RCS under number B 196840 and in 88north II S.à r.l., a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  and  being  registered  with  the  RCS  under  number  B  196839  (the  "Class  C
Investment") with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each; and,

- two million one hundred and five thousand five hundred fifty-eight (2,105,558) class D shares (the "Class D Shares")

which are entitled to track the direct or indirect investment of the Company in ENNIS S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its regis-
tered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under
number B 122836 (the "Class D Investment") with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each;

The Ordinary Shares, the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, and the Class D Shares are together

referred to as the "Shares".

In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed

accordingly."

15. Distributions on shares.
15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be

deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 The Class A Shares are exclusively entitled to the assets related to the Class A Investment (including the balance

of all incomes, profits or other receipts paid or due in any other manner in relation to the Class A Investment (including
capital gains, liquidation surplus and dividends distribution), minus the amount of the expenses, losses, taxes and other
transfers of funds incurred by the company and which can regularly and reasonably be attributed to the management,
operation of the Class A Investment (including fees, costs, corporate income tax on capital gain and expenses relating to
dividend distribution)).

15.3 The Class B Shares are exclusively entitled to the assets related to the Class B Investment (including the balance

of all incomes, profits or other receipts paid or due in any other manner in relation the Class B Investment (including capital
gains, liquidation surplus and dividends distribution), minus the amount of the expenses, losses, taxes and other transfers
of funds incurred by the company and which can regularly and reasonably be attributed to the management, operation of
the Class B Investment (including fees, costs, corporate income tax on capital gain and expenses relating to dividend
distribution)).

15.4 The Class C Shares are exclusively entitled to the assets related to the Class C Investment (including the balance

of all incomes, profits or other receipts paid or due in any other manner in relation the Class C Investment (including capital
gains, liquidation surplus and dividends distribution), minus the amount of the expenses, losses, taxes and other transfers
of funds incurred by the company and which can regularly and reasonably be attributed to the management, operation of
the Class C Investment (including fees, costs, corporate income tax on capital gain and expenses relating to dividend
distribution)).

15.5 The Class D Shares are exclusively entitled to the assets related to the Class D Investment (including the balance

of all incomes, profits or other receipts paid or due in any other manner in relation the Class D Investment (including capital
gains, liquidation surplus and dividends distribution), minus the amount of the expenses, losses, taxes and other transfers
of funds incurred by the company and which can regularly and reasonably be attributed to the management, operation of
the Class D Investment (including fees, costs, corporate income tax on capital gain and expenses relating to dividend
distribution)).

15.6 All other distribution will be made to the holders of the Ordinary Shares.

11103

L

U X E M B O U R G

15.7 The losses incurred by the Company in relation to one of its investments are subtracted from the amount attached

to the class of shares of such investment (whether profits, profits carried forward or the part representing the share capital).
If the losses exceed the amount attached to such class of shares, this excess will be borne by the other classes of shares pro
rata of their participation in the share capital. These provisions do not segregate the assets of the Company into compartments
enforceable in relation to third parties.

15.8 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder

(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits
since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by
carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles
and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant
Shareholder(s)."

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by

reason of the present deed are assessed to six thousand two hundred fifty Euro (EUR 6,250.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,

followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.

Whereof, the present deed is drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by her name, first name,

civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

L'an deux mille quinze, le neuf novembre.
Par-devant le soussigné Maître Jean SECKLER, notaire résidant à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU

OPCIMMO, une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable établie selon les lois de France,

ayant son siège social au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France, immatriculée auprès du registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro 533 506 234 (l'"Associé Unique"),

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, résidant à Junglinster, en vertu d'une procuration délivrée le

30 octobre 2015;

Ladite procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

attachée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de IMMO INVEST LUX HOLDCO S.à r.l., une société à responsabilité

limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
("RCS") sous le numéro B 186778, et constituée par un acte notarié du notaire soussigné, en date du 16 avril 2014, dont
les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1800,
page 86372, en date du 10 juillet 2014 (la "Société"). Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par
un acte notarié du notaire soussigné, en date du 27 mai 2015, publié au Mémorial numéro 1989, page 95439, en date du 6
août 2015.

La partie comparante, représentant l'ensemble du capital social requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes prises

conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915,
telle que modifiée, selon lesquelles l'associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'as-
semblée générale des associés de la société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès verbal
ou rédigées par écrit:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier les définitions des Investissement de Catégorie B (comme défini dans les Statuts)

et Investissement de Catégorie C (comme défini dans les Statuts) repris à l'article 5.1 des Statuts, afin de modifier les
adresses des sièges sociaux des investissements sous-jacents, lesquels auront la teneur suivante:

- deux cent cinq mille trois cent quarante (205.340) parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B"):

les Parts Sociales de Catégorie B financent des actifs spécifiques directs ou indirects de la Société dans Square 41 S.à r.l.
(anciennement RPTRE I S.à r.l.), une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140024 (l'"Investissement de Catégorie B")
ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

11104

L

U X E M B O U R G

- six millions quatre cent mille (6.400.000) parts sociales de catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C"): les Parts

Sociales de Catégorie C financent des actifs spécifiques directs ou indirects de la Société dans 88north I S.à r.l., une société
à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 196840 et 88north II S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois
du Grand- Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché
de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 196839
(l'"Investissement de Catégorie C") ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de créer une nouvelle catégorie de parts représentant le capital social de la Société:
- les parts sociales de catégorie D qui financent des actifs spécifiques directs ou indirects de la Société dans ENNIS S.à

r.l. une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6C,
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand- Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du RCS sous le numéro B
122836.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux millions cent cinq mille cinq

cent cinquante-huit euros (EUR 2.105.558,-) afin de le porter de son montant actuel de six millions huit cent quarante-huit
mille six cent quatre-vingt-dix euros (EUR 6.848.690,-) à huit millions neuf cent cinquante-quatre mille deux cent quarante-
huit euros (EUR 8.954.248,-) en créant et en émettant deux millions cent cinq mille cinq cent cinquante-huit (2.105.558)
nouvelles parts sociales de catégorie D ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts
Sociales de Catégorie D"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D ayant les droits et obligations prévus
par les Statuts et étant émises avec une prime d'émission d'une valeur totale de dix-huit millions deux cent quarante-huit
mille cent soixante-quinze euros (EUR 18.248.175,-).

<i>Souscription et libération

Les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D sont souscrites et entièrement libérées par l'Associé Unique par un apport

en nature consistant en une créance incontestable et librement transférable de vingt millions trois cent cinquante-trois mille
sept cent trente-trois euros (EUR 20.353.733,-) (la "Contribution") dont deux millions cent cinq mille cinq cent cinquante-
huit euros (EUR 2.105.558,-) sont alloués au capital social de la Société et dix-huit millions deux cent quarante-huit mille
cent soixante-quinze euros (EUR 18.248.175,-) sont alloués au compte de primes d'émission.

La preuve de l'existence et de la valeur de la Contribution a été produite par devant le notaire instrumentant.
Suite aux résolutions prises ci-dessus, l'Associé Unique décide que le capital social de la Société d'un montant de huit

millions neuf cent cinquante-quatre mille deux cent quarante-huit euros (EUR 8.954.248,-) sera divisé comme suit:

- douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires");
- deux cent trente mille huit cent cinquante (230.850) parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie

A");

- deux cent cinq mille trois cent quarante (205.340) parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B");
- six millions quatre cent mille (6.400.000) parts sociales de catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C"); et,
- deux millions cent cinq mille cinq cent cinquante-huit (2.105.558) parts sociales de catégorie D (les "Parts Sociales

de Catégorie D");

chacune ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier (i) l'article 5.1 des Statuts et (ii) l'article

15 des Statuts, qui se liront dorénavant comme suit:

5.1. Le capital social de la Société est fixé à huit millions neuf cent cinquante-quatre mille deux cent quarante-huit

euros (EUR 8.954.248,-) divisé en:

- douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires") ayant chacune une valeur

nominale d'un euro (EUR 1,-);

- deux cent trente mille huit cent cinquante (230.850) parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie

A"): les Parts Sociales de Catégorie A financent des actifs spécifiques directs ou indirects de la Société dans Silizium
Propco S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186795 (l'"Investissement de Catégorie A") ayant chacune
une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-);

- deux cent cinq mille trois cent quarante (205.340) parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B"):

les Parts Sociales de Catégorie B financent des actifs spécifiques directs ou indirects de la Société dans Square 41 S.à r.l.

11105

L

U X E M B O U R G

(anciennement RPTRE I S.à r.l.), une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140024 (l'"Investissement de Catégorie B")
ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

- six millions quatre cent mille (6.400.000) parts sociales de catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C"): les Parts

Sociales de Catégorie C financent des actifs spécifiques directs ou indirects de la Société dans 88north I S.à r.l., une société
à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 196840 et 88north II S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché
de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 196839
(l'"Investissement de Catégorie C") ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-); et

- deux millions cent cinq mille cinq cent cinquante-huit (2.105.558) parts sociales de catégorie D (les "Parts Sociales

de Catégorie D"): les Parts Sociales de Catégorie D financent des actifs spécifiques directs ou indirects de la Société dans
ENNIS S.à r.l. une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du RCS sous le
numéro B 122836 (l'"Investissement de Catégorie D") ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

Les Parts Sociales Ordinaires, les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de

Catégorie C, et les Parts Sociales de Catégorie D sont ensemble dénommées les "Parts Sociales".

Dans les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associé" doit

être interprété conformément."

15. Distributions sur les actions.
15.1 Du bénéfice net de la Société déterminé conformément au droit luxembourgeois, cinq pour cent seront déduits et

alloués à une réserve légale. Cette déduction cessera d'être obligatoire dès lors que ladite réserve légale atteint un dixième
du capital nominal de la Société.

15.2 Les Parts Sociales de Catégorie A donnent exclusivement droit aux actifs liés à l'Investissement de Catégorie A

(incluant le solde de tous les revenus, profits ou autres reçus payés ou dus de quelque manière que ce soit à la Société en
relation avec l'Investissement de Catégorie A (y compris les gains en capital, surplus à la liquidation et distribution de
dividendes), moins le montant des dépenses, pertes, impôts et autres transferts de fonds réalisés par la Société et qui peuvent
être régulièrement et raisonnablement attribués à la gestion et au fonctionnement de l'Investissement de Catégorie A (y
compris les honoraires, coûts, impôt sur les sociétés sur les gains et les dépenses relatives à la distribution de dividendes)).

15.3 Les Parts Sociales de Catégorie B donnent exclusivement droit aux actifs liés à l'Investissement de Catégorie B

(incluant le solde de tous les revenus, profits ou autres reçus payés ou dus de quelque manière que ce soit à la Société en
relation avec l'Investissement de Catégorie B (y compris les gains en capital, surplus à la liquidation et distribution de
dividendes), moins le montant des dépenses, pertes, impôts et autres transferts de fonds réalisés par la Société et qui peuvent
être régulièrement et raisonnablement attribués à la gestion et au fonctionnement de l'Investissement de Catégorie B (y
compris les honoraires, coûts, impôt sur les sociétés sur les gains et les dépenses relatives à la distribution de dividendes)).

15.4 Les Parts Sociales de Catégorie C donnent exclusivement droit aux actifs liés à l'Investissement de Catégorie C

(incluant le solde de tous les revenus, profits ou autres reçus payés ou dus de quelque manière que ce soit à la Société en
relation avec l'Investissement de Catégorie C (y compris les gains en capital, surplus à la liquidation et distribution de
dividendes), moins le montant des dépenses, pertes, impôts et autres transferts de fonds réalisés par la Société et qui peuvent
être régulièrement et raisonnablement attribués à la gestion et au fonctionnement de l'Investissement de Catégorie C (y
compris les honoraires, coûts, impôt sur les sociétés sur les gains et les dépenses relatives à la distribution de dividendes)).

15.5 Les Parts Sociales de Catégorie D donnent exclusivement droit aux actifs liés à l'Investissement de Catégorie D

(incluant le solde de tous les revenus, profits ou autres reçus payés ou dus de quelque manière que ce soit à la Société en
relation avec l'Investissement de Catégorie D (y compris les gains en capital, surplus à la liquidation et distribution de
dividendes), moins le montant des dépenses, pertes, impôts et autres transferts de fonds réalisés par la Société et qui peuvent
être régulièrement et raisonnablement attribués à la gestion et au fonctionnement de l'Investissement de Catégorie D (y
compris les honoraires, coûts, impôt sur les sociétés sur les gains et les dépenses relatives à la distribution de dividendes)).

15.6 Toutes les autres distributions seront faites aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires.
15.7 Les pertes réalisées par la Société dans le cadre de l'un des investissements viennent d'abord en déduction des

sommes attachées à la catégorie de parts sociales (qu'il s'agisse de profits, profits reportés ou de la part représentant le
capital social) à laquelle cet investissement est rattaché. Si les pertes excèdent les sommes rattachées à la catégorie de parts
sociales en question, ces pertes excédentaires viendront greffer les autres catégories de parts au pro rata de leur participation
dans le capital. Les présentes clauses ne créent pas une ségrégation des avoirs de la Société opposable aux tiers.

15.8 Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance comme il convient le cas échéant peut décider de payer des dividendes

intérimaires à l'Associé/aux Associés avant la fin de l'exercice sur base d'un relevé de comptes indiquant que des fonds
suffisants sont disponibles pour une distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut dépasser, le cas
échéant, les bénéfices réalisés depuis la fin de l'exercice précédent, augmenté des bénéfices reportés et des réserves dis-

11106

L

U X E M B O U R G

tribuables, mais diminué par les pertes reportées et les montants à allouer à une réserve à établir d'après la Loi de 1915 ou
les présents Statuts, et que (ii) toute somme distribuée qui ne correspond pas aux bénéfices effectivement réalisés peut être
récupérée auprès de l'Associé/des Associés concerné(s)."

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ six mille deux cent cinquante euros (EUR 6.250,-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé

en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Junglinster, à la date figurant en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence,

le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 novembre 2015. Relation GAC/2015/9664. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015185923/328.
(150207765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

BFIT Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 201.546.

STATUTES

In the year two thousand fifteen, on the eleventh day of the month of November.
Before us Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr René MOOS, residing at 50, Kasteellei, 2930 Brasschaat, Belgium,
duly represented by Mr Philippe PONSARD, “ingénieur commercial”, residing professionally at 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal dated 30 October 2015.
Said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to draw up the following articles

of a limited liability company to be incorporated.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.
The name of the company is BFIT Holding.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the
control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way  whatever,  any  type  of  securities  and  patents,  realise  them  by  way  of  sale,  transfer,  exchange  or  otherwise,  have
developed these securities and patents.

The company may, within the limits of the law, borrow in any form whatever. The company may grant to the companies

of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of 10 August
1915.

The company may also acquire, sell, manage and promote all sorts of real estate located in the Grand Duchy of Lu-

xembourg or abroad.

11107

L

U X E M B O U R G

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or

indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) divided into

12,500 (twelve thousand five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial

Companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer to non-members may only

be done in accordance with the law on Commercial Companies.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to

pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by one or several managers who need not to be members and who are appointed

by the general meeting of members.

Towards third parties the managers have the most extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances.
The company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole manager or by the joint signatures

of any two managers if more than one manager has been appointed.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the law on Com-

mercial Companies.

Art. 15. The business year begins on 1 

st

 January and ends on 31 December of each year.

Art. 16. Every year on 31 December, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution

will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the corporate capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be

members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,

pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of
the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant legislation.

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2016.

<i>Subscription and payment

The 12,500 (twelve thousand five hundred) corporate units have been entirely subscribed by the sole member, Mr René

MOOS, prenamed.

All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR

12,500 (twelve thousand five hundred Euros) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on Commercial Companies

of 18 September 1933 have been fulfilled.

11108

L

U X E M B O U R G

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

EUR 1,400 (one thousand four hundred euro).

<i>Resolutions of the sole member

The sole member, prenamed, represented as mentioned above, representing the whole of the corporate capital, passed

the following resolutions:

<i>First resolution

Are appointed managers, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:
1. Mr Philippe PONSARD, «ingénieur commercial», born on 16 March 1967 in Arlon (Belgium), residing professionally

at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

2. Mr Pierre LENTZ, «licencié en sciences économiques», born on 22 April 1959 in Luxembourg, residing professionally

at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

3. Mr Reno Maurizio TONELLI, «licencié en sciences politiques», born on 12 January 1955 in Cesena (Italy), residing

professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers are elected for an unlimited period.

<i>Second resolution

The company's registered office is located at 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the proxy holder of the appearing party, known to

the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with us, Notary, the present original
deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mil quinze, le onze novembre.
Par devant Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur René MOOS, demeurant au 50, Kasteellei, 2930 Brasschaat, Belgique,
ici représenté par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration sous seing privé donnée en date du 30 octobre 2015.
La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une

société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les

dispositions légales.

La société prend la dénomination de BFIT Holding.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute

11109

L

U X E M B O U R G

autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets.

Elle pourra, dans les limites de la loi, emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par

la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se

rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq

cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que

dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des

associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir sous leur signature individuelle au nom

de la société dans toutes les circonstances.

A l'égard des tiers, la société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique ou par la signature conjointe

de deux gérants si plus d'un gérant a été nommé.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales

qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est

une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les
articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2016.

<i>Souscription et paiement

Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique, Monsieur René

MOOS, prénommé.

11110

L

U X E M B O U R G

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le  notaire  instrumentant  a  constaté  que  les  conditions  prévues  par  l'article  183  des  lois  sur  les  sociétés  (loi  du  18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.400 (mille quatre cents

euros).

<i>Résolutions de l'associé unique

L'associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérants, avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts:
1. Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, né le 16 mars 1967 à Arlon, Belgique, demeurant profession-

nellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

2. Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

3. Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, né le 12 janvier 1955 à Cesena (Italie), demeurant

professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat des gérants est établi pour une durée illimitée.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par noms, prénoms, états

et demeures, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Ponsard, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 16 novembre 2015. GAC/2015/9832. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 19 novembre 2015.

Référence de publication: 2015186833/219.
(150209435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Mberp II (Luxembourg) 17 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 188.203.

Il convient de noter que Monsieur Walter TOCCO, Gérant, réside désormais professionnellement à l'adresse suivante:
- 12C, Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

11111

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 20 novembre 2015.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015188762/14.
(150210851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Newton Partners, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 179.647.

<i>Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 6 novembre 2015:

Le Conseil d'Administration prend note et accepte la démission de Monsieur Gérald de Roquemaurel de son poste

d'administrateur avec effet au 29/09/2015.

Le Conseil d'Administration prend note et accepte également la démission de Monsieur Jean-François Court de son

poste d'administrateur avec effet au 29/10/2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2015.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2015188801/15.
(150210986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Mberp II (Luxembourg) 18 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 188.205.

Il convient de noter que Monsieur Walter TOCCO, Gérant, réside désormais professionnellement à l'adresse suivante:
- 12C, Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2015.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015188763/14.
(150210861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Opaline Investissements S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 53.437.

Lors de l'Assemblée Générale du 19 novembre 2015, les décisions suivantes ont été prises:
- Les démissions de Mr Luc BRAUN de sa fonction d'administrateur, d'administrateur-délégué et de Président, de Mr

Jean-Marie POOS de de sa fonction d'administrateur et d'administrateur-délégué, et de FIDESCO S.A. de sa fonction
d'administrateur sont acceptées.

- Sont nommés administrateurs jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31.03.2017:
* Henri APPELSTEIN, né à Liège le 09.02.1955, dirigeant de sociétés, demeurant 4, Marouxdreef, B-8300 Westkapelle;
* Jacques APPELSTEIN, né à Liège le 12.09.1957, dirigeant de sociétés, demeurant 4, avenue Henri Elleboudt, B-1180

Bruxelles;

* Stephan JEGER, né à Wilrijk le 17.03.1961, dirigeant de sociétés, demeurant 9, Coudenbeghlaan, B-2290 Edegem.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2015188818/18.
(150211359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

11112

L

U X E M B O U R G

Norden Wynde S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 173.417.

L'adresse professionnelle des administrateurs B, A&amp;C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée

et Ingrid Hoolants, est fixée au Building Serenity - Bloc A, 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen à partir du 19 octobre
2015.

L'adresse professionnelle de Madame Maryse Mouton, la gérante et représentante permanente de la société A&amp;C MA-

NAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B127330, est fixée au
Building Serenity - Bloc A, 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen à partir du 19 octobre 2015

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015188807/14.
(150210807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Opportunity Two, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 111-115, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 138.966.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 20 novembre 2015.

Référence de publication: 2015188813/10.
(150211258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Rom7 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 119.537.

Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,

et par décision du Conseil d'Administration en date du 20 novembre 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SER-
VICES S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxem-
bourg sous le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions
au porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 20 novembre 2015.

<i>Pour: ROM7 S.A.
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015188875/16.
(150211232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Porto Conte S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 167.083.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015188829/14.
(150211164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

11113

L

U X E M B O U R G

Vansan Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 149.368.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 octobre 2015

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de:
- Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, dont le représentant

permanent est Mr Luigi MAULA, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg,

- Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg,
- Pieter VAN NUGTEREN, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg
- Lucas VANDERSANDEN, demeurant Leeuwerikweg 54, B-3140 Keerbergen,
- Gerard HUYBRECHTS, administrateur de sociétés, demeurant Teichmannstraat 2, B-2018 Antwerpen
Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui se tiendra en 2021.
L'Assemblée renouvelle également le mandat du commissaire aux comptes Co-Ventures SA, ayant son siège social 40,

avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée qui se tiendra en 2021.

Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015189024/22.
(150211406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Punto d'Oro S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 24, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 136.317.

Le siège social de la société est transféré, avec effet immédiat, de L-1870 Luxembourg 121, rue de Kohlenberg à L-2227

Luxembourg 24, avenue de la Porte-Neuve.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 Novembre 2015.

Punto D'oro S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.
Signature

Référence de publication: 2015188835/14.
(150210413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Pape Construction S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6925 Flaxweiler, 27A, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 186.066.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 21/10/2015

L'an deux mille quinze, le vingt-et-un octobre
A Differdange, à 18.30 heures.
L'assemblée générale extraordinaire a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
1) Monsieur Zlatan SUSIC, employé privé, né le 14 janvier 1971 à Zavidovici (Bosnie Herzégovine), ayant son domicile

au 4, Kraizenheicht L-6225 Altrier au Luxembourg, détenteur de 45 parts sociales sur un total de 100 parts sociales acquiert
55 parts sociales de Monsieur Fadil DACIC, gérant technique de la Société, né le 30 mars 1961 à Rozaje (Monténégro)
ayant son domicile au 34, Rue de la Gare, 34, L-3771 Tétange au Luxembourg détenteur de 55 parts de la Société.

2) Monsieur Fadil DACIC, précité, démissionne de ses fonctions de gérant technique
3) Monsieur Zlatan SUSIC, précité, est nommé le gérant et associé unique de la Société et détenteur de 100 parts sociales

sur un total de 100 parts sociales.

Plus rien d'autre n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée et de tout ce qui

précède, le présent procès-verbal est dressé et signé par les comparants, date qu'en tête des présentes.

DONT ACTE.

11114

L

U X E M B O U R G

Rédigé en trois exemplaires originaux, dont les personnes soussignées reconnaissent chacune avoir reçu un exemplaire

original dûment signé, le troisième exemplaire original étant destiné au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg
(RCSL).

Zlatan SUSIC / Fadil DACIC.

Référence de publication: 2015188840/25.
(150211293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Rapego S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 121.157.

<i>Décision de l'actionnaire unique du 20 novembre 2015

Monsieur Filip Volders, né le 18 juillet 1968 à Schoten (B), résident professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086

Luxembourg, est nommé comme administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée gé-
nérale qui se tiendra en 2019.

SGG S.A.
F. Lanners / Christiaan van Houtven
<i>Company Secretary / Administrateur

Référence de publication: 2015188879/15.
(150210494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Graycliff Private Equity Partners III GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 201.548.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the sixth day of the month of November.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

GRAYCLIFF PRIVATE EQUITY PARTNERS III GP LLC, a limited liability company formed and existing under the

laws of the State of Delaware of the United States of America, having its registered office in the State of Delaware at 2711
Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, 19808, United States of America,

here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, professionally residing at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Lu-

xembourg, Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a proxy given under private seal in New York, United States of
America on October 19 

th

 , 2015.

The proxy given, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this

deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in its capacity, has requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a “société

à responsabilité limitée” which it intends to incorporate in Luxembourg:

Art. 1. Denomination. There exists among the shareholders and all persons who will become shareholders thereafter a

private  limited  liability  company  (société  à  responsabilité  limitée)  with  the  name  “GRAYCLIFF  PRIVATE  EQUITY
PARTNERS III GP S.A.R.L.” (the “Company”). The Company will be governed by these articles of association and the
relevant legislation.

Art. 2. Object. The Company's corporate object is to act as general partner (associé commandité gérant) of one or several

limited partnership(s) governed by Luxembourg laws and incorporated under the legal form of a special limited partnership
(société en commandite spéciale), a common limited partnership (société en commandite simple) or a corporate partnership
limited by shares (société en commandite par actions).

The Company may carry on any activities which are useful for the accomplishment of its corporate object.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the municipality of Niederanven, in the Grand Duchy

of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

11115

L

U X E M B O U R G

an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the sole manager or as

the case may be the board of managers.

The Company may establish offices and branches, both in Luxembourg and abroad by resolution of the sole manager

or as the case may be the board of managers.

In the event that the sole manager or as the case may be the board of managers should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such
temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer
of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any
interested parties by the sole manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500)

divided into one hundred and twenty-five (125) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each. The
capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required
for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its own shares upon
resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five percent (75%)
of the Company's capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-

holders. In the case of one manager, the manager constitutes the “sole manager,” and in the case of more than one manager,
the managers constitute a “board of managers.”

The sole manager or as the case may be the board of managers is vested with the broadest powers to manage the business

of the Company and to authorize and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or these articles of association to the general meeting of shareholders
shall be within the competence of the sole manager or as the case may be the board of managers. Vis-à-vis third parties the
sole manager or as the case may be the board of managers has the most extensive powers to act on behalf of the Company
in all circumstances and to do, authorize and approve all acts and operations relating to the Company not reserved by law
or these articles of association to the general meeting of shareholders or as may be provided herein.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-

holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.

The board of managers may choose from among its members a chairman. The board of managers shall meet upon call

by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings
of shareholders and the board of managers, but in his absence the shareholders or managers may appoint another manager
as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for
a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company

(including by way of representation). In the event that at any meeting the number of votes for and against a resolution shall
be equal, the chairman shall have a casting vote. The minutes of the board meeting are signed by the chairman.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by facsimile or e-mail or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular

11116

L

U X E M B O U R G

resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager
or any person appointed by the board of managers for this purpose.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any

manager or any person appointed by the board of managers for this purpose, or as may be resolved at the relevant meeting
or a subsequent meeting.

The Company will be bound by (i) the sole signature of its sole manager, (ii) in the case of a board of managers, the

joint signature of any two managers or (iii) the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers
shall have been delegated by the board of managers.

The sole manager or as the case may be the board of managers may delegate its powers to conduct the daily management

and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to officers
of the Company who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily
management and affairs of the Company and such designated committees to effectively conduct the business of the Com-
pany. The designated committees may not bind the Company towards third parties. Any such appointment may be revoked
at any time by the manager(s). Officers or members of the designated committees need not to be managers or shareholders
of the Company. The officers and the members of the designated committees appointed, unless otherwise stipulated in
these articles of association, shall have the powers and duties given to them by the manager(s) in accordance with applicable
laws and regulations.

Art. 8. Personal Interest and Liability of the Managers. No contract or other transaction between the Company and any

other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the
Company is interested in, or is a director, manager, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any manager or officer of the Company who serves as a director, manager, officer or employee of any company or firm

with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business.

In the event that any manager or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company, such manager or officer shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider
or vote upon any such transaction, and such transaction and such manager's or officer's interest therein shall be reported to
the next succeeding meeting of shareholders. The term "personal interest" as used in the preceding sentence, shall not
include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving Graycliff Partners LP or any
subsidiary or any affiliate thereof or such other company or entity as may from time to time be determined by the sole
manager or as the case may be by the board of managers in its discretion.

The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are

responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgments, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence,

fraud or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the

board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defense of any claim, action, suit or proceeding of

the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this Article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. Each shareholder has a number

of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

11117

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed

by Luxembourg company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice in the forms provided by law at least eight (8) days prior to the date of the

meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed

in  the  register  of  shareholders  held  by  the  Company  at  least  eight  (8)  days  before  the  proposed  effective  date  of  the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions  (or  subject  to  the  satisfaction  of  the  majority  requirements,  on  the  date  set  out  therein).  Unanimous  written
resolutions may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting of shareholders shall be validly adopted

if approved by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first
meeting or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However,
decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y)
representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company
are to be taken by shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on 31 

st

 December of the

same year.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the sole

manager, or in case of plurality of managers, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the sole

manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, showing that sufficient funds are available for distri-
bution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last
accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried
forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to Article 179 (2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the “1915 Law”); in this case, Articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the 1915 Law.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on December 31 

st

 , 2016.

<i>Subscription and payment

The subscriber has subscribed for the number of shares and has paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Founding Shareholder

Subscribed

Capital

Number

of Shares

GRAYCLIFF PRIVATE EQUITY PARTNERS III GP LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500

125

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500

125

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

11118

L

U X E M B O U R G

<i>Statements

The undersigned notary states that the conditions provided for in Articles 182 and 183 of the 1915 Law have been

observed.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder has forthwith immediately taken the following resolutions:

<i>First resolution

The registered office of the Company is fixed at 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Second resolution

The following persons are appointed managers for an unlimited period of time:
- GRAYCLIFF PRIVATE EQUITY PARTNERS III GP LLC, having its registered office in the State of Delaware at

2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, 19808, United States of America;

- Mr Stephen C. HINDMARCH, having its professional address at 500 Fifth Avenue, 47 

th

 FI., New York, NY 10110,

United States of America; and

- Mr James W. MARLEY, having its professional address at 500 Fifth Avenue, 47 

th

 FI., New York, NY 10110, United

States of America.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person the present deed is worded in English, followed by a French version, on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le six novembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

GRAYCLIFF PRIVATE EQUITY PARTNERS III GP LLC, une société à responsabilité limitée constituée et existant

selon les lois de l'état du Delaware, aux États-Unis d'Amérique, ayant son siège social dans l'état du Delaware, au 2711
Centerville Road, Suite 400, dans la ville de Wilmington, Comté de New Castle, 19808, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé le 19 octobre
2015.

La procuration donnée, signée «ne varietur» par la personne comparante et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte afin d'être soumise aux formalités de l'enregistrement.

Cette partie comparante, agissant ès-qualités, a requis le notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée qu'elle entend constituer à Luxembourg:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé par les associés et toutes les personnes qui deviendront par la suite associés, une

société  à  responsabilité  limitée  sous  la  dénomination  de  «GRAYCLIFF  PRIVATE  EQUITY  PARTNERS  III  GP
S.A.R.L.» (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts ainsi que les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet d'agir en tant qu'associé commandité gérant d'une ou de plusieurs sociétés en

commandite régies par le droit luxembourgeois et constituées sous la forme juridique d'une société en commandite spéciale,
d'une société en commandite simple, ou d'une société en commandite par actions.

La Société peut effectuer toute opération utile à la réalisation de son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxem-

bourg. Le siège social peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de
l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues pour les modifications statutaires.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par décision du gérant ou, le cas échéant, du

conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales, tant au Luxembourg qu'à l'étranger par décision du gérant ou, le

cas échéant, du conseil de gérance.

Dans le cas où le gérant, ou le cas échéant, le conseil de gérance estimerait que des évènements extraordinaires d'ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre les activités normales de la Société au siège social ou la com-

11119

L

U X E M B O U R G

munication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social peut être transféré
provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront
aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert provisoire de son siège social, demeurera une société
luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance des parties intéressées par le gérant,
ou le cas échéant, le conseil de gérance.

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) divisé

en cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune. Le capital de la Société
peut être augmenté ou réduit par une résolution adoptée par les associés selon les modalités requises pour la modification
des présents statuts et la Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales sur résolution de ses associés.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf disposition contraire

de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément des associés représentant au moins soixante-
quinze pour cent (75 %) du capital de la Société.

Art. 7. Gérance de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Au cas où il y aurait un

gérant, le gérant constitue le «gérant unique» et au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un «conseil
de gérance».

Le gérant, ou le cas échéant, le conseil de gérance est doté des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la

Société et pour autoriser et/ou accomplir tous les actes de disposition et d'administration relevant de l'objet social de la
Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale
des associés relèveront de la compétence du gérant, ou le cas échéant, du conseil de gérance. À l'égard des tiers, le gérant,
ou le cas échéant, le conseil de gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances pour le
compte de la Société ainsi que pour effectuer, autoriser et approuver tous les actes et toutes les opérations qui se rapportent
à la Société et ne sont pas réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés ou conformément
aux dispositions des présents statuts.

Les  gérants  sont  nommés  et  révoqués  par  l'assemblée  générale  des  associés,  qui  statue  à  la  majorité  simple  et  qui

détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucune durée n'est indiquée, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motif (ad
nutum) et ce, à tout moment.

Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens

similaires de communication permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres
et de communiquer entre elles. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique.
La participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à cette
réunion ou à la tenue en personne de cette réunion. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un
autre gérant et ce, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil de gérance se réunira sur convocation

du président, ou de deux gérants, à l'endroit indiqué dans la convocation de la réunion. Le président présidera toutes les
assemblées des associés et toutes les réunions du conseil de gérance, mais en son absence, les associés ou les gérants
pourront nommer un autre gérant comme président pro tempore par un vote de la majorité présente à cette assemblée ou
réunion.

Un avis de convocation écrit doit être transmis aux gérants pour chaque réunion du conseil de gérance au moins vingt-

quatre (24) heures avant la date prévue de la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut toutefois être passé outre à cet avis de convocation si chaque gérant
donne son assentiment par écrit, courriel ou télécopie, ou par tout autre moyen similaire de communication. Il n'est pas
obligatoire de remettre un avis de convocation spécial pour toute réunion du conseil devant se tenir à une heure et un lieu
déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l'approbation de la majorité des gérants de la Société

(y compris par voie de représentation). Dans le cas où lors d'une réunion, le nombre de votes pour et le nombre de votes
contre une résolution sont égaux, le président aura une voix prépondérante. Les procès-verbaux des réunions du conseil
sont signés par le président.

Le conseil de gérance peut également et ce, à l'unanimité, adopter des résolutions sur un ou plusieurs documents simi-

laires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par télécopie ou courriel, ou tout autre moyen similaire
de communication. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment signés faisant foi de la résolution intervenue.
Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi ou un extrait de
celles-ci pourra être émis sous la signature individuelle de chaque gérant ou de toute personne nommée à cet effet par le
conseil de gérance.

11120

L

U X E M B O U R G

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient servir en justice ou ailleurs seront signés par un gérant ou

toute personne nommée à cet effet par le conseil de gérance, ou tel que décidé à la réunion en question ou lors d'une réunion
ultérieure.

La Société sera engagée par (i) la seule signature du gérant unique, (ii) dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature

conjointe de deux gérants ou (iii) la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront
été délégués par le conseil de gérance.

Le gérant unique ou le cas échéant le conseil de gérance peut déléguer ses pouvoirs de gestion journalière des affaires

de la Société ainsi que ses pouvoirs visant à accomplir les actes relevant de la politique et de l'objet social de la Société,
aux fondés de pouvoir de la Société qui auront tous les pouvoirs pour agir au nom de la Société concernant tout ce qui a
trait à la gestion journalière des affaires de la Société et ces comités désignés pour diriger de fait l'activité de la Société.
Les comités désignés ne peuvent pas engager la Société envers des tiers. Une telle nomination peut être révoquée à tout
moment par le(s) gérant(s). Les fondés de pouvoir ou membres des comités désignés ne doivent pas nécessairement être
gérants ou associés de la Société. Les fondés de pouvoirs et les membres des comités désignés nommés, sauf stipulation
contraire dans les présents statuts, auront les pouvoirs et les obligations qui leur auront été conférés par le(s) gérant(s)
conformément aux lois et règlementations applicables.

Art. 8. Intérêt personnel et responsabilité des gérants. Aucun contrat ou aucune autre transaction conclu(e) entre la

Société et une autre société ou entreprise ne sera affecté(e) ou invalidé(e) par le fait qu'un ou que plusieurs gérant(s) ou
fondé(s) de pouvoir de la Société aurai(en)t un intérêt dans, ou serai(en)t dirigeant(s), gérant(s), associé(s), fondé(s) de
pouvoir ou employé(s) de cette autre société ou entreprise.

Tout gérant ou fondé de pouvoir de la Société, qui est dirigeant, gérant, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou

entreprise avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne sera, en raison de sa position dans
cette autre société ou entreprise, empêché de délibérer, de voter ou d'agir sur quelque matière que ce soit en rapport avec
ce contrat ou cette autre affaire.

Dans le cas où un gérant ou fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société,

ce gérant ou fondé de pouvoir devra en informer le conseil de gérance et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur
cette opération, et un rapport devra être fait sur cette opération et l'intérêt de ce gérant ou fondé de pouvoir dans celle-ci à
l'assemblée des associés suivante. Le terme «intérêt personnel» tel qu'employé dans la phrase précédente, n'inclut aucun
rapport avec ou intérêt dans quelque matière, position ou transaction que ce soit impliquant Graycliff Partners LP ou toute
filiale ou tout affilié de celle-ci ou toute autre société ou entité déterminée de temps à autre par le gérant unique ou le cas
échéant par le conseil de gérance à sa discrétion.

Les gérants ne sont pas tenus personnellement responsables des dettes de la Société. En tant que représentants de la

Société, ils sont responsables de l'exécution de leur mandat.

Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou a été, gérant ou fondé de

pouvoir de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité
encourue et pour toutes les dépenses raisonnables contractées ou payées par elle dans le cadre d'une demande, action,
poursuite ou procédure dans laquelle elle est impliquée en tant que partie ou autrement en vertu de son mandat présent ou
passé de gérant ou fondé de pouvoir et pour les sommes payées ou engagées par elle dans le cadre de leur règlement. Les
termes «demande», «action», «poursuite» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, poursuites ou
procédures (civiles, pénales ou autres, y compris les procédures d'appel) actuelles ou éventuelles et les termes «responsa-
bilité» et «dépenses» comprendront et ce, de manière non limitative, les honoraires d'avocats, frais, jugements, montants
payés dans le cadre d'une transaction et toutes autres responsabilités.

Aucune indemnisation ne sera due à un gérant ou fondé de pouvoir:
(i) en cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir,

de mauvaise foi, de négligence grave, de fraude ou absence grave d'attention dans l'exécution des obligations découlant de
sa fonction;

(ii) dans le cadre d'une affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans

l'intérêt de la Société; ou

(iii) en cas de transaction, à moins que celle-ci n'ait été approuvée par une juridiction compétente ou par le conseil de

gérance.

Le droit à indemnisation prévu par les présentes est divisible, n'affectera aucun autre droit dont un gérant ou fondé de

pouvoir pourrait bénéficier actuellement ou ultérieurement, subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant
ou fondé de pouvoir et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les dis-
positions des présentes n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y
compris les dirigeants et fondés de pouvoir, en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

Les dépenses relatives à la préparation et la représentation d'une défense dans le cadre de toute demande, action, poursuite

ou procédure de la nature décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision définitive sur
la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du dirigeant ou fondé
de pouvoir de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation aux termes du
présent article.

11121

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Chaque associé dispose

d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées
des associés par l'intermédiaire d'un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Assemblées générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et à la/aux majorité(s) prévues

par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où la loi le permet) ou lors d'assemblées.
Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution écrite valable (le cas échéant)
représente l'ensemble des associés de la Société.

Les assemblées seront convoquées par un avis de convocation dans les formes prévues par la loi au moins huit (8) jours

avant la date de l'assemblée. Si l'intégralité du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée peut
être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions écrites, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite dans

le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions. Les
résolutions prendront effet après approbation de la majorité tel que prévu par la loi en matière de décisions collectives (ou
sous réserve du respect des conditions de majorité, à la date y précisée). Les résolutions écrites unanimes peuvent être
adoptées à tout moment et ce, sans convocation préalable.

Sauf disposition contraire de la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale des associés seront valablement adoptées

si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix exprimées, quelle que soit la portion
du capital représentée. (ii) Cependant, les décisions portant sur la modification des statuts sont prises par (x) la majorité
des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions portant sur le changement de
nationalité de la Société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100 %) du capital social émis.

Art. 11. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la

même année.

Art. 12. Comptes annuels. Chaque année à la fin de l'année sociale, le gérant unique, ou dans le cas d'une pluralité de

gérants, le conseil de gérance établit les comptes annuels.

Les comptes annuels sont mis à la disposition des associés au siège social de la Société.

Art. 13. Distributions. Il est prélevé, sur les bénéfices nets, cinq pour cent (5 %) affectés à la constitution d'une réserve

légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social émis de
la Société.

Les associés peuvent décider de verser des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable préparé par le gérant

unique, ou dans le cas d'une pluralité de gérants, le conseil de gérance, duquel il apparaît que des fonds suffisants sont
disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés
depuis la fin du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves et primes distribuables
mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés sur décision d'une assemblée générale des associés.

La prime d'émission peut être distribuée aux associés sur décision d'une assemblée générale des associés. L'assemblée

générale des associés peut décider d'allouer tout montant issu de la prime d'émission à la réserve légale.

Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs

liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rému-
nérations.

Art. 15. Associé unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre

ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»); dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la
même loi sont applicables.

Art. 16. Droit applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies expressément par les présents statuts seront réglées

conformément à la Loi de 1915.

<i>Dispositions Transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2016.

<i>Souscription et paiement

Le souscripteur a souscrit au nombre de parts sociales et a payé en numéraire les montants indiqués ci-après:

11122

L

U X E M B O U R G

Associé fondateur

Capital

souscrit

nombre

de parts
sociales

GRAYCLIFF PRIVATE EQUITY PARTNERS III GP LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500.- EUR

125

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500.- EUR

125

Preuve de ces paiements a été donnée au notaire soussigné.

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison

de sa constitution, sont estimés à environ mille quatre cents euros (1.400.- EUR).

<i>Déclarations

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues aux articles 182 et 183 de la Loi de 1915 ont été observées.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique a immédiatement pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social de la Société est fixé au 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Seconde résolution

Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:
- GRAYCLIFF PRIVATE EQUITY PARTNERS III GP LLC, ayant son siège social dans l'état du Delaware, au 2711

Centerville Road, Suite 400, dans la ville of Wilmington, Comté de New Castle, 19808, Etats-Unis d'Amérique;

- Monsieur Stephen C. HINDMARCH, ayant son adresse professionnelle au 500 Fifth Avenue, 47 

th

 FI., New York,

NY 10110, Etats-Unis d'Amérique; et

- Monsieur James W. MARLEY, ayant son adresse professionnelle au 500 Fifth Avenue, 47 

th

 FI., New York, NY

10110, Etats-Unis d'Amérique.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française, sur demande de la même partie comparante et
en cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du document à la personne comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et résidence,

ladite personne comparante a signé le présent acte original avec Nous, notaire.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 16 novembre 2015. Relation: 2LAC/2015/25807. Reçu soixante-quinze

euros Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Référence de publication: 2015187048/460.
(150209369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Sabadell Select Fund of Hedge Funds SICAV (Luxembourg), Société d'Investissement à Capital Variable,

(anc. Sabadell BS Select Fund of Hedge Funds SICAV (Luxembourg)).

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 123.767.

In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of November.
Before us Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the “Meeting”) of Sabadell BS Select Fund of Hedge Fund SICAV

(Luxembourg) (the “Company”), a public limited company with registered office in Luxembourg qualifying as an invest-
ment company with variable share capital within the meaning of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective
investment, incorporated by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, dated 12 January 2007,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 99 dated 2 February 2007.

11123

L

U X E M B O U R G

The Meeting was opened at twelve o'clock under the chairmanship of Géraldine Astgen, professionally residing in

Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Carla Portillo, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Céline Labarsouque, professionally residing in Luxembourg.
After the constitution of the board of the Meeting, the chairman declared and requested the notary to record that:
I. The names of the shareholders present at the Meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders

represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the
shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the Meeting and the notary.
The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be initialled “ne
varietur” by the members of the board of the Meeting and by the notary and shall be attached in the same way to this
document and registered therewith.

II. With regard to the items of the agenda, a quorum of at least one half of the capital is required by article 67-1 (2) of

the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the “Law of 1915”) and the resolution
on these items of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds (2/3) of the votes cast in the
Meeting.

III. The agenda of the present Meeting is the following:

<i>Agenda

1. Change of the Company's name into “Sabadell Select Fund of Hedge Funds SICAV (Luxembourg)” and subsequent

amendments to article 1 of the Articles;

2. Amendment of article 1 with reference to the Company's registration with the Commission de Surveillance du Secteur

Financier as internally managed below threshold alternative investment fund.

3. Replacement of the reference to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment (the “2002

Law”) by a reference to the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the “2010 Law”) and
subsequent amendments to articles 4, 21, 26 and 31 of the Articles;

4. Amendment of article 10 of the Articles (i) by deleting paragraphs 3, 4, 5 and 6 of item (4) therein and (ii) by adding

to the first paragraph of article 10 the following disclosure:

“More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm

or corporate body, which does not qualify as “FATCA Eligible Investor”, as defined in the prospectus of the Company
(such person, firm or corporate body being herein covered by the aforementioned term of “Prohibited Persons”).”;

5. Replacement of the reference to “U.S. person” by a reference to “Prohibited Person” and subsequent amendments to

articles 6 and 10 of the Articles;

6. Amendment of article 31 with reference to the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers; and
7. Miscellaneous.
IV. The Meeting was convened by registered mail to the shareholders containing the agenda sent on 6 November 2015.
V. It appears from the attendance list that out of 35,558.6470 outstanding shares of the Company, 35,558.6470 shares

are present or represented at the present Meeting.

As a consequence, 100 % of all shares being present or represented, the Meeting is validly constituted and may resolve

on all the items of the agenda.

The extraordinary general Meeting takes unanimously the following resolutions:

<i>First Resolution

The shareholders of the Company (the “Shareholders”) RESOLVE to change the corporate name of the Company to

“Sabadell Select Fund of Hedge Funds SICAV” and to subsequently amend article 1 of the Articles, so that it shall henceforth
be enforced and read as follows:

“ Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares

hereafter issued, a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable share
capital ("société d'investissement à capital variable") under the name of "Sabadell Select Fund of Hedge Funds SICAV
(Luxembourg)" (hereinafter the "Company").”

<i>Second Resolution

The Shareholders RESOLVE to add the following disclosure to article 1 of the Articles:
“The Company is registered with the Commission de Surveillance du Secteur Financier as an internally managed below

threshold alternative investment fund.”

<i>Third Resolution

The Shareholders RESOLVE to replace the reference to the Luxembourg law of 20 December 2002 on undertakings

for collective investment by a reference to the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective
investment (the “2010 Law”) in articles 4, 21, 26 and 31 of the Articles, which henceforth read as follows:

11124

L

U X E M B O U R G

“ Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities as well as

in other assets and financial instruments authorized by law with the aim of spreading investment risks and affording its
shareholders the results of the management of its assets.

The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and

development of its purpose to the largest extent permitted under the law of 17 December 2010 on undertakings for collective
investment (the "2010 Law").”

“ Art. 21. Auditor. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an auditor

("réviseur d'entreprises agréé", the "Auditor") appointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the
Company.

The Auditor shall fulfil all duties prescribed by the 2010 Law.”

“ Art. 26. Custodian. To the extent required by law, the Company will enter into a custody agreement with a banking

or saving institution as defined by the law of April 5, 1993 on the financial sector, as amended (herein referred to as the
"Custodian").

The Custodian shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the 2010 Law.
If the Custodian desires to retire, the Board of Directors shall use its best endeavours to find a successor custodian within

two months of the effectiveness of such retirement. The directors may terminate the appointment of the Custodian but shall
not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed to act in the place thereof.”

“ Art. 31. Applicable. Law All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and the 2010 Law as such laws have been or may be amended from time to
time.”

<i>Fourth Resolution

The Shareholders RESOLVE to amend article 10 of the Articles (i) by deleting paragraphs 3, 4, 5 and 6 of item (4) of

article 10 and (ii) by adding to the first paragraph of article 10 the following disclosure:

“More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm

or corporate body, which does not qualify as “FATCA Eligible Investor”, as defined in the prospectus of the Company
(such person, firm or corporate body being herein covered by the aforementioned term of “Prohibited Persons”).”

<i>Fifth resolution

The Shareholders RESOLVE to replace the reference to the “U.S. person” by a reference to “Prohibited Person” in

articles 6 and 10 of the Articles, which henceforth read as follows:

“ Art. 6. Form of Shares.
(1) The Board of Directors shall determine whether the Company shall issue shares in bearer and/or in registered form.

If bearer share certificates are to be issued, they will be issued in such denominations as the Board of Directors shall
prescribe and shall provide on their face that they may not be transferred to any Prohibited Person (as defined in Article
10 hereinafter).

All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by

the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of
each owner of record of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of
registered shares held by the owner of record and the amount paid up on each fractional share.

The inscription of the shareholder's name in the register of shares evidences the shareholder's right of ownership on such

registered shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the shareholder
or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding. Global certificates may also be issued
at the discretion of the Board of Directors.

If bearer shares are issued, registered shares may be converted into bearer shares and bearer shares may be converted

into registered shares at the request of the holder of such shares. A conversion of registered shares into bearer shares will
be effected by cancellation of the registered share certificate, if any, representation that the transferee is not a”Prohibited
Person” and issuance of one or more bearer share certificates in lieu thereof, and an entry shall be made in the register of
shareholders to evidence such cancellation. A conversion of bearer shares into registered shares will be effected by can-
cellation of the bearer share certificate, and, if applicable, by issuance of a registered share certificate in lieu thereof, and
an entry shall be made in the register of shareholders to evidence such issuance. At the option of the board of directors, the
costs of any such conversion may be charged to the shareholder requesting it.

Before shares are issued in bearer form and before registered shares shall be converted into bearer shares, the Company

may require assurances satisfactory to the board of directors that such issuance or conversion shall not result in such shares
being held by a "Prohibited Person".

Share certificates shall be signed by two directors. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile.

However, one of such signatures may be made by a person duly authorized thereto by the Board of Directors; in the latter

11125

L

U X E M B O U R G

case, it shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the Board of Directors may
determine.

(2) If bearer shares are issued, transfer of bearer shares shall be effected by delivery of the relevant share certificates.

Transfer of registered shares shall be effected (i) if share certificates have been issued, upon delivering the certificate or
certificates representing such shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company
and (ii) if no share certificates have been issued, by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of
shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act
therefore. Any transfer of registered shares shall be entered into the register of shareholders; such inscription shall be signed
by one or more directors or officers of the Company or by one or more other persons duly authorized thereto by the Board
of Directors.

(3) Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Company with an address to which all notices

and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered

into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company,
or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another address shall be provided
to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change the address as entered into the register of
shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be
set by the Company from time to time.

(4) If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that the shareholder's share certificate has been

mislaid, mutilated or destroyed, then, at the shareholder's request, a duplicate share certificate may be issued under such
conditions and guarantees, including but not restricted to a bond issued by an insurance company, as the Company may
determine. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share
certificate in replacement of which the new one has been issued shall become void.

Mutilated share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.
The Company may, at its election, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new share certificate and all

reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection with
the annulment of the original share certificate.

(5) The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership

of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such
share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise of all rights attached
to such shares.

(6) The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be

entitled to participate in the net assets attributable to the relevant class of shares on a pro-rata basis.”

“ Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares. The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the

Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the
Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the
Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise
incurred (such persons, firms or corporate bodies to be determined by the Board of Directors being herein referred to as
"Prohibited Persons"). More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by
any person, firm or corporate body, which does not qualify as “FATCA Eligible Investor”, as defined in the prospectus of
the Company (such person, firm or corporate body being herein covered by the aforementioned term of “Prohibited Per-
sons”).

For such purposes the Company may:
A.- decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry or

transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and

B.- at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares on

the register of shareholders, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for
the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests in a Prohibited Person,
or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and

C.- decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of shareholders of the Company; and
D.- where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is

a beneficial owner of shares, direct such shareholder to sell his shares and to provide to the Company evidence of the sale
within thirty (30) days of the notice. If such shareholder fails to comply with the direction, the Company may compulsorily
redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:

(1)  The  Company  shall  serve  a  second  notice  (the  "purchase  notice")  upon  the  shareholder  holding  such  shares  or

appearing in the register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased
as aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser.

Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed

to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall

11126

L

U X E M B O U R G

thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates, if any, representing the shares
specified in the purchase notice.

Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to be

the owner of the shares specified in such notice; in the case of registered shares, his name shall be removed from the register
of shareholders, and the certificate or certificates representing such registered shares will be cancelled.

(2) The price at which each such share is to be purchased (the "purchase price") shall be an amount based on the net

asset value per share of the relevant class as at the Valuation Day specified by the Board of Directors for the redemption
of shares in the Company next preceding the date of the purchase notice or next succeeding the surrender of the share
certificate or certificates representing the shares specified in such notice, whichever is lower, all as determined in accordance
with Article 8 hereof, less any service charge provided therein.

(3) Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency

fixed by the Board of Directors for the payment of the redemption price of the shares of the relevant class and will be
deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase
notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the share certificate or certificates specified
in such notice and unmatured dividend coupons attached thereto. Upon service of the purchase notice as aforesaid such
former owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the Company or its assets
in respect thereof, except the right to receive the purchase price (without interest) from such bank following effective
surrender of the share certificate or certificates as aforesaid. Any redemption proceeds receivable by a shareholder under
this paragraph, but not collected within a period of five years from the date specified in the purchase notice, may not
thereafter be claimed and shall revert to the relevant class or classes of shares. The Board of Directors shall have power
from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorize such action on behalf of the Company.

(4) The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any

case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any purchase notice, provided in such case the
said powers were exercised by the Company in good faith.

"Prohibited Person" as used herein does neither include any subscriber to shares of the Company issued in connection

with the incorporation of the Company while such subscriber holds such shares nor any securities dealer who acquires
shares with a view to their distribution in connection with an issue of shares by the Company.”

<i>Sixth Resolution

The Shareholders RESOLVE to amend article 31 of the Articles, which henceforth reads as follows:

“ Art. 31. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, and the 2010 Law and the law of 12 July 2013 on alternative investment
fund managers, as such laws have been or may be amended from time to time.”

There being no further item on the Agenda, the Meeting is closed.

<i>Expenses

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company

incurs or for which it is liable by reason of the present amendments, is approximately one thousand three hundred Euro
(EUR 1,300.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the Meeting, the members of the board of the Meeting, all of whom are known to

the notary by their names, family names, civil status and residences, signed together with us, the notary, the pre-sent original
deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Signé: G. ASTGEN, C. PORTILLO, C. LABARSOUQUE, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 17 novembre 2015. Relation: DAC/2015/19417. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 18 novembre 2015.

Référence de publication: 2015187314/234.

(150209016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

11127

L

U X E M B O U R G

Group Money Investment Holding SA, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 49.453.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 19 novembre 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société:

- Société anonyme GROUP MONEY INVESTMENT HOLDING SA, en liquidation volontaire, inscrite au RCS de

Luxembourg sous le n° B 49 453, dont le siège social à L-2560 Luxembourg, 16, rue de Strasbourg, a été dénoncé en date
du 11 décembre 1995,

Le même jugement a nommé Juge-Commissaire Madame Anita LECUIT, premier juge au tribunal d'Arrondissement

de et à Luxembourg, et désigné comme liquidateur Maître Emilie MELLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-4170
Esch-sur-Alzette, 24, Bd Kennedy.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 10 décembre 2015 au greffe du Tribunal

de commerce.

Pour extrait conforme
Emilie MELLINGER
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2015189456/2.
(150211809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.

Prince &amp; Princess S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 19, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 170.369.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 20 novembre 2015.

Référence de publication: 2015188854/10.
(150211253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Private Bank Funds I, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 114.378.

<i>Extrait des Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 Juillet 2015

Composition du Conseil d'Administration:
- L'Assemblée a décidé de réélire Messieurs Jacques Elvinger, Benoît Dumont, Alain Feis et Jean Fuchs en tant qu'Ad-

ministrateurs de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l'année
comptable se terminant le 31 Mars 2016.

- L'Assemblée a décidé de réélire PricewaterhouseCoopers Société Coopérative) en tant que réviseur d'entreprise jusqu'à

la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l'année comptable se terminant le 31 Mars
2016.

Au 24 avril 2015, le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- M. ELVINGER Jacques (Président du Conseil d'Administration)
- M. DUMONT Benoît
- M. FEIS Alain
- M. FUCHS Jean
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 Août 2015.

Private Bank Funds I
Au nom et pour le compte de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2015188855/25.
(150210425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

11128

L

U X E M B O U R G

Pulcinella S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 87, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 50.295.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015188858/10.
(150210272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Pyro-Protection S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 106.893.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015188860/10.
(150210453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Queensberry S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 67.420.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue Extraordinairement le 18 novembre 2015 que:
- Monsieur Vincent WILLEMS, né le 30 septembre 1975 à Liège (Belgique), demeurant professionnellement au 10, rue

Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur David RAVIZZA, admi-
nistrateur démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2021.
- Les mandats de Madame Valérie RAVIZZA, en qualité d'administrateur et Président, de Monsieur Alfredo SERICA,

en qualité d'administrateur, ainsi que celui de la société SER.COM S.à r.l., B117942, en qualité de commissaire aux comptes
ont été reconduits.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2021.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 18 novembre 2015.

Référence de publication: 2015188863/19.
(150210714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Rebecorp S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 47.716.

Par jugement rendu en date du 19 novembre 2015, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, statuant par un jugement par défaut à l'égard de la société concernée, a ordonné en vertu
de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société
anonyme REBECORP S.A.H., inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B 47716, avec siège social à Luxembourg,
13, rue Aldringen, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita LECUIT, premier juge au tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg et désigné liquidateur Me Isabelle PETRICIC-WELSCHEN, avocat, demeurant à Wickrange.

Il ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs

créances avant le 10 décembre 2015.

Il ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Il met les frais à charge de la société, sinon, en cas d'absence ou d'insuffisance d'actif, à charge du Trésor.

11129

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme
Me Isabelle PETRICIC- WELSCHEN
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2015188884/21.
(150211212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

RoCo Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.256,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25c, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 168.337.

<i>Résolution du Conseil de gérance

Le Conseil de gérance de la Société a décidé par la présente de transférer le siège social de la Société du 231 Val des

Bons Malades L-2121 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg au 25c, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-
duché de Luxembourg, et ce à compter du 15 octobre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

À Luxembourg, le 15 octobre 2015.

Référence de publication: 2015188878/14.
(150210395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Reskina S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 198.795.

Il est porté à la connaissance de tiers que, suite à un contrat de cession de parts sociales en date du 25 août 2015, la

société Samollie S.à r.l. a cédé les 100 parts sociales qu'elle détenait dans la société Reskina S.à r.l. à Hagag-Gaya Holding
B.V. ayant pour adresse professionnelle au Schiphol Boulevard 347, 1118 BJ, Amsterdam, The Netherlands.

Luxembourg, le 12 Novembre 2015.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015188873/14.
(150210419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Flexitech Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. NH VI Daled Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.).

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 198.936.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh of October.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of the corporate partnership limited by shares established and

existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name “NIH VI Daled Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.” (he-
reinafter, the Company), with registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 198936, incorporated pursuant to a deed
of the undersigned notary, dated July 14, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under
number 2554, dated September 19, 2015, and whose articles of incorporation have never been amended since.

The meeting is chaired by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, having her professional address at 13, route

de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Marisa GOMES employee, with professional address at 13, route de Luxem-

bourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Marisa GOMES, employee, with professional address at 13, route de Luxembourg,

L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to state that:

11130

L

U X E M B O U R G

The shareholders present or duly represented by virtue of two (2) proxies given on October 23, 2015 and the number of

their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned
notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.

As appears from said attendance list, one hundred percent (100%) of the Company's share capital, presently set at thirty-

one thousand Euro (EUR 31.000,00), are present or represented at the present general meeting so that the meeting can
validly decide on all the items of its agenda.

<i>Agenda

I. Change of name of the Company from “NIH VI Daled Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.” to “Flexitech Mana-

gement S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.”.

II. Subsequent amendment of article 1 of the Company's articles of incorporation, which shall henceforth read as follows:

“ Art. 1. There exists a partnership limited by shares under the name of “Flexitech Management S.à r.l. &amp; Partners

S.C.A.”, which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by
the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles
of association (hereinafter, the Articles) and by any securityholders agreement which may be entered into from time to
time between the Company's Shareholders (the Securityholders Agreement).”

III. Acknowledgment of the change of name of the Company's general partner from “NIH VI Daled Management S.à

r.l.” to “Flexitech Management S.à r.l.”.

IV. Conversion of the currency of the share capital of the Company from Euro (EUR) to United States Dollar (USD).
V. Subsequent conversion of the share capital of the Company from thirty-one thousand Euro (EUR 31.000,00) to thirty-

four thousand one hundred thirty-four United States Dollars (USD 34.134,00) represented by thirty-four hundred one
hundred thirty-three (34.133) ordinary shares and one (1) management share, all with a nominal value of one United States
Dollar (USD 1,00) each, based on the exchange rate as at October 27, 2015 of one Euro (EUR 1,00) for one dot one zero
one one United States Dollars (USD 1,1011), it being noted that the remaining amount of ten cents of United States Dollars
(USD 0,10) resulting from the conversion shall be allocated to the legal reserve account of the Company.

VI. Reallocation of the shares of the Company to the shareholders as follows:

Shares of one Euro

(EUR 1,00) each held

before the share capital

conversion

Shares of one United Sta-

tes Dollar (USD 1,00)

each held after the share

capital conversion

Neuheim VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.998 ordinary shares

34.132 ordinary shares

Flexitech Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 ordinary share

1 management share

1 ordinary share

1 management share

VII. Increase of the Company's share capital by an amount of ten thousand United States Dollar (USD 10.000,00) to

bring it from its current amount of thirty-four thousand one hundred thirty-four United States Dollars (USD 34.134,00) to
forty-four thousand one hundred thirty-four United States Dollars (USD 44.134,00) by creation and issuance of ten thousand
(10.000) ordinary shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1,00) each (the New Shares), vested with
the same rights and obligations as the existing ordinary shares (the New Shares Issuance).

VIII. Subscription by Neuheim VI S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) esta-

blished and existing under Luxembourg law, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand
Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) and registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 183355 for the New Shares (the Subscription), and full
payment  thereof  in  the  total  amount  of  ten  thousand  United  States  Dollar  (USD  10.000,00)  in  kind,  consisting  in  the
conversion of a receivable held by Neuheim VI S.à r.l., prenamed, towards the Company in the same amount, which
receivable is incontestable, payable and due (the Conversion).

IX. Subsequent amendment of article 5 paragraphs 1 and 5 of the Company's articles of incorporation, which shall

henceforth read as follows:

“ Art. 5. Paragraph 1. The Company's share capital is set at forty-four thousand one hundred thirty-four United States

Dollars (USD 44.134,00) represented by the following shares:

- forty-four thousand one hundred thirty-three (44.133) ordinary shares with a nominal value of one United States Dollar

(USD 1,00) each (the LP Shares); and

- one (1) management share with a nominal value of one United States Dollar (USD 1,00) (hereinafter, the Management

Share).”

“ Art. 5. Paragraph 5. The Management Share shall be held by Flexitech Management S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) established and existing under Luxembourg law, having its registered office at
1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies under number B 198821, as shareholder with unlimited liability and manager (hereinafter, the Manager).”

11131

L

U X E M B O U R G

X. Acknowledgment of the report issued by BJNP Audit, a private limited liability company (société à responsabilité

limitée) established and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 59, rue des Aubépines,
L-1145 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies register
under number B 171737, independent auditor, in relation with the New Shares Issuance, which report concludes as follows
(the Independent Auditor Report):

<i>Conclusion

“Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the Contributed

Assets does not correspond at least to the number and the nominal value of the shares to be issued in counterpart.”

<i>Resolutions

I. The meeting resolves to change the name of the Company from “NIH VI Daled Management S.à r.l. &amp; Partners

S.C.A.” to “Flexitech Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.”.

II. The meeting resolves to amend article 1 of the Company's articles of incorporation, which shall henceforth read as

follows:

“ Art. 1. There exists a partnership limited by shares under the name of “Flexitech Management S.à r.l. &amp; Partners

S.C.A.”, which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by
the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles
of association (hereinafter, the Articles) and by any securityholders agreement which may be entered into from time to
time between the Company's Shareholders (the Securityholders Agreement).”

III. The meeting resolves to acknowledge the change of name of the Company's general partner from “NIH VI Daled

Management S.à r.l.” to “Flexitech Management S.à r.l.”.

IV. The meeting resolves to convert the currency of the share capital of the Company from Euro (EUR) to United States

Dollar (USD).

V. The meeting resolves to convert the share capital of the Company from thirty-one thousand Euro (EUR 31.000,00)

to thirty-four thousand one hundred thirty-four United States Dollars (USD 34.134,00) represented by thirty-four hundred
one hundred thirty-three (34.133) ordinary shares and one (1) management share, all with a nominal value of one United
States Dollar (USD 1,00) each, based on the exchange rate as at October 27, 2015 of one Euro (EUR 1,00) for one dot one
zero one one United States Dollars (USD 1,1011), it being noted that the remaining amount of ten cents of United States
Dollars (USD 0,10) resulting from the conversion shall be allocated to the legal reserve account of the Company (the
Conversion).

VI. The meeting resolves to reallocate the shares of the Company to the shareholders as follows:

Shares of one Euro

(EUR 1,00) each held

before the Conversion

Shares of one United Sta-

tes Dollar (USD 1,00)

each held after the

Conversion

Neuheim VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.998 ordinary shares

34.132 ordinary shares

Flexitech Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 ordinary share

1 management share

1 ordinary share

1 management share

VII. The meeting resolves to increase the Company's share capital by an amount of ten thousand United States Dollar

(USD 10.000,00) to bring it from its current amount of thirty-four thousand one hundred thirty-four United States Dollars
(USD 34.134,00) to forty-four thousand one hundred thirty-four United States Dollars (USD 44.134,00) by creation and
issuance of ten thousand (10.000) ordinary shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1,00) each (the
New Shares), vested with the same rights and obligations as the existing ordinary shares (the New Shares Issuance).

VIII. Neuheim VI S.à r.l., prenamed resolves to subscribe for the New Shares (the Subscription), and to fully pay them

up in the total amount of ten thousand United States Dollar (USD 10.000,00) in kind, consisting in the conversion of a
receivable held by Neuheim VI S.à r.l., prenamed, towards the Company in the same amount, which receivable is incon-
testable, payable and due (the Conversion).

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given to the undersigned notary by:
i. a balance sheet dated as of October 27, 2015 of Neuheim VI S.à r.l., prenamed, certified “true and correct” by one of

its authorised representative;

ii. a contribution declaration from Neuheim VI S.à r.l., prenamed, annexed hereto; and
iii. the report annexed hereto and issued in accordance with article 32-1 (5) of the law on commercial companies,

established by BJNP Audit, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 59, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B 171737, independent
auditor, in relation with the New Shares Issuance, which report concludes as follows, and is here annexed (the Independent
Auditor Report):

11132

L

U X E M B O U R G

<i>Conclusion

“Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the Contributed

Assets does not correspond at least to the number and the nominal value of the shares to be issued in counterpart.”

IX. Following the above resolutions, the meeting resolves to amend article 5 paragraphs 1 and 5 of the Company's articles

of association, which shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. Paragraph 1. The Company's share capital is set at forty-four thousand one hundred thirty-four United States

Dollars (USD 44.134,00) represented by the following shares:

- forty-four thousand one hundred thirty-three (44.133) ordinary shares with a nominal value of one United States Dollar

(USD 1,00) each (the LP Shares); and

- one (1) management share with a nominal value of one United States Dollar (USD 1,00) (hereinafter, the Management

Share).”

“ Art. 5. Paragraph 5. The Management Share shall be held by Flexitech Management S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) established and existing under Luxembourg law, having its registered office at
1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies under number B 198821, as shareholder with unlimited liability and manager (hereinafter, the Manager).”

X. The meeting resolves to acknowledge the Independent Auditor Report.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the

appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the date first written above.
The document having been read to the members of the bureau and the proxy holder of the appearing persons, who are

known to the notary by their full name, civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-sept octobre.
Par-devant Nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions établie et existant au Grand-

Duché de Luxembourg sous la dénomination «NIH VI Daled Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.» (ci-après, la Société),
ayant son siège social au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 198936, constituée par acte du notaire soussigné,
en date du14 juillet 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2554, en date du 19 septembre
2015, et dont les statuts constitutifs n'ont jamais été amendés depuis.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, ayant son adresse profes-

sionnelle au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Ms. Marisa GOMES, employée, ayant son adresse professionnelle au 13, route

de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Ms. Marisa GOMES, employée, ayant son adresse professionnelle au 13, route

de Luxembourg, L-4761 Pétange, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
Les actionnaires présents ou dûment représentés en vertu de deux (2) procurations données le 23 octobre 2015, et le

nombre de leurs actions sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le
notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises
avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Il appert de cette liste de présence que cent pourcent (100%) du capital social de la Société, actuellement fixé à trente-

et-un mille Euro (EUR 31.000,00), est présent ou représenté à la présente assemblée générale, de sorte que l'assemblée
peut valablement délibérer sur tous les points portés à son ordre du jour.

<i>Ordre du jour

I. Changement de nom de la Société de «NIH VI Daled Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.» en «Flexitech Mana-

gement S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.».

II. Modification consécutive de l'article 1 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

11133

L

U X E M B O U R G

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société en commandite par actions sous la dénomination de «Flexitech Management S.à r.l.

&amp; Partners S.C.A.», qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-
après, les Statuts) et par tout pacte de détenteur de titres qui serait entré en vigueur entre les actionnaires le cas échéant (Le
Pacte de Détenteur de Titres).»

III. Prise de connaissance du changement de nom de l'associé commandité de la Société de «NIH VI Daled Management

S.à r.l.» en «Flexitech Management S.à r.l.».

IV. Conversion de la devise du capital social de la Société de l'Euro (EUR) au Dollar Américain (USD).
V. Conversion consécutive du capital social de la Société de trente-et-un mille Euro (EUR 31.000,00) à trente-quatre

mille cent trente-quatre Dollars Américains (USD 34.134,00) désormais représenté par trente-quatre mille cent trente-trois
(34.133) actions ordinaires et une (1) action de commandité, toutes d'une valeur d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune,
sur base du taux de change du jour des présentes résolutions d'un Euro (EUR 1,00) pour un virgule un zero un un Dollars
Américains (USD 1,1011), étant entendu que les dix centimes de Dollars Américains (USD 0,10) restants suite à la con-
version seront alloués au compte de réserve légale de la Société.

VI. Réaffectation des actions de la Société aux actionnaires comme suit:

Actions d'un Euro

(EUR 1,00) chacune

détenues avant la conversion

du capital social

Actions d'un Dollar

Américain (USD 1,00)

chacune détenues après la

conversion du capital social

Neuheim VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.998 actions ordinaires

34.132 actions ordinaires

Flexitech Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action de commandité

1 action ordinaire

1 action de commandité

1 action ordinaire

VII. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de dix mille Dollars Américains (USD 10.000,00) afin

de le porter de son montant actuel de trente-quatre mille cent trente-quatre Dollars Américains (USD 34.134,00) à quarante-
quatre mille cent trente-quatre Dollars Américains (USD 44.134,00) par création et émission de dix mille (10.000) actions
ordinaires d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune (les Nouvelles Actions), jouissant des mêmes
droits et obligations que les actions ordinaires existantes (l'Emission des Nouvelles Actions).

VIII. Souscription par Neuheim VI S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et existant selon la loi du Lu-

xembourg, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, un capital social
de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,00) et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 183355 aux Nouvelles Actions (la Souscription) et libération de ces dernières pour un montant
total de dix mille Dollars Américains (USD 10.000,00) en nature, consistant en la conversion d'une créance d'un même
montant détenue par Neuheim VI S.à r.l., prénommé, envers la Société, laquelle créance est incontestable, liquide et exigible
(la Conversion).

IX. Modification de l'article 5 paragraphes 1 et 5 des statuts de la Société afin de leur donner la teneur suivante:

« Art. 5. Paragraphe premier. Le capital social de la Société est fixé à la somme de quarante-quatre mille cent trente-

quatre Dollars Américains (USD 44.134,00) représenté par les actions suivantes:

- quarante-quatre mille cent trente-trois (44.133) actions ordinaires ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain

(USD 1,00) chacune (les Actions de Commanditaire); et

- une (1) action de commandité ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) (ci-après, l'Action de

Commandité).»

« Art. 5. Paragraphe 5. L'Action de Commandité est détenue par Flexitech Management S.à r.l., une société à respon-

sabilité  limitée  établie  et  existant  selon  la  loi  du  Luxembourg,  ayant  son  siège  social  au  1B,  Heienhaff,  L  1736
Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, un capital social de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,00) et enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198821, en tant qu'actionnaire
à responsabilité illimité et commandité (ci-après, le Gérant).»

X. Prise de connaissance du rapport émis par BJNP Audit, une société à responsabilité limitée établie et existant selon

les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 59, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171737,
réviseur d'entreprises indépendant, en relation avec l'Emission des Nouvelles Actions, lequel rapport conclut comme suit
(le Rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé):

<i>Conclusion

«Sur base de notre revue, rien qui n'a été porté à notre attention ne nous porte à croire que la valeur globale des Actifs

Contribués ne correspondent pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à être émises en contrepartie.»

<i>Résolutions

I. L'assemblée décide de changer le nom de la Société de «NIH VI Daled Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.» en

«Flexitech Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.».

11134

L

U X E M B O U R G

II. L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société en commandite par actions sous la dénomination de «Flexitech Management S.à r.l.

&amp; Partners S.C.A.», qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-
après, les Statuts) et par tout pacte de détenteur de titres qui serait entré en vigueur entre les actionnaires le cas échéant (Le
Pacte de Détenteur de Titres).»

III. L'assemblée décide de prendre connaissance du changement de nom de l'associé commandité de la Société de «NIH

VI Daled Management S.à r.l.» en «Flexitech Management S.à r.l.».

IV. L'assemblée décide de convertir la devise du capital social de la Société de l'Euro (EUR) au Dollar Américain (USD).
V. L'assemblée décide de convertir le capital social de la Société de trente-et-un mille Euro (EUR 31.000,00) à trente-

quatre mille cent trente-quatre Dollars Américains (USD 34.134,00) désormais représenté par trente-quatre mille cent
trente-trois (34.133) actions ordinaires et une (1) action de commandité, toutes d'une valeur d'un Dollar Américain (USD
1,00) chacune, sur base du taux de change du jour des présentes résolutions d'un Euro (EUR 1,00) pour un virgule un zero
un un Dollars Américains (USD 1,1011), étant entendu que les dix centimes de Dollars Américains (USD 0,10) restants
suite à la conversion seront alloués au compte de réserve légale de la Société.

VI. L'assemblée décide de réaffecter les actions de la Société aux actionnaires comme suit:

Actions d'un Euro

(EUR 1,00) chacune

détenues avant la conversion

du capital social

Actions d'un Dollar

Américain (USD 1,00)

chacune détenues après la

conversion du capital social

Neuheim VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.998 actions ordinaires

34.132 actions ordinaires

Flexitech Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action de commandité

1 action ordinaire

1 action de commandité

1 action ordinaire

VII. L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de dix mille Dollars Américains (USD

10.000,00) afin de le porter de son montant actuel de trente-quatre mille cent trente-quatre Dollars Américains (USD
34.134,00) à quarante-quatre mille cent trente-quatre Dollars Américains (USD 44.134,00) par création et émission de dix
mille (10.000) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune (les Nouvelles Actions),
jouissant des mêmes droits et obligations que les actions ordinaires existantes (l'Emission des Nouvelles Actions).

VIII. Neuheim VI S.à r.l., prénommée décide de souscrire aux Nouvelles Actions (la Souscription), et de les libérer

intégralement par paiement d'un montant total de dix mille Dollars Américains (USD 10.000,00) en nature, consistant en
la conversion d'une créance d'un même montant détenue par Neuheim VI S.à r.l., prénommé, envers la Société, laquelle
créance est incontestable, liquide et exigible (la Conversion).

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport en nature a été donnée au notaire instrumentaire par:
i. un bilan intérimaire en date du 27 octobre 2015 de la Société, certifié «sincère et véritable» par l'un de ses représentants

légaux;

ii. Une déclaration d'apport de Neuheim VI S.à r.l., prénommé, annexée aux présentes; et
iii. un rapport annexé aux présentes conformément à l'article 32-1 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, établi par

BJNP Audit, une société à responsabilité limitée établie et existant selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social au
59, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistré auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171737 (BJNP Audit), réviseur d'entreprises indépendant, lequel rapport
conclut comme suit (le Rapport du Réviseur d'Entreprises Indépendant):

«Sur base de notre revue, rien qui n'a été porté à notre attention ne nous porte à croire que la valeur globale des Actifs

Contribués ne correspondent pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à être émises en contrepartie.»

IX. L'assemblée décide de modifier l'article 5 paragraphes 1 et 5 des statuts de la Société afin de leur donner la teneur

suivante:

« Art. 5. Paragraphe premier. Le capital social de la Société est fixé à la somme de quarante-quatre mille cent trente-

quatre Dollars Américains (USD 44.134,00) représenté par les actions suivantes:

- quarante-quatre mille cent trente-trois (44.133) actions ordinaires ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain

(USD 1,00) chacune (les Actions de Commanditaire); et

- une (1) action de commandité ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) (ci-après, l'Action de

Commandité).»

« Art. 5. Paragraphe 5. L'Action de Commandité est détenue par Flexitech Management S.à r.l., une société à respon-

sabilité  limitée  établie  et  existant  selon  la  loi  du  Luxembourg,  ayant  son  siège  social  au  1B,  Heienhaff,  L  1736
Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, un capital social de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,00) et enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198821, en tant qu'actionnaire
à responsabilité illimité et commandité (ci-après, le Gérant).»

X. L'assemblée décide de prendre connaissance du Rapport du Réviseur d'Entreprises Indépendant.

11135

L

U X E M B O U R G

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des per-

sonnes  comparantes,  le  présent  acte  est  rédigé  en  anglais  suivi  d'une  version  française.  A  la  requête  des  personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des personnes comparantes, connus du

notaire par leur nom et prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Gomes, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 octobre 2015. Relation: EAC/2015/25158. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015187229/316.
(150209068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

PCO Holdco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 159.058.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société le 17 novembre 2015.

L'associé unique de la Société a décidé le 17 novembre 2015 de:
1. prendre acte et accepter la démission de Monsieur Vincent GOY, gérant de la Société avec effet immédiat;
2. élire en tant que gérant de la Société, pour une période indéterminée, Monsieur Grégory GOSSELIN, né le 8 novembre

1982 à Libramont-Chevigny (Belgique) et résidant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lu-
xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2015.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2015188841/18.
(150211150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

PCO HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 125.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 145.612.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 17 novembre 2015.

L'associé unique de la Société a décidé le 17 novembre 2015 de:
1 prendre acte et accepter la démission de Monsieur Vincent GOY, gérant de la Société avec effet immédiat;
1. élire en tant que gérant de la Société, pour une période indéterminée, Monsieur Grégory GOSSELIN, né le 8 novembre

1982 à Libramont-Chevigny (Belgique) et résidant professionnellement au 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lu-
xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2015.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2015188842/18.
(150211151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

11136


Document Outline

BFIT Holding

Fineos International (Luxembourg) S.A.

Fineos International (Luxembourg) S.à r.l.

Flexitech Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.

Graycliff Private Equity Partners III GP S.à r.l.

Group Money Investment Holding SA

Immo Invest Lux Holdco S.à r.l.

Mberp II (Luxembourg) 17 S.à r.l.

Mberp II (Luxembourg) 18 S.à r.l.

Newton Partners

NH VI Daled Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.

Norden Wynde S.A.

Opaline Investissements S.A. SPF

Opportunity Two

Pape Construction S.à r.l.

PCO Holdco II S.à r.l.

PCO HoldCo S.à r.l.

Porto Conte S.A.

Prince &amp; Princess S.à r.l.

Private Bank Funds I

Pulcinella S.à r.l.

Punto d'Oro S.à.r.l.

Pyro-Protection S.A.

Queensberry S.A.

Rapego S.A.

Rebecorp S.A.H.

Reskina S.à r.l.

RoCo Investment S.à r.l.

Rom7 S.A.

Sabadell BS Select Fund of Hedge Funds SICAV (Luxembourg)

Sabadell Select Fund of Hedge Funds SICAV (Luxembourg)

Vansan Holding S.A.