This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 134
19 janvier 2016
SOMMAIRE
Au Sud de l'Est Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6427
BNP Paribas Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6392
Château de Schengen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
6429
Codeis Securities SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6428
Cofralux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6387
Conical SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6428
Conti Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6428
DAMOI S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6430
Delebois & O'Donnell S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
6387
Delta Spain S.à r.l., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . .
6432
Detem Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6387
Dicar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6386
DIT Luxembourg 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
6387
D'Wäschfra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6429
Elite Groupe Recrutement S.A. . . . . . . . . . . . .
6430
ELSEN-BAU Luxemburg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
6386
Emerald Euro Investment Grade Bond . . . . .
6395
ENTREPRISE DE TRANSPORTS CORDEL-
LA Cosimino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6386
Feba Advice S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6386
Ficaroma S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6424
Finatech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6431
Finconsulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6387
Fingas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6406
France Menuiserie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6386
Gandria Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6431
Global Outsourcing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6391
Golden Profit Plus Oil S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
6432
Grenkelocation SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6432
House International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6391
Icon 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6391
Inversiones Bren S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6394
JAR Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6393
ParLyo Property Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
6420
RREI Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6389
SBF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6388
SBF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6388
Société de Participations FILUNOR . . . . . . . .
6389
Société de Participations FILUNOR . . . . . . . .
6388
Solway Commodities Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
6388
Spartech Luxembourg Holding Company S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6389
Spartech Luxembourg Holding Company S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6389
Step Luxco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6389
Swiss Alpha, SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6394
Synapse Mobile Networks S.A. . . . . . . . . . . . . .
6388
Synergo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6390
Synergo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6390
Synergo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6390
Triton III LuxCo 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
6390
T.S.I. Communication s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
6390
6385
L
U X E M B O U R G
France Menuiserie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 158.669.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2015190197/13.
(150212977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Feba Advice S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 148.587.
Les comptes annuels au 31-12-2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la gérance
i>Signatures
Référence de publication: 2015190201/11.
(150213127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
ELSEN-BAU Luxemburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 99.260.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 24 novembre 2015.
Référence de publication: 2015190173/10.
(150212795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
ENTREPRISE DE TRANSPORTS CORDELLA Cosimino, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.
R.C.S. Luxembourg B 93.592.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Référence de publication: 2015190175/10.
(150212486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Dicar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7540 Rollingen, 136, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 69.990.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le géranti>
Référence de publication: 2015190149/10.
(150212615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
6386
L
U X E M B O U R G
Finconsulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 68, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 173.892.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2015.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2015190204/14.
(150212914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Delebois & O'Donnell S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 136.068.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015190145/10.
(150212536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Detem Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 18, Z.I. In den Allen.
R.C.S. Luxembourg B 187.908.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 24 novembre 2015.
Référence de publication: 2015190146/10.
(150212794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
DIT Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 117.502.
Le bilan au 30 juin 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2015190151/10.
(150213195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Cofralux, Société Anonyme.
Siège social: L-4501 Differdange, rue Pierre Gansen.
R.C.S. Luxembourg B 37.071.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 novembre 2015.
Référence de publication: 2015182081/10.
(150203720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
6387
L
U X E M B O U R G
Société de Participations FILUNOR, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 6.739.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS FILUNOR S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015190547/11.
(150213020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Solway Commodities Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 155.934.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Remplace la 1
ère
version (art. 6bis du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 concernant le RCS) déposée
le 05/11/2015.
Numéro de dépôt initial au RCS: L150199697
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015190551/13.
(150212523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Synapse Mobile Networks S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 95.361.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Delphine Munier.
Référence de publication: 2015190564/10.
(150212709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
SBF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 108.036.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SBF S.A.
Référence de publication: 2015190566/10.
(150212545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
SBF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 108.036.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SBF S.A.
Référence de publication: 2015190567/10.
(150212546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
6388
L
U X E M B O U R G
Spartech Luxembourg Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 168.794.
Les comptes annuels au 31 Octobre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2015190554/11.
(150212869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Société de Participations FILUNOR, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 6.739.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS FILUNOR S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015190546/11.
(150212998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Spartech Luxembourg Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 168.794.
Les comptes annuels au 31 Octobre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2015190553/11.
(150212868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Step Luxco, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 122.605.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
STEP LUXCO S.C.A.
Référence de publication: 2015190559/10.
(150212735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
RREI Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 186-188, rue de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 158.781.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A Luxembourg, le 24 novembre 2015.
<i>Pour RREI HOLDING S.A.i>
Référence de publication: 2015190532/11.
(150212787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
6389
L
U X E M B O U R G
Synergo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 65.664.
Les comptes annuels au 30 Juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SYNERGO S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015190607/11.
(150213023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Synergo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 65.664.
Les comptes annuels au 30 Juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SYNERGO S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015190608/11.
(150213024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Synergo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 65.664.
Les comptes annuels au 30 Juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SYNERGO S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015190609/11.
(150213025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Triton III LuxCo 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 151.881.
Les comptes annuels au 30 avril 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Triton III LuxCo 3 S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015190619/11.
(150212564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
T.S.I. Communication s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 166.847.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015190610/10.
(150213134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
6390
L
U X E M B O U R G
Global Outsourcing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 133.004.
<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Global Outsourcing S.A. tenu au siège de la Société eni>
<i>date du 1 i>
<i>eri>
<i> octobre 2015i>
L'administrateur est présent.
L'actionnaire a pris la décision suivante
L'actionnaire décide:
- De révoquer la société PRISMA CONSULTING SARL (B 101674) ayant son siège social à Z.I. de Kehlen L-8287
KEHLEN en tant que Commissaire aux comptes,
- De nominer la société LUXVALUATION SARL (B 191112) ayant son siège social à 12, Henneschtgaass L-8373
HOBSCHEID, en tant que nouveau Commissaire aux comptes pour une période qui viendra à échéance lors de l'assemblée
générale ordinaire à tenir en 2015.
La décision a été admise à l'unanimité.
Après cela l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
GLOBAL OUTSOURCING S.A.
M. SARAVIA VIDAURRE Bruno
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2015183836/22.
(150204878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
House International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 155.947.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire le 28 octobre 2015i>
Acceptation de la démission de Madame Tazia BENAMEUR, et des sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVI-
CES S.A. en tant qu'Administrateurs de la société.
Acceptation de la nomination de Madame Gabriele SCHNEIDER, née le 31 octobre 1966 à Birkenfeld/Nahe (Allema-
gne), adresse professionnelle au 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, comme Administrateur unique de la société. Son
mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2020.
Acceptation de la démission de Monsieur Eric HERREMANS en tant que commissaire aux Comptes à partir de ce jour.
Acceptation de la nomination de Madame Tazia BENAMEUR, née le 9 novembre 1969 à Mohammadia (Algérie),
adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme nouveau Commissaire aux Comptes de la
société. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2020.
Acceptation de la démission de la société BPH FINANCE S.A., déléguée à la gestion journalière.
<i>Pour la société
i>HOUSE INTERNATIONAL S.A.
Référence de publication: 2015183875/20.
(150204782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Icon 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 159.612.
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu à Luxembourg en date du 25 octobre 2012i>
En date du 25 octobre 2012, le conseil d'administration a décidé de nommer Monsieur Pierre Stemper, administrateur
de la société, comme président du conseil d'administration jusqu'à l'expiration de son mandat d'administrateur.
Pour extrait conforme
Icon 1 S.A.
Référence de publication: 2015183899/12.
(150204921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
6391
L
U X E M B O U R G
BNP Paribas Plan, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 77.227.
I. STATUTORY GENERAL MEETING
The
STATUTORY GENERAL MEETING
will be held on Thursday, <i>February 18, 2016i> at 10.00 a.m. CET, to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the auditor;
2. Approval of the annual accounts for the financial period closed as at October 31, 2015 and allocation of the results;
3. Discharge to the Directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.
The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will be
taken by a simple majority of the proportion of shares represented. Account shall not be taken of abstentions. Every share,
whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.
And followed by:
II. SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
As the quorum required under Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, was not achieved for
the Extraordinary General Meeting held on Monday 18 January 2016, a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
will be held on Thursday <i>February 18, 2016i> at 10.30 a.m. CET, to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
Update of the Articles of Association as follows with effect as of 25 April 2016:
1. Article 4:
Transfer of the registered office of the Company in the commune of Luxembourg;
2. Article 8:
a) Addition of the possibility for the Board of Directors to issue dematerialised shares as described by the Act of 6
April 2013;
b) Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915 as
amended;
c) Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act of 10 August
1915 as amended.
3. Article 14(3):
Replacement of "the closing price on the order acceptance date" by "the last known closing price on the valuation
day" for the listed assets valuation price;
4. Article 16:
Rewording of the possibility for the Board of Directors to fill the vacancy of the office of a Director by using the
same terms as those of article 51 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended;
5. Article 19:
Cancellation of the possibility to jointly manage the assets of a sub-fund with the assets of other sub-funds of the
Company or other UCI.
Consequently, removal of the second paragraph of the article.
6. Article 20:
Cancellation of the following condition relating to the investment of a sub-fund into another sub-fund of the Company
to be compliant with article 181 (8) of the law of 17 December 2010 concerning UCI as amended by the law of 12
July 2013:
There shall be no duplication of management/subscription commissions or redemption between these commissions
at the level of the sub-fund that invested in the target sub-fund and this target sub-fund.
7. Article 22:
Replacement of the title of the article "invalidation clause" by "conflict of interest"
In accordance with Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, such second extraordinary general
meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. Decisions shall be taken by at least
two-thirds of the votes cast.
6392
L
U X E M B O U R G
III. PROVISIONS AVAILABLE FOR BOTH MEETINGS
The Meetings will be held at the offices of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, building H2O, block A,
ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.
In accordance with Luxembourg laws, holders of bearer shares wishing to attend or to be represented at both Meetings,
shall have them immobilised at BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch by February 18, 2016 at the latest.
Shareholders wishing to attend or to be represented at both Meetings are admitted upon proof of their identity and share-
blocking certificate. Their intention to participate shall be known at least five business days before both Meetings.
Annual accounts, as well as the report of the Auditor, the management report, the current prospectus and the draft new
articles of association are available at the registered office of the Company. Shareholders may request a copy of these
documents. Such request shall be sent by post at the following address : BNP Paribas Investment Partners Luxembourg,
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange - or by email to fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016051760/755/69.
JAR Capital, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 193.403.
NOTICE OF THE SHAREHOLDERS of JAR Capital
AND IT'S SUB-FUNDS
JAR Capital Sustainable Income UI
Share class JAR Capital Sustainable Income UI D EUR / LU1112873689
Share class JAR Capital Sustainable Income UI D USD / LU1112873846
Share class JAR Capital Sustainable Income UI A GBP / LU1112873416
Share class JAR Capital Sustainable Income UI R EUR / LU1231245298
Share class JAR Capital Sustainable Income UI I EUR / LU1231245611
The shareholders of JAR Capital are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders (the "AGM") which will be held on <i>4 February 2016i> , 10 a.m. (CET) at the company's registered office,
as set out above, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the Audited Annual Report for the financial year ended 30 September 2015
2. Discharge of the Board of Directors of the company for the performance of their duties carried out during the financial
year ended 30 September 2015
3. Approval of the Director's fees for the financial year ended 30 September 2015
4. Reappointment of Mr. Marc-Oliver Scharwath, Mr. Armin Clemens to serve as directors of the company until the
next Annual General Meeting
5. Acknowledgement of the resignation of Mr. Kerrin Tansley from the board of directors effective 27 January 2016
6. Approval of Mr. Peter Young as member of the board of directors effective 28 January 2016; subject to the approval
of the CSSF
7. Reappointment of KPMG Luxembourg, Société coopérative to serve as the company's statutory auditor until the next
Annual General Meeting
8. Allocation of the net results for the financial year ended 30 September 2015;
9. Miscellaneous
Shareholders who would like to participate in the Annual General Meeting and exercise their voting rights are entitled
to submit by 28th January 2016 a certificate of deposit of a credit institution from which it appears that the shares are
blocked until the end of the AGM.
Shareholders who cannot personally attend the Meeting and wish to be represented are entitled to appoint a proxy to
vote for them. A proxy need not be a shareholder of the company. The proxy is available at http://www.universal-
investment.lu/Publikumsfonds/Mitteilungen or alternatively from the registered office.
The resolutions set forth in the agenda for the AGM will require no special quorum and will be passed by a simple
majority of the votes of shareholders present or represented at the AGM.
A copy of the Audited Annual Report as of 30 September 2015 is available from the registered office of the company
or alternatively via email at VE.Comp-Secretary-UIL@universal-investment.com.
For and on behalf of the Board of Directors
6393
L
U X E M B O U R G
Grevenmacher, January 2016
Référence de publication: 2016051761/755/44.
Swiss Alpha, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6B, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 148.588.
Hiermit informieren wir Sie, dass der Verwaltungsrat gem. Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft beschlossen hat, für
den Teilfonds Swiss Alpha, SICAV - Strategy Europe die Rücknahme von Aktien aus Gründen der Liquiditätsbeschaffung
ab dem 12.01.2016 (Orderannahme 12.01.2016, 14 Uhr) bis auf weiteres auszusetzen.
Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Ausgabe von Aktien ab sofort einzustellen. Weiterhin hat der
Verwaltungsrat gemäß Art. 12 der Satzung der Gesellschaft beschlossen, die Berechnung und Veröffentlichung des Fonds-
preises ab dem 12.01.2016 bis auf weiteres einzustellen.
Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat beschlossen eine
AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
einzuberufen, die am <i>5. Februar 2016i> um 11:30 Uhr, in den Geschäftsräumen der Verwaltungsgesellschaft, 6Bb rue
Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach stattfinden wird.
<i>Tagesordnung:i>
1. Beschluss die Gesellschaft Swiss Alpha, SICAV in Liquidation zu setzen.
2. Benennung der Liquidatoren Herr Thorsten Eiglmeier (für die Swiss Alpha AG) und Frau Katja Mertes-Tegebauer
(für die BayernInvest Luxembourg S.A.), vorbehaltlich der Genehmigung der CSSF.
3. Festlegung der Befugnisse der Liquidatoren.
4. Annahme der Rücktrittsgesuche der Mitglieder des Verwaltungsrates.
5. Sonstiges
Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 02. Februar 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft
einreichen aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden.
Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Es besteht ein Quorum für die außerordentliche Generalversammlung. Die außerordentliche Generalversammlung ist
nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist.
Luxembourg den 12.01.2016
Der Verwaltungsrat, Swiss Alpha, SICAV
Référence de publication: 2016011091/30.
Inversiones Bren S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 123.601.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE
des actionnaires qui se tiendra le <i>15 février 2016i> à 14.30 heures au siège social de la Société avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Révocation et décharge des administrateurs ;
2. Nomination des administrateurs ;
3. Révocation et décharge du commissaire aux comptes ;
4. Nomination d'un commissaire aux comptes ;
5. Ratification de l'intégralité des actions prises par l'administrateur délégué, Madame Eliane Ricard, depuis le 22
septembre 2015 jusqu'au jour de la tenue de l'assemblée générale ;
6. Divers
Madame Eliane Ricard,
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2016012063/19.
6394
L
U X E M B O U R G
Emerald Euro Investment Grade Bond, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 203.047.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the ninth day of December.
Before Maître Jacques Kesseler, notary established in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned,
appears,
Mr. Marco Nicoletti, residing in 2 bis chemin des Oeillets, - 98000 Monaco
here duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address at 13, route de
Luxembourg, BP 7, L-4761 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of
association (the “Articles”) of a public company limited by shares, which such party declared to incorporate.
Title I. Name - Registered Office - Duration - Purpose
Art. 1. Name. There exists, a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with
variable share capital ("société d'investissement à capital variable") under the name of “Emerald Euro Investment Grade
Bond" (hereinafter the "Company").
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a decision of the board of directors. The registered office of the Company may be transferred within the same municipality
by simple decision of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, military economic or social events have
occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
Art. 4. Purpose. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of
any kind and other assets permitted by Part I of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective
investment, as may be amended from time to time (the “Law”) with the purpose of spreading investment risks and affording
its shareholders the results of the management of its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the development and
accomplishment of its purpose to the full extent permitted by Part I of the Law.
Title II. Share Capital - Shares - Net Asset Value
Art. 5. Share Capital - Classes of Shares. The capital of the Company shall be represented by fully paid up shares of no
par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof. The initial
capital for incorporation is EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro), represented by 31,000 (thirty-one thousand) shares of
no par value. The minimum capital of the Company shall be EUR 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand Euro)
to be reached within 6 months of its incorporation.
The shares to be issued pursuant to Article 7 hereof may, as the board of directors shall determine, be of different classes.
The proceeds of the issue of each class of shares shall be invested in transferable securities of any kind and other assets
permitted by law pursuant to the investment policy determined by the board of directors for the Company (as defined
hereinafter) established in respect of the relevant class or classes of shares, subject to the investment restrictions provided
by law or determined by the board of directors.
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class of shares shall, if
not expressed in EUR, be converted into EUR and the capital shall be the total of the net assets of all the classes of shares.
Art. 6. Form of Shares.
(1) Shares shall be issued in registered form only.
(2) Shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by the Company or by
one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner of record
of registered shares, residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered shares held by
the owner of record and the amount paid up on each share.
6395
L
U X E M B O U R G
The inscription of the shareholder's name in the register of shares evidences the shareholder's right of ownership on such
registered shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the shareholder
or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.
The share certificates (if issued) shall be signed by two directors. Such signatures shall be either manual, or printed, or
in facsimile. However, one of such signatures may be made by a person duly authorized thereto by the board of directors;
in the latter case, it shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the board of
directors may determine.
(3) Transfer of shares shall be effected (i) if share certificates have been issued, upon delivering the certificate or
certificates representing such shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company
and (ii) if no share certificates have been issued, by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of
shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act
therefore. Any transfer of registered shares shall be entered into the register of shareholders; such inscription shall be signed
by one or more directors or officers of the Company or by one or more other persons duly authorized thereto by the board
of directors.
(4) Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such
address will also be entered into the register of shareholders.
In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered
into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company,
or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another address shall be provided
to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change the address as entered into the register of
shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be
set by the Company from time to time.
(5) If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that the shareholder's share certificate has been
mislaid, mutilated or destroyed, then, at the shareholder's request, a duplicate share certificate may be issued under such
conditions and guarantees, including but not restricted to a bond issued by an insurance company, as the Company may
determine. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share
certificate in replacement of which the new one has been issued shall become void.
Mutilated share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.
The Company may, at its election, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new share certificate and all
reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection with
the annulment of the original share certificate.
(6) The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership
of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such
share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise of all rights attached
to such shares.
(7) The Company may decide to issue fractional shares up to the number of decimal places to be decided by the board
of directors. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable
to the relevant class of shares on a pro rata basis.
Art. 7. Issue of Shares. The board of directors is authorized without limitation to issue an unlimited number of fully paid
up shares at any time without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be
issued.
The board of directors may, at any time, issue different classes of shares, which may differ, inter alia, in their fee structure,
subscription and/or redemption procedures, minimum initial and subsequent investment and/or holding requirements, type
of target investors and distribution policy applying to them as more fully described in the sales documents.
The board of directors may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class of shares;
the board of directors may, in particular, decide that shares of any class shall only be issued during one or more offering
periods or at such other periodicity as provided for in the sales documents for the shares of the Company.
Whenever the Company offers shares for subscription, the price per share at which such shares are offered shall be based
on the net asset value per share of the relevant class of shares, as determined in compliance with the provisions of Article
11 hereof as of such Valuation Day (as defined in Article 12 hereof) as is determined in accordance with such policy as
the board of directors may from time to time determine. Such price may be increased by applicable sales commissions or
distribution fee, as approved from time to time by the board of directors. The price so determined shall be payable within
a maximum period as provided for in the sales documents for the shares and which shall not exceed ten Luxembourg bank
business days after the relevant Valuation Day.
The board of directors may delegate to any director, manager, officer or other duly authorized agent the power to accept
subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver them. If subscribed shares are
not paid for, the Company may cancel their issue whilst retaining the right to claim its issue fees and commissions.
The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities and/or other permitted
assets, in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, which may in particular provide for the obligation
6396
L
U X E M B O U R G
to deliver a valuation report from the auditor of the Company ("réviseur d'entreprises agréé") and provided that such
securities comply with the investment objectives and policies of the Company. Any costs incurred in connection with a
contribution in kind of assets shall be borne by the relevant shareholders unless from the opinion of the sole board of
directors, the contribution in kind appears in the best interest of the Company.
Art. 8. Redemption of Shares. Any shareholder may require the redemption of all or part of his shares by the Company,
under the terms and procedures set forth by the board of directors in the sales documents for the shares and within the limits
provided by law and these Articles.
The redemption price per share shall be paid within a period as determined by the board of directors which shall not
exceed ten Luxembourg bank business days from the relevant Valuation Day, as is determined in accordance with such
policy as the board of directors may from time to time determine, provided that the share certificates, if any, and the transfer
documents have been received by the Company, subject to the provision of Article 12 hereof.
The redemption price shall be equal to the net asset value per share of the relevant class, as determined in accordance
with the provisions of Article 11 hereof, less such charges and commissions (if any) at the rate provided by the sales
documents for the shares. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant
currency as the board of directors shall determine.
If as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any
shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the board of directors,
then the Company may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such shareholder's
holding of shares in such class.
Further, if on any given Valuation Day during the course of a Valuation Day, redemption requests pursuant to this Article
and conversion requests pursuant to Article 9 hereof exceed a certain level determined by the board of directors in relation
to the number of shares in issue in a specific class, the board of directors may decide that part or all of such requests for
redemption or conversion will be deferred for a period and in a manner that the board of directors considers to be in the
best interest of the Company. On the next Valuation Day following that period, these redemption and conversion requests
will be met in priority to later requests.
The Company shall have the right, if the board of directors so determines, to satisfy payment of the redemption price
to any shareholder who agrees, in kind, by allocating to the holder, investments from the portfolio of assets set up in
connection with such class or classes of shares equal in value (calculated in the manner described in Article 11) as of the
Valuation Day during the course of a Valuation Day on which the redemption price is calculated, to the value of the shares
to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable
basis and without prejudicing the interests of the other holders of shares of the relevant class or classes of shares and the
valuation used shall be confirmed by a special report of the auditor of the Company.
The costs of any such transfers shall be borne by the transferee.
All redeemed shares shall be cancelled.
Art. 9. Conversion of Shares. Unless otherwise determined by the board of directors for certain classes of shares, any
shareholder is entitled to require the conversion of whole or part of his shares of one class into shares of another class,
subject to such restrictions as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the board of directors
shall determine.
The price for the conversion of shares from one class into another class shall be computed by reference to the respective
net asset value of the two classes of shares, calculated on the same Valuation Day during the course of a Valuation Day.
If as a result of any request for conversion the number or the aggregate net asset value of the shares held by any
shareholder in any class of shares declines to, or fails to reach, such number or such value as determined by the board of
directors as the minimum appropriate level for the relevant class, then the Company may decide that this request be treated
as a request for conversion for the full balance of such shareholder's holding of shares in such class.
The shares which have been converted into shares of another class shall be cancelled.
Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares. The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the
Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding (i) may be detrimental to
the Company, (ii) if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, (iii) if as a result
thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have
otherwise incurred or (iv) if such person, firm or corporate body would not comply with the eligibility criteria of a given
class of shares. Such persons, firms or corporate bodies to be determined by the board of directors being herein referred to
as "Prohibited Persons".
For such purposes the Company may:
A.- decline to issue any shares where it appears to it that such registry would or might result in legal or beneficial
ownership of such shares by a Prohibited Person; and
B.- at any time require any person whose name is entered into the registry, to provide the Company any information,
supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership
of such shareholder's shares rests in a Prohibited Person; and
6397
L
U X E M B O U R G
C.- decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of shareholders of the Company; and
D.- where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is
a beneficial owner of shares, compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held by
such shareholder in the following manner:
(1) The Company shall serve a notice upon the shareholder holding such shares or appearing in the register of share-
holders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as aforesaid, the manner in which
the purchase price will be calculated and the name of the purchaser.
Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed
to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall
thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates representing the shares spe-
cified in the purchase notice.
Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to be
the owner of the shares specified in such notice and, in the case of registered shares, his name shall be removed from the
register of shareholders, and in the case of bearer shares, the certificate or certificates representing such shares shall be
cancelled.
(2) The price at which each such share is to be purchased shall be an amount based on the net asset value per share of
the relevant class as at the Valuation Day during the course of a Valuation Day specified by the board of directors for the
redemption of shares in the Company immediately preceding the date of the purchase notice or immediately following the
surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice, whichever is lower, all as
determined in accordance with Article 8 hereof, less any service charge provided therein.
(3) Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency
fixed by the board of directors for the payment of the redemption price of the shares of the relevant class and will be
deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase
notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the share certificate or certificates specified
in such notice and unmatured dividend coupons attached thereto. Upon service of the purchase notice as aforesaid such
former owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the Company or its assets
in respect thereof, except the right to receive the purchase price (without interest) from such bank following effective
surrender of the share certificate or certificates as aforesaid. Any redemption proceeds receivable by a shareholder under
this paragraph, but not collected within a period of five years from the date specified in the purchase notice, may not
thereafter be claimed and shall revert to the relevant class or classes of shares. The board of directors shall have power
from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorize such action on behalf of the Company.
(4) The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any purchase notice, provided in such case the
said powers were exercised by the Company in good faith.
Art. 11. Calculation of Net Asset Value per Share. The net asset value per share of each class of shares shall be calculated
in the class currency (as defined in the sales documents for the shares). It shall be determined as of any Valuation Date by
dividing the net assets of the Company attributable to each class of shares, being the value of the portion of assets less the
portion of liabilities attributable to such class, on any such Valuation Date by the number of shares in the relevant class
then outstanding, in accordance with the valuation rules set forth below. The net asset value per share may be rounded up
or down to the nearest 1/100 of the relevant currency as the board of directors shall determine. If since the time of deter-
mination of the net asset value there has been a material change in the quotations in the markets on which a substantial
portion of the investments attributable to the relevant class of shares are dealt in or quoted, the Company may, in order to
safeguard the interests of the shareholders and the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation.
The valuation of the net asset value of the different classes of shares shall be made in the following manner:
I. The assets of the Company shall include:
1) all fixed-term deposits, money market instruments, cash in hand or cash expected to be received or cash contributions
including interest accrued;
2) all debts which are payable upon presentation as well as all other money claims including claims for purchase price
payment not yet fulfilled that arise from the sale of investment fund shares or other assets;
3) all investment fund shares;
4) all dividends and distributions due in favor of the Company, as far as they are known to the Company;
5) all interest accrued on interest-bearing securities that the Company holds, as far as such interest is not contained in
the principal claim;
6) all financial rights which arise from the use of derivative instruments;
7) the provisional expenses of the Company, as far as these are not deducted, under the condition that such provisional
expenses may be amortized directly from the capital of the Company;
8) all other assets of what type or composition, including prepaid expenses.
6398
L
U X E M B O U R G
The value of the assets of each class of shares is determined as follows:
The assets of the Company contain the following:
1. all fixed-term deposits, money market instruments, cash in hand or cash expected to be received or cash contributions
including interest accrued;
2. all debts which are payable upon presentation as well as all other money claims including claims for purchase price
payment not yet fulfilled that arise from the sale of investment fund shares or other assets;
3. all investment fund shares;
4. all dividends and distributions due in favour of the Company, as far as they are known to the Company;
5. all interest accrued on interest-bearing securities that the Company holds, as far as such interest is not contained in
the principal claim;
6. all financial rights which arise from the use of derivative instruments;
7. the provisional expenses of the Company, as far as these are not deducted, under the condition that such provisional
expenses may be amortised directly from the capital of the Company;
8. all other assets of what type or composition, including prepaid expenses.
The value of such assets is fixed as follows:
1. Investment funds are valued at their net asset value;
2. Liquid assets are valued at their nominal value plus accrued interest;
3. Fixed term deposits are valued at their nominal value plus accrued interest. Fixed term deposits with an original term
of more than 30 calendar days can be valued at their yield adjusted price if an arrangement between the Company and the
bank, with which the fixed term deposit is invested has been concluded including that the fixed term deposits are terminable
at any time and the yield adjusted price corresponds to the realisation value;
4. Commercial papers are valued at their nominal value plus accrued interest. Commercial papers with an original term
of more than 90 calendar days can be valued at their yield adjusted price if an arrangement between the Company and the
bank, with which the commercial paper is invested has been concluded including that the commercial papers are terminable
at any time and the yield adjusted price corresponds to the realisation value;
5. Securities or financial instruments admitted for official listing on a regulated market are valued on the basis of the
last available price at the time when the valuation is carried out. If the same security is quoted on a regulated markets, the
quotation on the principal market for this security will be used. If there is no relevant quotation or if the quotations are not
representative of the fair value, the evaluation will be made in good faith by the board of directors or their delegate;
6. Unlisted securities or financial instruments are valued on the basis of their probable value realisation as determined
by the board of directors or their delegate using valuation principles which can be examined by the auditor, in order to
reach a proper and fair valuation of the total assets of the Company;
7. Any other assets are valued on the basis of their probable value realisation as determined by the board of directors or
their delegate using valuation principles which can be examined by the auditor, in order to reach a proper and fair valuation
of the total assets of the Company;
8. The valuation of derivatives traded over-the-counter (OTC), such as futures, forward or option contracts not traded
on exchanges or on other recognised markets, will be based on their net liquidating value determined, pursuant to the
policies established by the board of directors on the basis of recognised financial models in the market and in a consistent
manner for each category of contracts. The net liquidating value of a derivative position is to be understood as being equal
to the net unrealised profit/loss with respect to the relevant position; and
9. Units or shares of the master Fund will be valued at their last determined and available net asset value.
In the event that it is impossible or incorrect to carry out a valuation in accordance with the above rules owing to particular
circumstances, the board of directors or their delegate shall be entitled to use other generally recognised valuation principles
which can be examined by an auditor, in order to reach a proper valuation of the total assets of the Company.
II. The liabilities of the Company shall include:
1) all loans, bills of exchange and other sums due, including deposits of security such as margin accounts, etc. In
connection with the use of derivative instruments; and
2) all administrative expenses that are due or have been incurred, including the costs of formation and registration at
the registration offices as well as legal fees, auditing fees, all fees of the management company, the administration agent,
the investment manager (if any), the Depositary and all other representatives and agents of the Company, the costs of
mandatory publications, the sales documents for the shares of the Company, conclusions of transactions and other docu-
ments which are made available to the shareholders. If the fee rates agreed between the Company and the employed service
providers (such as the management company, the Administration Agent, and Depositary or the investment manager ) for
such services deviate with regard to individual classes, the corresponding varying fees shall be charged exclusively to the
respective class; and
3) all known liabilities, whether due or not, including dividends that have been declared but not yet been paid; and
4) a reasonable sum provided for taxes, calculated as of the day of the valuation as well as other provisions and reserves
approved by the board of directors; and
6399
L
U X E M B O U R G
5) all other liabilities of the Company, of whatever nature, vis-à-vis third parties.
For the purpose of valuing its liabilities, the Company may include all administrative and other expenses of a regular
or periodic nature by valuing these for the entire year or any other period and apportioning the resulting amount propor-
tionally to the respective expired period of time. The method of valuation may only apply to administrative or other expenses
which concern all of shares equally.
III. The assets shall be allocated as follows:
(a) The proceeds to be received from the issue of shares of a class shall be applied in the books of the Company to the
class or classes of shares issued;
(b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be attributable in the books of the Company
to the same class or classes of shares as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase
or decrease in value shall be applied to the relevant class or classes of shares;
(c) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
class of shares, such asset or liability shall be allocated to all the classes of shares pro rata to their respective net asset values
or in such other manner as determined by the board of directors acting in good faith, provided that (i) where assets are held
in one account and/or are co-managed as a segregated pool of assets by an agent of the board of directors, the respective
right of each class of shares shall correspond to the prorated portion resulting from the contribution of the relevant class
of shares to the relevant account or pool, and (ii) the right shall vary in accordance with the contributions and withdrawals
made for the account of the class of shares, as described in the sales documents for the shares of the Company;
(d) upon the payment of distributions to the holders of any class of shares, the net asset value of such class of shares
shall be reduced by the amount of such distributions.
All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted ac-
counting principles.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the net asset value taken
by the board of directors or by any bank, company or other organization which the board of directors may appoint for the
purpose of calculating the net asset value, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders.
IV. For the purpose of this Article:
a) Shares that are redeemed in accordance with the provisions under Article 8 above shall be treated as existing shares
and shall be posted until immediately after the point in time set by the board of directors for carry out the valuation; from
this point in time until the price is paid, they shall be treated as a liability of the Company; and
b) All investments, cash in hand and other assets of any fixed assets that are not in the currency of the class of shares
concerned shall be converted at the exchange rate applicable on the day of the calculation of net asset value, taking into
consideration their market value; and
c) On every Valuation Day all purchases and sales of securities which were contracted by the Company on this very
Valuation Day must be included in the valuation to the extent possible.
Art. 12. Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share, of Issue, Redemption and
Conversion of Shares. With respect to each class of shares, the net asset value per share and the price for the issue,
redemption and conversion of shares shall be calculated from time to time by the Company or any agent appointed thereto
by the Company, at least twice a month at a frequency determined by the board of directors, such date being referred to
herein as the "Valuation Day".
The Company may suspend the determination of the net asset value per share of any particular class and the issue and
redemption of its shares from its shareholders as well as the conversion from and to shares of each class:
a) during any period (other than ordinary holidays or customary weekend closings) when any market or stock exchange
is closed which is the principal market or stock exchange for a significant part of the Company's investments, or in which
trading is restricted or suspended;
b) during any period when an emergency exists as a result of which it is impossible to dispose of investments which
constitute a substantial portion of the assets of the Company, or it is impossible to transfer money involved in the acquisition
or disposal of investments at normal rates of exchange, or it is impossible to fairly determine the value of any assets in the
Company;
c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the
Company's investments or the current prices on any stock exchange;
d) when for any reason beyond the control of the board of directors, the prices of any investment held by the Company
cannot be reasonably, promptly or accurately ascertained; or
e) during any period when remittance of money which will or may be involved in the purchase or sale of any of the
Company's investments cannot, in the opinion of the and/or the board of directors, be effected at normal rates of exchange;
f) when calculating the net asset value of a UCITS/UCIs in which the Company has invested a substantial portion of its
assets is suspended or unavailable, or where the issue, redemption or conversion of shares or units of such UCITS or other
UCI is suspended or restricted;
6400
L
U X E M B O U R G
g) in the event of the publication of the convening notice to a general meeting of Shareholders at which a resolution to
wind up or merge the Company is to be proposed or;
h) during any period when in the opinion of the directors of the Company there exist circumstances outside the control
of the Company where it would be impracticable or unfair towards the Shareholders.
i) in the case the Company qualifies as a feeder UCITS, when its master UCITS temporarily suspends the redemption,
reimbursement or subscription of its units, whether this be at its own initiative or at the request of its competent authorities,
for a period identical to the period of suspension imposed on the master UCITS.
The suspension of the calculation of the net asset value and of the issue, redemption, and conversion of shares shall be
published in a daily newspaper in Luxembourg and in another newspaper generally available in jurisdictions in which the
Company is registered.
Such suspension as to any class of shares shall have no effect on the calculation of the net asset value per share, the
issue, redemption and conversion of shares of any other class of shares.
Any application for subscription, redemption or conversion of shares is irrevocable except in case of a suspension of
the calculation of the net asset value per share in the relevant class of shares, in which case shareholders may give notice
that they wish to withdraw their application. If no such notice is received by the Company, such application will be dealt
with on the first Valuation Day following the end of the period of suspension.
Title III. Administration and Supervision
Art. 13. Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members,
who need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years. The directors shall
be elected by the shareholders at a general meeting of shareholders, until their successors are elected. A director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders. The shareholders
shall further determine the number of directors, their remuneration and the term of their office.
If a legal entity is appointed as director, such legal entity must designate a physical person as its permanent representative
who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its
permanent representative if it appoints his successor at the same time.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may
meet and elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which shall take a
final decision regarding such nomination.
Art. 14. Board Meetings. The board of directors may choose from among its members a chairman and may choose from
among its members one or more vice-chairmen. It may choose a secretary, who need not be a director, who shall write and
keep the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors shall meet upon
call by the chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at the meetings of the directors but in his absence the board of directors may appoint another
director and, in the absence of a director, any other person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
The board of directors may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as
well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such
appointments may be cancelled at any time by the board of directors. The officers need not be directors or shareholders of
the Company. Unless otherwise stipulated by these Articles, the officers shall have the rights and duties conferred upon
them by the board of directors.
Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours prior to
the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall
be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, facsimile or any
other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in
a resolution adopted by the board of directors.
Any director may act at any meeting by appointing in writing, by facsimile or any other similar means of communication
another director as his proxy. A director may represent several of his colleagues.
Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference-call or video-conference or by other
similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting
by such means of communication shall constitute presence in person at such meeting. A meeting held through such means
of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.
The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The directors may not bind the Company
by their individual signatures, except if specifically authorized thereto by resolution of the board of directors.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or represented.
Resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of
extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the
meeting or any two directors.
6401
L
U X E M B O U R G
Resolutions are taken by a majority vote of the directors present or represented and voting at such meeting. In the event
that at any meeting the number of votes for or against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a
casting vote.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors'
meetings; each director shall approve such resolution in writing, by facsimile or any other similar means of communication.
Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that proves that such decision has
been taken.
Art. 15. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts
of disposition and administration within the Company's purpose, in compliance with the investment policy as determined
in Article 18 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders are in the
competence of the board of directors.
Art. 16. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two
directors or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the board of directors.
Art. 17. Delegation of Power. The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily
management and affairs of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers
to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities,
which need not be members of the board, who shall have the powers determined by the board of directors and who may,
if the board of directors so authorizes, sub-delegate their powers.
The Company has appointed a management company (the “Management Company”) as its management company and
has delegated to the Management Company all powers related to the investment management, administration and distri-
bution of the Company. The Management Company may delegate some of its responsibilities to affiliated and non-affiliated
parties.
In particular, the Management Company may enter into one or more investment management agreements with one or
several investment managers (the "Investment Manager(s)"), as further described in the sales documents for the shares of
the Company, who shall supply the Company with recommendations and advice with respect to the Company's investment
policy pursuant to Article 18 hereof and may, on a day-to-day basis and subject to the overall control of the Management
Company, have actual discretion to purchase and sell securities and other assets of the Company pursuant to the terms of
a written agreement.
The board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
Art. 18. Investment Policies and Restrictions. The board of directors, based upon the principle of risk spreading and in
compliance with the Law, has the power to determine (i) the investment policies to be applied, (ii) the hedging strategy to
be applied to specific classes of shares and (iii) the course of conduct of the management and business affairs of the
Company, all within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with the sales documents
and applicable laws and regulations.
The Company may in particular invest in transferable securities/money market instruments admitted to official listing
on a stock exchange in any other country in Europe, Asia, Australia, Oceania, the American continents and Africa, or dealt
in on another market that is regulated, in the countries referred to above, provided that such market operates regularly and
is recognized and open to the public.
The Company is authorized to invest up to 100% of its net assets, in accordance with the principle of risk spreading, in
transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, by its local authorities or
agencies, or by another member state of the OECD, the G20 or Singapore or by public international bodies of which one
or more member States of the EU, provided that the Company, must hold securities from at least six different issues and
securities from one issue do not account for more than 30% of its net assets.
The board of directors may, at any time it considers appropriate, under the conditions and within the limits laid down
by the Law and the relevant Luxembourg regulations and in accordance with the provisions laid down in the prospectus,
convert the Company into a feeder UCITS or master UCITS or replace the master UCITS in which it may invest as feeder
UCITS.
The Company is authorized (i) to employ techniques and instruments relating to transferable securities provided that
such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management and (ii) to employ techniques
and instruments intended to provide protection against exchange risks in the context of the management of its assets and
liabilities.
Art. 19. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall
be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or
is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Company who
serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
6402
L
U X E M B O U R G
In the event that any director or officer of the Company may have in any transaction of the Company an interest opposite
to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such opposite interest
and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or officer's interest therein
shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.
The term "opposite interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without interest
in any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be determined by
the board of directors in its discretion.
Art. 20. Indemnification of Directors. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and
administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he
may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any
other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such
matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not
commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be
entitled.
Art. 21. Auditors. The general meeting of shareholders shall appoint a “réviseur d'entreprises agréé” (auditor), who shall
carry out the duties prescribed by the Law.
The auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders and until their successor is elected.
The auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.
Title IV. General Meetings - Accounting Year - Distributions
Art. 22. General Meetings of Shareholders of the Company. The general meeting of shareholders of the Company shall
represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders re-
gardless of the class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to
the operations of the Company.
Shareholders shall meet upon call by the board of directors pursuant to a notice post at least eight calendar days prior
to the meeting at their addresses shown on the register of shareholders. Such notices will include the agenda and will specify
the time and place of the meeting and the conditions of admission.
General meeting of shareholders may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth of
the share capital.
The notice of any general meeting of shareholders may specify that the quorum and the majority applicable for this
general meeting will be determined by reference to the shares issued and in circulation at a certain date and time preceding
the general meeting (the “Record Date”), whereas the right of a shareholder to participate at a general meeting of share-
holders and to exercise the voting rights attached to his/its/her shares will be determined by reference to the shares held by
this shareholder as at the Record Date.
The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office
of the Company in Luxembourg on the first Monday the month of April at noon If such day is a legal or a bank holiday in
Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of
meeting. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors,
exceptional circumstances so require (i.e. political or military requirements).
The agenda shall be prepared by the board of directors except in the instance where the meeting is called on the written
demand of the shareholders in which instance the board of directors may prepare a supplementary agenda.
One or several shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital may request the adjunction
of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such a request must be sent to the registered
office of the Company by registered mail at least five calendar days before the relevant meeting.
If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.
Each whole share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another
person as his proxy in writing or by facsimile.
Shareholders taking part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing
their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The means of communication
used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an
effective participation of all such persons in the meeting.
Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to the
address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and
which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the
6403
L
U X E M B O U R G
decision of the meeting, as well as for each proposal, three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or
abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.
Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the proposed resolution, nor an abstention, are void. The
Company will only take into account voting forms received prior the general meeting which they are related to.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend any
meeting of shareholders.
The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which
shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the
shareholders present or represented.
Art. 23. General Meetings of Shareholders in a Class of Shares. The shareholders of the class or classes issued may
hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such class.
The provisions of Article 22 shall apply mutatis mutandis to such general meetings.
Each share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles.
Unless otherwise provided for by law or herein, the resolutions of the general meeting of shareholders of a class of
shares are passed by a simple majority of the votes validly cast.
Art. 24. Termination and Amalgamation of Classes of Shares. The board of directors may decide to liquidate any class
each time if in its reasonable judgment the continuation of the class is not in the interest of the shareholders, in particular,
if a change in the economic or political situation relating to the class concerned would justify such liquidation or if required
by the interests of the shareholders of any of the class concerned. The decision of the liquidation will be notified to the
shareholders concerned prior to the effective date of the liquidation and the notification will indicate the reasons for, and
the procedures of, the liquidation operations. Unless the board of directors otherwise decides in the interests of or to keep
equal treatment between the shareholders of the class concerned, they may continue to request redemption or conversion
of their shares on the basis of the applicable net asset value, taking into account the estimated liquidation expenses. Assets
which could not be distributed to their beneficiaries upon the close of the liquidation of the class will be deposited with the
Caisse de Consignation on behalf of their beneficiaries.
Under the same circumstances as provided in the preceding paragraph, the board of directors may decide to close down
a class by contribution into another class of the Company.
Art. 25. Mergers. The board of directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of the Law) of the
Company, either as receiving or absorbed UCITS, with:
- another existing or new Luxembourg or foreign UCITS (the "New UCITS"); or
- a compartment thereof,
and, as appropriate, to redesignate the shares of the Company, as shares of this New UCITS, or of the relevant com-
partment thereof as applicable.
In case the Company - involved in a merger - is the receiving UCITS (within the meaning of the Law), the board of
directors solely will decide on the merger and the effective date thereof.
In the case the Company - involved in a merger - is the absorbed UCITS (within the meaning of the Law), and hence
ceases to exist, the general meeting of the Shareholders, rather than the board of directors, has to approve, and decide on
the effective date of, such merger by a resolution adopted with no quorum requirement and at a simple majority of the votes
cast at such meeting.
Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the Law, in particular concerning the merger
project and the information to be provided to the Shareholders.
Shareholders will in any case be entitled to request, without any charge other than those retained by the Company to
meet disinvestment costs, the repurchase or redemption of their Shares, or, where possible, to convert them into units or
shares of another UCITS pursuing a similar investment policy and managed by the same management company or by any
other company with which the management company is linked by common management or control, or by substantial direct
or indirect holding, in accordance with the provisions of the Law.
Art. 26. Accounting Year. The accounting year of the Company shall commence on the first of January of each year
and shall terminate on the thirty-first of December of the same year.
Art. 27. Distributions. The general meeting of shareholders of the class or classes issued shall, upon proposal from the
board of directors and within the limits provided by law, determine how the results of the Company shall be disposed of,
and may from time to time declare, or authorize the board of directors to declare, distributions.
Distributions maybe effected either in the form of a distribution of dividends, or through redemption of shares according
to the rules defined in the Company's sale documents.
For any class of shares entitled to dividend distributions, the board of directors may decide to pay interim dividends in
compliance with the conditions set forth by law.
6404
L
U X E M B O U R G
Payment of distributions shall be made to such shareholders at their addresses in the register of shareholders.
Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall determine from
time to time.
The board of directors may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and conditions
as may be set forth by the board of directors.
Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the class
or classes of shares issued.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
Title V. Final Provisions
Art. 27. Depositary. To the extent required by law, the Company shall enter into a depositary bank agreement with a
banking or saving institution as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended (herein referred to
as the "Depositary").
The Depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law.
If the Depositary desires to retire, the board of directors shall use its best endeavours to find a successor Depositary
within two months of the effectiveness of such retirement. The directors may terminate the appointment of the Depositary
but shall not remove the Depositary unless and until a successor Depositary shall have been appointed to act in the place
thereof.
Art. 28. Dissolution of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting
of shareholders subject to the quorum and majority requirements referred to in Article 30 hereof.
Whenever the share capital falls below two-thirds of the minimum capital indicated in Article 5 hereof, the question of
the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting by the board of directors. The general meeting, for
which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the votes of the shares represented at the meeting.
The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the share
capital falls below one-fourth of the minimum capital set by Article 5 hereof; in such an event, the general meeting shall
be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one-fourth of the
votes of the shares represented at the meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets of
the Company have fallen below two-thirds or one-fourth of the legal minimum, as the case may be.
Art. 29. Liquidation. Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal
entities, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compensation.
Art. 30. Amendments to the Articles. These Articles may be amended by a general meeting of shareholders subject to
the quorum and majority requirements provided by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Art. 31. Statement. Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing persons
or shareholders also include corporations, partnerships associations and any other organized group of persons whether
incorporated or not.
Art. 32. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of
10 August 1915 on commercial companies and the Law as such laws may be amended from time to time.
Title VI. Transitory Measures
Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2016.
Title VII. Subscription - Payment
The appearing party hereby declares to subscribe to the 31,000 (thirty-one thousand) shares issued by the Company as
follows:
Marco Nicoletti, prenamed, subscribes to 31 (thirty-one) shares with no par value to be allocated to the Class R Shares.
All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) is at the
disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
The undersigned notary declares that the conditions set forth in articles 26, 26-3 and 26-5 of the law dated 10 August
1915 on commercial companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
Title VIII. Estimate of Costs
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about 3,300.- euro.
Title IX. Resolutions of the Shareholders
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder of the Company, representing the entirety of the
subscribed capital, passed the following resolutions:
6405
L
U X E M B O U R G
Are appointed as directors of the Company:
Sergio Bindi, born in Milan, on 11 June 1961 residing in 22 bld italie - 98000 Monaco
Paolo Bennici, born in Varese, on 12 July 1973, residing in via Bainsizza 9 - 21041 Alizzate (VA) Italy
Martin Rausch, born in Mettlach, on 30 september 1971, residing in Christian Kretzschmar Str. 3 D-66693 Germany
In accordance with article 16 of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of any two directors or
by the joint or single signature of any persons to who authority has been delegated by the board of directors.
The directors shall serve for a period of six (6) years.
Deloitte Audit, with registered at 560, rue de Neudorf, L- 2220 Luxembourg, is elected as independent statutory auditor
(réviseur d'entreprises).
The independent statutory auditor shall be appointed for a period ending at the close of the general meeting to be held
in 2017.
The Company shall have its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
Title X. Declaration
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned
appearing person, the present incorporation deed is worded in English.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 décembre 2015. Relation: EAC/2015/29548. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016050375/651.
(160009026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Fingas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 77.483.
In the year two thousand and fifteen, on the thirty-first day of December.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary established in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.
Appeared:
The board of FINGAS S.A., a company governed by the laws of Luxembourg with registration number RCS Luxembourg
B 77.483, registered and business address at 17, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, in person of its directors J. Rossi,
L. Vegas-Pieroni, R. Donati (hereinafter referred as “FINGAS” or the “Transferor Company” or the “Absorbed Company”)
And
The board of Cavagna Group UK Limited, Company registration number 03400444, registered and business address at
24 Longmoor Lane, Breaston, Derbyshire, United Kingdom DE72 3BB, acting by its authorised directors D. Cavagna and
N.J.E. Brown (hereinafter referred as “CG UK” or the “Transferee Company” or the “Absorbing Company” and together
with the Absorbed Company, the “Merging Companies”)
each of them here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at Pétange,
acting as the representative of the Merging Companies by virtue of board resolutions or proxies given under private seal.
Such board resolutions or proxies having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing
parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration
authorities.
Such appearing parties, acting in the here above stated capacities, have required the undersigned notary to record the
following:
COMMON CROSS-BORDER MERGER TERMS
Between
Cavagna Group UK Limited, Company registration number 03400444, registered and business address at 24 Longmoor
Lane, Breaston, Derbyshire, United Kingdom DE72 3BB, acting by its authorised directors D. Cavagna and N.J.E. Brown
(hereinafter referred as “CG UK”)
FINGAS S.A., Company registration number B 77.483, registered and business address at 17, Rue Beaumont, L-1219
Luxembourg, in person of its directors J. Rossi, L. Vegas-Pieroni, R. Donati (hereinafter referred as “FINGAS”)
(Jointly referred as the “Companies”)
6406
L
U X E M B O U R G
Whereas:
These Common Cross border Merger Terms have been prepared by the board of directors of the Companies in order to
establish a cross-border legal merger (the 7Merger”) within the meaning of EU Directive 2005/56/EC of the European
Parliament and Council of October 26, 2005 on Cross-border Mergers of private limited companies, implemented in the
United Kingdom by the Companies Regulation 2007 (the “UK Regulation”) and in Luxembourg by the bill of August 10,
1915, concerning the commercial companies as modified by the bill of June 10th, 2009 on cross-border mergers (the “Bill
on cross-border mergers”).
The Merger will consist of a Merger by absorption of wholly owned subsidiary, being namely the absorption of FINGAS
(the transferor company) by CG UK (the transferee company).
The Merger is conditional upon the completion of a precedent merger whereby Cavagna Group International B.V. (CGI
BV), a Dutch holding company with registered office in Amsterdam, the Netherlands, and with office address at Heriker-
bergweg 120, 1101 CM Amsterdam, the Netherlands, registered in the Dutch trade register under number 33296492,
currently owning 100% of FINGAS's shares, will be merging into CG UK and be transferring to the later all its assets and
liabilities under universal title of succession (the “Precedent Merger”), FINGAS's shares included.
By virtue of the Merger FINGAS will cease to exist as a standalone entity and CG UK will acquire all assets and assume
all liabilities and all other legal relationships of FINGAS under universal title of succession.
The following common draft terms refer to the Merger only.
The Merger will become effective at 00.00 AM GMT following the day on which the High Court of Justice of England
and Wales issue the order to approve the Merger (Effective Date of The Merger).
The purpose of the Merger is to streamline the group structure of Cavagna group, as better explained in the Directors
Report.
After the Merger will have effect, all existing business activities, shareholdings and other assets belonging to as well as
liabilities pertaining to CG UK and FINGAS will be consolidated into one single legal entity: CG UK.
1. Legal form, name, registered office and other information relating to the Merging Companies.
1.1. The Transferee Company is CG UK, company registration number 03400444, registered and business address at
24 Longmoor Lane, Breaston, Derbyshire, United Kingdom DE72 3BB.
1.2. CG UK, is a limited liability company, incorporated under and governed by the laws of England and Wales.
1.3. The Transferor Company is FINGAS, Company registration number B 77.483, registered and business address at
17, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
1.4. FINGAS, is a Société Anonyme, incorporated under and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
1.5. As a result of the Merger CG UK will not change any detail of its form, name and registered office and shall continue
to be subject to the laws of England and Wales.
2. The share exchange ratio and the amount of any cash payment.
2.1. Once the Precedent Merger has been completed, FINGAS will be wholly owned by CG UK and the Merger will
amount to a merger by absorption of a wholly owned subsidiary.
2.2. As a consequence of the Merger FINGAS will be dissolved, its net assets transferred to CG UK and FINGAS's
share capital held by CG UK cancelled, with no share exchange occurring.
2.3. No cash adjustments shall be made.
2.4. As the Merger amounts to a merger by absorption of a wholly owned subsidiary, the independent expert's report is
not required.
3. The terms relating to the allotment of shares in the transferee company.
3.1. Not applicable, as no allotment of shares will occur.
4. The likely effects of the cross-border merger for employees of each merging company.
4.1. FINGAS has no employees.
4.2. CG UK has 15 employees, whose employment contract will continue under the same terms and conditions.
4.3. The Merger is therefore not expected to affect, nor have any repercussions for the employees' position in the Merging
Companies.
5. The date from which the holding of shares in the transferee company will entitle the holders to participate in the
profits, and any special conditions affecting that entitlement.
5.1. Not applicable, as no share exchange will occur.
6. The date from which the transactions of the transferor company are to be treated for accounting purposes as being
those of the transferee company.
6.1. CG UK will include the transactions of FINGAS in its accounts from the beginning (1
st
January) of the financial
year in which the Merger will have affects (i.e. the Effective Date of The Merger).
6407
L
U X E M B O U R G
6.2. For tax purposes, as FINGAS will not leave any Luxembourg permanent establishment, the fiscal effects of the
Merger will start from the effective date of the Merger, and FINGAS's operations for the period form the starting date of
the financial year and the Effective date of the Merger, will be ordinarily taxed in the Luxembourg.
7. Any rights or restrictions attaching to shares or other securities in the transferee company to be allotted under the
cross border merger to the holders of shares in a transferor company to which any special rights or restrictions attach, or
the measures proposed concerning them.
7.1. Not applicable as no share allotment will occur.
8. Any amount of benefit paid or given or intended to be paid or given to the independent expert, or to any director of
a merging company, and the consideration for the payment of benefit.
8.1. No benefit or advantage will be paid to any expert, as no expert will be appointed.
8.2. No benefit or advantage will, or is intended to, be granted, paid or given to the directors, members of the adminis-
trative, management, supervisory or controlling bodies of the merging company as a consequence of the Merger.
9. The Transferee company's article of association.
9.1. CG UK's article of association is annexed sub 1, and will not change in any respect as a result of the Merger and/
or the Precedent Merger.
10. Employees' participation rights.
10.1. None of the merging Companies has in the 6 months before the publication of these draft terms of merger, an
average number of employees exceeding 500 people, nor has a proportion of employees' representatives amongst the
directors, nor has employees' representatives amongst members of the administrative or supervisory body or their com-
mittees or of the management group that covers the profit units of the company.
10.2. Considering above, Art. 16 of EU Directive 2005/56/EC (Employee participation), as implemented in the part 4
of UK regulation and in Luxembourg in the bill of August 10, 1915, concerning the commercial companies as modified
by the bill of June 10
th
, 2009 on cross-border mergers will not apply to the Merger.
11. Information on the evaluation of the assets and liabilities to be transferred to the transferee company.
11.1. For accounting purposes the assets and liabilities transfer from FINGAS to CG UK, will occur on a no gain/no
loss basis, i.e. in continuity of their accounting value.
11.2. For tax purposes, as no Luxembourg permanent establishment will be left in Luxembourg, the assets and liabilities
of FINGAS will be assessed by the directors of FINGAS at market value and the capital gains/losses be taxed (if taxable)/
deducted (if allowable) in Luxembourg.
12. Accounts used for the purpose of preparing the draft terms of the merger.
12.1. The draft term of the Merger have been prepared according to the financial situation of the companies as at 30
September 2015.
13. The terms for the exercise of the rights of the creditors and the address at which full information on these terms may
be obtained free of charge.
13.1. In accordance with article 268 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, a creditor
of the Transferor Company or the Transferee Company may request that his claims be secured if he demonstrates with
probability that their satisfaction is threatened by the merger.
13.2. In case of a dispute, based on a petition filed by the creditor of either the Transferor Company or the Transferee
Company within two months of the publication of the draft terms of merger either in United Kingdom or Luxembourg, the
court having jurisdiction for the seat of the Transferor Company or the Transferee Company (as the case may be), shall
resolve whether or not security should be granted as demanded by the creditor.
13.3. However, the creditor's petition shall not halt the issuance by the English registry court of the pre-merger certificate
conclusively attesting to the proper completion of the pre-merger acts and formalities to the extent that the Transferee
Company's court of jurisdiction has not ordered that a meeting of the creditors or the same class of creditors be summoned
pursuant to Regulation 11 of the Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 applicable in the United Kingdom.
13.4. Detailed information on the terms on which the creditors or the shareholders of the Transferor Company and the
Transferee Company may exercise their rights indicated above are available free of charge at the registered offices of each
of the merging companies, i.e. FINGAS, 17, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg; or Cavagna 24 Longmoor Lane, Breas-
ton, Derbyshire, United Kingdom, DE72 3BB.
14. Effects of the Merger.
14.1. On the effective date of the Merger:
a) all of the assets and liabilities of FINGAS will be transferred to CG UK;
b) FINGAS will be dissolved without going into liquidation;
14.2. All pending legal proceedings, if any, by or against FINGAS will be continued with the substitution of CG UK in
the place of FINGAS.
6408
L
U X E M B O U R G
14.3. Every contract, agreement or instrument to which FINGAS is a party shall, notwithstanding anything to the contrary
contained in the contract, agreement or instrument, be constituted and have effect as if:
i) CG UK has been a party thereto instead of FINGAS;
ii) for any reference (however worded and whether express or implied) to FINGAS there were substituted a reference
to CG UK; and
iii) any reference (however worded and whether express or implied) to the directors, officers, representatives or em-
ployees of FINGAS, or any of them, were, respectively a reference to the directors, officers, representatives or employees
of CG UK.
14.4. Every contract, agreement or instrument to which FINGAS is a party will become a contract, agreement or ins-
trument between CG UK and the counterparty at the same rights, and subject to the same obligations, liabilities and incidents
(including right of set off), as would have been applicable thereto if that contract, agreement or instrument had continued
in force between FINGAS and the counterparty, and any money due and owing (or payable) by or to FINGAS under or by
virtue of any such contract, agreement or instrument shall become due and owing (or payable) by or to CG UK instead of
FINGAS.
14.5. Any offer made to or by FINGAS before the merger effective date will be construed and have effect, respectively,
as an offer made to or by CG UK.
14.6. The powers of attorney issued by FINGAS, if any, shall remain valid and in force unless and until they are expressly
revoked by CG UK.
15. Amendments to these common Cross-Border Merger Terms.
15.1. CG UK and FINGAS may jointly consent, in the manners and within the limits provided under the respective
applicable laws, on behalf of all person concerned, to any modification of or addition to these Mergers terms or to any
terms or conditions to the Merger that the High Court of England and Wales or any Luxembourg competent authority may
approve or impose.
16. Publication of the draft terms.
16.1. These common draft terms of the Merger shall be published and be made available, inter alia, for inspection, by
those persons entitled to do so as set out in accordance with applicable law and regulation and for the avoidance of doubt,
they shall be made available for inspection free of charge at the registered office of FINGAS, 17, Rue Beaumont, L-1219
Luxembourg and the registered office of Cavagna UK Limited, 24 Longmoor Lane, Breaston, Derbyshire, United Kingdom,
DE72 3BB.
The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the common merger plan pursuant to Luxembourg
law.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On the request of the same appearing
parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le trente-et-un décembre.
Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1. Le conseil d'administration de Fingas S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 17,
rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 77.483, ci-après dénommée la «Société Absorbée»;
Ici représentée par Madame Sofia Da Chao, employée privée, demeurant professionnellement à Pétange, agissant en
qualité de mandataire du conseil d'administration de la Société Absorbante, en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par
une résolution prise par le conseil d'administration de la Société Absorbée le 4 décembre 2015.
2. Le conseil d'administration de Cavagna Group UK Limited, une société enregistrée sous le numéro 03400444, et
ayant son siège social 24 Longmoor Lane, Breaston, Derbyshire, Royaume-Uni DE72 3BB, ci-après dénommée la «Société
Absorbante», et avec la Société Absorbée, les «Sociétés qui Fusionnent»;
Ici représentée par Madame Sofia Da Chao, employée privée, demeurant professionnellement à Pétange, agissant en
qualité de mandataire du conseil de gérance de la Société Absorbée, en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par une
résolution prise par le conseil de gérance de la Société Absorbante le 21 décembre 2015.
Lesdites Résolutions, paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte.
6409
L
U X E M B O U R G
Les parties comparantes, représentées comme déclaré ci-dessus, ont requis le notaire soussigné d'acter le projet commun
de fusion qui suit:
PROJET COMMUN DE FUSION TRANSFRONTALIÈRE
Entre
Cavagna Group UK Limited, une société enregistrée sous le numéro 03400444, et ayant son siège social 24 Longmoor
Lane, Breaston, Derbyshire, Royaume-Uni DE72 3BB, représentée par ses administrateurs D. Cavagna and N.J.E. Brown
(ci-après désignée par “CG UK”)
FINGAS S.A., une société enregistrée sous le numéro B 77.483, et ayant son siège social et commercial au 17, Rue
Beaumont, L-1219 Luxembourg, représentée par ses administrateurs J. Rossi, L. Vegas-Pieroni, R. Donati (ci-après dési-
gnée par “FINGAS”)
(Ci-après ensemble désignées “les Sociétés”)
Préambule:
Ce Projet Commun de Fusion Transfrontalière a été préparé par le conseil d'administration des Sociétés en vue d'établir
une fusion transfrontalière légale (la «Fusion») au sens de la Directive 2005/56/EC du Parlement européen et du Conseil
du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, transposée au Royaume-Uni par la loi «Com-
panies Regulation 2007» (la «UK Regulation») et au Luxembourg par la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée par la loi du 10 juin 2009 relative aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux
(la «Loi sur les fusions transfrontalières»).
La Fusion consistera en une fusion par absorption d'une filiale détenue à 100%, à savoir l'absorption de FINGAS (la
société absorbée) par CG UK (la société absorbante).
La Fusion est subordonnée à l'accomplissement d'une fusion préalable par laquelle Cavagna Group International B.V.
(CGI BV), une société holding de droit néerlandais ayant son siège social au Herikerbergweg 120, 1101 CM Amsterdam,
Pays-Bas, enregistrée auprès du registre de commerce des Pays-Bas sous le numéro 33296492, détenant actuellement 100%
des actions de FINGAS, sera absorbée par CG UK et transférera à cette dernière tous ses actifs et passifs de manière
universelle (la «Fusion Préalable»), y compris les actions Fingas.
Par la Fusion, FINGAS cessera d'exister en tant qu'entité autonome et CG UK acquerra tous les actifs et supportera
toutes les dettes et autres relations de droit de FINGAS de manière universelle.
Le présent projet commun de fusion concerne uniquement la Fusion.
La Fusion produira ses effets à 0h00 GMT suivant l'approbation de la Fusion par la High Court of Justice of England
and Wales (Haute Cour de Justice d'Angleterre et de Galles), (Date Effective de la Fusion).
Le but de la Fusion est de rationaliser la structure du groupe Cavagna, ainsi qu'expliqué plus amplement dans le rapport
des Administrateurs.
Après que la Fusion ait produit ses effets, toute activité existante, participations ou autres actifs, ainsi que toutes dettes
relatives à CG UK et FINGAS seront réunis en une seule entité juridique: CG UK.
1. Forme sociale, dénomination sociale, siège social et autres informations concernant les Sociétés Fusionnantes.
1.1. La Société Absorbante est CG UK, enregistrée sous le numéro 03400444, ayant son siège social commercial 24
Longmoor Lane, Breaston, Derbyshire, Royaume-Uni DE72 3BB.
1.2. CG UK est une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles.
1.3.La Société Absorbée est FINGAS, une société enregistrée sous le numéro B 77.483, et ayant son siège social et
commercial au 17, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
1.4. FINGAS est une Société Anonyme, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg.
1.5. Suite à la Fusion, CG UK ne changera aucun détail sur sa forme juridique, dénomination sociale et siège social et
continuera d'être soumise aux lois d'Angleterre et du Pays de Galles.
2. Le rapport d'échange des actions et le montant de tout paiement en espèce.
2.1. Une fois la Fusion Préalable réalisée, FINGAS sera entièrement détenue par CG UK et la Fusion sera une fusion
par absorption d'une filiale détenue à 100%.
2.2. Par l'effet de la Fusion, FINGAS sera dissoute, ses actifs nets seront transférés à CG UK et le capital de FINGAS
détenu par CG UK sera annulé, sans qu'un échange d'actions n'ait lieu.
2.3. Aucun ajustement en espèces ne sera effectué.
2.4. Dans la mesure où la Fusion est une fusion par absorption d'une filiale détenue à 100%, le rapport d'experts indé-
pendant n'est pas exigé.
3. Les conditions relatives à l'attribution des actions à la société Absorbante.
3.1. Inapplicable, étant donné qu'aucune attribution n'aura lieu.
4. Les effets probables de la fusion transfrontalière pour les employés de chaque société fusionnante.
4.1. FINGAS n'emploie pas de personnel.
6410
L
U X E M B O U R G
4.2. CG UK a 15 employés, dont le contrat de travail continuera selon les mêmes termes et conditions.
4.3. La Fusion ne devrait donc pas affecter, ni n'avoir aucune répercussion sur la situation des employés des Sociétés
Fusionnantes.
5. Date à partir de laquelle la détention d'actions dans la société absorbante donnera le droit de participer aux bénéfices,
et toutes conditions spéciales affectant ce droit.
5.1. Non applicable, étant donné qu'aucun échange d'action n'aura lieu.
6. Date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée devront être considérées du point de vue comptable
comme étant celles de la société absorbante.
6.1. CG UK inclura les transactions de FINGAS dans ses comptes dès le début (1
er
janvier) de l'année financière lors
de laquelle la Fusion sera effective (c.à.d. la Date Effective de la Fusion).
6.2. Pour les besoins fiscaux, étant donné que FINGAS ne laissera aucun établissement stable au Luxembourg, les
conséquences fiscales de la Fusion débuteront à partir de la date effective de la Fusion, et les opérations de FINGAS pour
la période allant de la date de début de l'année financière à la date effective de la Fusion, seront normalement imposées au
Luxembourg.
7. Droits ou restrictions attachés aux actions ou autres titres de la société absorbante à attribuer lors de la fusion trans-
frontalière aux actionnaires de la société absorbée auxquels tout droit spécial ou restriction revient, ou les mesures proposées
à leur égard.
7.1. Non applicable, étant donné qu'aucune attribution d'action n'aura lieu.
8. Tout avantage payé ou donné ou destiné à être payé ou donné à l'expert indépendant, ou à chaque administrateur d'une
société fusionnante, et la contrepartie pour le paiement du bénéfice.
8.1. Aucune prestation ou avantage ne sera payé à un expert, étant donné qu'aucun expert ne sera nommé.
8.2. Aucune prestation ou avantage ne sera, ou n'est destiné à être accordé, payé ou donné aux administrateurs, membres
des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés fusionnantes suite à la Fusion.
9. Les statuts de la Société Absorbante.
9.1. Les statuts de CG UK sont annexés sub 1, et ne changeront pas suite à la Fusion et/ou la Fusion Préalable.
10. Les droits de participation des employés.
10.1. Aucune des sociétés fusionnantes n'a dans les 6 mois qui précède la publication de ce projet de fusion, un nombre
moyen d'employé excédant 500 personnes, ni de représentants des travailleurs parmi les administrateurs, ni de représentants
des travailleurs parmi les membres de l'organe d'administration ou de surveillance ou de leurs comités ou groupe de direction
qui gèrent les unités chargées d'atteindre des objectifs en termes de profit.
10.2. Par conséquent, l'article 16 de la directive UE 2005/56/EC (participation d'un employé), transposé dans la partie
4 de la loi de Grande-Bretagne et au Luxembourg dans Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée par la loi du 10 juin 2009 relative aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux, ne sera pas applicable
à la Fusion.
11. Information sur l'évaluation des actifs et passifs transférées à la société absorbante.
11.1. Pour les besoins comptables, les actifs et passifs de FINGAS seront transférés à CG UK, sans réalisation de perte
ou de gain, c.à.d. en continuité de leur valeur comptable.
11.2. Pour les besoins fiscaux, étant donné que FINGAS ne laissera aucun établissement stable au Luxembourg, les
actifs et passifs de FINGAS seront évalués par les administrateurs de FINGAS à valeur de marché, et les plus-values/moins-
values seront imposées (si imposable)/déductibles (si autorisé) au Luxembourg.
12. Comptes utilisés aux fins de préparation du projet de fusion.
12.1. Le projet de fusion a été préparé suivant la situation financière des sociétés au 30 Septembre 2015.
13. Conditions d'exercice des droits des créanciers et adresse à laquelle l'ensemble des détails relatifs à ces conditions
peuvent être obtenus gratuitement.
13.1. Conformément à l'article 268 de la Loi luxembourgeoise du 10 Août 1915 sur les Sociétés Commerciales, un
créancier de la Société Absorbée ou de la Société Absorbante peut demander que sa créance soit garantie s'il démontre de
façon probante que le remboursement de cette dernière est menacé par la fusion.
13.2. En cas de litige consécutif à une requête déposée par le créancier de la Société Absorbée ou de la Société Absorbante
dans le délai de deux mois suivant la publication du projet commun de fusion, au Royaume-Uni ou au Luxembourg, la
juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la Société Absorbée ou de la Société Absorbante sera, le cas
échéant, compétente pour décider si une garantie devra être accordée au créancier qui en fait la demande.
13.3. Toutefois, la requête du créancier n'interrompra pas la délivrance par le greffe du tribunal anglais d'un certificat
préalable à la fusion attestant que tous les actes et formalités préalables à la fusion ont été dûment accomplis, dans la mesure
où les tribunaux compétents du lieu de la Société Absorbante n'auront pas ordonné la tenue d'une assemblée des créanciers
6411
L
U X E M B O U R G
conformément au règlement 11 de la règlementation 2007 concernant les fusion transfrontalières [Regulation 11 of the
Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007] applicable en Grande Bretagne.
13.4. Les informations détaillées relatives aux conditions dans lesquelles les créanciers ou les actionnaires de la Société
Absorbée et la Société Absorbante peuvent exercer leurs droits mentionnés ci-dessus sont disponibles gratuitement aux
sièges sociaux des sociétés qui fusionnent, à savoir FINGAS, 17, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg; ou Cavagna 24
Longmoor Lane, Breaston, Derbyshire, Royaume-Uni DE72 3BB.
14. Effets de la Fusion.
14.1. A la date effective de la fusion:
a) Tous les actifs et passifs de FINGAS seront transférés à CG UK;
b) FINGAS sera dissoute sans liquidation;
14.2. Toutes les procédures judiciaires pendantes, s'il y en a, par ou contre FINGAS seront poursuivies par CG UK, à
la place de FINGAS.
14.3. Chaque contrat, accord ou instrument dans lesquels FINGAS est partie sera, nonobstant toute disposition contraire
dans le contrat, accord ou instrument, constitué et aura des effets comme si:
i) CG UK y a été partie à la place de FINGAS;
ii) toute référence (sous toute formulation et explicitement ou implicitement) à FINGAS sera substituée une référence
à CG UK; et
iii) toute référence (sous toute formulation et explicitement ou implicitement) aux administrateurs, cadres dirigeants,
représentants ou employés de FINGAS, ou n'importe lequel d'entre eux, fera respectivement référence aux administrateurs,
dirigeant, représentant ou employés de CG UK.
14.4. Tout contrat, accord ou instrument auquel FINGAS est partie deviendra un contrat, accord ou instrument entre
CG UK et le co-contractant avec les mêmes droits, et les mêmes obligations, responsabilités et leurs accessoires (incluant
le droit de compensation), qui aurait été applicable si ce contrat, accord ou instrument avait perduré entre FINGAS et le
co-contractant, et toute créance exigible ou payable par ou à FINGAS, dans le cadre d'un tel contrat, accord ou instrument
deviendra exigible ou payable par ou à CG UK au lieu de FINGAS.
14.5. Toute offre faite à, ou par FINGAS avant la date de fusion effective sera interprétée et aura des effets, respecti-
vement, comme une offre faite à, ou par CG UK.
14.6. Les procurations émises par FINGAS, s'il y en a, resteront valides et en vigueur, jusqu'à et à moins qu'elles ne
soient expressément révoquées par CG UK.
15. Modifications du Projet commun de fusion transfrontalière.
15.1. CG UK et FINGAS peuvent consentir conjointement, sous les formes et dans les limites fixées selon les lois
applicables, pour le compte de toute personne concernée, à toute modification ou ajout à ce Projet de Fusion, ou à tout
terme ou condition du Projet de Fusion, que la High Court d'Angleterre et du Pays de Galles ou toute autorité compétente
du Luxembourg pourrait approuver ou imposer.
16. Publication du projet.
16.1 Ce projet commun de fusion sera publié et rendu disponible, entre autres, aux fins de contrôle, par les personnes
compétentes pour ce faire en application des lois et règlements applicables, et plus précisément, aux fins d'un contrôle libre
et gratuit au siège social de FINGAS, 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg et au siège social de Cavagna UK Limited,
24 Longmoor Lane, Breaston, Derbyshire, United Kingdom, DE72 3BB
Le notaire soussigné certifie l'existence et la légalité du projet commun de fusion conformément à la loi luxembourgeoise.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des personnes comparantes mentionnées ci-
dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française. A la requête des mêmes personnes comparantes
et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont Acte, fait et passé à Pétange, à la date figurant en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et
résidence, ledit mandataire des parties comparantes a signé avec nous, notaire, le présent acte notarié.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 janvier 2016. Relation: EAC/2016/100. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
6412
L
U X E M B O U R G
Suivent les Statuts de la Société Absorbante
STATUTS DE CAVAGNA GROUP UK LIMITED
Acte et statuts constitutifs de Cavagna Group UK Limited Coordination officieuse réalisée pour les seuls besoins de la
fusion entre Cavagna Group UK Limited et Fingas S.A. Constituée le 1
er
septembre 1997
STATUTS CONSTITUTIFS DE CAVAGNA GROUP UK LIMITED
1. La dénomination de la Société est «Cavagna Group UK Limited».
2. Le siège social de la Société doit être situé en Angleterre et au Pays de Galles.
3. La Société a pour objet de:
A)
i) exercer le commerce ou les activités de marchands ou de négociants d'articles généraux, fabriquer, acheter, vendre,
importer, exporter, fournir et négocier des marchandises et des services de tous genres, accomplir tous actes en qualité de
distributeurs ou de mandataires, ainsi qu'acheter, vendre ou négocier des installations et des équipements de toute descrip-
tion,
ii) exercer tous autres commerces ou activités qui peuvent, de l'avis des administrateurs de la Société, être commodément
poursuivis par cette dernière,
B) acheter, prendre à bail ou en échange, louer ou par ailleurs acquérir et détenir, pour n'importe quel ayant cause ou
intérêt, des biens immobiliers ou mobiliers de toute nature s'avérant nécessaires ou commodes aux fins des activités, de
même que tous droits, privilèges ou servitudes de la Société sur de tels biens ou concernant ceux-ci,
C) construire, agrandir, transformer, maintenir, déménager ou remplacer de quelconques installations et machines, bâ-
timents, magasins, bureaux, usines, routes et autres ouvrages de quelque nature que ce soit, s'avérant nécessaires ou
commodes pour les activités de la Société, dégager les sites à ces fins et concourir à de telles activités ou subventionner
celles-ci,
D) acheter ou par ailleurs acquérir et assumer la responsabilité de tout ou partie des activités, des biens, de l'actif, du
passif et des opérations de toutes personne, entreprise ou société possédant des biens appropriés pour les besoins de la
présente Société, assurant ou se proposant de poursuivre toutes opérations dont l'exercice est autorisé par la présente Société,
lesquelles peuvent être mises en oeuvre conjointement avec ces activités ou sont susceptibles d'être menées de manière à
avantager, directement ou indirectement, la Société,
E) demander, déposer, acheter ou acquérir et protéger par tout autre moyen, prolonger et renouveler tous brevets, droits
attachés à des brevets, licences d'exploitation, marques de commerce, conceptions, protections et concessions, ainsi qu'uti-
liser, faire valoir, produire sous licence, octroyer des licences ou des privilèges y afférents,
F) emprunter ou réunir des fonds de la manière jugée indiquée par la Société pour les besoins de ses activités ou dans
le cadre de celles-ci,
G) pour les besoins de la Société, dans le cadre de ses activités ou obtenir le remboursement de tous fonds empruntés,
réunis ou exigibles par cette dernière, grever d'une hypothèque et d'une sûreté réelle les opérations et la totalité ou une
partie des biens et de l'actif actuels et à venir de la Société, ainsi que tout ou partie de son capital non libéré au moment
considéré et émettre au pair, au-dessus ou en dessous du pair, ce moyennant la contrepartie et dans le cadre et sous réserve
des droits, pouvoirs, privilèges et conditions pouvant être jugés adéquats, d'obligations ou d'actions préférentielles perma-
nentes, rachetables ou remboursables, et indirectement obtenir tous titres de la Société ou y contribuer par un acte fiduciaire
ou d'autres assurances,
H) prêter des fonds et accorder des crédits à toute société, entreprise ou personne, consentir toutes sortes de garanties
et de cautions, notamment se porter caution, soit par engagement personnel, soit en grevant d'une hypothèque ou d'une
sûreté réelle tout ou partie des opérations, des biens et de l'actif actuels et à venir, du capital non libéré de la Société, ou
en ayant recours à ces deux méthodes, l'exécution des obligations et le versement du capital ou du principal restant dû
(conjointement avec toute prime) de toutes obligations, actions ou d'autre titres (et des dividendes ou intérêts afférents à
ceux-ci) appartenant à une quelconque société, entreprise ou personne, y compris (mais sans limiter la généralité de ce qui
précède) toute société qui est, au moment considéré, la société holding ou une filiale de la Société; accomplir tous ces actes,
que la Société en perçoive ou non, directement ou indirectement, une contrepartie ou un avantage,
I) constituer et maintenir ou obtenir la constitution et le maintien d'une caisse de retraite ou d'un fonds de pension
contributif ou non, octroyer ou obtenir l'octroi de dons, d'indemnités, de pensions, d'allocations ou d'émoluments au profit
de personnes qui sont ou ont à tout moment été employées ou au service de la Société ou d'une société quelconque, laquelle
est, au moment considéré, la société ou une filiale de la Société ou est par ailleurs associée en affaires avec cette dernière,
ou qui sont ou ont à tout moment été administrateurs ou membres de la direction de la Société ou de cette autre société,
ainsi qu'au profit des conjoints, veufs, familles et personnes à charge de ces personnes; de même que constituer et sub-
ventionner tous établissements, associations, clubs ou fonds ou verser des sommes d'argent à de tels organismes ou fonds
conçus au profit ou pour la promotion des intérêts et du bien-être de la Société, d'une telle autre société ou de ces personnes;
effectuer des paiements au titre de l'assurance de ces personnes ou en vue de celle-ci et verser ou garantir des fonds à des
fins caritatives ou de bienfaisance, pour toute bourse d'études ou dans un but public, général ou utile; instaurer, établir,
6413
L
U X E M B O U R G
favoriser et maintenir des régimes d'achat d'actions ou d'intéressement du personnel au profit des employés de la Société
ou de toute société, laquelle est, au moment considéré, la société holding ou une filiale de la Société et accomplir tous les
points susvisés, soit seule, soit de concert avec une telle autre société,
J) retirer, souscrire, accepter, avaliser, négocier, escompter et signer des billets à ordre et d'autres effets négociables ou
transférables,
K) réaliser des investissements et négocier avec les fonds de la Société, qui ne sont pas immédiatement nécessaires pour
les besoins de ses activités, des placements ou des titres, ce de la manière pouvant être déterminée le cas échéant,
L) acquitter des biens ou droits acquis par la Société, soit en numéraire soit sous forme d'actions partiellement ou
entièrement libérées, assorties ou non de droits privilégiés, différés ou particuliers ou de restrictions de tout genre, soit
moyennant des titres que la Société est autorisée à émettre (ou en partie d'une manière et en partie d'une autre) et de manière
générale, selon les conditions pouvant être établies par la Société,
M) accepter le paiement en contrepartie de tout bien ou droit vendu ou par ailleurs aliéné ou géré par la Société, soit en
numéraire par acomptes ou autrement, soit sous forme d'actions partiellement ou entièrement libérées de toute société ou
personne morale, assorties ou non de droits privilégiés, différés ou particuliers ou de restrictions de tout genre, soit en
obligations ou actions privilégiées, hypothèques ou autres titres de toute société ou personne morale (ou en partie d'une
manière et en partie d'une autre) et de manière générale, selon les conditions pouvant être établies par la Société, ainsi que
détenir, céder ou par ailleurs négocier de quelconques actions ou titres ainsi acquis,
N) fusionner ou établir une société en nom collectif, une coentreprise ou un accord d'intéressement du personnel avec
toute société, entreprise ou personne poursuivant ou se proposant de mener des activités relevant des objets de la présente
Société, acquérir et détenir, vendre, négocier ou céder des actions ou des titres d'une telle société ainsi que se porter caution
des contrats ou du passif ou du paiement des dividendes, des intérêts ou du capital de toutes actions ou de titres de cette
société et octroyer des subventions ou par ailleurs prêter assistance à une telle société,
O) constituer, promouvoir ou approuver la constitution ou la promotion de toute autre société dont les objets s'entendent
de l'acquisition et de la reprise de la totalité ou d'une partie quelconque de l'actif et du passif de la présente Société ou de
la promotion de ce qui est, de quelque manière que ce soit, destiné à faire avancer, directement ou indirectement, les objets
ou intérêts de la présente Société, acquérir et détenir ou céder des actions ou des titres et garantir le versement des dividendes,
des intérêts ou du capital d'actions ou de titres émis par une telle autre société ou toutes autres obligations de cette dernière,
P) vendre, améliorer, gérer, développer, faire valoir, échanger, donner à bail les opérations et la totalité ou une partie
quelconque des biens et des éléments de l'actif de la Société, accorder des redevances, une part de bénéfices ou par ailleurs
délivrer des licences, octroyer des servitudes et d'autres droits s'y rattachant ainsi que, de quelque autre manière que ce soit,
gérer ou aliéner ceux-ci, au moment considéré, moyennant la contrepartie pouvant être jugée indiquée par la Société,
Q) souscrire, acheter ou par ailleurs acquérir les actions, les obligations ou d'autres titres d'une autre société,
R) procéder à la répartition en numéraire, entre les membres, de biens quelconques de la Société, de tous produits de la
vente ou de la cession de tels biens, mais de telle sorte qu'aucune répartition équivalant à une réduction de capital ne soit
versée, sauf avec l'autorisation (le cas échéant) exigée par la loi au moment considéré,
S) apporter une aide financière, directement or indirectement, dans le cadre de l'achat d'actions de la Société ou de sa
société holding ou aux fins de réduire ou d'acquitter tout passif encouru par n'importe quelle personne dans le cadre de
l'achat de telles actions, comme peut le permettre la loi,
T) souscrire et conserver une ou plusieurs polices d'assurance pour couvrir une éventuelle responsabilité des membres
de la direction de la Société ou de toute personne attachée à l'un de ces derniers, en raison de l'accomplissement de tous
actes ou de toutes omissions de leur part relativement à la Société,
U) accomplir tout ou partie des actes visés ci-dessus dans une quelconque région du monde, soit en qualité de mandants,
de mandataires, d'administrateurs, d'entreprise contractante ou autre, soit seule, ou de concert avec d'autres parties, soit par
l'intermédiaire de mandataires, d'administrateurs, de sous-traitants ou autrement et
V) accomplir tous les actes connexes ou propices à l'ensemble ou à l'un des objets visés ci-dessus.
Et il est déclaré par les présentes que chacun des paragraphes de la présente clause doit être considéré comme précisant
des objets distincts et indépendants et ne doit nullement, en conséquence, être limité par un renvoi ou une inférence à un
autre paragraphe. Aucun des objets mentionnés dans l'un des paragraphes de la présente clause ne saurait être réputé
simplement accessoire aux objets mentionnés dans un quelconque autre paragraphe.
4. La responsabilité des membres est limitée.
5. Le capital social de la Société est fixé à 2.940.000 livres sterling divisées en 2.940.000 parts de 1 livre sterling chacune.
Nous, soussignés les Souscripteurs du présent Acte constitutif, souhaitons être constitués en société en application du
présent Acte et nous engageons à souscrire le nombre de parts indiqué en face de nos noms respectifs.
STATUTS CONSTITUTIFS DE CAVAGNA GROUP UK LIMITED
Interprétation
1.1 Dans les présents statuts, sauf incompatibilité avec le contexte, les expressions suivantes ont la signification qui suit:
6414
L
U X E M B O U R G
«les Administrateurs»
Administrateurs de la Société désignés à tout moment agissant en qualité de personne morale
ou tout quorum de ces administrateurs présents lors d'une assemblée d'administrateurs.
«Table A»
Table A figurant à l'annexe du Règlement britannique de 1985 (tables A à F) sur les Sociétés
(Companies (tables A to F) Regulations 1985), tel que modifiée par le Règlement britannique
de 1985 (tables A à F) sur les Sociétés.
1.2 Dans la Table A, la définition de l'expression «le cachet» est modifiée et interprétée comme suit: «le cachet» désigne
le cachet ordinaire de la Société ou tout mode de signature sous la forme d'un acte autorisé par les statuts.
1.3 Sauf incompatibilité avec le contexte, les mots et expressions définis dans la Table A ont une signification semblable
à ceux utilisés dans les présents statuts, de même que les mots et expressions non définis dans la Table A, mais qui le sont
dans la Loi ont une signification semblable à celle qui leur y est attribuée (compte non tenu cependant d'une modification
légale quelconque non en vigueur lorsque les présents statuts ont été adoptés pour la première fois par la Société).
Observations préalables
2.1 Les règlements figurant dans la Table A s'appliquent à la Société, sauf dans la mesure où ils sont modifiés, exclus
par les présents statuts ou incompatibles avec ces derniers.
2.2 Les présents statuts, conjointement avec les règlements de la Table A ainsi modifiés ou exclus, forment les statuts
constitutifs de la Société.
Actions
3.1 Sous réserve de l'article 3.2, toutes les actions non émises du capital de la Société, au moment considéré, sont sous
le contrôle des Administrateurs et ces derniers peuvent attribuer, accorder ou par ailleurs négocier ou céder des options sur
celles-ci aux personnes, selon les conditions et la manière qu'ils jugent indiquée en règle générale.
3.2 Aux fins de l'article 80 de la Loi, les Administrateurs sont autorisés, de manière générale et sans condition, à attribuer
les titres appropriés (au sens de l'article 80 de la Loi), sous réserve que la valeur nominale globale des titres attribués en
vertu de ce pouvoir ne dépasse pas le montant du capital social autorisé avec lequel la Société a été constituée et à condition
que ce pouvoir, sauf modification, annulation ou renouvellement préalable, prenne fin au cinquième anniversaire de la
constitution de la Société.
3.3 En vertu du pouvoir conféré par l'article 3.2, les Administrateurs sont à tout moment fondés à formuler une offre ou
à conclure une entente qui peut nécessiter ou imposera l'attribution des titres appropriés après l'expiration de ce pouvoir.
3.4 Conformément à l'article 91 de la Loi, les articles 89(1) et 90(1) à (6) de la Loi ne s'appliquent à aucune attribution
de titres de capitaux propres (au sens de l'article 94 de la Loi) de la part de la Société.
Privilège
4. La Société jouit d'un privilège de premier rang et prépondérant sur toutes ses actions, qu'elles soient entièrement
libérées ou non, immatriculées au nom d'une personne endettée ou ayant un passif à l'égard de la Société, que cette personne
soit l'unique détentrice enregistrée ou l'une des codétentrices de ces actions, pour toutes les sommes d'argent actuellement
dues par elle-même ou ses ayants cause à la Société, que ce soit ou non relativement aux actions considérées. Le Règlement
8 de la Table A doit être modifié en conséquence.
Assemblées générales
5.1 Le Règlement 40 de la Table A doit être interprété comme si les mots «au moment où l'assemblée passe à l'ordre du
jour» étaient ajoutés à la fin de la première phrase.
5.2 En l'absence de quorum dans un délai d'une demi-heure à compter de l'heure convenue d'une assemblée générale,
celle-ci doit être reportée aux autres jour, heure et lieu pouvant être déterminés par les Administrateurs. En l'absence de
quorum lors d'une assemblée ajournée dans un délai d'une demi-heure à compter de l'heure convenue pour celle-ci, le ou
les membres présents en personne, représentés par un fondé de pouvoir ou (s'agissant d'une personne morale) par un
représentant et habilités à voter les points inscrits à l'ordre du jour, constituent un quorum. Le Règlement 41 de la Table A
ne s'applique pas.
5.3 Lors des assemblées générales de la Société, les membres peuvent voter en personne ou par procuration, à main
levée ou lors d'un scrutin. Le Règlement 54 de la Table A doit être modifié en conséquence.
Administrateurs
6.1 Le nombre d'administrateurs de la Société n'est pas limité. Si et dès lors que cette dernière ne dispose que d'un seul
administrateur, celui-ci peut exercer tous les pouvoirs conférés aux Administrateurs par les présents statuts ou par la Table
A. Le Règlement 89 de la Table A doit être modifié en conséquence.
6.2 Un administrateur peut, en cette qualité, voter toute résolution concernant un contrat ou un accord auquel il est
intéressé ou toute question en découlant. De surcroît, dans l'hypothèse de l'exercice de ce droit, son vote doit être pris en
considération dans le décompte et l'administrateur doit être compté pour établir un quorum lorsqu'un tel contrat ou accord
est à l'étude. Le Règlement 94 de la Table A doit être modifié en conséquence.
6415
L
U X E M B O U R G
6.3 Tout administrateur, y compris un administrateur suppléant, peut prendre part à une assemblée des administrateurs
ou à un comité d'administrateurs dont il est membre au moyen d'un téléphone de conférence ou d'un autre équipement de
communication semblable, par lequel toutes les personnes participant à l'assemblée peuvent s'entendre. La participation à
une assemblée de cette façon est considérée comme valant présence physique à celle-ci et l'administrateur doit, sous réserve
des présents statuts et de la Loi, être autorisé à voter et à être compté dans un quorum en conséquence. Une telle assemblée
est réputée se tenir soit dans le lieu de rassemblement du groupe recensant le plus grand nombre de participants, soit là où
se trouve alors le président de l'assemblée.
Nomination des administrateurs
7.1 Les administrateurs de la société ne sont pas tenus de mettre fin à leur mandat à tour de rôle et les Règlements 73 à
80 (compris) de la Table A ne s'appliquent pas.
7.1 La Société peut nommer, par résolution ordinaire des Administrateurs, toute personne disposée à agir en qualité
d'administrateur, soit afin de pourvoir à un poste vacant soit comme administrateur supplémentaire.
Le cachet
8. Le cachet ne doit être utilisé qu'avec l'autorisation des Administrateurs ou d'un comité d'administrateurs autorisé par
les Administrateurs. Ces derniers peuvent déterminer qui doit signer tout acte sur lequel est opéré ce mode de signature et
un tel acte doit être revêtu, sauf décision contraire des administrateurs, de la signature d'un administrateur et du secrétaire
ou d'un second administrateur.
Administrateurs suppléants
9.1 Tout administrateur (à l'exception d'un administrateur suppléant) peut nommer une personne pour exercer les fonc-
tions d'administrateur suppléant et démettre un administrateur suppléant ainsi nommé par ses soins. Le Règlement 65 de
la Table A ne s'applique pas.
9.2 Un administrateur suppléant n'est pas fondé à percevoir de rémunération de la part de la Société au titre des services
assurés en cette qualité, à ceci près qu'il peut être rétribué par la Société de la partie (le cas échéant) de la rémunération par
ailleurs due à l'administrateur l'ayant nommé qui peut, en tant que besoin, donner des instructions en ce sens par notification
écrite adressée à la Société.
9.3 Lorsqu'un administrateur suppléant s'avère également être administrateur ou agir en qualité d'administrateur sup-
pléant pour le compte de plusieurs administrateurs, il bénéficie d'une voix pour chacun des administrateurs qu'il représente
(en sus de sa propre voix s'il exerce lui-même les fonctions d'administrateur) et doit être considéré, lorsqu'il agit ainsi,
comme représentant deux administrateurs aux fins d'atteindre un quorum.
Garantie
10. Sous réserve des dispositions de la Loi, les Administrateurs et le secrétaire de la Société sont fondés à être garantis
sur les éléments de l'actif de la Société contre toutes pertes subies ou tout passif encouru par ces derniers dans le cadre de
l'acquittement et de l'exercice de leurs fonctions. Le Règlement 118 de la Table A ne s'applique pas.
Cession d'actions
11. Les administrateurs peuvent, à leur entière appréciation et sans devoir le justifier, refuser d'enregistrer une cession
quelconque d'actions, qu'il s'agisse d'actions entièrement libérées ou non. Le Règlement 24 de la table A doit être modifié
en conséquence.
Notifications
12. Toute notification requise de la part de la Société par les présents statuts doit être remise moyennant une quelconque
forme visible sur papier, y compris par télex, télécopie ou courrier électronique. Une notification communiquée par ces
formes de transmission immédiate est réputée avoir été remise au moment de sa transmission au destinataire. Les règlements
111 et 112 de la Table A doivent être interprétés en conséquence.
LOIS DE 1985 À 1989 SUR LES SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE PAR ACTIONS
STATUTS CONSTITUTIFS DE CAVAGNA GROUP UK LIMITED
Art. 1
er
. Observations préalables.
1(a) La Table A (ci-après désignée par le terme «Table A»), conformément aux règlements pris en application de l'article
8 de la loi de 1985 sur les Sociétés (Companies Act 1985), s'applique à la Société, sauf exclusion, modification, ou in-
compatibilité avec les règlements suivants ou avec l'acte constitutif de la Société. Les statuts qui suivent et les règlements
applicables figurant dans la Table A ou dûment modifiés, selon le cas constituent les règlements de la Société et comprennent
les statuts constitutifs de la Société.
1(b) Les Règlements 24, 30, 64, 73, 74, 75, 78, 79 et 80 de la Table A ne s'appliquent pas à la Société.
6416
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Actionnaires.
2(a) Assemblée générale annuelle: l'assemblée générale annuelle des actionnaires doit se tenir, moyennant la remise
dans un délai de 21 (vingt-et-un) à 60 (soixante) jours d'un avis de convocation écrit indiquant l'heure, le lieu et l'objet de
l'assemblée, le second mercredi du mois de mars de chaque année commençant le 1
er
janvier, au siège social de la Société
ou à l'heure et au lieu, pouvant également se situer à l'étranger, précisés dans la convocation, afin d'élire les administrateurs
et de délibérer des autres questions devant être mises en discussion par l'assemblée. Si cette date correspond à un jour férié,
l'assemblée doit se tenir à la même heure au cours du jour ouvrable suivant.
2(b) Assemblées extraordinaires: une assemblée extraordinaire peut être convoquée pour tout motif par le président ou
le conseil d'administration. Une assemblée extraordinaire peut se tenir, moyennant la remise dans un délai de 21 (vingt-et-
un) à 60 (soixante) jours d'un avis de convocation écrit indiquant l'heure, le lieu et l'objet de l'assemblée, dans le cas d'une
assemblée générale annuelle ou d'une assemblée visant l'adoption d'une résolution extraordinaire. Dans tous les autres cas,
un préavis de convocation d'au moins 14 (quatorze) jours doit être remis par écrit. Sous réserve des dispositions de la Loi
concernant les convocations aux assemblées générales, l'avis doit faire état de la date, du lieu et de l'objet de l'assemblée.
2(c) Intervention sans convocation d'assemblée: une résolution par écrit signée ou approuvée par courrier, télex, trans-
mission télécopiée ou câble par tous les membres de la Société, qui auraient été habilités à voter celle-ci si elle avait été
dûment proposée lors d'une assemblée générale ou lors d'une assemblée spéciale de membres actionnaires de toutes caté-
gories de la Société, ou par leurs mandataires dûment nommés, est aussi valide que si elle avait été adoptée lors d'une
assemblée générale ou d'une telle assemblée spéciale d'actionnaires (selon le cas) dûment convoquée et tenue. Une telle
résolution peut comprendre plusieurs documents de forme semblable, lesquels étant chacun signés par un ou plusieurs des
membres ou par leurs mandataires (ou dans le cas d'un membre qui est une personne morale, par un administrateur de celle-
ci ou par un représentant dûment nommé). Le Règlement 53 de la Table A ne s'applique pas à la Société. Des règles
particulières s'appliquent à la nomination des administrateurs, aux fusions, aux regroupements, aux acquisitions d'actions
ou aux ventes d'éléments de l'actif.
2(d) Mandat de l'assemblée générale: le mandat de l'assemblée générale consiste:
a. sous réserve du chapitre 1 de la partie 1 de la Loi sur les sociétés, à modifier et à compléter les présents statuts,
b. à approuver le rapport et le bilan annuels, à répartir les bénéfices et à décider de leurs versements ainsi que du paiement
des dividendes,
c. sous réserve du chapitre 1 de la partie V de la Loi, à augmenter ou à diminuer le capital social,
d. à nommer les administrateurs, à établir leur rémunération et à les dégager de leurs responsabilités,
e. à arrêter l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers et des droits réels à cet égard,
f. à décider de l'ouverture et de la fermeture de succursales et de la prise de participations dans d'autres sociétés et
g. à examiner la liquidation, la cessation d'activité ou la fusion de la Société avec une autre entreprise et à prendre des
arbitrages à cet égard.
2(e) Les résolutions en vertu des alinéas 2(d)(a) et 2(d)(c) doivent être adoptées par résolution extraordinaire (soit par
une majorité de 75 %) en application du chapitre 1 de la partie V de la Loi sur les sociétés. Les résolutions en vertu des
alinéas 2(d)(e), 2(d)(f) et 2(d)(g) doivent être adoptées par une majorité des deux tiers du capital social.
2(f) Quorum: aucune question ne doit être traitée lors d'une assemblée à moins que le quorum ne soit atteint. Deux
personnes habilitées à voter les questions inscrites à l'ordre du jour, chacune représentant un membre, un fondé de pouvoir
d'un membre ou un représentant dûment autorisé d'une personne morale, forment un quorum. En l'absence du quorum
mentionné ci-dessus lors de la première assemblée, le quorum de la deuxième assemblée doit atteindre un nombre d'ac-
tionnaires représentant la majorité du capital social de la société.
Art. 3. Conseil d'administration.
3(a) Nombre de membres et durée des fonctions: le conseil d'administration compte entre un (minimum) et cinq membres
(maximum). Les membres du conseil ne sont pas nécessairement actionnaires de la Société. Le nombre précis doit en être
fixé par les actionnaires lors de chaque assemblée annuelle avant l'élection des administrateurs. Chaque administrateur est
nommé par les actionnaires lors de chaque assemblée annuelle et exerce ses fonctions jusqu'à l'assemblée annuelle suivante
des actionnaires et en attendant que son successeur soit nommé et dispose des qualifications requises.
3(b) Assemblée ordinaire: une assemblée ordinaire du conseil d'administration doit être organisée sans avis de convo-
cation immédiatement après l'assemblée annuelle des actionnaires dans le même lieu que celle-ci, aux fins de nommer les
membres de la direction et d'expédier toutes autres affaires pouvant être mises en discussion par l'assemblée. Le conseil
peut, par résolution, prévoir des assemblées ordinaires complémentaires pouvant se tenir sans remise de convocation,
excepté cependant pour les membres absents au moment de l'adoption de la résolution.
3(c) Assemblée extraordinaire: une assemblée extraordinaire du conseil d'administration peut être à tout moment con-
voquée par le président ou par les administrateurs pour tout motif. Une telle assemblée doit être organisée dans un délai de
cinq jours à compter de la remise d'un avis de convocation si celui-ci a été transmis par télécopie ou par télégraphe ou de
dix jours en cas de remise par courrier affranchi. Cet avis doit préciser la date, l'heure et le lieu de l'assemblée, qui peut
également se tenir à l'étranger.
6417
L
U X E M B O U R G
3(d) Intervention sans convocation d'assemblée: une résolution écrite signée par tous les administrateurs habilités à
recevoir un avis de convocation à une assemblée des administrateurs ou du comité des administrateurs est aussi valide que
si elle avait été adoptée lors d'une assemblée des administrateurs ou d'un comité des administrateurs dûment convoquée et
tenue. Une telle résolution peut comprendre plusieurs documents de forme semblable, lesquels étant chacun signés par un
ou plusieurs administrateurs.
3(e) Quorum: une majorité de l'ensemble du conseil constitue un quorum pour l'expédition des affaires.
3(f) Restrictions des pouvoirs du conseil: le conseil est autorisé à diriger la Société pour atteindre et accomplir les buts
et objectifs de cette dernière, à l'exception des pouvoirs expressément réservés aux actionnaires en vertu de la loi ou des
présents statuts. Le conseil a notamment le droit de:
- établir la politique de prix et la stratégie commerciale de la société,
- prendre des décisions concernant les nouveaux investissements de la société,
- décider du budget annuel et du plan à long terme présenté par le directeur général,
- décider de l'acquisition de technologies, de brevets et de marques de commerce,
- engager ou révoquer les directeurs de la société,
- agir à titre de caution et accorder des prêts,
- autoriser l'inscription, la mainlevée et l'enregistrement des hypothèques,
- contracter des emprunts et d'autres lignes de crédit,
- conclure des contrats en tout genre avec les sociétés concurrentes des partenaires,
- trancher toutes les questions liées aux activités de la Société et
- arrêter et ratifier les rapports importants transmis par le directeur général (comme les budgets prévisionnels des frais,
les rapports d'activités annuels, etc.).
À la fin de chaque exercice, le directeur général doit établir les budgets trimestriels des frais de la société au titre de
l'année à venir, lesquels doivent être approuvés par les actionnaires jouissant de la majorité du capital social. Au cours des
trimestres, le directeur général est autorisé à signer les opérations prévues dans les budgets de frais mentionnés ci-dessus.
Toute dépense ne figurant pas au budget doit être autorisée par accord écrit de la majorité des actionnaires. Le directeur
général est personnellement responsable de toutes les dépenses non inscrites au budget et des opérations mises en oeuvre
sans l'accord des actionnaires.
3(g) Incapacité des administrateurs: le poste d'un administrateur devient vacant si celui-ci devient incapable, en raison
d'une maladie ou d'une blessure, de gérer et d'administrer ses biens et ses affaires et le Règlement 81 de la Table A doit
être modifié en conséquence. Sous réserve de l'article 303 de la partie IX de la Loi, la Société peut, par résolution ordinaire,
destituer un administrateur avant le terme de la période de ses fonctions, nonobstant toute stipulation des présents statuts
ou figurant dans un quelconque accord entre elle et ce dernier.
3(h) Présence aux assemblées: lorsque les installations de communications appropriées sont raisonnablement disponi-
bles, l'un ou l'ensemble des administrateurs sont autorisés à prendre part à l'intégralité ou à une partie d'une assemblée du
conseil ou d'un comité du conseil au moyen d'un téléphone de conférence ou d'un autre équipement de communication, par
lequel toutes les personnes participant à l'assemblée sont en mesure de s'entendre.
Art. 4. Cession d'actions.
4(a) Les actions d'un actionnaire peuvent être cédées ou acquises par héritage. La cession des actions à un autre action-
naire doit être mise en oeuvre sans aucune restriction, tandis que la cession d'actions à un tiers doit être réalisée selon les
modalités figurant ci-dessous.
4(b) Lorsqu'un actionnaire a l'intention de céder l'ensemble ou une partie de ses actions à un tiers, il est tenu de par ses
fonctions d'aviser tous les actionnaires moyennant une notification écrite indiquant le prix demandé, des renseignements
à propos de l'acheteur, le nombre d'actions devant être vendues, le délai et les modalités de paiement.
4(c) Dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la réception de la notification écrite, chaque actionnaire est autorisé
à acheter le nombre d'actions proposées à la vente, en proportion du nombre d'actions dont il est déjà détenteur, en remettant
une notification écrite à l'actionnaire vendeur. Dans le cas où un ou plusieurs actionnaires exercent le droit de préemption,
le prix de cession de l'action doit être calculé selon le critère déterminé par les actionnaires. La transaction doit être conclue
dans un délai de 30 (trente) jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification et après ce terme, l'actionnaire
a la latitude de céder ses actions à un tiers selon les conditions mentionnées dans la notification de l'offre.
4(d) Chaque actionnaire est fondé, selon les mêmes conditions, à acheter toutes les actions non vendues aux autres
actionnaires. Lorsque les actions proposées n'ont pas toutes été achetées par les actionnaires, l'actionnaire vendeur peut
céder les actions non vendues à un tiers ou retirer l'offre de vente dans son intégralité.
4(e) Toute cession d'actions qui ne satisfait pas aux stipulations du présent article est réputée nulle et non avenue. Les
stipulations précédentes ne s'appliquent pas aux cessions d'actions réalisées, en totalité ou en partie, au bénéfice de sociétés
dans lesquelles les actionnaires possèdent une participation à la date de réalisation de la cession. En pareils cas, chaque
actionnaire est à tout moment autorisé à céder ses propres actions, après avoir remis une notification écrite en ce sens aux
autres actionnaires, en faveur de ladite société sans être tenu à l'obligation de les proposer auparavant aux autres actionnaires
de la Société.
6418
L
U X E M B O U R G
Art. 5. Membres de la direction.
5(a) Élection: lors de son assemblée ordinaire suivant l'assemblée annuelle des actionnaires, le conseil doit élire un
président, un secrétaire et peut désigner d'autres membres de la direction, y compris un ou plusieurs directeurs généraux,
selon qu'il le juge nécessaire. Une personne peut exercer une ou plusieurs fonctions.
5(b) Fonctions et pouvoirs du président: le président est le président-directeur général de la Société. Sous réserve de
l'autorisation du conseil, il assure la charge et la direction générale, ainsi que la responsabilité, des opérations et des affaires
de la Société. Sauf instructions contraires du conseil, tous les autres membres de la direction sont soumis au pouvoir et à
la surveillance du président. Ce dernier peut, au nom de la Société, conclure et signer des contrats ou d'autres actes ne
s'inscrivant pas dans le cours normal de ses activités lesquels sont autorisés, soit de manière générale soit expressément,
par le conseil.
5(c) Fonctions et pouvoirs du directeur général: le directeur général exerce les fonctions et jouit du pouvoir qui peuvent,
à tout moment, lui être délégués par le conseil. En l'absence du président ou en cas de décès, d'incapacité ou de défaut
d'exécution de ce dernier, le directeur général exerce les fonctions et est investi du pouvoir du président.
5(d) Fonctions et pouvoirs du trésorier: sous réserve de la Loi sur les sociétés, le trésorier assume la garde des fonds et
des titres de la Société et tient ou faire tenir les livres comptables réguliers de la Société. Le trésorier exerce les autres
fonctions et bénéficie des autres pouvoirs découlant de cette fonction ou qui lui ont été confiés par le conseil.
5(e) Fonctions et pouvoirs du secrétaire: sous réserve de la Loi sur les sociétés, le secrétaire fait signifier les avis de
convocation à toutes les assemblées requises, dans les formes prescrites par les présents statuts et tient ou fait dresser le
procès-verbal de toutes les assemblées d'actionnaires et du conseil. Le secrétaire a la charge du cachet de la Société si cette
dernière en possède un. Il exerce les autres fonctions et bénéficie des autres pouvoirs découlant de cette fonction ou qui lui
ont été confiés par le président ou le conseil.
5(f) Destitution et démission des membres de la direction. Dotation des postes vacants: sous réserve de la Loi sur les
sociétés, tout membre de la direction élu par le conseil peut être destitué par ce dernier pour faute ou sans motif. Un membre
de la direction élu par les actionnaires peut seulement être destitué, pour faute ou sans motif, moyennant un vote des
actionnaires, mais son pouvoir d'exécution en qualité de membre de la direction peut être suspendu par le conseil pour un
motif valable. La destitution d'un membre de la direction doit intervenir sans préjudice de ses droits contractuels, le cas
échéant. L'élection d'un membre de la direction ne doit pas en tant que tel générer de droits contractuels. Un membre de la
direction peut démissionner moyennant un préavis écrit adressé à la Société. La démission prend effet à la suite de la
réception de celui-ci par la Société ou à une date ultérieure précisée dans l'avis de démission. Tout poste devenant vacant
parmi les membres de la direction, quelle qu'en soit la cause, doit être pourvu par le conseil.
Art. 6. Modifications apportées aux statuts et effets de ces derniers. Période comptable.
6(a) Effets des présents statuts: les présents statuts sont assujettis aux dispositions de la Loi sur les sociétés pouvant à
tout moment être modifiée. En cas d'incompatibilité de l'une des stipulations des présents statuts avec une disposition de
la Loi, la Loi s'applique.
6(b) Modifications relatives à ces règlements: sous réserve de la Loi sur les sociétés, les présents statuts peuvent être
modifiés ou annulés par l'assemblée générale des actionnaires.
6(c) Période comptable: l'exercice de la Société commence le 1
er
janvier de chaque année.
Art. 7. Notifications.
7(a) Toute notification ou un autre document peut être remis à l'un des membres par la Société soit personnellement,
soit moyennant un envoi par la poste adressé au membre à son adresse légale, par transmission télécopiée, par télex ou en
le laissant à son adresse légale à l'intention du membre, soit par d'autres moyens autorisés par écrit par le membre concerné.
Dans le cas de codétenteurs, la remise d'une notification ou d'un autre document à l'un des codétenteurs est, à toutes fins,
réputée valable pour tous les autres codétenteurs. Le Règlement 112 de la Table A doit être modifié en conséquence.
7(b) Toute notification ou un autre document adressé par la poste doit être envoyé par courrier recommandé. Toute
notification ou un autre document quelconque laissé à l'adresse légale par un biais autre que par la poste ou un envoi par
transmission télécopiée, télex ou un autre moyen de transmission, est réputé avoir été remis lorsqu'il a été ainsi laissé ou
envoyé. Le Règlement 115 de la Table A ne s'applique pas.
Enregistré à Esch/AI, A.C., le 05 JAN. 2016. Relation: EAC/2016/100. Reçu QUARANTE-QUATRE EUROS.
<i>Le Receveuri> .
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016050422/739.
(160008209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
6419
L
U X E M B O U R G
ParLyo Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 560.500,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 120.822.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth (24
th
) day of December,
before Maître Jacques Kesseler, notary public residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
were adopted the resolutions of the sole shareholder of ParLyo Property Holdings S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with
the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés) (the Register) under registration
number B 120822 (the Company).
The Company has been incorporated on 27 September 2006, pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary public
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Luxembourg official gazette (Journal Officiel du
Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) (the Official Gazette) n° 2284 of 7
December 2006. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on 12 July
2012, pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
published in the Official Gazette n° 2078 of 22 August 2012.
THERE APPEARS:
ParLyo Holdings Limited, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Cyprus, having its
registered office at 30, Karpenisiou Street, CY - 1660 Nicosia, Cyprus, and registered with the Cyprus companies register
under registration number HE 183890 (the Sole Shareholder),
duly and validly represented for the purpose hereof by Mrs Sofia Da Chao-Conde, private employee, residing profes-
sionally in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal (the Proxyholder).
Said proxy, after having been signed ne varietur by the Proxyholder and the undersigned notary, will remain attached
to this deed to be filed alongside with the registration authorities.
According to the resolutions of a meeting of the board of managers of the Company dated 22 December 2015, and the
resolutions of a meeting of the board of managers of ParLyo Property Holdings II S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Register
under registration number B 155357 (the Absorbing Company, and together with the Company, the Merging Companies)
dated 22 December 2015, the respective boards of managers of the Merging Companies (together, the Boards of Managers)
have approved the completion of a normal merger between the Company, as absorbed company, and the Absorbing Com-
pany, as absorbing company, through the absorption of the former by the latter (the Merger) in accordance with the terms
of a merger plan dated 18 November 2015, drawn up by the Boards of Managers in accordance with the provisions of
article 261 of the law of the Grand Duchy of Luxembourg dated 10 August 1915 governing commercial companies, as
amended (the Law), and published in the Official Gazette n° 3170 on 23 November 2015 (the Merger Plan).
The Sole Shareholder, duly and validly represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:
I. All the twenty-two thousand four hundred and twenty (22,420) ordinary shares of the Company, with a nominal value
of twenty-five euro (EUR25) each, representing the entire issued and outstanding share capital of the Company amounting
to five hundred sixty thousand and five hundred euro (EUR560,500), are present or duly and validly represented so that
the Sole Shareholder may validly resolve on all the items composing the Agenda (as this term is defined below);
II. The Sole Shareholder has been called in order to resolve on the items contained in the following agenda (the Agenda):
1. Acknowledgment of the completion of all the formalities prescribed by article 267 of the law of the Grand Duchy of
Luxembourg dated 10 August 1915 governing commercial companies, as amended;
2. Approval of a normal merger between the Company and ParLyo Property Holdings II S.à r.l. as a result of which the
Company, without being liquidated, will be absorbed by ParLyo Property Holdings II S.à r.l.;
3. Decision to cancel, with effect as of the day of publication of the notarial deed recording the resolutions of the Sole
Shareholder in the Official Gazette the twenty-two thousand four hundred and twenty (22,420) ordinary shares of the
Company, with a nominal value of twenty-five euro (EUR25) each, representing the entire issued and outstanding share
capital of the Company;
4. Acknowledgement of the resignation of, and grant of discharge (quitus) to, the managers and members of the board
of managers of the Company for the performance of their duties as managers and members of the board of managers of
the Company; and
5. Miscellaneous.
III. After due and careful consideration, the Sole Shareholder has adopted the following resolutions:
6420
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledges having due knowledge of the documents listed under article 267(1) a), b) and c)
of the Law and which are as follows:
1. the Merger Plan;
2. the annual accounts of the Company for the financial years ended 31 December 2012, 31 December 2013 and 31
December 2014; and
3. the interim non-audited statement of financial position of the Company as at 30 September 2015.
The Sole Shareholder, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, confirms that in accordance with the
provisions of article 267 of the Law, the documents listed above were made available to itself for inspection, as well as to
inspection by ParLyo Holdings II Ltd, a limited company incorporated and existing under the laws of Cyprus, having its
registered office at 30, Karpenisia Street, CY - 1660 Nicosia, Cyprus, and registered with the Cyprus companies register
under registration number 273721 (ParLyo Cyprus II), at the respective registered offices of the Merging Companies at
least one (1) month ahead of the date of these resolutions.
The Sole Shareholder acknowledges that in accordance with the provisions of article 265(3) of the Law, it has fully
waived the requirement for the board of managers of the Company to (i) prepare a detailed written report established for
consideration by the sole shareholder, or the extraordinary general meeting of shareholders, as the case may be, of each of
the Merging Companies, explaining the Merger Plan and setting forth and outlining the legal and economic drivers of the
Merger, in particular for the share exchange ratio, as provided for by article 265 (1) of the Law and (ii) provide the
information referred to in article 265(2) of the Law regarding any material change in the assets and/or liabilities position
which might have occurred between the date of the preparation of the Merger Plan and the date of the adoption of the
resolutions of the respective sole shareholder, or the extraordinary general meeting of shareholders, as the case may be, of
each of the Merging Companies, resolving, inter alia, upon the approval of the Merger Plan.
The Sole Shareholder further acknowledges that in accordance with the provisions of article 266(5) of the Law, it has
fully waived the requirement to have the Merger Plan examined by one or several independent expert(s) (expert(s) indé-
pendant(s)) and the preparation of a written report by such independent expert(s) (expert(s) indépendant(s)) for conside-
ration by the sole shareholder or shareholders of each of the Merging Companies regarding, inter alia, the determination
of the exchange ratio, in accordance with the provisions of article 266(1) of the Law.
In consideration of the above, the Sole Shareholder acknowledges that all the formalities prescribed by article 267 of
the Law have been duly satisfied.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the Merger and the terms of the Merger Plan.
The Sole Shareholder further resolves to approve that all the operations and transactions of the Company which are still
or have been carried out by the Company since 1 January 2015 will be considered for accounting purposes as being or
having been carried out by the Absorbing Company.
The Sole Shareholder finally resolves to approve that the Merger will be effective (i) between the Merging Companies
as of the date of the resolutions of the sole shareholder or the extraordinary general meeting of shareholders, as the case
may be, of each of the Merging Companies, approving the Merger, and (ii) towards third parties from the date of the
publication of the resolutions of the sole shareholder, or the extraordinary general meeting of shareholders, as the case may
be, of each of the Merging Companies, in the Official Gazette (the Effective Date).
As a result of the completion of the Merger and with effect as of the Effective Date, the Sole Shareholder acknowledges:
(i) the universal transfer of all of the assets and liabilities (transmission universelle de patrimoine) of the Company to
the benefit of the Absorbing Company; and
(ii) the dissolution without liquidation of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to cancel, with effect as of the day of publication of the present notarial deed in the
Official Gazette twenty-two thousand four hundred and twenty (22,420) ordinary shares of the Company, with a nominal
value of twenty-five euro (EUR25) each representing the entire issued and outstanding share capital of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the Merger, the Sole Shareholder acknowledges the resignation, effective as of the date of the present
resolutions, of the managers and members of the board of managers of the Company (each, a Manager) from their respective
mandate as managers and members of the board of managers of the Company, being namely:
- Mr David Barrett, with professional address at 72, boulevard Prince Felix, bâtiment Résidence Burlington I, L-1513
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Spiros Seretis, with professional address at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Aris Serbetis, with professional address at 3-5, chemin des Tuileries, CH - 1293 Bellevue, Geneva, Switzerland,
and
6421
L
U X E M B O U R G
- Mr Christopher Potter, with professional address at 3-5, chemin des Tuileries, CH - 1293 Bellevue, Geneva, Switzer-
land.
The Sole Shareholder resolves to grant discharge (quitus) to each Manager for the performance of their duties as managers
and members of the board of managers of the Company.
<i>Statementi>
In accordance with article 271(2) of the Law, the undersigned notary public declares that he has verified and certifies
the existence and the validity of (i) the legal acts and formalities required to be carried out by the Company and of (ii) the
Merger Plan.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the Sole Shareholder,
the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the Sole Shareholder, in case of
discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the year and day first above
written.
The document having been read to the Proxyholder, the said Proxyholder signed together with us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième (24
ème
) jour du mois de décembre,
par devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, ont été adoptées des
résolutions de l’associé unique de ParLyo Property Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et
existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le Re-
gistre) sous le numéro d’immatriculation B 1208223 (la Société).
La Société a été constituée le 27 septembre 2006 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le Journal Officiel) n° 2284 en date du 7 décembre 2006. Les statuts de la Société
(les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 12 juillet 2012 suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, publié au
Journal Officiel n° 2078 du 22 août 2012.
COMPARAIT:
ParLyo Holdings Limited, une limited liability company constituée et existante selon les lois de Chypre, ayant son siège
social sis 30, Karpenisiou Street, CY - 1660 Nicosie, Chypre, et immatriculé auprès du registre de commerce de Chypre
sous le numéro d'immatriculation HE 183890 (l’Associé Unique),
dûment et valablement représenté à l’effet des présentes par Mme Sofia Da Chao-Conde, employée, ayant son domicile
professionnel à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé (le Mandataire).
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le Mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront anne-
xées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci auprès des autorités compétentes.
Conformément au procès-verbal d’une réunion du conseil de gérance de la Société en date du 22 décembre 2015 et au
procès-verbal d’une réunion du conseil de gérance de ParLyo Property Holdings II S.à r.l., une société à responsabilité
limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre sous le numéro d’immatriculation
B 155357 (la Société Absorbante et ensemble avec la Société, les Sociétés Fusionnantes) en date du 22 décembre 2015,
les conseils de gérance respectifs des Sociétés Fusionnantes (ensemble, les Conseils de Gérance) ont décidé d’approuver
la réalisation d'une fusion normale entre la Société, en tant que société absorbée, et la Société Absorbante, en tant que
société absorbante, par voie d'absorption de la première par cette dernière (la Fusion), conformément aux stipulations d'un
projet commun de fusion en date du 18 novembre 2015 préparé par les Conseils de Gérance conformément aux dispositions
de l’article 261 de la loi du Grand-Duché de Luxembourg du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la Loi), et publié au Journal Officiel numéro 3170 du 23 novembre 2015 (le Projet de Fusion).
L'Associé Unique, dûment et valablement représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de
prendre acte que:
I. La totalité des vingt-deux mille quatre cent vingt (22.420) parts sociales ordinaires de la Société d'une valeur nominale
de vingt-cinq euro (EUR 25) chacune, représentant la totalité du capital social émis de la Société s'élevant à cinq cent
soixante mille cinq cents euro (EUR 560.500), sont présentes ou dûment et valablement représentées de sorte que l’Associé
Unique peut valablement délibérer sur l’ensemble des points composant l’Ordre du Jour (tel que ce terme est défini ci-
dessous);
II. L'Associé Unique a été convoqué afin de délibérer sur les éléments figurant à l’ordre du jour suivant (l’Ordre du
Jour):
1. Constatation de l’accomplissement de l’ensemble des formalités prévues à l’article 267 de la loi du Grand-Duché de
Luxembourg du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;
6422
L
U X E M B O U R G
2. Approbation d’une fusion normale entre la Société et ParLyo Property Holdings II S.à r.l. par voie d’absorption par
cette dernière de la Société, sans liquidation;
3. Décision d'annuler, avec effet au jour de la publication de l’acte notarié contenant les résolutions de l’Associé Unique
au Journal Officiel, les vingt-deux mille quatre cent vingt (22.420) parts sociales ordinaires de la Société d'une valeur
nominale de vingt-cinq euro (EUR 25) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société;
4. Constatation de la démission et de l’octroi d'un quitus aux gérants et membres du conseil de gérance de la Société
pour l’exercice de leurs fonctions en tant que gérants et membres du conseil de gérance de la Société; et
5. Divers.
III. Qu'après avoir dûment considéré l’Ordre du Jour, l’Associé Unique a adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique reconnaît avoir pris connaissance des documents visés à l’article 267(1) a), b) et c) de la Loi, qui sont
les suivants:
1. le Projet de Fusion;
2. les comptes annuels de la Société pour les exercices sociaux clos au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2013 et au
31 décembre 2014; et
3. les comptes intérimaires noon-audités de la Société au 30 septembre 2015.
L'Associé Unique, agissant en sa qualité d'associé unique de la Société, confirme que, conformément aux dispositions
de l’article 267 de la Loi, les documents énumérés ci-dessus ont été mis à sa disposition ainsi qu’à la disposition de ParLyo
Holdings II Ltd, une limited company constituée et existante selon les lois de Chypre, ayant son siège social sis 30, Kar-
penisia Street, CY - 1660 Nicosie, Chypre, et immatriculé auprès du registre de commerce de Chypre sous le numéro
d'immatriculation 273721 (ParLyo Cyprus II), aux sièes sociaux respectifs des Sociétés Fusionnantes au moins un (1) mois
avant l’adoption des présentes résolutions.
L'Associé Unique reconnaît que, conformément aux dispositions de l’article 265(3) de la Loi, il a entièrement renoncé
à l’obligation pesant sur le conseil de gérance de la Société, de (i) préparer un rapport écrit détaillé établi à l’intention de
l’associé unique, ou le cas échéant de l’assemblée générale extraordinaire des associés, de chacune des Sociétés Fusion-
nantes, expliquant le Projet de Fusion et exposant les motifs juridiques et économiques du Projet de Fusion, en particulier
le rapport d'échange des parts sociales conformément à l’article 265(1) de la Loi et (ii) fournir les informations visées à
l’article 265(2) de la Loi concernant tout changement important de l’actif et du passif qui aurait pu avoir lieu entre la date
de la préparation du Projet de Fusion et la date de l’adoption des résolutions de l’associé unique respectif, ou, le cas échéant,
de l’assemblée générale extraordinaire des associés, de chacune des Sociétés Fusionnantes, se prononçant, entre autres, sur
l’approbation du Projet de Fusion.
L'Associé Unique reconnaît en outre que, conformément aux dispositions de l’article 266(5) de la Loi, il a entièrement
renoncé à l’obligation de faire procéder à l’examen du Projet de Fusion par un ou plusieurs expert(s) indépendant(s) et la
préparation de rapports écrits par ledit (lesdits) expert(s) indépendant(s) à l’intention de l’associé unique ou, le cas échéant,
des associés de chacune des Sociétés Fusionnantes relativement à, entre autres, la détermination du rapport d'échange,
conformément aux dispositions de l’article 266(1) de la Loi.
En considération de ce qui précède, l’Associé Unique constate que l’ensemble des formalités prescrites par l’article 267
de la Loi ont été dûment respectées.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'approuver la Fusion et les termes du Projet de Fusion.
L'Associé Unique approuve en outre que l’ensemble des opérations et transactions de la Société qui sont ou ont été
réalisées ou accomplies par la Société depuis le 1 janvier 2015 sont réputées d'un point de vue comptable comme étant ou
ayant été réalisées ou accomplies par la Société Absorbante.
L'Associé Unique approuve également que la Fusion sera effective (i) entre les Sociétés Fusionnantes à la date des
résolutions de l’associé unique, ou le cas échéant de l’assemblée générale extraordinaire des associés, de chacune des
Sociétés Fusionnantes, se prononçant sur la Fusion et (ii) à l’égard des tiers à compter de la publication des résolutions de
l’associé unique, ou le cas échéant de l’assemblée générale extraordinaire des associés, de chacune des Sociétés Fusion-
nantes, au Journal Officiel (la Date d'Effet).
En conséquence de la réalisation de la Fusion et avec effet à compter de la Date d'Effet, l’Assemblée Générale constate:
(i) la transmission universelle du patrimoine de la Société au bénéfice de la Société Absorbante; et
(ii) la dissolution sans liquidation de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de supprimer, avec effet à compter de la date de publication du présent acte notarié au Journal
Officiel, vingt-deux mille quatre cent vingt (22.420) parts sociales ordinaires de la Société d'une valeur nominale de vingt-
cinq euro (EUR25) chacune, représentant la totalité du capital social émis de la Société.
6423
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de la Fusion, l’Associé Unique prend acte de la démission, effective à compter de la date des présentes
résolutions, des gérants et membres du conseil de gérance de la Société (chacun, un Gérant) de leur mandat respectif en
tant que gérants et membres du conseil de gérance de la Société, ces derniers étant respectivement:
- Mr David Barrett, ayant son adresse professionnelle au 72, boulevard Prince Felix, bâtiment Résidence Burlington I,
L-1513 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Mr Spiros Seretis, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg;
- Mr Aris Serbetis, ayant son adresse professionnelle au 3-5 chemin des Tuileries, CH - 1293 Bellevue, Genève, Suisse;
et
- Mr Christopher Potter, ayant son adresse professionnelle au 3-5 chemin des Tuileries, CH - 1293 Bellevue, Genève,
Suisse.
L'Associé Unique décide de donner quitus à chaque Gérant pour l’exercice de ses fonctions en qualité de gérants et
membres du conseil de gérance de la Société.
<i>Déclarationi>
En vertu de l’article 271(2) de la Loi, le notaire instrumentaire déclare qu’il a vérifié et atteste de l’existence et de la
validité (i) des actes légaux et des formalités requises à accomplir par la Société et (ii) du Plan de Fusion.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a
été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête des parties comparantes, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête de la présente.
Et après lecture faite aux parties comparantes, ledit Mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’original du présent
acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 janvier 2016. Relation: EAC/2016/7. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2016008614/254.
(160008193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Ficaroma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.975,40.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 201.757.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of December.
In front of Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
Mr. Maurice Augustin Paul Mane, born in Le Muy, on 11 May 1927, with address at 46, Avenue Auguste Renoir, 06520
Magagnosc, France (the “Sole Shareholder"),
hereby represented by Mrs. Sofia Afonso Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 13, route de Lu-
xembourg, L-4761 Pétange, by virtue of a proxy given under private seal.
Such power of attorney having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party
and the undersigned notary shall remain attached to this deed to be filed with it with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of Ficaroma S.à r.l., a private limited liability company (société à res-
ponsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 124, Boulevard
de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register ("R.C.S. Luxem-
bourg") under number 201757, with share capital of EUR 14,975.40 (fourteen thousand nine hundred seventy-five Euros
and forty cents), having transferred its registered office and its central administration from Curaçao to the Grand Duchy of
Luxembourg pursuant to a deed enacted by the undersigned notary on 25 November 2015 published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 3223 dated 28 November 2015 (the “Absorbed Company”).
II.- It is intended to merge the Absorbed Company into Finaroma International B.V., a private company with limited
liability organized and existing under the laws of the Netherlands, having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands,
with office address at Prins Hendriklaan 26, 1075 BD Amsterdam, the Netherlands, registered with the Trade Register of
6424
L
U X E M B O U R G
the Dutch Chamber of Commerce under number 33179849 and with an issued and outstanding share capital of NLG
3,750,000.00 (the "Absorbing Company") whereby the Absorbed Company will cease to exist, and its entire assets and
liabilities will be transferred to the Absorbing Company (the “Merger”).
III.- The 330 (three hundred thirty) shares of a nominal value of EUR 45.38 (forty-five Euros and thirty-eight Cents)
each, representing the whole share capital of the Absorbed Company, are represented so that the Sole Shareholder can
validly decide on all the items of the agenda of which it expressly states having been duly informed beforehand.
IV.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Acknowledgement of (i) the common terms of merger established by Finaroma International B.V. and Ficaroma S.à
r.l. and (ii) the explanatory reports of Finaroma International B.V. and Ficaroma S.à r.l. and acknowledgement of the
availability of documents in relation to the merger;
3. Approval of the absorption of Ficaroma S.à r.l. by Finaroma International B.V. as described in the above-mentioned
common terms of merger; and
4. Miscellaneous."
After the foregoing was approved, the Sole Shareholder declares the following:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder
acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put
at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each
document.
<i>Second resolution:i>
The board of directors of the Absorbed Company has approved the common terms of merger between the Absorbing
Company and the Absorbed Company (the "Common Terms of Merger") on 26 November 2015.
COMMON TERMS OF MERGER
The Common Terms of Merger have been executed by the Absorbing Company and the Absorbed Company under
private seal on 27 November and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3223 dated
28 November 2015. Further, the Common Terms of Merger have been published in Trouw (a Dutch national newspaper)
and in the Dutch State Gazette on 27 November 2015 in accordance with Dutch law.
<i>Explanatory reports of the Absorbing Company and the Absorbed Companyi>
The board of managing directors of the Absorbing Company and the board of managers of the Absorbed Company have
adopted and executed explanatory merger report on 26 November 2015, relating to the Merger.
<i>Public documentationi>
In accordance with Article 267 of the Luxembourg Law on Commercial Companies dated 10 August 1915, as amended,
and following a notice addressed by the Absorbed Company to its Sole Shareholder, the legal documentation in relation
to the Merger has been made available for inspection by the Sole Shareholder at the registered office of the Absorbed
Company.
<i>Third resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to approve the Merger, which is described in the Common Terms of Merger.
The Merger shall become effective between the Absorbing Company and the Absorbed Company one day after the
execution of the notarial deed of merger, subject to the relevant Dutch legal provisions (the “Effective Date”), on which
date notably the Absorbed Company will cease to exist and its assets and liabilities shall be transferred by operation of law
to the Absorbing Company under universal succession of title.
The 3,750 shares in the capital of the Absorbing Company held by the Absorbed Company, numbered 1 up to and
including 3,750, with a nominal value of NLG 1,000.00 each, in accordance with article 2:178c Dutch Civil Code, has a
countervalue of EUR 453,78 shall be redeemed. In exchange for the 330 currently issued shares, with a nominal value of
EUR 45.38, in the capital of the Absorbed Company, the Absorbing Company shall allot 3,750 shares, with a nominal
value of NLG 1,000.00, in accordance with article 2:178c Dutch Civil Code, has a countervalue of EUR 453,78, in its own
capital to Maurice Mane as sole shareholder of the Absorbed Company. Pursuant to the exchange ratio for the shares, no
additional payment shall be made to the sole shareholder of the Absorbed Company. It was noted that the newly issued
shares in the capital of the Absorbing Company shall entitle Maurice Mane to the profits of the Absorbing Company, as
from the Effective Date.
6425
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the Merger, of the Common Terms of Merger and
of all acts, documents and formalities incumbent to the Absorbed Company pursuant to Luxembourg law.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le trentième jour de décembre.
Par devant Maître Jacques Kesseler, notaire résidant à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
M. Maurice Augustin Paul Mane, né à Le Muy, le 11 mai 1927, résidant à 46, Avenue Auguste Renoir, 06520 Magagnosc,
France (l’“Associé Unique"),
ici représenté par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, clerc de notaire, résidant professionnellement au 13, route de
Luxembourg, L-4761 Pétange, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Ladite procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le
notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l’en-
registrement.
La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I.- La partie comparante est l’associé unique de Ficaroma S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg ("R.C.S. Luxembourg") sous le numéro B
201757, disposant d'un capital social de 14.975,40 EUR (quatorze mille neuf cent soixante-quinze Euros et quarante cents),
ayant transféré son siège social et sa direction de Curaçao au Grand-Duché de Luxembourg suite à un acte reçu par le
notaire soussigné le 25 novembre 2015 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3223 daté du
28 novembre 2015 (la “Société Absorbée”).
II.- Il est envisagé de procéder à la fusion absorption de la Société Absorbée par Finaroma International B.V., une société
à responsabilité limitée organisée et existante selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social sis à Amsterdam, Pays-
Bas, avec adresse au Prins Hendriklaan 26, 1075 BD Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée auprès du registre de commerce
de la chambre de commerce néerlandaise (Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce) sous le numéro 33179849
et disposant d'un capital social d'un montant de 3.750.000,00 NLG (la "Société Absorbante"), fusion selon laquelle la
Société Absorbée cessera d'exister, et la totalité de ses actifs et de ses passifs seront transférés à la Société Absorbante (la
“Fusion”).
III.- Les 330 (trois cent trente) parts sociales d'une valeur nominale de 45,38 EUR (quarante-cinq Euros et trente-huit
cents) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société Absorbée, sont représentées de sorte que l’assemblée
peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l’ordre du jour dont l’Associé Unique reconnaît expressément
avoir été dûment et préalablement informé.
IV.- L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation préalable;
2. Prise en compte (i) du projet commun de fusion établi par Finaroma International B.V. et Ficaroma S.à r.l. et (ii) des
rapports explicatifs de Finaroma International B.V. et Ficaroma S.à r.l. et reconnaissance de la disponibilité des documents
en rapport avec la fusion;
3. Approbation de l’absorption de Ficaroma S.à r.l. par Finaroma International B.V. tel que décrit dans le projet commun
de fusion susmentionné; et
4. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède, l’Associé Unique a déclaré ce qui suit:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l’Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable afférent à la présente assemblée. L’As-
socié Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et
en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que toute
la documentation pertinente a été mise à la disposition de l’Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un
examen attentif de chaque document.
6426
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolution:i>
Le conseil d'administration de la Société Absorbée a approuvé le projet commun de fusion entre la Société Absorbante
et la Société Absorbée (le "Projet Commun de Fusion") le 26 novembre 2015.
PROJET COMMUN DE FUSION
Le Projet Commun de Fusion a été adopté par la Société Absorbante et la Société Absorbée par signature d'un acte sous
seing privé le 27 novembre et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3223 daté du 28
novembre 2015. Le Projet Commun de Fusion a été publié au Trouw (un journal national néerlandais) et au journal officiel
des Pays-Bas le 27 novembre 2015 conformément à la loi néerlandaise.
<i>Rapports explicatifs de la Société Absorbante et de la Société Absorbéei>
Le conseil d'administration de la Société Absorbante et le conseil de gérance de la Société Absorbée ont adopté et signé
un rapport explicatif sur la fusion le 26 novembre 2015, en lien avec la Fusion.
<i>Documentation publiquei>
Conformément à l’article 267 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915, telle que
modifiée, et suite à une notice adressée par la Société Absorbée à son Associé Unique, la documentation légale en lien ave
la Fusion a été mise à disposition de l’Associé Unique au siège social de la Société Absorbée.
<i>Troisième résolution:i>
L'Associé Unique décide d'approuver la Fusion, qui est décrite dans le Projet Commun de Fusion.
La Fusion deviendra effective entre la Société Absorbante et la Société Absorbée un jour après la signature de l’acte
notarié de fusion, sous réserve des dispositions afférentes de la loi hollandaise (la “Date d'Effet”), à cette date la Société
Absorbée cessera d'exciter et ses actifs et passifs seront transférés par opération de la loi à la Société Absorbante par
succession universelle.
Les 3.750 parts sociales dans le capital de la Société Absorbante détenues par la Société Absorbée, numérotées de 1 à
3.750 inclues, d'une valeur nominale de 1.000,00 NLG chacune conformément à l’article 2:178c du Code civil néerlandais,
ayant une contre-valeur de 453.78 EUR devront être rachetées. En échange de 330 parts sociales actuellement émises, d'une
valeur nominale de 45.38 EUR, dans le capital social de la Société Absorbée, la Société Absorbante allouera 3.750 parts
sociales, d'une valeur nominale de 1.000,00 NLG, conformément à l’article 2:178c du Code civil néerlandais, ayant une
contrevaleur de 453.78 EUR, dans son propre capital à Maurice Mane en tant qu'associé unique de la Société Absorbée.
Conformément au ratio d'échange des parts sociales, aucun paiement additionnel ne sera effectué au profit de l’associé
unique de la Société Absorbée. Il a été noté que les parts sociales nouvellement émises dans le capital de la Société
Absorbante donnent droit à Maurice Mane aux profits de la Société Absorbante, à compter de la Date d'Effet.
Le notaire soussigné certifie par la présente l’existence et la légalité de la Fusion, du Projet Commun de Fusion et de
tous les actes, documents et formalités qui incombent à la Société Absorbée conformément à la Loi Luxembourgeoise.
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont Acte, fait et passé à Pétange, au jour indiqué en tête du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l’original
du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes compa-
rantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 janvier 2016. Relation: EAC/2016/95. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2016050907/179.
(160008062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Au Sud de l'Est Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 35, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 136.161.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés tenue à Dudelange en date du 11 novembre 2015i>
Après en avoir délibéré, l'associé présent prend les résolutions suivantes:
1. Le siège social est transféré de son adresse actuelle à L-3450 Dudelange, 35, rue du Commerce.
6427
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015183569/13.
(150204640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Codeis Securities SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 136.823.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu le 21 octobre 2015:i>
I. Démission de Monsieur Christophe GUIGNARD en tant qu'Administrateur du Conseil d'Administration:
Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Monsieur Christophe GUIGNARD, résidant professionnel-
lement au 17 Cours Valmy, F-92987 Paris, France de sa fonction d'Administrateur, avec effet au 21 Octobre 2015.
II. Cooptation de Madame Delphine RECH-GUITEL en tant qu'Administrateur du Conseil d'Administration en rem-
placement de Monsieur Christophe GUIGNARD:
Conformément aux prescriptions de l'article 11 des Statuts Coordonnées datés du 29 Mars 2011, le Conseil d'Adminis-
tration décide d'élire, à compter du 21 Octobre 2015 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en
Avril 2016, Mme Delphine RECH-GUITEL, résidant professionnellement au 10 Bishops Square, E1 6EG, London Roy-
aume-Uni, en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Christophe GUIGNARD, qui a démissionné.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015183633/18.
(150204862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Conti Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 193.300.
La Société a récemment changé d'adresse comme suit:
46a, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
vers le
49, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Christina Horf.
Référence de publication: 2015183637/18.
(150205064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Conical SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.581.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire uniquei>
Le mandat d'administrateur de
- IMT Trust Services Establishment, avec siège social situé au 56, Austrasse, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, représentée
par Monsieur Daniel KIEBER, représentant permanent,
- SGG ANSTALT, avec siège social situé au 56, Austrasse, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, représentée par Monsieur
François LANNERS, représentant permanent
- Madame Françoise DUMONT, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Lu-
xembourg,
- Monsieur Carlo SCHLESSER, domicilié professionnellement au 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg
6428
L
U X E M B O U R G
- ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTRÔLE SA, Société Anonyme, ayant son
siège social situé au 12, rue Guillaume Kroll, bâtiment F, L-1882 Luxembourg,
sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 4 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale
Statutaire de l'an 2019.
Fait, le 29 octobre 2015.
Certifié sincère et conforme
CONICAL SPF S.A.
Référence de publication: 2015183669/23.
(150204668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Château de Schengen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 111, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 147.919.
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue le 17 décembre 2012 le changement de commissaire:
Les actionnaires ont décidé de révoquer le commissaire TOP Audit (anciennement PKF Abax Audit), ayant son siège
social au 6, Place de Nancy L-2212 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce sous le numéro B 142.867. Les
actionnaires ont décidé de nommer le commissaire Compliance & Control, ayant son siège social au 6, Place de Nancy
L-2212 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce sous le numéro B 172.482.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée qui se tiendra en 2014.
Les actionnaires acceptent la démission des administrateurs suivants:
- Yves Ruppert, demeurant au 8, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg
- Christian Coljon, demeurant 4, rue Widderbierg, L-6675 Mertert
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2015183655/18.
(150204945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
D'Wäschfra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 12, rue Christophe Plantin.
R.C.S. Luxembourg B 199.888.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2015i>
<i>Première résolutioni>
Madame Dos Santos Matos Albina Antonia, demeurant à L-3770 Tétange 107 rue Principale a démissionné de son poste
d'administrateur.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur de la société:
- Madame SCIMA Claudia, demeurant au 3 place Grande-Duchesse Charlotte L-3710 Rumelange.
Suite à cette résolution le Conseil d'Administration se compose comme suit:
1. Madame BOJKOSVSKA Valentina, administrateur et premier président, demeurant à L-2624 Luxembourg 63 rue
Auguste Tremont.
2. Madame DE LIMA COSTA Maria, administrateur, demeurant à L-6919 Roodt-sur-Syre 4A Millesch.
3. Madame SCIMIA Claudia, administrateur, demeurant à L-3710 Rumelange 3 Place Grande-Duchesse Charlotte.
Le mandat des administrateurs et du premier président prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
BOJKOSVSKA Valentina / DE LIMA COSTA Maria / SCIMIA Claudia.
Référence de publication: 2015183690/22.
(150205240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
6429
L
U X E M B O U R G
DAMOI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 143.857.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire le 27 octobre 2015i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, et des sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS
SERVICES S.A. en tant qu'Administrateurs de la société.
Acceptation de la nomination de Madame Gabriele SCHNEIDER, née le 31 octobre 1966 à Birkenfeld/Nahe (Allema-
gne), adresse professionnelle au 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, comme Administrateur unique de la société.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2020.
Acceptation de la démission de Monsieur Eric HERREMANS en tant que commissaire aux Comptes à partir de ce jour.
Acceptation de la nomination de Madame Tazia BENAMEUR, née le 9 novembre 1969 à Mohammadia (Algérie),
adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme nouveau Commissaire aux Comptes de la
société.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2020.
Acceptation de la démission de la société BPH FINANCE S.A., déléguée à la gestion journalière.
<i>Pour la société
i>DAMOI S.A.
Référence de publication: 2015183699/21.
(150204606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Elite Groupe Recrutement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5720 Aspelt, 1, Um Klaeppchen.
R.C.S. Luxembourg B 163.701.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 6 novembre 2015i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société tenue en date du 6 novembre 2015 que:
<i>Première résolutioni>
Les Actionnaires décident d'accepter la démission des administrateurs actuels de la Société à savoir:
- Monsieur Pierre THOMAS demeurant professionnellement à L-5720 ASPELT, 1 um Klaeppchen
- Madame Martine CARRIERE demeurant professionnellement à L-5720 ASPELT, 1 um Klaeppchen
- Monsieur Pascal ROBINET demeurant à L-7412 BOUR, 5 rue d'Arlon.
<i>Seconde résolutioni>
Les Actionnaires décident de créer deux classes d'administrateur, une de classe A et une de classe B et de nommer en
remplacement des Administrateurs démissionnaires les personnes suivantes:
1. La société anonyme de droit luxembourgeois EUROCOM NETWORKS SA, établie et ayant son siège à L-5720
ASPELT, 1, Um Klaeppchen immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 45673
laquelle aura pour représentant personne physique, Monsieur Pierre THOMAS, né le 17 mai 1966 à Metz demeurant
professionnellement à L-5720 ASPELT, 1 Um Klaeppchen, administrateur de classe B
2. Monsieur Laurent HALIMl, né le 26 mai 1980 à Echirolles (France) demeurant à 49, Broom Lane NE16 4QU
WHICKHAM Tyne and Wear (Angleterre) administrateur de classe A
3. Monsieur Andrew ROBINSON né le 5 juin 1986 à Consett (Angleterre) demeurant à 39, Skendelby Drive, Kenton
Bar Newastle upon Tyne, NE3 3GJ Tyne and Wear administrateur de classe A
Les administrateurs nouvellement nommés jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2015.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015183741/32.
(150204870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
6430
L
U X E M B O U R G
Finatech S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 78.180.
Constituée suivant acte reçu par Me Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 9 octobre
2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 231 du 19 mars 2001.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 11 novembre 2015 que les membres
actuels du Conseil d'Administration ont été révoqués avec effet immédiat et qu'ils ont été remplacés comme suit:
- Ont été révoqués de leur mandat d'Administrateur avec effet immédiat:
* Monsieur Nello LAVIO, expert-comptable, demeurant professionnellement 4, Via Vicenzo d'Alberti CH-6830 Chias-
so.
M. Nello LAVIO a également été révoqué en tant qu'administrateur-délégué.
* Madame Silvia LAVIO-SCHNEIDER, employée privée, demeurant professionnellement 4, Via Vicenzo d'Alberti
CH-6830 Chiasso.
* Madame Mara DE BIASI, employée privée, demeurant professionnellement 4, Via Vicenzo d'Alberti CH-6830
Chiasso.
- Ont été nommés comme Administrateurs:
* Monsieur Claude FABER, expert-comptable, demeurant professionnellement 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Lu-
xembourg.
* Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Lu-
xembourg.
* Monsieur Denis MORAUX, expert-comptable, demeurant professionnellement 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Lu-
xembourg.
Luxembourg, le 11 novembre 2015.
<i>Pour la société FINATECH S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Référence de publication: 2015183792/29.
(150204799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Gandria Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 69.918.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 6 octobre 2015i>
1. M. Sébastien ANDRE a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2020.
2. M. Julien NAZEYROLLAS a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
statutaire de 2020.
3. M. David SANA a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire
de 2020.
4. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2020.
Veuillez noter que le siège social de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S. à r. l., R.C.S. Luxembourg B
58545, se situe désormais à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour GANDRIA HOLDING S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015183821/22.
(150204804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
6431
L
U X E M B O U R G
Grenkelocation SARL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 149.514.
EXTRAIT
Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Grenkelocation Sàrl qui s'est tenue au
siège social de la société le 30 octobre 2015 que:
- La société transfert son siège social au 2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach avec effet au 25 novembre 2015.
- La société accepte la démission de Monsieur Guillaume CUNY de son poste de gérant avec effet au 31 octobre 2015.
- Sont nommés en tant que gérant technique Monsieur Nicolas ZABERA, né le 21 mai 1970 à Troyes (France), et
Monsieur Conradus AARNINCK, né le 24 mars 1968 à Venlo (Pays-Bas), demeurant professionnellement à 6A, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, pour une durée de 3 ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2015.
<i>Pour Grenkelocation Sàrl
i>LPL Expert-Comptable Sàrl
Référence de publication: 2015183841/19.
(150204808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Golden Profit Plus Oil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 161.036.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 25 Août 2015i>
1. Monsieur Dennis Bosje a démissionné de son mandat de Gérant avec effet au 25 Août 2015.
2. Monsieur Frank Pletsch, né le 15 juillet 1974 à Trèves, Allemagne, demeurant professionnellement à 5, Avenue
Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, a été nommé comme Gérant avec effet au 25 Août 2015 pour une période indéter-
minée.
3. Monsieur Sinan Sar a démissionné de son mandat de Gérant avec effet au 25 Août 2015.
4. Monsieur Mark Gorholt, né le 26 novembre 1980 à Trèves, Allemagne, demeurant professionnellement à 5, Avenue
Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, a été nommé comme Gérant avec effet au 25 Août 2015 pour une période indéter-
minée.
Luxembourg, le 11.11.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Golden Profit Plus Oil Sàrl
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2015183813/20.
(150204582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Delta Spain S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital
à Risque.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 116.321.
Lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 23 octobre 2015, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé de Deloitte Audit S.à r.l. avec siège social au 560, Rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur
les comptes dont l'exercice se clôture au 31 décembre 2015.
Luxembourg, le 23 Octobre 2015.
Référence de publication: 2015183695/13.
(150204895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
6432
Au Sud de l'Est Sàrl
BNP Paribas Plan
Château de Schengen S.A.
Codeis Securities SA
Cofralux
Conical SPF S.A.
Conti Holding S.à.r.l.
DAMOI S.A.
Delebois & O'Donnell S.à.r.l.
Delta Spain S.à r.l., SICAR
Detem Luxembourg S.A.
Dicar S.à r.l.
DIT Luxembourg 1 S.à r.l.
D'Wäschfra S.A.
Elite Groupe Recrutement S.A.
ELSEN-BAU Luxemburg S.à r.l.
Emerald Euro Investment Grade Bond
ENTREPRISE DE TRANSPORTS CORDELLA Cosimino
Feba Advice S.à r.l.
Ficaroma S.à r.l.
Finatech S.A.
Finconsulting S.à r.l.
Fingas S.A.
France Menuiserie S.à r.l.
Gandria Holding S.A.
Global Outsourcing S.A.
Golden Profit Plus Oil S.à r.l.
Grenkelocation SARL
House International S.A.
Icon 1 S.A.
Inversiones Bren S.A.
JAR Capital
ParLyo Property Holdings S.à r.l.
RREI Holding S.A.
SBF S.A.
SBF S.A.
Société de Participations FILUNOR
Société de Participations FILUNOR
Solway Commodities Sàrl
Spartech Luxembourg Holding Company S.à r.l.
Spartech Luxembourg Holding Company S.à r.l.
Step Luxco
Swiss Alpha, SICAV
Synapse Mobile Networks S.A.
Synergo S.A.
Synergo S.A.
Synergo S.A.
Triton III LuxCo 3 S.à r.l.
T.S.I. Communication s.à r.l.