This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 124
18 janvier 2016
SOMMAIRE
Bordeso Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5932
DCM Systematic GP, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
5943
EHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5926
Elika Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5934
Famhold S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5926
G.A. - Fund -L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5912
Generali Investments SICAV . . . . . . . . . . . . . .
5913
Generali Multinational Pension Solutions SI-
CAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5918
Generali Multi Portfolio Solutions SICAV . . .
5918
International Real Estate Management S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5906
Jabiro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5950
Jabiro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5950
J.C.A. Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5950
Julima S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5950
La Française IC Fund, SICAV-FIS . . . . . . . . .
5915
Log S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5911
Luxicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5908
Luxicav Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5908
Magellan Equity Investments S.à r.l. . . . . . . . .
5952
Magella S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5951
Mandrinvest Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
5952
Mapau Consult S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5951
Margaux Immobilière S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
5951
Martin Currie Global Funds . . . . . . . . . . . . . .
5909
Matières Grises SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5952
MaxxCap S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5951
MDO Management Company . . . . . . . . . . . . .
5909
Michaël Schulzen et Christian Meyer S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5952
Mohawk Financing International S.à.r.l. . . . .
5928
Mohawk Foreign Funding S.à r.l. . . . . . . . . . .
5951
Mohawk International Financing S.à r.l. . . . .
5936
Mstab Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5950
North Low S .à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5949
PTF Acquisition Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . .
5952
RBS Market Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5911
Riskelia Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5920
Save Time Services s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5924
Structured Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5942
Symphonia Lux Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5921
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5940
Vison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5906
Walser Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5907
WALSER Vermögensverwaltung . . . . . . . . . .
5907
WB Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5926
Yellow Funds Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5922
5905
L
U X E M B O U R G
International Real Estate Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 70.426.
The Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held exceptionally on <i>5th February, 2016i> at 9.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Management report of the Board of Directors and report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31st , 2014 and as at December 31st,
2015;
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor;
4. Ratification of the co-option of Ms. Nisia NGO BAYIHA as Director;
5. Special discharge to Mr. Christian FRANCOIS with respect to the period of his mandate until the day of his resig-
nation;
6. Miscellaneous
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016050206/795/19.
Vison, Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 173.151.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 février 2016i> à 09:30 heures au 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la forme de la Société en une société de gestion de patrimoine familial (" SPF ").
2. Modification de la dénomination sociale actuelle de la Société et modification subséquente de l'article 1er des statuts
de la Société.
3. Modification de l'objet social afin de donner à l'article 4 des statuts la teneur suivante:
"Article 4. La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou
autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire
tous concours, prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet
identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énu-
mération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.
La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social".
4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société.
5. Modification de l'article 17 des statuts de la Société.
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016050208/1267/36.
5906
L
U X E M B O U R G
Walser Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 79.320.
Die Aktionäre der WALSER PORTFOLIO werden hiermit zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der aktionäre eingeladen, die am <i>27. Januar 2016i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen mit folgender
Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung der Schreibweise der Investmentgesellschaft, Änderung des Artikel 1 der Satzung.
Die Schreibweise der Investmentgesellschaft wird geändert in WALSER Portfolio.
2. Änderung des Artikel 18 der Satzung.
Das Datum der jährlichen Generalversammlung wird verlegt auf den dritten Freitag im Juli.
3. Aktualisierung der Satzung der Investmentgesellschaft hinsichtlich rechtlicher Vorgaben sowie redaktionelle An-
passungen.
Von den Änderungen betroffen sind die Artikel 4 und 16 der Satzung.
4. Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären vor, Frau Mag. Regina Reitter in den Verwaltungsrat der Investment-
gesellschaft zu berufen.
Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 28. Januar 2016 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.
Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung, verlangen ein Anwesenheitsquorum von
mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle,
in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite
Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts
einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist
kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.
Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der
Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt
gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage
vor der Generalversammlung vorliegen.
Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden ge-
beten sich bis spätestens 22. Januar 2016 anzumelden.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der WALSER PORTFOLIO (DZ PRIVATBANK
S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016003532/755/38.
WALSER Vermögensverwaltung, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 133.042.
Die Aktionäre der WALSER Vermögensverwaltung werden hiermit zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der aktionäre eingeladen, die am <i>27. Januar 2016i> um 11.15 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen mit folgender
Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung des Namens der Investmentgesellschaft, Änderung des Artikel 1 der Satzung.
Die Investmentgesellschaft wird umbenannt in WALSER Strategie.
2. Änderung des Artikel 18 der Satzung.
Das Datum der jährlichen Generalversammlung wird verlegt auf den dritten Freitag im Juli.
3. Aktualisierung der Satzung der Investmentgesellschaft hinsichtlich rechtlicher Vorgaben sowie redaktionelle An-
passungen.
Von den Änderungen betroffen sind die Artikel 4 und 16 der Satzung.
4. Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären vor, Frau Mag. Regina Reitter in den Verwaltungsrat der Investment-
gesellschaft zu berufen.
Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 28. Januar 2016 in Kraft.
5907
L
U X E M B O U R G
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.
Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung, verlangen ein Anwesenheitsquorum von
mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle,
in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite
Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts
einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist
kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.
Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der
Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt
gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage
vor der Generalversammlung vorliegen.
Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden ge-
beten sich bis spätestens 22. Januar 2016 anzumelden.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der WALSER Vermögensverwaltung (DZ PRI-
VATBANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016003851/755/38.
Luxicav Plus, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 108.752.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>25 janvier 2016i> à 11.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 30 septembre 2015 ;
2. rapport du réviseur d'entreprises sur l'exercice clôturé au 30 septembre 2015;
3. approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2015 et affectation des résultats ;
4. décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat;
5. nominations statutaires;
6. ratification des décisions prises par le conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2016;
7. divers.
Ces décisions ne requièrent aucun quorum et seront prises à la majorité simple des voix exprimées.
Les Actionnaires désirant assister à cette Assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l'Assemblée
Générale soit au guichet de l'Agent de Transfert à International Financial Data Services, 47, avenue J. F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, soit au siège social de Luxicav Plus, 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016004309/755/22.
Luxicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 30.337.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>25 janvier 2016i> à 11.00 heures au siège social. L'ordre du jour est le suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 30 septembre 2015 ;
2. rapport du réviseur d'entreprises sur l'exercice clôturé au 30 septembre 2015;
3. approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2015 et affectation des résultats ;
4. décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat;
5. nominations statutaires;
6. ratification des décisions prises par le conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2016;
7. divers.
Ces décisions ne requièrent aucun quorum et seront prises à la majorité simple des voix exprimées.
5908
L
U X E M B O U R G
Les Actionnaires désirant assister à cette Assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l'Assemblée
Générale soit au guichet de l'Agent de Transfert à International Financial Data Services, 47, avenue J. F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, soit au siège social de Luxicav, 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016004310/755/22.
MDO Management Company, Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 96.744.
Le règlement de gestion du fonds commun de placement – fonds d'investissement spécialisé Nissay UCITS Funds a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 5 janvier 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016003975/12.
(160002376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Martin Currie Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 65.796.
Shareholders are hereby convened to attend
EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS OF
Legg Mason Martin Currie GF Greater China Fund,
Legg Mason Martin Currie GF Global Resources Fund,
Legg Mason Martin Currie GF Japan Absolute Alpha Fund,
Legg Mason Martin Currie GF Asia Long Term Unconstrained Fund,
Legg Mason Martin Currie GF European Absolute Alpha Fund,
Legg Mason Martin Currie GF North American Fund, and
Legg Mason Martin Currie GF Asia Pacific Fund
(each a "Meeting", together the "Meetings") sub-funds of the Fund, which will be held on <i>5 February 2016i> at 11 a.m.
CET at the registered office of the Fund, to deliberate and vote on the following agenda:
<i>Agendai>
I. To approve separately the Mergers of the seven sub-funds of the Martin Currie Global Funds mentioned in the table
below (the "Merging Sub-Funds"), into the sub-funds of Legg Mason Global Funds Plc (the "Receiving Fund"), a company
having its registered office in Ireland, upon hearing:
a. the information notice on the proposed merger (the "Merger Notice");
b. a report of the Board of Directors (the "Board") of the Fund explaining and justifying the merger proposal (the
"Common Terms of Merger") as follows;
Martin Currie Global Funds
Merging Sub-Funds
Legg Mason Global Funds Plc
Receiving Sub-Funds
Merger of Legg Mason Martin Currie GF Greater China Fund into Legg Mason Martin Currie Greater China Fund
Merger of Legg Mason Martin Currie GF Global Resources
Fund
into Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund
Merger of Legg Mason Martin Currie GF Japan Absolute
Alpha Fund
into Legg Mason Martin Currie Japan Absolute Alpha Fund
Merger of Legg Mason Martin Currie GF Asia Long Term
Unconstrained Fund
into Legg Mason Martin Currie Asia Long-Term Uncon-
strained Fund
Merger of Legg Mason Martin Currie GF European Absolute
Alpha Fund
into Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha
Fund
Merger of Legg Mason Martin Currie GF North American
Fund
into Legg Mason Martin Currie North American Fund
Merger of Legg Mason Martin Currie GF Asia Pacific Fund into Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund
as well as on the related actions, namely
5909
L
U X E M B O U R G
• to approve the proposed Mergers as set forth in the Merger Notice and the Common Terms of Merger;
• to determine 11 March 2016 as the effective date of the mergers as defined in the Common Terms of Merger (the
"Effective Date");
• to approve that on the Effective Date, the net assets of the Merging Sub-Funds will be automatically transferred to
the Receiving Sub-Funds;
• to approve that on the Effective Date, the Receiving Sub-Funds will issue to the shareholders in the Merging Sub-
Funds, shares in the Receiving Sub-Funds as detailed in the Merger Notice on page 7. The shareholders of the Merging
Sub-Funds will receive an identical number of shares in the relevant Receiving Sub-Fund using an exchange ratio
of 1:1. The value of the shares will be determined on the basis of the net asset value of the shares in the relevant
Merging Sub-Fund as at 1:00 p.m. Luxembourg time on the Effective Date;
• to state that, as a result of each of the approved Merger, all the Shares of each Merging Sub-Fund will be cancelled
as of the Effective Date and the relevant Merging Sub-Funds will continue to exist for the sole purpose of the orderly
liquidation of such Merging Sub-Funds until the liabilities have been discharged;
• to acknowledge that the Board has decided that if any of the Mergers of the Merging Sub-Funds are not approved,
the Merging Sub-Funds will continue to operate while alternative rationalisation plans are considered;
• subject to the terms of the foregoing resolutions, to grant any director of the Board the power:
a) to take or cause to be taken any and all actions and to execute and deliver or cause to be executed and delivered
the present resolutions and all such further agreements, certificates, instruments and documents, as deemed appro-
priate, and to incur and pay all such fees and expenses as may be necessary or advisable in order to carry out and
perform the purpose and intent of the present resolutions, the signature of any such person being due evidence for
all purposes of approval of the terms thereof by and in the name of the Fund and / or Merging Sub-Funds, as the case
may be;
b) to enter into all corporate documents necessary for the present resolutions;
• to delegate any or all of the powers and discretions vested in them by virtue of the present resolutions by way
of power or powers of attorney to such individuals and upon such terms as the individual acting may in his
absolute discretion determine, the exercise of such discretion to be conclusively evidenced by his execution
thereof, by his sole signature, in the name and on behalf of the Fund and / or the Merging Sub-Funds as the
case may be; and
• to consider any other matter that may properly come before the present Meeting.
Voting requirements:
The Meetings of each Merging Sub-Fund will vote on the Merger of their relevant Merging Sub-Fund into the corre-
sponding Receiving Sub-Fund in the Legg Mason Global Funds Plc (as per the table above) but will not deliberate on the
Mergers of the other Merging Sub-Funds.
In accordance with the Directive 2009/65/EC of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative
provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (the "UCITS IV Directive") the
meeting may deliberate validly on the items on the agenda without any quorum and the passing of the resolution requires
the consent of a simple majority of the votes of those present or represented and voting at the Meeting of each Merging
Sub-Fund.
Proxy:
Shareholders may vote in person or by proxy. Shareholders who are unable to attend the Extraordinary Class Meeting
(s) are kindly requested to exercise their voting rights by completing and returning a proxy card to State Street Bank
Luxembourg S.C.A., the Administrator of the Fund, to the attention of Zakia Aouinti or fax it to 00 352 464 010 413 not
later than 3rd February 2016 at 5 p.m. CET. A proxy form may be obtained at the Fund's registered office.
The following documents are available for inspection, if required, and can be obtained free of charge at the registered
office of the Fund:
1) copy of the Merger Notice;
2) copy of the Common Terms of Merger established by the Fund and the Receiving Fund;
3) copy of the latest visa stamped prospectus of the Receiving Fund;
4) copies of the key investor information documents of the Receiving Sub-Funds;
5) copy of the articles of association of the Receiving Fund;
6) copy of the report prepared by the independent auditor appointed by the Fund to validate the conditions foreseen in
Article 42 (1), items (a) to (c) of the UCITS IV Directive; and
7) copies of certificates related to the Merger issued by each custodian bank of both Fund and Receiving Fund in
compliance with Article 41 of the UCITS IV Directive.
By order of the Board of Directors
Référence de publication: 2016050209/755/97.
5910
L
U X E M B O U R G
Log S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 83.888.
Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LOG S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015122249/11.
(150131872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2015.
RBS Market Access, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 78.567.
You are hereby informed that the extraordinary general meeting of the shareholders of the Fund convened on 15 January
2016, with the same agenda as mentioned below, did not reach the required quorum.
As a result of the above, you are thus invited to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the shareholders of the Fund, as reconvened, to be held before a public notary on <i>19 February 2016i> at 14.30 CET,
at the premises of RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette (the "Extraordinary
General Meeting") with the agenda set forth below.
The board of directors of the Fund (the "Board") would like to take this opportunity to inform the shareholders that the
Board has selected China Post & Capital Global Asset Management Limited ("China Post Global") to take over the roles
of The Royal Bank of Scotland plc ("RBS plc") as investment manager and global distributor of the Fund as of 29 February
2016.
China Post Global is a joint venture domiciled in Hong Kong established in 2015 as the international asset management
arm of China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
China Post Global intends to provide its management services to the Fund out of the UK. To that end, it has introduced
an application file with the UK Financial Conduct Authority ("FCA") to establish a branch. Pending its authorisation by
the FCA, China Post Global will use the services of Mirabella Financial Services LLP ("Mirabella") a reputed investment
firm established in the UK to act as investment manager during the interim period.
Further, in order to ensure the continuity in the management of the Fund, China Post Global intends to retain the services
of part of the current investment management team of the Fund (the "Continuing Management Team") to manage, promote
and distribute the Fund. In this context, the Continuing Management Team will be seconded to Mirabella during this interim
period. The re-location of the Continuing Management Team within China Post Global and Mirabella is expected to have
no impact on the management of the Fund and allows a smooth transition from RBS plc to Mirabella and, ultimately, China
Post Global.
As a result of the change of investment manager, you are entitled to redeem your shares in the Fund free of charge for
one month, as from the date of this convening notice.
You are also hereby informed that, further to a change of ownership, the name of the management company of the Fund
has changed from RBS (Luxembourg) S.A. to FundRock Management Company S.A.
The above changes and this convening notice have been approved by the Commission de Surveillance du Secteur
Financier. The changes will be reflected in the prospectus of the Fund dated March 2016.
Agenda for the extraordinary general meeting
1. Report on declared conflicts of interest as per article 57 of the amended law of 10 August 1915 on commercial
companies
2. Change of name of the Fund into "Market Access" and subsequent amendment of Article 1 of the Articles, as follows:
"Among the shareholders and all those who shall become holders of the shares in the future, there exists a company
in the form of a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable
capital ("société d'investissement à capital variable") under the name of "Market Access" (hereafter the "Fund")."
3. Miscellaneous
******
5911
L
U X E M B O U R G
ORGANISATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
As the Extraordinary General Meeting is hereby reconvened for a second call, in accordance with the provisions of
Article 67-1(2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law of 1915"), and in accordance
with the provisions of Article 33 of the Articles, no quorum will be required to decide on the matters mentioned under
items 2 and 3 of the agenda and the resolutions on such items will be passed by the affirmative vote of at least two third
(2/3) of the shares present or represented and voting at the Extraordinary General Meeting.
If you cannot be personally present at the Extraordinary General Meeting and want to be represented, please sign and
date the enclosed proxy form and return it, at least three (3) days before the Extraordinary General Meeting, to RBC Investor
Services Bank S.A., 14 porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, to the attention of Christina
Kipper.
If you want to attend the Extraordinary General Meeting in person, please inform us by post, at least five (5) days before
the Extraordinary General Meeting, at the address mentioned above.
<i>The Board of Directors of the Fundi>
Référence de publication: 2016050210/755/57.
G.A. - Fund -L, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 69.871.
L'an deux mille quinze, le huit octobre.
Pardevant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV-FIS «G.A. - FUND-L» (ci-après la «Société»), ayant
son siège social à L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 69.871, constituée suivant acte notarié en date du 21 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations du 26 juin 1999, numéro 490. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et en dernier
lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 mars 2012, publié au Mémorial du 13 avril 2012, numéro 956.
L'assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Madame Gwendoline BOONE, employée privée, demeurant
professionnellement à Hesperange,
qui désigne comme secrétaire Madame Vinciane ALEXANDRE, employée privée, demeurant professionnellement à
Hesperange.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Valérie LETELLIER, employée privée, demeurant professionnellement
à Hesperange,
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter que:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social de la Société, à partir du 1
er
janvier 2016 de 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange au
60 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
2. Modification du premier alinéa de l'article 4 «siège social» des statuts de la Société afin de refléter le changement du
siège social. Le premier paragraphe sera reformulé comme suit:
“Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre
endroit au Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, délibérant de
la manière prévue pour la modification des statuts ou, par le Conseil d'Administration de la Société, suivant les provisions
prévues par la loi. Le siège social pourra être transféré dans les limites de la commune par décision du Conseil d'Admi-
nistration de la Société.”
3. Modification du premier alinéa de l'article 9 «Assemblée Générale annuelle» des statuts de la Société afin de refléter
le changement du siège social. Le premier paragraphe sera reformulé comme suit:
“L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle
qu'amendée (la «Loi de 1915») au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, qui
sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier jour ouvrable du mois de juin à 12 heures. Si ce jour est un jour férié,
l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable précédent L'Assemblée Générale annuelle pourra se
tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration souverainement constate que des circonstances exceptionnelles le requiè-
rent.”
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
5912
L
U X E M B O U R G
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
"ne varietur" par les comparants et le notaire.
III.- Conformément à l'article 70 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, les convo-
cations établissant l'ordre du jour de l'assemblée ont été envoyées aux actionnaires le 28 septembre 2015.
IV.- Il apparaît, selon la liste de présence, que la totalité des 464.526,164 actions actuellement émises, est représentée
à la présente Assemblée.
V.- En conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur le point porté
à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Première et unique résolution:i>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société à partir du 1
er
janvier 2016 de 33 rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange au 60 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg et par conséquent de modifier le premier alinéa de
l'article 4 et le premier alinéa de l'article 9 comme suit à compter du 1
er
janvier 2016:
« Art. 4. Al. 1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Le siège social de la Société pourra être transféré
à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société,
délibérant de la manière prévue pour la modification des statuts ou, par le Conseil d'Administration de la Société, suivant
les provisions prévues par la loi. Le siège social pourra être transféré dans les limites de la commune par décision du Conseil
d'Administration de la Société. (...)»
« Art. 9. Al. 1. L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle qu'amendée (la «Loi de 1915») au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de
Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier jour ouvrable du mois de juin à 12 heures. Si ce jour est
un jour férié, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable précédent L'Assemblée Générale annuelle
pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration souverainement constate que des circonstances exceptionnelles
le requièrent.(...)»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Hesperange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: G. BOONE, V. ALEXANDRE, V. LETELLIER et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 13 octobre 2015 1LAC/2015/32575. Reçu soixante-quinze euros. 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 26 octobre 2015.
Référence de publication: 2016002039/78.
(160000269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Generali Investments SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 86.432.
In the year two thousand fifteen, on the eleventh day of December.
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
is held
an extraordinary general meeting of the shareholders of "Generali Investments SICAV", a société d'investissement à
capital variable having its registered office at L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich, recorded in the Luxembourg Trade
and Companies' Register under number B 86.432, incorporated pursuant to a notarial deed on 14 March 2002, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 543 of 8 April 2002 (the “Company”).
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by a deed dated 30 January 2015,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 408 of 14 February 2015.
The meeting is chaired by Mrs Gwendoline Boone, private employee, residing professionally in Hesperange,
who appointed as secretary Mrs Agathe Kahn, private employee, residing professionally in Hesperange.
The meeting elects as scrutineer Mr Emmanuel Gilson de Rouvreux, private employee, residing professionally in Hes-
perange.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
5913
L
U X E M B O U R G
I. - That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Transfer of the registered office of the Company, as from 1
st
January 2016, from 33 rue de Gasperich, L-5826
Hesperange to 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Amendment to the first paragraph of the article 2 of the articles of incorporation to reflect the change of the registered
office. The first paragraph to be reworded as follows:
“The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.”
3. Inclusion of a paragraph in the article 2 of the articles of association to confirm the transfer of registered office rule.
The paragraph being as follows:
“The registered office of the company may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg
by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company, deliberately in the manner provided for amendments
to the Articles of Incorporation or by the board of directors of the Company if and to the extent permitted by the law. It
may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company.”
4. Amendment to first paragraph of the article 5 of the articles of association to update the section on share capital as
follows:
“The capital of the Company shall be represented by fully paid up Shares of no par value and shall at any time be equal
to the total net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof. The minimum capital is one million two hundred and
fifty thousand euro (1,250,000.- EUR).”
5. Amendment to the ninth paragraph of the article 14 of the articles of association to be reworded as follows:
“Resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meetings. Copies of
extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the
meeting or any two directors or by any other person specifically appointed by the Board of Directors.”
II.- That the general meeting has been convened by registered mail sent to the shareholders on 9 November 2015, and
that the convening notices have been published on 6 and 25 November 2015 in:
- the Memorial C number 3038 and 3186,
- the Luxemburger Wort and
- the Tageblatt
- the Milano Finanza
- the Bundesanzeiger.
III.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list and the proxies of the represented shareholders, being signed
by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
According to the attendance list, out of 86,659,881.071 shares in issue, 2,868,348 shares are represented.
IV. That a first extraordinary general meeting with the same agenda had been held on 26 October 2015 where the quorum
conditions in order to vote the items on the agenda were not fulfilled.
The second extraordinary general meeting can, in accordance with the provisions of article 67-1 of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended, validly deliberate whatever proportion of the share capital is present or
represented.
V. As a consequence, the present extraordinary general meeting is regularly constituted and may validly deliberate on
all the items of the agenda regardless of the number of shares represented at the meeting.
Then the general meeting after deliberation takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to transfer the registered office of the Company, as from 1
st
January 2016, from 33 rue
de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The general meeting decides to amend subsequently the first paragraph of Article 2 of the articles of association in order
to reflect the change of the registered office, and to amend the rules of the transfer of the registered office by decision of
the Board. Effective as from 1
st
January 2016, the first paragraph to be reworded as follows:
"The registered office of the Company is established in Luxembourg, in the Grand-Duchy of Luxembourg. The registered
office of the Company may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of
the general meeting of shareholders of the Company, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles
or by the board of directors of the Company if and to the extent permitted by law. It may be transferred within the boundaries
of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company. (...)"
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to amend the first paragraph of the article 5 to be read as follows
5914
L
U X E M B O U R G
“The capital of the Company shall be represented by fully paid up Shares of no par value and shall at any time be equal
to the total net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof. The minimum capital is one million two hundred and
fifty thousand euro (1,250,000.- EUR).”
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to reword the ninth paragraph of the article 14 as follows:
“Resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meetings. Copies of
extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the
meeting or any two directors or by any other person specifically appointed by the Board of Directors.”
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named persons,
the present deed is worded in English.
Whereupon, the present deed is drawn up in Hesperange at the date named at the beginning of this document.
After reading and interpretation to the appearers, the members of the board signed together with the notary the present
deed.
Signé: G. BOONE, A. KAHN, E. GILSON DE ROUVREUX et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 15 décembre 2015. 1LAC/2015/39904. Reçu soixante-quinze euros. 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Référence de publication: 2016002045/94.
(160000271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
La Française IC Fund, SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 148.892.
In the year of two thousand and fifteen, on the fourteenth December,
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg,
Was held
An extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of La Française IC Fund, SICAV-FIS, a société
anonyme, société d'investissement à capital variable (SICAV), fonds d'investissement spécialisé (FIS), existing under the
laws of Luxembourg, with registered office at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under number B 148.892, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated
16
th
October 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2169 of 6
th
November
2009 (the “Company”).
The article of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary on 23
rd
February 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 699 of 16
th
March 2012.
The present Meeting was opened at 11.30 a.m. with Mrs Valérie Letellier, employee, professionally residing in Hespe-
range, in the chair (the “Chairman”),
who appointed as secretary Mrs Pauline Lahure, employee, professionally residing in Hesperange.
The Meeting elected as scrutineer Mrs Aline Biej, employee, professionally residing in Hesperange.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the convening notices establishing the agenda of the meeting were sent by registered mail to all the shareholders
dated 1
st
December 2015.
II. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company, as from 1
st
January 2016, from 33, rue de Gasperich, L-5826
Hesperange to 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
2. Amendment to the first paragraph of Article 4 of the articles of incorporation in order to reflect the change of the
registered office and amend the rules of the transfer of registered office by decision of the Board, as from 1
st
January 2016.
The first paragraph to be reworded as follows:
“The registered office of the Company is established in the commune of Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
Branches, subsidiaries or other offices may be established, either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a
5915
L
U X E M B O U R G
decision of the board of directors. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple
resolution of the board of directors. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a
resolution of the general meeting of shareholders of the Company, deliberating in the manner provided for amendments to
the articles of incorporation or by the board of directors of the Company if and to the extent permitted by law.”
3. Amendments of the articles 1, 9, 20, 22, 31 and 33 of the articles of incorporation in order to comply with the new
regulation concerning the Alternative Investment Funds, according to the law of 12 July 2013 on alternative investment
fund managers (the “Law of 12 July 2013”).
III. That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholders of
the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain attached to this deed, to be filed at the same time
with the registration authorities.
The said proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will also remain attached
to this deed.
IV. That it results from the attendance list that out of 24,391.942 shares, 19,472.490 shares are represented at the present
general meeting.
V. That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company from L-5826 Hesperange, 33, rue de
Gasperich to L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy, with effect on 1
st
January 2016.
The resolution was adopted by 19.472 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the general meeting resolves to amend the first paragraph of article 4 of the
articles of incorporation of the Company, which shall be read as follows, with effect on 1
st
January 2016:
“ Art. 4. Registered office. (first paragraph). The registered office of the Company is established in the commune of
Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg). Branches, subsidiaries or other offices may be established, either in the
Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the board of directors. Within the same borough, the registered
office may be transferred through simple resolution of the board of directors. It may be transferred to any other place within
the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company, deliberating in
the manner provided for amendments to the articles of incorporation or by the board of directors of the Company if and to
the extent permitted by law.”
The resolution was adopted by 19.472 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to amend articles 1, 9, 20, 22, 31 and 33 of the articles of incorporation in order to comply
with the new regulation concerning the Alternative Investment Funds, according to the law of 12
th
July 2013 on alternative
investment fund managers (the “Law of 12 July 2013”).
Those articles will henceforth be read as follows:
“ Art. 1. Name and form. There exists among the existing shareholder and those who may become owners of shares in
the future, a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable share capital
("société d'investissement à capital variable") under the name of "La Française IC FUND, SICAV-FIS" (hereinafter the
"Company").
The Company qualifies as an alternative investment fund as per the law of 12 July 2013 on alternative investment fund
managers (the “Law of 12 July 2013”).”
“Art. 9. Classes of shares. The board of directors may decide to issue one or more classes of shares for the Company or
for each Sub-Fund. The board of directors may offer new classes of shares without approval of the shareholders.
Each class of shares may differ from the other classes with respect to its cost structure, the initial investment required
or the currency in which the net asset value is expressed or any other feature as may be determined by the board of directors
from time to time.
Within each class, there may be capitalisation shares and/ or distribution shares.
Whenever dividends are distributed on distribution shares, the portion of net assets of the class of shares to be allotted
to all distribution shares shall subsequently be reduced by an amount equal to the amounts of the dividends distributed,
thus leading to a reduction in the percentage of net assets allotted to all distribution shares, whereas the portion of net assets
allotted to all capitalisation shares shall remain the same. The alternative investment funds manager of the Company will
adopt such provisions as necessary to ensure that any preferential treatment accorded by the Company or the Company's
5916
L
U X E M B O U R G
alternative investment funds manager to a shareholder will not result in an overall material disadvantage to other share-
holders, as further disclosed in the Company's issuing documents.”
“ Art. 20. Powers of the board of directors. The board of directors is vested with the widest powers to manage the business
of the Company and to take all actions of disposal and administration which are in line with the purpose of the Company.
All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders are
in the competence of the board of directors.
The board of directors shall determine, applying the principle of risk spreading, the investment policies and strategies
of the Company and of each Sub-Fund, as well as the course of conduct of the management and business affairs of the
Company, as set forth in the issuing documents of the Company, in compliance with applicable laws and regulations. The
board of directors shall designate an alternative investment fund manager in accordance with the provisions of the Law of
12 July 2013. The designated alternative investment fund manager may carry out all investment management, adminis-
tration and marketing functions relating to the Company as may be further specified in the corresponding service agreement,
(i.e., for the avoidance of doubt all core and ancillary functions as defined in Annex 1 of the Law of 12 July 2013).
Art. 22. Delegation of power. The board of directors may, to the extent not conferred upon an alternative investment
fund manager, delegate, under its overall responsibility and control, its powers to conduct the daily management and affairs
of the Company (including the right to act as authorised signatory for the Company) and its powers to carry out acts in
furtherance of the corporate policy and purpose to directors or officers of the Company or to one or several natural persons
or corporate entities, which need not be members of the board of directors. Such delegated persons shall have the powers
determined by the board of directors and may be authorised to sub-delegate their powers.
Subject to the functions delegated to the alternative investment fund manager, the board of directors may appoint in-
vestment advisers and managers, as well as any other management or administrative agents. The board of directors may
enter into agreements with such persons or companies for the provision of their services, the delegation of powers to them,
and the determination of their remuneration to be borne by the Company. The board of directors may also confer special
powers of attorney by notarial or private proxy.
The board of directors may appoint any special committee as described more fully in the issuing documents, in order
to conduct certain tasks and functions expressly delegated to such committee.
Art. 31. Depositary. The Company will enter into a depositary agreement with a Luxembourg bank which meets the
requirements of the Law of 13 February 2007 and the Law of 12 July 2013.
The depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law of 13 February 2007 and the Law
of 12 July 2013. In carrying out its role as depositary, the depositary must act solely in the interests of the investors.
Where the law of a third country requires that certain financial instruments be held in custody by a local entity and there
are no local entities that satisfy the delegation requirements under the Law of 12 July 2013, the Company shall be expressly
authorized to discharge in writing the depositary from its liability with respect to the custody of such financial instruments
to the extent it has been instructed by the Company to delegate the custody of such financial instruments to such local
entity, and provided that the conditions of article 19 (14) of the Law of 12 July 2013 are met.
Art. 33. Applicable law. In respect of all matters not governed by these articles of incorporation, the parties shall refer
to the provisions of the law of August 10
th
1915 on commercial companies and the amendments thereto, and the relevant
law and regulations applicable to Luxembourg undertakings for collective investment, notably the Law of 13 February
2007 and the Law of 12 July 2013.
The resolution was adopted by 19.472 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions.
There being no further business, the meeting is closed.
Whereof, this deed is drawn up in Hesperange, in the registered office of the Company, on the day stated at the beginning
of this document.
The document having been read to the appearing persons, the board of the meeting signed together with the notary this
deed.
Signé: V. LETELLIER, P. LAHURE, A. BIEJ et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 15 décembre 2015. 1LAC/2015/39910. Reçu soixante-quinze euros. 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Référence de publication: 2016002160/140.
(160000273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
5917
L
U X E M B O U R G
Generali Multi Portfolio Solutions SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. Generali Multinational Pension Solutions SICAV).
Siège social: L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 141.004.
In the year two thousand fifteen, on the twenty first day of December.
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
is held
an extraordinary general meeting of the shareholders of "Generali Multinational Pension Solutions SICAV", a société
d'investissement à capital variable having its registered office at L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich, recorded in the
Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 141.004, incorporated pursuant to a notarial deed on 12
August 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2159 of 5 September 2008 (the
“Company”).
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by a deed dated 30 January 2015,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 408 of 14 February 2015.
The meeting is chaired by Mrs Flore SENDEGEYA, private employee, residing professionally in Hesperange,
who appointed as secretary Mrs Pauline LAHURE, private employee, residing professionally in Hesperange.
The meeting elects as scrutineer Mr. Emmanuel GILSON de ROUVREUX, private employee, residing professionally
in Hesperange.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Transfer of the registered office of the Company, as from 1
st
January 2016, from 33, rue de Gasperich, L-5826
Hesperange to 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Amendment of Article 1 to change the name of the Company from «Generali Multinational Pension Solutions SICAV»
to «Generali Multi Portfolio Solutions SICAV», with effect as from 1
st
January 2016.
3. Amendment of the first paragraph of Article 2 of the articles of association to reflect the change of the registered
office, effective as from 1
st
January 2016. The first paragraph to be reworded as follows:
“The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.”
4. Amendment of the second paragraph of Article 2 of the articles of association to confirm the transfer of registered
office rules, effective as from 1
st
January 2016. The second paragraph to be reworded as follows:
“The board of directors is authorised to transfer the registered office of the Company within the same municipality. The
registered office may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting
of shareholders deliberating in the manner provided for any amendment to the Articles of Incorporation or by the board of
directors of the Company if and to the extent permitted by law. (...)”
5. Amendment of the first paragraph of Article 5 of the articles of association to update the section on share capital and
deletion of the entire second paragraph of this same Article 5. The first paragraph to be reworded as follows:
“The capital of the Company shall be represented by fully paid up Shares of no par value and shall at any time be equal
to the total net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof. The minimum capital is one million two hundred and
fifty thousand Euro (EUR 1.250.000.-). (...)”
6. Amendment of paragraph 9 of Article 14 of the articles of association to authorize any person specifically appointed
by the board of directors to sign copies of extracts of minutes.
7. Amendment of the fourth paragraph of article 22 of the articles of association with regard to the place of holding of
the annual general meeting. The fourth paragraph to be reworded as follows:
“The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law, at the registered office of the Company
or at such other place in the municipality, as may be specified in the notice of meeting, on the last Tuesday of April each
year at 11 a.m. Luxembourg time. (...)”
II.- That the general meeting has been convened by registered mail sent to the shareholders on 18 November 2015 and
that the convening notices have been published on 18 November and 4 December 2015 in:
- the Memorial C number 3133 and 3265,
- the Luxemburger Wort
- the Tageblatt
III.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list and the proxies of the represented shareholders, being signed
5918
L
U X E M B O U R G
by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
According to the attendance list, out of 3,984,219.123 shares in issue, 472,742 shares are represented.
IV. That a first extraordinary general meeting with the same agenda had been held on 6 November 2015 where the
quorum conditions in order to vote the items on the agenda were not fulfilled.
The second extraordinary general meeting can, in accordance with the provisions of article 67-1 of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended, validly deliberate whatever proportion of the share capital is present or
represented.
V. As a consequence, the present extraordinary general meeting is regularly constituted and may validly deliberate on
all the items of the agenda regardless of the number of shares represented at the meeting.
Then the general meeting after deliberation takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to transfer the registered office of the Company, as from 1
st
January 2016, from 33 rue
de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to change the name of the Company «Generali Multi Portfolio Solutions SICAV», with
effect as from 1
st
January 2016.
The general meeting decides to amend accordingly with effect as from 1
st
January 2016 the first article of the articles
of incorporation as follows:
“ Art. 1. Denomination. The Company is hereby formed as a public limited company (société anonyme) qualifying as
an investment company with variable share capital (société d'investissement à capital variable) under the name of «Generali
Multi Portfolio Solutions SICAV» (hereinafter the "Company").”
<i>Third resolution:i>
The general meeting decides to amend the first and second paragraphs of the article 2 of the articles of association to
confirm the transfer of registered office and the change of the registered office rules, effective as from 1
st
January 2016,
as follows:
“The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The board of directors is authorised to transfer the registered office of the Company within the same municipality. The
registered office may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting
of shareholders deliberating in the manner provided for any amendment to the Articles of Incorporation or by the board of
directors of the Company if and to the extent permitted by law. (...)”
<i>Fourth resolution:i>
The general meeting decides to amend the first paragraph of Article 5 of the articles of association to update the section
on share capital, and to delete the entire second paragraph of this same Article 5. The first paragraph to be reworded as
follows:
“The capital of the Company shall be represented by fully paid up Shares of no par value and shall at any time be equal
to the total net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof. The minimum capital is one million two hundred and
fifty thousand Euro (EUR 1.250.000.-). (...)”
<i>Fifth resolution:i>
The general meeting decides to amend the paragraph 9 of Article 14 of the articles of association to authorize any person
specifically appointed by the board of directors to sign copies of extracts of minutes as follows:
“(...) Resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, in his
absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or by any two Directors. Copies of extracts of such
minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by any person specifically appointed
by the board of directors (...)”.
<i>Sixth resolution:i>
The general meeting decides to amend the fourth paragraph of article 22 of the articles of association with regard to the
place of holding of the annual general meeting. The fourth paragraph to be reworded as follows:
“The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law, at the registered office of the Company
or at such other place in the municipality, as may be specified in the notice of meeting, on the last Tuesday of April each
year at 11 a.m. Luxembourg time. (...)”.
5919
L
U X E M B O U R G
Whereupon, the present deed is drawn up in Hesperange at the date named at the beginning of this document.
After reading and interpretation to the appearers, the said appearers signed together with the notary the present deed.
Signé: F. SENDEGEYA, P. LAHURE, E. GILSON et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 23 décembre 2015. 1LAC/2015/41348. Reçu soixante-quinze euros. 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Référence de publication: 2016002046/117.
(160000359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Riskelia Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 172.172.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty third day of November.
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg.
Is held
an extraordinary general meeting of the shareholders of RISKELIA FUND (hereafter referred to as the “Company”),
an investment company with variable share capital, incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg,
having its registered office at L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under number B 172.172, incorporated pursuant to a notarial deed on 10
th
October 2012, published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on 29
th
October 2012, under number 2656, whose articles of
association have been amended for the last time on 13 October 2014, pursuant to a deed of the undersigned notary, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 7 November 2014, under number 3286.
The extraordinary general meeting was opened with Ms Valérie LETELLIER, private employee, residing professionally
in Hesperange, in the chair,
who appointed Ms Aline BIEJ, private employee, residing professionally in Hesperange, as secretary of the meeting.
The meeting appointed as scrutineer Ms Vinciane ALEXANDRE, private employee, residing professionally in Hespe-
range.
Having thus been constituted, the board of the meeting drew up the attendance list, which, having been signed by the
proxyholders representing the represented shareholders and by the members of the board, will remain attached to the present
minutes together with the proxies.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the registered office of the Company from 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, with effect as from 1
st
January 2016.
2. Amendment to the first paragraph of Article 2 of the articles of association in order to reflect the change of the
registered office and amend the rules of the transfer of registered office by decision of the Board, with effect as from 1
st
January 2016. The first paragraph to be reworded as follows:
“The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered
office of the Company may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of
the general meeting of shareholders of the Company, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles
or by the board of directors of the Company if and to the extent permitted by law. It may be transferred within the boundaries
of the municipality by a resolution of the Board. (...)”
II.- That the general meeting has been convened by registered mail sent to the shareholders on 16 October 2015, and
that the convening notices have been published in the Memorial C number 2851 on October 16 2015 and number 3008 on
4 November 2015, as well as in the Luxemburger Wort and in the Tageblatt on 16 October 2015 and 4 November 2015.
III.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to
the present deed.
According to the attendance list, out of 147,387.414390 shares in issue, 1,148.822 shares are represented.
IV. That a first extraordinary general meeting with the same agenda had been held on 8 October 2015 where the quorum
conditions in order to vote the items on the agenda were not fulfilled.
5920
L
U X E M B O U R G
The second extraordinary general meeting can, in accordance with the provisions of article 67-1 of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended, validly deliberate whatever proportion of the share capital is present or
represented.
V. As a consequence, the present extraordinary general meeting is regularly constituted and may validly deliberate on
all the items of the agenda regardless of the number of shares represented at the meeting.
Then the general meeting after deliberation takes the following resolutions:
<i>Sole resolutioni>
The meeting decides to transfer the registered office of the Company, as from 1
st
January 2016, from 33 rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange to 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The meeting decides that as from 1
st
January 2016 to amend the first paragraph of Article 2 of the articles of association
in order to reflect the change of the registered office and to amend the rules of the transfer of registered office by decision
of the Board. The first paragraph to be reworded as follows as from 1
st
January 2016:
“The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered
office of the Company may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of
the general meeting of shareholders of the Company, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles
or by the board of directors of the Company if and to the extent permitted by law. It may be transferred within the boundaries
of the municipality by a resolution of the Board. (...)”
WHEREOF, the present deed is drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the board of the meeting signed together with the notary this
original deed.
Signé: V. LETELLIER, A. BIEJ, V. ALEXANDRE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 24 novembre 2015. 1LAC / 2015 / 36931. Reçu soixante quinze euros. 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Référence de publication: 2016002328/74.
(160000471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Symphonia Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 65.036.
In the year two thousand fifteen, on the eleventh day of November
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
is held
an extraordinary general meeting of the shareholders of "SYMPHONIA LUX SICAV", a société d'investissement à
capital variable having its registered office in L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich, recorded in the Luxembourg Trade
and Companies' Register under number B 65.036, incorporated under the denomination IBI FUND pursuant to a notarial
deed on 6 July 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 577 of 8 August 1998
(the “Company”).
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary
dated 15 November 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3071 of 21 December
2012.
The meeting is chaired by Mrs Agathe Kahn, private employee, residing professionally in Hesperange.
who appointed as secretary. Mrs Flora Gibert, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Agathe Kahn, private employee, residing professionally in Hesperange prenamed
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Transfer of the registered office of the Company, as from 1st January 2016, from 33 rue de Gasperich, L-5826
Hesperange to 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Amendment to the first paragraph of the Article 4 of the articles of incorporation in order to reflect the change of the
registered office. The first paragraph to be reworded as follows:
5921
L
U X E M B O U R G
“The registered office of the Corporation is established in Luxembourg. The registered office of the Corporation may
be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of share-
holders of the Corporation, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles or by the board of directors
of the Corporation if and to the extent permitted by law. It may be transferred within the boundaries of the municipality by
a resolution of the board of directors. (...)”
II.- That the general meeting has been convened by registered mail sent to the shareholders on October 7, 2015, and that
the convening notices have been published in the Memorial C number 2757 on 7 October 2015 and number 2914 on 23
October 2015, in the Luxemburger Wort and in the Tageblatt on 7 October 2015 as well as on 23 October 2015
III.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to
the present deed.
According to the attendance list, out of 26,527,527.85 shares in issue, 160,895 shares are represented.
IV. That a first extraordinary general meeting with the same agenda had been held on 24 September 2015 where the
quorum conditions in order to vote the items on the agenda were not fulfilled.
The second extraordinary general meeting can, in accordance with the provisions of article 67-1 of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended, validly deliberate whatever proportion of the share capital is present or
represented.
V. As a consequence, the present extraordinary general meeting is regularly constituted and may validly deliberate on
all the items of the agenda regardless of the number of shares represented at the meeting.
Then the general meeting after deliberation takes the following resolutions:
<i>Sole resolutioni>
The meeting decides to transfer the registered office of the Company, as from 1
st
January 2016, from 33 rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange to 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The meeting decides that as from 1
st
January 2016 the first paragraph of the Article 4 of the articles of incorporation
will be amended in order to reflect the change of the registered office. The first paragraph to be reworded as follows:
“The registered office of the Corporation is established in Luxembourg. The registered office of the Corporation may
be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of share-
holders of the Corporation, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles or by the board of directors
of the Corporation if and to the extent permitted by law. It may be transferred within the boundaries of the municipality by
a resolution of the board of directors. (...)”
Whereupon, the present deed is drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
After reading and interpretation to the appearers, the said appearers signed together with the notary the present deed.
Signé: A. KAHN, F. GIBERT et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 16 novembre 2015. 1LAC / 2015 / 35989. Reçu soixante quinze euros. 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Référence de publication: 2016002460/68.
(160000382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Yellow Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 175.534.
In the year two thousand fifteen, on the fourteenth day of October.
Before Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg,
Was held
an extraordinary general meeting of shareholders of “YELLOW FUNDS SICAV” (the “Company”), a société anonyme
qualifying as a société d'investissement à capital variable, having its registered office at 33, rue de Gasperich - L-5826
Hesperange, registered with the Trade Register of Luxembourg under the number B 175.534, incorporated pursuant to a
deed of the undersigned notary enacted on 21 February 2013 published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (the "Mémorial") on 6 March 2013 number 544, the articles of incorporation of which have been amended by deed
5922
L
U X E M B O U R G
enacted by the undersigned notary on 18 March 2015 published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
(the "Mémorial") on 1
st
April 2015 number 888.
The meeting was opened at 11.30 a.m. with Mrs. Agathe KAHN private employee, professionally residing in Hespe-
range, in the chair, who appointed as secretary Mrs. Flore SENDEGEYA, professionally residing in Hesperange.
The meeting also elected as scrutineer Mr. Emmanuel GILSON DE ROUVREUX, professionally residing in Hespe-
range.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company, as from 1
st
January 2016, from 33 rue de Gasperich, L-5826
Hesperange to 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Amendment of the first paragraph of Article 2 of the articles of association in order to reflect the change of the
registered office and amend the rules of the transfer of the registered office by decision of the Board. Effective as from 1
st
January 2016, the first paragraph to be reworded as follows:
"The registered office of the Company is established in Luxembourg, in the Grand-Duchy of Luxembourg. The registered
office of the Company may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of
the general meeting of shareholders of the Company, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles
or by the board of directors of the Company if and to the extent permitted by law. It may be transferred within the boundaries
of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company. (...)"
II.- That the general meeting has been convened by registered mail sent to the shareholders on 11 September 2015, and
that the convening notices have been published in the Memorial C number 2461, in the Luxemburger Wort and in the
Tageblatt on 11 September 2015 as well as on 28 September 2015.
III.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to
the present deed.
According to the attendance list, out of 589,965,661 shares in issue, 203,459 shares are represented.
IV. That a first extraordinary general meeting with the same agenda had been held on 25 August 2015 where the quorum
conditions in order to vote the items on the agenda were not fulfilled.
The second extraordinary general meeting can, in accordance with the provisions of article 67-1 of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended, validly deliberate whatever proportion of the share capital is present or
represented.
V. As a consequence, the present extraordinary general meeting is regularly constituted and may validly deliberate on
all the items of the agenda regardless of the number of shares represented at the meeting.
Then the general meeting after deliberation takes the following resolutions:
<i>Sole resolutioni>
The general meeting decides to transfer the registered office of the Company, as from 1
st
January 2016, from 33 rue
de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The general meeting decides to amend subsequently the first paragraph of Article 2 of the articles of association in order
to reflect the change of the registered office, and to amend the rules of the transfer of the registered office by decision of
the Board. Effective as from 1
st
January 2016, the first paragraph to be reworded as follows:
"The registered office of the Company is established in Luxembourg, in the Grand-Duchy of Luxembourg. The registered
office of the Company may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of
the general meeting of shareholders of the Company, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles
or by the board of directors of the Company if and to the extent permitted by law. It may be transferred within the boundaries
of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company. (...)"
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named persons,
the present deed is worded in English.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Hesperange, 33, rue de Gasperich, on the day named at the beginning of
this document.
The document having been read to the appearing persons, the board of the meeting signed together with the notary this
original deed.
Signé: A. KAHN, F. SENDEGEYA, E. GILSON DE ROUVREUX et J. BADEN.
5923
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 20 octobre 2015 1LAC / 2015 / 33264. Reçu soixante quinze euros. 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Référence de publication: 2016002573/74.
(160000220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Save Time Services s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 202.826.
STATUTS
L'an deux mil quinze, le seize décembre,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
Ont comparu:
Madame Christelle CLERO, gérante de société, née à Paris, France, le 20 avril 1970, demeurant à L-3412 Dudelange,
40, rue Grand-Duc Adolphe,
et
La société à responsabilité limitée SOLOTIGO s.à r.l. avec siège à L-8447 Steinfort, 3A, rue Boxepull, constituée aux
termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 novembre 2015, en voie de formalisation, représentée aux
fins des présentes par son gérant en la personne de Monsieur Michaël GONRY, demeurant à L-8447 Steinfort, 3A, rue
Boxepull,
Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles constituent:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «SAVE TIME
SERVICES s.à r.l.»
Art. 2. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet toute activité relative au commerce de prestations de services et de conseils en matière
d'assistance administrative et d'organisation quotidienne aux particuliers et aux entreprises.
En outre, la société pourra exercer toute activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.
D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rat-
tachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (Eur 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent
vingt-cinq Euros (Eur 125,-) chacune.
Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif
net en cas de dissolution.
Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de
mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée
sur les sociétés commerciales.
Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales bien
déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.
Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les présents
statuts.
Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-
vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.
Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur
les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir
leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.
Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.
5924
L
U X E M B O U R G
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.
Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les 3/4 du capital social.
Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de
leur mandat.
Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les
pièces comptables exigées par la loi.
Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal
jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs
liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août
1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant
sur requête de tout intéressé.
Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
légales.
<i>Fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille cent Euros
(Eur 1.100,-).
Le notaire instrumentant attire l'attention des comparantes qu'avant toute activité commerciale de la société présentement
fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social.
Les comparantes reconnaissent avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives
à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des
Notaires en date du 16 mai 2001.
<i>Loi anti-blanchimenti>
En application de la loi du 12 novembre 2004, les comparantes déclarent être les bénéficiaires réels de cette opération
et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1
du code pénal luxembourgeois.
<i>Souscriptioni>
Les 100 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire
qui le constate expressément, et toutes souscrites comme suit:
- Mme Christelle CLERO préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cinquante (50) parts sociales, et
- SOLOTIGO s.à r.l., préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cinquante (50) parts sociales,
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts sociales
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil seize.
<i>Assemblée généralei>
Les fondatrices prénommées, détenant l'intégralité des parts sociales, se sont constituées en Assemblée Générale et ont
pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
1) Le siège social est fixé à L-1660 Luxembourg, 60, Grand Rue.
2) La société sera gérée par deux gérantes:
Gérante pour la branche commerce: Madame Christelle CLERO, gérante de société, née à Paris, France, le 20 avril
1970, demeurant à L-3412 Dudelange, 40, rue Grand-Duc Adolphe,
Gérante pour la branche ménage: Madame Maria Helena BORGES ALVES CASTANHEIRA, gérante de société, née
à Vidago/Chaves, Portugal, le 10 mai 1973, demeurant à L-2149 Luxembourg, 9, rue Emile Metz.
5925
L
U X E M B O U R G
3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chacune des gérantes dans sa branche.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte, après
s'être identifiées au moyen de leurs cartes d'identité.
Signé: C. CLERO, M. GONRY, C. MINES.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/4037. Reçu soixante-quinze euros.
75,-€
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR COPIE CONFORME,
Capellen, le 29 décembre 2015.
Référence de publication: 2016004139/111.
(160002240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
EHT, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 64.354.
Famhold S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 64.315.
WB Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 64.572.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of the month of December;
Before Us, Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned;
THERE APPEARED:
Mrs Vanessa TIMMERMANS, employee, with professional address in Howald, acting in the name and on behalf of the
board of directors of EHT, a public limited company (“société anonyme”) governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, established and having its registered office in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under the number 64354, incorporated on May 13, 1998 pursuant
to a deed of Me Joseph GLODEN, then notary residing in Grevenmacher, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the "Mémorial C") number 547 of July 28, 1998 and whose articles of association have been amended for
the last time on April 4, 2001 pursuant to a resolution of the board of directors, an extract of which has been published in
the Mémorial number 969 of November 7, 2001 (hereafter referred to as the “Absorbing Company”),
pursuant to the powers she has been granted by the board of directors in the meeting held on November 13, 2015, a copy
of the minutes of said meeting, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and the officiating notary, shall
remain attached to the present deed for registration purposes.
Such person appearing, acting in the above stated capacities, requested the undersigned notary to record the merger of
the Absorbing Company with
- FAMHOLD, a public limited company (“société anonyme”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
established and having its registered office in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register, section B, under the number 64315, (hereafter referred to as “FAMHOLD”); and
- WB HOLDING, a public limited company (“société anonyme”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, established and having its registered office in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register, section B, under the number 64572, (hereafter referred to as “WBH” and together with
FAMHOLD, the “Absorbed Companies” and the Absorbed Companies together with the Absorbing Company, the “Merg-
ing Companies”);
as follows:
- the board of directors of the Absorbing Company and of the Absorbed Companies resolved to merge the Merging
Companies by acquisition (absorption) of the Absorbed Companies by the Absorbing Company (the “Merger”);
- the Absorbing Company is the sole shareholder of the Absorbed Companies holding 100 % of their share capital so
that the Merger will follow the simplified procedure according to the provisions of articles 278 and following of the law
of August 10, 1915 on Commercial Companies as amended (the “Law”);
- the board of directors of the Absorbing Company and of the Absorbed Companies have drawn up common draft terms
of merger according to the provisions of articles 261 and 278 of the Law;
5926
L
U X E M B O U R G
- the common draft terms of merger have been recorded in a notarial deed dated November 23, 2015, filed with the
Luxembourg Trade and Companies Register on November 24, 2015 and published in the Mémorial C, number 3223 of
November 28, 2015, page 154683;
- the shareholders of the Absorbing Company were entitled, at least one month before the effective date of the Merger
between the Merging Companies, to inspect the documents mentioned in article 267 paragraph (1) a), b) and c) of the Law
at the registered office of the Absorbing Company;
- none of the shareholders of the Absorbing Company has required that a general meeting of the Absorbing Company
is called in order to decide whether to approve the merger according to the provisions of article 279 (1) c) of the Law;
- a period of at least one month has lapsed since the publication of the common draft terms of merger in the Mémorial
C.
The foregoing being stated, the Absorbed Companies, following their acquisition (absorption) by the Absorbing Com-
pany, cease to exist and their shares are cancelled.
The Merger is effective, pursuant to the above-mentioned common draft terms of merger, (i) between the Merging
Companies at the date of this notarial deed as mentioned above, and (ii) vis-à-vis third parties after the publication of the
present deed in accordance with article 9 of the Law.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Absorbing Company
as a result of the present deed are estimated at approximately five hundred Euros (EUR 500.-).
<i>Certificationi>
In accordance with article 271 of the Law, the undersigned notary declares having verified and certifies the existence
and validity of the legal acts and formalities required in relation to the Merger of the Merging Companies.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
person appearing, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person
appearing, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the person appearing, acting as said before, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-neuf décembre;
Pardevant Nous, Maître Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, avec adresse professionnelle à Howald, agissant au nom et pour le
compte du conseil d'administration de EHT, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie
et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 64354, constituée le 13 mai 1998 suivant acte reçu par Maître Joseph GLODEN,
alors notaire de résidence à Grevenmacher, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»)
numéro 547 du 28 juillet 1998 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 4 avril 2001 suivant décision du
conseil d'administration, publiée par extrait au Mémorial numéro 969 du 7 novembre 2001 (ci-après la «Société Absor-
bante»),
en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'administration lors de la réunion du 13 novembre 2015,
une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Laquelle comparante, agissant es-dites qualités, a demandé et requis au notaire soussigné d'acter la fusion entre la Société
Absorbante et
- FAMHOLD, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social
à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 64315, (ci-après dénommée «FAMHOLD»); et
- WB HOLDING, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège
social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 64572, (ci-après dénommée «WBH» et ensemble avec FAMHOLD, les «Sociétés Absorbées», et les
Sociétés Absorbées ensemble avec la Société Absorbante, les «Sociétés Fusionnantes»);
comme suit:
5927
L
U X E M B O U R G
- le conseil d'administration de la Société Absorbante et des Sociétés Absorbées ont décidé de fusionner les Sociétés par
acquisition (absorption) des Sociétés Absorbées par la Société Absorbante (la “Fusion”);
- la Société Absorbante est l'actionnaire unique des Sociétés Absorbées et détient 100 % de leur capital social de sorte
que la Fusion sera soumise à la procédure simplifiée conformément aux dispositions des articles 278 et suivants de la loi
du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la “Loi”);
- le conseil d'administration de la Société Absorbante et des Sociétés Absorbées ont établi un projet commun de fusion
conformément aux articles 261 et 278 de la Loi;
- le projet commun de fusion a été enregistré sous forme d'acte notarié en date du 23 novembre 2015, il a été déposé
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 24 novembre 2015 et publié au Mémorial C, numéro
3223 du 28 novembre 2015, page 154683;
- les actionnaires de la Société Absorbante ont eu le droit, un mois au moins avant que l'opération de Fusion ne prenne
effet entre les Sociétés Fusionnantes, de prendre connaissance, au siège social de la Société Absorbante, des documents
indiqués à l'article 267, paragraphe (1) a), b) et c) de la Loi;
- aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a demandé la convocation d'une assemblée générale de la Société Ab-
sorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion conformément à l'article 279 (1) c) de la Loi;
- un délai d'un mois au moins s'est écoulé depuis la publication du projet commun de fusion au Mémorial C.
Ceci exposé, les Sociétés Absorbées après avoir été acquises (absorbées) par la Société Absorbante cessent d'exister et
leurs actions sont annulées.
La Fusion prend effet, tel que déterminé selon le projet commun de fusion mentionné ci-dessus, (i) entre les Sociétés
Fusionnantes à la date du présent acte mentionnée ci-avant, et (ii) vis-à-vis des tiers, après la publication du présent acte
en vertu de l'article 9 de la Loi.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, de quelque nature que ce soit, qui seront pris en charge par
la Société Absorbante en raison du présent acte est estimé approximativement à la somme de cinq cents euros (EUR 500,-).
<i>Attestationi>
Conformément aux dispositions de l'article 271 de la Loi, le notaire soussigné déclare avoir vérifié et atteste l'existence
et la légalité des actes et formalités en relation avec la Fusion incombant aux Sociétés Fusionnantes.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante, et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état
civil et domicile, ladite comparante a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: V. TIMMERMANS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 30 décembre 2015. 2LAC/2015/30390. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Référence de publication: 2016006533/138.
(160005432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.
Mohawk Financing International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 195.576.
In the year two thousand and sixteen, on the seventh day of January.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in repla-
cement of her colleague, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
momentarily absent, who will remain the depositary of the present deed,
There appeared:
Mohawk Global Investments S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, whose registered office is at 10B, rue des Mérovingiens,
5928
L
U X E M B O U R G
L-8070 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 111.052 (the “Sole Shareholder”),
here represented by Mr. Pierre Maucet, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal granted on 24 November 2015,
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the Sole Shareholder of Mohawk Financing International S.à r.l., a société à responsabilité
limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-8070
Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B
195.576 (the "Company").
The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement, the general
meeting of the shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Acknowledgment and approval of the documents in relation to the merger by absorption of the Company by Mohawk
International Financing S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 182.772 (the “Absorbing Company”);
2. Approval of the merger by absorption of the Company by the Absorbing Company;
3. Approval of the transfer of the entire assets and liabilities of the Company to the Absorbing Company as a consequence
of the merger and the subsequent dissolution without liquidation of the Company;
4. Miscellaneous.
In view of the above, the Sole Shareholder, which represents the entire share capital, has requested the officiating notary
to record the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
In accordance with article 265 (3) of the Luxembourg law dated 10 August 1915 concerning commercial companies, as
amended (the “Law”), the Sole Shareholder of the Company and of the Absorbing Company waived its right (i) to be
provided with a detailed written report drawn up by the board of managers of the Company and by the board of managers
of the Absorbing Company, explaining the terms of the Joint Merger Plan (defined here below) and setting out their
economic and legal grounds and (ii) pursuant to which each of the board of managers of the Company and the board of
managers of the Absorbing Company. has to inform its general meeting and the board of managers of the other merging
company of any significant changes to its assets and liabilities occurring between the date of the Joint Merger Plan and the
day of the present deed,
in accordance with article 266 (5) of the Law, the Sole Shareholder of the Company and of the Absorbing Company
waived its right to be provided with an examination of the Joint Merger Plan by independent experts and the related experts'
report, and
in accordance with article 267 (1) of the Law, the Sole Shareholder of the Company and of the Absorbing Company
waived the requirement to be provided with the interim accounts pursuant to a waiver letter, dated 6 January 2016.
The Sole Shareholder has been able to review all of the relevant documents provided for by article 267 (1) of the Law,
being the following documents:
- the Joint Merger Plan approved by the board of managers of the Company and the board of managers of the Absorbing
Company on 24 November 2015 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3272 dated
5 December 2015 (the “Joint Merger Plan”);
- the annual accounts for the Absorbing Company for the last two (2) accounting years, with the corresponding reports
from the statutory auditors of the Absorbing Company as they are legally required.
The Sole Shareholder hereby acknowledges having been notified that the documents listed above have been made
available for its review at the registered office of the Company within the period of time provided for by the Law.
The Sole Shareholder hereby decides to approve the documents listed above.
<i>Second Resolutioni>
The Sole Shareholder hereby decides to approve the merger between the Company and the Absorbing Company ac-
cording to the terms set out in the Joint Merger Plan and the related documents listed above.
The merger shall become effective between the Company and the Absorbing Company on the day of the extraordinary
general meeting of the shareholders of the Absorbing Company approving the merger, and shall become effective towards
third parties following the publication of this notarial deed in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Sole Shareholder hereby decides to approve that the merger shall be deemed effective for accounting and tax
purposes as of 1 January 2016.
5929
L
U X E M B O U R G
<i>Third Resolutioni>
Following the first and second resolutions here above, the Sole Shareholder hereby approves that the entire assets and
liabilities of the Company will be transferred to the Absorbing Company and the Company will be automatically dissolved
without liquidation.
<i>Estimation of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall
be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about four thousand four hundred euros (EUR
4,400.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxyholder of
the appearing party, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing
proxyholder of the appearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version
will be prevailing.
The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the merger and of all acts, documents and formalities
incumbent upon the merging companies pursuant to the Law.
Whereof, this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party known to the undersigned notary by
name, surname, civil status and residence, such person signed together with the notary this deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le septième jour du mois de janvier.
Par-devant nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant
en remplacement de son confrère empêché, Maitre Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché
de Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute,
ONT COMPARU:
Mohawk Global Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 111.052 (l'«Associé Unique»),
ici représentée par Monsieur Pierre Maucet, Maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 novembre 2015, à lui délivrée,
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
La partie comparante est l'Associé Unique de Mohawk Financing International S.à r.l., une société à responsabilité
limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 10B, rue des Mé-
rovingiens, L-8070 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 195.576 (la «Société»).
La partie comparante représentant l'intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation,
l'assemblée générale des associés est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à
l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Reconnaissance et approbation des documents relatifs à la fusion par absorption de la Société par Mohawk Interna-
tional Financing S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 182.772 (la «Société Absorbante»);
2. Approbation de la fusion par absorption de la Société par la Société Absorbante;
3. Approbation du transfert de l'ensemble de l'actif et du passif de la Société à la Société Absorbante en conséquence
de la fusion et de la dissolution sans liquidation subséquente de la Société;
4. Divers.
Qu'au vu de ce qui précède, l'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, prie le notaire instrumentant
d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
En conformité avec l'article 265 paragraphe (3) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, (la «Loi»), l'Associé Unique de la Société et de la Société Absorbante a expressément
renoncé à son droit (i) d'obtenir un rapport écrit détaillé établi par le conseil de gérance de la Société et le conseil de gérance
5930
L
U X E M B O U R G
de la Société Absorbante, expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le Projet Commun de Fusion
(défini ci-dessous) et (ii) suivant lequel le conseil de gérance de la Société et le conseil de gérance de la Société Absorbante
doivent informer leur assemblée générale respective ainsi que le conseil de gérance de l'autre société fusionnante de toute
modification importante de son actif et passif qui a eu lieu entre la date d'établissement du Projet Commun de Fusion et la
date du présent acte,
en conformité avec l'article 266 paragraphe (5) de la Loi, l'Associé Unique de la Société et de la Société Absorbante a
expressément renoncé à son droit d'obtenir un examen du Projet Commun de Fusion par des experts indépendants et le
rapport écrit préparé à cet effet par les experts indépendants, et
en conformité avec l'article 267 paragraphe (1) de la Loi, l'Associé Unique de la Société et de la Société Absorbante a
expressément renoncé à l'exigence d'obtenir les comptes intérimaires conformément à une lettre de renonciation en date
du 6 janvier 2016.
L'Associé Unique a pu prendre connaissance de tous les documents pertinents énumérés à l'article 267, alinéa (1) de la
Loi, à savoir les documents suivants:
- le projet commun de fusion approuvé par le conseil de gérance de la Société et le conseil de gérance de la Société
Absorbante le 24 novembre 2015 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3272 daté du 5
décembre 2015 (le «Projet Commun de Fusion»);
- les comptes annuels de la Société Absorbante des deux (2) derniers exercices financiers ainsi que les rapports corres-
pondants des commissaires aux comptes de la Société Absorbée tels qu'exigés par la loi.
L'Associé Unique déclare avoir été averti que les documents énumérés ci-dessus ont été mis à sa disposition au siège
social de la Société au cours de la période prévue par la Loi.
L'Associé Unique décide d'approuver les documents énumérés ci-dessus.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'approuver la fusion entre la Société et la Société Absorbante selon les modalités établies
dans le Projet Commun de Fusion ainsi que dans les documents connexes repris ci-avant.
La fusion prendra effet entre la Société et la Société Absorbante à compter de l'assemblée générale extraordinaire des
associés de la Société Absorbante approuvant la fusion, et sera opposable aux tiers suivant la publication du présent acte
notarié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'Associé Unique décide d'approuver le fait que d'un point de vue comptable et fiscale la fusion soit considérée effective
au 1
er
janvier 2016.
<i>Troisième résolutioni>
Suivant les premières et deuxièmes résolutions ci-dessus, L'Associé Unique approuve par la présente que tout l'actif et
le passif de la Société sera transféré à la Société Absorbante et que la Société sera automatiquement dissoute sans liquidation.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ quatre mille quatre cents euros (EUR 4.400.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du mandataire de cette même partie
comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Le notaire soussigné atteste par les présentes l'existence et la légalité de la fusion et de tous les actes, documents et
exigences formelles imposés aux sociétés fusionnantes par la Loi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg à la date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par
nom, prénom, qualité et demeure, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Maucet, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 11 janvier 2016. GAC/2016/311. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 11 janvier 2016.
Référence de publication: 2016006818/171.
(160006545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.
5931
L
U X E M B O U R G
Bordeso Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 69.346.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of December,
Before Maître Danielle KOLBACH, Notary residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Bordeso Holding S.A., a Luxembourg public limited liability
company (société anonyme) having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg registered with
the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under section B number 69346, incorporated pursuant to a notarial
deed enacted by Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notary residing in Luxembourg, on 7 April 1999, published
in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the Mémorial C) number 480 on 24 June 1999; and the
Articles of Association of which have been amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted by Maître Martine
SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg on 6 November 2009, published in the Mémorial C number 2421 on 12
December 2009.
The meeting is chaired by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Barbara Schmitt, private employee, professio-
nally residing in Redange-sur-Attert.
The chairman requests the notary to record that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list. That
list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.
II.- The attendance list let appear that the seventy five thousand (75,000) shares with a nominal value of one hundred
euro (EUR 100.-) each, representing the entirety of the seven million five hundred thousand euros (EUR 7,500,000.-) of
the share capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1.- Decrease of the share capital of the company by an amount of one million five hundred euros (EUR 1,500,000.-) so
as to bring it from its current amount of seven million five hundred euros (EUR 7,5000,000.-) down to six million euros
(EUR 6,000,000.-) by reduction of the nominal value of the shares and reimbursement to the Sole Shareholder.
2.- Subsequent amendment of Article 3 of the Articles of Association of the Company.
IV.- The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Shareholders waive the convening
notices.
The sole shareholder agrees, to deliberate and vote upon all the items of the agenda.
The Sole Shareholder further confirms that all the documentation produced to the meeting has been put at its disposal
within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.
After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder unanimously decides what follows:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to decrease the share capital of the company by an amount of one million five hundred euros (EUR
1,500,000.-) so as to bring it from its current amount of seven million five hundred euros (EUR 7,500,000.-) down to six
million euros (EUR 6,000,000.-) by reduction of the nominal value of the shares from one hundred euros (EUR 100.-)
down to eighty euros (EUR 80.-) and reimbursement to the Sole Shareholder.
<i>Reimbursement delayi>
The undersigned notary has drawn the attention of the assembly to the provisions of article 69 of the law on commercial
companies establishing a legal protection in favour of eventual creditors of the Company, the effective reimbursement to
the sole shareholder cannot be made freely and without recourse from them before 30 (thirty) days after publication of the
present deed in the Luxembourg Memorial C.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the meeting decides to subsequently amendment Article 3 of the Articles of
Association of the Company both in the German and in the English version so that it will read as follows:
German version
“ Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt sechs Millionen Euro (EUR 6.000.000.-) eingeteilt in fünfundsiebzigtausend
(75.000) Aktien mit einem Nominalwert von achtzig (EUR 80.-) Euro.”
5932
L
U X E M B O U R G
English version
“ Art. 3. The corporate capital is set at six millions Euro (EUR 6,000,000.-) divided into seventy-five thousand (75,000)
shares with a par value of eighty euros (EUR 80.-) euro.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result
of the present deed, are estimated at approximately one thousand three hundred euros (EUR 1,300.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le trentième jour de décembre,
Par devant Maître Danielle KOLBACH, Notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.
Se réunit
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Bordeso Holding S.A. ayant son siège social
au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous la section B numéro 69346, constituée suivant acte notarié reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN,
notaire de résidence à Luxembourg en date du 7 Avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations (le Mémorial C) numéro 480 du 24 juin 1999; dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte
reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 6 novembre 2009, publié au Mémorial
C numéro 2421 du 12 décembre 2009.
L'assemblée est présidée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Barbara Schmitt, employée privée,
demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'actionnaire unique présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence.
Cette liste et la procuration, une fois signée par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être
enregistrées avec l'acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que soixante-quinze mille (75.000) actions d'une valeur nominale de
cent euros (EUR 100.-) chacune, représentant l'intégralité des sept millions cinq cent mille euros (EUR 7.500.000,-) du
capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'actionnaire unique été préalablement informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1.- Réduction du capital social de la Société d'un montant d'un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) afin de
le porter de son montant actuel de sept millions cinq cent mille euros (EUR 7.500.000,-) pour le porter à six millions d'euros
(EUR 6.000.000,-) par réduction de la valeur nominale des actions pour la porter de cent euros (EUR 100.-) à quatre-vingts
euros (EUR 80,-) et remboursement à l'actionnaire unique.
2.- Modification subséquente de l'Article 3 des Statuts de la Société.
IV.- L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, l'Actionnaire Unique décide de renoncer
aux formalités de convocation.
L'Actionnaire Unique accepte dès lors de délibérer et de voter les points portés à l'ordre du jour. Il confirme que toute
la documentation présentée lors de l'assemblée a été mise à sa disposition endéans une période suffisante pour lui permettre
d'examiner attentivement chaque document.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'actionnaire unique décide ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de réduire capital social de la Société d'un montant d'un million cinq cent mille euros (EUR
1.500.000,-) afin de le porter de son montant actuel de sept millions cinq cent mille euros (EUR 7.500.000,-) pour le porter
à six millions d'euros (EUR 6.000.000,-) par réduction de la valeur nominale des actions pour la porter de cent euros (EUR
100.-) à quatre-vingts euros (EUR 80,-) et remboursement à l'actionnaire unique.
5933
L
U X E M B O U R G
<i>Délai de remboursementi>
Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales
instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement effectif aux associés ne pouvant
avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication du présent acte au Mémorial C.
<i>Seconde résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier la version allemande et la version anglaise
l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Version allemande
“ Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt sechs Millionen Euro (EUR 6.000.000.-) eingeteilt in fünfundsiebzigtausend
(75.000) Aktien mit einem Nominalwert von achtzig (EUR 80.-) Euro.”
Version anglaise
“ Art. 3. The corporate capital is set at six millions Euro (EUR 6,000,000.-) divided into seventy-five thousand (75,000)
shares with a par value of eighty euros (EUR 80.-) euro.”
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Redange-sur-Attert, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française.
Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais
fera foi.
Signé: S. LECOMTE, B. SCHMITT, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 31 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22792. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Carlo RODENBOUR.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 12 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007301/135.
(160006743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Elika Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 282, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 202.997.
STATUTS
L'an deux mil quinze, le vingt-deux décembre,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
A comparu:
Monsieur Reza BAHREHVAR, administrateur de sociétés, né à Teheran, Iran, le 23 septembre 1972, demeurant à
L-8139 Bridel, 15, rue des Jardins.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «ELIKA INVEST-
MENTS s.à r.l.»
Art. 2. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, le financement et
le développement de ces participations.
Elle pourra donner du conseil économique et financier de tout genre.
Elle a encore pour objet la gestion d'immeubles et de biens immobiliers, l'achat, la vente, la mise en valeur, la location,
la promotion et la commercialisation d'immeubles et de biens immobiliers.
5934
L
U X E M B O U R G
Elle pourra emprunter, donner ses immeubles en garantie, se porter caution, consentir toutes hypothèques, le tout tant
pour son propre compte que pour le compte de tiers.
Elle pourra accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances
ou garanties.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des
valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
Elle pourra, après obtention le cas échéant des autorisations nécessaires, réaliser tous travaux de construction, de réno-
vation et de remise en état d'immeubles et de leurs alentours, pour son compte propre ou pour compte de tiers.
Elle pourra acquérir et obtenir tous brevets d'invention et de perfectionnement, licences, procédés et marques de fabri-
ques, les exploiter, céder et concéder toutes les licences.
Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec d'autres entre-
prises, associations ou sociétés.
D'une manière générale, elle pourra accomplir tous actes et opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser sa réali-
sation ou son développement.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (Eur 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent
vingt-cinq Euros (Eur 125,-) chacune.
Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif
net en cas de dissolution.
Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de
mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée
sur les sociétés commerciales.
Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales bien
déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.
Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les présents
statuts.
Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-
vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.
Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur
les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir
leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.
Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.
Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les 3/4 du capital social.
Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de
leur mandat.
Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les
pièces comptables exigées par la loi.
Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal
jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs
liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août
5935
L
U X E M B O U R G
1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant
sur requête de tout intéressé.
Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
légales.
<i>Fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille cent Euros
(Eur 1.100,-).
Le notaire instrumentant attire l'attention du comparant qu'avant toute activité commerciale de la société présentement
fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social.
Le comparant reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l'octroi
d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notaires
en date du 16 mai 2001.
<i>Loi anti-blanchimenti>
En application de la loi du 12 novembre 2004, le comparant déclare être le bénéficiaire réel de cette opération et déclare
en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal
luxembourgeois.
<i>Souscriptioni>
Les 100 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire
qui le constate expressément, et toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Reza BAHREHVAR préqualifié.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil seize.
<i>Assemblée généralei>
Le fondateur prénommé, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constitué en Assemblée Générale et a pris à
l'unanimité les résolutions suivantes:
1) Le siège social est fixé à L-2441 Luxembourg, 282, rue de Rollingergrund.
2) La société sera gérée par un gérant unique: Monsieur Reza BAHREHVAR, administrateur de sociétés, né à Teheran,
Iran, le 23 septembre 1972, demeurant à L-8139 Bridel, 15, rue des Jardins.
3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être
identifié au moyen de sa carte d'identité.
Signé: R. BAHREHVAR, C. MINES.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/42110. Reçu soixante-quinze
euros 75,-€
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR COPIE CONFORME,
Capellen, le 6 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007443/116.
(160007106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Mohawk International Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 182.772.
In the year two thousand and sixteen, on the seventh day of January.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in repla-
cement of her colleague, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
momentarily absent, who will remain the depositary of the present deed,
There appeared:
Mohawk Global Investments S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, whose registered office is at 10B, rue des Mérovingiens,
5936
L
U X E M B O U R G
L-8070 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 111.052 (the “Sole Shareholder”),
here represented by Mr. Pierre Maucet, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal granted on 24 November 2015,
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the Sole Shareholder of Mohawk International Financing S.à r.l., a société à responsabilité
limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-8070
Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B
182.772 (the "Company").
The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement, the general
meeting of the shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Acknowledgment and approval of the documents in relation to the merger by absorption of Mohawk Financing
International S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under number B 195.576 (the “Absorbed Company”) by the Company;
2. Approval of the merger by absorption of the Absorbed Company by the Company;
3. Approval of the transfer of the entire assets and liabilities of the Absorbed Company to the Company as a consequence
of the merger and acknowledgment of the subsequent dissolution without liquidation of the Absorbed Company;
4. Approval of the increase in capital of the Company resulting from the above-mentioned merger, by an amount of
twenty-five thousand US dollars (USD 25,000) as to raise it from its current amount of thirty-five thousand US dollars
(USD 35,000) up to sixty thousand US dollars (USD 60,000) by issuing twenty-five thousand (25,000) shares with a par
value of one US dollar (USD 1) each;
5. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as
follows:
“ 5.1. The Company's corporate capital is fixed at sixty thousand US dollars (USD 60,000) represented by sixty thousand
(60,000) shares in registered form with a par value of one US dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paidup”;
6. Miscellaneous.
I. It is proposed that the Company absorbs the Absorbed Company.
II. In view of the above, the Sole Shareholder, which represents the entire share capital, has requested the officiating
notary to record the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
In accordance with article 265 (3) of the Luxembourg law dated 10 August 1915 concerning commercial companies, as
amended (the “Law”), the Sole Shareholder of the Company and of the Absorbed Company waived its right (i) to be
provided with a detailed written report drawn up by the board of managers of the Company and by the board of managers
of the Absorbed Company, explaining the terms of the Joint Merger Plan (defined here below) and setting out their economic
and legal grounds and (ii) pursuant to which each of the board of managers of the Company and the board of managers of
the Absorbed Company has to inform its general meeting and the board of managers of the other merging company of any
significant changes to its assets and liabilities occurring between the date of the Joint Merger Plan and the day of the present
deed,
in accordance with article 266 (5) of the Law, the Sole Shareholder of the Company and of the Absorbed Company
waived its right to be provided with an examination of the Joint Merger Plan by independent experts and the related experts'
report, and
in accordance with article 267 (1) of the Law, the Sole Shareholder of the Company and of the Absorbed Company
waived the requirement to be provided with the interim accounts pursuant to a waiver letter, dated 6 January 2016.
The Sole Shareholder has been able to review all of the relevant documents provided for by article 267 (1) of the Law,
being the following documents:
- the Joint Merger Plan approved by the board of managers of the Company and the board of managers of the Absorbed
Company on 24 November 2015 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3272 dated
5 December 2015 (the “Joint Merger Plan”);
- the annual accounts for the Company for the last two (2) accounting years, with the corresponding reports from the
statutory auditors of the Company as they are legally required;
The Sole Shareholder hereby acknowledges having been notified that the documents listed above have been made
available for its review at the registered office of the Company within the period of time provided for by the Law.
The Sole Shareholder hereby decides to approve the documents listed above.
5937
L
U X E M B O U R G
<i>Second Resolutioni>
The Sole Shareholder hereby decides to approve the merger between the Company and the Absorbed Company according
to the terms set out in the Joint Merger Plan and the related documents listed above.
The merger shall become effective between the Company and the Absorbed Company on the day of this present deed
and shall become effective towards third parties following the publication of this notarial deed in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
The Sole Shareholder hereby decides to approve that the merger shall be deemed effective for accounting and tax
purposes as of 1 January 2016.
<i>Third Resolutioni>
Following the first and second resolutions here above, the Sole Shareholder hereby approves that the entire assets and
liabilities of the Absorbed Company will be transferred to the Company and acknowledges that the Absorbed Company
will be automatically dissolved without liquidation.
<i>Fourth Resolutioni>
Following the absorption of the Absorbed Company, the capital of the Absorbing Company is increased by an amount
of by an amount of twenty-five thousand US dollars (USD 25,000) as to raise it from its current amount of thirty-five
thousand US dollars (USD 35,000) up to sixty thousand US dollars (USD 60,000) by issuing twenty-five thousand (25,000)
shares with a par value of one US dollar (USD 1) each.
Allotment:
The newly issued twenty-five thousand (25,000) shares are allotted on the basis of the exchange ratio set out in the Joint
Merger Plan to the Sole Shareholder.
Said new shares are fully paid up as a result of the merger, through a contribution in kind consisting of all assets and
liabilities of the Absorbed Company.
<i>Fifth Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth
read as stated in the agenda.
<i>Estimation of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall
be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about four thousand four hundred euros (EUR
4,400.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxyholder of
the appearing party, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing
proxyholder of the appearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version
will be prevailing.
The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the merger and of all acts, documents and formalities
incumbent upon the merging companies pursuant to the Law.
Whereof, this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party known to the undersigned notary by
name, surname, civil status and residence, such person signed together with the notary this deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le septième jour du mois de janvier.
Par-devant nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant
en remplacement de son confrère empêché, Maitre Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché
de Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute,
ONT COMPARU:
Mohawk Global Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 111.052 (l'«Associé Unique»),
ici représentée par Monsieur Pierre Maucet, Maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 novembre 2015, à lui délivrée, Ladite procuration, paraphée ne
varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
5938
L
U X E M B O U R G
La partie comparante est l'Associé Unique de Mohawk International Financing S.à r.l., une société à responsabilité
limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 10B, rue des Mé-
rovingiens, L-8070 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 182.772 (la «Société»).
La partie comparante représentant l'intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation,
l'assemblée générale des associés est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à
l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Reconnaissance et approbation des documents relatifs à la fusion par absorption de la Société de Mohawk Financing
International S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ayant son siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 195.576 (la «Société Absorbée»);
2. Approbation de la fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société;
3. Approbation du transfert de l'ensemble de l'actif et du passif de la Société Absorbée à la Société en conséquence de
la fusion et prise d'acte de la dissolution sans liquidation subséquente de la Société Absorbée;
4. Approbation de l'augmentation de capital social de la Société résultant de la fusion susvisée d'un montant de vingt-
cinq mille dollars américains (USD 25.000), pour le porter de son montant actuel de trente-cinq mille dollars américains
(EUR 35.000) à soixante mille dollars américains (USD 60.000), par l'émission de vingt-cinq mille (25.000) nouvelles
parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune;
5. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société qui sera désormais lu comme suit:
« 5.1. Le capital de la Société est fixé à soixante mille dollars des Etats-Unis (USD 60.000), représenté par soixante
mille (60.000) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis (USD 1) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées.»
6. Divers.
I- Qu'il est proposé que la Société Absorbée soit absorbée par la Société.
II- Qu'au vu de ce qui précède, l'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, prie le notaire instrumentant
d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
En conformité avec l'article 265 paragraphe (3) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, (la «Loi»), l'Associé Unique de la Société et de la Société Absorbée a expressément
renoncé à son droit (i) d'obtenir un rapport écrit détaillé établi par le conseil de gérance de la Société et le conseil de gérance
de la Société Absorbée, expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le Projet Commun de Fusion (défini
ci-dessous) et (ii) suivant lequel le conseil de gérance de la Société et le conseil de gérance de la Société Absorbée doivent
informer leur assemblée générale respective ainsi que le conseil le conseil de gérance de l'autre société fusionnante de toute
modification importante de son actif et passif qui a eu lieu entre la date d'établissement du Projet Commun de Fusion et la
date du présent acte,
en conformité avec l'article 266 paragraphe (5) de la Loi, l'Associé Unique de la Société et de la Société Absorbée a
expressément renoncé à son droit d'obtenir un examen du Projet Commun de Fusion par des experts indépendants et le
rapport écrit préparé à cet effet par les experts indépendants, et
en conformité avec l'article 267 paragraphe (1) de la Loi, l'Associé Unique de la Société et de la Société Absorbée a
expressément renoncé à l'exigence d'obtenir des comptes intérimaires conformément à une lettre de renonciation en date
du 6 janvier 2016.
L'Associé Unique a pu prendre connaissance de tous les documents pertinents énumérés à l'article 267, alinéa (1) de la
Loi, à savoir les documents suivants:
- le projet commun de fusion approuvé par le conseil de gérance de la Société et le conseil de gérance de la Société
Absorbée le 24 novembre 2015 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3272 daté du 5
décembre 2015 (le «Projet Commun de Fusion»);
- les comptes annuels de la Société des deux (2) derniers exercices financiers ainsi que les rapports correspondants des
commissaires aux comptes de la Société tels qu'exigés par la loi;
L'Associé Unique déclare avoir été averti que les documents énumérés ci-dessus ont été mis à sa disposition au siège
social de la Société au cours de la période prévue par la Loi.
L'Associé Unique décide d'approuver les documents énumérés ci-dessus ainsi que l'évaluation de l'actif et du passif
contribué et sa rémunération.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'approuver la fusion entre la Société et la Société Absorbée selon les modalités établies dans
le Projet Commun de Fusion ainsi que dans les documents connexes repris ci-avant.
5939
L
U X E M B O U R G
La fusion prendra effet entre la Société et la Société Absorbée à compter de la date de ce présent acte et sera opposable
aux tiers suivant la publication du présent acte notarié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'Associé Unique décide d'approuver le fait que d'un point de vue comptable et fiscale la fusion soit considérée effective
au 1
er
janvier 2016.
<i>Troisième résolutioni>
Suivant les premières et deuxièmes résolutions ci-dessus, l'Associé Unique approuve par la présente que tout l'actif et
le passif de la Société sera transféré à la Société et prend acte que la Société Absorbée sera automatiquement dissoute sans
liquidation.
<i>Quatrième résolutioni>
Suivant l'absorption de la Société Absorbée, le capital de la Société sera augmenté d'un montant de vingt-cinq mille
dollars américains (USD 25.000), pour le porter de son montant actuel de trente-cinq mille dollars américains (USD 35.000)
à soixante mille dollars américains (USD 60.000), par l'émission de vingt-cinq mille (25.000) nouvelles parts sociales ayant
une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune.
Attribution des parts sociales:
Les vingt-cinq mille (25.0000) parts sociales nouvellement émises sont attribuées selon le ratio d'échange établi dans
le Projet Commun de Fusion à l'Associé Unique de la Société Absorbée.
Ces nouvelles actions sont intégralement libérées sous l'effet de la fusion, par un apport en nature consistant en l'uni-
versalité des actifs et passifs de la Société Absorbée.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique de la Société décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société
qui sera désormais lu tel que précité dans l'ordre du jour.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ quatre mille quatre cents euros (EUR 4.400.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du mandataire de cette même partie
comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Le notaire soussigné atteste par les présentes l'existence et la légalité de la fusion et de tous les actes, documents et
exigences formelles imposés aux sociétés fusionnantes par la Loi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par
nom, prénom, qualité et demeure, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Maucet, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 11 janvier 2016. GAC/2016/312. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 11 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007651/216.
(160006544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 154.210.
Mitteilung an die Aktionäre des UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 -
Global Quantitative (USD) und des UBS (Lux) Equity SICAV -
Global Quantitative (USD) (die "Aktionäre")
Die Verwaltungsgesellschaft der UBS (Lux) Key Selection SICAV 2, einer "Société d'Investissement à Capital Variable
(SICAV)", und der UBS (Lux) Equity SICAV, einer "Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)", möchte Sie
von der Entscheidung der jeweiligen Verwaltungsräte in Kenntnis setzen, den Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV
2 - Global Quantitative (USD) (der "übertragende Subfonds") mit Wirkung vom 25. Februar 2016 (das "Datum des In-
5940
L
U X E M B O U R G
krafttretens") mit dem Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV - Global Quantitative (USD) (der "übernehmende Subfonds")
(beide gemeinsam als die "Subfonds" bezeichnet) zu verschmelzen (die "Verschmelzung").
Angesichts sich verändernder Anlegerbedürfnisse und im Hinblick auf die Rationalisierung und Straffung des Angebots
an globalen Aktienfonds sowie aufgrund der Tatsache, dass der übertragende Subfonds und der übernehmende Subfonds
durch denselben Portfolioverwalter mit sehr ähnlichen Risiko-Ertrags-Zielen, Anlagepolitik und -richtlinien verwaltet
werden, ist es nach Ansicht des Verwaltungsrats des übertragenden Subfonds und des Verwaltungsrats des übernehmenden
Subfonds im besten Interesse der Aktionäre, den übertragenden Subfonds auf den übernehmenden Subfonds gemäss Artikel
25.2 der Satzung der UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 bzw. Artikel 25.2 der Satzung der UBS (Lux) Equity SICAV zu
verschmelzen.
Mit dem Datum des Inkrafttretens haben die Aktien des übertragenden Subfonds, die mit dem übernehmenden Subfonds
verschmolzen werden, in jeder Hinsicht dieselben Rechte wie die Aktien, die vom übernehmenden Subfonds ausgegeben
werden.
Die Verschmelzung wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil/Aktie zum 24. Februar 2016 (das "Refe-
renzdatum") erfolgen. Im Zusammenhang mit dieser Verschmelzung werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
des übertragenden Subfonds dem übernehmenden Subfonds zugerechnet. Die Zahl der dadurch auszugebenden neuen
Aktien wird am Datum des Inkrafttretens auf Basis des Umtauschverhältnisses entsprechend dem Nettoinventarwert je
Aktie des übertragenden Subfonds am Referenzdatum im Vergleich zu entweder (i) dem Erstausgabepreis der entspre-
chenden übernehmenden Aktienklasse des übernehmenden Subfonds - sofern diese Aktienklasse vor dem Referenzdatum
noch nicht ausgegeben wurde - oder (ii) dem Nettoinventarwert je Aktie der übernehmenden Aktienklasse des überneh-
menden Subfonds am Referenzdatum berechnet. Die Verschmelzung bringt für die Aktionäre folgende Änderungen mit
sich:
UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 - Global
Quantitative (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Quantitative
(USD)
Übertragende
Aktienklassen
I-B-acc (ISIN: LU1285692783)
I-X-acc (ISIN: LU0992307545)
I-B-acc (ISIN: LU1289529346)
U-X-acc (ISIN: LU1289529262)
Maximale Gebühr p. a.
I-B-acc: 0,065 %
I-X-acc: 0,000 %
I-B-acc: 0,065 %
U-X-acc: 0,000 %
Referenzwährung des
Subfonds
USD
USD
Laufende Gebühren
(gemäss den
wesentlichen
Anlegerinformationen,
"KII")
I-B-acc: 0,08 %
I-X-acc: 0,01 %
I-B-acc: 0,08 %
U-X-acc: 0,01 %
Risiko- und
Ertragsprofil ("SRRI")
gemäss KII
5
5
Anlagepolitik
Der Subfonds investiert zumindest zwei Drittel
seines Vermögens in Aktien oder Kapitalanteile
von Unternehmen gemäss dem Grundsatz der
Risikostreuung.
Das Anlageverfahren basiert auf quantitativen
Modellen für die Ermittlung von Bewertungs-
diskrepanzen bei gleichzeitiger Risikokontrolle.
Die dafür benötigten Bewertungskriterien bauen
auf einer Auswahl an statischen Daten und theo-
retischen Bewertungsindikatoren auf. Diese
quantitativen Modelle werden anschliessend ver-
wendet, um Prognosen zu der erwarteten Kur-
sentwicklung einer jeden Aktie im Verhältnis zur
Kursentwicklung des Gesamtmarktes und der
verschiedenen Sektoren zu erstellen. Unter Ver-
wendung eines Algorithmus werden die einzel-
nen Prognosen im Rahmen der Portfoliozusam-
menstellung eingesetzt, unter der Vorausse-
tzung, dass keine unnötigen Risiken in Bezug auf
einzelne Aktien, Sektoren oder Faktoren entste-
hen.
Der Subfonds investiert sein Vermögen weltweit
in Aktien oder andere Eigenkapitalanteile von
Unternehmen gemäss dem Grundsatz der Risi-
kostreuung.
Das Anlageverfahren basiert auf quantitativen
Modellen, mit denen Bewertungsdifferenzen bei
gleichzeitiger Risikokontrolle ermittelt werden.
Die dafür benötigten Bewertungskriterien bauen
auf einer Auswahl an für die Bewertungen rele-
vanten statischen Daten und Indikatoren auf.
Diese quantitativen Modelle werden verwendet,
um das Risiko eines Kursrückgangs zu testen und
zu reduzieren, dabei jedoch das Potenzial von
Kurssteigerungen zu erhalten. Ein Algorithmus
wird verwendet, um die Einzelprognosen im
Hinblick auf die Portfoliozusammenstellung zu
verarbeiten, mit der Einschränkung, dass keine
unnötigen Risiken für einzelne Titel, Sektoren
oder Faktoren geschaffen werden.
Dieser Subfonds kann sowohl in entwickelte
Länder als auch in Schwellenländer investieren.
Cut-off-Zeitpunkt
15.00 Uhr MEZ an einem Geschäftstag
15.00 Uhr MEZ an einem Geschäftstag
Geschäftsjahr
1. Oktober bis 30. September
1. Juni bis 31. Mai
5941
L
U X E M B O U R G
Da vor dem Datum des Inkrafttretens unter Umständen ein beträchtlicher Teil des Vermögens des übertragenden Sub-
fonds verkauft und in liquide Mittel investiert wird, kann die Verschmelzung die Zusammensetzung des Portfolios des
übertragenden Subfonds wesentlich beeinflussen. Wie jede andere Verschmelzung birgt auch die vorliegende Verschmel-
zung aufgrund der Neustrukturierung des Portfolios des übertragenden Subfonds ein potenzielles Risiko der Performan-
ceverwässerung. Ausserdem bleiben die Merkmale des Subfonds wie die Handelshäufigkeit und die Referenzwährung
unverändert. Die Risikokategorie des übernehmenden Subfonds entspricht dem SRRI des übertragenden Subfonds. Die
maximale pauschale Verwaltungskommission des übernehmenden Subfonds entspricht der maximalen pauschalen Ver-
waltungskommission des übertragenden Subfonds. Die laufenden Gebühren des übernehmenden Subfonds entsprechen
den laufenden Gebühren des übertragenden Subfonds. Die Rechts-, Beratungs- und Verwaltungskosten und -auslagen (mit
Ausnahme eventueller Transaktionskosten für den übertragenden Subfonds) in Verbindung mit dieser Verschmelzung
werden von der UBS AG getragen und haben weder Auswirkungen auf den übertragenden noch auf den übernehmenden
Subfonds.
Für Aktionäre des übertragenden Subfonds und des übernehmenden Subfonds, die der Verschmelzung nicht zustimmen,
ist die Rücknahme ihrer Aktien kostenlos bis zum Cut-off-Zeitpunkt um 15.00 Uhr MEZ am 18. Februar 2016 möglich.
Der übertragende Subfonds wird anschliessend für Rücknahmen geschlossen. Ab sofort ist für den übertragenden Subfonds
eine Abweichung von dessen Anlagepolitik zulässig, soweit dies für die Anpassung des zugehörigen Portfolios an die
Anlagepolitik des übernehmenden Subfonds erforderlich ist. Die Verschmelzung tritt am 25. Februar 2016 in Kraft und ist
bindend für alle Aktionäre, die keine Rücknahme ihrer Aktien beantragt haben.
Aktien des übernehmenden Subfonds wurden bis zum 15. Januar 2016, Cut-off-Zeitpunkt 15.00 MEZ ausgegeben. Am
Datum des Inkrafttretens der Verschmelzung werden die Aktionäre des übertragenden Subfonds in das Aktionärsregister
des übernehmenden Subfonds eingetragen und sind darüber hinaus in der Lage, ihre Rechte als Aktionäre des überneh-
menden Subfonds auszuüben, so z. B. das Recht, den Rückkauf, die Rücknahme oder den Umtausch von Aktien des
übernehmenden Subfonds zu beantragen.
PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg, wurde mit der Erstellung
eines Berichts beauftragt, in dem die in Artikel 71 Absatz 1 Buchstabe a bis c Alternative 1 des luxemburgischen Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010") vorgesehenen Bedingungen
zum Zwecke dieser Verschmelzung überprüft werden. Ein Exemplar dieses Berichts wird den Aktionären rechtzeitig vor
der Verschmelzung auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Ferner wird PricewaterhouseCoopers mit der Überprü-
fung des tatsächlichen Umtauschverhältnisses beauftragt, das am Tag der Berechnung des Umtauschverhältnisses festgelegt
wird, so wie dies in Artikel 71 Absatz 1 Buchstabe c Alternative 2 des Gesetzes von 2010 vorgesehen ist. Ein Exemplar
dieses Berichts wird den Aktionären auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird den Aktionären
des übertragenden Subfonds empfohlen, die KII für den übernehmenden Subfonds zu lesen, die online unter www.ubs.com/
funds verfügbar sind. Aktionäre, die weiterführende Informationen wünschen, können sich an die Verwaltungsgesellschaft
wenden. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass Anleger für ihre Beteiligungen an Investmentfonds möglicherweise
steuerpflichtig sind. Bei steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit dieser Verschmelzung wenden Sie sich bitte an Ihren
Steuerberater.
Luxemburg, den 18. Januar 2016
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
Référence de publication: 2016050207/755/114.
Structured Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 112.174.
PensionProtect 2015
ISIN: LU0206724808
Gemäß den Bestimmungen in Ziff. 8.1 e) des Verkaufsprospektes des o.g. Fonds, hat dieser zum 31. Dezember 2015
sein Laufzeitende erreicht und wurde von der offiziellen Liste für Organismen für gemeinsame Anlagen gestrichen.
Die jeweilige Liquidation ist abgeschlossen, alle Investoren wurden ausbezahlt. Es wurden keine Gelder an die Caisse
de Consignation gezahlt.
Hinweis zur Bekanntmachung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Association
Luxemburg, im Januar 2016
Structured Invest S.A.
Dr. Wolfgang Höhn / Pascal Loscheider
Référence de publication: 2016050205/16.
5942
L
U X E M B O U R G
DCM Systematic GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.
R.C.S. Luxembourg B 202.640.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of December.
Before, Maître Henri Hellinckx, notary professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
(1) Jérôme Callut, born on 7 March 1980 at Uccle, Belgium, residing in 34, avenue de la Croix de Bourgogne, B-1410
Waterloo, Belgium, here represented by Allen & Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Lu-
xembourg bar, by virtue of a power of attorney given under private seal, itself represented by Mathieu Voos, residing
professionally in 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
(2) Anthony Dearden, born on 9 October 1979 in Birkenhead, United Kingdom, residing in 28a, Rue de Saint-Jean,
Geneva, Switzerland, here represented by Allen & Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Lu-
xembourg bar, by virtue of a power of attorney given under private seal, itself represented by Mathieu Voos, residing
professionally in 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
Said powers of attorney, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and by the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
1. Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "DCM
Systematic GP, S.à r.l." (the Company).
2. Art. 2. Corporate object.
2.1 The Company will manage, and act as general partner of, and take general partner shares in, DCM Systematic Fund
SICAV-SIF, a corporate partnership limited by shares (société en commandite par action) organised as a specialised in-
vestment fund (fonds d'investissement spécialisé) subject to the Luxembourg act of 13 February 2007 relating to specialised
investment funds, as amended (the 2007 Act).
2.2 The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the
accomplishment and development of its purpose.
3. Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
4. Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the board of managers of the Company.
4.3 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
5. Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand and five hundred euro (EUR
12,500) represented by twelve thousand and five hundred (12,500) shares having a nominal value of one euro (EUR 1)
each.
6. Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by a decision of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance with article 15 of
these articles of association.
7. Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
8. Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a single representative towards the Company.
9. Art. 9. Transfer of shares.
9.1 In case the Company has only one shareholder, the shares held by the sole shareholder are freely transferable.
9.2 In case the Company has several shareholders, any transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised
by the general meeting of shareholders who represent at least three-quarters of the share capital of the Company. No such
authorisation is required for a transfer of shares among shareholders.
9.3 Any transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters
of the rights belonging to the surviving shareholders.
5943
L
U X E M B O U R G
9.4 The requirements of articles 189 and 190 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the
1915 Act) will apply to the transfer of shares.
10. Art. 10. Redemption of shares.
10.1 The Company shall have the power to acquire shares of its own share capital, provided that the Company has
sufficient distributable reserves and funds to that effect.
10.2 The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue
of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the
shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association of the Com-
pany shall apply in accordance with article 15 of these articles of association.
11. Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of
civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.
12. Art. 12. Management.
12.1 The Company is managed by at least three managers forming a board of managers. Each manager shall be assigned
either an A or a B signatory power. The managers need not to be shareholders. The managers are appointed, revoked and
replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the
share capital.
12.2 The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace any of
the managers.
12.3 In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name and on behalf of the Company
in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects provided
that the terms of this article 12 have been complied with.
12.4 All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the board of managers.
12.5 The Company shall be bound by the joint signatures of any manager with an A signatory power and any manager
with a B signatory power.
12.6 Any manager with an A signatory power and any manager with a B signatory power, jointly, may sub-delegate
their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The delegating managers will determine this agent's res-
ponsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his
agency.
12.7 The resolutions of the board of managers shall be adopted by (i) the majority of the managers present or represented
and (ii) the positive vote of any manager with an A signatory power and any manager with a B signatory power. The board
of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers and provided that any manager with an A signatory power and any manager with a B signatory
power are present or represented at such meeting.
12.8 A chairman pro tempore may be appointed by the board of managers for each meeting of the board of managers.
The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed.
The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers
present or represented at the board meeting.
12.9 In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all
managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for
such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager
with an A signatory power and any manager with a B signatory power jointly. This notice may be waived if all the managers
are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice
shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of managers.
12.10 A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail
(e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to
be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other
similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the
meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will
be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or
by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes
of the relevant meeting.
12.11 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case
the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager.
The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by
way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
5944
L
U X E M B O U R G
13. Art. 13. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company.
14. Art. 14. General meetings of the shareholder(s).
14.1 An annual general meeting of the shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such
other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.
14.2 Other general meetings of the shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
14.3 As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
15. Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and majority.
15.1 The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.
15.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions regardless of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital of the Company.
15.3 However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company
can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the 1915 Act.
16. Art. 16. Financial year. The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year,
except the first financial year that will begin today and will end on 31 December 2016.
17. Art. 17. Financial statements.
17.1 Each year as at the end of the financial year, the Company's balance sheet and the profit and loss statement are
established under the responsibility of the board of managers.
17.2 Each shareholder may inspect the balance sheet and the profit and loss statement at the Company's registered office.
18. Art. 18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%)
of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the
Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) on a pro rata basis
in proportion to his (their) shareholding in the Company. The board of managers may decide to pay interim dividends.
19. Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders(s) or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine his (their) powers and remuneration.
20. Art. 20. Auditor. In accordance with article 200 of the 1915 Act, the Company needs only to be audited by a statutory
auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption
provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the
accounting and financial accounts of companies does not apply.
21. Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the 1915 Act for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been established, all shares have been subscribed as follows:
Jérôme Callut, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . six thousand two hundred fifty (6,250) shares
Anthony Dearden, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . six thousand two hundred fifty (6,250) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500 shares
All these shares have been fully paid-up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred
euro (EUR 12,500) is from now on at the free disposal of the Company, proof of which has been duly given to the officiating
notary.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it will end on 31 December 2016.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,200.-
5945
L
U X E M B O U R G
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has
herewith adopted the following resolutions:
1. the number of managers of the Company is set at three (3);
2. the meeting appoints as members of the board of managers of the Company for an unlimited period of time and with
the following signature power:
- Mr Jérôme Callut, born on 7 March 1980 in Uccle, Brussels, Belgium, whose private address is at 34, avenue de la
Croix de Bourgogne, B-1410 Waterloo, Belgium, having an A signatory power;
- Mr Stéphane Bonneau-Popot, born on 24 July 1980 in Bourges, France, whose professional address is at 34, rue de
Cléry, 75002 Paris, France, having a B signatory power;
- Mr Jean de Courrèges d'Ustou, born on 16 December 1952 in Toulouse, France, whose professional address is at 2,
rue Jean L'Aveugle, L-1148 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a B signatory power;
3. the meeting give power to Mr Jérôme Callut to open a bank account for the account of the Company;
4. the registered office of the Company is established at 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above, in witness whereof We, the
undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil quinze, le dix-huit décembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
(1) Jérôme Callut, né le 7 mars 1980 à Uccle, Belgique, demeurant à 34, avenue de la Croix de Bourgogne, B-1410
Waterloo, Belgique, ici représenté par Allen & Overy, société en commandite simple, enregistrée sur la liste V du barreau
luxembourgeois, en vertu d'une procuration donnée sous seing-privé, elle-même représentée par Mathieu Voos, résidant
professionnellement à 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
(2) Anthony Dearden, né le 9 octobre 1979 à Birkenhead, Royaume-Uni, demeurant à 28a, Rue de Saint-Jean, Genève,
Suisse, ici représenté par Allen & Overy, société en commandite simple, enregistrée sur la liste V du barreau luxembour-
geois, en vertu d'une procuration donnée sous seing-privé, elle-même représentée par Mathieu Voos, résidant profession-
nellement à 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter de la façon
suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
1. Art. 1
er
. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée du nom de «DCM Systematic GP, S.à r.l.». (la Société).
2. Art. 2. Objet social.
2.1 La Société gérera et agira comme associé gérant commandité de, et prendre des actions d'associé gérant commandité
dans, DCM Systematic Fund SICAV-SIF, une société en commandite par action organisée en fonds d'investissement
spécialisé soumis à la loi luxembourgeois du 13 février 2007 relative au fonds d'investissement spécialisé, telle que modifiée
(la Loi de 2007).
2.2 La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l'accomplissement et le développement de son objet social.
3. Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4. Art. 4. Siège social
4.1 Le Siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale
extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du conseil de gérance de la
Société.
4.3 La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'à
l'étranger.
5946
L
U X E M B O U R G
5. Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500)
représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.
6. Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de
l'associé unique sinon de l'assemblée des associés de la Société, conformément à l'article 15 des présents statuts (les Statuts).
7. Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des
parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.
8. Art. 8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un
seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès
de la Société par une seule et même personne.
9. Art. 9. Transfert de parts sociales.
9.1 Lorsque la Société a un associé unique, toutes les cessions des parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
9.2 En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise
pour une cession de parts sociales entre associés.
9.3 La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux associés survivants.
9.4 Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée
(la Loi de 1915), doivent être respectées en ce qui concerne le transfert de parts sociales.
10. Art. 10. Rachat de parts sociales.
10.1 La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distri-
buables ou des fonds suffisants.
10.2 L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne
pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée
générale de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts
en vertu de l'article 15 des présents Statuts sont d'application.
11. Art. 11. Décès, Interdiction, Faillite ou déconfiture des associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture
de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.
12. Art. 12. Gérance.
12.1 La Société est gérée par au moins trois gérants formant un conseil de gérance. Chaque gérant se verra attribué soit
un pouvoir de signature A, soit un pouvoir de signature B. Les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Les gérants sont
désignés, révoqués et remplacés par une résolution de l'assemblée générale des associés adoptée par des associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
12.2 L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer
n'importe lequel des gérants.
12.3 Vis-à-vis des tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société
en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve
du respect des dispositions du présent article 12.
12.4 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du conseil de gérance.
12.5 La Société sera engagée par la signature conjointe de n'importe quel gérant ayant un pouvoir de signature A et un
gérant ayant un pouvoir de signature B.
12.6 Tout gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement, pourront
déléguer leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Les gérants qui délèguent
détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de
représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
12.7 Les décisions du conseil de gérance seront prises (i) à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et
(ii) le vote positif d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B. Le conseil de
gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres et au moins un gérant avec
pouvoir de signature A et un gérant avec pouvoir de signature B sont présent ou représentés lors de la réunion du conseil
de gérance.
12.8 Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion
du conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance
pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des
gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.
12.9 En cas de pluralité de gérant, un avis écris de toute assemblée du conseil de gérance sera donné à tous les gérant,
par écrit ou par téléfax ou par courriel, au moins 24 heures avant l'heure déterminée d'une telle assemblée, sauf en cas
5947
L
U X E M B O U R G
d'urgence. Une assemblée du conseil de gérant peut être convoquée par n'importe quel gérant ayant un pouvoir de signature
A et n'importe quel gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement. Cette notice peut être levée si tous les gérants
sont présents ou représentés, et s'ils déclarent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée. Une notice séparée
ne sera pas requise pour des assemblées individuelles tenues à des heures et des lieux décrites dans des ordres du jour
adoptés précédemment par une résolution du conseil de gérance.
12.10 Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant
comme son mandataire. Tout gérant peut également participer à une réunion du conseil de gérance par conférence télé-
phonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui
prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance
par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait
référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été
tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance,
si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.
12.11 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie
circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil
de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du
conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue au Grand-Duché de Luxembourg.
13. Art. 13. Responsabilité des gérants.
13.1 Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société.
14. Art. 14. Assemblées générale des associés.
14.1 Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à
tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.
14.2 D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués
dans la convocation.
14.3 Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés
pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse,
un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera
par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).
15. Art. 15. Droits de vote des associés, Quorum et majorité.
15.1 L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
15.2 En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre
de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
15.3 Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité
en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être
changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
16. Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année, excepté la première année sociale qui commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2016.
17. Art. 17. Comptes annuels.
17.1 Chaque année à la fin de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance dresse un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
17.2 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
18. Art. 18. Distribution des bénéfices, Réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels,
déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital
social. L'assemblée générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le conseil de gérance pourra
décider de verser un dividende intérimaire.
19. Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
20. Art. 20. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la
Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur
d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.
5948
L
U X E M B O U R G
21. Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en
réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915
<i>Souscription et libérationi>
les Statuts ayant donc été établis, toutes les parts ont été souscrites comme suite:
Jérôme Callut, susmentionné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250 parts sociales
Anthony Dearden, susmentionné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 parts sociales
Toutes les parts ont été entièrement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2016.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1,200.-
<i>Assemblée générale constitutivei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés préqualifiés représentant la totalité du capital souscrit
ont pris les résolutions suivantes:
1. les membres du conseil de gérance sont au nombre de trois (3);
2. les personnes suivantes sont nommées, pour une durée indéterminée, gérant de la Société avec les pouvoirs de signature
suivants:
- Mr Jérôme Callut, né le 7 mars 1980 à Uccle, Bruxelles, Belgique, dont l'adresse est au 34, avenue de la Croix de
Bourgogne, B-1410 Waterloo, Belgique, ayant un pouvoir de signature A;
- Mr Stéphane Bonneau-Popot, né le 24 juillet 1980 à Bourges, France, dont l'adresse est au 34, rue de Cléry, 75002
Paris, France, ayant un pouvoir de signature B;
- Mr Jean de Courrèges d'Ustou, né le 16 décembre 1952 à Toulouse, France, dont l'adresse professionnelle est au 2,
rue Jean L'Aveugle, L-1148 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, ayant un pouvoir de signature B;
- L'Assemblée donné pouvoir à Monsieur Callut d'ouvrir un compte en banque pour le compte de la Société;
3. le siège social de la société est établi à 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: M. VOOS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 22 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41180. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 29 décembre 2015.
Référence de publication: 2015212249/372.
(150238686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
North Low S .à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 188.669.
Les comptes annuels au 30 avril 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015190421/9.
(150212745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
5949
L
U X E M B O U R G
J.C.A. Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 120, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 74.527.
Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24/11/2015.
Référence de publication: 2015190293/10.
(150212578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Jabiro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 55.598.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015190296/10.
(150212826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Jabiro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 55.598.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015190297/10.
(150212827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Julima S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4440 Soleuvre, 125A, rue d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 175.019.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Soleuvre, le 24 novembre 2015.
Référence de publication: 2015190305/11.
(150212576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Mstab Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: SEK 140.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 190.180.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2015190417/13.
(150213109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
5950
L
U X E M B O U R G
Mapau Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5652 Mondorf-les-Bains, 1, Domaine Malpartes.
R.C.S. Luxembourg B 164.299.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2015190370/12.
(150212529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Mohawk Foreign Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 173.946.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015190381/12.
(150213125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Magella S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1322 Luxembourg, 1, rue des Cerisiers.
R.C.S. Luxembourg B 169.989.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MAGELLA S.à r.l.
i>Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2015190385/12.
(150212479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
MaxxCap S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3698 Foetz, 166, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 147.227.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015190373/9.
(150212542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Margaux Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2157 Luxembourg, 7, rue Mil Neuf Cents.
R.C.S. Luxembourg B 139.181.
Les comptes annuels au 30.09.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015190387/9.
(150212982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
5951
L
U X E M B O U R G
Michaël Schulzen et Christian Meyer S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 67, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 102.311.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le mardi 24 novembre 2015.
Fiduciaire SMGR Steuerberatungs-und Treuhandgesellschaft P.G.m.b.H.
Signature
Référence de publication: 2015190379/12.
(150213068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Magellan Equity Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 44.383.535,66.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 164.076.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Référence de publication: 2015190367/10.
(150212499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Mandrinvest Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 172.480.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015190368/10.
(150213011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Matières Grises SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8550 Noerdange, 16A, Arelerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 89.619.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015190391/10.
(150212435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
PTF Acquisition Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 167.469.
Le Bilan au 30.06.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015190487/10.
(150212550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
5952
Bordeso Holding S.A.
DCM Systematic GP, S.à r.l.
EHT
Elika Investments S.à r.l.
Famhold S.A.
G.A. - Fund -L
Generali Investments SICAV
Generali Multinational Pension Solutions SICAV
Generali Multi Portfolio Solutions SICAV
International Real Estate Management S.A.
Jabiro S.à r.l.
Jabiro S.à r.l.
J.C.A. Finance S.A.
Julima S.à r.l.
La Française IC Fund, SICAV-FIS
Log S.A.
Luxicav
Luxicav Plus
Magellan Equity Investments S.à r.l.
Magella S.à r.l.
Mandrinvest Finance S.A.
Mapau Consult S.à r.l.
Margaux Immobilière S.à r.l.
Martin Currie Global Funds
Matières Grises SA
MaxxCap S.à r.l.
MDO Management Company
Michaël Schulzen et Christian Meyer S.à.r.l.
Mohawk Financing International S.à.r.l.
Mohawk Foreign Funding S.à r.l.
Mohawk International Financing S.à r.l.
Mstab Lux S.à r.l.
North Low S .à r.l.
PTF Acquisition Finance S.à r.l.
RBS Market Access
Riskelia Fund
Save Time Services s.à r.l.
Structured Invest S.A.
Symphonia Lux Sicav
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vison
Walser Portfolio
WALSER Vermögensverwaltung
WB Holding
Yellow Funds Sicav