This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 100
13 janvier 2016
SOMMAIRE
AAAA (Agence Andersen & Associés) S.A. . .
4760
ALUBRA S.à r.l. Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4759
A & M Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4758
Antilope S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4760
Avion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4759
Cabalon Investments Holding S.A. . . . . . . . . .
4758
Centre de Formation National (CFN) S.A. . . .
4757
Climalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4757
Dasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4757
DLX Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4759
Duralex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4759
European Education Holdings S.à.r.l. . . . . . . .
4798
INSIDE group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4760
Jardin Du Luxembourg GmbH . . . . . . . . . . . .
4755
Kebec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4755
KML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4759
Kollector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4754
LA Coussinerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4756
La Piada 5 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4754
La Piada 5 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4754
LBREP I Fides S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4756
LBREP III CH S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4760
LCE Allemagne 9 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4754
Lean4Health S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4754
Luxembourg Hospitality . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4755
Luxembourg Space Telecommunication S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4756
LuxStrategy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4756
Mansford France Fund I S. à r.l. . . . . . . . . . . .
4755
Marrow Architecture Group S.A. . . . . . . . . . .
4760
Mogo Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4754
PineBridge New Europe III GP S.à r.l. . . . . . .
4761
PQ Energy Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
4775
Presidential Nursing Homes Holding III S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4770
RTCTM S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4798
Springlux Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4781
Starpoint Investments (Lux) BRL S.à r.l. . . . .
4787
Swiss Life Hotel Management S.à r.l. . . . . . . .
4789
Van Gelder International Button Agencies Sàrl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4757
Vectea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4758
VEM Financière Holdings S.A. . . . . . . . . . . . .
4758
Victor Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4755
Vodafone Procurement Company S.à r.l. . . . .
4758
WMP I Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4757
WS&S Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4756
4753
L
U X E M B O U R G
Mogo Finance, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.457.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184019/9.
(150205562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
LCE Allemagne 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 191.609.
Les comptes annuels au 31/03/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015183967/9.
(150205238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
La Piada 5 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3364 Leudelange, 5, rue du Château d'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 180.671.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015183960/9.
(150205488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
La Piada 5 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3364 Leudelange, 5, rue du Château d'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 180.671.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015183959/9.
(150205442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Kollector, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8440 Steinfort, 71, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 104.898.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015183936/9.
(150204955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Lean4Health S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.
R.C.S. Luxembourg B 103.761.
Les comptes annuels au 31. Dezember 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015183939/9.
(150204979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
4754
L
U X E M B O U R G
Luxembourg Hospitality, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 135.375.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015183947/9.
(150205394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Jardin Du Luxembourg GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 173.878.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015183917/9.
(150204765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Kebec S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 145.156.
Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015183929/9.
(150205097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Mansford France Fund I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 108.982.
Les comptes annuels au 31/03/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184036/9.
(150205239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Victor Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 122.742.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 Octobre 2015i>
L'Assemblée Générale accepte, avec effet immédiat, la démission d'un administrateur, à savoir:
- Monsieur Rob SONNENSCHEIN, administrateur, né le 30 août 1955 à Eindhoven (Pays-Bas), domicilié profession-
nellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.
L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, de nommer un administrateur, à savoir:
- Madame Emilie GALLAIS, administrateur, né le 3 Mai 1978 à Coutances (France), domicilié professionnellement au
50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.
Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
La société Zimmer & Partners S.A. est domiciliée professionnellement au 50 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015182730/18.
(150203377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
4755
L
U X E M B O U R G
Luxembourg Space Telecommunication S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 185.602.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Référence de publication: 2015183953/10.
(150205396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
LuxStrategy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1259 Senningerberg, 13-15, Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 155.263.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015183955/10.
(150205508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
LA Coussinerie, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 2, avenue Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 16.627.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
12, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg
Référence de publication: 2015183956/10.
(150204928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
LBREP I Fides S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 122.497.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 novembre 2015.
Référence de publication: 2015183965/10.
(150204833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
WS&S Lux S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 129.403.
Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, telle que modifiée, l'étude
Chevalier & Sciales (le «Domiciliataire») dénonce, avec effet au 30 octobre 2015, le contrat de domiciliation conclu le 2
février 2009 entre le Domiciliataire et la société WS&S LUX S.A. ayant le numéro B 129403 (la «Société»).
Par conséquent, le Domiciliataire dénonce avec effet au 30 octobre 2015 le siège de la Société sis 51, Route de Thionville,
L-2611 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Chevalier & Sciales
Référence de publication: 2015182744/14.
(150203023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
4756
L
U X E M B O U R G
Centre de Formation National (CFN) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3932 Mondercange, rue de Limpach.
R.C.S. Luxembourg B 67.624.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015184537/10.
(150206036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Climalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 17.165.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2015184550/10.
(150205708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Dasco, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 63, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 41.131.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DASCO SARL
Référence de publication: 2015184585/10.
(150206455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Van Gelder International Button Agencies Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1209 Senningerberg, 17, Domaine des Bleuets.
R.C.S. Luxembourg B 81.292.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Référence de publication: 2015185050/10.
(150205922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
WMP I Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 174.466.
<i>Auszug aus dem Beschluss des Verwaltungsratesi>
Der Verwaltungsrat nimmt zur Kenntnis, dass Herr Claus Bering, berufsansässig in L-5884 Hesperange, Route de
Thionville, zum Ablauf des Monats Oktober 2015 seinen Rücktritt aus dem Verwaltugnsrat der Gesellschaft erklärt hat.
Der Verwatlungsrat beschließt, mit der Genehmigung der CSSF vom 14. Oktober 2015, Herrn Prof. Dr. Hans-Jörg Henri
von Mettenheim, berufsansässig in Saldernstraße 8, D-30559 Hannover, in den Verwaltungsrat der Gesellschaft als Mitglied
des Verwaltungsrates zu kooptieren und dies mit Wirkung ab dem 1. November 2015 und bis zum Ablauf der ordentlichen
Generalversammlung des Jahres 2016.
Référence de publication: 2015182742/14.
(150203055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
4757
L
U X E M B O U R G
Vodafone Procurement Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 97.920.
En date du 29 Octobre 2015, le Conseil de Gérance de Vodafone Procurement Company S.à r.l. a décidé:
- de nommer Madame Sonia Hernandez, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
en tant que déléguée à la gestion journalière de la société avec effet au 29 octobre 2015.
La société ne sera engagée que par la signature de deux gérants dont au moins un délégué à la gestion journalière.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Référence de publication: 2015182727/14.
(150202667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Vectea S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 97.054.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour VECTEA S.A.i>
Référence de publication: 2015185052/10.
(150205997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Cabalon Investments Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 109.396.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015184526/10.
(150206372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
VEM Financière Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 167.595.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Référence de publication: 2015185054/10.
(150205652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
A & M Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 150.366.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015185111/10.
(150206579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
4758
L
U X E M B O U R G
Duralex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 108.337.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
DURALEX S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015185280/13.
(150206543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
DLX Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 157.795.
Les comptes consolidés de la société mère DONALDSON COMPANY, INC. pour la période se terminant au 31 juillet
2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Référence de publication: 2015185272/11.
(150206918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
ALUBRA S.à r.l. Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 1, Kiricheneck.
R.C.S. Luxembourg B 139.311.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 13 novembre 2015.
Référence de publication: 2015184436/10.
(150205900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Avion S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 14.246.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Référence de publication: 2015184454/10.
(150205669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
KML, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 173.085.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Référence de publication: 2015183935/10.
(150204869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
4759
L
U X E M B O U R G
INSIDE group, Société Anonyme.
Siège social: L-4410 Soleuvre, 2, Zone Um Woeller.
R.C.S. Luxembourg B 28.822.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015183909/10.
(150205560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
LBREP III CH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 138.823.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 novembre 2015.
Référence de publication: 2015183966/10.
(150204593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Marrow Architecture Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7650 Heffingen, 14, Beezebierg.
R.C.S. Luxembourg B 89.835.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015184016/10.
(150205089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Antilope S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 54.848.
AUSZUG
Es geht aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Oktober 2015 hervor dass:
Die Gesellschaft DADE FINANCE S.A. als Verwaltungsratsmitglied austritt.
Herr Alexander DREU, geboren am 03.06.1965 in Maribor (Slowenien), wohnhaft in 18, avenue Grand-Duc Jean,
L-1842 Howald wird als Alleinverwalter ernannt.
Sein Mandat endet während der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2020.
Für gleichlautenden Auszug
Référence de publication: 2015181944/14.
(150203093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
AAAA (Agence Andersen & Associés) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1424 Luxembourg, 16, rue André Duchscher.
R.C.S. Luxembourg B 174.878.
Par la présente, je vous notifie que je souhaite démissionner de mes postes d'administrateur et d'administrateur déléguée
à la gestion journalière que j'occupe au sein de l'entreprise AAAA (Agence Andersen & Associés) S.A.
Luxembourg, le 13 Juillet 2015.
Grosse Marie-Françoise.
Référence de publication: 2015181903/10.
(150203188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
4760
L
U X E M B O U R G
PineBridge New Europe III GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 201.272.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the ninth day of October.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
PineBridge Investments LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Delaware, regis-
tered in the State of Delaware having its registered office at 399 Park Avenue, 4
th
Floor, New York, NY 10022. USA,
here represented by Mrs Anissa Kabbage, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company
(société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
PineBridge New Europe III GP S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may also act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations
of any Luxembourg or foreign entity.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) divided into one hundred
shares (100) with a nominal value of one hundred and twenty five euros (EUR 125) each.
4761
L
U X E M B O U R G
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by the
surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, des-
cendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second
time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are
validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share
capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
4762
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote.
17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
4763
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the single signature of any manager, or (ii) by
the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the
board of managers within the limits of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
4764
L
U X E M B O U R G
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2015.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The one hundred (100) shares issued have been subscribed by PineBridge Investments LLC, aforementioned, for the
price of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500).
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred euros (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Resolutions of the shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy
of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
(ii) George Hornig, born in New York, USA on 03 June 1954, professionally residing at 399 Park Avenue, NY10022,
New York, USA;
(iii) David Giroux, born in New York, USA on 03 October 1960, professionally residing at 399 Park Avenue, NY10022,
New York, USA;
(iv) Alain Guérard, born in Sainte-Adresse, France on 19 January 1968, professionally residing at 24 rue Beaumont, L-
1219 Luxembourg; and
(v) Anders Faergemann, born in Roskilde, Denmark on 30 November 1970, professionally residing at 33 St. Mary Axe,
London, EC3A 8AA, United Kingdom.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède.
L’an deux mille quinze, le neuf octobre.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
PineBridge Investments LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) constituée et existant selon
les lois du Delaware, immatriculée auprès de l’Etat du Delaware, ayant son siège social à 399 Park Avenue, 4
ème
étage,
New York, NY 10022., Etats-Unis d’Amérique,
dûment représentée par Madame Anissa Kabbage, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte de constitution d’une société à responsabilité limitée
qu'elle souhaite constituer avec les statuts suivants:
4765
L
U X E M B O U R G
A. Nom - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «PineBridge New Europe
III GP S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l’admi-
nistration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3 Excepté par voie d’appel publique à l’épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute
forme ou en émettant toute sorte d’obligations, de titres ou d’instruments de dettes, d’obligations garanties ou non garanties,
et d’une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4 La Société a également la possibilité d’agir en tant qu'associé ou actionnaire à responsabilité illimitée ou limitée
pour les dettes et les obligations de n’importe quelle entité luxembourgeoise ou étrangère.
2.5 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu'elle estime utile pour l’accomplissement de ces objets.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l’assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
4.4 Dans l’hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, écono-
mique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité
normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation
complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de
la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cent (100) parts
sociales ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.
5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l’insolvabilité ou tout autre
événement similaire d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la Société.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour
consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d’inscription peuvent être émis
sur demande et aux frais de l’associé demandeur.
4766
L
U X E M B O U R G
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à
cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession
ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.
7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l’acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.
7.6 En cas de décès, les parts sociales de l’associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous
réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants représentant les trois quarts des droits des survivants.
Un tel agrément n’est cependant pas requis dans l’hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants,
descendants ou au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l’associé décédé.
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les
présents statuts.
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il
détient.
8.3 Dans l’hypothèse où et tant que la Société n’a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d’ordinaire de la compétence de l’assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.
8.4 En cas d’associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés en vertu des
dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l’assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l’associé unique selon le contexte et le cas échéant et
les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés seront exercés par l’associé unique.
Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l’hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une
assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l’exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée
générale. D’autres assemblées générales d’associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations
aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale des
associés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication pré-
alable.
Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d’un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés
de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital social. Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés peuvent
être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec le même ordre du jour et les décisions sont
valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement
unanime des associés.
Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l’accord d’une (i) majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social.
D. Gérance
Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un
conseil de gérance.
13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n’est pas
expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme
une référence au «gérant unique».
13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute
mesure nécessaire ou utile pour l’accomplissement de l’objet social de la Société, à l’exception des pouvoirs réservés par
la Loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale des associés.
4767
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l’assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et
la durée de son (leur) mandat.
14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par
une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Art. 15. Vacance d’un poste de gérant.
15.1 Dans l’hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l’incapacité juridique, la faillite, la
démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne pouvant
excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des associés
appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.
15.2 Dans l’hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est
comblée sans délai par l’assemblée générale des associés.
Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au
siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.
16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures
à l’avance par rapport à l’heure fixée dans la convocation, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs d’une
telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d’accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d’un tel document signé
constituera une preuve suffisante d’un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance
dont le lieu et l’heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d’un précédent conseil de gérance, communiquée
à tous les membres du conseil de gérance.
16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l’hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés
à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l’hypothèse de décisions écrites et approu-
vées par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner
un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance.
17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,
le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.
17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme
son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du
mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l’intégralité des membres
du conseil de gérance.
17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans
discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s’être tenue
au siège social de la Société.
17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance.
17.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de
gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d’une voix prépondérante.
17.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l’ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions
sera la date de la dernière signature.
Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou,
en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits
de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par
deux (2) gérants.
18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés
par le gérant unique.
4768
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par
la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la seule signature d’un gérant, ou (ii) par la signature
conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué
par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.
E. Audit et surveillance
Art. 20. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
20.1 Dans l’hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront
surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la
durée de leurs fonctions.
20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.
20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.
20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 21. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente et un décembre de la même année.
Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif
et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.
22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l’affectation du solde des
bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
22.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la
Société.
Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d’un état comptable
intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées
à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.
23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-
formément à la Loi et aux présents statuts.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l’article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera
les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l’actif et du passif de la Société.
24.2 Le surplus résultant de la réalisation de l’actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre
de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2015.
4769
L
U X E M B O U R G
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et paiementi>
Les cent (100) parts sociales émises ont été souscrites par PineBridge Investments LLC, susmentionnée, pour un prix
de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d’apport en numéraire, de sorte que le
montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.
L’apport global d’un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est entièrement affecté au capital social.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ EUR 1.500,-.
<i>Résolutions de l’associéi>
L’associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convo-
cation, a adopté les résolutions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie à 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange , Grand-Duché de Lu-
xembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:
(i) George Hornig, né à New York, Etats-Unis d’Amérique le 03 juin 1954, résidant professionnellement à 399 Park
Avenue, NY10022, New York, Etats-Unis d’Amérique; et
(ii) David Giroux, né à New York, Etats-Unis d’Amérique le 03 octobre 1960, résidant professionnellement à 399 Park
Avenue, NY10022, New York, Etats-Unis d’Amérique; et
(iii) Alain Guérard, né à Sainte-Adresse, France le 19 janvier 1968, résidant professionnellement à 24 rue Beaumont,
L- 1219 Grand-Duché de Luxembourg; et
(iv) Anders Faergemann, né à Roskilde, Danemark le 30 novembre 1970, résidant professionnellement à 33 St. Mary
Axe, London, EC3A 8AA, Royaume-Uni.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande de la comparante que le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande de la même comparante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit
mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. KABBAGE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/32484. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181614/524.
(150202138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Presidential Nursing Homes Holding III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 201.276.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the ninth day of November.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
BERFIELD ASSETS LTD, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered
office at 146, Wickhams Cay 1, BVI, Road Town Tortola, British Virgin Islands and registered with the Register of
Companies of the British Virgin Islands under number 263061
here represented by Mr. Max MAYER, employee, with professional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and delivered to him.
4770
L
U X E M B O U R G
Said proxy after signature “ne varietur” by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée, the Articles of which it has established as
follows:
Title I
er
. - Form - Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée" which will be governed by actual laws, especially the
law of August 10
th
, 1915 on commercial companies such as amended.
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and
carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The object of the Company is also the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether
furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in real estate,
and those concerning the placement and management of money. The Company can also perform in Luxembourg as well
as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which
are directly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and
companies whose object is the performance of any activities in whatsoever form, as well as the management and develop-
ment, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a financial
participations company according to the applicable provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object or which may favor its development or the extension of its operations.
Art. 3. The private limited liable Company is incorporated under the name of "Presidential Nursing Homes Holding III
S.à r.l.".
Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg.
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.
Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by one hundred
(100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid
up.
Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of
shares in existence.
Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance
or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.
If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are transferable
to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated August 10
th
, 1915 on
commercial companies, the value of a share is based on average balance sheet of the last three financial years and, in case
the Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last financial year
or of those of the last two financial years.
Title III. - Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the sole
member or, as the case may be, the members.
The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to
third parties.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either members
or not.
Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
Title IV. - Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the foresaid law
of August 10
th
, 1915.
4771
L
U X E M B O U R G
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the
meeting.
Title V. - Financial year - Balance sheet - Distributions
Art. 10. The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December.
Art. 11. Each year, on the thirty-first day of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of
the Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve
until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever
the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual contribution shall be resumed until
such one tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the
sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant
laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Title VI. - Dissolution
Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure
of a member.
In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in office
or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator
or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to
the members proportionally to the shares they hold.
Title VII.- General provisions
Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law of
August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and paymenti>
All the shares have been entirely subscribed by the private liable company BERFIELD ASSETS LTD, prenamed. They
have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)
is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness
to it.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on December 31
st
, 2015.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,500.- EUR.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed capital,
acting as foresaid, has passed the following resolutions:
1) The following is appointed manager of the Company for an unlimited period:
Mrs Claudia Daxelhoffer, manager, born on July 19, 1955 in Oberrieden ZH, Swiss and with professional address at
Gessnerallee 28, CH-8023 Zürich, who can bind the company towards third parties by her sole signature.
2) The Company shall have its registered office at L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German translation. Upon request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.
4772
L
U X E M B O U R G
Deutsche Übersetzung des Vorhergehenden Textes
Im Jahr zweitausendfünfzehn, den neunten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit Amtswohnsitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
BERFIELD ASSETS LTD, Gesellschaft, mit Sitz in 146, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola British Virgin Islands
(British Virgin Islands 263061 Register of companies)
hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Angestellter, geschäftsansässig in Junglinster, 3, route de Luxemburg, auf-
grund einer ihm ausgestellten Vollmacht,
Welche Vollmacht, nach „ne varietur“ Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den instrumentierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
Welche Komparentin, vertreten wie vorgenannt, beschlossen hat eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen
zu wollen gemäss folgender Satzung:
Titel I. - Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das abgeäderte
Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.
Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art, in
Luxemburg oder im Ausland, sowie dem Besitz, der Verwaltung, Entwicklung und Leitung ihres Portfolios. Die Gesell-
schaft kann Pfandbriefe, Obligationen, Schuldverschreibungen, Wertpapiere und Anleihen durch Zeichnung, Ankauf oder
in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Tausch oder in sonstiger Weise veräußern. Die Gesellschaft kann
zudem Anteile an Gesellschaften halten und ihre Geschäfte über Niederlassungen in Luxemburg oder im Ausland tätigen.
Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Erschließung, der Verkauf und die Vermietung
von jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen, die Immobilien betreffen,
mit Ausnahme derjenigen, die einem Immobilienhändler vorbehalten sind und die Platzierung von Geld und die Vermö-
gensverwaltung betreffen. Die Gesellschaft kann zudem, in welcher Form auch immer, sowohl in Luxemburg als auch im
Ausland, sämtliche Industrie-, Handels-, Finanz-, Immobiliar- oder Mobiliargeschäfte tätigen, die, ganz gleich auf welche
Art, direkt oder indirekt mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung von Unternehmen und Gesellschaften in Ver-
bindung stehen, deren Zweck Aktivitäten jedweder Art als auch die dauerhafte oder zeitweilige Verwaltung und Entwick-
lung des eigens zu diesem Zweck geschaffenen Portfolios sein können. Die Gesellschaft wird gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen als Société de Participations Financières (Finanzbeteiligungsgesellschaft) gegründet.
Die Gesellschaft kann sich durch beliebige Mittel an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften beteiligen,
die einen identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck haben oder ihren Gesellschaftszweck fördern oder ihm nützlich
sind.
Art. 3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung besteht unter dem Namen "Presidential Nursing Homes Holding III
S.à r.l.".
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Art. 5. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.
Titel II. - Kapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhun-
dert (100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,-EUR), alle gezeichnet und vollends
eingezahlt.
Art. 7. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von
Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich. Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der
Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten,
übertragen werden.
Im Falle einer Übertragung im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften, wird der Wert eines Anteils auf der Basis der Durchschnittsbilanz der letzten drei Ge-
schäftsjahre berechnet und, falls die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre zählt, wird er auf der Basis der Bilanz des
letzten oder der beiden letzten Geschäftsjahre berechnet.
4773
L
U X E M B O U R G
Titel III. - Geschäftsführung
Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,
verwaltet. Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt und haben die ausgedehntesten Vollmachten gegenüber
Drittpersonen.
Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Bevollmäch-
tigte, die nicht Gesellschafter sein müssen, erteilt werden.
Gegenüber Drittpersonen wird die Gesellschaft in jedem Fall durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers
rechtskräftig verpflichtet.
Titel IV. - Entscheidungen des Einzigen Gesellschafters - Gemeinsame Entscheidungen Mehrerer Gesellschafter
Art. 9. Der einzige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche durch das vorbenannte Gesetz vom 10. August 1915,
der Versammlung der Gesellschafter vorbehalten sind.
Demzufolge werden alle Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer überschreiten, vom
einzigen Gesellschafter getroffen.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, werden die Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer
überschreiten, durch die Gesellschafterversammlung getroffen.
Titel V. - Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.
Art. 11. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per einunddreißigsten Dezember, wird durch die Geschäftsführung ein
Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlust-
rechnung aufgestellt.
Der Saldo dieses Kontos, nach Abzug der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist der
Nettogewinn der Gesellschaft.
Von diesem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Reserve der Gesellschaft
zugeführt, solange bis die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem gegebenen Augenblick
und aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Reserve unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals fallen, so muss die jähr-
liche Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden bis das ein Zehntel Verhältnis wieder hergestellt ist.
Der Restbetrag wird dem einzigen Gesellschafter zugeteilt oder, je nachdem, unter den Gesellschaftern verteilt, wobei
dieser oder diese, handelnd laut den gesetzlichen Bestimmungen, entscheiden kann oder können, dass der Restbetrag, nach
Abzug jeglicher Reserven, auf das folgende Jahr übertragen oder auf einer außergesetzlichen Reserve zugeführt wird.
Titel VI. - Auflösung
Art. 12. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die notorische Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche
Entmündigung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im
Amt oder von einem oder mehreren Liquidatoren, vom einzigen Gesellschafter oder von der Generalversammlung der
Gesellschafter ernannt, ausgeführt. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung
der Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.
Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, dem einzigen Gesellschafter zugeteilt, oder, je nachdem,
unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile aufgeteilt.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 13. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden
ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle Anteile wurden gezeichnet durch die Gesellschaft BERFIELD ASSETS LTD, vorgenannt, und vollständig in bar
eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-EUR) zur Verfügung
steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.500,- EUR.
4774
L
U X E M B O U R G
<i>Beschlüssei>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter welcher das Gesamtkapital vertritt, folgende
Beschlüsse gefasst:
1) Es wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:
Frau Claudia Daxelhoffer, Manager, geboren am 19. Juli 1955 in Oberrieden ZH, Schweiz und geschäftsansässig Ge-
ssnerallee 28, CH-8023 Zürich, welche die Gesellschaft gegenüber dritten durch ihre alleinige Unterschrift rechtskräftig
vertreten kann.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1313 Luxemburg, 2a, rue des Capucins.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass der Text der vorliegenden Sat-
zung auf Wunsch der Erschienenen in englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, dass es der Wunsch der Erschienenen ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text der englische Text Vorrang hat.
Und nach Vorlesung und Erklärung an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 09 novembre 2015. Relation GAC/2015/9542. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015181621/241.
(150202241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
PQ Energy Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 181.232.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of September.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
PQ Energy Luxembourg Holding S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) existing under the
laws of Luxembourg, with registered office at 2-4, Rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies’ Register under number B166.801,
here represented by Solange Wolter, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of PQ Energy Luxembourg S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a société
à responsabilité limitée, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 181232, incorporated
pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 22 October
2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3046 on 2 December 2013. The articles
of association of the Company have not been amended since.
The appearing party representing the entire share capital deliberates on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Creation of two categories of managers who shall be referred to as class A managers and class B managers.
2. Subsequent amendment of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect the creation of
the classes of managers.
3. Amendment of article 9 of the articles of association of the Company in order to reflect the creation of the classes of
managers.
4. Creation of a new article, to be numbered as article 10 of the articles of association of the Company, in relation to the
vacancy in the office of a manager.
5. Amendment of article 11 of the articles of association of the Company, to be renumbered as article 12 of the articles
of association of the Company, in order to reflect the changes of quorum and vote for board meetings.
4775
L
U X E M B O U R G
6. Amendment of article 12 of the articles of association of the Company, to be renumbered as article 13 of the articles
of association of the Company, in order to reflect the changes of powers of signature of minutes of board meetings.
7. Amendment of article 13 of the articles of association of the Company, to be renumbered as article 14 of the articles
of association of the Company, in order to reflect the changes of statutory authorisation to sign for the Company to deal
with third parties.
8. Subsequent renumbering of article 14 up to article 24 of the articles of association of the Company.
9. Appointment of Blackstone Capital Partners Holdings Director L.L.C., Mr. Vijay Bharadia and Ms. Claire Gerault
as class B managers of the Company with immediate effect and for an unlimited period.
10. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the appearing party takes and requires the undersigned notary to enact
the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The sole shareholder resolves to create two categories of managers who shall be referred to as class A managers (the
“Class A Managers”) and class B managers (the “Class B Managers”) so that the Company will be managed by a board of
managers composed of at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.
<i>Second Resolutioni>
Subsequently, the sole shareholder resolves to amend article 8 of the articles of association of the Company which shall
henceforth read as follows:
“ Art. 8. Powers of the sole manager; Composition and powers of the board of managers.
8.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers composed of at least one (1) manager of class A (the “Class A Manager”) and one (1) manager
of class B (the “Class B Manager”). Any reference made hereinafter to the “managers” shall be construed as a reference
to the Class A Managers and/or to the Class B Managers, depending on the context and as applicable. If the Company is
managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not expressly mentioned in these
articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of association is to be construed as a
reference to the “sole manager”.
8.2 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders”.
<i>Third Resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 9 of the articles of association of the Company which shall henceforth
read as follows:
“ Art. 9. Election, removal and term of office of managers.
9.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their class, remune-
ration and term of office.
9.2 The managers are elected and may be removed from office at any time, with or without cause, by a vote of the
shareholders representing more than half of the Company’s share capital”.
<i>Fourth Resolutioni>
The sole shareholder resolves to create a new article, to be numbered as article 10 of the articles of association of the
Company, in relation to the vacancy in the office of a manager and which shall read as follows:
“ Art. 10. Vacancy in the office of a manager.
10.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions
10.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders".
<i>Fifth Resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 11 of the articles of association of the Company, to be renumbered as
article 12 of the articles of association of the Company as a consequence of the above resolution, and which shall henceforth
read as follows:
4776
L
U X E M B O U R G
“ Art. 12. Conduct of meetings of the board of managers.
12.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
12.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
12.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy in
writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more, but not all of his colleagues.
12.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
12.5 The board of managers can deliberate or act validly only if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B
Manager are present or represented at a meeting of the board of managers.
12.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting provided however
that at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager vote in favour of such decision and in case of equality
of votes, no manager, including without limitation the chairman, if any, shall have a casting vote.
12.7 The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. The manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature”.
<i>Sixth Resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 12 of the articles of association of the Company, to be renumbered as
article 13 of the articles of association of the Company as a consequence of the above resolutions, and which shall henceforth
read as follows:
“ Art. 13. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
13.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or, in his absence,
by the chairman pro tempore (if applicable), or by any Class A Manager with any Class B Manager, or by any person
appointed to that effect by the board of managers of the Company. Copies or excerpts of such minutes, which may be
produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or, in his absence, by the chairman
pro tempore (if applicable), or by any Class A Manager with any Class B Manager, or by any person appointed to that
effect by the board of managers of the Company.
13.2 The decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies
or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole
manager”.
<i>Seventh Resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 13 of the articles of association of the Company, to be renumbered as
article 14 of the articles of association of the Company as a consequence of the above resolutions, and which shall henceforth
read as follows:
“ Art. 14. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, (ii) if the Company has several managers, by the joint signature of any Class A Manager
together with any Class B Manager, or (iii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such
signatory power may have been delegated by the board of managers or the Company within the limits of such authorisation”.
<i>Eighth Resolutioni>
The sole shareholder resolves to further renumber the following articles of the Company:
- article 14 into article 15 of the articles of association of the Company;
- article 15 into article 16 of the articles of association of the Company;
- article 16 into article 17 of the articles of association of the Company;
- article 17 into article 18 of the articles of association of the Company;
- article 18 into article 19 of the articles of association of the Company;
- article 19 into article 20 of the articles of association of the Company;
- article 20 into article 21 of the articles of association of the Company;
- article 21 into article 22 of the articles of association of the Company;
- article 22 into article 23 of the articles of association of the Company;
- article 23 into article 24 of the articles of association of the Company; and
4777
L
U X E M B O U R G
- article 24 into article 25 of the articles of association of the Company.
<i>Ninth Resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves that the current sole manager, being Mr. John Sutherland, shall henceforth
be a Class A Manager and further resolves to appoint with immediate effect and for an unlimited period:
- Blackstone Capital Partners Holdings Director L.L.C., a limited liability company existing under the laws of the State
of Delaware, registered with Secretary of State of the State of Delaware under number 5334735, having its registered office
at c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United
States of America, as Class B Manager of the Company;
- Mr. Vijay Bharadia, born in Nairobi, Kenya, on 13 April 1967, professionally residing at 40 Berkeley Square, London
W1J 5AL United Kingdom, as Class B Manager of the Company; and
- Ms. Claire Gérault, born in Saint André-Les-Vergers, France, on 29 May 1981, professionally residing at 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as Class B Manager of the Company.
<i>Tenth Resolutioni>
Following the present meeting, the sole shareholder resolves to confirm the new composition the board of managers of
the Company which will be henceforth composed as follows:
- Mr. John Sutherland, Class A Manager;
- Blackstone Capital Partners Holdings Director L.L.C., Class B Manager;
- Mr. Vijay Bharadia, Class B Manager; and
- Mrs. Claire Gérault, Class B Manager.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundfünfzehn, den dreißigsten September.
Vor uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
PQ Energy Luxembourg Holding S.à r.l., eine Luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à res-
ponsabilité limitée) mit Sitz in 2-4, Rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxemburg, eingetragen Im Luxemburgischem Handels-
und Gesellschaftsregister unter Nummer B166.801,
vertreten durch Frau Solange Wolter, geschäftsansässig in Luxemburg, kraft einer privatschriftlich erteilten Vollmacht.
Die genannte Vollmacht, ne varietur vom Bevollmächtigen der erschienenen Partei und vom Notar paraphiert, ist der
gegenwärtigen Urkunde beigefügt um gleichzeitig bei den Registerbehörden eingereicht zu werden.
Die erschiene Partei ist der alleinige Gesellschafter von PQ Energy Luxembourg S.à r.l. (nachfolgend die „Gesell-
schaft“), eine Luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 2-4, Rue
Eugène Ruppert, L - 2453 Luxemburg, eingetragen Im Luxemburgischem Handels- und Gesellschaftsregister unter Num-
mer B181.232, gegründet gemäß Urkunde von Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum
Luxemburg, am 22 Oktober 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associatons Nummer 3046
am 2 Dezember 2013. Die Satzung der Gesellschaft wurde seither nicht geändert.
Die erschienene Partei, die das gesamte Kapital der Gesellschaft vertritt, bestimmt über die folgende Tagesordnung:
<i>Agendai>
1. Gründung von zwei Kategorien von Geschäftsführer, die als Klasse A Geschäftsführer und Klasse B Geschäftsführer
bezeichnet werden.
2. Nachträgliche Abänderung von Artikel 8 der Satzung der Gesellschaft um die Gründung der Klassen von Geschäfts-
führer widerzuspiegeln.
3. Abänderung von Artikel 9 der Satzung der Gesellschaft um die Gründung der Klassen von Geschäftsführer wider-
zuspiegeln.
4. Gründung eines neuen Artikels, der als Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft nummeriert wird, in Bezug auf die
Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
5. Abänderung von Artikel 11 der Satzung der Gesellschaft, der als Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft um num-
meriert wird, um die Abänderungen von Quorum und Stimme für Geschäftsführungsrate widerzuspiegeln.
4778
L
U X E M B O U R G
6. Abänderung von Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft, der als Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft um num-
meriert wird, um die Abänderungen der Zeichnungsbefugnisse für Geschäftsführungsrate widerzuspiegeln.
7. Abänderung von Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft, der als Artikel 14 der Satzung der Gesellschaft um num-
meriert wird, um die Abänderungen der gesetzlichen Ermächtigung um für die Gesellschaft zu unterzeichnen und
Geschäften mit Dritten widerzuspiegeln.
8. Nachträgliche Um Nummerierung von Artikel 14 bis 24 der Satzung der Gesellschaft.
9. Bestimmung von Blackstone Capital Partners Holdings Director L.L.C., Herr Vijay Bharadia und Frau Claire Gerault
als Klasse B Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung und für einen unbeschränkten Zeitraum.
10. Sonstiges.
Nach gebührender Prüfung aller Tagesordnungspunkte, beschließt und erfordert die erschiene Partei den amtierenden
Notar folgende Beschlüsse zu erlassen:
<i>Erster Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt zwei Kategorien von Gesellschaftsführer zu gründen, die als Klasse A Ge-
schäftsführer (die „Klasse A Geschäftsführer“) und Klasse B Geschäftsführer (die „Klasse B Geschäftsführer“) bezeichnet
werden, sodass die Gesellschaft von einem Geschäftsführungsrate, bestehend aus mindestens einem (1) Klasse A Ge-
schäftsführer und einem (1) Klasse B Geschäftsführer geleitet wird.
<i>Zweiter Beschlussi>
Folgend, beschließt der Alleinige Gesellschafter Artikel 8 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, der nun wie folgt
lauten soll:
„ Art. 8. Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
8.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, die nicht Gesellschafter sein müssen. Sollte
die Gesellschaft durch mehrere Geschäftsführer geleitet werden, dann bilden diese den Geschäftsführungsrat, bestehend
aus mindestens einem (1) Klasse A Geschäftsführer (die „Klasse A Geschäftsführer“) und einem (1) Klasse B Geschäfts-
führer (die „Klasse B Geschäftsführer“). Jeden nachfolgenden Verweis auf die Geschäftsführer, soll als Hinweis auf die
Klasse A Geschäftsführer und/oder Klasse B Geschäftsführer gelten, je nach Kontext und soweit anwendbar. Sofern die
Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäftsführer" nicht aus-
drücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat" als Verweis auf den
Einzelgeschäftsführer auszulegen.
8.2 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und
alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Handlungen.“
<i>Dritter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt Artikel 9 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, der nun wie folgt lauten soll:
“ Art. 9. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
9.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Klasse, Bezüge
und Amtszeit festlegt.
9.2 Geschäftsführer können jederzeit ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr
als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, abberufen werden.“
<i>Vierter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt einen neuen Artikel zu gründen der als Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft
nummeriert wird, in Bezug auf die Vakanz einer Geschäftsführerstelle und der nun wie folgt lauten soll:
„ Art. 10. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
10.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderem Grund
aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüngliche
Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum, kommissarisch bis zur nächsten Gesellschafterversammlung besetzt werden,
in welcher diese im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entschei-
det.
10.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-
züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.“
<i>Fünfter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt Artikel 11 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, der nun aufgrund des obigen
Beschluss als Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft um nummeriert wird und wie folgt lauten soll:
4779
L
U X E M B O U R G
„ Art. 12. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
12.1 Der Geschäftsführungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden aus. Der Geschäftsführungsrat kann
auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und der für
die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.
12.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats geleitet, sofern
dieser anwesend ist. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat jedoch ein anderes Mitglied des Geschäfts-
führungsrats durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
12.3 Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an jedem Geschäftsführungsrat teilnehmen, indem es ein anderes
Mitglied des Geschäftsführungsrats durch ein unterzeichnetes Dokument, welches per Faxschreiben, E-Mail oder ein an-
deres vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevoll-
mächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere aber nicht
alle Kollegen aus dem Verwaltungsrat vertreten.
12.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-
deres Kommunikationsmittel, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an
der Sitzung teilzunehmen, abgehalten werden. Eine solche Teilnahme ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme
an einer solchen Sitzung und eine derartig abgehaltene Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft abgehalten.
12.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest ein (1) Geschäftsführer
der Klasse A und ein (1) Geschäftsführer der Klasse B in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
12.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst sofern mindestens ein (1) Geschäftsführer der Klasse A und ein
(1) Geschäftsführer der Klasse B für diesen Beschluss stimmen und im Falle einer Stimmengleichheit, kein Geschäftsführer
einschließlich, aber ohne Beschränkung auf den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats hat im Falle von Stimmgleichheit
die entscheidende Stimme.
12.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung per
Faxschreiben, per EMail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines so gefassten Beschlusses.“
<i>Sechster Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, der nun aufgrund der obigen
Beschlüsse als Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft um nummeriert wird und wie folgt lauten soll:
„ Art. 13. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats -Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
13.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates oder,
im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore (gegebenenfalls) unterzeichnet oder von einem Ge-
schäftsführer der Klasse A mit einem Geschäftsführer der Klasse B, oder von jeder anderen, zu diesem Zweck vom
Geschäftsführungsrat benannte Person. Jede Kopie und jeder Auszug solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren
oder auf sonstige Weise vorgezeigt werden müssen, müssen vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates, unterzeichnet
werden oder im Falle von dessen Abwesenheit, vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates pro tempore (gegebenen-
falls), oder von einem Geschäftsführer der Klasse A mit einem Geschäftsführer der Klasse B, oder von jeder anderen, zu
diesem Zweck vom Geschäftsführungsrat benannte Person.
13.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers müssen in ein Protokoll aufgenommen werden, welches von dem
Einzelgeschäftsführer unterzeichnet werden muss. Jede Kopie und jeder Auszug solcher Protokolle, die in einem Ge-
richtsverfahren oder aus sonstigen Gründen benötigt werden, müssen vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet werden.“
<i>Siebter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, der nun aufgrund der obigen
Beschlüsse als Artikel 14 der Satzung der Gesellschaft um nummeriert wird und wie folgt lauten soll:
Art. 14. Geschäfte mit Dritten.
14.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift des Einzelgeschäftsfüh-
rers oder, (ii) für den Fall, dass die Gesellschaft über mehrere Geschäftsführer verfügt, durch die gemeinsame Unterschriften
eines Geschäftsführer der Klasse A mit einem Geschäftsführer der Klasse B,, oder durch (iii) die gemeinsame Unterschrift
oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat
übertragen worden ist, oder die Gesellschaft im Rahmen einer solchen Erlaubnis gebunden.
<i>Achter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt zusätzlich die folgenden Artikel der Satzung umzunummerieren;
- Artikel 14 als Artikel 15 der Satzung der Gesellschaft;
- Artikel 15 als Artikel 16 der Satzung der Gesellschaft;
- Artikel 16 als Artikel 17 der Satzung der Gesellschaft;
4780
L
U X E M B O U R G
- Artikel 17 als Artikel 18 der Satzung der Gesellschaft;
- Artikel 18 als Artikel 19 der Satzung der Gesellschaft;
- Artikel 19 als Artikel 20 der Satzung der Gesellschaft;
- Artikel 20 als Artikel 21 der Satzung der Gesellschaft;
- Artikel 21 als Artikel 22 der Satzung der Gesellschaft;
- Artikel 22 als Artikel 23 der Satzung der Gesellschaft;
- Artikel 23 als Artikel 24 der Satzung der Gesellschaft; und
- Artikel 24 als Artikel 25 der Satzung der Gesellschaft;
<i>Neunter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt mit sofortiger Wirkung und für einen unbeschränkten Zeitraum zu ernennen;
- Blackstone Capital Partners Holdings Director L.L.C., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability
company) gegründet nach dem Recht des States von Delaware, eingetragen mit dem Staatssekretär des States Delaware
unter der Nummer 5334735, mit Sitz in c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle
County, Delaware 19801, Vereinigte Staaten von Amerika, als Klasse B Geschäftsführer der Gesellschaft;
- Herr Vijay Bharadia, geboren in Nairobi, Kenya, am 13 April 1967, beruflich ansässig in 40 Berkeley Square, London
W1J 5AL Vereinigtes Königreich Großbritannien, als der Klasse B Geschäftsführer der Gesellschaft; und
- Frau Claire Gérault, geboren in Saint André-Les-Vergers, Frankreich, am 29 May 1981, beruflich ansässig in 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, als Klasse B Geschäftsführer der Gesellschaft.
<i>Zehnter Beschlussi>
Folglich der vorliegenden Sitzung, hat der Alleinige Gesellschafter beschlossen die neue Zusammensetzung des Ge-
schäftsführungsrats der Gesellschaft zu bestätigen, der fortan wie folgt zusammengesetzt ist;
- Herr John Sutherland, Klasse A Geschäftsführer;
- Blackstone Capital Partners Holdings Director L.L.C., Klasse B Geschäftsführer;
- Herr Vijay Bharadia, Klasse B Geschäftsführer; und
- Frau Claire Gérault, Klasse B Geschäftsführer.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Erschienenen
diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, die dem Notar
mit Name, Vorname und Wohnsitz bekannt ist, hat dieser gemeinsam mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: S. WOLTER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 6 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/31920. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 6. November 2015.
Référence de publication: 2015181647/339.
(150202338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Springlux Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 192.419.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth of October.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. P5 Sub L.P.1, a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995 (as
amended), acting by its general partner, Permira V G.P. L.P., a limited partnership registered in Guernsey under the Limited
Partnerships (Guernsey) Law, 1995 (as amended), acting by its general partner Permira V G.P. Limited whose registered
office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands;
2. Permira V L.P.2, a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995
(as amended), acting by its general partner, Permira V G.P. L.P., a limited partnership registered in Guernsey under the
4781
L
U X E M B O U R G
Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995 (as amended), acting by its general partner Permira V G.P. Limited whose
registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands;
3. P5 Co-Investment L.P., a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law,
1995 (as amended), acting by its general partner Permira V G.P. L.P., acting by its general partner Permira V G.P. Limited
whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands;
4. Permira Investments Limited, acting by its nominee Permira Nominees Limited whose registered office is at Trafalgar
Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands;
5. P5 CIS S.à r.l., a company organised under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register with number B 178 072, having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
6. Permira V I.A.S L.P., a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law,
1995 (as amended), acting by its general partner Permira V G.P. L.P., acting by its general partner Permira V G.P. Limited
whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands;
All here represented by Mr Gianpiero SADDI, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given in Guernesey,
which remained attached and has been registered with the deed of Springlux Topco S.à r.l., a société à responsabilité
limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 282,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 192.419, signed on February 6
th
, 2015 before Maître Martine SCHAEFFER, number 251/2015 of her Répertoire
and registered with the Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, Actes Civils, on February 16
th
, 2015 with the relation 2LAC/2015/3414 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, number
961 of April 10
th
, 2015. The said deed of incorporation has been deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, on March 3
rd
, 2015 with the relation L150039833.
The prenamed person was the appearing party in the prenamed deed signed on February 6
th
, 2015 before Maître Martine
SCHAEFFER.
The said appearing party, acting as above-mentioned, requested the officiating notary to record that it results from later
verifications that clerical errors occurred in the Deed in the fourth and sixth resolutions of the Deed because it was not
referred to the newly created class A10 shares.
- Therefore, the fourth and sixth resolutions of the Deed shall be read as follows:
<i>"Fourth resolutioni>
The Shareholders resolve to insert new articles 8 and 9 in the Articles and to subsequently renumber the current articles
8 to 20 into articles 10 to 22 of the Articles.
The new articles 8 and 9 shall be read as follows:
Art. 8. The share capital of the Company may be reduced by the cancellation of one or more entire classes of A Shares
through the repurchase and cancellation of all the A Shares in issue in such class(es), in accordance with the provisions as
set out in this article 8. In the case of repurchases and cancellations of classes of A Shares such cancellations and repurchases
shall be made in the reverse numerical order (starting with the class A10).
In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of A Shares, such class
of A Shares gives the right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with the
limitation however to the Total Cancellation Amount) and the holders of A Shares of the repurchased and cancelled class
of A Shares shall be entitled to an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each A Share of the relevant class
held by them and repurchased and cancelled.
The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of A
Shares in issue in the class of A Shares to be repurchased and cancelled.
The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Board of Managers on the basis of the relevant
Interim Accounts and in accordance with the provisions of Article 21 of the Articles. The Total Cancellation Amount for
each relevant class of A Shares shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the redemption and
cancellation of the relevant class of A Shares, provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher
than the Available Amount. Upon the repurchase and cancellation of the A Shares of the relevant class of A Shares, the
Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.
For the purposes of these Articles, the following words shall have the following definitions:
-"Available Amount" means in relation to the relevant class of A Shares the total amount of net profits attributable to
that class of A Shares (subject to the provisions of Article 21 of the Articles) (including carried forward profits), to the
extent the Shareholders would have been entitled to dividend distributions according to Article 21 of the Articles, increased
by (i) any freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium reserve) and (ii) as the case
may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of A Shares to be
cancelled to the extent this corresponds to the available amounts in accordance with the law but reduced by (i) any losses
(included carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the law or
4782
L
U X E M B O U R G
of the Articles or in the reasonable opinion of the board of managers set aside to cover running costs of the Company, each
time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA= (NP + P+ CR) - (L + LR + PR)
Whereby:
AA= Available Amount;
NP= net profits attributable to the class of A Shares in accordance with the provisions of Article 21 of the Articles
(including carried forward profits as determined for the relevant class of A Shares in accordance with the provisions of
Article 21 of the Articles)
P= freely distributable share premium and reserves;
CR= the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of A Shares to be cancelled
to the extent this corresponds to the available amounts in accordance with the law;
L= losses (including carried forward losses if any);
LR= any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the law or of the Articles;
PR= sums set aside to cover running costs of the Company in the reasonable opinion of the Manager.
-"Cancellation Value Per Share" means the cancellation amount per A Share within the relevant class to be paid to the
Shareholders.
-"Interim Accounts" means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
-"Interim Accounts Date" means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation
of the relevant class of Shares.
-"Total Cancellation Amount" means the amount to be paid as the redemption price for the class of A Shares so redeemed.
Art. 9. Any amount of share premium paid in addition to the nominal value of any Share shall be allocated to a premium
reserve(s), not reserved to specific class of shares or to the holder of the Shares in relation to which it has been paid. Such
premium reserve(s) shall be freely distributable by the Company.""
<i>"Sixth resolutioni>
The Shareholders resolve to insert a new article 21 in the Articles and subsequent renumbering of the articles 21 and 22
(previous articles 19 and 20) into articles 22 and 23:
" Art. 21. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the
Shareholders in accordance with the following provisions of this article 21.
The holders of the A Shares are entitled to the following annual fixed dividends:
- the holders of class A1 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point ten per cent
(0.10%) of the par value of the class A1 Shares held by them, then,
- the holders of class A2 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point fifteen per
cent (0.15%) of the par value of the class A2 Shares held by them, then,
- the holders of class A3 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point twenty per
cent (0.20%) of the par value of the class A3 Shares held by them, then,
- the holders of class A4 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point twenty-
five per cent (0.25%) of the par value of the class A4 Shares held by them, then,
- the holders of class A5 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point thirty per
cent (0.30%) of the par value of the class A5 Shares held by them, then,
- the holders of class A6 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point thirty-five
per cent (0.35%) of the par value of the class A6 Shares held by them, then
- the holders of class A7 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point forty per
cent (0.40%) of the par value of the class A7 Shares held by them, then
- the holders of class A8 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point forty-five
per cent (0.45%) of the par value of the class A8 Shares held by them, then
- the holders of class A9 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point fifty per
cent (0.50%) of the par value of the class A9 Shares held by them, then
- the holders of class A10 Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
Should any class of shares have been cancelled following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the
distribution, the remainder of any dividend distribution shall then be allocated to the next outstanding class of shares to be
redeemed in the reverse numerical order (e.g. initially class A10 Shares).
If the dividends referred to above are not declared or paid during one or more particular years, the fixed dividends
entitlement shall continue to accrue.
4783
L
U X E M B O U R G
In any case, dividends can only be distributed and Shares redeemed to the extent that the Company has distributable
sums within the meaning of the law of August 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto and in accor-
dance with the applicable provisions of such law.
Notwithstanding the preceding provisions, the Board of Managers is authorized to declare and pay interim dividends to
the shareholder(s) in accordance with the distribution provisions described in the preceding provisions of this Article 21
before the end of the financial year and in accordance with the applicable legal provisions.""
The appearing parties require the notary to mention the rectification wherever necessary.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the appearing parties, n case of discrepancies
between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present rectification deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames,
civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille quinze, le vingt-neuf octobre.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. P5 Sub L.P.1, un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995,
agissant par son general partner, Permira V G.P. L.P., un limited partnership inscrite à Guernsey sous la loi du Limited
Partnerships (Guernsey) de 1995, agissant par son general partner Permira V G.P. Limited avec siège social à Trafalgar
Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands;
2. Permira V L.P.2 un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995,
agissant par son general partner, Permira V G.P. L.P., un limited partnership inscrite à Guernesey sous la loi du Limited
Partnerships (Guernsey) de 1995, agissant par son general partner Permira V G.P. Limited avec siège social à Trafalgar
Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands;
3. P5 Co-Investment L.P., un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de
1995, agissant par son general partner Permira V G.P. L.P., agissant par son general partner Permira V G.P. Limited avec
siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands;
4. Permira Investments Limited, agissant par son nominée Permira Nominees Limited avec siège social à Trafalgar
Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands;
5. P5 CIS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous numéro B 178 072, ayant son siège social au 282, route de Longwy, L-1940
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
6. Permira V I.A.S L.P., a limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de
1995, agissant par son general partner Permira V G.P. L.P., agissant par son general partner Permira V G.P. Limited avec
siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands;
Tous ici représentées par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxem-
bourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée à Guernesey,
Lesquelles procurations sont restées annexées et ont été enregistrées avec l'acte de «Résolutions prises par les associés
- modification des statuts» de la société SPRINGLUX TOPCO S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et
existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 282, route de Longwy, L-1940 Luxem-
bourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192.419 (la "Société"),
signé le 6 février 2015 par devant Maître Martine SCHAEFFER, numéro 251/2015 de son répertoire et enregistré à l'Ad-
ministration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, Actes Civils, le 16 février 2015 sous la relation 2LAC/
2015/3414 et publié auprès du Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 961 du 10 avril 2015. Ledit acte
de constitution a été déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2015 sous la relation
L150039833.
La personne prénommée était la partie comparante dans le prédit acte signé le 6 février 2015 par devant Maître Martine
SCHAEFFER.
La partie comparante, agissant comme susmentionné, requiert le notaire instrumentant d'enregistrer qu'il résulte de
vérifications ultérieures que des erreurs matérielles se sont produites dans les quatrième et sixième résolutions de l'Acte
car il n'a pas été fait référence aux parts sociales de classe A10 nouvellement créées.
- De ce fait, les quatrième et sixième résolutions de l'Acte devraient se lire comme suit:
4784
L
U X E M B O U R G
<i>"Quatrième résolutioni>
Les Associés décident d'insérer de nouveaux articles 8 et 9 dans les Statuts de la Société et de renuméroter les actuels
articles 8 à 20 en nouveaux articles 10 à 22 des Statuts.
Les articles 8 et 9 se liront désormais comme suit:
" Art. 8. Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation d'une ou plusieurs catégories de Parts Sociales
A émises dans de telle(s) catégorie(s), et ce conformément aux dispositions prévues au présent article 8. Dans les cas de
rachats et d'annulations de catégories de Parts Sociales, ces annulations et rachats devront être réalisés dans l'ordre numé-
rique inverse (commençant avec la catégorie A10).
Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une catégorie de Parts Sociales A, cette
catégorie de Parts Sociales A donne le droit à ses détenteurs au pro rata de leur détention dans cette catégorie au Montant
Disponible (dans la limite cependant du Montant Total d'Annulation) et les détenteurs des Parts Sociales A de la catégorie
de Parts Sociales A rachetée et annulée auront droit à un montant égal à la Valeur d'Annulation Par Part Sociale pour chaque
Part Sociale A de la catégorie détenue par eux et rachetée et annulée.
La Valeur d'Annulation Par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de Parts
Sociales A émises dans la catégorie de Parts Sociales A devant être rachetée et annulée.
Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le Conseil de Gérance sur la base de Comptes Intérimaires
pertinents et conformément aux dispositions de l'Article 21 des Statuts. Le Montant Total d'Annulation pour chaque caté-
gorie de Parts Sociales A pertinente sera le Montant Disponible de la catégorie de Parts Sociales A pertinente au moment
du rachat et de l'annulation de la catégorie de Parts Sociales A pertinente, étant entendu toutefois que le Montant Total
d'Annulation ne devra jamais être supérieur au Montant Disponible. A compter du rachat et de l'annulation des Parts Sociales
A de la catégorie de Parts Sociales A concernée, la Valeur d'Annulation Par Action sera due et payable par la Société.
Pour les besoins de cet Article, les mots suivants auront les définitions suivantes:
"Montant Disponible" signifie en relation avec la catégorie de Parts Sociales A pertinente, le montant total des bénéfices
nets attribuables à la catégorie de Parts Sociales A (sous réserve des dispositions de l'article 21 des présents Statuts)(y
compris les reports bénéficiaires), dans la mesure où les Associés auraient été en droit de réclamer des distributions de
dividende conformément à l'Article 21 des Statuts, augmenté par (i) toute prime d'émission librement distribuable (y
compris pour éviter tout doute la réserve de prime d'émission) et (ii), le cas échéant, par le montant de la réduction du
capital social et la réduction de la réserve légale liée à la catégorie de Parts Sociales A devant être annulée dans la mesure
où ceci correspond aux montants disponibles conformément à la loi mais réduit par (i) toutes pertes (y compris les pertes
reportées) et (ii) toutes sommes devant être mises en réserve(s) conformément aux dispositions légales ou aux Statuts ou
mises à part pour couvrir les coûts de fonctionnement de la Société selon l'opinion raisonnable du conseil de gérance, à
chaque fois comme indiqué dans les Comptes Intérimaires pertinents (pour éviter tout doute, sans double calcul) de telle
façon que:
AA= (NP + P+ CR) - (L + LR + PR)
Où:
AA= Montant Disponible;
NP= bénéfices nets attribuables à la catégorie d'Actions conformément aux dispositions de l'Article 21 des Statuts (y
compris les profits à reporter ainsi que déterminés pour la catégorie de Parts Sociales A pertinente conformément aux
dispositions de l'Article 21 des Statuts);
P= toute réserve librement distribuable;
CR= le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale lié à la catégorie de Parts Sociales
A devant être annulée dans la mesure où ceci correspond aux montants disponibles conformément à la loi;
L= pertes (y compris, le cas échéant, les pertes reportées);
LR= toutes sommes devant être mises en réserve(s) conformément aux dispositions légales ou aux Statuts;
PR= les sommes mises à part pour couvrir les coûts de fonctionnement de la Société selon l'opinion raisonnable du
conseil de gérance.
"Valeur d'Annulation Par Part Sociale" signifie le montant d'annulation par part sociale à payer aux Associés;
"Comptes Intérimaires" signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernés;
"Date des Comptes Intérimaires" signifie la date pas avant huit (8) jours avant la date de rachat de la catégorie de Parts
Sociales concernée;
"Montant Total d'Annulation" signifie le montant à payer comme prix de rachat pour la catégorie de Parts Sociales A
ainsi rachetée;
"Valeur d'Annulation Par Part Sociale" signifie le montant d'annulation par part sociale à payer aux Associés;
"Comptes Intérimaires" signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernés;
"Date des Comptes Intérimaires" signifie la date pas avant huit (8) jours avant la date de rachat de la catégorie de Parts
Sociales concernée;
4785
L
U X E M B O U R G
"Montant Total d'Annulation" signifie le montant à payer comme prix de rachat pour la catégorie de Parts Sociales A
ainsi rachetée."
" Art. 9. Tout montant de prime d'émission versé en plus de la valeur nominale de toute Part Sociale sera alloué à une
ou des réserves de prime d'émission, non réservée(s) à une catégorie de Parts Sociales spécifique ou au détenteur de Parts
Sociales au titre desquelles il a été payé. Cette ou ces réserves de prime d'émission sera(ont) librement distribuable(s) par
la Société.""
<i>"Sixième résolutioni>
Les Associés décident d'insérer un nouvel article 21 dans les Statuts de la Société, et par conséquent de renuméroter les
articles 21 et 22 (précédents articles 19 et 20) en articles 22 et 23:
" Art. 21. La décision de distribuer des fonds et la détermination du montant d'une telle distribution seront prises par les
Associés conformément aux dispositions suivantes du présent article 21.
Les détenteurs de Part Sociales A ont droit aux dividendes fixes annuels suivants:
- les détenteurs de Parts Sociales de catégorie A1 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un
montant de zéro virgule dix pourcent (0,10%) de la valeur nominale des Parts Sociales de catégorie A1 détenus par eux,
puis,
- les détenteurs de Parts Sociales de catégorie A2 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un
montant de zéro virgule quinze pourcent (0,15%) de la valeur nominale des Parts Sociales de catégorie A2 détenus par eux,
puis,
- les détenteurs de Parts Sociales de catégorie A3 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un
montant de zéro virgule vingt pourcent (0,20%) de la valeur nominale des Parts Sociales de catégorie A3 détenus par eux,
puis,
- les détenteurs de Parts Sociales de catégorie A4 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un
montant de zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de catégorie A4 détenus par
eux, puis,
- les détenteurs de Parts Sociales de catégorie A5 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un
montant de zéro virgule trente pourcent (0,30%) de la valeur nominale des Parts Sociales de catégorie A5 détenus par eux,
puis,
- les détenteurs de Parts Sociales de catégorie A6 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un
montant de zéro virgule trente-cinq pourcent (0,35%) de la valeur nominale des Parts Sociales de catégorie A6 détenus par
eux, puis,
- les détenteurs de Parts Sociales de catégorie A7 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un
montant de zéro virgule quarante pourcent (0,40%) de la valeur nominale des Parts Sociales de catégorie A7 détenus par
eux, puis,
- les détenteurs de Parts Sociales de catégorie A8 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un
montant de zéro virgule quarante-cinq pourcent (0,45%) de la valeur nominale des Parts Sociales de catégorie A8 détenus
par eux, puis,
- les détenteurs de Parts Sociales de catégorie A9 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un
montant de zéro virgule cinquante pourcent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales de catégorie A9 détenus par
eux, puis,
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A10 seront habilités à recevoir le restant de la distribution de dividende.
Dans le cas où une catégorie de Parts Sociales a été annulée à la suite de son rachat ou autrement au moment de la
distribution, le reste de toute distribution de dividendes sera affecté à la catégorie de Parts Sociales suivante restante devant
être rachetée dans l'ordre numérique inverse (par exemple, d'abord les Parts Sociales de catégorie A10).
Si les dividendes susmentionnés ne sont pas déclarés ou payés durant une ou plusieurs années en particulier, les divi-
dendes fixes continueront de produire des intérêts.
Dans tous les cas, les dividendes peuvent seulement être distribués et les Parts Sociales rachetées dans la mesure où la
Société a des sommes distribuables au sens de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses amendements
relatifs et conformément aux dispositions applicables de ladite loi.
Nonobstant les dispositions précédentes, le conseil de gérance est autorisé à déclarer et payer des dividendes intérimaires
au(x) associé(s) conformément aux dispositions relatives à la distribution décrites dans les précédentes dispositions du
présent Article 21 avant la fin de l'exercice social et conformément aux dispositions légales applicables.""
Les parties comparantes prient le notaire de faire mention de la présente rectification partout où besoin sera.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande des parties comparantes, en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
4786
L
U X E M B O U R G
Et après lecture donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures,
ces derniers ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 4 novembre 2015. Relation: 2LAC/2015/24847. Reçu douze euros Eur 12.-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181702/300.
(150202090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Starpoint Investments (Lux) BRL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 170.573.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth of October.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Starpoint Holdings (Lux) BRL S.à r.l., a private limited liability company governed by the laws of Luxembourg, with
registered office at 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 170 550,
here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, Avenue
Victor Hugo, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on October 27, 2015.
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the representative of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to enact the following declarations and
statements:
- That the limited liability company "Starpoint Investments (Lux) BRL S.à r.l." (the “Company”), with registered office
at 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg under
number B 170 573 has been incorporated pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxem-
bourg, dated July 24
th
, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2206 dated
September 5
th
, 2012. The articles of association of the Company have not been amended since.
- That the issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500), represented
by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each, fully subscribed and paid-up.
- That the sole shareholder owns the totality of shares of the Company.
- That the Company's activities have ceased; that the sole shareholder decides in general meeting to proceed to the
anticipatory and immediate dissolution of the Company.
- That the here represented sole shareholder appoints himself as liquidator of the Company and acting in this capacity
requests the notary to authentify his declaration that all the liabilities of the Company have been paid and that the liabilities
in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that with
respect to eventual liabilities of the Company presently unknown that remain unpaid, he irrevocably undertakes to pay all
such eventual liabilities; that as a consequence of the above all the liabilities of the company are paid. The liquidation report
will remain attached to the present deed.
- That the remaining net assets have been paid to the sole shareholder.
- The declarations of the liquidator have been certificated, pursuant to a report that remains attached as appendix,
established by Silver Star LLC, a limited liability company having its registered office in the State of Delaware, registered
with the Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801 under
number 5409963, represented by Mr Thierry Drinka having his professional address at 3, rue W.A. Mozart, L-2166 Lu-
xembourg appointed as auditor to the liquidation by the sole shareholder.
- That the liquidation of the Company is done and finalised.
- That full discharge is granted to the managers of the Company for the execution of their mandates.
- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five (5) years at the former
registered address of the Company being 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.
4787
L
U X E M B O U R G
The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and regis-
tration.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
entity, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing entity
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surnames, name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-huit octobre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Starpoint Holdings (Lux) BRL S.à r.l. une société à responsabilité limitée établie sous les lois du Luxembourg, ayant
son siège social au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Lu-
xembourg sous le numéro B 170 550,
ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74,
Avenue Victor Hugo, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg
le 27 octobre 2015.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "Starpoint Investments (Lux) BRL S.à r.l." (la «Société»), ayant son social au
4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 170 573, a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 24 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2206 du 5 septembre 2012.
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis.
- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR), représenté par
cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.
- Que l'associé unique, possède la totalité des parts sociales de la Société.
- Que l'activité de la Société ayant cessé, l'associé unique, siégeant en assemblée générale extraordinaire prononce la
dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
- Que l'associé unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire instrumentant
d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est
dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non
payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le
passif de ladite Société est réglé. Le rapport du liquidateur reste annexé au présent acte.
- Que l'actif restant est réparti à l'associé unique.
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi,
établi par Silver Star LLC une limited liability company établie et ayant son siège social dans l'Etat du Delaware, inscrite
auprès du Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801,
enregistrée sous le numéro 5409963 représentée par Monsieur Thierry Drinka avec adresse professionnelle au 3, rue W.A.
Mozart, L-2166 Luxembourg, désigné commissaire à la liquidation par l'associé unique de la Société.
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
- Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats.
- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans auprès de l'ancien siège social de la
Société au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.
Le titulaire de la copie du présent acte disposera de tous les pouvoirs nécessaires relatifs aux publications légales et aux
formalités.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
4788
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 octobre 2015. 2LAC/2015/24495. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181705/108.
(150201710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Swiss Life Hotel Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxemburg, 4a, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 201.277.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen,
on the twenty-seventh day of the month of October.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, a branch of a swiss stock company incorporated and organised under
the laws of Switzerland, registered with the trade register of Munich, Germany, under number HRB120565, having its
registered office at Zeppelinstraße 1, 85748 Garching near Munich (Germany),
here represented by Mr Alexander WAGNER, Rechtsanwalt, professionally residing at 10, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte,, L-1330 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Garching, Germany, on 22 October 2015.
The proxy given, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of incor-
poration of a société à responsabilité limitée governed by the relevant laws and the present articles of incorporation.
<i>Definitionsi>
The following terms shall have the meaning as set out hereafter whenever used herein with initial capital letters:
"1915 Law" means the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to
time;
"2007 Law" means the Luxembourg law dated 13 February 2007 on specialised investment funds, as amended from
time to time;
"Articles" means the present articles of incorporation;
"Board" means the board of Managers of the Company;
"Business Day" means any day, other than a Saturday or Sunday, when banks in Luxembourg are open for the transaction
of normal business;
"Euro" or "EUR" means the lawful currency of the European Union member States that have adopted the single currency
in accordance with the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union;
"Manager" means a manager appointed to the Board in accordance with these Articles or as the case may be a member
of the Board;
"Share(s)" means the shares issued by the Company and any share issued in exchange for those shares or by way of
conversion or reclassification, and any shares representing or deriving from those shares as a result of any increases in or
reorganization or variation of the capital of the Company; and
"Shareholder" means a holder of Shares.
Title I. Name, Purpose, Duration, Registered Office
Art. 1. There is hereby formed by the present and all persons and entities who may become Shareholders in the future
a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of Swiss Life Hotel Management S.à r.l.
(hereinafter referred to as the "Company").
Art. 2. The Company's corporate object is to act solely as general partner (associé gérant commandité) of "Swiss Life
Hotel Management SCS", a Luxembourg common limited partnership (société en commandite simple).
The Company shall carry out any activities connected with its status of general partner of the aforementioned entity.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly with all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
4789
L
U X E M B O U R G
Art. 3. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 4. The registered office of the Company is established in city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board, after having
received Shareholders consent.
In the event that the Board, determines that extraordinary political or military developments have occurred or are im-
minent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until
the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality
of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office abroad, will remain a Luxembourg
company.
Title II. Capital, Shares
Art. 5. The Company's capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred
(100) Shares of one hundred and twenty five Euro (EUR 125.-) each.
The one hundred (100) Shares have all been fully paid in cash.
The capital may be increased or reduced by a resolution of the single Shareholder or by resolution of the Shareholders
of the Company adopted in accordance with Article 19 hereof.
Shares will only be issued in registered form and will be inscribed in the register of Shares, which is held by the Company
or by one or more persons on behalf of the Company. Such register of Shares shall set forth the name of each Shareholder,
his residence or elected domicile, the number and class of Shares held by him.
In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the 1915 Law.
Title III. Shareholder meetings
Art. 6. Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company shall represent the entire body of Sha-
reholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of
Company.
Art. 7. In case of a single Shareholder, the single Shareholder assumes all powers conferred to the Shareholders' meeting.
Any resolutions to be taken by the single Shareholder may be taken in writing.
In case of plurality of Shareholders, the provisions of Article 8 will apply to any resolution to be taken by a meeting of
Shareholders.
Each Share is entitled to one vote.
A Shareholder may be represented (at any meeting of Shareholders) by another person, which does not need to be a
Shareholder and which may be a Manager. The proxy established to this effect may be in writing or by cable, telegram,
facsimile or e-mail transmission.
Art. 8. If legally required or if not so required upon the decision of the Board, annual general meetings of Shareholders
of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company,
or such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting. Such annual general meetings may be
held abroad if, in the judgement of the Board, exceptional circumstances so require.
The Board, may convene other meetings of Shareholders to be held at such place and time as may be specified in the
respective notices of meetings.
The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of Shareholders of the
Company, unless otherwise provided herein.
Except as otherwise required by law or provided herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly convened will
be passed by simple majority of the votes cast by those Shareholders present and voting.
The general meeting of Shareholders shall be called by the Board, by notices containing the agenda and which will be
published as required by law.
The Board will prepare the agenda, except if the meeting takes place due to the written request of Shareholders provided
for by law; in such case the Board may prepare an additional agenda.
If all of the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
The matters dealt with by the meeting of Shareholders are limited to the issues contained in the agenda which must
contain all issues prescribed by law as well as to issues related thereto, except if all the Shareholders agree to another
agenda. In case the agenda should contain the nomination of Managers or of the auditor, the names of the eligible Managers
or of the auditors will be inserted in the agenda.
4790
L
U X E M B O U R G
Title IV. Administration
Art. 9. The Company shall be managed by at least three Managers. The appointed Managers will constitute a Board.
The Manager(s) need not be Shareholders of the Company.
The Manager(s) shall be elected by the general meeting of Shareholders for a period as determined by such general
meeting of Shareholders and until their successors are elected and take up their functions. Upon expiry of its mandate, a
Manager may seek reappointment.
The Manager(s) mandate may be revoked at any time with or without a reason by the general meeting of Shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a Manager because of death, retirement or otherwise, the remaining Managers
may meet and may elect, by majority vote, a Manager to fill such vacancy until the next general meeting of Shareholders.
Art. 10. The Board shall choose from among its members a chairman.
The chairman shall preside at all meetings of the Board but in his absence or incapacity to act, the Managers present
may appoint anyone of their number to act as chairman for the purposes of the meeting.
The Board may also choose a secretary, who need not be a Manager and who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the Board and of the Shareholders.
The Board may from time to time appoint officers of the Company, including a managing director, a general manager
and any assistant managers or other officers considered necessary for the operation and management of the Company.
Officers need not be Managers or Shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated herein,
shall have the powers and duties given to them by the Board.
The Board shall meet upon call by the chairman, or any two Managers, at the place indicated in the notice of meeting.
Written notice, containing an agenda which sets out any points of interest for the meeting, of any meeting of the Board
shall be given to all Managers at least three (3) Business Days prior to the beginning of such meeting, except in circumstances
of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice
may be waived by the consent in writing or by telegram, facsimile or e-mail transmission of each Manager. Separate notice
shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by
resolution of the Board.
Any Manager may act at any meeting of the Board by appointing, in writing or by telegram, facsimile or e-mail trans-
mission, another Manager as his proxy.
Any Manager who is not physically present at the location of a meeting may participate in such a meeting of the Board
by remote conference facility or similar means of communication equipment, whereby all persons participating in the
meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting.
The Board can deliberate or act validly only if at least two Managers are present or represented at a meeting of the Board.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented. In case of a deadlock, the
chairman shall have the casting vote.
Resolutions signed by all Managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such
signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letters,
telegrams, facsimile or e-mail transmissions.
The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore
who presided at such meeting or by any two Managers.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the
chairman or by any two Managers or by a Manager together with the secretary or the alternate secretary.
Art. 11. The Board shall have power to determine the course and conduct of the management and business affairs of the
Company.
It is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the interests of the Company.
All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of Shareholders fall within the
competence of the Board.
Art. 12. The Company shall be bound by the joint signature of any two Managers of the Company, by the joint signature
of one Manager and any single person to whom such signatory authority has been delegated by the Board or by the joint
signature of any two persons to whom such signatory authority has been delegated by the Board.
Art. 13. The Board may delegate any of its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine
any such agent's powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of its agency.
Art. 14. No contract or other transaction which the Company and any other company or firm might enter into shall be
affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or officers of the Company is interested in such
other company or firm by a relation, or is a director, officer or employee of such other company or legal entity.
4791
L
U X E M B O U R G
In the event that any Manager or officer of the Company may have any personal interest in any contract or transaction
of the Company other than that arising out of the fact that he is a Manager, officer or employee or holder of securities or
other interests in the counterparty, such Manager or officer shall make known to the Board such personal interest and shall
not consider or vote upon any such contract or transaction. Such contract or transaction, and such Manager's or officer's
personal interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of Shareholders.
Art. 15. The Company may indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Manager or officer of the Company or, at its request, of any other company of
which the Company is a unitholder or a creditor and which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct;
in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement
as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty.
The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Title V. Accounting, Distributions
Art. 16. The accounting year of the Company shall begin on 1 October and shall end on 30 September of the following
year.
Art. 17. From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital
of the Company as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to time in accordance with Article 5
hereof.
The general meeting of Shareholders shall decide each year how the remainder of the annual net profit shall be allocated
and may declare dividends from time to time or instruct the Board to do so.
The Board may within the conditions set out by law unanimously resolve to pay out interim dividends.
Title VI. Winding up, Liquidation
Art. 18. In the event of a winding-up of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators.
Liquidators may be physical persons or legal entities and are named by the meeting of Shareholders deciding such winding-
up and which shall determine their powers and their compensation.
Title VII. Amendments
Art. 19. These Articles may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the respect of the
quorum and majority requirements provided by Luxembourg law.
Art. 20. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law and the 2007
Law.
<i>Transitory dispositioni>
The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on 30
September 2016.
<i>Subscription and Paymenti>
The capital of the Company is subscribed as follows:
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, above named, subscribes for one hundred (100) Shares, resulting in a
total payment in cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).
Evidence of the above payment was given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately
thousand euro.
<i>General Meeting of Shareholdersi>
The above named person representing the entire subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting,
passed the following resolutions:
(i) The following are elected as Managers for an undetermined period:
- Mr Vincent Charuel, born on 28 January 1978 in Saint-Quentin, France, residing professionally at 4a rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Matthias Kath-Burdack, born on 29 September 1970 in Jena, Germany, residing professionally at 4a rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
4792
L
U X E M B O U R G
- Mr Uwe Druckenmüller, born on 21 June 1961 in Albstadt-Ebingen, Germany, residing professionally at 4a rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Florian Bauer, born on 7 March 1975 in Frankfurt am Main, Germany, residing professionally at Zeppelinstraße
1, 85748 Garching, Germany;
- Mr Johannes Becker, born on 16 March 1971 in Bad Homburg v.d.H., Germany, residing professionally at
Zeppelinstraße 1, 85748 Garching, Germany.
(ii) The registered office of the Company is set at 4a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the above named
person, this deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing person, in case
of divergence between the English and the German versions, the English version will be prevailing.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, surname, status and residence,
the person appearing signed together with Us notary the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden englischen Textes.
Im Jahre zweitausendfünfzehn,
am siebenundzwanzigsten Tag des Monats Oktober.
Vor Uns Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in SASSENHEIM, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, eine Niederlassung einer schweizerischen Aktiengesellschaft gegründet
nach dem Recht der Schweiz, mit Sitz in Zeppelinstraße 1, 85748 Garching b. München, Deutschland, eingetragen im
Handelsregister München unter der Nummer HRB120565,
hier vertreten durch Herrn Alexander WAGNER, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in 10, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxemburg,
aufgrund einer am 22. Oktober 2015 in Garching, Deutschland, erteilten Vollmacht.
Die von dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" gezeichnete Voll-
macht bleibt dieser Urkunde beigefügt und ist zusammen mit dieser bei der zuständigen Registerstelle einzureichen.
Die wie vorstehend beschrieben vertretene Erschienene hat den Notar gebeten, die nachstehende Satzung (articles of
incorporation) einer den einschlägigen Gesetzen sowie den Bestimmungen dieser Satzung unterliegenden Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu Protokoll zu nehmen.
<i>Definitioneni>
Die folgenden Begriffe haben, wen sie mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben sind, die ihnen jeweils zugeordnete
Bedeutung:
"Euro" oder "EUR" ist die gesetzliche Währung derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die gemäß dem
Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union die gemeinsame
Währung eingeführt haben;
"Geschäftsführer" ist einer der gemäß dieser Satzung zum Mitglied des Rates der Geschäftsführung bestellten Ge-
schäftsführer bzw. ein Mitglied des Rates der Geschäftsführung;
"Geschäftstag" ist ein Tag, außer Samstag und Sonntag, an dem die Banken in Luxemburg für die üblichen Geschäfte
geöffnet sind;
"Gesellschafter" ist ein Inhaber von Anteilen;
"Gesellschaftsanteil(e)" sind die von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile sowie im Tausch gegen solche Anteile oder
aufgrund einer Umwandlung oder Reklassifizierung ausgegebene Anteile sowie Anteile, die aufgrund von Kapitalerhö-
hungen, Umwandlungen oder Reklassifizierung für diese Anteile stehen oder aus ihnen hervorgehen;
"Gesetz von 1915" ist das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils
geltenden Fassung;
"Gesetz von 2007" ist das luxemburgische Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in seiner
jeweils geltenden Fassung;
"Rat der Geschäftsführung" ist der Rat der Geschäftsführung der Gesellschaft; und
"Satzung" ist die vorliegende Satzung.
Abschnitt I. Name, Zweck, Dauer, Sitz
Art. 1. Hiermit wird durch die gegenwärtigen und künftigen Gesellschafter eine Gesellschaft in der Rechtsform einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Namen Swiss Life Hotel Management S.à r.l.
(nachstehend "Gesellschaft" genannt) gegründet.
4793
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Der einzige Zweck der Gesellschaft ist es, als Komplementärin (associé gérant commandité) der "Swiss Life
Hotel Management SCS" zu fungieren, einer Luxemburgischen Kommanditgesellschaft (société en commandite simple).
Die Gesellschaft soll alle Tätigkeiten ausführen, die mit ihrer Stellung als Komplementärin der vorbezeichneten Ge-
sellschaft zusammenhängen.
Die Gesellschaft kann alle gewerblichen, technischen oder finanziellen Tätigkeiten ausführen, die direkt oder indirekt
mit allen oben beschriebenen Bereichen verbunden sind, um die Erfüllung ihres Zweckes zu fördern.
Art. 3. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxembourg (Stadt), Großherzogtum Luxemburg. Niederlassungen oder Büros
können aufgrund eines Beschlusses des Rates der Geschäftsführung gegründet werden, wobei solche Beschlussfassungen
unter dem Vorbehalt der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gesellschafter stehen.
Für den Fall, dass der Rat der Geschäftsführung befindet, dass außergewöhnliche politische oder militärische Umstände
eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die üblichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz stören oder die
Kommunikation zwischen dem Sitz und im Ausland ansässigen Personen erschweren könnten, kann der Sitz vorübergehend
solange ins Ausland verlagert werden, bis die außergewöhnlichen Umstände nicht mehr vorherrschen. Solche vorüber-
gehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden
Verlagerung ihres Sitzes ins Ausland eine Gesellschaft nach luxemburgischem Recht bleibt.
Abschnitt II. Kapital, Gesellschaftsanteile
Art. 5. Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgelegt und in einhundert
(100) Gesellschaftsanteile mit einem Wert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) je Anteil aufgeteilt.
Die einhundert (100) Gesellschaftsanteile sind vollständig eingezahlt.
Das Kapital kann aufgrund eines gemäß Artikel 19 dieser Satzung getroffenen Beschlusses des Alleingesellschafters
oder der Gesellschafter der Gesellschaft erhöht oder herabgesetzt werden.
Gesellschaftsanteile werden nur als Namensanteile ausgegeben und sind ins Anteilsregister einzutragen, das von der
Gesellschaft oder von einer oder mehreren Personen im Namen der Gesellschaft geführt wird. In diesem Anteilsregister
wird der Name des Gesellschafters, sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort, die Nummer und die Klasse der von
ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile vermerkt.
Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, sind die von dem Alleingesellschafter gehaltenen Gesellschafts-
anteile frei übertragbar.
Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, können die von jedem Gesellschafter gehaltenen Gesellschaftsan-
teile gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes von 1915 übertragen werden.
Abschnitt III. Gesellschafterversammlungen
Art. 6. Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Gesellschafter der Gesellschaft gilt als Vertretung sämtlicher
Gesellschafter der Gesellschaft. Sie verfügt über größtmögliche Befugnisse, mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft
verbundene Handlungen anzuordnen, durchzuführen oder zu bewilligen.
Art. 7. Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, stehen diesem sämtliche der Gesellschafterversammlung
übertragenen Befugnisse zu. Von dem Alleingesellschafter zu fassende Beschlüsse können schriftlich gefasst werden.
Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, gelten die Bestimmungen von Artikel 8 für sämtliche von einer
Gesellschafterversammlung zu fassenden Beschlüsse.
Jeder Gesellschaftsanteil gewährt eine Stimme.
Ein Gesellschafter kann sich (auf Gesellschafterversammlungen) von einer anderen Person vertreten lassen, die kein
Gesellschafter sein muss und ein Geschäftsführer sein kann. Eine zu diesem Zweck gewährte Vollmacht kann schriftlich,
per Telegramm, per Fernschreiben, per Fax oder E-Mail erteilt werden.
Art. 8. Sofern kraft Gesetz erforderlich oder, andernfalls, aufgrund einer Entscheidung des Rates der Geschäftsführung,
werden die jährlichen Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft gemäß luxemburgischem Recht am Sitz der Gesell-
schaft in Luxemburg oder einem anderen, in der Einladung zur Versammlung genannten Ort abgehalten. Solche jährlichen
Gesellschafterversammlungen können im Ausland abgehalten werden, wenn der Rat der Geschäftsführung dies aufgrund
des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände für erforderlich hält.
Der Rat der Geschäftsführung kann weitere Gesellschafterversammlungen einberufen, die an den in den jeweiligen
Einladungen genannten Orten und zu den darin ebenfalls genannten Zeiten abgehalten werden.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in dieser Satzung gelten im Hinblick auf die Fristen für Einladungen zu
Gesellschafterversammlungen und deren Beschlussfähigkeit die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.
Vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen oder Bestimmungen dieser Satzung sind auf einer ordnungs-
gemäß einberufenen Gesellschafterversammlung zu fassende Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen der anwesenden und sich an der jeweiligen Abstimmung beteiligenden Gesellschafter zu fassen.
4794
L
U X E M B O U R G
Die jährlichen Gesellschafterversammlungen sind von dem Rat der Geschäftsführung durch Versendung von Einla-
dungen einzuberufen, die die Tagesordnung enthalten und die gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu
veröffentlichen sind.
Der Rat der Geschäftsführung wird die Tagesordnung erstellen, es sei denn, eine Versammlung findet auf schriftliches
Verlangen der Gesellschafter gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen statt; in einem solchen Fall kann der
Rat der Geschäftsführung eine weitere Tagesordnung erstellen.
Sofern bei einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie
über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann eine Versammlung ohne vorherige Einladung oder
Veröffentlichung abgehalten werden.
Die Angelegenheiten, die von einer Gesellschafterversammlung behandelt werden, sind auf die in der Tagesordnung
genannten Punkte zu beschränken, wobei alle gesetzlich vorgeschriebenen und mit diesen zusammenhängende Punkte zu
behandeln sind, es sei denn, alle Gesellschafter einigen sich auf eine andere Tagesordnung. Sofern die Bestellung von
Geschäftsführern oder eines Abschlussprüfers auf der Tagesordnung steht, sind die Namen der zur Wahl stehenden Ge-
schäftsführer oder Abschlussprüfer in die Tagesordnung aufzunehmen.
Abschnitt IV. Verwaltung
Art. 9. Die Geschäfte der Gesellschaft werden von mindestens drei Geschäftsführern geführt. Die bestellten Geschäfts-
führer bilden einen Rat der Geschäftsführung.
Der bzw. die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.
Der bzw. die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung für einen von dieser bestimmten Zeitraum
gewählt, bis ihre Nachfolger gewählt sind und ihr Amt übernehmen. Nach Ablauf seiner Amtszeit kann sich ein Ge-
schäftsführer wieder zur Wahl stellen.
Der bzw. die Geschäftsführer können jederzeit von der Gesellschafterversammlung mit oder ohne die Angabe von
Gründen ihres Amtes enthoben werden.
Für den Fall, dass der Posten eines Geschäftsführers aufgrund des Todes, der Eintritts in den Ruhestand eines Ge-
schäftsführers oder aus anderen Gründen vakant wird, können sich die verbleibenden Geschäftsführer versammeln und mit
einfacher Mehrheit einen Geschäftsführer wählen, der eine solche Vakanz bis zur nächsten jährlichen Gesellschafterver-
sammlung ausfüllt.
Art. 10. Der Rat der Geschäftsführung ernennt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden.
Der Vorsitzende führt den Vorsitz sämtlicher Versammlungen der Geschäftsführer der Gesellschaft. Sofern der Vor-
sitzende bei einer Versammlung abwesend oder nicht handlungsfähig ist, können die Geschäftsführer aus ihrer Mitte einen
Vorsitzenden für die Zwecke der jeweiligen Versammlung ernennen.
Der Rat der Geschäftsführung kann einen Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer sein muss und für die Führung
des Protokolls von Versammlungen des Rates der Geschäftsführung und von Gesellschafterversammlungen verantwortlich
ist.
Der Rat der Geschäftsführung kann jeweils Bevollmächtigte („Officers“) der Gesellschaft ernennen, einschließlich eines
Managing Directors, eines General Managers, eines Assistant Managers oder sonstiger Bevollmächtigte, die im Hinblick
auf den Betrieb und die Verwaltung der Gesellschaft für erforderlich gehalten werden. Bevollmächtigte müssen keine
Geschäftsführer, oder Gesellschafter der Gesellschaft sein. Die ernannten Bevollmächtigte haben die ihnen von dem Rat
der Geschäftsführung zugewiesenen Befugnisse und Pflichten.
Der Rat der Geschäftsführung versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern an dem
in der jeweiligen Einladung genannten Ort.
Sämtlichen Geschäftsführern ist mindestens drei (3) Tage vor Beginn einer solchen Versammlung eine schriftliche
Einladung zusammen mit einer Tagesordnung zu übermitteln, in der sämtliche Geschäftsordnungspunkte aufgeführt sind.
Von dieser Frist kann in dringenden Ausnahmefällen abgewichen werden, in denen die näheren Umstände in der Einladung
auszuführen sind. Auf eine Einladung kann verzichtet werden, sofern sämtliche Geschäftsführer einer solchen Verfah-
rensweise schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zustimmen. Für einzelne Versammlungen, deren Zeit und Ort vorab
durch Gesellschafterbeschluss festgelegt worden sind, ist keine weitere Einladung erforderlich.
Geschäftsführer können sich bei Versammlungen des Rates der Geschäftsführung vertreten lassen, indem sie einen
anderen Geschäftsführer schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zu ihrem Vertreter ernennen.
Geschäftsführer, die an einem Versammlungsort nicht physisch anwesend sind, können an einer Versammlung des Rates
der Geschäftsführung per Konferenzschaltung oder auf einem ähnlichen Kommunikationsweg teilnehmen, wobei sich alle
Teilnehmer einer solchen Versammlung gegenseitig hören können müssen, und eine Teilnahme an einer solchen Ver-
sammlung kommt einer persönlichen Teilnahme gleich.
Eine Versammlung der Geschäftsführer der Gesellschaft kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens zwei
Geschäftsführer bei einer Versammlung des Rates der Geschäftsführung anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse sind
mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer zu fassen. Im Falle eines Patts hat der Vorsitzende
die entscheidende Stimme.
4795
L
U X E M B O U R G
Von sämtlichen Geschäftsführern unterzeichnete Beschlüsse sind genauso gültig und wirksam wie bei einer ordnungs-
gemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können auf einem
einzigen Dokument oder auf mehreren Ausfertigungen eines Beschlusses gezeichnet sein und können per Brief, Telegramm,
Fax oder E-Mail erfolgen.
Das Protokoll von Versammlungen der Geschäftsführer der Gesellschaft ist von dem Vorsitzenden oder, sofern dieser
abwesend ist, von dem stellvertretenden, nur für die jeweilige Versammlung ernannten Vorsitzenden oder von zwei Ge-
schäftsführern zu unterzeichnen.
Kopien von oder Auszüge aus solchen Protokollen, die gegebenenfalls in Gerichtsverfahren oder bei anderen Gelegen-
heiten vorgelegt werden, sind von dem Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einem Geschäftsführer
gemeinsam mit dem Sekretär oder dem stellvertretenden Sekretär zu unterzeichnen.
Art. 11. Der Rat der Geschäftsführung ist befugt, die Richtung und Art der Geschäftsführung und der Geschäfte der
Gesellschaft festzulegen.
Der Geschäftsführer bzw. der Rat der Geschäftsführung ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um sämt-
liche im Interesse der Gesellschaft stehenden Verwaltungshandlungen und -verfügungen vorzunehmen. Sämtliche Befug-
nisse, die nicht kraft Gesetzes oder gemäß dieser Satzung ausdrücklich der jährlichen Gesellschafterversammlung
zugewiesen sind, werden vom Rat der Geschäftsführung ausgeübt.
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern der Gesellschaft, durch
die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers und einer Person, auf die ein solches Zeichnungsrecht durch den Rat
der Geschäftsführung übertragen worden ist oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Personen, auf die ein solches
Zeichnungsrecht durch den Rat der Geschäftsführung übertragen worden ist, rechtlich gebunden.
Art. 13. Der Rat der Geschäftsführung kann seine Befugnisse für bestimmte Aufgaben an einen oder mehrere spezielle
Handlungsbevollmächtigte übertragen und legt die Befugnisse, den Verantwortungsbereich sowie die Vergütung (sofern
anwendbar) dieser Handlungsbevollmächtigten fest, sowie die Dauer des Vertretungszeitraums und alle weiteren relevanten
Bedingungen hinsichtlich der Stellvertretung.
Art. 14. Verträge oder andere Transaktionen der Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder einem anderen Un-
ternehmen bleiben unberührt und werden nicht unwirksam, wenn einer oder mehrere der Geschäftsführer oder Bevoll-
mächtigte der Gesellschaft aufgrund persönlicher Beziehungen ein Interesse an dieser anderen Gesellschaft oder diesem
anderen Unternehmen hat oder haben oder dort Geschäftsführer oder Bevollmächtigter oder Mitarbeiter ist oder sind.
Falls ein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Gesellschaft möglicherweise aus anderen Gründen als aufgrund
des Umstands, dass er Geschäftsführer, Bevollmächtigter, Mitarbeiter oder Inhaber von Wertpapieren oder sonstigen Be-
teiligungen des anderen Unternehmens ist, ein persönliches Interesse an einem Vertrag oder einer Transaktion der
Gesellschaft hat, wird der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte den Rat der Geschäftsführung von diesem persönlichen
Interesse in Kenntnis setzen und von einer Beteiligung an Beschlussfassungen hinsichtlich eines solchen Vertrags oder
einer solchen Transaktion absehen. Die jeweils nächste Gesellschafterversammlung ist von einem solchen Vertrag oder
einer solchen Transaktion und dem persönlichen Interesse des betreffenden Geschäftsführers oder Bevollmächtigten zu
unterrichten.
Art. 15. Die Gesellschaft kann einen Geschäftsführer oder Bevollmächtigter, seine Erben, Testamentsvollstrecker oder
Nachlassverwalter für angemessene Kosten schadlos halten, die diesem oder diesen in Zusammenhang mit einem Anspruch,
einer Klage oder einem Verfahren entstanden sind, die möglicherweise auf der jetzigen oder früheren Tätigkeit des Be-
treffenden als Geschäftsführer oder Bevollmächtigte für die Gesellschaft oder für eine andere Gesellschaft beruhen, sofern
dies verlangt wird, deren Anteilinhaber oder Gläubiger die Gesellschaft ist, wenn der Betreffende insoweit keinen anderen
Schadloshaltungsanspruch hat; dies gilt nicht, wenn der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte wegen grober Fahrlässigkeit
oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird; wird ein Vergleich geschlossen, erfolgt die Schadloshaltung nur bezüglich sol-
cher vom Vergleich erfassten Punkte, bezüglich derer - laut Auskunft eines Rechtsberaters gegenüber der Gesellschaft -
keine Pflichtverletzung der schadlos zu haltenden Person vorliegt. Das vorstehende Recht auf Schadloshaltung schließt
andere, dem Geschäftsführer oder Bevollmächtigten möglicherweise zustehende Rechte nicht aus.
Abschnitt V. Buchhaltung, Ausschüttung von Dividenden
Art. 16. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des darauffolgenden
Jahres.
Art. 17. Von dem Jahresüberschuss der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die gesetzlich vorgeschriebenen
Reserven eingestellt. Diese Zuführung von Geldern endet, sobald und solange die Reserven bei zehn Prozent (10 %) des
Kapitals der Gesellschaft gemäß Artikel 5 dieser Satzung oder dem gegebenenfalls gemäß Artikel 5 dieser Satzung herauf-
oder herabgesetzten Betrag liegen.
Die Gesellschafterversammlung beschließt jährlich über die Verwendung des Jahresüberschusses; sie kann ggf. Divid-
enden festsetzen oder den Rat der Geschäftsführung anweisen, dies zu tun.
Der Rat der Geschäftsführung kann im gesetzlich vorgesehenen Rahmen einstimmig die Ausschüttung von Interimdi-
videnden beschließen.
4796
L
U X E M B O U R G
Abschnitt VI. Auflösung, Liquidation
Art. 18. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren. Bei
den Liquidatoren kann es sich um natürliche oder juristische Personen handeln, die von der Gesellschafterversammlung
bestellt werden, die über die Auflösung entscheidet und die Befugnisse und die Vergütung der Liquidatoren bestimmt.
Abschnitt VII. Änderungen
Art. 19. Diese Satzung kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung geändert werden, wenn diese beschlussfähig
ist und die nach luxemburgischem Recht erforderlichen Mehrheiten erreicht werden.
Art. 20. Alle Fragen, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, sind gemäß dem Gesetz von 1915 und dem Gesetz von
2007 zu lösen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. September 2016.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Das Kapital der Gesellschaft wird folgendermaßen gezeichnet:
Die oben genannte Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, zeichnet einhundert (100) Gesellschaftsanteile gegen
eine Bareinzahlung von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-).
Der Nachweis über diese Zahlung wurde gegenüber dem unterzeichneten Notar erbracht.
<i>Kosteni>
Die von der Gesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf tausend Euro.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Als Inhaberin des gesamten gezeichneten Kapitals der Gesellschaft fasst die oben genannte Person in Ausübung der der
Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse die folgenden Beschlüsse:
(i) Die folgenden Personen werden für unbestimmte Dauer als Geschäftsführer bestellt:
- Herr Vincent Charuel, geboren am 28. Januar 1978 in Saint-Quentin, Frankreich, mit beruflicher Anschrift in 4a rue
Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
- Herr Matthias Kath-Burdack, geboren am 29. September 1970 in Jena, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in 4a
rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
- Herr Uwe Druckenmüller, geboren am 21. Juni 1961 in Albstadt-Ebingen, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in
4a rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
- Herr Florian Bauer, geboren am 7. März 1975 in Frankfurt am Main, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in Zep-
pelinstraße 1, 85748 Garching, Deutschland;
- Herr Johannes Becker, geboren am 16. März 1971 in Bad Homburg v.d.H., Deutschland, mit beruflicher Anschrift in
Zeppelinstraße 1, 85748 Garching, Deutschland.
(ii) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der vorstehend
genannten Person die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung;
auf Wunsch der vorstehend genannten Person ist bei Widersprüchen zwischen der englischen und der deutschen Fassung
die englische Fassung maßgeblich.
Daraufhin wurde der vorstehende Akt in Luxemburg, zu dem oben genannten Datum notariell beurkundet.
Nachdem der Text dem Bevollmächtigten der Erschienenen vorgelesen wurde, deren Vor- und Nachname, Status und
Wohnsitz dem Notar bekannt sind, wurde die vorliegende Urkunde im Original von dem Bevollmächtigen der Erschienenen
gemeinsam mit Uns dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: A. WAGNER, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 27. Oktober 2015. Relation: EAC/2015/24869. Erhalten fünfundsiebzig Euro
(75.- EUR).
<i>Der Einnehmer ff.i> (gezeichnet): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2015181712/476.
(150202312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
4797
L
U X E M B O U R G
European Education Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 10.008.310,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 125.331.
EXTRAIT
Il résulte de contrats de transfert de parts sociales signés en date du 5 novembre 2015 que les transferts suivants ont été
effectués:
- European Education Holdings S.à r.l., a transféré douze mille cent quarante-huit (12.148) parts sociales de classe A,
douze mille cent quarante-huit (12.148) parts sociales de classe B, douze mille cent quarante-huit (12.148) parts sociales
de classe C, douze mille cent quarante-huit (12.148) parts sociales de classe D, douze mille cent quarante-huit (12.148)
parts sociales de classe E, douze mille cent quarante-huit (12.148) parts sociales de classe F, douze mille cent quarante-
huit (12.148) parts sociales de classe G, douze mille cent quarante-huit (12.148) parts sociales de classe H, douze mille
cent quarante-huit (12.148) parts sociales de classe I et douze mille cent quarante-huit (12.148) parts sociales de classe J
qu'elle détenait dans la Société à BRIDGEPOINT EUROPE III NOMINEES 1 LIMITED, associé de la Société;
- Infinitas Learning Dutch Management B.V., associé de la Société, a transféré cent onze mille cinq cent quarante-neuf
(111.549) parts sociales de classe A, cent onze mille cinq cent quarante-neuf (111.549) parts sociales de classe B, cent onze
mille cinq cent quarante-neuf (111.549) parts sociales de classe C, cent onze mille cinq cent quarante-neuf (111.549) parts
sociales de classe D, cent onze mille cinq cent quarante-neuf (111.549) parts sociales de classe E, cent onze mille cinq cent
quarante-neuf (111.549) parts sociales de classe F, cent onze mille cinq cent quarante-neuf (111.549) parts sociales de
classe G, cent onze mille cinq cent quarante-neuf (111.549) parts sociales de classe H, cent onze mille cinq cent quarante-
neuf (111.549) parts sociales de classe I et cent onze mille cinq cent quarante-neuf (111.549) parts sociales de classe J
qu'elle détenait dans la Société à BRIDGEPOINT EUROPE III NOMINEES 1 LIMITED, associé de la Société; et
- STICHTING MANAGEMENT EEH, associé de la Société, a transféré trente-neuf mille trente (39.030) parts sociales
de classe A, trente-neuf mille trente (39.030) parts sociales de classe B, trente-neuf mille trente (39.030) parts sociales de
classe C, trente-neuf mille trente (39.030) parts sociales de classe D, trente-neuf mille trente (39.030) parts sociales de
classe E, trente-neuf mille trente (39.030) parts sociales de classe F, trente-neuf mille trente (39.030) parts sociales de classe
G, trente-neuf mille trente (39.030) parts sociales de classe H, trente-neuf mille trente (39.030) parts sociales de classe I et
trente-neuf mille trente (39.030) parts sociales de classe J qu'elle détenait dans la Société à BRIDGEPOINT EUROPE III
NOMINEES 1 LIMITED, associé de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181246/35.
(150201899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
RTCTM S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 50, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg E 5.766.
STATUTS
L’an deux mille quinze,
le vingt-six octobre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
ont comparu:
1.- Monsieur Raymond Joseph BISDORFF, enseignant-chercheur, né à Schifflange, le 12 septembre 1952 (numéro
d’identification: 1952 0912 110 06) demeurant au 50, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg;
2.- Madame Thérèse Claudine dite Tessy HEINERSCHEID, enseignante, née à Luxembourg, le 26 janvier 1955 (numéro
d’identification: 1955 0126 187 73) demeurant au 50, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg;
3.- Madame Claire Janine BISDORFF, enseignante, née à Luxembourg, le 15 juillet 1981 (numéro d’identification:
1981 0715 106 25) demeurant Flat 10 Morton House, 142, Southwold Road, Londres E5 9PB (Royaume-Uni);
4.- Monsieur Tun Antoine Claude BISDORFF, artisan de l'Etat, né à Luxembourg, le 31 décembre 1983, (numéro
d’identification: 1983 1231 117 04), demeurant au 1B, boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg; et
5.- Monsieur Max Fernand BISDORFF, étudiant en médecine, né à Luxembourg, le 16 mai 1988, (numéro d’identifi-
cation: 1988 0516 038 15) demeurant au 50, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg,
ici valablement représenté par:
son père, Monsieur Raymond BISDORFF, prénommé,
4798
L
U X E M B O U R G
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 20 octobre 2015,
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et tous les autres comparants à l'acte et le
notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d’enregistrement.
Lesquels comparants ont déclaré avoir convenu de constituer une société civile immobilière (S.CI.) dont ils vont établir
les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre les comparants, une société civile immobilière (la «Société») qui existera
entre les propriétaires actuels et futurs des parts d’intérêt ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement.
Cette Société sera régie par les présents statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises applicables et notamment par
les articles 1832 à 1872 du Code civil.
Art. 2. La Société a pour objet, dans la limite d’opérations à caractère strictement civil, et à l'exclusion de toutes opérations
à caractère commercial: l'acquisition, la vente, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs
immeubles ou parts d’immeubles tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l'étranger et la mise à disposition gratuite aux
associés.
La Société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou in-
directement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte
au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.
Art. 3. La Société prend la dénomination suivante: «RTCTM S.C.I.», société civile immobilière.
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.
Art. 4. Le siège de la Société est fixé au 50, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réunis
en assemblée générale.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours ce jour. Elle peut être dissoute par décision de
l'assemblée générale statuant à une majorité de deux tiers (2/3) des parts d’intérêt. La dissolution de la Société n’est pas
entraînée de plein droit par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un associé, ni par la cessation des fonctions
ou la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non.
Art. 6. Le capital social est fixé à TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350'000.- EUR) divisé en trois mille
cinq cents (3'500) parts d’intérêt en pleine propriété ayant chacune une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR).
Ces mêmes trois mille cinq cents (3'500) parts d’intérêt ont été souscrites par les associés comme suit:
1.- Monsieur Raymond Joseph BISDORFF, prénommé,
sept cents parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700
2.- Madame Thérèse Claudine dite Tessy HEINERSCHEID, prénommée,
sept cents parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700
3.- Madame Claire Janine BISDORFF, prénommée,
sept cents parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700
4.- Monsieur Tun Antoine Claude BISDORFF, prénommé,
sept cents parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700
5.- Monsieur Max Fernand BISDORFF, prénommé,
sept cents parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700
TOTAL: TROIS MILLE CINQ CENTS PARTS D’INTERET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3’500
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte
bancaire au nom de la Société, de sorte que la somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350’000.- EUR)
se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate
expressément.
Art. 7. Les parts d’intérêt ne sont représentées par aucun titre. Elles ne sont pas négociables.
Chaque année, l'assemblée des associés fixe la valeur d’une part d’intérêt.
Art. 8. La cession de parts d’intérêt doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. Pour être opposable
à la Société, la cession doit, conformément à l'article 1690 du Code civil, lui être notifiée par un acte authentique ou un
acte sous seing privé ou être acceptée par la gérance dans un tel acte. Pour être opposable aux tiers, la cession doit faire
l'objet d’une publicité au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Les parts d’intérêt ne peuvent être cédées entre vifs, même entre associés, qu’avec l'agrément unanime de tous les
associés. Cet agrément s’impose quelles que soient la cause et la nature de la mutation, à titre onéreux ou à titre gratuit.
A cet effet, l'associé désirant céder tout ou partie de ses parts d’intérêt, notifiera le projet de cession à chacun de ses
coassociés et à la société elle-même, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception. Cette lettre contiendra
4799
L
U X E M B O U R G
toutes les données de l'opération. A partir de la date de la réception du projet de cession, les coassociés disposent d’un délai
de trente jours calendrier pour prendre position. L’absence de réponse affirmative unanime dans ledit délai équivaut à un
refus d’agrément.
Chaque fois qu’il y a refus d’agrément, les parts d’intérêts en instance de mutation seront reprises par les autres associés,
proportionnellement au nombre de parts qu’ils possèdent, au prix calculé en application de la valeur dont question à l'article
sept (7) ci-dessus.
Pour le calcul de nombre des parts à reprendre par chaque associé, les parts en instance de mutation ne sont pas prises
en considération.
Dans le cas où un associé veut céder tout ou partie de ses parts d’intérêt et qu’il y a refus d’agrément, il lui est loisible
de renoncer à son projet de cession et de rester comme associé dans la Société.
En cas de décès d’un associé, la Société n’est pas dissoute par le fait du décès, mais continue avec les héritiers ou
légataires de l'associé décédé.
Art. 9. La Société est gérée et administrée par Monsieur Raymond Joseph BISDORFF, prénommé, en sa qualité de
gérant unique.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l'engager valablement
par sa seule signature.
Le mandat du gérant est fixé pour une durée illimitée.
Art. 10. Chaque année au 31 décembre, il est dressé un inventaire de l'actif et du passif de la Société. Cet inventaire sera
signé par tous les associés.
Les bénéfices nets constatés par cet inventaire seront partagés entre les associés. Proportionnellement à leur participation
dans le capital social, les pertes, s’il en existe, seront supportées par eux dans les mêmes proportions.
Art. 11. Chaque associé a le droit de concourir aux décisions collectives, lesquelles, y compris celles sur les modifications
statutaires, seront prises à une majorité de deux tiers (2/3) des parts d’intérêt.
Art. 12. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, sur convocation d’un
ou de plusieurs associés, mais au moins une fois par an.
Art. 13. En cas de dissolution de la Société, sa liquidation sera faite par les associés conjointement.
Art. 14. Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les
associés relativement aux affaires de la société seront soumises obligatoirement à deux arbitres, chacune des parties en
nommant un.
En cas de désaccord les deux premiers arbitres désigneront d’un commun accord un troisième arbitre et les décisions
seront prises à la majorité.
La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire et sans recours.
A défaut de nomination par l'une des parties d’un arbitre endéans la huitaine suivant invitation lui adressée par lettre
recommandée, la partie la plus diligente saisira le Président du Tribunal d‘Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
en matière de référé, qui nommera un arbitre.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunération et charges incombant à la Société en raison des présentes est estimé sans nul préjudice
à la somme de mille deux cents euros.
Dont acte, passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en
tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire instru-
mentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. BISDORFF, T. HEINERSCHEID, C. BISDORFF, T. BISDORFF, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 27 octobre 2015. Relation: EAC/2015/24866. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2015181683/124.
(150202251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
4800
AAAA (Agence Andersen & Associés) S.A.
ALUBRA S.à r.l. Luxembourg
A & M Investment S.A.
Antilope S.A.-SPF
Avion S.A.
Cabalon Investments Holding S.A.
Centre de Formation National (CFN) S.A.
Climalux S.A.
Dasco
DLX Capital S.à r.l.
Duralex S.A.
European Education Holdings S.à.r.l.
INSIDE group
Jardin Du Luxembourg GmbH
Kebec S.A.
KML
Kollector
LA Coussinerie
La Piada 5 S.A.
La Piada 5 S.A.
LBREP I Fides S.à r.l.
LBREP III CH S.à r.l.
LCE Allemagne 9 S.à r.l.
Lean4Health S.à r.l.
Luxembourg Hospitality
Luxembourg Space Telecommunication S.A.
LuxStrategy S.A.
Mansford France Fund I S. à r.l.
Marrow Architecture Group S.A.
Mogo Finance
PineBridge New Europe III GP S.à r.l.
PQ Energy Luxembourg S.à r.l.
Presidential Nursing Homes Holding III S.à r.l.
RTCTM S.C.I.
Springlux Topco S.à r.l.
Starpoint Investments (Lux) BRL S.à r.l.
Swiss Life Hotel Management S.à r.l.
Van Gelder International Button Agencies Sàrl
Vectea S.A.
VEM Financière Holdings S.A.
Victor Finance S.A.
Vodafone Procurement Company S.à r.l.
WMP I Sicav
WS&S Lux S.A.