This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 92
13 janvier 2016
SOMMAIRE
Advent Ship (Luxembourg) Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4377
Alpilla S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4374
Amaris Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4373
AMM Finance Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4375
AMP Capital Investors (IDF III JPY No. 2) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4400
AMPLEXOR International S.A. . . . . . . . . . . .
4381
Arcoop S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4373
ASA Holdings S.A., Spf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4373
Auberge La Calèche S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
4373
Auberge La Calèche S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
4373
Belfort S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4378
belRfrance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4372
CMC Mexico Limited S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
4374
CMH Holdings II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4391
Cubeo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4373
De Leo Sassone Architects S.A. . . . . . . . . . . . .
4407
Delweis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4374
Desalline S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4370
Electra Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4370
Eliseo Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4370
European Retail Enterprises II B.V. . . . . . . . .
4370
euroscript international S.A. . . . . . . . . . . . . . .
4381
Financière Vitale S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4370
Finnova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4377
FRANC AB S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4370
HollisWealth S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4377
International Packaging SC . . . . . . . . . . . . . . .
4415
Librairie Bei Der Schoul S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
4371
Librairie Bei Der Schoul S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
4371
Lobbel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4371
Lys International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4371
Magrelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4371
MET Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4377
Morgan Stanley Investment Funds . . . . . . . . .
4387
MSDK Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4374
Norvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4375
Patrono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4374
Sahu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4371
Soft S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4376
Sokaris Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4376
Transports Faber S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4372
Tudor Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4376
U.P.I. - Union de Participations et d'Investisse-
ments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4372
Valin Mittelstand Senior Debt Fund S.A., SI-
CAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4414
Venti One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4372
Vespa Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4372
Vitale Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4372
4369
L
U X E M B O U R G
Desalline S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 49.195.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184592/9.
(150206369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Eliseo Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 167.697.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184605/9.
(150205884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
European Retail Enterprises II B.V., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 113.807.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184611/9.
(150206061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Electra Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3383 Noertzange, 44, Cité Beaulieu.
R.C.S. Luxembourg B 135.783.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184625/9.
(150205692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Financière Vitale S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 160.399.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184649/9.
(150205947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
FRANC AB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 20, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 185.373.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184658/9.
(150206254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
4370
L
U X E M B O U R G
Librairie Bei Der Schoul S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4601 Differdange, 2, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 71.720.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184792/9.
(150206133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Librairie Bei Der Schoul S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4601 Differdange, 2, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 71.720.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184793/9.
(150206139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Lobbel, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9515 Wiltz, 100, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 107.061.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184796/9.
(150206054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Lys International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 180.486.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184809/9.
(150206167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Magrelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 132.350.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184821/9.
(150206161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Sahu S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 20, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 74.642.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184980/9.
(150206262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
4371
L
U X E M B O U R G
Transports Faber S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4438 Soleuvre, 206, rue de Differdange.
R.C.S. Luxembourg B 21.069.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015185036/9.
(150205600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
U.P.I. - Union de Participations et d'Investissements, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 41.793.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015185040/9.
(150206155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Vespa Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 144.504.
Les comptes annuels au 31/03/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015185044/9.
(150205945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Vitale Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 160.214.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015185049/9.
(150205949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Venti One S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 20, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 145.926.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015185055/9.
(150206282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
belRfrance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 139.590.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015185108/9.
(150206629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
4372
L
U X E M B O U R G
Cubeo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 149.299.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184571/9.
(150206414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Amaris Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 168.753.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015185159/9.
(150206832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Arcoop S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 60.765.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015185171/9.
(150207110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
ASA Holdings S.A., Spf, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 147.304.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015185175/9.
(150207217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Auberge La Calèche S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8211 Mamer, 83, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 25.478.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015185181/9.
(150207133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Auberge La Calèche S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8211 Mamer, 83, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 25.478.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015185182/9.
(150207134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
4373
L
U X E M B O U R G
CMC Mexico Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 156.389.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CMC Mexico Limited S.à r.l.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015185235/13.
(150206949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Alpilla S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 35.685.
Les comptes annuels du 1
er
janvier 2013 au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015185157/11.
(150206875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Delweis, Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 64, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 140.771.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 13 novembre 2015.
Référence de publication: 2015184589/10.
(150206362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
MSDK Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 37-39, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 170.659.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015184846/10.
(150205978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Patrono, Société Anonyme.
Siège social: L-9779 Eselborn, 18, Op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler.
R.C.S. Luxembourg B 185.119.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 13 novembre 2015.
Référence de publication: 2015184892/10.
(150206195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
4374
L
U X E M B O U R G
Norvest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 80.047.
Au nom des liquidateurs de la société NORVEST, société d'investissement à capital variable, ayant son siège social au
1, place de Metz, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.047 (la " Société "), en liquidation suivant décision de l'assemblée générale
des actionnaires de la Société du 9 novembre 2009, nous avons l'honneur de vous convoquer à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires du compartiment Norvest - Arbitrage de la Société qui se tiendra le <i>22 janvier 2016i> au 1, place de Metz
à L-1930 Luxembourg à partir de 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Information sur les opérations de liquidation des actifs de la Société ;
2. Information sur la situation financière de la Société ;
3. Information sur l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant total de 700.000,- EUR ;
4. Autorisation d'émettre un second emprunt obligataire d'un montant total de 350.000 EUR ;
5. Divers.
Représentation à l'assemblée générale:
Les propriétaires d'actions désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée devront en aviser
la Société et délivrer un certificat de blocage de leur institution financière au plus tard la veille avant l'Assemblée au siège
de la Société au 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg.
Au cas où vous ne pourriez pas assister personnellement à l'Assemblée, vous pouvez vous y faire représenter en envoyant
la formule de procuration, dûment datée et signée, par fax au numéro +352 4015 3224 et par courrier à la Banque et Caisse
d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, Service Investment Funds au 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg, dans les meilleurs
délais et au plus tard la veille avant l'Assemblée.
<i>s. les liquidateursi>
Référence de publication: 2016000005/755/28.
AMM Finance Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 99.080.
Mesdames et Messieurs les actionnaires de AMM FINANCE SICAV sont convoqués à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
de la Société qui aura lieu à l'étude de Me Hellinckx le <i>1er février 2016i> , à 11h00 afin de prendre connaissance et voter
sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de nom de la Société de "AMM Finance Sicav" en "Asset Management Model Sicav" et refonte complète
des statuts afin de les soumettre à la Loi du 17 décembre 2010 concernant les Organismes de Placement Collectif.
VOTE
Les actionnaires sont informés que cette deuxième assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital
représentée et les résolutions seront adoptées à la majorité des deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou
représentés.
Les actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration.
Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent confirmer leur présence par fax au +352.26.39.60.02 ou par
email à domiciliation@lemanik.lu en précisant leurs coordonnées au moins deux jours francs avant la tenue de l'assemblée.
Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter à cette Assemblée Générale doivent remplir et retourner le formulaire
de procuration ci-joint au numéro de fax suivant: +352. 26.39.60.02, deux jours ouvrables au moins avant la date de la
réunion de l'Assemblée Générale.
Les actionnaires peuvent obtenir le texte complet des modifications aux statuts sur simple demande et sans frais au siège
social du Fonds.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015208710/755/26.
4375
L
U X E M B O U R G
Sokaris Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5553 Remich, 26-28, Quai de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 152.267.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre der Sokaris Shipping SA, welche am <i>21. Januar 2016i> um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nach-
folgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014
3. Beschlussfassung über Gewinnverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.i>
Référence de publication: 2015201313/17.
Tudor Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5515 Remich, 9, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 147.042.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre der Tudor Investments SA., welche am <i>21. Januar 2016i> um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der
nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014
3. Beschlussfassung über Gewinnverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.i>
Référence de publication: 2015205062/17.
Soft S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 98.239.
<i>Extrait des résolutions prises à Luxembourg lors de l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire tenue extraordinai-i>
<i>rement le 9 novembre 2015i>
L'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:
- Renouvellement du mandat, avec effet immédiat, de la société Kohnen & Associés S.à r.l., ayant son siège social au
62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 114190, aux fonctions de commissaire aux comptes.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se clôturant le
31 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 Novembre 2015.
<i>Pour Soft S.A.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015182651/20.
(150202563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
4376
L
U X E M B O U R G
Finnova, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Jean Fischbach.
R.C.S. Luxembourg B 153.305.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Am 28 Dezember 2015, hat die Alleingesellschafterin der Gesellschaft das Abschließen der Liquidation der Gesellschaft
mit sofortiger Wirkung beschlossen.
Des weiteren hat die Alleingesellschafterin beschlossen die Bücher und Dokumente der Gesellschafter für eine Dauer
von fünf Jahren ab der Veröffentlichung des Abschlusses der Auflösung im Amtsblatt des Großherzogtum Luxemburg in
2, rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange, Großherzogtum Luxemburg aufzubewahren.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FINNOVA (en liquidation volontaire)
Unterschrift
<i>Ein bevollmächtigter Vertreteri>
Référence de publication: 2016002901/18.
(160001563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
HollisWealth S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 65, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 70.415.
CLOSURE OF LIQUIDATION
<i>Extraiti>
La liquidation d'HOLLISWEALTH S.A. (la "Société") a été clôturée à la date du 18 décembre 2015, en vertu d'une
résolution prise par l'actionnaire unique de la Société.
Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir de la date de la
clôture de la liquidation à l'adresse de la société 1832 L.P., dont le siège social est au Dynamic Funds Tower, 1 Adelaide
Street, 28
th
Floor, Toronto, ON M5C 2V9.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2016.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016002075/17.
(160000862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
MET Fonds, Fonds Commun de Placement.
Die Änderungsvereinbarung betreffend die Sonderreglements des Fonds MET Fonds, welche am 25. August 2015 in
Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Référence de publication: 2015208663/9.
(150233795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Advent Ship (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 154.655.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Référence de publication: 2015180971/10.
(150202254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
4377
L
U X E M B O U R G
Belfort S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 102.735.
In the year two thousand and fifteen, on the thirty-first day of December,
Before the undersigned, Henri BECK, notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
is held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Belfort S.A., a public limited liability company
organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 10A, rue Henri
Schnadt, L-2530 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies, under number B 102735 (the
Company).
The Company was incorporated under the name Carfinco, S.à r.l. on 16 August 2004, pursuant to a deed drawn up by
Maître Jean Seckler, notary resident in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the Mémorial) number 1163, page 55781 of 17 November 2004. Since that date, the
Company’s articles of association (the Articles) have been amended, most recently on 22 August 2005 pursuant to a deed
drawn up by the abovementioned Maître Jean Seckler, published in the Mémorial under number 126, page 6003 on 19
January 2006.
The Meeting is opened at 13:10 p.m. and chaired by Joseph Moroney, lawyer, with professional address at 18-20 rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Phillipe Toussaint, private employee, residing professionally at 10A, rue Henri
Schnadt, L-2530 Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Eric Tazzieri, private employee, residing professionally at 24, rue Astrid, L-1143
Luxembourg.
The Meeting’s officers having thus been appointed, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the shareholders have been convened to the Meeting by registered letters sent on 22 December 2015.
II. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list signed by the shareholders or their authorised representatives, the Meeting’s officers and the notary. This attendance
list and the powers of attorney will be registered with this deed.
III. That it appears from the attendance list that all of the voting shares are present or represented. The Meeting is thus
regularly constituted and may deliberate and decide on the items on its agenda.
IV. That the agenda of the Meeting is as follows:
1. Acknowledgement of the joint cross-border merger proposal providing for the absorption by the Company of its 100%
subsidiary Intractor B.V., a private limited liability company under Dutch law (besloten vennootschap met beperkte aans-
prakelijkheid);
2. Acknowledgement that all the documents required by articles 267 and 278 of the Luxembourg law on commercial
companies dated 10 August 1915, as amended have been deposited at the Company’s registered office or its website for
due inspection by the shareholders at least one month before the date of the general meeting of shareholders of the Company
resolving on the joint draft merger terms;
3. Approval of the joint cross-border merger proposal and decision to carry out the merger by way of the absorption by
the Company of Intractor;
acknowledgment that from an accounting point of view, the operations of Intractor will be treated as having being carried
out on behalf of the Company as from effective date of the merger; acknowledgment of the effective date of the merger
between parties and of the date of enforceability of the merger towards third parties;
4. Granting of all powers to any member of the Company’s board of directors and to any lawyer of Loyens & Loeff
Luxembourg SARL, acting individually, with full power of substitution, to execute any documents and perform any actions
and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the merger; and
V. That the Meeting has unanimously taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting notes that it has been acquainted with the joint cross-border merger proposal dated 24 November 2015,
published in the Mémorial, number 32030 of 30 November 2015 (the Joint Merger Proposal), in accordance with article
262 of the law of August 15, 1915 on commercial companies (the Law) and providing for the absorption by the Company
of Intractor B.V., a private limited liability company under Dutch law (besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid), having its official seat in Rotterdam, the Netherlands and its registered office address at Rapenburgerstraat 177,
J, 1011VM Amsterdam, the Netherlands, registered with the Dutch trade register of the Chamber of Commerce under
number 24134050 (the Company Ceasing to Exist and together with the Company, the Merging Companies or individually,
a Merging Company).
4378
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Meeting acknowledges that the Joint Merger Proposal, the Merging Companies’ annual accounts and annual reports
(if any) of the last three financial years and the Merging Companies interim balance sheet dated 15 October 2015 have
been deposited at the Company’s registered office or its website, if any, for due inspection by the shareholders at least one
month before the date hereof. The Meeting further acknowledges that the shareholders of each Merging Company as well
as the holders of other securities giving a voting right have unanimously waived the requirement of a special board report
explaining and justifying the merger from a legal and economic point of view.
A certificate attesting the deposit of said documents, duly signed by an authorised representative of the Company, and
a unanimous waiver of the special board report explaining and justifying the merger from a legal and economic point of
view and of the requirement for the board of directors of each Merging Company to inform the general meeting about any
major change in the assets and liabilities of the Merging Companies which would have taken place between the date when
the joint cross-border merger proposal was drawn up and today has been given to the notary.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to approve the Joint Merger Proposal and to carry out the merger by way of the absorption by the
Company of the Company Ceasing to Exist, in accordance with the conditions detailed in the Joint Merger Proposal. The
Meeting acknowledges (i) the dissolution without liquidation of the Company Ceasing to Exist as per the effective date by
way of transfer of all the assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist to the Company, all in accordance with the
Joint Merger Proposal and (ii) the cancellation, as a consequence of the merger, of the shares held by the Company in the
Company Ceasing to Exist.
The Meeting further acknowledges (i) that from an accounting point of view, the operations of the Company Ceasing
To Exist will be treated as having being carried out on behalf of the Company as from effective date of the merger, (ii) that
the merger takes effect between the Merging Companies and is enforceable towards third parties after the publication in
the Mémorial of the minutes of the general meetings of the Merging Companies’ shareholders approving the merger.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting grants all powers to any member of the Company’s board of directors and to any lawyer of Loyens & Loeff
Luxembourg SARL, acting individually, with full power of substitution, to execute any documents and perform any actions
and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the merger.
<i>Declarationi>
The undersigned notary states, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, having verified and
certifies the existence and the validity of the legal acts and formalities incumbent upon the Company and of the Joint Merger
Proposal and, in particular, that the merging companies have approved the Joint Merger Proposal in the same terms.
There being no further business, the Meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing parties, this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences, the English text prevails.
WHEREOF, this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Meeting’s officers and the shareholders’ authorised represen-
tative.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le trente-et-unième jour de décembre,
Par-devant le soussigné, Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,
Se tient
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de Belfort S.A., une société anonyme organisée
et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
102735 (la Société).
La Société a été constituée sous la dénomination Carfinco, S.à r.l. le 16 août 2004, suivant acte reçu par Maître Jean
Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le Mémorial) numéro 1163, page 55781 du 17 novembre 2004. Depuis, les statuts de la Société (les Statuts)
ont été modifiés le plus récemment le 22 aout 2005 suivant acte reçu par Jean Seckler, précité, publié au Mémorial numéro
126, page 6003 du 19 janvier 2006.
L’Assemblée a commencé à 13 heures 10 sous la présidence de Joseph Moroney, avocat, avec adresse professionnelle
à 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
Le président nomme Philippe Toussaint, employé privé, avec adresse professionnelle à 24, rue Astrid, L-1143 Luxem-
bourg comme secrétaire.
4379
L
U X E M B O U R G
L’Assemblée nomme Eric Tazzieri, employé privé, avec adresse professionnelle à 10A, rue Henri Schnadt, L-2530
Luxembourg comme scrutateur.
Le bureau de l’Assemblée ayant été formé, le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Que les actionnaires ont été convoqués à l’Assemblée par lettres recommandées envoyées le 22 décembre 2015.
II. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre de leurs actions sont renseignés sur une liste de présence
signée par les actionnaires ou leurs représentants, par le bureau de l’Assemblée et le notaire. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations seront enregistrées avec le présent acte.
III. Qu’il ressort de la liste de présence que toutes les actions à droit de vote sont présentes ou représentées. L’Assemblée
est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer et décider sur les points de son ordre du jour.
IV. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Prise d’acte du projet commun de fusion transfrontalière prévoyant l’absorption par la Société de sa filiale à 100%
Intractor B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais (besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid);
2. Prise d’acte que tous les documents requis par les articles 267 et 278 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été déposés au siège social de la Société ou mis sur son site internet pour que les
actionnaires puissent en prendre connaissance au moins un mois avant la date de réunion de l’assemblée générale des
actionnaires de la Société se prononçant sur le projet commun de fusion transfrontalière;
3. Approbation du projet commun de fusion transfrontalière et décision d’exécuter la fusion par absorption par la Société
de Intractor; prise d’acte que, d’un point de vue comptable, les opérations de Intractor seront traitées comme si elles avaient
été exécutées pour le compte de la Société à compter de la date d’effet de la fusion; prise d’acte de la date de réalisation
de la fusion entre les parties et de la date d’effet de la fusion envers les tiers;
4. Pouvoir et autorité à tout membre du conseil d’administration de la Société et à tout avocat de Loyens & Loeff
Luxembourg SARL, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, afin d’exécuter tous documents
et d’accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la
fusion; et
5. Divers.
V. Que l’Assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée note qu’elle a pris connaissance du projet commun de fusion transfrontalière daté du 24 novembre 2015,
publié au Mémorial, numéro 32030 du 30 novembre 2015 (le Projet Commun de Fusion) conformément à l’article 262 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et prévoyant l’absorption par la Société de
Intractor B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais (besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid) dont le siège social se situe à Rotterdam, les Pays-Bas et son adresse à Rapenburgerstraat 177, J, 1011VM
Amsterdam, les Pays-Bas, immatriculée au registre du commerce néerlandais de la Chambre de Commerce sous le numéro
24134050 (la Société Absorbée et ensemble avec la Société, les Sociétés qui Fusionnent ou individuellement, une Société
qui Fusionne).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le Projet Commun de Fusion, les comptes annuels et, le cas échéant, les rapports annuels
des Sociétés qui Fusionnent des trois derniers exercices et le bilan intérimaire des Sociétés qui Fusionnent daté du 15
octobre 2015 ont été déposés au siège social de la Société ou, le cas échéant, mis sur son site internet pour que les actionnaires
puissent en prendre connaissance au moins un mois avant la date des présentes. L’Assemblée prend par ailleurs acte que
les actionnaires de chaque Société qui Fusionne ainsi que les détenteurs d’autres titres donnant un droit de vote ont à
l’unanimité renoncé à l’exigence d’un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant la fusion d’un point de vue juridique et
économique.
Un certificat attestant le dépôt de ces documents, dûment signé par un représentant autorisé de la Société, ainsi qu’une
renonciation unanime au rapport écrit détaillé expliquant et justifiant la fusion d’un point de vue juridique et économique
et à l’exigence pour les conseils d’administration de chacune des Sociétés qui Fusionnent d’informer l’assemblée générale
de toute modification importante de l’actif et du passif qui aurait eu lieu entre la date de l’établissement du Projet Commun
de Fusion et la date d’aujourd’hui a été remis au notaire.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide d’approuver le Projet Commun de Fusion et d’effectuer la fusion par absorption de la Société
Absorbée par la Société, conformément aux conditions détaillées dans le Projet Commun de Fusion. L’Assemblée prend
acte (i) de la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée à la date d’effet par transfert de tous les actifs et passifs
de la Société Absorbée à la Société, en conformité avec le Projet Commun de Fusion et (ii) de l’annulation, en conséquence
de la fusion, des actions détenues par la Société dans la Société Absorbée.
L’Assemblée prend ensuite acte (i) que d’un point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée seront traitées
comme si elles avaient été exécutées pour le compte de la Société depuis la date d’effet de la fusion, (ii) que la fusion est
4380
L
U X E M B O U R G
réalisée entre les Sociétés qui Fusionnent et n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication au Mémorial des procès-
verbaux des assemblées générales qui approuvent la fusion pour chacune des Sociétés qui Fusionnent.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner pouvoir et autorité à tout membre du conseil d’administration de la Société et à tout
avocat de Loyens & Loeff Luxembourg SARL, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, afin
d’exécuter tous documents et d’accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhai-
tables en relation avec la fusion.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare, conformément à l’article 271(2) de la Loi, avoir vérifié et certifie l’existence et la légalité
de tous actes et formalités incombant à la Société et du Projet Commun de Fusion, et notamment que les sociétés qui
fusionnent ont approuvé le Projet Commun de Fusion dans les mêmes termes.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le bureau et le mandataire des parties comparantes.
Signé: J. MORONEY, P. TOUSSAINT E. TAZZIERI, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 janvier 2016. Relation: GAC/2016/90. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 06 janvier 2016.
Référence de publication: 2016005346/193.
(160004951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
AMPLEXOR International S.A., Société Anonyme,
(anc. euroscript international S.A.).
Siège social: L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 122.347.
Im Jahre zweitausendfünfzehn, den zehnten Dezember,
Vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle BADEN, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg,
Wurde abgehalten:
Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft "euroscript International S.A.", mit
Sitz in L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter
der Nummer B 122.347, gegründet gemäß notarieller Urkunde am 8. Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Nummer 2419 vom 28. Dezember 2006.
Die Gesellschaftssatzung wurde zuletzt, gemäß notarieller Urkunde am 22. Oktober 2014, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 3621 vom 28. November 2014, abgeändert.
Die Versammlung wird um 9.50 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Cheryl GESCHWIND, Privatangestellte, mit Beruf-
sanschrift in L-1212 Luxemburg, 17, rue des Bains, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Martine ZELLINGER, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in L-1212 Lu-
xemburg, 17, rue des Bains.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Peter STEINLE, Privatangestellter, mit Berufsanschrift
in L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I.- Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
<i>Tagesordnung:i>
1. Namensänderung der Gesellschaft in „AMPLEXOR International S.A.“, rückwirkend zum 9. Dezember 2015;
2. Neuformulierung der Gesellschaftssatzung;
3. Verschiedenes.
II.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Stückzahl
ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden Aktio-
4381
L
U X E M B O U R G
näre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Vorstandsmitglieder unterschrieben wurde, bleibt gegen-
wärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben hinterlegt zu werden.
Die Vollmachten, welche durch die Erschienenen "ne varietur" unterschrieben wurden, bleiben der gegenwärtigen Ur-
kunde beigefügt.
III.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten
ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
beschließen.
IV.- Dass die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß gebildet ist und sodann zu vorstehender Tagesord-
nung beschlussfähig ist.
Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den Namen der Gesellschaft, rückwirkend zum 9. Dezember 2015, in „AMPLE-
XOR International S.A.“ umzuändern.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt die Satzung der Gesellschaft neu zu formulieren. Die Gesellschaftssatzung lautet
ab sofort wie folgt:
„ Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und führt den Namen „AMPLEXOR
International S.A.“.
Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von jeglichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung,
der Bearbeitung und Übersetzung sowie der Verbreitung von Dokumenten und Daten aller Art, einschließlich der Über-
nahme von Geschäftsprozessen, der Beratung, dem Verkauf von Hardware und Softwarelizenzen, der Softwareentwicklung
und - implementierung sowie des Betriebs von Rechenzentren. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften im
In- und Ausland mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck in jeder Weise beteiligen, die Geschäfte solcher Ge-
sellschaften führen und für diese in jeder Weise tätig werden. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die der
Erreichung ihres Zwecks förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehn-
hundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesellschaftsgesetz“) zulässig sind.
Die Gesellschaft hat außerdem als Zweck die Erbringung von Dienstleistungen, unter anderem im Bereich der Allge-
meinen Verwaltung, Finanzen (inkl. Rechnungswesen und Controlling), IT, Marketing und Human Resources für die
Tochtergesellschaften im In- und Ausland.
Art. 4.
(1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bertrange. Durch einfachen Beschluss des Vorstandes mit Zustimmung
des Aufsichtsrates können jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im
Ausland gegründet werden.
(2) Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft nach
Ansicht des Vorstandes und des Aufsichtsrates in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz eingeschränkt oder der reibungslose
Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird oder falls eine solche Einschränkungen oder
Behinderung unmittelbar bevorsteht, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Vorstandes mit Zus-
timmung des Aufsichtsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt
werden. Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische Staatszugehörigkeit der Gesellschaft nicht.
II. Kapital - Aktien
Art. 5.
(1) Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 470.588 (vierhundertsiebzigtausendfünfhundertachtundachtzig Euro) und ist
in 200.000 (zweihunderttausend) Aktien der Klasse 1 und 35.294 (fünfunddreißigtausendzweihundertvierundneunzig)
Aktien der Klasse 2 mit einem Nominalwert von je EUR 2,00 (zwei Euro) eingeteilt. Mit den Aktien der Klasse 1 und der
Klasse 2 sind dieselben Rechte und Pflichten verbunden.
(2) Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in
der für Satzungsänderungen geltenden Form zu fassen ist, erhöht oder herabgesetzt werden. Die Gesellschaft kann innerhalb
der gesetzlich zulässigen Beschränkungen eigene Aktien erwerben.
(3) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzes kann die Hauptversammlung der Aktionäre Aktien ver-
schiedener Aktienklassen ausgeben. Die mit diesen Aktienklassen verbundenen besonderen Rechte werden durch diese
Satzung festgelegt. In dieser Satzung ist jede Bezugnahme auf „Aktien“ und „Aktionäre“ im Plural wie auch im Singular
als Bezugnahme auf „Aktien aller Aktienklassen“ und „Aktionäre aller Aktienklassen“ zu verstehen soweit nicht anders
vorgesehen.
4382
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben. Der Tod oder die Auflösung des alleinigen Aktionärs
(oder eines anderen Aktionärs) führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.
Art. 7.
(1) Die Aktien sind ausschließlich Namensaktien, vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen.
(2) Es können Aktienzertifikate über Namensaktien ausgestellt werden. Diese Aktienzertifikate sind von zwei Vors-
tandsmitgliedern zu unterzeichnen.
(3) Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Recht an einer Aktie geteilt, abgeleitet oder
streitig sein, müssen diejenigen, die das Recht an der Aktie geltend machen, einen einzigen Bevollmächtigten ernennen
um die Aktie gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Wahrnehmung aller Rechte bezüglich
dieser Aktie suspendieren, bis eine einzige Person zum Rechtsinhaber an der Aktie im Verhältnis zur Gesellschaft ernannt
worden ist.
III. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 8.
(1) Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat jegliche
Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Gesellschaft,
welche nicht ausdrücklich dem Vorstand/Aufsichtsrat vorbehalten sind. Besitzt die Gesellschaft lediglich einen Aktionär,
übt dieser Aktionär die Funktion der Hauptversammlung der Aktionäre aus.
(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Kapitals vertreten, einberufen werden.
Aktionäre, die wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft vertreten, können verlangen, dass ein oder
mehrere Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung der Aktionäre gesetzt werden. Eine solche Eingabe muss
an den Sitz der Gesellschaft geschickt werden und der Gesellschaft wenigstens fünf (5) Tage vor dem Datum der Haupt-
versammlung der Aktionäre zugehen.
Art. 9.
(1) Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten
Ort innerhalb der Gemeinde Bertrange jeweils um 12.00 Uhr am letzten Montag des Monats Mai eines jeden Jahres oder,
wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Werktag statt. Andere, außerordentliche Haupt-
versammlungen können an dem im Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkt und Ort abgehalten werden.
(2) Die erforderlichen Anwesenheits-Quoren sowie die gesetzlich erforderlichen Fristen und die Leitung der Versamm-
lung der Aktionäre der Gesellschaft werden im jeweiligen Einberufungsschreiben aufgeführt, soweit diese Satzung keine
anderweitige Bestimmung trifft.
(3) Aktionäre können an Hauptversammlungen der Aktionäre durch Videokonferenz oder durch andere Kommunika-
tionsmittel teilnehmen, die die Identifizierung der Teilnehmer zulassen, es ihnen erlauben sich ständig gegenseitig zu hören
und wirksam teilzunehmen. Die derart beteiligten Aktionäre sind für die Berechnung des Quorums und der Mehrheit als
anwesend anzusehen.
(4) Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per
E-Mail oder Telefax bevollmächtigten Dritten vertreten lassen. Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn die an-
wesenden oder vertretenen Aktionäre mindestens die Hälfte aller Stimmen haben, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung
ein anderes Anwesenheitsquorum vorgesehen ist. Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung
werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst, sofern das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung keine anderweitige Bestimmung treffen.
(5) Der Vorstand kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an
einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können. Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder
vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu kennen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten
werden.
IV. Vorstand
Art. 10.
(1) Der Unterparagraf 2 zum § 4 des Gesellschaftsgesetzes ist anwendbar auf die Gesellschaft, soweit in der vorliegenden
Satzung nichts anderes bestimmt ist.
(2) Die Gesellschaft wird durch einen Vorstand verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Ak-
tionäre sein müssen. Die Mitglieder werden vom Aufsichtsrat für eine Dauer gewählt werden, die fünf Jahre nicht
überschreiten darf; sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Aufsichtsrat abberufen werden; der Aufsichtsrat
wählt sie mit einfacher Mehrheit und bestimmt ihre nähere Anzahl und ihre Bezüge. Vorstandsmitglieder können wieder
gewählt werden.
(3) Sofern (i) die Gesellschaft nur einen Alleinaktionär hat oder (ii) ihr Aktienkapital geringer als EUR 500.000.-
(fünfhunderttausend Euro) ist kann der Vorstand aus einem oder mehreren Mitgliedern bestehen.
4383
L
U X E M B O U R G
(4) Scheidet in Folge des Todes, Rücktritts oder aus einem sonstigen Grund ein Vorstandsmitglied aus seinem Amt, so
kann das freigewordene Amt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, vorläufig bis zur nächsten Sitzung des Aufsichtsrates
besetzt werden. Besteht der Vorstand nur aus einem Mitglied, so kann im vorausgehenden Fall das freigewordene Amt
vorläufig bis zur nächsten Sitzung des Aufsichtsrates durch ein Mitglied des Aufsichtsrates besetzt werden, welches vom
Aufsichtsrat bestimmt wird. Während dieser Zeit ruht für dieses Mitglied des Aufsichtsrates seine Funktion als Aufsichtsrat.
Die nächste Sitzung des Aufsichtsrates zur endgültigen Neubesetzung findet möglichst zeitnah zur vorbenannten vorläu-
figen Besetzung statt.
(5) Der Vorstandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden durch den Aufsichtsrat bestellt. Der Vorstand kann einen
Sekretär, welcher für die Protokollierung der Sitzungen des Vorstands verantwortlich ist und kein Vorstandsmitglied sein
muss, bestimmen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Vorstands. Im Falle der Verhinderung des Vorsi-
tzenden übernimmt der Stellvertreter zeitweilig den Vorsitz. Bei Verhinderung des Vorsitzenden und des Stellvertreters
bestimmen die anwesenden Vorstandsmitglieder mit einfacher Mehrheit der Stimmen der Anwesenden ein Vorstandsmit-
glied zum zeitweiligen Vorsitzenden.
(6) Sofern ein Vorstandsmitglied eine juristische Person ist, muss es eine natürliche Person als seinen permanenten
Vertreter ernennen, der das Mandat im Namen für Rechnung der juristischen Person ausübt. Der permanente Vertreter ist
für die Ausübung seines Mandates in gleichem Maße haftbar, als wenn er in eigenem Namen und für eigene Rechnung
handeln würde, unbeschadet der gesamtschuldnerischen Haftung der durch ihn vertretenen juristischen Person. Letztere
kann ihren permanenten Vertreter nur abberufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen neuen permanenten Vertreter ernennt.
Art. 11.
(1) Der Vorstand wird vom Vorsitzenden, seinem Stellvertreter oder auf Antrag von zwei Vorstandsmitgliedern einbe-
rufen.
(2) Die Einberufungen zu jeder Vorstandssitzung erfolgen separat an jedes Mitglied. Außer in Dringlichkeitsfällen,
deren Natur und Gründe in dem Einberufungsschreiben erwähnt werden müssen, muss das Einberufungsschreiben we-
nigstens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Sitzungstermin zugegangen sein.
(3) Auf das Einberufungsschreiben kann durch schriftliche Zustimmung, E-Mail, Fax oder ein vergleichbares Kom-
munikationsmittel seitens jedes Vorstandsmitglieds verzichtet werden. Ein gesondertes Einberufungsschreiben ist auch
dann nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung in einem vorausgehenden Vorstandsbeschluss festgelegt wurden.
Sogar ohne Einberufungsschreiben ist eine Sitzung als rechtmäßig abgehalten zu betrachten, falls alle Vorstandsmitglieder
anwesend oder vertreten sind.
(4) Die Sitzungen finden an den im Einberufungsschreiben erwähnten Ort, Tag und Stunde statt.
(5) Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Besteht der
Vorstand aus zwei Mitgliedern, so ist der Vorstand nur beschlussfähig, wenn beide Mitglieder anwesend sind. Der Anwe-
senheit ist gleichzusetzen die Teilnahme per Telefon oder Videokonferenz oder durch ein vergleichbares Kommunika-
tionsmittel, sofern alle teilnehmenden Mitglieder sich untereinander verständigen und verstehen und so effektiv an der
Sitzung teilnehmen können.
(6) Jedes Vorstandsmitglied kann sich in einer Sitzung des Vorstands aufgrund einer schriftlich, per Fax, per E-Mail
oder in vergleichbarer Weise erteilten Vollmacht durch ein anderes Vorstandsmitglied vertreten lassen. Ein Vorstands-
mitglied kann mehrere andere Vorstandsmitglieder vertreten.
(7) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit der auf der Sitzung anwesenden oder ver-
tretenen Vorstandsmitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend (soge-
nanntes „casting vote“). Dieses casting vote steht nicht dem Stellvertreter des Vorsitzenden oder zeitweiligen Vorsitzenden
im Sinne des Artikels 10 Absatz 5 zu. Lässt der Vorsitzende sich bei einer Sitzung durch ein anderes Vorstandsmitglied
vertreten, so kann dieses Vorstandsmitglied im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis das casting vote für und im Namen
des Vorsitzenden ausüben.
(8) Eine Beschlussfassung ist auch im schriftlichen Umlaufverfahren zulässig. Schriftlich gefasste einstimmige Bes-
chlüsse, die von allen Vorstandsmitgliedern genehmigt und unterschrieben sind, sind genauso rechtswirksam wie anlässlich
einer Vorstandssitzung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehr-
fachen Abschriften eines identischen Beschlusses stehen und können bestätigt werden durch Brief, oder Fernschreiben;
die Gesamtheit aller Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung dient.
(9) Ein Vorstandsmitglied, welches entgegengesetzte Interessen hat gegenüber der Gesellschaft in einer Angelegenheit,
welche dem Vorstand zu Genehmigung vorgelegt wird, ist verpflichtet, den Vorstand hierüber zu benachrichtigen und muss
die diesbezügliche Eintragung in den Sitzungsbericht anstreben. Dieses Vorstandsmitglied wird nicht an dem betreffenden
Beschluss des Vorstands teilnehmen. Die Bestimmungen dieses Absatzes finden keine Anwendung, wenn der Vorstand
nur aus einem Mitglied besteht. Im letzten Fall wird im Sitzungsprotokoll vermerkt, welche Geschäfte bzw. Handlungen
zwischen der Gesellschaft und dem Vorstand gemacht wurden, bei welchen der Vorstand der Gesellschaft entgegen gesetzte
Interessen hatte.
(10) Bevor die nächstfolgende Sitzung des Vorstands über andere Punkte zu beschließen hat, müssen die Aktionäre
Kenntnis erhalten von den Fällen, in welchen ein Vorstandsmitglied einen Interessenkonflikt gegenüber der Gesellschaft
hat.
4384
L
U X E M B O U R G
(11) Für den Fall, dass ein Vorstandsmitglied sich wegen eines Interessenkonfliktes enthält, werden Beschlüsse, welche
durch die Mehrheit der anderen Vorstandsmitglieder in solch einer Sitzung gefasst werden, als gültig angesehen.
Art. 12.
(1) Die Protokolle der Sitzungen des Vorstands werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit von zwei Vors-
tandsmitgliedern unterschrieben. Sofern Vorstandssitzungen durch ein schriftliches Verfahren ersetzt werden, sind die dem
schriftlichen Verfahren zugrunde liegenden Unterlagen zusammenzuführen; Satz 1 dieses Absatzes findet entsprechende
Anwendung.
(2) Abschriften oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom
Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet.
Art. 13.
(1) Der Vorstand hat die weitest gehenden Befugnisse um alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Interesse
der Gesellschaft vorzunehmen. Der Vorstand wird die Gesellschaft vor Gericht als Klägerin oder als Beklagte vertreten.
Er kann hierzu geeignete Personen bevollmächtigen.
(2) Der Vorstand ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesellschaftsgesetz und durch die gegen-
wärtige Satzung der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten ist.
(3) Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können
gemäß Artikel 60 des Gesellschaftsgesetzes auf ein oder mehrere Vorstandsmitglieder, leitende Angestellte, Geschäfts-
führer oder sonstige Vertretungsberechtigte übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse
werden durch Beschluss des Vorstands geregelt.
(4) Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte
Vollmacht auf ein oder mehrere Vorstandsmitglieder oder auf Dritte übertragen.
Art. 14.
(1) Alle Schriftstücke sowie jede Ernennung von Bevollmächtigten verpflichten die Gesellschaft rechtskräftig, wenn
dieselben von zwei Vorstandsmitgliedern oder von einem im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Dele-
gierten des Vorstands unterschrieben werden.
Wurde nur ein Vorstandsmitglied gewählt, so genügt die Unterschrift dieses einzelnen Vorstandsmitglieds.
(2) Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern oder durch die gemeinsame
Unterschrift eines Vorstandsmitgliedes zusammen mit der Unterschrift eines Vertretungsberechtigten, so wie vom Vorstand
ernannt, rechtmäßig gegenüber von Drittparteien vertreten.
V. Aufsichtsrat
Art. 15.
(1) Die Gesellschaft wird durch einen Aufsichtsrat überwacht, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine
Aktionäre sein müssen. Falls die Gesellschaft einen Alleinaktionär hat oder wenn in einer Hauptversammlung festgestellt
wird, dass alle ausgegebenen Aktien der Gesellschaft von einem Aktionär gehalten werden, kann der Aufsichtsrat aus einem
Mitglied oder mehreren bestehen. Satz 2 dieses Absatzes gilt bis zur ersten jährlichen ordentlichen Hauptversammlung
welche auf den Zeitpunkt folgt, an dem die Gesellschaft feststellt, dass die Voraussetzungen von Satz 1 dieses Absatzes
nicht mehr vorliegen.
(2) Sofern ein Mitglied des Aufsichtsrates keine natürliche Person ist, muss es eine natürliche Person als seinen per-
manenten Vertreter ernennen, der das Mandat im Namen und für Rechnung der juristischen Person ausübt. Der permanente
Vertreter ist für die Ausübung seines Mandates in gleichem Maße haftbar, als wenn er in eigenem Namen und für eigene
Rechnung handeln würde, unbeschadet der gesamtschuldnerischen Haftung der durch ihn vertretenen juristischen Person.
Letztere kann ihren permanenten Vertreter nur abberufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen neuen permanenten Vertreter
ernennt.
(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Hauptversammlung der Gesellschafter für eine Dauer gewählt,
die fünf Jahre nicht überschreiten darf; sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen von der Hauptversammlung der
Gesellschafter abberufen werden; die Hauptversammlung der Gesellschafter wählt sie mit einfacher Mehrheit und bestimmt
ihre Anzahl und ihre Bezüge. Aufsichtsräte können wieder gewählt werden.
(4) Der Aufsichtsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit, einen
stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Aufsichts-
rates sein muss, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Aufsichtsrates verantwortlich ist. Sollte bei der Wahl des
Vorsitzenden keine Mehrheit zustande kommen, wählt die Hauptversammlung einen Vorsitzenden.
(5) Die Geschäftsführung des Vorstands wird vom Aufsichtsrat überwacht. Der Aufsichtsrat nimmt nicht an der Ge-
schäftsführung der Gesellschaft teil und hat diesbezüglich keine Befugnisse. Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschaft nicht
gegenüber Dritten.
(6) Die folgenden Geschäfte der Gesellschaft und der von ihr beherrschten Unternehmensgruppe bedürfen einer vorhe-
rigen Zustimmung durch den Aufsichtsrat:
(i) alle über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehende Geschäftsführungsmaßnahmen;
4385
L
U X E M B O U R G
(ii) Feststellung der jährlich vor Beginn eines Geschäftsjahres aufzustellenden Planung für das folgende Geschäftsjahr,
bestehend aus Umsatz- und Ergebnisplan, Finanzplan, Personalplan und Investitionsplan
(iii) Erwerb, Veräußerung, Auflösung, Kündigung und Belastung von wesentlichen Beteiligungen an anderen Unter-
nehmen;
(iv) Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken und Rechten an solchen, sowie Veräußerung oder Belastung
von Teilen der Geschäftsvermögens, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen;
(v) Vornahme von Investitionen, welche den vom Aufsichtsrat für das einzelne Geschäftsjahr gemäß Art. 15 (6) (ii)
festgesetzten Rahmen - wenn ein solcher nicht festgesetzt ist, den des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs - überschreiten;
(vi) Aufnahme von langfristigen Krediten jeder Art sowie Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen
Haftungen, welche den vom Aufsichtsrat für das einzelne Geschäftsjahr gemäß Art. 15 (6) (ii) festgesetzten Rahmen - wenn
ein solcher nicht festgesetzt ist, den des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs - überschreiten;
(vii) Abschluss von Miet- oder sonstigen Dauerschuldverhältnissen - soweit nicht gem. Art. 15 (6) (ii) budgetiert - mit
einer Vertragsdauer von mehr als einem Jahr und/oder mit einer Belastung von mehr als 300.000 EUR (dreihunderttausend
Euro);
(viii) Bestellung von Organmitgliedern wesentlicher Beteiligungsgesellschaften und Erteilung von Prokura oder ähn-
licher Vollmachten anderer Rechtsordnungen;
(ix) alle Maßnahmen, die der Aufsichtsrat dem Vorstand gegenüber als zustimmungspflichtig bezeichnet.
(7) Sollte der Aufsichtsrat seine Zustimmung zu einem dieser Geschäfte nach Absatz 6 verweigern, kann der Vorstand
dieses auf der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre zur Genehmigung durch die Gesellschafter vorlegen. Sollte die
Hauptversammlung ihre Zustimmung erteilen, so gilt die Zustimmung des Aufsichtsrates zu diesem Geschäft als erteilt.
Sollte sie ihre Zustimmung verweigern, so gilt die Zustimmung zu diesem Geschäft als endgültig verweigert.
(8) Artikel 10 (4); Artikel 11 und Artikel 12 dieser Satzung sind auf den Aufsichtsrat entsprechend anwendbar mit der
Maßgabe, dass (i) jeweils der Begriff „Sitzung des Aufsichtsrates“ durch den Begriff „Hauptversammlung der Gesell-
schafter“ und die Begriffe „Vorstand“ und Vorstandsmitglieder“ durch die Begriffe „Aufsichtsrat“ und „Aufsichtsrats-
mitglieder“ zu ersetzen sind und (ii) zusätzlich für eine gültige Beschlussfassung des Aufsichtsrates zumindest die
Zustimmung eines durch die Aktionäre der Aktienklasse 1 vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieds erforderlich ist.
(9) Der Vorstand erstattet alle drei (3) Monate dem Aufsichtsrat schriftlich Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft
und übermittelt nach Maßgabe des Aufsichtsrates diesem zu gegebener Zeit alle Informationen und Dokumente, die einen
erheblichen Einfluss auf ihre Geschäfte oder ihre Lage haben können. Der Aufsichtsrat hat ein unbeschränktes Frage - und
Auskunftsrecht gegenüber dem Vorstand und kann zu jeder Zeit Einsicht in die Bücher und Gesellschaftsdokumente der
Gesellschaft nehmen sowie die alle ihm notwendig erscheinenden Überprüfungen zur Erfüllung seiner Aufgabe vornehmen.
(10) Kein Aufsichtsrat kann gleichzeitig die Funktion eines Vorstandsmitglieds innehaben.
V. Überwachung
Art. 16. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre
der Gesellschaft sein müssen.
Die Hauptversammlung ernennt sie, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates, die
fünf Jahre nicht überschreiten darf, fest.
VI. Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 17. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 18. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab der gesetzlichen
Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals
betragen. Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des restli-
chen Betrages des Reingewinns. Der Vorstand kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden
ausschütten.
VII. Auflösung der Gesellschaft
Art. 19. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen
oder mehrerer Liquidatoren (welche natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt, welche von der
Hauptversammlung ernannt und deren Vergütungen von der Hauptversammlung festgesetzt werden.
VIII. Satzungsänderung
Art. 20. Die gegenwärtige Satzung kann von einer Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, vorausgesetzt
die Anwesenheits- und Mehrheits-Quoren gemäß Artikel siebenundsechzig-eins (67-1) des Gesellschaftsgesetzes sind
gewahrt.
4386
L
U X E M B O U R G
IX. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 21. Für sämtliche Fragen, welche durch diese Satzung nicht geregelt werden, gelten die Bestimmungen des Ge-
sellschaftsgesetzes.“ Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Nach Vorlesung der Urkunde an die Erschienenen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: C. GESCHWIND, M. ZELLINGER, P. STEINLE und J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A. C., le 15 décembre 2015. LAC / 2015 / 39897. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 21. Dezember 2015.
Référence de publication: 2015208716/320.
(150235304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2015.
Morgan Stanley Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 29.192.
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of December,
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg) undersigned,
was held
an extraordinary general meeting of shareholders of MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS (the “Company”),
a Société d’Investissement à Capital Variable with its registered office at 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
incorporated on 21 November 1988 by deed of Maître Edmond Schroeder, published in the Mémorial C number 8 of 11
January 1989 and which Articles of Incorporation have been amended for the last time by deed enacted on 29 June 2012,
(the “Meeting”).
The Meeting was opened at 11.00 a.m. CET with Ms Géraldine LEONARD, professionally residing professionally in
Luxembourg, in the chair (the “Chairman”), who appointed as secretary to the Meeting Ms Julie Anne GABRIELSSON,
residing professionally in Luxembourg. The Meeting elected as scrutineer Ms Christine SCHUEBEL, residing professio-
nally in Senningerberg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the Notary to state that:
(i) The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list signed
by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled “ne
variatur” by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.
(ii) This Meeting has been convened by notices containing the agenda sent to each of the shareholders registered in the
shareholders’ register on 10 November 2015 and published in Tageblatt, d’Wort and in Mémorial on 10 November 2015
and on 30 November 2015.
(iii) It appears from the attendance list that out of 4,955,376,706 shares in issue, 30,756,522 shares are duly represented
at the Meeting.
(iv) In view of the fact that this meeting was duly convened for the second time, no quorum having been reached on 9
November 2015 at a first meeting, the shareholders may validly decide on all the items of the agenda regardless of the
number of shares represented.
(v) The agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
I. Approval of the amendments of the articles of incorporation of the Company (the “Articles”):
1. Supplement the second paragraph of article 7. “Issue of Shares” so as to clarify that the board of directors has the
right to reject any subscription request and restrict any share class to further subscription:
“Furthermore, the board of directors may, at its full discretion, decide to reject any subscription in whole or in part, or
to discontinue the issue of shares in any class of shares or Sub-Fund (“soft-closure”).”
2. Amendment of article 10. “Restrictions on Ownership of Shares” so as to:
(i) replace the current first paragraph with the following:
“The board of directors may restrict or prevent the legal or beneficial ownership of shares or prohibit certain practices
as disclosed in the sales documents such as late trading and market timing by any person (individual, corporation, partnership
or other entity), if in the opinion of the board of directors such ownership or practices may (i) result in a breach of any
provisions of these Articles of Incorporation, the sales documents or law or regulations of any jurisdiction, or (ii) require
4387
L
U X E M B O U R G
the Company, its management company or its investment manager to be registered under any laws or regulations whether
as an investment fund or otherwise, or cause the Company to be required to comply with any registration requirements in
respect of any of its shares, whether in the United States of America or any other jurisdiction; or (iii) may cause the Company,
its management company, its investment managers or shareholders any legal, regulatory, taxation, administrative, financial
or any other disadvantages which they would not have otherwise incurred (such person being herein referred to as "Pro-
hibited Person”).”
(ii) replace item D of the second paragraph and the subsequent paragraph with the following:
“D. grant a grace period to the relevant shareholder for remedying the situation as described in the sales documents and/
or propose to convert the shares into shares of another class available for such shareholder to the extent that this conversion
would cure the situation; and
E. compulsorily redeem or cause to be redeemed all shares held by a Prohibited Person. To that end, the Company will
notify the relevant shareholder of the reasons which justify the compulsory redemption of shares, the number of shares to
be redeemed and the indicative valuation day on which the compulsory redemption will occur. The redemption price shall
be determined in accordance with Article 8 above.”
3. Amendment of article 11. “Calculation of the Net Asset Value per Share” so as to (i) remove the reference to the
maximum level of adjustment that may be applied in relation to the net asset value of the sub-funds of the Company and
(ii) specify that such adjustment mechanism is more fully described in the sales documents of the Company.
4. Amendment of article 17. “Delegation of Power” so as to clarify that the “duly appointed management company” of
the Company shall delegate the portfolio management of the Company to any affiliated or associated company of the
Morgan Stanley Group.
5. Amendment of article 18. “Investment Policies and Restrictions” so as to:
(i) replace the reference to “full Prospectus”, as set out in the fourth paragraph of this article, by “sales documents”.
(ii) extend the eligible issuers within the meaning of article 45 (1) of the law of 17 December 2010 relating to undertakings
for collective investment to the members of the Group of twenty (G20), the Republic of Singapore and Hong-Kong.
6. Amendment of article 24. “Termination and Amalgamation of Sub-Funds and Share Classes” so as to:
(i) clarify that, when deciding to compulsory redeem all the shares within such share class or sub-fund, the board of
directors of the Company or the general meeting of shareholders, where applicable, “terminate” such share class or sub-
fund;
(ii) clarify that the “liquidation costs” may be taken into account in the calculation of the price at which the shares of
the relevant share class or sub-fund shall be compulsorily redeemed as a result of the termination of the said share class or
sub-fund;
(iii) clarify that the merger between UCITS will be subject to the shareholders’ approval in case the Company will cease
to exist as a result of the merger;
(iv) In view to allow absorption of other UCIs, or compartment thereof, replace the current sixth and seventh paragraphs
with the following:
“The board of directors may decide to proceed with the absorption by the Company or one or several Sub-Funds of (i)
one or several sub-funds of another Luxembourg or a foreign UCI, irrespective of their form, or (ii) any Luxembourg or
foreign UCI constituted under a non-corporate form. The exchange ratio between the relevant shares of the Company and
the shares or units of the absorbed UCI or of the relevant sub-fund thereof will be calculated on the basis of the relevant
net asset value per share or unit as of the effective date of the absorption.
Notwithstanding the powers conferred on the board of directors by the preceding paragraphs, the shareholders of the
Company or any Sub-Fund may also decide on any of the mergers or absorptions described above and on their effective
date thereof. The convening notice to the general meeting of shareholders will indicate the reasons for and the process of
the proposed merger or absorption. Such decision can be adopted by a simple majority of the votes validly cast with no
quorum requirement.
In addition to the above, the Company may also absorb another Luxembourg or foreign UCI incorporated under a
corporate form in compliance with the 1915 Law and any other applicable laws and regulations.”
(v) allow the board of directors of the Company to (i) terminate a subfund or a share class on the basis of “any other
reason” as further determined in the sales documents of the Company (in addition to those currently set forth in the Articles)
and/or (ii) amalgamate share classes “in case of a substantial modification in the political, economic or monetary situation”
or for “any other reason” as further determined in the sales documents of the Company (in addition to those currently set
forth in the Articles).
After having taken knowledge of the agenda, the Meeting takes the following resolution:
<i>First resolutioni>
The Meeting, with effect from 16 December 2015 RESOLVED TO amend the second paragraph of article 7. “Issue of
Shares” so as to clarify that the board of directors has the right to reject any subscription request and restrict any share class
to further subscription: “Furthermore, the board of directors may, at its full discretion, decide to reject any subscription in
whole or in part, or to discontinue the issue of shares in any class of shares or Sub-Fund (“soft-closure”).”
4388
L
U X E M B O U R G
Votes in favour: 27,807,411
Votes against: 47,238
Abstention: 2,901,873
<i>Second resolutioni>
The Meeting, with effect from 16 December 2015 RESOLVED TO amend article 10. “Restrictions on Ownership of
Shares” so as to:
(i) replace the current first paragraph with the following:
“The board of directors may restrict or prevent the legal or beneficial ownership of shares or prohibit certain practices
as disclosed in the sales documents such as late trading and market timing by any person (individual, corporation, partnership
or other entity), if in the opinion of the board of directors such ownership or practices may (i) result in a breach of any
provisions of these Articles of Incorporation, the sales documents or law or regulations of any jurisdiction, or (ii) require
the Company, its management company or its investment manager to be registered under any laws or regulations whether
as an investment fund or otherwise, or cause the Company to be required to comply with any registration requirements in
respect of any of its shares, whether in the United States of America or any other jurisdiction; or (iii) may cause the Company,
its management company, its investment managers or shareholders any legal, regulatory, taxation, administrative, financial
or any other disadvantages which they would not have otherwise incurred (such person being herein referred to as "Pro-
hibited Person”).”
Votes in favour: 23,998,949
Votes against: 6,353,864
Abstention: 403,709
(ii) replace item D of the second paragraph and the subsequent paragraph with the following:
“D. grant a grace period to the relevant shareholder for remedying the situation as described in the sales documents and/
or propose to convert the shares into shares of another class available for such shareholder to the extent that this conversion
would cure the situation; and E. compulsorily redeem or cause to be redeemed all shares held by a Prohibited Person. To
that end, the Company will notify the relevant shareholder of the reasons which justify the compulsory redemption of
shares, the number of shares to be redeemed and the indicative valuation day on which the compulsory redemption will
occur. The redemption price shall be determined in accordance with Article 8 above. The Company reserves the right to
require the Prohibited Person to indemnify the Company against any losses, costs or expenses arising as a result of any
compulsory redemption of shares due to the shares being held by, or for the benefit of, such Prohibited Person. The Company
may pay such losses, costs or expenses out of the proceeds of any compulsory redemption and/or redeem all or part of the
Prohibited Person’s shares in order to pay for such losses, costs or expenses.”
Votes in favour: 24,697,262
Votes against: 7,585
Abstention: 6,051,675
<i>Third resolutioni>
The Meeting, with effect from 16 December 2015 RESOLVED TO amend article 11. “Calculation of the Net Asset
Value per Share” so as to (i) remove the reference to the maximum level of adjustment that may be applied in relation to
the net asset value of the sub-funds of the Company and (ii) specify that such adjustment mechanism is more fully described
in the sales documents of the Company.
Votes in favour: 21,461,618
Votes against: 6,353,864
Abstention: 2,941,040
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting, with effect from 16 December 2015 RESOLVED TO amend article 17. “Delegation of Power” so as to
clarify that the “duly appointed management company” of the Company shall delegate the portfolio management of the
Company to any affiliated or associated company of the Morgan Stanley Group.
Votes in favour: 27,846,578
Votes against: 2,506,721
Abstention: 403,223
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting, with effect from 16 December 2015 RESOLVED TO amend article 18. “Investment Policies and Res-
trictions” so as to:
(i) replace the reference to “full Prospectus”, as set out in the fourth paragraph of this article, by “sales documents”.
4389
L
U X E M B O U R G
(ii) extend the eligible issuers within the meaning of article 45 (1) of the law of 17 December 2010 relating to undertakings
for collective investment to the members of the Group of twenty (G20), the Republic of Singapore and Hong-Kong.
Votes in favour: 27,807,897
Votes against: 7,585
Abstention: 2,941,040
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting, with effect from 16 December 2015 RESOLVED TO amend article 24. “Termination and Amalgamation
of Sub-Funds and Share Classes” so as to:
(i) clarify that, when deciding to compulsory redeem all the shares within such share class or sub-fund, the board of
directors of the Company or the general meeting of shareholders, where applicable, “terminate” such share class or subfund;
Votes in favour: 27,846,578
Votes against: 8,071
Abstention: 2,901,873
(ii) clarify that the “liquidation costs” may be taken into account in the calculation of the price at which the shares of
the relevant share class or sub-fund shall be compulsorily redeemed as a result of the termination of the said share class or
sub-fund;
Votes in favour: 27,732,818
Votes against: 121,831
Abstention: 2,901,873
(iii) clarify that the merger between UCITS will be subject to the shareholders’ approval in case the Company will cease
to exist as a result of the merger;
Votes in favour: 30,226,386
Votes against: 7,585
Abstention: 263,421
(iv) In view to allow absorption of other UCIs, or compartment thereof, replace the current sixth and seventh paragraphs
with the following: “The board of directors may decide to proceed with the absorption by the Company or one or several
Sub-Funds of (i) one or several sub-funds of another Luxembourg or a foreign UCI, irrespective of their form, or (ii) any
Luxembourg or foreign UCI constituted under a non-corporate form. The exchange ratio between the relevant shares of
the Company and the shares or units of the absorbed UCI or of the relevant sub-fund thereof will be calculated on the basis
of the relevant net asset value per share or unit as of the effective date of the absorption.
Notwithstanding the powers conferred on the board of directors by the preceding paragraphs, the shareholders of the
Company or any Sub-Fund may also decide on any of the mergers or absorptions described above and on their effective
date thereof. The convening notice to the general meeting of shareholders will indicate the reasons for and the process of
the proposed merger or absorption. Such decision can be adopted by a simple majority of the votes validly cast with no
quorum requirement.
In addition to the above, the Company may also absorb another Luxembourg or foreign UCI incorporated under a
corporate form in compliance with the 1915 Law and any other applicable laws and regulations.”
Votes in favour: 27,846,578
Votes against: 7,585
Abstention: 2,902,359
(v) allow the board of directors of the Company to (i) terminate a sub-fund or a share class on the basis of “any other
reason” as further determined in the sales documents of the Company (in addition to those currently set forth in the Articles)
and/or (ii) amalgamate share classes “in case of a substantial modification in the political, economic or monetary situation”
or for “any other reason” as further determined in the sales documents of the Company (in addition to those currently set
forth in the Articles).
Votes in favour: 21,461,618
Votes against: 6,393,031
Abstention: 2,901,873
The Meeting is thereupon closed at 12.00 a.m. CET.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the Meeting, the members of the board of the Meeting, all of whom are known to
the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original
deed.
Signé: G. LEONARD, A. GABRIELSSON, C. SCHUEBEL, D. KOLBACH.
4390
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 17 décembre 2015. Relation: DAC/2015/21995. Reçu soixante quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): J. THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Redange-sur-Attert, le 31 décembre 2015.
Référence de publication: 2016004879/215.
(160002808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
CMH Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route dr Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 201.263.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of October.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
CMH Holdings I S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office
at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand
Pounds Sterling (GBP 12,000) and in process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
(R.C.S. Luxembourg),
here represented by Me Louise N'GAPOU, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given under private seal.
The power of attorney, after signature “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is CMH Holdings II S.à r.l. (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other
location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
4391
L
U X E M B O U R G
of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.
3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand Pounds Sterling (GBP 12,000), represented by twelve thousand (12,000)
shares in registered form, having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior
approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company
in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if
the redemption results from a reduction in the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the
term of their mandate. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board)
composed of one (1) or several class A managers and one (1) or several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board meets at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which in
principle is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in
the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that they know the agenda for
the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices
are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented, including at
least one class A manager and one class B manager. Board resolutions are validly adopted by a majority of the votes by
the managers present or represented, including the votes of at least one class A manager and one class B manager. Board
resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by
all the managers present or represented.
4392
L
U X E M B O U R G
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any class A manager and any
class B manager, save for administrative matters, where the Company is bound towards third parties by the single signature
of any manager but only for transactions up to an amount of five thousand Pounds Sterling (GBP 5,000) on a per transaction
basis.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been
delegated.
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to be
read as references to the sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has
delegated special powers.
Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly
made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).
(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent
to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the shareholders
are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.
(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or
shareholders representing more than ten per cent (10%) of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the
meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.
(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be
represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters
of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the
Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
4393
L
U X E M B O U R G
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the
value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its manager
(s) and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders'
Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d'entreprises agréés).
14.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration
and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requirement
ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.
15.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment
of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal
provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distri-
butable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim
accounts;
(iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund
the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or
more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers and
remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company's assets
and pay its liabilities.
16.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in pro-
portion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may
be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board
meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,
subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitional provision:i>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31
st
, 2016.
4394
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription and payment:i>
CMH Holdings I S.à r.l., represented as stated above, subscribes to twelve thousand (12,000) shares in registered form,
having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of
twelve thousand Pounds Sterling (GBP 12,000).
The amount of twelve thousand Pounds Sterling (GBP 12,000) is at the Company's disposal, as has been proved to the
notary who acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand euros.
<i>Resolutions of the shareholder:i>
Immediately after the incorporation of the Company, its shareholder, representing the entire subscribed capital, adopted
the following resolutions:
1. The following person is appointed as class A manager of the Company for an indefinite period:
Mr. Richard Weissmann, partner, born on September 5, 1962 in New York, United States of America, having his
professional address at c/o KSL Capital Partners, LLC, 100 Fillmore Street, Suite 600, Denver, CO 80206, United States
of America.
2. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Cédric Bradfer, director, born on August 2, 1978 in Chambery, France, having his professional address at 6D,
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
- Mr. Dylan Davies, director, born on November 16, 1966, in Swansea, United Kingdom, having his professional address
at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg;
3. The registered office of the Company is located at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the proxyholder of the appearing party, who has signed it together with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois d’octobre.
Par devant le soussigné Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
CMH Holdings I S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Gand Duché du Luxembourg,
dont le siège social se situe au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital
social de douze mille livres sterling (GBP 12.000) et en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg,
représentée par Maître Louise N'GAPOU, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procura-
tion donnée sous seing privé.
Après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite pro-
curation restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est CMH Holdings II S.à r.l. (la Société). La Société est une société à
responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être
transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre
4395
L
U X E M B O U R G
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification
des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires
d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature
à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments
financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets
ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées, ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever
de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation
requise.
3.3. La Société peut employer tous les instruments et moyens juridiques nécessaires à une gestion efficace de ses
investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt
et autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille livres sterling (GBP 12.000), représenté par douze mille (12.000) parts
sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable
des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet
effet, ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
4396
L
U X E M B O U R G
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil), composé
d'un (1) ou plusieurs gérant(s) de classe A et un (1) ou plusieurs gérant(s) de classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,
qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe,
est au Luxembourg.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures
à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et déclarent avoir
connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce
soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans
des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, en
ce compris au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à
la majorité des voix des gérants présents ou représentés, en ce compris les votes d'au moins un gérant de classe A et un
gérant de classe B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion
ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de
communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler.
La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et
tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de tout gérant de classe
A et tout gérant de classe B, à l'exception des matières administratives pour lesquelles la Société est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature individuelle de tout gérant, mais uniquement pour les transactions ne dépassant pas un montant de
cinq mille livres sterling (GBP 5.000,-).
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués par le gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Lorsque les résolutions sont adoptées par voie de Résolutions Circulaires des Associés, le texte de ces résolutions
est envoyé à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les
4397
L
U X E M B O U R G
associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale dûment
convoquée et tenue, et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou associés
représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances doivent être précisées dans la convo-
cation.
(iii) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vi) Les décisions de l'Assemblée Générale ou les Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par les associés
détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou à la
première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et
les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par voie de Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des
voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts ne sont modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins
les trois-quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la
Loi à l'Assemblée Générale.
12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1
er
) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Le Conseil dresse chaque année le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant ses engagements ainsi que les dettes du ou des gérant(s) et
des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés l'Assemblée Générale annuelle ou par voie de
Résolutions Circulaires des Associé dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.
Art. 14. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus
par la loi.
14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six (6) ans mais qui peut être renouvelé.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la loi. Cette
affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris les primes
d'émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à
la réserve légale;
4398
L
U X E M B O U R G
(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires; et
(iv) Les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés en prenant les actifs de la Société.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les
associés doivent reverser l'excès à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, est distribué aux associés propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, ainsi que les
Résolutions Circulaires des Gérants et des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail ou tout autre moyen
de communication électronique.
17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont
apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoire:i>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libération:i>
CMH Holdings I S.à r.l., représentée comme ci-avant, déclare souscrire les douze mille (12.000) parts sociales sous
forme nominative, d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune, et de les libérer intégralement moyennant
apport en numéraire d'un montant de douze mille livres sterling (GBP 12.000).
Le montant de douze mille livres sterling (GBP 12.000) est à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été prouvé au
notaire instrumentant qui le constate.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent
approximativement à mille euros (EUR 1.000.-).
<i>Résolutions de l'associée unique:i>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associée unique, représentée comme ci-avant et représentant l'in-
tégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée en qualité de gérant de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
M. Richard Weissmann, associé, né le 5 septembre 1962 à New York, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse pro-
fessionnelle à c/o KSL Capital Partners, LLC, 100 Fillmore Street, Suite 600, Denver, CO 80206, Etats-Unis d'Amérique.
2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Cédric Bradfer, gérant, né le 2 août 1978 à Chambéry, France, ayant son adresse professionnelle au 6D, route de
Trêves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- M. Dylan Davies, gérant, né le 16 novembre 1966 à Swansea, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 6D,
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare à la requête de la partie comparante que le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
4399
L
U X E M B O U R G
Après avoir lu le présent acte, le notaire le signe avec la mandataire de la partie comparante.
Signé: L. N'GAPOU, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 3 novembre 2015. 2LAC/2015/24706. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181153/486.
(150201721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
AMP Capital Investors (IDF III JPY No. 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: JPY 2.000.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 201.270.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the twenty-second day of October,
Before us, Maître Marc Loesch, Notary residing in Mondorf-les-Bains,
THERE APPEARED
AMP Capital Investors (IDF III JPY No. 1) S.à r.l., a Luxembourg private limited company, being in the process of
registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, having its registered office at 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg,
here represented by Mrs. Khadigea Klingele, senior legal counsel, with professional address in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy given under private seal on 22 October 2015 in Luxembourg.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company ("Société à responsabilité limitée"), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - Registered Office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company ("Société à responsabilité limitée") under the name
AMP Capital Investors (IDF III JPY No. 2) S. à r. l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of
Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law),
as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case
may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in
the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager
or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
4400
L
U X E M B O U R G
3.2 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations
of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or
otherwise create security over all or over some of its assets. For the avoidance of doubt, the Company shall not carry out
any regulated activities of the financial sector.
3.3 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against currency ex-
change and interest rate risks as well as other risks.
3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at two million Japanese Yen (JPY 2,000,000) represented by twenty
thousand (20,000) shares in registered form without a par value, all subscribed and fully paid-up for JPY 2,000,000.
5.2 The share capital of the Company may be (i) increased by the issuance of additional shares or (ii) reduced in one or
several times. Capital increases or reductions may be decided by a resolution of the sole shareholder or, as the case may
be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.2 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is not more than one shareholder, to third parties.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to nonshareholders is subject to the prior approval of the general
meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company. A share transfer will only
be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance
with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.3 A share register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law
and may be examined by each shareholder who so requests.
6.4 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general
meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute
a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
7.2 The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.
8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or
not, by the manager, or if there is more than one manager, by any two managers of the Company.
Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the
place indicated in the convening notice.
9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
4401
L
U X E M B O U R G
9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another person as their
proxy.
9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or electronic documents such as scanned copies or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any
two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been
validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of
December.
14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an
indication of the value of the Company's assets and liabilities.
14.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased
4402
L
U X E M B O U R G
by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the single shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.
VII. General provision
Art. 17. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is foreseen in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year of the Company shall begin on the date of the incorporation and shall end on 31 December
2015.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, AMP Capital Investors (IDF III JPY No. 1) S.à r.l., prenamed and represented as stated here-above, declares
to having subscribed to the entire share capital of the Company and to have fully paid all twenty thousand shares (20,000)
shares by a contribution in cash, so that the amount of two million Japanese Yen (JPY 2,000,000) is at the disposal of the
Company, as has been proved to the undersigned notary.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
i. Mrs. Virginia Strelen, manager, born on 30 May 1977 in Bergisch Gladbach (Germany), with professional address at
15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
ii. Ms. Emma Haight, manager, born on 4 March 1980 in Toronto (Canada) with professional address at 4
th
floor
Berkeley Square House, Berkeley Square London W1J 6BX United Kingdom; and
iii. Mr. Wim Ritz, manager, born on 14 June 1970 in Merksem (Belgium), with professional address at 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
2. The registered office of the Company is set at L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known by the notary by name, surname, civil
status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille-quinze, le vingt-deuxième jour du mois d’octobre,
Par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains,
A COMPARU:
4403
L
U X E M B O U R G
AMP Capital Investors (IDF III JPY No. 1) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, en
cours d’inscription auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, dont le siège social se situe au 15,
rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
représentée par Madame Khadigea Klingele, juriste sénior, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 22 octobre 2015 délivrée à Luxembourg.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire agissant au nom de la partie com-
parante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter comme suit
les statuts d'une société à responsabilité limitée:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination AMP Capital Investors
(IDF III JPY No.2) S. à r. l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré
dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant unique, ou en cas échéant par le conseil de
gérance de la Société. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution
de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts
2.2 Des succursales, filiales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger
par une résolution du gérant unique, ou, le cas échéant, le conseil de gérance de la Société. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des développements ou évènements extraordinaires d'ordre politique ou militaire ont eu lieu
ou sont imminent et de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège
social et l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger,
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans d'autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par
souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.
Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra
en outre investir dans l’acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de
quelque nature ou origine que ce soit.
3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et / ou de créances et / ou des titres de participation. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des
emprunts et / ou des problèmes de titres de créance à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties ou des suretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de
ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, transférer, grever ou créer une
garantie sur tout ou partie de ses avoirs. En tout état de cause, la Société ne devra pas effectuer une activité réglementée
du secteur financier.
3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de
taux d'intérêt et autres risques.
3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes transactions
de propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y
rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite de décès, de suspension de droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à deux millions de Yen Japonais (JPY 2.000.000), représenté par vingt mille (20.000) parts
sociales nominatives sans valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées pour JPY 2.000.000.
4404
L
U X E M B O U R G
5.2 Le capital social de la Société pourra être (i) augmenté par l’émission de parts sociales ordinaires supplémentaires
ou (ii) réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés
délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Vis-à-vis la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, puisque seulement un propriétaire est admis
par part sociale. Copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés ou, si’ il n'y a pas plus d'un associé, à des tiers.
En cas de pluralité des associés, le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l’approbation préalable de
l’assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société. Une cession de parts
sociales ne sera opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été notifiée à ou à l’acceptation de la Société conformément
à l’article 1690 du code civil.
Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la loi.
6.3 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la loi et peut être
examiné par chaque associé qui en fait la demande.
6.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée
générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Dans la mesure où plusieurs gérants ont été nommés, ils
constituent le conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement un/des associé(s).
7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du gérant unique ou, si la Société est gérée par plus d’un gérant, du conseil de gérance, qui aura
tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformément à l’objet de la société.
8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des taches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par le gérant, ou s'il y a plusieurs gérants, par deux gérants de la Société.
Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou
représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dument informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être
renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donne par écrit soit en original, soit par télégramme,
télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit une autre personne
comme son mandataire.
9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée.
Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre
moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre
et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme
si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées
sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou en tant que document
électronique, tel que des copies scannés ou par téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de
deux gérants ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature
ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
4405
L
U X E M B O U R G
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit,
soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne ou entité comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax
ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés
apparaitront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société
seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Bilan Annuel.
14.1 L'exercice comptable de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un
décembre.
14.2 Chaque année, à la fin de l’exercice comptable, les comptes de la Société sont arrêtées et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de
la Société.
14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
15.3 Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à
la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés;
(iv) une assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération.
Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l’associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est
fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale de la Société débutera à la date de constitution et se terminera au 31 décembre 2015.
4406
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription - Paiementi>
AMP Capital Investors (IDF III JPY No. 1) S.à r.l., représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’intégralité
du capital social de la Société et avoir entièrement libéré les vingt mille (20,000) parts sociales par versements en espèces,
de sorte que la somme de deux millions de Yen Japonais (JPY 2.000.000) soit à la disposition de la Société, ce qui a été
prouvé au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge a raison de sa constitution est évalué à environ mille trois cents Euro (EUR 1.300).
<i>Décision de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associée unique, représentant la totalité du capital social a pris les
résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée
- Madame Virginia Strelen, née le 30 mai 1977 à Bergisch Gladbach (Allemagne), avec adresse professionnelle au 15,
rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Madame Emma Haight, née le 4 mars 1980 à Toronto (Canada), avec adresse professionnelle au 4
ème
stage, Berkeley
Square House, Berkeley Square LondresW1J 6BX, Angleterre;
- Monsieur Wim Ritz, né le 14 juin 1970 à Merksem (Belgique), avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen,
L2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte
en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom,
qualité et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Klingele, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 26 octobre 2015. GAC/2015/9093. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. PIERRET.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 5 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181028/399.
(150202004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
De Leo Sassone Architects S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5850 Howald, 2, rue Sangenberg.
R.C.S. Luxembourg B 201.290.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the day of ninth day of October.
Before Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange,
There appeared:
- Mr Domenico SASSONE, Architect, born in Scalea (Italy) on October 1
st
, 1959, residing in L-5850 Howald, 2, rue
Sangenberg,
Such appearing person has required the undersigned notary to enact the deed of incorporation of a public limited liability
company (société anonyme) on the basis of the Articles of Incorporation on which he has agreed as follows:
Name, Registered office, Object, Duration, Share capital
Art. 1. There is hereby established a company in the form of a public limited liability company (société anonyme) which
will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present Articles of Incorporation under the
name of “DE LEO SASSONE ARCHITECTS S.A.”.
Art. 2. The registered office is established in the municipality of Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.
4407
L
U X E M B O U R G
The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of
the shareholders' meeting.
In the event that the board of directors, or the sole director if there is one, determines that extraordinary political, economic
or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the company at its registered
office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures will have no effect on the nationality of the company, which, notwithstanding the temporary transfer of the
registered office, will remain a Luxembourg company.
Art. 3. The object of the company is the exercise of the professions of architect and urban planner.
To the extent and in the compatibility limit with the ethical rules of the «Ordre des Architectes et Ingénieurs-Conseils»
of the Grand Duchy of Luxembourg, the company may execute, in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, any
industrial, commercial, financial, movable and real estate operations, directly or indirectly linked to its purpose or which
may help the development of its purpose.
The company prohibits any participation or activity that may create a conflict of interest and undermine the professional
independence of architect's liberal activity. It is committed to complying with all laws and regulations to which is subject
the regulated activity.
The company must comply with the ethical requirements of the Regulation of the «Ordre des Architectes et Ingénieurs-
Conseils». Only persons legally authorized for that purpose may exercise the architectural profession in the company.
Art. 4. The company is formed for an unlimited period of time.
Art. 5. The corporate capital of the company is set at thirty-one thousand Euro (€ 31,000), divided into thirty-one thousand
(31,000) registered shares with a par value of one Euro (€ 1.-) each.
The share capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of incorporation. The company may, to the extent and under terms permitted by
the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), redeem its own shares.
The shares are registered shares.
Board of directors, Statutory auditor
Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not be
shareholders.
The directors shall be elected by the shareholders' meeting, which shall determine their number, for a period not ex-
ceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are reeligible and they may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled
out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.
However, in case the company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of
shareholders that the company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to
one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in
the company.
Art. 7. The board of directors may choose from among its members a chairman.
The board of directors shall meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two
directors so require.
Written notices of any meeting of the board of directors will be given by letter or by telefax to all directors at least 48
hours in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such
circumstances will be set forth in the notice of meeting. The notice indicates the place and agenda for the meeting.
This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram or telefax of each director. No separate notice
is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of
directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing of by cable, telegram or telefax
another director as his proxy.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, a written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted
at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content.
Art. 8. The minutes of any meeting of the board of Directors will be signed by the chairman of the meeting and by any
other director. The proxies will remain attached thereto.
4408
L
U X E M B O U R G
In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.
Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing
the company's object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of share-
holders are in the competence of the board of directors.
In case the company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
Art. 10. The board of directors may delegate the daily management of the company and the representation of the company
within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but need
not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to
persons or agents chosen by it.
Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting
of shareholders.
The first general meeting after the incorporation of the company may proceed to the nomination of one or several
«administrateur(s)-délégué(s)».
Art. 11. The company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors, the signature of
the person to whom the daily management of the company has been delegated is being compulsory in any case, or by the
individual signature of the person to whom the daily management of the company has been delegated, within such daily
management.
In case the board of directors is composed of one (1) member only, the company will be bound by the signature of the
sole director.
Art. 12. The company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be shareholders.
The statutory auditors shall be elected by the shareholders' meeting, which shall determine their number, for a period
not exceeding six years. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution
of the general meeting.
General meeting of shareholders
Art. 13. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company represents the entire body of shareholders.
Subject to the provisions of article 10 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the company.
In case the company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general meeting
of shareholders.
Art. 14. The annual general meeting shall be held on the first Friday of May of each year, at 2.00 p.m. at the registered
office of the company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 15. The board of directors or the statutory auditor may convene other general meetings. Such meetings must be
convened if shareholders representing at least one tenth of the company's capital so require.
Art. 16. Shareholders' meetings are convened by notice made in compliance with the provisions of law.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been informed
of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax as
his proxy another person who need not be a shareholder.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders'
meeting.
Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by a
simple majority of votes.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by
the chairman of the board or by any two directors.
In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.
Fiscal year, Allocation of profits
Art. 17. The company's accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each
year.
Art. 18. From the annual net profits of the company, five per cent (5%) will be allocated to the reserve required by law.
That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the company.
4409
L
U X E M B O U R G
Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder of
the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a
provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board
fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
Dissolution, Liquidation
Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority
as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general
meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.
Applicable law
Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of
10
th
August 1915 governing commercial companies, as amended.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year runs from the date of incorporation and ends on 31 December 2016.
The first General Meeting will be held in the year 2017.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of the company having thus been established, the party appearing and sole shareholder, Mr. Domenico
SASSONE, hereby declares that he subscribes to thirty-one thousand (31,000) shares representing the total share capital
of the company.
The said capital has been paid in by contribution in cash to concurrence of twenty five percent (25%), so that the amount
of seven thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 7750.-), is at the disposal of the company, where-over proof has
been given to the undersigned notary by a bank certificate.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10
th
, 1915 on
commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be born by the company as a result of the present deed are estimated
at EUR 1,240.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The above-named party, representing the entire subscribed capital, declares acting as a general meeting of the share-
holders, and has decided to take the following resolutions:
1) Resolved to fix at 1 (one) the number of directors and further resolved to elect as director:
- Mr Domenico SASSONE, prenamed, born in Scalea (Italy) on October 1
st
, 1959, residing in L-5850 Howald, 2, rue
Sangenberg.
2) Resolved to fix at 1 (one) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory
auditor:
- Glowsquare S.A., a société anonyme having its share registered in L-1520 Luxembourg, 10-12, rue Adolphe Fischer
(R.C.S. Luxembourg B 194.828).
3) The director and statutory auditor will hold office until the end of the annual general meeting of shareholders to be
held in 2021.
4) The registered office's address is fixed in L-5850 Howald, 2, rue Sangenberg.
Whereover, the present deed has been drawn up by the undersigned notary, in Hesperange, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above named person
the present deed is worded in French followed by a English version; upon request of the appearing person and in case of
divergences between the two versions, the English will be prevailing.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by name, civil status and residence, the
said appearing person signed the present original deed together with Us, Notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil quinze, le neuf octobre,
4410
L
U X E M B O U R G
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
- Monsieur Domenico SASSONE, Architecte, né à Scalea (Italie) le 1
er
Octobre 1959, demeurant à L-5850 Howald,
2, rue Sangenberg,
Lequel comparant a arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer:
Dénomination, Siège, Objet, Durée, Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg et par les présents statuts, sous la dénomination «DE LEO SASSONE ARCHITECTS S.A.».
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée
des actionnaires.
Au cas où le conseil d'administration, ou l'administrateur unique le cas échéant, estimerait que des événements extraor-
dinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la
communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer
temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provi-
soires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera
luxembourgeoise.
Art. 3. La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste.
Dans la mesure et dans la limite de compatibilité avec les règles déontologiques de l'Ordre des Architectes et des
Ingénieurs-Conseils du Grand-Duché de Luxembourg, la société peut effectuer, tant à l'intérieur du Grand-Duché de Lu-
xembourg qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières ou civiles, mobilières ou immobilières,
qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation.
La société s'interdit toute participation ou activité pouvant créer un conflit d'intérêts et porter atteinte à l'indépendance
professionnelle de l'activité libérale d'architecte. Elle s'engage à respecter toutes les dispositions législatives et réglemen-
taires auxquelles est soumise l'activité réglementée en question.
La société devra respecter les prescriptions du règlement de déontologie de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-
Conseils. Seules les personnes légalement habilitées à cet effet pourront exercer la profession d'architecte dans le cadre de
la société.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trente-et-un mille (31.000) actions
d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) chacune.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en
matière de modification des statuts. La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.
Les actions sont nominatives.
Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une
durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale,
avec ou sans motif.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut
être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,
il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à
un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.
Art. 7. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si
deux administrateurs le demandent.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donnée par lettre ou télécopieur à tous les administrateurs
au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en
contiendra l'ordre du jour.
4411
L
U X E M B O U R G
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par câble, par télégramme ou par
télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date
et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par câble,
par télégramme ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente
ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d'urgence une décision écrite signée par l'ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle
avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit au par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.
Art. 8. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion et
par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 9. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi ou
les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres
agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des
fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.
Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination d'un
ou de plusieurs administrateur(s)-délégué(s).
Art. 11. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle
obligatoire de l'administrateur délégué à la gestion journalière, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la
gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut pas
dépasser six ans. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.
Assemblée générale des actionnaires.
Art. 13. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.
Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier
les actes en relation avec les activités de la société.
Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai de chaque année à
14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 15. Le conseil d'administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales.
De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social le
demandent.
Art. 16. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de
l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par
télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.
Chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la majorité
simple.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du
conseil d'administration ou par deux administrateurs.
4412
L
U X E M B O U R G
Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.
Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 17. L'année sociale de la société commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent
(10%) du capital social souscrit de la société.
Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bé-
néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de
provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.
Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la
loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.
Dissolution, Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions
de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Loi applicable
Art. 20. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application
partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2016.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2017.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts ayant été ainsi établis, le comparant et unique actionnaire, Monsieur Domenico SASSONE, déclare souscrire
à trente-et-un mille (31.000) actions représentant la totalité du capital social de la société.
Toutes les actions ont été libérées par versement en espèces à concurrence de vingt-cinq pourcent (25%), de sorte que
la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,-EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné au moyen d'un certificat bancaire.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitution
sont estimés à environ EUR 1.240,-.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et à l'instant le comparant prénommé, représentant l'intégralité du capital social, a déclaré agir en lieu et place d'une
assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à un (1).
Est nommé administrateur unique:
- Monsieur Domenico SASSONE, prénommé, né à Scalea (Italie) le 1
er
Octobre 1959, demeurant à L-5850 Howald,
2, rue Sangenberg.
2) Le nombre des commissaires est fixé à 1 (un).
Est nommé commissaire aux comptes:
- Glowsquare S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-1520 Luxembourg, 10-12, rue Adolphe Fischer
(R.C.S. Luxembourg B 194.828).
3) Les mandats de l'administrateur et du commissaire viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
qui se tiendra en l'année 2021.
4) L'adresse du siège social est fixée à L-5850 Howald, 2, rue Sangenberg.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
4413
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue française,
suivi d'une traduction anglaise, à la requête du comparant et que la version anglaise primera en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état
et demeure, il signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: D. SASSONE, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/33148. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole Frising.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 9 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181183/345.
(150202584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Valin Mittelstand Senior Debt Fund S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-
vestissement Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 187.738.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second of December.
Before us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of Valin Mittelstand Senior Debt Fund S.A., SICAV-SIF, a public
limited company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg as an investment
company with variable capital - specialised investment fund (société d'investissement à capital variable - fonds d'investis-
sement spécialisé) with registered office at 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 187.738 (the “Company”).
The meeting was opened at 10.30 am with Mrs. Sylvie Dobson, private employee, residing professionally at 33, Rue de
Gasperich, L5826 Hesperange, in the chair, who appointed as secretary Mrs. Aghate Kahn, private employee, residing
residing professionally at 33, Rue de Gasperich, L5826 Hesperange.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Danièle Maton, private employee, residing professionally at 33, rue de Gasperich,
L5826 Hesperange.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company, as from 1
st
January 2016, from 33, rue de Gasperich, L-5826
Hesperange to 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Amendment of the first paragraph of the Article 4 of the articles of incorporation in order to reflect the change of the
registered office. The first paragraph to be reworded as follows: “The registered office of the Company is located in the
municipality of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established, either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad by a decision of the board of directors. Within the same borough, the registered office may be
transferred through simple resolution of the board of directors.”
3. Miscellaneous.
II. This general meeting has been duly convened by mail to the registered shareholders on December 7
th
, 2015.
The related copies of the said publications are deposited on the desk of the bureau of the meeting.
III. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, and by the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to this deed to be filed at
the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialed “ne varietur” by the appearing parties will remain annexed to this
deed.
IV. That it appears from the attendance list that all shareholders of the Company are present or represented at the present
meeting and the shareholders present or represented considered themselves as duly convened and informed of the agenda
and waive any convening notice.
V. That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
The general meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
4414
L
U X E M B O U R G
<i>First resolution:i>
The general meeting RESOLVED to transfer the registered office of the Company, as from 1
st
January 2016, from 33,
rue de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The resolution has been taken as follows:
Votes in favour: 459,000 Class A shares and 36,261Class B shares
Vote(s) against: 0
Abstention: 229,500 Class A shares
The resolution is consequently adopted.
<i>Second resolutioni>
The general meeting RESOLVED to amend the first paragraph of the Article 4 of the articles of association of the
Company in order to reflect the change of the registered office and give the following wording:
“ Art. 4. Registered Office - first paragraph. The registered office of the Company is located in the municipality of
Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established, either in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by a decision of the Board of Directors. Within the same borough, the registered office may be transferred through
simple resolution of the Board of Directors.”
The resolution has been taken as follows:
Votes in favour: 459,000 Class A shares and 36,261Class B shares
Vote(s) against: 0
Abstention: 229,500 Class A shares
The resolution is consequently adopted.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English.
Whereof this deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
In accordance with article 26(2) of the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds as amended by
the law of 26 March 2012, such deed shall not be followed by any translation in an official language.
The document having been read to the persons appearing known to the notary, these persons signed together with the
notary this deed.
Signé: S. Dobson, A. Kahn, D. Maton et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/30221. Reçu soixante-quinze
euros Eur 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Référence de publication: 2016005175/79.
(160002726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
International Packaging SC, Société Civile.
Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue.
R.C.S. Luxembourg E 5.767.
STATUTS
1. Madame ZORKANI Narima, née le 12 Juin 1975 à Mons (BE) demeurant au 401 Boite 0002, Boulevard de Smet de
Naeyer, BE-1090 JETTE (BE);
2. Monsieur GARDAVOIR Patrick, né le 06 Mai 1967 à Charleroi, demeurant au 683/D, Longchamps, BE-6688 BER-
TOGNE (BE);
Lesquels comparants ont décidé d’acter les statuts d’une Société Civile qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit
le 03 / 11 / 2015:
Art. 1
er
. Il est formé une Société Civile régie par la loi de 1915 sur les Sociétés Commerciales et Civiles, telle qu'elle
a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code Civil Luxembourgeois.
Art. 2. La Société a pour objet la détention, l’utilisation et la mise à disposition de biens mobiliers à des fins privées. La
société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques. La société
4415
L
U X E M B O U R G
pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à cet
objet ou de nature à en faciliter la réalisation.
Art. 3. La dénomination est [INTERNATIONAL PACKAGING SC].
Art. 4. Le siège social est établi à 82, Grand Rue L-9711 Clervaux, il pourra être transféré en toute autre localité du
Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l’assemblée générale.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée, elle pourra être dissoute par décision de la majorité des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 6. Le capital social est fixé à 100,00 EUR, répartis en 100 parts de 1,00 EUR chacune et constitué par l’apport en
numéraire sur un compte ouvert pour la société.
Art. 7. En raison de leur apport, il est attribué 99 parts à Madame ZORKANI Narima et 1 part à Monsieur GARDAVOIR
Patrick, les comparants ci-dessus mentionnés. La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord représentant
au moins 50% des parts. L’intégralité de l’apport devra être libérée sur demande du gérant ou des associés.
Art. 8. Les parts sociales sont cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des tiers
non-associés sans l’accord unanime de tous les associés restants. En cas de transfert par l’un des associés de ses parts
sociales, les autres associés bénéficieront d’un droit de préemption sur ses parts, à un prix fixé entre associés et agréé
d’année en année lors de l’assemblée générale statuant le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de préemption
s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d’un associé
à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.
Art. 9. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survivants
n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de l’associé décédé.
Toutefois, les héritiers devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu'à régularisation, désigner dans
les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant la Société.
Art. 10. La Société est administrée par un gérant nommé et révocable à l’unanimité de tous les associés.
Art. 11. Le gérant est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en nom et pour compte
de la Société. La Société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle de son gérant.
Art. 12. Le bilan est soumis à l’approbation des associés, qui décident de l’emploi des bénéfices. Les bénéfices sont
répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.
Art. 13. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du
Code Civil. Les pertes et dettes de la Société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts dans
la Société.
Art. 14. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation du
gérant ou sur convocation d’un des associés. Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement le troisième vendredi de
juin de chaque année à 10 heures afin de délibérer du bilan, du résultat de l’année écoulée et pour fixer la valeur des parts
conformément à l’article 6. L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises
à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix. Toutes modifications
des statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.
Art. 15. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que
l’assemblée n’en décide autrement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont à sa charge, en raison de sa constitution à 100 EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
A l’instant, les parties comparantes représentant l’intégralité du capital social se sont réunies en assemblée générale
extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris les résolutions
suivantes:
1. Madame ZORKANI Narima, précitée, est nommée gérante,
2. Le siège de la Société est établi à 82, Grand Rue L-9711 Clervaux.
Lu, accepté et signé par les parties intervenantes.
Référence de publication: 2015181401/67.
(150202535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
4416
Advent Ship (Luxembourg) Holding S.à r.l.
Alpilla S.A.
Amaris Group S.A.
AMM Finance Sicav
AMP Capital Investors (IDF III JPY No. 2) S.à r.l.
AMPLEXOR International S.A.
Arcoop S.à r.l.
ASA Holdings S.A., Spf
Auberge La Calèche S.à r.l.
Auberge La Calèche S.à r.l.
Belfort S.A.
belRfrance S.à r.l.
CMC Mexico Limited S.à r.l.
CMH Holdings II S.à r.l.
Cubeo S.A.
De Leo Sassone Architects S.A.
Delweis
Desalline S.A.
Electra Sàrl
Eliseo Finance S.à r.l.
European Retail Enterprises II B.V.
euroscript international S.A.
Financière Vitale S.à r.l.
Finnova
FRANC AB S.A.
HollisWealth S.A.
International Packaging SC
Librairie Bei Der Schoul S.à r.l.
Librairie Bei Der Schoul S.à r.l.
Lobbel
Lys International S.A.
Magrelux S.A.
MET Fonds
Morgan Stanley Investment Funds
MSDK Invest S.A.
Norvest
Patrono
Sahu S.A.
Soft S.A.
Sokaris Shipping S.A.
Transports Faber S.à r.l.
Tudor Investments S.A.
U.P.I. - Union de Participations et d'Investissements
Valin Mittelstand Senior Debt Fund S.A., SICAV-SIF
Venti One S.A.
Vespa Capital S.A.
Vitale Capital S.A.