logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 73

11 janvier 2016

SOMMAIRE

Acerta S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3463

Allard Invest Holding Bresil S.à r.l. . . . . . . . . .

3463

BGG Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3463

CleanServe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3459

Compagnie Financière Hispania S.A.  . . . . . . .

3469

CSII Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3459

De Feinen Heizungsknechler s.à r.l. . . . . . . . . .

3462

Diamantina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3459

Duke Energy International El Salvador Invest-

ments No. 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3492

East & West Trade Link S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .

3458

Easy Hotels Company  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3458

EIRSP Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

3458

Elitek S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3458

Emcube S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3460

Erre Tre S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3459

Everfit S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3466

Ex-d S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3459

Expansion Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

3458

Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l.  . . . . . . . . . .

3480

Financière SDS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3460

Fräiwëlleg Pompjeeën vu Koler  . . . . . . . . . . . .

3474

FSB-Systems S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3461

Golf Mulligan S.P.F. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3460

Green Clean S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3459

Groupe Steffen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3460

HellermannTyton Alpha S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

3460

H.I.G. Luxembourg Holdings 38 S.à r.l.  . . . . .

3461

H.I.G. Luxembourg Holdings 39 S.à r.l.  . . . . .

3461

Hobevest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3461

HORIZON Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

3471

IBG Global Funds SICAV-SIF  . . . . . . . . . . . .

3504

ICRED - International Company for Real Es-

tate Development S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3462

In der Laey S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3461

Jugend und Senioren Für Europa  . . . . . . . . . .

3489

Les P'tits Mousses S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3463

LIC US Growth Fund SICAV-FIS  . . . . . . . . .

3491

Locinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3462

Logicor (Scorpion) Pledgeco S.à r.l.  . . . . . . . .

3480

Lux Property Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3479

Magenlux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3472

Marim S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3464

Menarini International Investment S.A. - Lu-

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3462

Metis Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3504

Mirai S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3462

Op der Gare Lima S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3463

3457

L

U X E M B O U R G

EIRSP Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 158.006.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184623/9.
(150206297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

East & West Trade Link S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8365 Hagen, 3, Jeckelsgaass.

R.C.S. Luxembourg B 65.704.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184616/10.
(150205614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Easy Hotels Company, Société Anonyme.

Siège social: L-6370 Haller, 2, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 144.561.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015184617/10.
(150206089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Elitek S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 47.916.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ELITEK S.A.
Signatures

Référence de publication: 2015184626/11.
(150206203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Expansion Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 41, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 132.215.

Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2015184614/14.
(150206035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

3458

L

U X E M B O U R G

Erre Tre S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 55.549.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184637/9.
(150206260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Ex-d S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 136.675.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015184613/10.
(150206385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Diamantina, Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 97.489.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIAMANTINA S.A.

Référence de publication: 2015184594/10.
(150206329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

CSII Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 64.254.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CSII INVESTISSEMENTS S.A.
Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2015184569/12.
(150206434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Green Clean S.A., Société Anonyme,

(anc. CleanServe S.A.).

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 170.102.

<i>Extrait de la résolution prise par l'actionnaire unique en date du 02 novembre 2015

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 novembre 2015.

<i>Pour GREEN CLEAN S.A.
L'administrateur

Référence de publication: 2015184671/13.
(150206183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

3459

L

U X E M B O U R G

Financière SDS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 151.930.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184648/9.
(150205948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Golf Mulligan S.P.F. S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 170.971.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184684/10.
(150205691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Groupe Steffen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8410 Steinfort, 10, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 179.959.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13/11/2015.

Référence de publication: 2015184689/10.
(150206384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

HellermannTyton Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 113.627.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévue par l'article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2014 de sa société
mère, HellermannTyton Group PLC ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184699/12.
(150205664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Emcube S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 176.337.

30/10/2015 L150195853
La mention rectificative remplacera la précédente version déposée.

RECTIFICATIF

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184627/13.
(150206333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

3460

L

U X E M B O U R G

FSB-Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 81.095.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184661/9.
(150205784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

H.I.G. Luxembourg Holdings 38 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 181.078.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184692/10.
(150205646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

H.I.G. Luxembourg Holdings 39 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 182.328.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184693/10.
(150205647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

In der Laey S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 137.914.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2015184733/11.
(150206042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Hobevest S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 15.574.

Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13.11.2015.

<i>Pour: HOBEVEST S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015184710/14.
(150206192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

3461

L

U X E M B O U R G

Menarini International Investment S.A. - Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 66.819.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 Octobre 2015.

Référence de publication: 2015184829/10.
(150205594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Mirai S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 92.628.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2015184841/10.
(150206185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

De Feinen Heizungsknechler s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9150 Eschdorf, 17, an der Huuscht.

R.C.S. Luxembourg B 107.618.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015184575/10.
(150206041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

ICRED - International Company for Real Estate Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 59.527.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2015.

<i>Pour compte de ICRED-International Company for Real Estate Development S.A.
Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2015184722/12.
(150206000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Locinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 71.220.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13/11/2015.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2015184797/12.
(150206450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

3462

L

U X E M B O U R G

Les P'tits Mousses S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 63, route de Dudelange.

R.C.S. Luxembourg B 81.536.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184788/9.
(150205694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Acerta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.700.000,00.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 26, rue Marie-Adelaïde.

R.C.S. Luxembourg B 166.876.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184417/10.
(150205863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Op der Gare Lima S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7448 Lintgen, 5, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 122.795.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015184871/10.
(150206429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Allard Invest Holding Bresil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 144.537.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015184431/10.
(150206010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

BGG Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 157.421.

Par résolutions signées en date du 27 octobre 2015, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Bruno Bagnouls, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de son mandat de gérant B, avec effet au 12 octobre 2015;

2. Nomination de Fabrice Huberty, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant B, avec effet au 12 octobre 2015 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2015.

Référence de publication: 2015181083/15.
(150202217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.

3463

L

U X E M B O U R G

Marim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 51.726.

L’AN DEUX MILLE QUINZE, LE VINGT-SEPT OCTOBRE
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (ci-après «l'Assemblée») de MARIM S.A., une société anonyme

ayant son siège social au 412 F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, (ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu
par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 juin 1995, publié au Mémorial C (ci-après le
«Mémorial»), Recueil des Sociétés et Associations, numéro 499 de 1995. Les statuts de la Société ont été modifiés pour
la dernière fois suivant procès-verbal de l’assemblée générale tenu sous seing privé en date du 5 avril 2002, publié au
Mémorial numéro 963 du 25 juin 2002.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Hugues DOUBET, employé, résidant professionnellement

à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Nathalie LOUREIRO, employée, résidant professionnellement à Lu-

xembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Hugues DOUBET, employé, résidant professionnellement à Lu-

xembourg

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter:
I. Qu'il appert d’une liste de présence établie et signée par les membres du Bureau que 1.250 (mille deux cent cinquante)

actions, sans désignation de valeur nominale, toutes sous forme nominative, représentant l’intégralité du capital social de
la Société qui s’élève à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents), sont dûment
représentées à la présente Assemblée, de sorte que l’Assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur tous les
points portés à l’ordre du jour, tel que reproduit ci-dessous, sans convocation préalable, les actionnaires présents ou re-
présentés à l’Assemblée ayant décidé de se réunir après avoir consulté l'ordre du jour.

II. La liste de présence, signée par tous les actionnaires représentés à l'Assemblée, les membres du Bureau et le notaire,

resteront annexées au présent acte avec les procurations pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.

III. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Décision d’abandonner la version anglaise des statuts.
2. Confirmation de la conversion du capital de la société en Euro.
3. Suppression du capital autorisé.
4. Décision des actionnaires conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle

qu'amendée (dissolution ou continuation de la Société eu égard à la perte encourue par le Société).

5. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 1.622.226,28 (un million six cent vingt-deux

mille deux cent vingt-six euros et vingt-huit cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 (trente mille
neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) à EUR 1.653.212,97 (un million six cent cinquante-trois mille deux
cent douze euros et quatre-vingt-dix-sept cents), sans émission d’actions nouvelles.

6. Libération du capital social d’un montant de EUR 1.622.226,28 (un million six cent vingt-deux mille deux cent vingt-

six euros et vingt-huit cents) par les actionnaires existants au pro rata de leurs participations respectives au capital de la
Société, par conversion d’une créance certaine, liquide et exigible.

7. Réduction du capital social d’un montant de EUR 1.240.787,27 (un million deux cent quarante mille sept cent quatre-

vingt-sept euros et vingt-sept cents) pour:

- compenser les pertes indiquées au bilan de la Société arrêté au 31 décembre 2014 d’un montant total de EUR 960.210,86

(neuf cent soixante mille deux cent dix euros et quatre-vingt-six cents), qui ne peuvent pas être absorbées par d’autres fonds
propres,

- créer d’une réserve spéciale afin de couvrir la perte de EUR 280.576,41 (deux cent quatre-vingt mille cinq cent soixante-

seize euros et quarante et un cents) pour la période allant du 1 

er

 janvier 2015 au 31 juillet 2015,

le tout sans annulation d’actions.
8. Modification de l’article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 3. Le capital social de la société est fixé à EUR 412.425,70,- (quatre cent douze mille quatre cent vingt-cinq euros

et soixante-dix cents) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont et resteront nominatives.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

3464

L

U X E M B O U R G

9. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l'ordre du jour, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’abandonner la version anglaise des statuts de sorte que les statuts seront dorénavant rédigés que

dans la seule version française.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée confirme que le capital social de la société a été converti en Euro par décision du 05 août 2002 publiée au

Mémorial numéro 963 du 25 juin 2002. Après cette conversion le capital social s’élève à EUR 30.986,69 réparti en 1.250
actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de supprimer la faculté du capital autorisé dans les statuts.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales telle qu'amendée, de continuer l'exploitation de la Société malgré les pertes encourues par le Société d'un montant
de EUR 1.240.787,27 (un million deux cent quarante mille sept cent quatre-vingt-sept euros et vingt-sept cents) tel que
cela ressort de la situation intérimaire de la Société arrêtée au 31 juillet 2015. L'Assemblée reconnaît avoir été informée
de cette situation par le Conseil d'Administration de la Société en temps utile.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d’un montant de EUR 1.622.226,28 (un million six

cent vingt-deux mille deux cent vingt-six euros et vingt-huit cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69
(trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) à EUR 1.653.212,97 (un million six cent cinquante-
trois mille deux cent douze euros et quatre-vingt-dix-sept cents), sans émission d’actions nouvelles.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de libérer le capital social de ce montant de EUR 1.622.226,28 (un million six cent vingt-deux

mille deux cent vingt-six euros et vingt-huit cents) par les actionnaires existants au pro rata de leurs participations respectives
au capital de la Société, par conversion d’une créance certaine, liquide et exigible.

Preuve de l’existence de cette créance a été apportée au notaire instrumentant dans un rapport établi par FIDUCIAIRE

EVERARD &amp; KLEIN SARL, cabinet de révision agréé, ayant son siège à L-5969 Itzig, 83, rue de la Libération, en la
personne de Monsieur Roland KLEIN, en date du 13 octobre 2015, qui conclut comme suit:

“6 CONCLUSION:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous sommes d’avis que l’apport projeté est décrit de

façon claire et précise et que les modes d’évaluation retenus sont appropriés aux circonstances données et conduisent à une
valeur au moins égale au nombre des 1.250 actions sans valeur nominale représentant le capital social de € 412.425,70 à
l’issue de l’opération d’augmentation de € 1.622.226,28 et de réduction de 1.240.787,27 du capital ainsi qu'à l’opération
de création d’une réserve spéciale de € 280.576,41 couvrant les pertes pour la période allant du 1 

er

 janvier 2015 au 31

juillet 2015.”

étant précisé que les opérations de réduction de capital de 1.240.787,27 ainsi que de création d’une réserve spéciale de

€ 280.576,41 dont question dans ledit rapport, sont mieux détaillées dans la septième résolution à prendre par l’assemblée
ci-après.

Ledit rapport restera, après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social d’un montant de EUR 1.240.787,27 (un million deux cent quarante mille

sept cent quatre-vingt-sept euros et vingt-sept cents) pour:

- compenser les pertes indiquées au bilan de la Société arrêté au 31 décembre 2014 d’un montant total de EUR 960.210,86

(neuf cent soixante mille deux cent dix euros et quatre-vingt-six cents), qui ne peuvent pas être absorbées par d’autres fonds
propres,

- créer au bilan de la société une réserve spéciale, afin de couvrir la perte de EUR 280.576,41 (deux cent quatre-vingt

mille cinq cent soixante-seize euros et quarante et un cents) pour la période allant du 1 

er

 janvier 2015 au 31 juillet 2015,

le tout sans annulation d’actions.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

3465

L

U X E M B O U R G

« Art. 3. Le capital social de la société est fixé à EUR 412.425,70 (quatre cent douze mille quatre cent vingt-cinq Euros

et soixante-dix cents) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont et resteront nominatives.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à la somme de EUR 2.900,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  aux  membres  du  Bureau  et  au  mandataire  des  actionnaires,  ceux-ci  ont  signé  avec  le  notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: J.-H. DOUBET, N. LOUREIRO, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/34575. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 novembre 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015180683/131.
(150201224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.

Everfit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5241 Sandweiler, 56, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 201.224.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünfzehn dreiundzwanzigsten
Vor dem unterzeichnenden Notar Christine Doerner, mit Amtssitz in Bettemburg.

Sind erschienen:

1° Herr John Edward Marley, Geschäftsmann, geboren in London (England) am 24. März 1953, wohnhaft in L-3390

Peppange, 6, rue an der Griecht (Großherzogtum Luxemburg),

2° Herr Miguel Alberto Menes Soro, Geschäftsmann, geboren ind Madrid (Spanien) am 6. Dezember 1986, wohnhaft

in L-3390 Peppange, 6, rue an der Griecht (Großherzogtum Luxemburg),

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die

hiermit gegründet werden soll, wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Gesellschaftsform.  Es  wird  hiermit  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  gegründet  (nachstehend  die

„Gesellschaft“), die dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung
und dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag unterliegt (nachstehend der „Gesellschaftsvertrag“).

Art. 2. Name. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „EVERFIT S.à r.l.“.

Art. 3. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben von Fitnessstudios, das Vermarkten von Fitnessgeräten,

die Vergabe von Lizenzen im Bereich Gesundheitsförderung und Sport sowie die Erbringung von Beratungsdienstleis-
tungen, ebenso der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen,
sowie die Verwaltung und Entwicklung solcher Beteiligungen und deren Verkauf. Die Gesellschaft kann Beteiligungen in
einer oder mehreren Kapital- oder Kommanditgesellschaften (société en commandite simple) halten und als Gesellschafter
mit beschränkter Haftung oder als Geschäftsführer dieser Gesellschaften agieren.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, welche der Gesellschaftsgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung

gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form. Die Ge-
sellschaft kann ihre finanziellen Mittel auch in Grundbesitz, Wertpapieren und intellektuellen Eigentumsrechten jeglicher
Art und Form anlegen sowie Obligationen oder Schuldscheine ausgeben.

Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle und finanzielle Tätigkeit durchführen, welche zur Aus-

führung und Entwicklung ihrer Geschäftszwecke dient.

3466

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Dauer. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt. Die Gesellschaft kann jederzeit durch

einen Beschluss der Gesellschafter gemäß den Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit, die für die
Abänderung des vorliegenden Gesellschaftervertrags erforderlich sind, aufgelöst werden.

Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Sandweiler.
Er kann durch einen Beschluss der Geschäftsführer innerhalb der Gemeinde und der Gesellschafter an jeden anderen

Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Die Geschäftsführer können innerhalb des Großherzogtums Luxemburg
oder in anderen Ländern Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen gründen.

Sollten die Geschäftsführer feststellen, dass außerordentliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaft-

licher Art unmittelbar bevorstehen oder bereits eingetreten sind, welche die gewöhnliche Geschäftsführung der Gesellschaft
am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Kommunikation zwischen dem
Gesellschaftssitz und Personen im Ausland stören könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft vorübergehend, bis zur volls-
tändigen Normalisierung der Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden. Solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen
Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des Sitzes der
Gesellschaft, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von der
Geschäftsführung auszuführen und Dritten gegenüber zur Kenntnis zu bringen.

Art. 6. Gesellschaftskapital.  Das  Gesellschaftskapital  beträgt  zwölftausendfünfhundert  Euro  (12.500,-  EUR).  Es  ist

aufgeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (1,- EUR) und jeweils
voll einbezahlt (zusammen die „Gesellschaftsanteile“).

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluss einer Meh-

rheit von Gesellschaftern, die zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden.

Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt seinen Eigentümer zur Teilhabe am

Gewinn und am Vermögen der Gesellschaft, wie es der vorliegende Gesellschaftsvertrag vorsieht. Jeder Gesellschaftsanteil
gibt seinem Eigentümer das Recht auf eine Stimme bei Abstimmung der Beschlüsse der Gesellschafter.

Das Eigentum eines Gesellschaftsanteils bewirkt automatisch die Annahme des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

und der Beschlüsse der Gesellschafter.

Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. Ge-

meinschaftliche  Eigentümer  eines  Gesellschaftsanteils  müssen  sich  gegenüber  der  Gesellschaft  durch  einen  einzigen
gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Art. 10. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Die Gesellschaftsanteile sind nur unter den Gesellschaftern frei über-

tragbar. Sie dürfen unter Lebenden lediglich dann an Nichtgesellschafter übertragen werden, wenn die Eigentümer von
Gesellschaftsanteilen, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, sich damit einverstanden erklären.

Im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf die Übertragung von Gesellschaftsanteilen des verstorbenen Gesell-

schafters an einen Dritten der Zustimmung der anderen Gesellschafter in einer Hauptversammlung mit einer Mehrheit von
drei Vierteln des Gesellschaftskapitals. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Eltern
oder Abkömmlinge oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 11. Formerfordernisse. Der Beweis für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen wird durch notarielle Urkunde

oder durch privatschriftlichen Vertrag erbracht.

Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie nicht gemäß Artikel

1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt wurde.

Art. 12. Entmündigung, Tod, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters. Die Gesellschaft wird weder

durch die Entmündigung, den Tod, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit, noch durch jedes andere ähnliche Ereignis,
das einen der Gesellschafter betrifft, in Liquidation versetzt.

Art. 13. Geschäftsführung.  Die  Geschäftsführung  obliegt  einem  oder  mehreren  Geschäftsführern,  die  nicht  Gesell-

schafter sein müssen.

Die Geschäftsführer werden durch einen Beschluss der Gesellschafter, welche die Zahl der Geschäftsführer und die

Dauer des Mandates festsetzen, ernannt, wobei die Geschäftsführer bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt bleiben.

Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Angabe von Gründen von den Gesellschaftern abberufen werden.
Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, nicht

aufgelöst.

Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführers. Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft und sind ermächtigt, alle Ge-

schäfte, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind, auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht durch
das Gesetz oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten
sind, liegen in der Zuständigkeit der Geschäftsführer.

Art. 15. Vertretung der Gesellschaft. Sofern ein Geschäftsfürerrat besteht, wird die Gesellschaft durch die gemeinsame

Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet. Der Geschäftsführerrat kann seine Befugnisse für

3467

L

U X E M B O U R G

spezifische Geschäfte einem oder mehreren ad hoc Agenten übertragen. Sofern nur ein Geschäftsführer benannt ist, vertritt
dieser die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift.

Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im Namen der

Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 16. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der Gesellschafterversammlung

gefasst oder durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse, der durch die Geschäftsführer
per Einschreiben an die Gesellschafter übersandt wird. In letzterem Falle sind die Gesellschafter verpflichtet, ihre Stimme
innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab dem Zugang des Wortlauts des vorgeschlagenen Beschlusses schriftlich ab-
zugeben und an die Gesellschaft zu übersenden.

Die Gesellschafter können eine Gesellschafterversammlung nach Einberufung durch die Geschäftsführer gemäß lu-

xemburgischen  Rechts  oder  auf  Anfrage  von  Gesellschaftern,  welche  mehr  als  die  Hälfte  des  Gesellschaftskapitals
darstellen, abhalten. Die Einberufung, welche gemäß Gesetz den Gesellschaftern zugesandt wird, beinhaltet Zeitpunkt und
Ort der Versammlung sowie Tagesordnung und Art des abzuschließenden Geschäfts.

Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären, dass

sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.

Jeder Gesellschafter kann an den Gesellschaftsversammlungen teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der in seinem

Eigentum stehenden Gesellschaftsanteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Ein Gesellschafter kann an einer Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er durch Telefax, Telegramm oder

schriftliche Erklärung einen Vertreter bestellt, welcher kein Gesellschafter sein muss.

Gesellschafterversammlungen, die Jahreshauptversammlung ausgeschlossen, können im Ausland abgehalten werden,

gemäß Urteil der Gesellschafter.

Sofern hierin oder durch das Gesetz nichts anderes bestimmt ist, ist ein Beschluss nur dann rechtswirksam gefasst, wenn

er von Gesellschaftern angenommen wurde, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung
der Satzung benötigt die Zustimmung der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten.

Art. 17. Sitzungsprotokolle der Gesellschafterversammlungen. Die Sitzungsprotokolle der Gesellschafterversammlun-

gen werden von den Geschäftsführern am Gesellschaftssitz aufbewahrt. Vollmachten bleiben beigefügt.

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 19. Bilanz. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und die Geschäftsführer

erstellen ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft, die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung in
Übereinstimmung mit dem Gesetz. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden der Gesellschafterversamm-
lung zur Verabschiedung vorgelegt.

Jeder Gesellschafter oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht, Dokumente hinsichtlich des Jahresabschlusses

während fünfzehn Tagen vor dem Datum der Gesellschafterversammlung am Sitz der Gesellschaft einzusehen.

Art. 20. Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen

Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Über den verbleibenden jährlichen Gewinn wird durch Beschluss der Gesellschafter gemäß Anzahl der Geschäftsanteile

entschieden.

Art. 21. Auflösung, Liquidation. Bei Auflösung der Gesellschaft, veranlasst durch gleich welchen Auflösungsgrund und

zu gleich welchem Zeitpunkt, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler durchgeführt, der/die nicht Ge-
sellschafter sein muss/müssen und der/die durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird/werden, die die Befugnisse
und die Vergütung des/der Abwickler/s festlegen. Bei Fehlen ausdrücklicher anderweitiger Bestimmungen haben die Ab-
wickler die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung der Vermögenswerte und zur Berichtigung der Verbindlichkeiten
der Gesellschaft.

Nach Begleichung aller Schulden und Gebühren der Gesellschaft sowie der Liquidationsausgaben wird der verbleibende

Gewinn gemäß der Anzahl der Geschäftsanteile gleichmäßig an die Inhaber der Gesellschaftsanteile ausgeschüttet.

Art. 22. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag gere-

gelt  sind,  werden  in  Übereinstimmung  mit  dem  anwendbaren  Recht  und  insbesondere  in  Übereinstimmung  mit  dem
Luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung bestimmt.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile wurden sämtlich gezeichnet und vollständig wie folgt ein-

bezahlt:

3468

L

U X E M B O U R G

Gesellschafter

Gezeichnetes

Kapital

Anzahl der

Anteile

Nennwert Einzahlung

Herr Marley, vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.125,-

3.125

1

3.125,-

Herr Menes Soro, vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.375,-

9.375

1

9.375,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,-

12.500

1

12.500,-

Die  Gesellschaftsanteile  wurden  voll  in  barem  Gelde  eingezahlt,  sodass  ab  heute  der  Gesellschaft  die  Summe  von

ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht.

Ein Nachweis der Einzahlung wurde dem unterzeichnenden Notar vorgelegt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2015.

<i>Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

entstehen, werden auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro (1.500,- EUR) geschätzt.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter haben unverzüglich nach Gesellschaftsgründung die folgenden Beschlüsse gefasst:
I. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in L-5241 Sandweiler, 56, rue Principale.
II. Herr John Edward Marley, vorbenannt, wird zum technischen Geschäftsführer (gérant technique) auf unbestimmte

Zeit bestellt. Herr Miguel Alberto Menes Soro, vorbenannt, wird zum administrativen Geschäftsführer (gérant adminis-
tratif) auf unbestimmte Zeit bestellt.

III. Die Gesellschaft ist rechtsgültig vertreten durch die gemeinsamen Unterschriften des technischen Geschäftsführer

und des administrativen Geschäftsführer.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Bettemburg, Datum wie eingangs erwähnt, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: Marley, Menes Soro, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 28 octobre 2015. Relation: EAC/2015/24922. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Bettembourg, le 02 novembre 2015.

Référence de publication: 2015180447/172.
(150201031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.

Compagnie Financière Hispania S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 193.329.

In the year two thousand fifteen, on the twenty-ninth day of October,
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, undersigned,

Was held

an extraordinary general meeting of COMPAGNIE FINANCIERE DU TAFILALET S.A., a company incorporated in

Luxembourg under the form of a société anonyme, having its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the “Register”) under number B 193.329 and
incorporated on 8 December 2014, pursuant to a deed drawn up by Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) dated
3 February 2015, number 280, page 13413 (the “Company”). The articles of association of the Company (as amended from
time to time, including pursuant to the present deed, the “Articles”) have not been amended since its incorporation.

THERE APPEARED

National Floors S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of

Belgium, with registered address at 51, rue du Vieux Marché aux Grains, 1000 Brussels, Belgium and registered with the
Banque Carrefour des Entreprises of Belgium under number 425 292 936,

hereby represented by Barbara Schmitt, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert, by virtue of a

power of attorney given on 22 October 2015,

3469

L

U X E M B O U R G

The power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated above, holding all of the issued shares of the Company (the “Shareholder”),

hereby take the following written resolutions in accordance with the provisions of article 67 of the Luxembourg law of
August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the “Law”).

<i>Sole resolution

The Shareholder resolves to change the corporate name of the Company to “Compagnie Financière Hispania S.A.”.

Consequently, the first paragraph of article 1 of the Articles is hereby amended as follows:

- “There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of Compagnie Financière Hispania

S.A. (the “Company”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and in particular (i) by the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended and (ii) by the present articles (the “Articles”).”

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result

of the present deed, are estimated at approximately nine hundred euros (EUR 900.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, she/he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

En l'année deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois d'octobre,
Par  devant  Maître  Danielle  KOLBACH,  notaire  de  résidence  à  Redange-sur-Attert,  Grand-Duché  de  Luxembourg,

soussignée,

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire de COMPAGNIE FINANCIERE DU TAFILALET S.A., une société constituée

au Luxembourg sous forme de société anonyme, ayant son siège social au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (le «Registre») sous le numéro B 193.329, constituée le 8
décembre 2014 par un acte du notaire Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, dont
l'immatriculation a été publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») en date du 3 février
2015, numéro 280, page 13413. Les statuts de la Société (qui seront désignés tels que modifiés, y compris par le présent
acte, comme les «Statuts») n'ont pas encore été modifiés depuis la constitution.

A COMPARU

National Floors S.A., une société anonyme constituée et existante sous le droit belge, ayant son siège social au 51, rue

du Vieux Marché aux Grains, 1000 Bruxelles, Belgique et immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises de
la Belgique sous le numéro 425 292 936,

ici représenté par Barbara Schmitt, employée privée résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d'une

procuration signée le 22 octobre 2015,

La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, détenant toutes les actions émises par la Société (l'«Ac-

tionnaire»), prend les résolutions suivantes en conformité avec les dispositions de l'article 67 de la loi concernant les sociétés
commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi»).

<i>Résolution unique

L'Actionnaire décide de changer la dénomination sociale de la Société en «Compagnie Financière Hispania S.A.». En

conséquence, le premier paragraphe de l'article 1 des Statuts est modifié pour refléter ce changement comme suit:

- «Il existe une société anonyme sous la dénomination de «Compagnie Financière Hispania S.A.» (la «Société») régie

par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et plus particulièrement (i) par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée ainsi que (ii) par les présents statuts (les «Statuts»).»

<i>Coûts

Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous toute forme que ce soit, devant être mis à la charge de la Société en

raison du présent acte, s'élèvent à environ neuf cents euros (900,- EUR).

3470

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête du représentant de la partie

comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. Sur demande de la partie comparante, en
cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, rédigé et passé à Redange-sur-Attert, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé avec le notaire instrumentant le présent

acte original.

Signé: S. LECOMTE, B. SCHMITT, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 2 novembre 2015. Relation: DAC/2015/18472. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): J. THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Redange-sur-Attert, le 5 novembre 2015.

Référence de publication: 2015180383/88.
(150200822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.

HORIZON Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5670 Altwies, "Le Moulin", route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 169.056.

L'an deux mille quinze, le vingt-deux octobre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S’est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «HORIZON Consulting S.A.», avec siège

social à L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 169.056, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 16 mai 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1624 du 28 juin 2012 et
modifiée suivante acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 juin 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2093 du 14 août 2015.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à

Junglinster.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gerhard NELLINGER, con-

seiller, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social vers L-5670 Altwies, «Le Moulin», route de Luxembourg.
2.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.
3.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société vers L-5670 Altwies, «Le Moulin», route de Luxembourg.

3471

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier premier alinéa

de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. (Premier alinéa). Le siège social est établi dans la commune de Mondorf-les-Bains.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille euros.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Henri DA CRUZ, Gerhard NELLINGER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 octobre 2015. Relation GAC/2015/9174. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2015180545/56.
(150201175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.

Magenlux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 198.634.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of October;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

MagenLux MIPCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 488, route de Longwy, L-1940

Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Companies Register under number B 200.440 (the "Sole Sharehol-
der"),

in its capacity as Sole Shareholder of Magenlux S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at

488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 198.634 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 13 July 2015, whose articles
of incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 9 September 2015, number
2442, page 117207 (the "Articles"). The Articles have been not been amended since then.

The Sole Shareholder is represented by Mrs Alexia UHL, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of

a proxy given under private seal, which, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, acting in its capacity as sole shareholder of the Company and represented as stated here above,

hereby passes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law
of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended from time to time:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two million one hundred

twenty thousand five hundred US Dollars (USD 2,120,500.-) so as to raise it from its present amount of twenty-five thousand
US Dollars (USD 25,000.-) to two million one hundred forty-five thousand five hundred US Dollars (USD 2,145,500.-)
by the issue of two hundred twelve million fifty thousand (212,050,000) new shares with a nominal value of one US Dollar
cent (USD 0.01) each and having the rights and obligations set out in the Articles (the "New Shares"), each of such New
Shares being paid up by way of contribution in cash, together with a share premium in a total amount of two hundred nine
million nine hundred twenty-nine thousand five hundred US Dollars (USD 209,929,500.-).

<i>Subscription and payment

The Sole Shareholder declares to subscribe to the New Shares, together with a share premium of two hundred nine

million nine hundred twenty-nine thousand five hundred US Dollars (USD 209,929,500.-), through a contribution in cash.

The total amount of the capital increase amounting to two hundred twelve million fifty thousand US Dollars (USD

212,050,000.-):  is  allocated  as  follows:  two  million  one  hundred  twenty  thousand  five  hundred  US  Dollars  (USD
2,120,500.-) to the share capital of the Company and two hundred nine million nine hundred twenty-nine thousand five
hundred US Dollars (USD 209,929,500.-) to the share premium account of the Company.

3472

L

U X E M B O U R G

Proof  of  the  payment  of  the  aggregate  amount  of  two  hundred  twelve  million  fifty  thousand  US  Dollars  (USD

212,050,000.-) has been given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Articles of the Company to reflect the capital increase, which

shall now read as follows:

Art. 5. The Company's share capital is set at two million one hundred forty-five thousand five hundred US Dollars

(USD 2,145,500.-) represented by two hundred fourteen million five hundred fifty thousand (214,550,000) shares with a
par value of one US-Dollar cent (USD 0.01) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of shares

in existence."

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxyholder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by

name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour d'octobre;
Par-devant le soussigné, Maître Carlo WERSANDT, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

A COMPARU:

Magenlux MIPCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 488, route de Longwy, L-1940

Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200.440 (l "Associé
Unique"),

en tant qu'Associé Unique de Magenlux S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 488, route

de Longwy, L-1940 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 198.634 (la "Société") et constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 juillet 2015, dont les
statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 9 septembre, numéro 2442, page 117207 (les
"Statuts"). Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'Associé Unique est représenté par Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d'une procuration qui a été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire soussigné et qui restera
annexée au présent acte afin d'être soumise aux mêmes formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique agissant en tant qu'associé unique de la Société et représenté comme indiqué ci-dessus, adopte les

résolutions suivantes conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commer-
ciales du 10 août 1915, telle que modifiée le cas échéant:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux millions cent vingt mille cinq

cents dollars américains (2.120.500,- USD) de façon à le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille dollars américains
(25.000,-USD) à deux millions cent quarante-cinq mille cinq cents dollars américains (2.145.500,- USD) par l'émission de
deux cent douze millions cinquante mille (212.050.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un centime de
dollar américain (0,01 USD) chacune et ayant les droits et obligations décrits dans les Statuts (les "Nouvelles Parts Socia-
les"),  chacune  de  ces  Nouvelles  Parts  Sociales  étant  libérées  par  un  apport  en  numéraire,  ensemble  avec  une  prime
d'émission  d'un  montant  total  de  deux  cent  neuf  millions  neuf  cent  vingt-neuf  mille  cinq  cents  dollars  américains
(209.929.500,- USD).

<i>Souscription et paiement

L'Associé Unique déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales, ensemble avec une prime d'émission de deux cent

neuf millions neuf cent vingt-neuf mille cinq cents dollars américains (209.929.500,- USD), par un apport en numéraire.

Le montant total de l'augmentation de capital s'élevant à deux cent douze millions cinquante mille dollars américains

(212.050.000,- USD) a été alloué comme suit: deux millions cent vingt mille cinq cents dollars américains (2.120.500,-
USD) au capital social de la Société et deux cent neuf millions neuf cent vingt-neuf mille cinq cents dollars américains
(209.929.500,- USD) au compte de prime d'émission de la Société.

La preuve du paiement du montant total de deux cent douze millions cinquante mille dollars américains (212.050.000,-

USD) a été remise au notaire soussigné.

3473

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts de la Société pour refléter l'augmentation de capital, qui se

lira désormais comme suit:

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à deux millions cent quarante-cinq mille cinq cents dollars américains

(2.145.500,- USD) représenté par deux cent quatorze millions cinq cent cinquante mille (214.550.000) parts sociales ayant
chacune une valeur nominale d'un centime de dollars américain (0,01 USD).

Chaque part sociale a un droit de vote lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Chaque part sociales donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe du nombre de

parts sociales en existence."

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare qu'à la requête de la partie comparante ci-

dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même partie comparante, et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par ses

nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 03 novembre 2015. 2LAC/2015/24704. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 05 novembre 2015.

Référence de publication: 2015180669/114.
(150200708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.

Fräiwëlleg Pompjeeën vu Koler, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8376 Kahler, 38, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg F 10.578.

STATUTEN

Kapitel I. Name, Sitz, Dauer, Zweck

Art. 1. Die Vereinigung trägt den Namen "Fräiwëlleg Pompjeeën vu Koler".

Art. 2. Der Sitz der Vereinigung ist im Feuerwehrlokal in Kahler, welches von der Gemeinde Garnich zu Verfügung

gestellt wird.

Art. 3. Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt.

Art. 4. Die Aufgabe der Vereinigung ist, als Feuerwehr: die geordnete Hilfeleistung und Prävention bei Bränden, Ret-

tungseinsätzen, Unfällen und anderen Notständen, wo die Sicherheit von Personen und Gütern in Gefahr ist.

Die Vereinigung gehört dem Luxemburger Landesfeuerwehrverband und dem zuständigen Kantonalverband an. Sie

steht ehrenamtlich und autonom im Dienste der Gemeinde Garnich.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe dient die theoretische und praktische Ausbildung der aktiven Wehrmitglieder auf lokaler,

kantonaler und nationaler Ebene.

Eine weitere Aufgabe besteht darin, die Mitglieder zur Hilfsbereitschaft anzuregen, sowie die Kameradschaft unter

ihnen zu fördern und zu pflegen.

Die eventuelle Bildung einer Jugendfeuerwehr ist ins Auge zu fassen und nach den Reglements der Nationalen Jugend-

kommission auszurichten.

Die Vereinigung kann alle zu ihrem Geschäftszweck nötigen Tätigkeiten und Akte unternehmen ohne den Feuerwehr-

dienst zu beeinträchtigen.

Die Vereinigung, hierunter als "Wehr" benannt, ist politisch und ideologisch neutral.

Kapitel II. Mitglieder

Art. 5. Die Wehr besteht aus:
Aktiven Mitgliedern;
Inaktiven Mitgliedern;
Ehrenmitgliedern.

3474

L

U X E M B O U R G

Die Anzahl der aktiven Mitglieder ist unbegrenzt, soll jedoch nie unter 6 sinken.

Art. 6. Aktives Mitglied kann jeder unbescholtene Bürger werden, welcher die vorgeschriebenen Mindestfeuerweh-

rausbildungen absolviert hat und den vorgeschriebenen Jahresbeitrag leistet. Aktive Mitglieder können werden:

a) Jugendliche vom 8. bis 16. Lebensjahr. Sie sind Mitglieder der Jugendfeuerwehr.
b) Personen vom 16. bis zum 65. Lebensjahr. Sie bilden die Erwachsenenabteilung.
Für Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr ist die Zustimmung der Eltern oder des Erziehungsberechtigten erfordert.
Jugendliche, die sich in der Jugendfeuerwehr bewährt haben, werden ab dem 16. Lebensjahr in die Erwachsenenabtei-

lung übernommen.

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand in geheimer Wahl. Eine eventuelle Ablehnung ist zu begründen und dem

Antragsteller schriftlich mitzuteilen.

Die aktive Dienstzeit erlischt mit dem Erreichen der vom Landesfeuerwehrverband festgesetzten Altersgrenze. Erwor-

bene Rechte auf Ehrenzeichen, Veteranenzulage und Sterbegeld bleiben jedoch gewahrt.

Art. 7. Inaktives Mitglied wird jedes aktive Mitglied beim Erreichen der Altersgrenze, bei Invalidität und bei festges-

tellter Feuerwehrdienstunfähigkeit und welches den vorgeschriebenen Jahresbeitrag leistet. Im Notfall können inaktive
Mitglieder für die ihnen zumutbaren Aufgaben und Arbeiten hinzugezogen werden.

Art. 8. Ehrenmitglied kann jeder werden, der zur Förderung und Unterstützung der Wehr den hierzu vorgeschriebenen

Jahresbeitrag leistet. Ehrenmitglieder sind nicht stimmberechtigt.

Art. 9. Jedes aktive Mitglied hat die Pflicht bei der Gestaltung des Wehrgeschehens mitzuwirken und das Recht in

eigener Sache gehört zu werden. Ab dem 16. Lebensjahr ist es stimmberechtigt in der Generalversammlung falls es seinen
Mitgliedsbeitrag vor der Generalversammlung entrichtet hat.

Jedes aktive Mitglied übernimmt freiwillig die Verpflichtung:
- die im Rahmen der Statuten und Reglements gegebenen Anordnungen genau zu befolgen;
- an den angesetzten praktischen und theoretischen Übungen und Wehrmanifestationen regelmäßig, pünktlich und aktiv

teilzunehmen;

- sich soweit als möglich an allen Einsätzen der Wehr bei Bränden und sonstigen Notständen aktiv zu beteiligen;
- Disziplin und Gehorsam gegenüber den Vorgesetzten zu wahren sowie Kameradschaft innerhalb der Mannschaft zu

respektieren;

- aktiv am Ansehen und Gedeihen der Wehr teilzunehmen.

Art. 10. Jedes inaktive Mitglied hat das Recht bei der Gestaltung des Wehrgeschehens mitzuwirken und in eigener Sache

gehört zu werden. Ab dem 16. Lebensjahr ist es stimmberechtigt in der Generalversammlung

Jedes inaktive Mitglied übernimmt freiwillig die Verpflichtung:
- die im Rahmen der Statuten und Reglements gegebenen Anordnungen genau zu befolgen;
- Disziplin und Gehorsam gegenüber den Vorgesetzten zu wahren sowie Kameradschaft innerhalb der Mannschaft zu

respektieren;

- aktiv am Ansehen und Gedeihen der Wehr teilzunehmen.

Art. 11. Bei Verstößen gegen die Statuten und Reglements der Wehr, des Kantonalverbandes oder des Landesfeuer-

wehrverbandes können folgende Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden:

a. Verweis durch den Wehrchef;
b. Verweis vor dem Vorstand;
c. Suspendierung durch den Vorstand;
d. Ausschluss durch die Generalversammlung;
e. Offiziere mit Ausnahme des Wehrchefs resp. Offiziere welche einer oder mehreren Sektionen vorstehen können ihres

Postens vorübergehend oder vorläufig durch mehrheitlichen Vorstandsbeschluss enthoben werden wenn sie gegen die
Statuten und Reglements der Wehr, des Kantonal- oder Landesfeuerwehrverbandes verstoßen, ihren Pflichten nicht ge-
wachsen sind oder sie vernachlässigen bez. auf persönlichen Antrag. Der Vorstand ist in diesem Falle nur beschlussfähig,
wenn mindestens 3/4 der Mitglieder anwesend sind. Eine vorübergehende Amtsenthebung kann nur über einen Zeitraum
von maximal 12 Monaten ausgesprochen werden. Eine vorläufige Amtsenthebung kann nur bis zur nächsten Generalver-
sammlung ausgesprochen werden. Letztere entscheidet über eine endgültige Amtsenthebung. Die Generalversammlung
kann laut großherzoglichem Reglement vom 07. Mai 1992 betreffend die Organisation des Feuerlöschund Rettungsdienstes,
Art. 29, dem Gemeinderat die Abberufung des Wehrchefs vorschlagen.

Gegen die Ordnungsmaßnahmen steht jedem aktiven und inaktiven Mitglied der Wehr das Recht auf Beschwerde zu.

Diese muss spätestens 7 Tage nach Ausspruch der Ordnungsmaßnahme schriftlich beim Wehrchef eingebracht werden.
Die anschließende Entscheidung des Vorstandes wird dem Beschwerdeführer schriftlich mitgeteilt.

3475

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Die Mitgliedschaft erlischt durch:
- Tod;
- Freiwilligen Austritt;
- Nichtbezahlung des Mitgliedsbeitrags;
- Ausschluss durch die Generalversammlung.

Art. 13.  Der  Ausschluss  eines  Mitgliedes  wird  durch  die  Generalversammlung  mit  einer  2/3  Stimmenmehrheit  der

anwesenden stimmberechtigten Mitglieder vorgenommen und zwar in folgenden Fällen:

- wenn ein Mitglied durch eine Tat oder eine Nachlässigkeit schwerwiegend gegen die Statuten oder Reglements der

Wehr, des Kantonal- oder Landesfeuerwehrverbandes verstoßen hat;

- wenn ein Mitglied durch eine Tat oder eine Nachlässigkeit seinem guten Ruf oder seiner persönlichen Ehre, der Ehre

eines anderen Mitgliedes oder derjenigen der Wehr geschadet hat.

Die ausgetretenen oder ausgeschlossenen Mitglieder, sowie die Nachkommen von verstorbenen Mitgliedern, können

weder gezahlte Beiträge zurückfordern, noch irgendwelche Ansprüche auf das Vermögen der Wehr geltend machen. Jed-
wedes Effekt oder anderer zur Verfügung gestellter Besitz der Wehr oder des Feuerlöschdienstes sind spätestens 30 Tage
nach Erhalt einer schriftlichen Zurückforderung beim Wehrchef abzuliefern. Fehlendes oder Beschädigtes ist zu ersetzen,
wenn nötig durch das Bezahlen der Neuanschaffungssumme. Bei verstorbenen Mitgliedern kommen die legalen Erben
diesen Verpflichtungen nach. In jedem Fall behält die Wehr sich gerichtliche Schritte zur Zurückerlangung ihres Eigentums
vor.

Art. 14. Der Mitgliederbeitrag wird jedes Jahr vom Vorstand vorgeschlagen und von der Generalversammlung festge-

setzt.  Dieser  Beitrag  kann  die  Summe  von  EUR  5,-(fünf)  Indexziffer  100  für  aktive  und  inaktive  Mitglieder  nicht
übersteigen. Der für Ehrenmitglieder festgesetzte Beitrag ist jeweils der Mindestbeitrag.

Der Mitgliedsbeitrag ist innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach der Generalversammlung zu zahlen. Nach 3 Monaten

erhält das Mitglied vom Kassierer eine schriftliche Zahlungserinnerung. Bei Nichtzahlung des Beitrags bis 6 Monate nach
der Generalversammlung erlischt die Mitgliedschaft.

Kapitel III. Der Vorstand

Art. 15. Der Vorstand setzt sich mit Ausnahme der Beisitzenden aus aktiven Feuerwehrleuten zusammen.

Art. 16. Die Leitung der Wehr geschieht durch den Wehrchef. Ihm zur Seite steht der Vorstand:
a. der Wehrchef (chef de corps);
b. der (die) Wehrchefstellvertreter (chef(s) de corps adjoint(s));
c. der Schriftführer (secrétaire);
d. der Kassierer (caissier)
e. der (die) Offiziere (chef(s) de section)
f. der Jugendleiter
g. der (die) Beisitzenden (Mannschaftsvertreter);
Aus der Zahl der Wehrsektionen zu 9 Feuerwehrleuten der Erwachsenenabteilung ergeben sich laut Reglement des

Landesfeuerwehrverbandes Dienstgrad des Wehrchefs, Anzahl und Dienstgrad der Stellvertreter, sowie die Anzahl der
Beisitzenden und Offiziere (chef(s) de section). Die Zahl der Beisitzenden wird auf- bez. abgerundet um eine ungerade
Anzahl von Vorstandsmitgliedern zu ergeben.

Art. 17. Der Wehrchef, der (die) Wehrchefstellvertreter, der (die) Offiziere (chef(s) de section) und der Jugendleiter

werden auf unbestimmte Zeit mit einfacher Stimmenmehrheit von der Generalversammlung in geheimer Wahl bestimmt.

Die Ernennung der hier aufgeführten Chargierten geschieht gegebenenfalls wie im Gesetz betreffend das Feuerlösch-

wesen vorgesehen. Sie müssen alle vier Jahre von der Generalversammlung im Amt bestätigt werden. Falls eine Bestätigung
verweigert wird, wird der die Ernennung vornehmenden Verwaltung die Abberufung des Chargierten vorgeschlagen.

Die Beisitzenden werden auf die Dauer von vier Jahren durch die Generalversammlung bestimmt.
Die Bestätigung von Wehrchef und der Unteroffiziere sowie des Jugendleiters werden in verschränkter Reihenfolge mit

jenen der Wehrchefstellvertreter und der Beisitzenden vorgenommen.

Diese Wahlen sind umgehend der Gemeindeverwaltung sowie über die zuständige Dienststelle dem Generalsekretariat

des Landesfeuerwehrverbandes über den Kantonalverband schriftlich mitzuteilen.

Art. 18. Jeder (freie) Posten im Vorstand wird einzeln ausgeschrieben. Kann ein Posten in der Generalversammlung

nicht besetzt werden, so kann der Vorstand den Posten vorläufig neu besetzen, unbeschadet der Bestätigung durch die
nächste Generalversammlung.

Art. 19. Bei eventueller Stimmengleichheit bei allen Wahlen wird sofort ein zweiter Wahlgang abgehalten. Bei even-

tueller Stimmengleichheit beim zweiten Wahlgang ist der dienstälteste Kandidat gewählt.

3476

L

U X E M B O U R G

Art. 20.  Kandidaten  für  einen  Posten  als  Offizier  (chef  de  corps,  chef(s)  de  corps  adjoint,  chef(s)  de  section)  oder

Jugendleiter müssen die durch den Landesfeuerwehrverband vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen.

Art. 21. Kandidaten für einen Posten im Wehrvorstand müssen wenigstens zwei Jahre aktives oder inaktives Mitglied

der Wehr sein und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Kandidaturen müssen wenigstens 8 Tage vor der Generalver-
sammlung schriftlich beim Wehrchef eingegangen sein.

Art. 22. Die Vorstandsmitglieder treten aus ihrem Amt: durch Tod; freiwilligen Austritt; Abberufung; Ausschluss.
Wird ein Vorstandsposten während dem Geschäftsjahr frei, so kann der Vorstand den Posten vorläufig neu besetzen,

unbeschadet der Bestätigung durch die nächste Generalversammlung. Im Falle einer Neubesetzung vor Ablauf der normalen
Mandatsdauer übernimmt das neue Vorstandsmitglied den Posten für die restliche Mandatsdauer.

Im Falle des Wehrchefs übernimmt der dienstälteste Stellvertreter das Amt bis zur nächsten Generalversammlung.
Fehlt ein Vorstandsmitglied unentschuldigt bei drei aufeinanderfolgenden Vorstandssitzungen, so scheidet es automa-

tisch aus dem Vorstand aus.

Art. 23. Der Vorstand trifft sooft zusammen, wie es die Belange der Wehr erfordern, wenigstens jedoch 3 Mal im Jahr,

auf Einberufung durch den Wehrchef oder falls 1/3 des Vorstandes dies wünscht. Der Vorstand ist beschlussfähig wenn
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stim-
mengleichheit wird die Angelegenheit auf die kommende Sitzung vertagt. Bei erneuter Stimmengleichheit ist die Stimme
des Wehrchefs ausschlaggebend.

Art. 24. Der Vorstand hat die weitgehendsten Befugnisse zur Führung der Wehrgeschäfte. Alles was nicht ausdrücklich

durch die vorliegenden Statuten oder durch Gesetz der Generalversammlung vorbehalten ist, gehört zu seinem Aufgaben-
bereich. Er kann Reglements und Dienstvorschriften erlassen, abändern oder aufheben. Der Vorstand legt seine interne
Aufgabenverteilung fest. Er kann allgemeine oder spezielle Vollmachten erteilen, darunter die Bankvollmachten. Er kann
Kommissionen einsetzen, denen jedoch ein Vorstandsmitglied angehören muss.

Art. 25. Die Aufgaben des Wehrchefs sind:
a. die Leitung aller Einsätze sowie des Ausbildungs-, Übungs-, Rettungs- und Brandschutzdienstes;
b. die Leitung der Vorstandssitzungen und der Generalversammlung;
c. die Vertretung der Wehr;
d. die Beurkundung, mit dem Sekretär, der Sitzungsberichte, der Korrespondenz und aller wichtigen Schriftstücke;
e. die Aufsicht über ordnungsgemäßen Auftritt und vorschriftsmäßige Bekleidung der Feuerwehrleute bei Ausgängen

der Wehr;

f. die Beratung der Gemeinde in allen Angelegenheiten des Brand- und Rettungsdienstes, der Anschaffung von Feuer-

lösch- und Rettungsmaterial und die Anregung von Verbesserungsmaßnahmen;

g. die Überwachung einer ordnungsgemäßen Führung von Inventar- und Dienstbuch, sowie die Mitglieder- und An-

wesenheitslisten;

h. er betraut einen seiner Mitarbeiter mit der Ausbildung der Feuerwehrleute in der Wehr.

Art. 26. Der (die) Wehrchefstellvertreter (chef(s) de corps adjoint(s)) haben die Aufgabe den Wehrchef bei der Aus-

führung seiner Mission zu unterstützen und ihn im Abwesenheits- oder Verhinderungsfall zu ersetzen.

Art. 27. Der (die) Offiziere (chef(s) de section) haben die Aufgabe, Wehrchef und seine Stellvertreter bei der Ausbildung

und im Einsatz zu unterstützen.

Art. 28. Der Jugendleiter unterrichtet die Jugendfeuerwehr nach den Reglements und Vorschriften der Nationalen Ju-

gendfeuerwehrkommission. Er legt dem Wehrchef Rechenschaft ab.

Art. 29. Der Sekretär der Wehr führt das Mitgliedsverzeichnis. Er erledigt alle die ihm auferlegten schriftlichen Arbeiten.

Er verfasst die Berichte über die Vorstandssitzungen und die Generalversammlungen.

Art. 30. Alle Gerichtsverfahren werden im Namen der Wehr durch den Vorstand, vertreten durch den Wehrchef und

ein zweites Vorstandsmitglied, geführt.

Die Wehr ist in allen Fällen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern gebunden, darunter

obligatorisch jene des Wehrchefs oder im Verhinderungsfalle jene seines Stellvertreters, unbeschadet der Artikel 24 und
36.

Kapitel IV. Die Generalversammlung

Art. 31. Die Generalversammlung wird jedes Jahr im ersten Viertel des Jahres vom Vorstand einberufen. Stimmbe-

rechtigt sind alle aktive und inaktive Mitglieder.

Eine außerordentliche Generalversammlung kann vom Vorstand einberufen werden, wenn die Umstände dies verlangen.

Bei schriftlicher Anfrage von 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder muss eine außergewöhnliche Generalversammlung
innerhalb von zwei Monaten einberufen werden.

3477

L

U X E M B O U R G

Einberufungen zur Generalversammlung erfolgen schriftlich mit einer Frist von 14 Tagen, unter Angabe der Tagesord-

nung an alle stimmberechtigten Mitglieder.

Art. 32. Die Generalversammlung wird vom Wehrchef oder im Verhinderungsfall von seinem Stellvertreter geleitet.

Sie ist öffentlich.

Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens 1/2 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Ist dies nicht der Fall, so

kann sofort eine außergewöhnliche Generalversammlung einberufen werden, welche in jedem Fall beschlussfähig ist.

Jedes stimmberechtigte Mitglied verfügt über eine Stimme.
Ein Mitglied kann sich per schriftlicher Vollmacht durch ein anderes Feuerwehrmitglied vertreten lassen.
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, sofern die vorliegenden Statuten es nicht anders bestimmen.
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.
Die Beschlüsse der Generalversammlung werden in einem eigenen Register festgehalten.

Art. 33. Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben:
a. das Vorschlagen der Chargierten zur Ernennung an die vom Gesetz vorgesehene Verwaltung;
b. die Wahl des Vorstandes und der Kassenrevisoren;
c. die 4-jährliche Bestätigung des Wehrchefs und der übrigen Vorstandsmitglieder, bez. deren Abberufung;
d. den Ausschluss eines Mitgliedes;
e. die Festlegung der Mitgliedsbeiträge;
f. die Beratung und Beschlussfassung über eingebrachte Anträge;
g. die Abänderung der Wehrstatuten;
h. die Entscheidung über Angelegenheiten die der Vorstand nicht verabschieden kann;
i. die Auflösung der Wehr.

Art. 34. 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder kann durch schriftlichen Antrag einen zusätzlichen Tagesordnungspunkt

zur Diskussion stellen.

Dieser Antrag muss dem Wehrchef 8 Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Beschlüsse über Punkte welche nicht auf der Tagesordnung stehen können nur gefasst werden, wenn 2/3 der anwesenden

stimmberechtigten Mitglieder dies so beschließen. Dabei darf jedoch kein Beschluss über die unter Artikel 33 aufgeführten
Punkte gefasst werden.

Art. 35. Die Statuten der Wehr können nur abgeändert werden, wenn die zur Änderung anstehenden Artikel in der

Einberufung zur Generalversammlung aufgeführt sind und wenn 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.

Für eine Änderung ist eine 2/3 Stimmenmehrheit erforderlich. Wenn keine 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder an-

wesend  sind  kann  eine  zweite  Generalversammlung  stattfinden,  wobei  die  Hälfte  der  stimmberechtigten  Mitglieder
anwesend sein muss.

Kapitel V. Kassenwesen und Geschäftsjahr

Art. 36. Das Kassenwesen wird vom Kassierer der Wehr versehen. Er führt ordnungsgemäß Buch über Einnahmen und

Ausgaben und legt Rechnung ab. Er vertritt die Wehr gegenüber Geldinstituten für alle laufenden Geschäfte. Im Verhin-
derungsfall wird er hierbei durch den Wehrchef persönlich vertreten.

Kassen- und Buchführung sind jährlich, nach Ablauf des Geschäftsjahres abzuschließen und von mindestens zwei Kas-

senrevisoren zu prüfen und abzuzeichnen.

Der Vorstand erhält Entlastung durch die Generalversammlung.
Der Kassierer hält das Kassen- und Kontenbuch dem Vorstand jederzeit zur Ansicht zur Verfügung.
Die Generalversammlung bestimmt jedes Jahr mindestens zwei Kassenrevisoren unter den aktiven oder inaktiven Mit-

gliedern, welche dem Vorstand nicht angehören dürfen. Sie legen dem Vorstand und der Generalversammlung Bericht
über die Kassenprüfung ab.

Art. 37. Das Geschäftsjahr geht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr

an dem Datum der Unterzeichnung vorliegender Statuten und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Kapitel VI. Fusion, Auflösung

Art. 38. Eine Fusion oder die Auflösung der Wehr kann nur geschehen, wenn in einer zu diesem Zweck einberufenen

Generalversammlung 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Wenn keine 2/3 der stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend sind kann eine zweite Generalversammlung einberufen werden, wobei die Hälfte der stimmberechtigten
Mitglieder anwesend sein muss.

Die Fusion oder Auflösung der Wehr kann nur durch eine Stimmenmehrheit von 3/4 angenommen werden.

Art. 39. Im Falle der Auflösung der Wehr wird das Liquidationsverfahren von der Generalversammlung festgelegt. Nach

Begleichung aller Schulden wird das Vermögen der Wehr der Gemeinde Garnich überwiesen, mit dem Auftrag es einer

3478

L

U X E M B O U R G

neuen Feuerwehr in Kahler zu übergeben. Andernfalls soll das gesamte Vermögen dem Sozialfond der Gemeinde Garnich
zugeführt werden.

Art. 40. Im Falle einer Fusion mit einer anderen Wehr kann der gesamte Besitz der Wehr einem von der Generalver-

sammlung zu bestimmenden Verein aus Kahler überschrieben werden. Findet sich kein Verein aus Kahler, so wird der
gesamte Besitz der Wehr der neuen Fusionswehr überschrieben.

Kapitel VII. Verschiedenes:

Art. 41. Die Wehr übernimmt keine Haftung für eventuell im Dienst erlittene Schäden. Schadensansprüche können nur

nach den geltenden gesetzlichen oder reglementarischen Regeln gestellt werden.

Art. 42. Das Corps "Fräiwëlleg Pompjeeën vu Koler" übernimmt ab dem Datum der Gründung alle historische und

materielle Rechte und Verpflichtungen der "Freiwilligen Feuerwehr von Kahler, gegründet Juni 1914".

Der Vorstand der "Freiwilligen Feuerwehr von Kahler, gegründet Juni 1914" bleibt bis zur ersten Generalversammlung

der "Fräiwëlleg Pompjeeën vu Koler" unverändert im Amt.

Art. 43. Für alle in den gegenwärtigen Statuten nicht ausdrücklich vorgesehenen Fällen gelten die allgemeinen Bes-

timmungen des Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck, die Satzungen und Richtlinien
des Landesfeuerwehrverbandes, die großherzoglichen und ministeriellen Reglements betreffend das Feuerlösch- und Ret-
tungswesen, sowie die diesbezüglichen Reglements der Gemeinde Garnich.

Référence de publication: 2015180465/259.
(150201506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.

Lux Property Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 171.739.

L'an deux mille quinze, le vingt-trois septembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «LUX PROPERTY INVEST S.A.», avec

siège social à L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, notaire
de résidence à Luxembourg en date du 20 septembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2638 du 25 octobre 2012, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement

à -1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,

qui désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, demeurant professionnellement à la même

adresse.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabel DIAS, prénommée.
Le bureau ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l'adresse du siège social de la société de L-2449 Luxembourg, 2 , Boulevard Royal à L-4210 Esch-

sur-Alzette, 69, rue de la Libération et modification de l'article 1, deuxième alinéa des statuts de la Société.

2. Divers.
Ce fait exposé et reconnu exact par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de changer l'adresse du siège social de la société de de L-2449 Luxembourg, 2 , Boulevard Royal

à L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération et de modifier l'article 1, deuxième alinéa ainsi que l'article 8, premier
alinéa, des statuts de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:

3479

L

U X E M B O U R G

 Art. 1 

er

 . Deuxième alinéa.  Le siège social est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette.".

« Art. 8. Premier alinéa. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier mardi du mois de juin à 11.00

heures à Esch-sur-Alzette au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Les autres alinéas des prédits articles restent inchangés.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille trois cents Euros (EUR 1.300.-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits

comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: I. Dias, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 1 octobre 2015. Relation: AC/2015/22045. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 5 novembre 2015.

Référence de publication: 2015180655/56.
(150200678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.

Logicor (Scorpion) Pledgeco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l.).

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 195.167.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth day of the month of October;
Before Us Maître Cosita DELVAUX, notary, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

There appeared

Logicor Europe Holdings II S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share
capital of EUR 25,000 and registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des
Sociétés, Luxembourg) under number B181.528 (the “Sole Shareholder”),

represented by Me Vianney de Bagneaux, avocat, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 27

October 2015 which after having been signed ne varietur shall remain attached to the present deed to be submitted together
with it to the registration formalities,

being the Sole Shareholder of Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée,

having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B195.167, incorporated on 2 March 2015 by a deed
of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of 20 April
2015 number 1036.

The articles of association of the Company have been amended for the last time on 4 July 2015 pursuant to a deed of

Maître Leonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître
Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial on 6 October
2015, number 2754.

The appearing party, represented as stated above, declared and the notary recorded as follows:
I. That the appearing party is the sole shareholder of the Company and holds all the one thousand (1,000) shares in issue

in the Company represented by five hundred (500) class A shares and five hundred (500) class B shares with a par value
of twenty-five Euro (EUR 25) each so that the entire share capital is represented and decisions can be validly taken by the
Sole Shareholder.

II. That the Sole Shareholder wishes to take decisions on the items on the following agenda:

3480

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. To change the name of the Company into “Logicor (Scorpion) Pledgeco S.à r.l.” and consequently to amend Article

1 of the articles of association of the Company as set forth in the third resolution below.

2. To restructure the issued share capital of the Company by:
(i) Removing the two classes of shares, namely class A and class B shares with such rights and obligations as reflected

in the articles of association as amended and restated as set forth in the third resolution below;

(ii) reclassifying five hundred (500) class A shares in issue in the Company into five hundred (500) ordinary shares;
(iii) reclassifying five hundred (500) class B shares in issue in the Company into five hundred (500) ordinary shares.
3. Consequently to amend and restate the articles of association of the Company in their entirety so that they shall read

as set forth in the third resolution below.

Thereafter the following resolutions were passed by the Sole Shareholder of the Company:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to change the name of the Company into “Logicor (Scorpion) Pledgeco S.à r.l.” and

consequently to amend Article 1 of the articles of association of the Company as set forth in the third resolution below.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to restructure the issued share capital of the Company as set forth below.
The Sole Shareholder resolved to remove the two classes of shares, namely the class A shares and the class B shares

with such rights and obligations and to replace it by ordinary shares only, as reflected in the articles of association of the
Company as amended and restated as set forth in the third resolution below.

The Sole Shareholder resolved to reclassify five hundred (500) existing class A shares in issue in the Company into five

hundred (500) ordinary shares.

The Sole Shareholder resolved to reclassify five hundred (500) existing class B shares in issue in the Company into five

hundred (500) ordinary shares.

The Sole Shareholder resolves to acknowledge that the issued share capital of the Company is represented by 1,000

ordinary shares.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to fully amend and restate the Company’s articles of association to take into account the

above resolutions so that they shall read as follows:

“ Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Logicor (Scorpion)

Pledgeco S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.

The  Company  may  also  carry  out  all  transactions  pertaining  directly  or  indirectly  to  the  acquisition  of  real  estate,

properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.

The Company may further give guarantees (including upstream and side stream), grant security interests, grant loans or

otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of
companies as the Company.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance

money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.

3481

L

U X E M B O U R G

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly

in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.  It  may  be  transferred  to  any  other  place  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  by  means  of  a  resolution  of  an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case

may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,

economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twenty-five thousand Euros (EUR 25,000)

represented by one thousand (1,000) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each. The capital of the
Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment
of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its
shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%)
of the Company's share capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be

shareholders.

The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business

of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.

Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to

act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-

holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.

3482

L

U X E M B O U R G

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,

by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.

As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the

board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of

the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal

to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed

by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in

the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed

in  the  register  of  shareholders  held  by  the  Company  at  least  eight  (8)  days  before  the  proposed  effective  date  of  the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions  (or  subject  to  the  satisfaction  of  the  majority  requirements,  on  the  date  set  out  therein).  Unanimous  written
resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

3483

L

U X E M B O U R G

At no time shall the Company have more than forty (40) shareholders. At no time shall an individual be allowed to

become a shareholder of the Company.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on 31 

st

 December of the

same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

 December

2015.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies,

as amended; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.”

All items in the agenda have thus been resolved on.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated

at EUR 2,200.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that at the request of the party hereto, these

minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in case of
discrepancies between the English and German version, the English version will prevail.

WHEREAFTER, the present deed was done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am achtundzwanzigsten Tag des Monats Oktober.
Vor dem Notar Me Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

ist erschienen,

Logicor Europe Holdings II S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) ge-

gründet und bestehend unter luxemburgischem Recht, mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, und einem
Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 25.000 und eingetragen im Registre de commerce et des sociétés in Luxemburg
unter der Nummer B 181.528 (der „Alleinige Gesellschafter“),

hier vertreten durch Me Vianney de Bagneaux, avocat, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschrift-

lichen Vollmacht, ausgestellt am 27. Oktober 2015, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der
Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

als alleiniger Gesellschafter der Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l. (die „Gesellschaft“), eine société à responsablité

limitée luxemburgischen Rechts, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg und beim Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg unter der Nummer B
195.167 eingetragen, gegründet am 2. März 2015 durch Urkunde des unterzeichnenden Notars, veröffentlicht am 20. April
2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“) unter der Nummer 1036.

3484

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschaftssatzung wurde zuletzt am 4. Juli 2015 abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Leonie

GRETHEN, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, in Vertretung von Maître Cosita DELVAUX,
Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht am 6. Oktober 2015 im Mémorial unter der
Nummer 2754.

Die erschienene Partei, wie oben dargestellt vertreten, erklärt und ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beur-

kunden:

I. Die erschienene Partei ist alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft und hält alle eintausend (1.000) ausgegebenen

Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25), eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile
der Klasse A und fünfhundert (500) Anteile der Klasse B, sodass das gesamte Stammkapital vertreten ist und Beschlüsse
vom Alleinigen Gesellschafter wirksam getroffen werden können.

II. Der Alleinige Gesellschafter wünscht Beschlüsse über die folgenden Punkte der Tagesordnung zu treffen:

<i>Agenda

1. Die Namensänderung der Gesellschaft in „Logicor (Scorpion) Pledgeco S.à r.l.“ und infolgedessen die Abänderung

von Artikel 1 der Satzung wie im untenstehenden dritten Beschluss beschrieben.

2. Die Restrukturierung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals durch:
(i) Die Löschung von zwei Anteilsklassen, und zwar Anteilsklasse A und Anteilsklasse B, mit den Rechten und Pflichten,

wie in der infolge des untenstehenden dritten Beschlusses geänderten Fassung der Satzung der Gesellschaft vorgesehen;

(ii) Die Reklassifizierung von fünfhundert (500) ausgegebenen Anteilen der Klasse A in fünfhundert (500) Stamman-

teile;

(iii) Die Reklassifizierung von fünfhundert (500) ausgegebenen Anteilen der Klasse B in fünfhundert (500) Stamman-

teile.

3. Daraus resultierende Abänderung und Neuformulierung der gesamten Satzung der Gesellschaft, sodass diese wie im

dritten Beschluss beschrieben lautet.

Daraufhin fasste der Alleinige Gesellschafter die folgenden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen den Namen der Gesellschaft in „Logicor (Scorpion) Pledgeco S.à r.l.“ zu

ändern und infolgedessen Artikel 1 der Gesellschaftssatzung wie im dritten Beschluss beschrieben abzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, das ausgegebene Gesellschaftskapital wie unten beschrieben umzustruk-

turieren.

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen die beiden Anteilsklassen zu löschen, und zwar Anteilsklasse A und An-

teilsklasse B, und diese durch Stammanteile zu ersetzen, mit den Rechten und Pflichten, wie in der infolge des untenste-
henden dritten Beschlusses geänderten Fassung der Satzung der Gesellschaft vorgesehen.

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen fünfhundert (500) ausgegebene Anteile der Klasse A in fünfhundert (500)

Stammanteile umzuklassifizieren.

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen fünfhundert (500) ausgegebene Anteile der Klasse B in fünfhundert (500)

Stammanteile umzuklassifizieren.

Der Alleinige Gesellschafter beschließt anzuerkennen, dass das ausgegebene Gesellschaftskapital in 1.000 Stammanteile

eingeteilt ist.

<i>Dritter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen die Gesellschaftssatzung in ihrer Gesamtheit abzuändern sodass die oben-

stehenden Beschlüsse berücksichtigt werden und die Satzung somit wie folgt lautet:

„ Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem

Namen „Logicor (Scorpion) Pledgeco S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen
Personen, die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende
Satzung und durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-

und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise sowie die Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich direkt oder indirekt auf den Erwerb von Grundbesitz,

Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen,
welche im Besitz von Grundrechten sind, oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen
sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögens ausführen.

3485

L

U X E M B O U R G

Die  Gesellschaft  kann  Bürgschaften  geben  (einschließlich  up-stream  und  down-stream  Bürgschaften),  Sicherheiten

leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt
oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen vergeben, Kapital in jeder be-

liebigen Form verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich  und  ohne  Einschränkungen  Kredite,  in  Bezug  auf  ein  Immobilien-Unternehmen  oder  -  Unterfangen,  die  sich  aus
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methoden und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immo-
biliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten
und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte
vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Im-
mobiliengeschäfte  jegliche  erforderliche  Rolle  übernehmen,  einschließlich  und  ohne  Einschränkungen  der  Rolle  des
Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der
Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern
würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünf-
tigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-

denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und

Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann

durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-

schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-

liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende
solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung
auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf fünfundzwanzig-

tausend Euro (EUR 25.000), eingeteilt in eintausend (1.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfund-
zwanzig Euro (EUR 25).

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung

vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesellschaftsanteile
durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht

anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.

Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die

keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-

gestattet um das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse

um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im

3486

L

U X E M B O U R G

Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und

abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der

Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung

mittels schriftlicher Einberufung zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,

von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig

abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen

Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder
einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich

haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder

leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“
und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen

unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;

(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-

schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder

von der Geschäftsführung genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das

Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern  und  Verwaltern  einer  solchen  Person  dienen.  Nichts  hierin  Enthaltenes  berührt  die  Rechte  zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.

3487

L

U X E M B O U R G

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder

Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.

Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl

seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-

schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.

Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage

vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses

mindestens  acht  (8)  Tage  bevor  der  Beschluss  wirksam  werden  soll,  an  alle  Gesellschafter  an  ihre  im  Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-

schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen

Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

(31.) Dezember desselben Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird
am 31. Dezember 2015 enden.

Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die

Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich

vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die  Gesellschafter  können  auf  der  Grundlage  eines  von  dem  alleinigen  Geschäftsführer,  beziehungsweise  der  Ge-

schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet

werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.

Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-

datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.

Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179

(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.

3488

L

U X E M B O U R G

Art. 16. Anwendbares. Recht Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich

nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.

Über alle Punkte auf der Tagesordnung wurden somit Beschlüsse gefasst.

<i>Kosten

Die von der Gesellschaft zu tragenden Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren jeglicher Art werden auf ungefähr

EUR 2.200,- geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Antrag der er-

schienenen Partei, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Überset-
zung, auf Antrag derselben erschienenen Person ist im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen
Text die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxembourg, am vorgenannten Tag.
Nach Verlesung des Dokuments an die erschienene Person hat diese gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde

unterzeichnet.

Gezeichnet: V. DE BAGNEAUX, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/34291. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 06. November 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015180458/501.
(150201280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.

Jugend und Senioren Für Europa, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2727 Howald, 1, rue Pierre Wigreux.

R.C.S. Luxembourg G 45.

Im Jahre zweitausendfünfzehn.
Den siebten August;
Vor dem unterzeichneten Notar Christine DOERNER, mit dem Amtswohnsitz in Bettemburg.

Sind erschienen:

1. Herr Dr. Bernhard WORMS, im Ruhestand, geboren am 14 März 1930 in Stommeln (Deutschland), zu D-50259

Pulheim, Hahnenstrasse 89, wohnend;

2. Dame Ingeborg UHLENBROCK, ESU-GS a.D., mit deutscher Nationalität, wohnhaft in D-40547 Düsseldorf (Deuts-

chland), 90, Schorlemerstrasse;

3. Herr Heinz BECKER, MEP, GS des Österreichischen Seniorenbundes, mit österreichischer Nationalität, wohnhaft

in 1010 Wien (Österreich), 7, Lichtenfelsgasse;

4. Herr Dr. Marilies FLEMMING, Bundesminister a.D., mit österreichischer Nationalität, wohnhaft in 1170 Wien (Ös-

terreich), 61, Gerhard Fritsch Gasse;

Die vorgenannten Personen sub1) - sub4) hier vertreten durch Frau Clode FRISCH, geboren in Luxemburg am 14. März

1946, Ehefrau von Herrn Georges CARBON, wohnhaft in L-7248 Bereldange, 36, rue Michel Rodange, auf Grund meh-
reren speziellen Vollmachten datiert vom 12. März 2015;

von welche eine Kopie nach gehöriger „ne-varietur“ Zeichnung vom Notar und der Parteien, gegenwärtiger Urkunde

beigebogen bleibt um mit derselben formalisiert zu werden;

handelnd gemäß Artikel XIII der Satzung der Stiftung „JUGEND UND SENIOREN FÜR EUROPA“, mit Sitz in L-2727

Howald, 1, rue Paul Wigreux, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer G45;

Die Gründungsurkunde der Stiftung wurde aufgenommen durch den handelnden Notar, am 4. Juli 2005, veröffentlicht

im Memorial C im Jahre 2005, Seite 27.528;

Und umgeändert durch eine Generalversammlung aufgenommen durch den handelnden Notar, am 11, Juni 2014, ve-

röffentlicht im Memorial C im Jahre 2014, Seite 156.292;

Der Verwaltungsrat beschließt folgende Satzungsänderungen vorzunehmen:

<i>Erster Beschluss

Der Verwaltungsrat beschließt einen neuen Schatzmeister zu ernennen:

3489

L

U X E M B O U R G

Wird als neuer Schatzmeister Herrn Karlheinz GIERDEN, geboren in Köln (Deutschland) am 07. August 1926, wohnhaft

in D-50226 Frechen (Deutschland), Aachener Strasse 709b, ernannt;

<i>Zweiter Beschluss

Verlegung des Gesellschaftsitzes von Howald nach L-7248 Bereldange, 36, rue Michel Rodange.

<i>Dritter Beschluss

Gemäss vorhergehendem Beschluss erhält der Absatz des Artikels III der Statuten folgenden Wortlaut:

„ Art. 3. Sitz der Stiftung. Der Sitz der Stiftung befindet sich in L-7248 Bereldange, 36, rue Michel Rodange.“

<i>Vierter Beschluss

Der Verwaltungsrat erklärt dass sich das Kommunikationssekretariat der vorgenannten Stiftung in AT-1010 Wien (Ös-

terreich), Lichtenfelsgasse, 7, befindet.

<i>Fünfter Beschluss.

Die Verwaltungsrat beschließt die vorgenannte Stiftung rechtsgültig wie folgt zu vertreten:
- für niedrigere Beträge als EINTAUSEND EURO (1.000.- Euro) wird die vorgenannte Stiftung rechtsgültig vertreten

durch die alleinige Unterschrift des Verwaltungsratsvorsitzender Herrn Dr. Bernhard WORMS, im Ruhestand, geboren
am 14 März 1930 in Stommeln (Deutschland), zu D-50259 Pulheim, Hahnenstrasse 89, wohnend, oder durch die alleinige
Unterschrift der Verwaltungsmitglieder 1) Herrn Karlheinz GIERDEN, geboren in Köln am 073 August 1926, wohnhaft
in D-50226 Frechen (Deutschland), Aachener Strasse 709b, respektiv 2) Frau Clode FRISCH, geboren zu Luxemburg am
14. März 1946, Ehefrau von Herrn Georges CARBON, wohnhaft in L-7248 Bereldange, 36 rue Michel Rodange;

- Ab der Summe von EINTAUSEND EURO (1.000.- Euro) wird die vorgenannte Stiftung rechtsgültig vertreten durch

die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratmitglieder oder die gemeinsame Unterschrift des Verwaltungsrat-
vorsitzenden Herrn Dr. Bernhard WORMS, vorgenannt, und einem Verwaltungsratmitglied.

Desweiteren erklärt der Verwaltungsratsvorsitzende dass folgende Verwaltungsratsmitglieder zum Verwaltungsrat ge-

nannt wurden:

a) Herr Dr. Bernhard WORMS, im Ruhestand, geboren in Stommeln (Deutschland) am 14. März 1930, zu D-50259

Pulheim, Hahnenstrasse 89, wohnend;

b) Herr Heinz BECKER, MEP, GS des Österreichischen Seniorenbundes, geboren in Baden (Österreich) am 29. Juni

1950, wohnhaft in 1010 Wien (Österreich), 7, Lichtenfelsgasse;

c) Frau Dr. Marilies FLEMMING, Bundesministerin a.D., geboren in Wiener-Neustadt (Österreich) am 16. Dezember

1933 wohnhaft in 1170 Wien (Österreich), 61, Gerhard Fritsch Gasse;

d) Dame Ingeborg UHLENBROCK, ESU-GS a.D., geboren in Essen (Deutschland) am 02. Dezember 1936, zu D-40547

Düsseldorf (Deutschland), 90, Schorlemerstrasse wohnend;

e) Herr Dr. Stefan GEHROLD, geboren in Freiburg (Deutschland) am 14. November 1965, zu D-49377 Vechta (Deuts-

chland), Mozartstrasse 9, wohnend;

f) Herr Roland FREUDENSTEIN, Deputy Director, geboren in Bonn (Deutschland) am 22. April 1960, zu B-1170

Brüssel (Belgien), Berensheide 254 wohnend;

g) Herr Siegfried MURESAN, geboren in Hunedoara (Rumänien) am 20. September 1981, zu Hunedoara (Rumänien),

E. Margineanu Str. Nr 4, bl 46, sc. A, et 3, ap.5 wohnend;

h) Herr Karlheinz GIERDEN, geboren in Köln (Deutschland) am 07. August 1926, wohnhaft in D-50226 Frechen

(Deutschland), Aachener Strasse 709b;

i) Frau Clode FRISCH, geboren in Luxemburg am 14. März 1946, Ehefrau von Herrn Georges CARBON, wohnhaft in

L-7248 Bereldange, 36, rue Michel Rodange;

Desweiteren erklärt der Verwaltungsrat dass folgende Verwaltungsratsmitglieder ihr Amt niederlegen:
a) Dame Maria MANTZIAFOU-KANELLOPOULOU, Rentnerin, mit griechischer Nationalität, wohnhaft in GR-11635

Pagrati Athénes (Griechenland), 42, Rue Empédokléous;

b) Herr Prof. Nicolas ESTGEN, Rentner, mit luxemburgischer Nationalität, wohnhaft in L-2763 Luxemburg, 30, rue

Ste Zithe, Centre St Jean de la Croix;

c) Dame Elisabeth DISPAUX-CORNIL, Rentnerin, mit belgischer Nationalität, wohnhaft in B-5140 Sombreffe (Bel-

gien), Place de Mont 12;

dass der Verwaltungsrat sich somit aus den vorgenannten sub 1) - sub 4) Komparenten zusammensetzt;

<i>Schaetzung der Kosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Generalversammlung obliegen

oder zur Last gelegt werden, werden auf ZWEITAUSEND EURO (2.000.-EUR) abgeschätzt.

WORUEBER URKUNDE, Aufgenommen zu Bettemburg, in der Amtsstube.

3490

L

U X E M B O U R G

Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben, welche Urkunde ausdrücklich der Genehmigung
durch Großherzoglichen Beschluss vorbehalten bleibt.

L’acte a été approuvé en vertu d’un arrêté grand-ducal en date du 14 septembre 2015.
Signé: Carbon, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 17 septembre 2015. Relation: EAC/2014/21261. Reçu vingt-cinq euros (25.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Bettembourg, le 28 septembre 2015.

Référence de publication: 2015180600/95.
(150200918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.

LIC US Growth Fund SICAV-FIS, Société en Commandite simple.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 201.229.

STATUTEN

Auszug aus dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft

1. Name der Gesellschaft. LIC US Growth Fund SICAV-FIS

2. Rechtsform. Kommanditgesellschaft (Société en commandite simple)

3. Unbeschränkt Haftender Gesellschafter. LIC US Growth Fund GP S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée), gegründet unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, rue Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister un-
ter der Nummer B201.179, (der "Komplementär").

4. Haftung der Gesellschafter. In seiner Eigenschaft als Komplementär haftet der Komplementär unbegrenzt und ge-

samtschuldnerisch für alle Verbindlichkeiten und Verluste der Gesellschaft, die nicht aus dem Fondsvermögen bedient
werden können.

Im Rahmen des Gesetzes von 1915 und des Gesellschaftsvertrags haften die Kommanditisten für die Verbindlichkeiten

und Verluste der Gesellschaft nicht über ihre Einlage bzw. noch Offene Kapitalzusage hinaus, solange sie nicht für die
Gesellschaft handeln. Hiervon unberührt sind Handlungen in Ausübung ihrer Rechte als Kommanditisten der Gesellschaft.

5. Anfangskapital. Das Kapital der Gesellschaft ist variabel.

6. Gesellschaftszweck. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage ihres Vermögens nach dem Prinzip der

Risikostreuung  in  Immobilien,  mit  dem  Ziel,  den  Gesellschaftern  Erträge  aus  der  Verwaltung,  Bewirtschaftung  und
Veräußerung der Immobilien zukommen zu lassen. Dabei können Investments entweder direkt oder indirekt über Immo-
biliengesellschaften  getätigt  werden.  Die  Gesellschaft  ist  befugt,  alle  Maßnahmen  zu  ergreifen  und  Geschäfte
abzuschließen, die sie zur Erfüllung und Entwicklung ihres Geschäftszwecks für nützlich hält, soweit dies nach dem Gesetz
von 2007 zulässig ist. Die Gesellschaft kann zudem in Ausübung und im Rahmen ihres Geschäftszwecks Garantien für
Tochtergesellschaften gegenüber Dritten übernehmen.

7. Eingetragener Sitz. 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg

8. Geschäftsführung / Vertretungsbefugnisse. Die Gesellschaft wird von dem Komplementär LIC US Growth Fund GP

S.à r.l. in seiner Funktion als Verwalter (gérant) der Gesellschaft verwaltet. Der Komplementär hat mindestens drei Ge-
schäftsführer.

Der  Komplementär  hat  in  seiner  Funktion  als  Verwalter  (gérant)  der  Gesellschaft  die  umfassenden  Befugnisse,  im

Namen der Gesellschaft sämtliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen innerhalb des Geschäftszwecks der Gesell-
schaft und im Rahmen der Anlagepolitik gemäß Artikel 21 vorzunehmen, sowie im Namen der Gesellschaft aufzutreten
und zu handeln. Er hat insbesondere die Befugnis, die Anlageziele, -richtlinien und -beschränkungen sowie die generelle
Verwaltungs- und Geschäftspolitik der Gesellschaft festzulegen und Verwaltungs-, Beratungs- und sonstige Verträge im
Namen der Gesellschaft zu schließen, die er für die Ausübung seiner Funktion im Sinne des Geschäftszwecks der Gesell-
schaft für notwendig oder nützlich hält, jeweils im Rahmen der Vorgaben des Gesellschaftsvertrages, des Emissionsdo-
kuments und der anwendbaren Gesetze und Vorschriften. Er werden bei der Verwaltung der Gesellschaft die Governance-
Regeln dieses Titels III berücksichtiget, insbesondere die Artikel 17 und 23.

Sämtliche Befugnisse, die nicht gemäß anwendbarem Recht oder dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschafterversamm-

lung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Komplementärs in seiner Funktion als Verwalter (gérant)
der Gesellschaft.

3491

L

U X E M B O U R G

Die Kommanditisten dürfen nicht an der Leitung bzw. Verwaltung der Gesellschaft teilnehmen oder sein Geschäft bzw.

seine  Handlungen  beeinflussen  und  haben  keine  Befugnis  und  kein  Recht,  auf  die  Geschäftsführung  der  Gesellschaft
Einfluss zu nehmen oder daran teilzuhaben, sofern dies nicht durch das Gesetz von 1915 und/oder den Gesellschaftsvertrag
ausdrücklich vorgesehen ist, aber in diesem Fall jeweils in den Grenzen des Gesetzes von 1915.

Dritten gegenüber wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die alleinige Unterschrift des Komplementärs vertreten.

Dieser handelt durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die gemeinsame oder alleinige
Unterschrift von Personen, die durch den Komplementär mit entsprechender Vertretungsbefugnis ausgestattet sind.

Kein Kommanditist darf die Gesellschaft nach außen vertreten.

9. Gründungsdatum / Laufzeit.  Die  Gesellschaft  wurde  am  30.  Oktober  2015  gegründet.  Die  Gesellschaft  hat  eine

Laufzeit von 12 Jahren ab dem Tag ihrer Gründung.

Référence de publication: 2015180647/55.
(150201057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.

Duke Energy International El Salvador Investments No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, rue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 201.235.

STATUTES

In the year two thousand fifteen, on the first day of October.
Before US Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

DUKE ENERGY INTERNATIONAL GROUP S.À R.L., a private limited liability company (société à responsabilité

limitée) validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-8 rue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg , in process of registration with the Luxembourg Trade and
Companies Register (the “Sole Shareholder”),

here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Cha Conde, notary’s clerk, with professional address at 13, route de Lu-

xembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given by the Sole Shareholder on October

st

 , 2015.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party is currently the sole shareholder of DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL SALVADOR IN-

VESTMENTS NO. 1 LTD, a limited company duly incorporated and validly existing under the laws of the Bermuda,
having its registered office at Canon's Court 22, Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda registered with the Registrar
of Companies, under registration number 26122 (the “Company”), to be transferred to the Grand-Duchy of Luxembourg
in the form of a Luxembourg société à responsabilité limitée.

That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1) Consider waiving the convening formalities;
2) Confirmation and ratification of the sole shareholder’s resolutions of the Company dated September 18, 2015 ap-

proving the transfer of the Company’s registered office, principal establishment and central administration from Bermuda
to the Grand-Duchy of Luxembourg;

3) Approval of the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company

to the Grand-Duchy of Luxembourg and change of nationality of the Company to Luxembourg nationality, without the
Company being dissolved and with full corporate continuance;

4) Adoption by the Company of the form of a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité

limitée) with the name “DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL SALVADOR INVESTMENTS NO. 1 S.À R.L.”;

5) Approval of the interim balance sheet of the Company dated August 31, 2015 as opening balance sheet of the Company

and acknowledgement of the statement of value of the directors of the Company;

6) Determination of the corporate purpose of the Company to give the following content:
“The corporate purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg

or foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

3492

L

U X E M B O U R G

The Company may borrow or lend monies in any form, in particular, but not limited to, through the entering into credit

agreements or facility agreements and proceed to the issuance of bonds, debentures or any other type of debt securities,
convertible or not, without, however, offering such bonds, debentures or debt securities to the public.

The Company may issue any type of shares, certificates or equity securities, redeemable or not, without, however,

offering them to the public.

The Company may further mortgage, pledge or otherwise encumber all or some of its assets. It may also grant any type

of guarantees and grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries
and/or its parent(s), affiliated companies or any other companies which form part of the same group of companies as the
Company.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.”

7) Amendment and full restatement and renumbering of the bye-laws into articles of association of the Company;
8) (i) Acceptance of the resignation of Andrea E. Bertone, Elizabeth C. De La Rosa and Cheryl I. Lipshutz as director

(s) of the Company, if any, as well as all other current officers of the Company, and granting them full discharge, and (ii)
appointment of:

<i>- Category A managers:

* Andrea E. BERTONE, born on May 22, 1961, in Sao Paulo, Brazil, and residing professionally at 5555 San Felipe

Road, Houston, Texas 77056, USA;

* Cheryl I. LIPSHUTZ, born on November 26, 1955, in Washington, DC, US and residing professionally at 5555 San

Felipe Road, Houston, Texas 77056, USA;

* Kris C. DUFFY, born on July 28, 1959, in North Carolina, USA, and residing professionally at 5555 San Felipe Road,

Houston, Texas 77056, USA;

<i>- Category B managers:

* Xavier DE CILLIA, born on April 11, 1978, in Nice, France, and residing professionally at 2-8 Avenue Charles De

Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

* Julien ANSAY, born on September 12, 1984, in Libramont, Belgium, and residing professionally at 2-8 Avenue

Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

* Robert-Jan BERTINA, born on May 8, 1977 in Leidschendam, the Netherlands, and residing professionally 2-8 avenue

Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

9) Determination of the address of the registered office, principal establishment and central administration of the Com-

pany at 2-8 Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

10) Miscellaneous.
That, on basis of the agenda, the Sole Shareholder, takes the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present extraordinary general shareholder’s meeting, the Sole

Shareholder waives the convening formalities, as it considers having been duly convened and declares having perfect
knowledge of the Agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder confirms and ratifies (i) the sole shareholder’s resolution of the Company dated September 18,

2015 deciding to transfer the Company’s registered office, principal establishment and central administration from Bermuda
to the Grand-Duchy of Luxembourg, as from the date hereof, and (ii) that all necessary steps in Bermuda to transfer the
registered office, principal establishment and central administration of the Company to the Grand-Duchy of Luxembourg
have been taken in Bermuda.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves, as of the date hereof, to transfer the registered office, principal establishment and central

administration of the Company to the Grand-Duchy of Luxembourg and to change the nationality of the Company into the
Luxembourg nationality without the Company being dissolved but to the contrary with full corporate and legal continuance.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves that the Company shall adopt the form of a Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limitée) with the name “DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL SALVADOR INVESTMENTS
NO. 1 S.À R.L.”

3493

L

U X E M B O U R G

<i>Fifth resolution

It results from (i) a balance sheet of the Company that the net asset value of the Company is equal to at least twenty

thousand US Dollars (USD 20,000) and (ii) a statement of value of the directors of the Company certifying that as of the
date hereof, no material change in the business of the Company and/or the Company's affairs has occurred which results
in the information contained in the balance sheet being materially incorrect and/or not giving a true and fair view of the
Company's financial situation as of the date hereof.

The Sole Shareholder approves the balance sheet of the Company dated August 31, 2015 as opening balance sheet of

the Company upon its migration to the Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves, by way of a special resolution, to modify the corporate purpose of the Company as

follows:

“The corporate purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg

or foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow or lend monies in any form, in particular, but not limited to, through the entering into credit

agreements or facility agreements and proceed to the issuance of bonds, debentures or any other type of debt securities,
convertible or not, without, however, offering such bonds, debentures or debt securities to the public.

The Company may issue any type of shares, certificates or equity securities, redeemable or not, without, however,

offering them to the public.

The Company may further mortgage, pledge or otherwise encumber all or some of its assets.
It may also grant any type of guarantees and grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or

the obligations of its subsidiaries and/or its parent(s), affiliated companies or any other companies which form part of the
same group of companies as the Company.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.”

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and fully restate and renumber the articles of association of the Company so

as to conform them to Luxembourg law on the occasion of the transfer of the Company and its corporate and legal conti-
nuation in the Grand Duchy of Luxembourg. The restated and renumbered articles of association of the Company shall
now read as follows:

Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will

be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10,
1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter
the «Articles»), which set forth in Articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 13 the specific rules applying to sole shareholder companies.

Art. 2. Corporate purpose. The corporate purpose of the Company is the holding of participations, in any form what-

soever, in other Luxembourg or foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and
the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in
partnerships.

The Company may borrow or lend monies in any form, in particular, but not limited to, through the entering into credit

agreements or facility agreements and proceed to the issuance of bonds, debentures or any other type of debt securities,
convertible or not, without, however, offering such bonds, debentures or debt securities to the public.

The Company may issue any type of shares, certificates or equity securities, redeemable or not, without, however,

offering them to the public.

The Company may further mortgage, pledge or otherwise encumber all or some of its assets.
It may also grant any type of guarantees and grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or

the obligations of its subsidiaries and/or its parent(s), affiliated companies or any other companies which form part of the
same group of companies as the Company.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

3494

L

U X E M B O U R G

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Corporate name. The Company will have the denomination “DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL SAL-

VADOR INVESTMENTS NO. 1 S.À R.L.”.

Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary

general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 Subscribed share capital
The share capital of the Company amounts to twenty thousand US Dollars (USD 20,000) represented by twenty thousand

(20,000) shares with a par value of one US Dollar (USD 1) each, all fully subscribed and entirely paid up.

In addition to the share capital, there may be set up a share premium account, into which any premium paid on any share

is transferred.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(“société unipersonnelle”) in the meaning of article 179 (2) of the Law.

In this contingency articles 200-1 and 200-2, amongst others, will apply, this entailing that each decision of the sole

shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established
in writing.

6.2 Reserve - Share Premium Account
The Company shall maintain a share premium reserve account for the Company’s shares (the “Share Premium Reserve

Account”), and there shall be recorded to such account, the amount or value of any premium paid up on the Company’s
shares.

The shareholder(s) may also resolve to increase the amount of the Share Premium Reserve Account by way of a con-

tribution or by incorporation of Company’s available reserves, prescribed that shareholder(s) representing at least half of
the Company’s share capital are present or represented at the meeting where such resolution is taken and that two thirds
of the shareholder(s) present or represented vote in favor.

Such increase may be performed without issuance of new Company’s shares as long as all the Company’s shares are

held by only one (1) shareholder.

Amounts so recorded to the Share Premium Reserve Account will constitute freely distributable reserves of the Company

for the sole benefit of the shareholder(s).

6.3 Modification of share capital
The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general

shareholders’ meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of
the Law.

6.4 Profit participation
The shares entitle to a fraction of the Company’s assets and profits as provided by article 12 of the present Articles.
6.5 Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.6 Transfer of shares
In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the

requirements of article 189 and 190 of the Law.

6.7 Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in accordance

with article 185 of the Law.

Art. 7. Management.
7.1 Appointment and removal
The Company is managed by one (1) or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute

a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B.

Upon the appointment of any manager, other than a sole manager, that manager shall be designated by the shareholder

(s) as a category A manager or a category B manager.

3495

L

U X E M B O U R G

If at a time when there is a sole manager, a further manager is appointed, the shareholder(s) shall, at such time, in addition

to designating the new managers as category A manager or category B manager, also designate the existing manager, to
the extent not already categorized, as a category A manager or a category B manager.

The manager(s) need(s) not to be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and may be dismissed ad nutum by

the shareholder(s) of the Company.

7.2 Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object and provided
the terms of this article shall have been complied with.

The Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its sole manager, and in case of

plurality of managers, by the joint signature of a manager of category A and a manager of category B or by the single
signature of any ad hoc agent to whom such signatory power has been delegated, but only within the limits of such power.

The Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of any of its managers when acting

on behalf of the Company as direct and indirect legal representative of the active partner of DUKE ENERGY INTERNA-
TIONAL EL SALVADOR INVESTMENTS No.1 y Cia, S. en C. de C.V. or DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL
SALVADOR, S. en C. de C.V. Any manager may execute and deliver on behalf of the Company any acts, deeds, decla-
rations, certificates, notices, documents or statements as may be necessary, appropriate, required or desirable in order to
act as the active partner of DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL SALVADOR INVESTMENTS No.1 y Cia, S. en C.
de C.V. or DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL SALVADOR, S. en C. de C.V. and to perform any actions or for-
malities necessary or useful in relation to the Company’s role as active partner of DUKE ENERGY INTERNATIONAL
EL SALVADOR INVESTMENTS No.1 y Cia, S. en C. de C.V. or DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL SALVADOR,
S. en C. de C.V.

Any agreements, letters, instruments and certificates and other documents executed and delivered or act or thing done

by any Manager related to the Company’s role as active partner of DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL SALVADOR
INVESTMENTS No.1 y Cia, S. en C. de C.V. or DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL SALVADOR, S. en C. de
C.V. referred to in the preceding paragraph, shall be acknowledged and confirmed by the managers at the following board
of managers’ meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his/its powers

for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers
will determine these agents' responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of their agency.

7.3 Powers
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.4 Procedures
The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of managers of category A and managers of

category B is present or represented at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or repre-

sented at such meeting; such majority shall include the vote of at least one category A manager and the vote of at least one
category B manager.

The managers shall designate among them a Chairperson at the beginning of each meeting of the board of managers of

the Company. The board of managers may also elect a secretary, who need not be a manager or a shareholder of the
Company, and who will be responsible for keeping the minutes of the relevant meeting of the board of managers of the
Company. The Chairperson has the casting vote in the event of a tied vote.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing either in writing or by fax or e-mail another

manager of the same category as proxy.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the board

of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

7.5 Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders’ meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’

meeting. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing. Each contract entered into
between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn-
up in writing.

3496

L

U X E M B O U R G

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted at the majority of the votes by shareholders owning more than half of the
entire share capital.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s entire share
capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed

twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders’ meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), an annual

general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the Law at the registered office of the
Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be

supervised by one (1) or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder.
If there is more than one (1) statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the

thirty first of December of each year.

Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder may inspect, at the Company’s registered office, the above inventory, balance sheet and profit and

loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the
Law.

Art. 12. Distribution of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general

expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the
Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends, including

during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available
for distribution. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet reviewed by an inde-
pendent auditor at the Company’s expenses. The amount to be distributed may not exceed total profits since the end of the
last financial year, if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and
amount to be allocated to a reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to
the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

After payment of all the debts of and charges due from the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

<i>Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to accept the resignation, effective as of the date hereof, of Andrea E. Bertone, Elizabeth

C. De La Rosa and Cheryl I. Lipshutz as directors of the Company, as well as all other current officers of the Company, if
any, with immediate effect and grants them full discharge for the exercise of their mandate.

The Sole Shareholder further resolves to appoint the following persons as manager of the Company with immediate

effect and for an unlimited period of time:

<i>- Category A managers:

- Andrea E. BERTONE, born on May 22, 1961, in Sao Paulo, Brazil, and residing professionally at 5555 San Felipe

Road, Houston, Texas 77056, USA;

3497

L

U X E M B O U R G

- Cheryl I. LIPSHUTZ, born on November 26, 1955, in Washington, DC, US and residing professionally at 5555 San

Felipe Road, Houston, Texas 77056, USA;

- Kris C. DUFFY, born on July 28, 1959, in North Carolina, USA, and residing professionally at 5555 San Felipe Road,

Houston, Texas 77056, USA;

<i>- Category B managers:

- Xavier DE CILLIA, born on April 11, 1978, in Nice, France, and residing professionally at 2-8 Avenue Charles De

Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

- Julien ANSAY, born on September 12, 1984, in Libramont, Belgium, and residing professionally at 2-8 Avenue Charles

De Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

- Robert-Jan BERTINA, born on May 8, 1977 in Leidschendam, the Netherlands, and residing professionally 2-8 avenue

Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>Ninth resolution

The Sole Shareholder resolves to establish the registered office, principal establishment and central administration of

the Company at 2-8 Avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation and on the request of the same appearing
party in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the day specified at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, the said proxy holder signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le premier octobre.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

DUKE ENERGY INTERNATIONAL GROUP S.A R.L., une société à responsabilité limitée dûment constituée et

valablement existante sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-8 avenue Charles De
Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d’enregistrement auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés (l’«Associé Unique»),

ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 13, route de

Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée par l’Associé Unique le

er

 octobre 2015.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec les autorités d’enregistrement.

Le comparant est l’associé unique de DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL SALVADOR INVESTMENTS NO. 1

LTD, une société de droit des Bermudes, ayant son siège social à Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12,
Bermudes, enregistrée auprès du «Registrar of Companies», sous le numéro 26122 (la «Société»), devant être transférée
au Grand-Duché de Luxembourg sous la forme sociale d’une société à responsabilité limitée luxembourgeoise.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

<i>Agenda

1) Considérer la renonciation aux formalités de convocation;
2) Confirmation et ratification des résolutions de l’associé unique de la Société du 18 septembre 2015 décidant du

transfert du siège social, de l’établissement principal et de l’administration centrale de la Société des Bermudes au Grand-
Duché de Luxembourg;

3) Approbation du transfert du siège social, de l’établissement principal et de l’administration centrale de la Société au

Grand-Duché de Luxembourg et changement de nationalité de la Société en nationalité luxembourgeoise, sans que la Société
ne soit dissoute mais au contraire avec pleine continuation de sa personnalité morale;

4) Adoption par la Société de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise sous la déno-

mination «DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL SALVADOR INVESTMENTS NO. 1 S.A R.L.»;

5) Approbation du bilan intérimaire de la Société du 31 août 2015 en tant que bilan d’ouverture de la Société et recon-

naissance de la déclaration de valeur des administrateurs de la Société;

6) Détermination de l’objet social de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«L’objet de la Société consiste en la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par

3498

L

U X E M B O U R G

vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, ainsi
que la possession, l’administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.

La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés de personnes.
La Société peut emprunter ou prêter sous quelque forme que ce soit, en particulier, mais sans limitation, par la conclusion

de contrats de crédit et procéder à l'émission d'obligations, de titres d'emprunt ou de tout autre type de titre de créance,
convertible ou non, sans toutefois offrir ces obligations, titres d'emprunt ou titres de créance au public.

La Société peut procéder à l'émission de tous types d’actions, sûretés ou garanties rachetables ou non, sans toutefois

pouvoir les offrir au public.

La Société pourra en outre hypothéquer, nantir ou grever tout ou partie de ses actifs. Elle peut également accorder tout

type de garanties et de sûretés en faveur de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales et/ou société
(s) parente(s), sociétés affiliées ou toutes autres sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

D’une manière générale, elle pourra prêter assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et de

supervision et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction

sur des biens mobiliers ou immobiliers, utile à l'accomplissement et au développement de son objet».

7) Modification, reformulation et renumérotation intégrale des statuts de la Société;
8) (i) Acceptation de la démission de Andrea E. Bertone, Elizabeth C. De La Rosa and Cheryl I. Lipshutz en tant

qu'administrateurs de la Société ainsi que des autres mandataires de la Société, si tel est le cas, et octroi d’une décharge
pleine et entière, et (ii) nomination de:

<i>- Gérants de catégorie A:

- Andrea Elis abeth BERTONE, né le 22 mai 1961, à Sao Paulo, Brésil, et résidant professionnellement au 5555 San

Felipe Road, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d’Amérique;

- Cheryl I. LIPSHUTZ, né le 26 novembre 1955, à Washington, DC, US et résidant professionnellement au 5555 San

Felipe Road, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d’Amérique;

- Kris COX DUFFY, né le 28 juillet 1959, en Caroline du Nord, Etats-Unis d’Amérique, et résidant professionnellement

au 5555 San Felipe Road, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d’Amérique;

<i>- Gérants de catégorie B:

- Xavier DE CILLIA, né le 11 avril 1978, à Nice, France, et résidant professionnellement au 2-8 Avenue Charles De

Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Julien ANSAY, né le 12 septembre 1984, à Libramont, Belgique, et résidant professionnellement au 2-8 Avenue

Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Robert-Jan BERTINA, né le 8 mai 1977, à Leidschendam, Pays-Bas, et résidant professionnellement au 2-8 Avenue

Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

9) Etablissement du siège social, principal établissement et administration centrale de la Société au 2-8 Avenue Charles

De Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

10) Divers.
Que, sur base de l’ordre du jour, l’Associé Uniqueprend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’ensemble du capital social étant représenté à la présente assemblée générale des associés, l’Associé Unique renonce

aux formalités de convocation, se considérant dûment convoqué et déclarant ayant une parfaite connaissance de l’ordre du
jour de la présente assemblée lui ayant été communiqué en avance.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique confirme et ratifie (i) la résolution de l’associé unique de la Société du 18 septembre 2015 décidant

de transférer le siège social, principal établissement et administration centrale de la Société des Bermudes au Grand-Duché
de Luxembourg, à compter de la date des présentes, et (ii) que toutes les formalités requises aux Bermudes afin de transférer
le siège social, principal établissement et administration centrale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, ont été
accomplies aux Bermudes.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide, à compter de la date des présentes, de transférer le siège social, l'établissement principal et

l'administration centrale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg et de changer la nationalité de la Société en natio-
nalité  luxembourgeoise,  sans  dissolution  de  la  Société  mais  au  contraire  avec  pleine  continuation  de  sa  personnalité
juridique.

3499

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide que la Société adopte la forme sociale d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise

sous la dénomination «DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL SALVADOR INVESTMENTS NO. 1 S.A R.L.».

<i>Cinquième résolution

Il résulte (i) d'un bilan de la Société que la valeur de l’actif net de la Société s'élève au moins à vingt mille US Dollars

(USD 20.000) et (ii) d'un certificat de valeur des administrateurs de la Société certifiant que depuis la date du bilan aucun
changement matériel dans les activités commerciales de la Société et/ou les affaires de la Société n'a eu lieu, qui se traduirait
par le fait que les informations contenues dans le bilan soient matériellement inexactes et/ou ne donnent pas une image
fidèle de la situation financière de la Société à la date des présentes.

L'Associé Unique décide d'approuver le bilan de la Société au 31 août 2015, comme bilan d’ouverture de la Société

suite à sa migration au Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique décide, par le biais d’une résolution spéciale, de modifier l’objet social de la Société qui aura désormais

la teneur suivante:

«L’objet de la Société consiste en la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, ainsi
que la possession, l’administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.

La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés de personnes.
La Société peut emprunter ou prêter sous quelque forme que ce soit, en particulier, mais sans limitation, par la conclusion

de contrats de crédit et procéder à l'émission d'obligations, de titres d'emprunt ou de tout autre type de titre de créance,
convertible ou non, sans toutefois offrir ces obligations, titres d'emprunt ou titres de créance au public.

La Société peut procéder à l'émission de tous types d’actions, sûretés ou garanties rachetables ou non, sans toutefois

pouvoir les offrir au public.

La Société pourra en outre hypothéquer, nantir ou grever tout ou partie de ses actifs. Elle peut également accorder tout

type de garanties et de sûretés en faveur de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales et/ou société
(s) parente(s), sociétés affiliées ou toutes autres sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

D’une manière générale, elle pourra prêter assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et de

supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction

sur des biens mobiliers ou immobiliers, utile à l'accomplissement et au développement de son objet.»

<i>Septième résolution

L'Associé Unique décide de modifier et de reformuler et renuméroter intégralement les statuts de la Société afin de les

conformer à la loi luxembourgeoise à l'occasion du transfert de la Société et de la continuation de sa personnalité morale
et juridique au Grand-Duché de Luxembourg. Les statuts reformulés et renumérotés de la Société auront la teneur suivante:

Art. 1 

er

 . Forme sociale.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle

entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée
(ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
6.1, 6.2, 6.5, 8 et 13, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social. L’objet de la Société consiste en la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans

d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière ainsi
que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de
toutes espèces, ainsi que la possession, l’administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.

La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés de personnes.
La Société peut emprunter ou prêter sous quelque forme que ce soit, en particulier, mais sans limitation, par la conclusion

de contrats de crédit et procéder à l'émission d'obligations, de titres d'emprunt ou de tout autre type de titre de créance,
convertible ou non, sans toutefois offrir ces obligations, titres d'emprunt ou titres de créance au public.

La Société peut procéder à l'émission de tous types d’actions, sûretés ou garanties rachetables ou non, sans toutefois

pouvoir les offrir au public.

La Société pourra en outre hypothéquer, nantir ou grever tout ou partie de ses actifs. Elle peut également accorder tout

type de garanties et de sûretés en faveur de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales et/ou société
(s) parente(s), sociétés affiliées ou toutes autres sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

D’une manière générale, elle pourra prêter assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et de

supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement de son objet.

3500

L

U X E M B O U R G

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction

sur des biens mobiliers ou immobiliers, utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination «DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL SALVADOR IN-

VESTMENTS NO. 1 S.A R.L.».

Art. 5. Siège social. le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché du Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale

extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 Capital souscrit et libéré
Le capital social de la Société est fixé à vingt mille US Dollars (USD 20.000) représenté par vingt mille (20.000) parts

sociales d’une valeur nominale d’un US Dollar (USD 1) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées. En complément
du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute
part sociale sera versée.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent
à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont
inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 Prime d’émission
La Société doit maintenir un compte de prime d’émission pour les parts sociales de la Société (le «Compte de Réserve

de Prime d’Emission») et toute prime payée sur les parts sociales de la Société doit y être inscrite.

Les Associés peuvent également augmenter le montant du Compte de Réserve de Prime d’Emission par un apport ou

par incorporation de réserves de la Société pourvu que les associés représentant au moins la moitié du capital social de la
Société soient présents ou représentés à la réunion durant laquelle une telle décision est prise et que les deux tiers des
associés présents ou représentés votent en faveur.

Une telle augmentation peut être effectuée sans l’émission de parts sociales nouvelles tant que toutes les parts sociales

de la Société sont détenues par un associé unique.

Les montants ainsi enregistrés sur le Compte de Réserve de Prime d’Emission constitueront une réserve librement

disponible au seul bénéfice des associés.

6.3 Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de

l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199
de la Loi.

6.4 Participation aux bénéfices
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société conformément à l’article 12 des

présents Statuts.

6.5 Indivisibilité des parts sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.6 Transfert de parts sociales
Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.7 Enregistrement des parts sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés

conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Gérance.
7.1 Nomination et révocation
La Société est gérée par un (1) gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront

un conseil de gérance, composé de gérant(s) de catégorie A et de catégorie B.

Dès sa nomination, tout gérant autre que le gérant unique devra être désigné par l’associé unique ou les associés comme

étant gérant de catégorie A ou de catégorie B.

3501

L

U X E M B O U R G

Si la Société ne compte qu’un seul gérant au moment où un second gérant est nommé, l’associé unique ou les associés,

devra/ont en plus d’indiquer la catégorie à laquelle appartient ce nouveau gérant, indiquer celle du gérant existant, au cas
où celui-ci n’aurait pas déjà été catégorisé comme gérant de catégorie A ou gérant de catégorie B.

Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Ils sont nommés et susceptibles d’être révoqués ad nutum

par le(s) associé(s) de la Société.

7.2 Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance

aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à
l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article.

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la

signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B ou par la seule signature de tout mandataire
ad hoc à qui un tel pouvoir de signature a été délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature d’un de ses gérants lorsqu'il agit au nom de la Société

en tant que représentant juridique direct ou indirect de l’associé actif DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL SALVA-
DOR INVESTMENTS No.1 y Cia, S. en C. de C.V. ou DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL SALVADOR, S. en C.
de C.V. Tout gérant peut signer et remettre au nom de la Société tous actes, déclarations, certificats, notices, documents
pour autant que nécessaire, convenable, requis ou désiré afin d’agir en tant qu'associé actif de DUKE ENERGY INTER-
NATIONAL EL SALVADOR INVESTMENTS No.1 y Cia, S. en C. de C.V. ou DUKE ENERGY INTERNATIONAL
EL SALVADOR, S. en C. de C.V. et d’accomplir toutes actions et formalités nécessaires ou utiles en relation avec le rôle
de la Société en tant qu'associé actif de DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL SALVADOR INVESTMENTS No.1 y
Cia, S. en C. de C.V. ou DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL SALVADOR, S. en C. de C.V.

Tous contrats, lettres, instruments et certificats et tous autres documents signés et remis, ou les actions ou choses en-

treprises par tout gérant en relation avec le rôle de la Société en tant qu’associé actif de DUKE ENERGY INTERNATIO-
NAL  EL  SALVADOR  INVESTMENTS  No.1  y  Cia,  S.  en  C.  de  C.V.  ou  DUKE  ENERGY  INTERNATIONAL  EL
SALVADOR, S. en C. de C.V. mentionnés au paragraphe précédent, devront être admis et confirmés par les gérants à la
prochaine réunion du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations

spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déter-
minera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et
n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.3 Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.4 Procédures
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants de catégorie A et des

gérants de catégorie B est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les gérants

présents ou représentés à ladite réunion; cette majorité doit inclure la voix d’au moins un gérant de catégorie A et celle
d’au moins un gérant de catégorie B.

Les gérants désignent parmi eux un Président au début de chaque réunion du conseil de gérance de la Société. Le conseil

de gérance peut également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un gérant ou un associé de la Société, et qui sera
responsable de la tenue des procès-verbaux de la réunion du conseil de gérance de la Société. Le Président a une voix
prépondérante en cas de partage des voix.

Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance en nommant par écrit, fax ou e-mail un autre gérant de

même catégorie comme son représentant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via télé-

phone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au
conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en
personne à la réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise

lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts.

7.5 Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

associés. Les décisions de l'associé unique sont consignées en procès-verbaux ou établis par écrit. Chaque contrat conclu
entre l'associé unique et la Société représentée par l'associé unique sont consignées en procès-verbaux ou établis par écrit.

3502

L

U X E M B O U R G

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts qu’il détient. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par la majorité des voix des associés détenant
plus de la moitié de l’ensemble du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un

vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les
trois quarts de l’ensemble du capital social de la Société, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25).

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son
vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre d’associés est supérieur à vingt-cinq (25), une assemblée

générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre
endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée.

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq (25), les opérations de la Société

sont contrôlées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un (1) commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil des commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le

trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire

(indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels
apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaire
(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits. Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des

frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net
de la Société pour la constitution de la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social
de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à/aux associé(s) en proportion de sa/leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement d'acomptes sur

dividendes, y compris durant le premier exercice social, à condition d’établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds
suffisants sont disponibles pour la distribution. Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, demander que ce bilan
intérimaire soit revu par un réviseur d’entreprises aux frais de la Société. Le montant distribué ne doit pas excéder le montant
des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables, et diminué des pertes reportées et sommes à allouer à une réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,

de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de
la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les
associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le boni net de la liquidation

sera distribué à/aux associé(s), selon les mêmes règles de distribution que celles énoncées pour les distributions de divi-
dendes, de manière à atteindre le montant global du résultat économique.

Art. 14. Référence a la loi. Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence

aux dispositions de la Loi.

<i>Huitième résolution

L'Associé Unique décide d’accepter la démission de Andrea E. Bertone, Elizabeth C. De La Rosa and Cheryl I. Lipshutz

en tant qu'administrateurs de la Société ainsi que des autres mandataires de la Société, si tel est le cas, avec effet immédiat
et de leur octroyer une décharge pleine et entière pour l’exercice de leur mandat.

L’Associé Unique décide ensuite de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société avec effet immédiat

et pour une durée illimitée:

<i>- Gérants de catégorie A:

3503

L

U X E M B O U R G

* Andrea Elis abeth BERTONE, né le 22 mai 1961, à Sao Paulo, Brésil, et résidant professionnellement au 5555 San

Felipe Road, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d’Amérique;

* Cheryl I. LIPSHUTZ, né le 26 novembre 1955, à Washington, DC, US et résidant professionnellement au 5555 San

Felipe Road, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d’Amérique;

* Kris COX DUFFY, né le 28 juillet 1959, en Caroline du Nord, Etats-Unis d’Amérique, et résidant professionnellement

au 5555 San Felipe Road, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d’Amérique;

<i>- Gérants de catégorie B:

* Xavier DE CILLIA, né le 11 avril 1978, à Nice, France, et résidant professionnellement au 2-8 Avenue Charles De

Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

* Julien ANSAY, né le 12 septembre 1984, à Libramont, Belgique, et résidant professionnellement au 2-8 Avenue

Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

* Robert-Jan BERTINA, né le 8 mai 1977, à Leidschendam, Pays-Bas, et résidant professionnellement au 2-8 Avenue

Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Neuvième résolution

L'Associé Unique décide d'établir le siège social, l'établissement principal et l'administration centrale de la Société au

2-8 Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 octobre 2015. Relation: EAC/2015/23103. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015180414/674.
(150201187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.

IBG Global Funds SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-

tissement Spécialisé.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 181.959.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2015.

Référence de publication: 2015180563/11.
(150200919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.

Metis Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 163.315.

Les statuts coordonnés au 26/10/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 novembre 2015.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2015180673/12.
(150200957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

3504


Document Outline

Acerta S.à r.l.

Allard Invest Holding Bresil S.à r.l.

BGG Management S.à r.l.

CleanServe S.A.

Compagnie Financière Hispania S.A.

CSII Investissements S.A.

De Feinen Heizungsknechler s.à r.l.

Diamantina

Duke Energy International El Salvador Investments No. 1 S.à r.l.

East &amp; West Trade Link S.à.r.l.

Easy Hotels Company

EIRSP Investments S.à r.l.

Elitek S.A.

Emcube S.A.

Erre Tre S.A.

Everfit S.à r.l.

Ex-d S.à r.l.

Expansion Immobilière S.A.

Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l.

Financière SDS S.à r.l.

Fräiwëlleg Pompjeeën vu Koler

FSB-Systems S.A.

Golf Mulligan S.P.F. S.A.

Green Clean S.A.

Groupe Steffen S.à r.l.

HellermannTyton Alpha S.à r.l.

H.I.G. Luxembourg Holdings 38 S.à r.l.

H.I.G. Luxembourg Holdings 39 S.à r.l.

Hobevest S.A.

HORIZON Consulting S.A.

IBG Global Funds SICAV-SIF

ICRED - International Company for Real Estate Development S.A.

In der Laey S.A.

Jugend und Senioren Für Europa

Les P'tits Mousses S.àr.l.

LIC US Growth Fund SICAV-FIS

Locinvest S.A.

Logicor (Scorpion) Pledgeco S.à r.l.

Lux Property Invest S.A.

Magenlux S.à r.l.

Marim S.A.

Menarini International Investment S.A. - Luxembourg

Metis Holding S.à r.l.

Mirai S.A.

Op der Gare Lima S.à r.l.