logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3

2 janvier 2016

SOMMAIRE

Afton Chemical EA Holdings S.à r.l.  . . . . . . . .

135

A.R.S. Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

Brass Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

Carre Invest S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

CBRE Global Investment Partners Fund Se-

ries S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

Finnery Acquisitions III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

118

Future Foncia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

Garfunkelux Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

121

GMT Connect S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

Golden Gate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132

GOPERF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

Harry & Cie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

Hesperides Equity S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A. . . . . . . .

140

Highgreen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

Hyrule S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

Invista European RE Lutterberg PropCo S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

Invista European RE Marseille PropCo S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131

Invista European RE Monbonnot HoldCo 1 S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

I.R.D.V. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

Janili S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131

La Choral Notre Dame de Fatima A.s.b.l.  . . .

116

Laguardia Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

L.M.I. Reconstruction Luxembourg  . . . . . . . .

132

Medtronic Advanced Energy Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140

Medtronic Ardian Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

134

Orchis Inwest SCSp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134

ParisInvest III S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135

Samera S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

Tulpen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

VAP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

ZAB Invest Co. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

97

L

U X E M B O U R G

ZAB Invest Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 201.007.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of October,
before Maitre Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

ZAB Prop Co. A S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern,
Grand Duchy of Luxembourg, which registration with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
200.845 and a share capital of twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-),

ZAB Prop Co. B S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern,
Grand Duchy of Luxembourg, which registration with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
200.825 and a share capital of twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-),

ZAB Prop Co. C S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern,
Grand Duchy of Luxembourg, which registration with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
200.846 and a share capital of twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-),

here all represented by José María Ortiz, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of powers of attorney dated 22 October 2015.

Such powers of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is ”ZAB Invest Co. S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Contern, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution  of  the  board  of  managers.  Where  the  board  of  managers  determines  that  extraordinary  political  or  military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances.
Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer
of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition, directly or indirectly, of real estate property in Luxembourg or

abroad, in particular shopping centres, and the holding and managing of the assets required for the management of the real
estate property.

3.2 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

98

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company’s share capital is set at twenty five thousand euro (EUR 25,000.-), represented by (i) twelve thousand

five hundred (12,500) ordinary, (ii) one thousand two hundred and fifty shares of class A (the “Class A Shares”), (iii) one
thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class B (the “Class B Shares”), (iv) one thousand two hundred and fifty
(1,250) of class C (the “Class C Shares”), (v) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class D (the “Class D
Shares”), (vi) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class E (the “Class E Shares”), (vii) one thousand two
hundred and fifty (1,250) shares of class F (the “Class F Shares”), (viii) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares
of class G (the “Class G Shares”), (ix) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class H (the “Class H Shares”),
(x) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class I (the “Class I Shares”) and (xi) one thousand two hundred
and fifty (1,250) shares of class J (the “Class J Shares”); each in registered form fully paid-up with a nominal value of one
euro (EUR 1) each.

5.2 In addition to the issued capital, there may be set up a share premium account to which any share premium paid on

the ordinary shares of the Company in addition to its nominal value is transferred. The amount of the share premium account
may be used to provide for the payment of any ordinary shares which the Company may repurchase from its shareholder
(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds
to the legal reserve.

5.3. The subscribed share capital of the Company may be increased through the issuance of shares, or reduced, by a

resolution of the General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolution adopted in the manner required for
amendment of the Articles. In no case may the subscribed share capital be reduced to an amount lower than twenty five
thousand Euro (EUR25,000.-). Notwithstanding the above, the share capital of the Company may be reduced through the
cancellation of a class of shares, in whole but not in part, consisting in the repurchase and cancellation of all shares in issue
in such class as may be determined from time-to-time by the board of managers and approved at the General Meeting or
by way of Shareholders Circular Resolution, provided however that the Company may not at any time repurchase and
cancel the ordinary Shares. In the case of any repurchase and cancellation of a whole class of shares, such repurchase and
cancellation of shares shall be made in the following order: (i) Class A Shares; (ii) Class B Shares; (iii) Class C Shares;
(iv) Class D Shares; (v) Class E Shares; (vi) Class F Shares; (vii) Class G Shares; (viii) Class H Shares; (ix) Class I Shares
and (x) Class J Shares.

5.4. In the event of a reduction of share capital through the cancellation of a whole class of shares consisting in the

repurchase and cancellation of all shares in issue in such class (in the order provided for above), each such class of shares
entitles the holders thereof (pro rata to their holding in such class of shares) to such portion of the Total Cancellation Amount
with respect to the class of shares to be redeemed, and the holders of shares of the repurchased and cancelled shares shall
receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class of
shares.

5.5. A reduction of share capital through the repurchase of a class of shares may only be made within the respective

Class Periods, e.g.:

The period for the Class A Shares is the period starting on the date of the notarial deed of 16 October 2015 and ending

no later than on 31 December 2015 (the “Class A Period”).

The period for the Class B Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on no later than

31 December 2016 (the “Class B Period”).

The period for the Class C Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending no later than on

31 December 2017 (the “Class C Period”).

The period for the Class D Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending no later than on

31 December 2018 (the “Class D Period”).

The period for the Class E Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on no later than

31 December 2019 (the “Class E Period”).

The period for the Class F Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on no later than

31 December 2020 (the “Class F Period”).

The period for the Class G Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on no later than

31 December 2021 (the “Class G Period”).

The period for the Class H Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending no later than on

31 December 2022 (the “Class H Period”).

The period for the Class I Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no later than on

31 December 2023 (the “Class I Period”).

99

L

U X E M B O U R G

The period for the Class J Shares is the period starting on the day after the Class I Period and ending no later than on

31 December 2024 (the “Class J Period”).

5.6. Where a class of shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the redemption

and cancellation of such class(es) of shares can be made during a new period (the “New Period”) which shall start on the
date after the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately preceding New Period of
another class) and end no later than one year after the start date of such New Period. The first New Period shall start on
the day after the Class J Period and the class of shares not repurchased and not cancelled in their respective Class Period
shall come in the order from class A to class J (to the extent not previously repurchased and cancelled).

For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a class of shares shall take place prior to

the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period (or as the case
may be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such class of shares and shall continue
to end on the day such as initially defined in the Articles above.

Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount will become due and

payable by the Company to the Shareholder(s) pro-rata to their holding in such class(es). For the avoidance of doubt the
Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.

5.7. The Company may repurchase its shares as provided herein only to the extent otherwise permitted by Law.
5.8. For the purpose of this article:
“Available Amount” means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the

extent shareholders would have been entitled to dividend distributions according to these Articles, increased by (i) any
freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium account up to the amount of losses
including carried forward losses) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve
reduction relating to the class of shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward
losses), and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of these Articles, each
time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR+OD+PE)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves (including the share premium account up to the amount of L)
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of these Articles.
OD = any annual fixed dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to these Articles.
PE = Profit Entitlement (the annual fixed dividends to which the holder(s) of the classes of Shares is entitled pursuant

to these Articles.

The Available Amount, as determined by using the formula described here above, can be increased by any surplus cash

or/and assets available to the Company at the time of the redemption, such surplus cash or/and assets being paid from the
share premium account up to the amount of the share premium at the time of the redemption.

“Available Liquidities” shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining

maturity  exceeding  six  (6)  months),  (ii)  any  readily  marketable  money  market  instruments,  bonds  and  notes  and  any
receivable which in the opinion of the Board of Managers will be paid to the Company in the short term less any indebtedness
or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating
to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of
other kind held by the Company.

“Cancellation Amount” shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period

(or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available Liquidities
relating to the relevant Class Period (or New Period).

“Cancellation Value Per Share” means the amount calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number

of shares in issue in the class of shares to be cancelled.

“Class Period” shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class E Period, the

Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I Period and the Class J Period.

“Interim Accounts” means the interim accounts of the Company under Luxembourg GAAP as at the relevant Interim

Account Date.

“Interim Account Date” means the date no earlier than eight (8) days before the date of the cancellation of a class of

shares.

“Total Cancellation Amount” means the amount determined by the board of managers or as the case may be the sole

manager and approved at the General Meeting (or as the case may be the sole shareholder of the Company) or by way of
Shareholders Circular Resolution on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount shall be

100

L

U X E M B O U R G

lower or equal to the entire Available Amount at the time of the cancellation of the relevant class of shares unless otherwise
resolved at the General Meeting (or as the case may be by the sole shareholder of the Company) or by way of Shareholders
Circular Resolution in the manner provided for an amendment of the Articles, provided however that the Total Cancellation
Amount shall never be higher than such Available Amount.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are and will remain in registered form (parts sociales nominatives). The shares are indivisible and the

Company recognises only one (1) owner per share.

6.2 The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-

quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for that

purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is jointly managed by two managers or more managers appointed by a resolution of the General

Meeting or by way of Shareholders Circular Resolution, which sets the term of their office. The managers need not be
shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting or by

way of Shareholders Circular Resolution.

Art. 8. Board of managers. The Company will be managed by a board of managers (the Board). The Board shall be

composed of at least two (2) managers who will be A managers (hereafter each a Manager A) or B managers (hereafter
each a Manager B).

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board that has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except

in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if (a) a majority of its members is present or represented, and (b) at

least one Manager A is present or represented at the meetings. Resolutions of the Board are validly taken by a simple
majority of the managers present or represented provided that at least one Manager A votes in favour of the decision(s) to
be adopted. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman
has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The parti-
cipation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of two managers, including at least

the signature of one Manager A.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been

delegated.

Art. 9. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law and that the manager has acted in good faith.

101

L

U X E M B O U R G

IV. Shareholder(s)

Art. 10. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
10.1. Powers and voting rights
(i)  Resolutions  of  the  shareholders  are  adopted  at  a  general  meeting  of  shareholders  of  the  Company  (the  General

Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent

to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders
are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i)  The  shareholders  are  convened  to  General  Meetings  or  consulted  in  writing  at  the  initiative  of  any  manager  or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of

the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi)  Resolutions  to  be  adopted  at  General  Meetings  or  by  way  of  Shareholders  Circular  Resolutions  are  passed  by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority
of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters

of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

10.3. Subject-Matters of Resolutions
The shareholders shall resolve on the subject-matters prescribed by the Law.

Art. 11. Sole shareholder.
11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by

the Law to the General Meeting.

11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions

is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
12.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders

Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 13. Allocation of profits.
13.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

13.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to

the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.

13.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last

102

L

U X E M B O U R G

financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the

interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

(vi) the interim dividends shall be allocated and paid in the following order:
the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a dividend equal to 1% (or alternatively 10%) of the nominal

value of the Class A Shares;

the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a dividend equal to 2% (or alternatively 9%) of the nominal value

of the Class B Shares;

the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a dividend equal to 3% (or alternatively 8%) of the nominal value

of the Class C Shares;

the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a dividend equal to 4% (or alternatively 7%) of the nominal value

of the Class D Shares;

the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to 5% (or alternatively 6%) of the nominal value

of the Class E Shares;

the holder(s) of the Class F Shares shall be entitled to a dividend equal to 6% (or alternatively 5%) of the nominal value

of the Class F Shares;

the holder(s) of the Class G Shares shall be entitled to a dividend equal to 7% (or alternatively 4%) of the nominal value

of the Class G Shares;

the holder(s) of the Class H Shares shall be entitled to a dividend equal to 8% (or alternatively 3%) of the nominal value

of the Class H Shares;

the holder(s) of the Class I Shares shall be entitled to a dividend equal to 9% (or alternatively 2%) of the nominal value

of the Class I Shares;

the holder(s) of the Class J Shares shall be entitled to a dividend equal to 10% (or alternatively 1%) of the nominal value

of the Class J Shares;

the holders of the ordinary Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to 0.5% of the nominal value of the

ordinary Shares.

VI. Dissolution - Liquidation

14.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a

majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one (1)
or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and
remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets
and pay the liabilities of the Company.

14.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in

proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

15.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders

Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

15.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board

meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

15.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board
by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original
or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same document.

15.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law and, subject

to any non waivable provisions of the Law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

<i>Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2016.

<i>Subscription and payment

ZAB Prop Co. A S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for seven thousand three

hundred forty-eight (7,348) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-) each, and agrees to pay them
in full by a contribution in cash in the amount of seven thousand three hundred forty-eight euro (EUR 7,348.-).

103

L

U X E M B O U R G

ZAB Prop Co. B S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for seven thousand four hundred

thirty-two (7,432) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-) each, and agrees to pay them in full by
a contribution in cash in the amount of seven thousand four hundred thirty-two euro (EUR 7,432.-).

ZAB Prop Co. C S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for ten thousand two hundred

twenty (10,220) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-) each, and agrees to pay them in full by
a contribution in cash in the amount of ten thousand two hundred twenty euro (EUR 10,220.-).

The amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) is at the disposal of the Company, evidence of which has been

given to the undersigned notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this deed

are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).

<i>Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire subscribed

capital, have passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed for an indefinite period:

<i>a. as Manager A of the Company

- Jose Maria Ortiz, Director, born on January 3, 1970, in Madrid, Spain, with professional address at 17, rue Edmond

Reuter, L-5326 Contern

<i>b. as Manager B of the Company

- Hildegard Winnebeck, Manager, born on June 5, 1965 in Trier, Germany, with professional address at 17, rue Edmond

Reuter, L-5326 Contern

2. The registered office of the Company is established at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of

Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, upon request of the appearing party, this deed

is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the German
text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned

notary.

Deutsche Üebersetzung des Vorstehenden Textes

Am dreiundzwanzigsten Tag des Monats Oktober im Jahre zweitausendfunfzehn,
ist vor dem unterzeichneten Notar Maitre Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Diekirch, Grosherzogtum Luxemburg,

ERSCHIENEN:

Die ZAB Prop Co. A S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet

und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum
Luxemburg,  eingetragen  beim  Luxemburger  Handels-und  Gesellschaftsregister  unter  der  Nummer  B  200.845  und  ein
Gesellschaftskapital von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) hat,

Die ZAB Prop Co. B S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet

und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum
Luxemburg,  eingetragen  beim  Luxemburger  Handels-und  Gesellschaftsregister  unter  der  Nummer  B  200.825  und  ein
Gesellschaftskapital von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) hat,

Die ZAB Prop Co. C S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet

und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum
Luxemburg,  eingetragen  beim  Luxemburger  Handels-und  Gesellschaftsregister  unter  der  Nummer  B  200.846  und  ein
Gesellschaftskapital von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) hat,

hier alle vertreten durch Herrn José María Ortiz, mit Geschäftsadresse in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern,

Großherzogtum Luxemburg, aufgrund von Vollmachten, welche jeweils am 22. Oktober 2015 erteilt wurden.

Besagte Vollmachten, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurden, wer-

den der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.

Die erschienenen Parteien, vertreten wie oben dargestellt, haben den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzu-
setzen.

104

L

U X E M B O U R G

I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „ZAB Invest Co. S.à r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner
derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Contern, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann

durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die
Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-

land durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat feststellen, dass
außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass
diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Ver-
bindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende
Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung
des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb von Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder

im Ausland, insbesondere von Einkaufszentren, und der Erwerb und die Verwaltung von zur Bewirtschaftung von Immo-
bilien erforderlichen Gegenständen.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie

kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, über-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen
anderer  Gesellschaften  nachzukommen  und  im  Allgemeinen  zu  ihrem  eigenen  Vorteil  und  zum  Vorteil  jeder  anderen
Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche
Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,

Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

II. Kapital - Geschäftsanteile

Art. 5. Kapital.
5.1. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf fünfundzwanzigtausendEuro (EUR 25.000,-), aufgeteilt in (i) zwölftau-

senfünfhundert (12.500) Stammanteile, (ii) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse A (die “Klasse
A Anteile”), (iii) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse B (die “Klasse B Anteile”), (iv) eintausend
zweihundertundfünfzig  (1.250)  Anteile  der  Klasse  C  (die  “Klasse  C  Anteile”),  (v)  eintausend  zweihundertundfünfzig
(1.250) Anteile der Klasse D (die “Klasse D Anteile”), (vi) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse
E (die “Klasse E Anteile”), (vii) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse F (die “Klasse F Anteile”),
(viii) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse G (die “Klasse G Anteile”), (ix) eintausend zweihun-
dertundfünfzig  (1.250)  Anteile  der  Klasse  H  (die  “Klasse  H  Anteile”),  (x)  eintausend  zweihundertundfünfzig  (1.250)
Anteile der Klasse I (die “Klasse I Anteile”) und (xi) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse J (die
“Klasse J Anteile”); jede jeweils ausgegeben in voll liberierten Namensanteile mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1).

5.2. Zusätzlich zum gezeichneten Gesellschaftskapital kann ein Rücklagenkonto für das Emmissionsagio eingerichtet

werden, auf welchem das auf die Stammanteile über deren Nominalwert eingezhalten Emissionsagio als Kapitalrücklage
verbucht werden kann. Der Betrag des Rücklagenkontos kann für Zahlungen der Gesellschaft an ihre(n) Gesellschafter im
Rahmen des Rückerwerbs von Stammanteilen, zum Ausgleich des realisierten Nettoverlusts, für Ausschüttungen an den/
die Gesellschafter in Form von Dividenden verwednet werden oder der gesetzlichen Kapitalrücklage zugeführt zu werden.

5.3. Durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit den für eine Satzungs-

änderung erforderlichen Bestimmungen zu fassen ist, kann das gezeichnete Gesellschaftskapital durch die Ausgabe von
Anteilen erhöht oder herabgesetzt werden. In keinem Fall darf das Gesellschaftskapital unter einen Betrag von fünfund-
zwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) fallen. Dessen ungeachtet kann das Gesellschaftskapital der Gesellschaft verringert

105

L

U X E M B O U R G

werden durch die Löschung einer gesamten Anteilsklasse (nicht jedoch eines Teils Anteilsklasse), welche durch Rücker-
werb  und  Annullierung  aller  in  dieser  Klasse  ausgegebenen  Anteilen  erfolgt,  wie  es  von  Zeit  zu  Zeit  durch  den
Geschäftsführungsrat festgestellt und durch die Hauptversammlung oder im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesell-
schafter bestätigt wird; der Rückerwerb und die Annullierung von Stammanteilen durch die Gesellschaft sind ausgeschlos-
sen. Sofern der Rückerwerb und die Annullierung einer gesamten Klasse beabsichtigt sind, haben diese in der folgenden
Reihenfolge zu erfolgen: (i) Klasse A Anteile; (ii) Klasse B Anteile; (iii) Klasse C Anteile; (iv) Klasse D Anteile; (v) Klasse
E Anteile; (vi) Klasse F Anteile; (vii) Klasse G Anteile; (viii) Klasse H Anteile; (ix) Klasse I Anteile und (x) Klasse J
Anteile.

5.4. Im Falle der Kapitalherabsetzung durch Löschung einer gesamten Anteilsklasse durch Rückerwerb und Annullie-

rung aller ausgegebenen Anteile in der betreffenden Klasse (gemäß obiger Reihenfolge) steht jedem Inhaber von Anteilen
dieser Anteilsklasse (pro rata gemäß der gehaltenen Anteile in der jeweiligen Anteilsklasse) ein anteiliger Anspruch aus
dem Gesamtannullierungsbetrag in Bezug auf die einzuziehende Anteilsklasse zu; jeder Inhaber von rückerworbenen oder
annullierten Anteilen erhält von der Gesellschaft einen Betrag, der dem Annullierungswert pro Anteil für jeden Anteil der
relevanten Anteilsklasse entspricht.

5.5. Eine Verminderung des Gesellschaftskapitals durch Rückerwerb einer Anteilsklasse kann nur innerhalb der be-

treffenden Klassenperiode erfolgen, z.B.:

Die Periode für die Anteile der Klasse A ist die Periode beginnend vom Zeitpunkt der notariellen Urkunde vom 16.

Oktober 2015 bis längstens 31. Dezember 2015 (die Klasse A Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse B ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse A Periode bis längstens 31.

Dezember 2016 (die Klasse B Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse C ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse B Periode bis längstens 31.

Dezember 2017 (die Klasse B Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse D ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse C Periode bis längstens 31.

Dezember 2018 (die Klasse D Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse E ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse D Periode bis längstens 31.

Dezember 2019 (die Klasse E Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse F ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse E Periode bis längstens 31.

Dezember 2020 (die Klasse F Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse G ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse F Periode bis längstens 31.

Dezember 2021 (die Klasse G Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse H ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse G Periode bis längstens 31.

Dezember 2022 (die Klasse H Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse I ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse H Periode bis längstens 31.

Dezember 2023 (die Klasse I Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse J ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse I Periode bis längstens 31.

Dezember 2024 (die Klasse J Periode).

5.6. Im Falle, dass eine Anteilsklasse nicht zurückerworben und aufgelöst wurde innerhalb der relevanten Klassenpe-

riode, kann die Rückgabe und Auflösung dieser Anteilsklasse(n) innerhalb einer neuen Periode (die Neue Periode) erfolgen,
welche am Datum nach der letzten Klassenperiode (oder gegebenenfalls dem Datum nach der unmittelbar vorangehenden
Neuen Periode einer anderen Klasse) und spätestens ein Jahr nach dem Datumbeginn einer solchen Neuen Periode enden.
Die erste neue Periode beginnt am Tag nach der Klasse J Periode und die in ihrer betreffenden Klassenperiode nicht
zurückerworbene und nicht aufgelöste Anteilsklasse erfolgt der Reihe nach von Klasse A bis Klasse J (soweit sie nicht
zuvor zurückerworben und aufgelöst wurde9:

Um Zweifel zu vermeiden, im Falle, dass ein Rückerwerb und eine Auflösung einer Anteilsklasse vor dem letzten Tag

ihrer betreffenden Klassenperiode erfolgt (oder gegeben falls Neuen Periode), beginnt die nachfolgende Klassenperiode
(oder gegeben falls die Neue Periode) am Tag nach dem Rückerwerb und der Auflösung dieser Anteilsklasse und endet an
demjenigen Tag wie ursprünglich in den obigen Artikeln definiert.

Mit Rückerwerb und Auflösung der gesamten relevanten Klassen wird die Auflösungssumme fällig und zahlbar durch

die Gesellschaft an die Gesellschafter(in) anteilsmäßig gemäss deren Klassenanteil(en). Die Gesellschaft kann ihre Zah-
lungsverpflichtung in bar, durch Sachleistung oder Aufrechnung erfüllen.

Für Zwecke dieses Artikels:
“Verfügbarer Betrag” bedeutet den Gesamtbetrag des Nettogewinns der Gesellschaft (einschließlich vorgetragener Ge-

winne) soweit Gesellschafter gemäß dieser Satzung zum Erhalt von Dividendenausschüttungen berechtigt gewesen wären,
erhöht um (i) alle frei ausschüttbaren Reserven (einschließlich des Rücklagenkontos für das Emissionsagio bis zur Höhe
der Verluste einschließlich vorgetragener Verluste) und (ii) gegebenenfalls den Betrag der Kapitalherabsetzung und der
Verringerung der gesetzlichen Rücklagen im Hinblick auf die einzuziehenden/zu löschenden Anteilsklassen, jedoch ver-
ringert um (i) alle Verluste (einschließlich vorgetragener Verluste), und (ii) aller Beträge, welche aufgrund des Gesetzes
oder dieser Satzung als Rücklage(n) gebildet werden müssen, jedes Mal wie in den betreffenden Zwischenbilanzen dar-
gestellt (jedoch ohne doppelte Buchung) so dass:

106

L

U X E M B O U R G

AA = (NP + P+ CR) – (L + LR +OD+PE)
Wobei:
AA = Verfügbarer Betrag
NP = Nettogewinn (einschließlich vorgetragener Gewinne)
P = alle frei ausschüttbaren Reserven (einschließlich des Rücklagenkontos für das Emissionsagio bis zu einem Betrag

von L)

CR = der Betrag der Kapitalherabsetzung und der Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage bezogen auf diejenige An-

teilsklasse, welche aufgelöst werden soll

L = Verluste (einschließlich vorgetragene Verluste)
LR = alle Beträge, welche aufgrund Anforderungen des Gesetzes oder dieser Satzung als Rücklage(n) gebildet werden

müssen.

OD = sämtliche jährlich festgelegten Dividenden, zu welchen der/die Inhaber der Stammanteile gemäß diesen Artikeln

berechtigt ist/sind.

PE = Gewinnanspruch (die jährlich festgelegten Dividenden, zu welchen der/die Inhaber von Anteilsklassen gemäß

diesen Artikeln berechtigt ist/sind.

Der Verfügbare Betrag, basierend auf obiger Formel, kann um sämtliche der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Rücknahme

zur Verfügung stehende überschüssige Liquidität und/oder Vermögenswerte, erhöht werden, wobei überschüssige Liqui-
dität und Vermögenswerte aus dem Rücklagenkonto des Emissionsagio bis zur Höhe des Betrags der an das Emissionsagio
gebundenen Kapitalrücklage zum Zeitpunkt der Rücknahme zu zahlen sind.

„Verfügbare Liquidität“ bedeutet (i) alles Bargeld, das von der Gesellschaft gehalten wird (mit Ausnahme von Fest-

geldanlagen mit einer Restlaufzeit von mehr als sechs (6) Monaten, (ii) sämtliche leicht vermarktbaren Geldmarktinstru-
mente, Bonds, Banknoten und alle Forderungen, welche nach Meinung des Geschäftsführungsrats in Kürze gezahlt werden
abzüglich jeglicher Schuldenlast oder anderer Verbindlichkeiten der Gesellschaft, welche auf Grundlage der Zwischenbi-
lanzen der betreffenden Klassenperiode (oder gegebenen falls Neuen Periode) in weniger als sechs (6) Monaten fällig sind
und (iii) sämtliche Vermögenswerte wie Anteile, Wertpapiere oder Sicherheiten oder sonstige Vermögenswerte, welche
die Gesellschaft besitzt.

„Annullierungsbetrag“ bedeutet ein Betrag, welcher den zu der betreffenden Klassenperiode (oder gegeben falls Neuen

Periode) gehörenden verfügbaren Betrag nicht übersteigt, vorausgesetzt, dass der Annullierungsbetrag Neuen Periode).

“Annullierungswert pro Anteil” bedeutet den durch Division des Gesamtannullierungsbetrages durch die ausgegebene

Anzahl von Anteilen in der von der Annullierung betroffenen Anteilsklasse errechneten Wert.

„Klassenperiode“ bedeutet jede der Klasse A Periode, Klasse B Periode, Klasse C Periode, Klasse D Periode, Klasse E

Periode, Klasse F Periode, Klasse G Periode, Klasse H Periode, Klasse I Periode und Klasse J Periode.

“Zwischenbilanzen” bedeuten die Zwischenbilanzen der Gesellschaft gemäß Luxemburger GAAP zum betreffenden

Zwischenbilanzzeitpunkt.

“Zwischenbilanzzeitpunkt” bedeutet das Datum frühestens acht (8) Tage vor dem Datum der Löschung einer Anteils-

klasse.

“Gesamtannullierungsbetrag” bedeutet der vom Geschäftsführungsrat oder gegebenenfalls dem Alleingeschäftsführer

festgelegten und von der Hauptversammlung (oder gegebenenfalls dem Alleingesellschafter der Gesellschaft) oder im
Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter bestätigten Betrag, basierend auf den relevanten Zwischenbilanzen. Der
Gesamtannullierungsbetrag muss niedriger oder gleich dem gesamten Verfügbaren Betrag zum Zeitpunkt der Löschung
der betreffenden Anteilsklasse sein, es sei denn, dass dies anderweitig durch die Hauptversammlung (oder gegebenenfalls
durch den Alleingesellschafter der Gesellschaft) oder im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter gemäß den
Bestimmungen  zur  Änderung  dieser  Satzung  beschlossen  worden  ist,  vorausgesetzt  jedoch,  dass  der  Gesamtannullie-
rungsbetrag nie höher sein darf als der Verfügbare Betrag.

Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile (parts sociales nominatives). Die Geschäftsanteile sind unteilbar

und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.

6.2. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen

Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.

Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel 1690

des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt wurde.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter

eingesehen werden kann.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über

ausreichend ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals beruht.

107

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Geschäftsanteile.
6.5. Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile (parts sociales nominatives). Die Geschäftsanteile sind unteilbar

und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.

6.6. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen

Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.

Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel 1690

des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt wurde.

6.7. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter

eingesehen werden kann.

6.8. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über

ausreichend ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals beruht.

III. Verwaltung - Stellvertretung

Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von zwei oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch

einen  Beschluss  der  Hauptversammlung  oder  im  Wege  eines  Umlaufbeschlusses  bestellt,  welcher  auch  ihre  Amtszeit
festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung oder im Wege

eines Umlaufbeschlusses abberufen werden.

Art. 8. Geschäftsführungsrat. Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsführungsrat (der Rat) verwaltet. Der Rat soll

aus  mindestens  zwei  (2)  Geschäftsführern  bestehen,  die  entweder  A  Geschäftsführer  (Geschäftsführer  A)  oder  B  Ge-
schäftsführer (Geschäftsführer B) sein sollen.

8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern

vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und
Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.

(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Hand-

lungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.

8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung ge-

nannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vier-

undzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann
in der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder

vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des

Rates vertreten zu lassen.

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn (a) die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind

und (b) wenigstens ein Geschäftsführer A bei der Versammlung anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Rates
sind wirksam, wenn sie mit einer einfachen Mehrheit der von den anwesenden und vertretenen Geschäftsführern gefasst
werden, wobei mindestens ein Geschäftsführer A für den Beschluss oder die Beschlüsse gestimmt haben muss. Die Be-
schlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn
kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet
werden müssen.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommuni-

kationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind und im Umlaufverfahren gefasst

worden sind (die Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in
einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt
hinzugefügten Unterschrift.

8.3. Vertretung

108

L

U X E M B O U R G

(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei

(2) Geschäftsführern gebunden, wobei stets mindestens ein Geschäftsführer A unterzeichnet haben muss.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit gemäß Sinne von Artikel 8.1.

(ii) Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.

Art. 9. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Ver-

bindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen und der Geschäfts-
führer in gutem Glauben gehandelt hat.“

IV. Gesellschafter

Art. 10. Hauptversammlung und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter.
10.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Hauptversammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder

durch Beschlüsse im Umlaufverfahren (die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.

(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse

gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten
Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter, welcher das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift trägt, ist genauso gültig
und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst
wurde.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals

vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage

im Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten

Zeit statt; die Hauptversammlungen sollten grundsätzlich im Groβherzogtum Luxemburg abgehalten werden.

(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-

tretenen  Gesellschafter  erklären,  dass  ihnen  die  Tagesordnung  im  Voraus  bekannt  gegeben  wurde  und  sich  selbst  als
ordnungsgemäß einberufen betrachten.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine

schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Umlaufbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse

werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die Gesellschafter
per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung gebeten und die
Beschlüsse oder die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals

vertreten, abgeändert werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters

gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

10.3. Gegenstände von Beschlüssen
Die Gesellschafter sollen über die Gegenstände abstimmen welche per Gesetz vorgeschrieben sind.

Art. 11. Alleingesellschafter.
11.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch

der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

11.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Umlaufbeschluss der Gesellschafter

innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

11.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
12.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden Jahres.
12.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste,

welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft,
die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

109

L

U X E M B O U R G

12.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
12.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines

Umlaufbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.

Art. 13. Gewinnausschüttung.
13.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage

zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des
Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

13.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu

verfügen  ist.  Sie  können,  in  Übereinstimmung  mit  den  geltenden  gesetzlichen  Regelungen,  mit  dem  Überschuss  eine
Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.

13.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive des Emissionsagio) zur

Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende
des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht
um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der
gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten

ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;

(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüt-

tung nicht gefährdet werden; und

(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so

müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.

(vi) die Abschlagsdividenden werden in folgender Reihenfolge ausgezahlt:
die Inhaber der Klasse A Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 1% (oder alternativ 10%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse A entspricht

die Inhaber der Klasse B Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 2% (oder alternativ 9%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse B entspricht

die Inhaber der Klasse C Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 3% (oder alternativ 8%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse C entspricht

die Inhaber der Klasse D Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 4% (oder alternativ 7%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse D entspricht

die Inhaber der Klasse E Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 5% (oder alternativ 6%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse A entspricht

die Inhaber der Klasse F Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 6% (oder alternativ 5%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse F entspricht

die Inhaber der Klasse G Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 7% (oder alternativ 4%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse G entspricht

die Inhaber der Klasse H Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 8% (oder alternativ 3%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse H entspricht

die Inhaber der Klasse I Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 9% (oder alternativ 2%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse I entspricht

die Inhaber der Klasse J Anteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 10% (oder alternativ 1%) des Nominalwerts

der Anteilsklasse J entspricht

die Inhaber der Stammanteile sind zu einer Dividende berechtigt, welche 0,5% des Nominalwerts der Stammanteile

entspricht.

VI. Auflösung - Liquidation

14.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschafter,

welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen
(1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der
Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die
Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft zu erfüllen.

14.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesellschaf-

tern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.

110

L

U X E M B O U R G

VII. Allgemeine Bestimmungen

15.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Umlaufbe-

schlüsse der Geschäftsführer und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-
Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

15.2. Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer

Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.

15.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es werden

alle  gesetzlichen  Erfordernisse  für  handschriftliche  Unterschriften  entsprechend  erfüllt.  Unterschriften  auf  Umlaufbe-
schlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst
werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche
zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

15.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprech-

enden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2016.

<i>Zeichnung und Zahlung

ZAB Prop Co. A S.à r.l., wie vorstehend bezeichnet und vertreten, zeichnet siebentausenddreihundertachtundvierzig

(7.348) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser
Geschäftsanteile in Höhe von siebentausenddreihundertachtundvierzig Euro (EUR 7.348.-).

ZAB Prop Co. B S.à r.l., wie vorstehend bezeichnet und vertreten, zeichnet siebentausendvierhundertzweiunddreißig

(7.432) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser
Geschäftsanteile in Höhe von siebentausendvierhundertzweiunddreißig Euro (EUR 7.432,-).

ZAB Prop Co. C S.à r.l., wie vorstehend bezeichnet und vertreten, zeichnet zehntausendzweihundertzweiundzwanzig

(10.220) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser
Geschäftsanteile in Höhe von zehntausendzweihundertzweiundzwanzig Euro (EUR 10.220,-).

Die Geschäftsanteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR

25.000) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-

genden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-) betragen.

<i>Beschlüsse der ersten Hauptversammlung Gesellschafter

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die Hauptversammlung der Gesellschafter, welche die Gesamt-

heit der gezeichneten Geschäftsanteile vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum ernannt:

<i>a. als Geschäftsführer A der Gesellschaft

- José María Ortiz, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 3. Januar 1970 in Madrid, Spanien, geschäftsansässig in 17,

rue Edmond Reuter, L-5326 Contern

<i>b. als Geschäftsführer B der Gesellschaft

- Hildegard Winnebeck, Geschäftsführerin, geboren am 5. Juni 1965 in Trier, Germany, geschäftsansässig in 17, rue

Edmond Reuter, L-5326 Contern

2. Sitz der Gesellschaft ist in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt

hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.
Sie wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen und von der letzteren und dem unterzeichneten

Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J.M. ORTIZ, DELOSCH.

111

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 26 octobre 2015. Relation: DAC/2015/17821. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 27. Oktober 2015.

Référence de publication: 2015176386/786.
(150195044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2015.

Harry &amp; Cie, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 39, rue Zénon Bernard.

R.C.S. Luxembourg B 191.615.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales (du 16 octobre 2015 de la société Harry &amp; Cie, société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
191.615),

que Monsieur Frédéric BUA, né le 3 octobre 1986 à Forbach, demeurant au 39, rue Zénon Bernard, L-4031 Esch-Sur-

Alzette,

a cédé à
La société SEMINAIRE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois avec siège sociale au

16, avenue de la Gare, L-4873 Lamadelaine, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 65.937,

50 (cinquante) part sociale de la société Harry &amp; Cie
Après la cession ci-avant décrite, le capital social de la société Harry &amp; Cie se trouve réparti comme suit:

Madame Sarah DE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
SEMINAIRE INVESTISSEMENT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales

Pour avis sincère et conforme
Sarah DE SA
<i>Gérant

Référence de publication: 2015179114/24.
(150199039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Tulpen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 157, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 91.898.

L'an deux mille quinze, le quatorze octobre,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «TULPEN S.à r.l.», ayant son

siège social à L-1221 Luxembourg, 157, rue de Beggen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 91.898, constituée suivant acte notarié en date du 13 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 328 du 26 mars 2003 (la Société).

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis.
L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Bing QIAN, commerçant, résidant profession-

nellement à L-1221 Luxembourg, 157, rue de Beggen,

qui désigne comme secrétaire Madame Cheryl GESCHWIND, employée privée, résidant professionnellement à L-1212

Luxembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée  choisit  comme  scrutatrice  Madame  Ying  QIAN,  commerçante,  résidant  professionnellement  à  L-1221

Luxembourg, 157, rue de Beggen.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Décision de la dissolution et de la liquidation volontaire de la Société,
2. Décharge à la gérante de la Société pour l'exécution de son mandat respectif jusqu'à ce jour,

112

L

U X E M B O U R G

3. Nomination du liquidateur,
4. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la procédure de liquidation,
5. Instruction au liquidateur de réaliser au mieux tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne

varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce

jour conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'accorder décharge à la gérante de la Société pour l'exécution de son mandat respectif

jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer en tant que liquidateur de la Société Madame Ying QIAN, commerçante, née

le 10 janvier 1968 à Hangzhou/Zhejiang (Chine), résidant professionnellement à L-1221 Luxembourg, 157, rue de Beggen
(le Liquidateur).

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'attribuer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148

bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas

où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droit réels, privilèges,

hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypo-
thécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé d'établir un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de charger le Liquidateur de réaliser au mieux tous les actifs de la Société, et de payer

toutes les dettes de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, en date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: B. QIAN, C. GESCHWIND, Y. QIAN et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 20 octobre 2015. 1LAC/2015/33265. Reçu douze euros € 12,-

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Référence de publication: 2015177928/74.
(150197648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

113

L

U X E M B O U R G

Carre Invest S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 199.754.

IN THE YEAR TWO THOUSAND FIFTEEN,
ON THE TWENTY-THIRD DAY OF THE MONTH OF OCTOBER.
Before Us Maître Cosita DELVAUX, duly appointed notary in Luxembourg;

THERE APPEARED:

Mr Fons MANGEN, director, chartered accountant, residing professionally in Luxembourg,
acting as special proxyholder of the board of directors of the company CARRE INVEST S.A.-SPF, named here below,
by virtue of a resolution of the board of directors adopted on 24 September 2015, a copy of which, signed "ne varietur"

by the appearing person and the officiating notary, will remain attached to the present deed.

Said appearing person, acting in the above stated capacity, asked the notary to document that:
I.- The company CARRE INVEST S.A.-SPF, a Private Wealth Management Company (“SPF”), organized as a joint

stock company (société anonyme), with its registered office at 9b, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 199754 (the “Company”), was incorporated
on 25 August 2015 by deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, acting in replacement of the
undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2889 of 20 October 2015,
with an entirely subscribed and paid up share capital of USD 50,000 (fifty thousand United States dollars) divided into
5,000 (five thousand) shares with a nominal value of USD 10 (ten United States dollars) each;

II.- L'article 5 (five), paragraphs 4 (four) to 9 (nine) of the Articles of Incorporation of the Company, state that:
"For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at USD 100,000,000 (one hundred million United

States dollars) to be divided into 10,000,000 (ten million) shares with a nominal value of USD 10 (ten United States dollars)
each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period ending five (5) years after the date of publication of

the deed of incorporation of the Company in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, to increase in one or
several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be
subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in
kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by
incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as mentioned
below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present

article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.”;

III.- The board of directors, in its meeting of 24 September 2015, has decided to proceed to an increase of the share

capital by USD 19,950,000.- (nineteen million nine hundred fifty thousand United States dollars) in order to bring it from
its current amount of at USD 50,000 (fifty thousand United States dollars) to USD 20,000,000.- (twenty million United
States dollars) by the issue of 1,995,000 (one million nine hundred ninety-five thousand) shares with a nominal value of
USD 10.- (ten United States dollars) each, vested with the same rights and advantages as the existing shares;

IV.- The board of directors has admitted to the subscription of the new 1,995,000 (one million nine hundred ninety-five

thousand) shares the current sole shareholder of the Company;

V.- The capital increase has been entirely paid up by the above named subscribing sole shareholder by contribution in

cash wired to the bank account of the Company, so that the total amount of USD 19,950,000.- (nineteen million nine
hundred fifty thousand United States dollars) was at the free disposal of the Company and the proof of the subscription and
payment have been submitted to the undersigned notary;

VI.- As a consequence of this capital increase, paragraph 1 (one) of article 5 (five) of the Articles of Incorporation is

amended and will henceforth read as follows:

“ Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at USD 20,000,000 (twenty million United States dollars) divided

into 2,000,000 (two million) shares with a nominal value of USD 10 (ten United States dollars) each.".

114

L

U X E M B O U R G

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated

at EUR 6,300.- (six thousand three hundred Euro).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by her surname, first name, civil status

and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'AN DEUX MIL QUINZE, LE VINGT-TROIS OCTOBRE.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg;

A COMPARU:

Monsieur Fons MANGEN, administrateur, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société CARRE INVEST S.A.-SPF, ci-

après désignée,

en vertu d'une résolution du conseil d'administration adoptée en date du 24 septembre 2015 dont une copie, signée «ne

varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agît, a requis le notaire d'acter ses déclarations comme suit:
I.- La société CARRE INVEST S.A.-SPF, une société de gestion de patrimoine familial, en abrégé «SPF», sous forme

d'une société anonyme, ayant son siège social au 9b, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 199754 (la “Société”), a été constituée le 25 août
2015 suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement du
notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2889 du 20 octobre 2015, avec
un capital social entièrement souscrit et libéré de USD 50.000,-(cinquante mille US dollars) représenté par 5.000 (cinq
mille) actions d'une valeur nominale de USD 10,- (dix US dollars) chacune;

II.- L'article 5 (cinq), alinéas 4 (quatre) à 9 (neuf) des statuts de la Société stipule que:
«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de USD 100.000.000 (cent millions US dollars) qui

sera représenté par 10.000.000 (dix millions) actions d'une valeur nominale de USD 10 (dix US dollars) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période se terminant cinq (5) ans après la publication de

l'acte de constitution de la Société au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou plusieurs
fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de
capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices
reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment

autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il

fera adapter le présent article.»;

III.- Le conseil d'administration, en sa réunion du 24 septembre 2015 a décidé de procéder à la réalisation d'une partie

du capital autorisé à concurrence de USD 19.950.000,- (dix-neuf millions neuf cent cinquante mille US dollars) pour le
porter de son montant actuel de USD 50.000,- (cinquante mille US dollars) à USD 20.000.000,- (vingt millions US dollars),
par l'émission de 1.995.000 (un million neuf cent quatre-vingt-quinze mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de
USD 10,- (dix US dollars) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes;

IV.- Le conseil d'administration a admis à la souscription des 1.995.000 (un million neuf cent quatre-vingt-quinze mille)

actions nouvelles l'actionnaire unique existant;

V.- L'augmentation de capital a été intégralement libérée par le l'actionnaire unique souscrivant prénommé moyennant

apport en numéraire au compte bancaire de la Société, de sorte que la somme de USD 19.950.000,-(dix-neuf millions neuf
cent cinquante mille US dollars) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.

115

L

U X E M B O U R G

VI.- A la suite de cette augmentation de capital, l'alinéa 1 (premier) de l'article 5 (cinq) des statuts est modifié et aura

dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à USD 20.000.000,- (vingt millions US dollars) représenté par 2.000.000

(deux millions) actions d'une valeur nominale de USD 10,- (dix US dollars) chacune.».

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite des présentes s'élèvent

approximativement à EUR 6.300,- (six mille trois cents euros).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite de tout ce qui précède au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. MANGEN, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/33947. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015177380/135.
(150197093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

La Choral Notre Dame de Fatima A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-9370 Gilsdorf, 35, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg F 10.570.

STATUTS

Entre les soussignés:

Araújo Ferreira Aurora

35, rue Principale

L-9370 Gilsdorf

Portugaise

Glória Fontela Pereira

5, rue Joseph Theis

L-9286 Diekirch

Portugaise

Alberto Ferreira Freitas

25, Place Bleech

L-7610 Larochette

Portugaise

José Vaz do Rio

3, rue am Treppchen

L-9372 Gilsdorf

Portugaise

Et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21

avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

Titre 1 

er

 . Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  L'association porte la dénomination de: La Choral Notre Dame de Fatima A.s.b.l.

Art. 2. L'association a pour objet: Participation à la messe et exécution de chant liturgique et religieuse

Art. 3. L'association a son siège social à Luxembourg: L-9370 Gisdorf, 35, rue Principale
Le siège social peut être transfère à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du

conseil d'administration.

Art. 4. La durée de l'association est indéterminée.

Titre 2. Exercice social

Art. 5. L'exercice social coïncide avec l'année civile.

Titre 3. Membres

Art. 6. Peut devenir membre effectif de l'association La Choral Notre Dame de Fatima A.s.b.l.
Toute personne physique ou moral désirant faire partie de l'association doit présenter une demande d'adhésion écrite au

conseil d'administration, que précède à l'examen de la demande et s'entoure de tous éléments d'appréciation nécessaires
pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs
pour lesquels l'adhésion aura, le cas de échéant, été refusée.

116

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Le nombre minimum des nombres associes est de trois.

Art. 8. Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'adminis-

tration.

Est réputé démissionnaire tout associe qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas

acquitte de la cotisation dans délai de 10 jours à partir de l'envoi de la mise en demeure.

Art. 9. Tout associe peut être exclu par le conseil d'administration:
- En cas d'infraction grave aux présents statuts,
- En cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constates par le conseil d'administration.
Un recours dûment devant l'assemblée général est possible. L'assemblée générale décide souverainement en dernière

instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentantes.

Titre 4. Assemble générale

Art. 10. L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe

de l'association.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'adminis-

tration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire a tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du jour.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'une cinquième des membres de l'association.
Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par outre membre à l'aide d'une procuration.
Les résolutions d'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par carte circulaire ou

par tout autre moyen approprient.

Art. 11. les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale

y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentantes.

Titre 5. Administration

Art. 12. L'association est gérée par un conseil d'administration compose de 4 (quatre) membres au moins, élus par

l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de ... ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront

les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier. Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la
loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Art. 13. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil

d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration son convoques par simple lettre ou par tout autre moyen approprie.

Art. 14. La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association.

Art. 15. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à

un de ses membres ou à un tiers.

Titre 6. Contributions et cotisations

Art. 16. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'association, seront tenus de payer une con-

tribution dont le montant est fixé par l'assemble générale.

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

Art. 17. La cotisation annuelle maxima pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l'assemblée

générale.

Titre 7. Mode d'établissement des comptes

Art. 18. Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour

approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

Titre 8. Modification des statuts

Art. 19. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur modifications à apporter aux statuts que si celles-ci sont

expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des membres.

Art. 20. les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de

la loi du 21 Avril 1928, telle que modifiée.

Titre 9. Dissolution et liquidation

Art. 21. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du

21 Avril 1928, telle que modifiée.

117

L

U X E M B O U R G

Art. 22. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association a designer par l'assemble

générale.

Titre 10. Dispositions finales

Art. 23. Pour les points non règles par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux

dispositions de la loi du 21 Avril 1928. Telle que modifiée.

Référence de publication: 2015177634/85.
(150198211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Finnery Acquisitions III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.124,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 197.478.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of October,
Before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Bandon Acquisitions S.à r.l., a Luxembourg private limited company (société à responsabilité limitée), having its re-

gistered office at 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Registrar under number B 197.993 (the Sole Shareholder),

represented by Ms Anne de Bourcy, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under

private seal.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following:
I. The Sole Shareholder holds all the shares in Finnery Acquisitions III S.à r.l., a Luxembourg private limited liability

company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of USD 20,000, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 197.478 (the Company). The Company was incorporated on 30 April 2015 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer,
notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2013, on 7 August
2015. The articles of incorporation of the Company have not been amended since the date of incorporation.

II. The Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance

with article 200-2 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

III. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:
(1) Conversion of the currency of the share capital of the Company from USD to GBP at the exchange rate applicable

on 13 October 2015 so that the share capital be set at GBP 13,124 (thirteen thousand one hundred and twenty-four British
pounds);

(2) Amendment of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the above-mentioned changes;
(3) Granting of powers; and
(4) Miscellaneous.
IV. The Sole Shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the currency of the share capital of the Company from US dollars (USD) to

British pounds (GBP), on the basis of the exchange rate displayed on 13 October 2015 on the website www.xe.com, which
is set at USD 1 (one US dollar) for GBP 0.6562 (zero point six thousand five hundred and sixty-two British pounds).

The Sole Shareholder acknowledges that, as a result thereof, the share capital of the Company is set at GBP 13,124

(thirteen thousand one hundred and twenty-four British pounds) represented by 13,124 (thirteen thousand one hundred and
twenty-four) shares, with a nominal value of GBP 1 (one British pound) each.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the

above resolutions, so that it reads henceforth as follows:

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at GBP 13,124 (thirteen thousand one hundred

and twenty-four British pounds), represented by 13,124 (thirteen thousand one hundred and twenty-four) shares having a
nominal value of GBP 1 (one British pound) each.”

118

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to empower and to authorise any manager of the Company, each acting individually

under his/her sole signature on behalf of the Company, to record and sign the changes made under the above resolutions
to the amount and currency of the share capital and the number of shares in the share register, and generally to perform
any other action that may be necessary or useful in relation thereto.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 1,400 (one thousand

four hundred euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the attorney-in-fact of

the Sole Shareholder, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
attorney-in-fact of the Sole Shareholder, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of the present

deed.

The document having been read to the attorney-in-fact of the Sole Shareholder, the attorney-in-fact of the Sole Share-

holder signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt-deux octobre,
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Bandon Acquisitions S.àr.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.993 (l'Associé Unique),

ici représentée par Mademoiselle Anne de Bourcy, avocate, demeurant professionnellement au Grand-Duché du Lu-

xembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique détient l'intégralité des parts sociales de Finnery Acquisitions III S.àr.l., une société à responsabilité

limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.478
(la Société). La Société a été constituée le 30 avril 2015 par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 2013, daté du 7 août 2015. Les statuts de
la Société n'ont jamais été modifiés depuis la date de la constitution.

II. L'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés de la Société conformément à

l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

III. L'Associé Unique désire prendre des résolutions sur les points suivants:
1) Conversion en livres sterling (GBP) de la devise du capital social de la Société actuellement exprimée en dollars des

Etats-Unis d'Amérique (USD) sur la base du taux de change applicable au 13 octobre 2015 afin que le capital social soit
fixé à 13.124 GBP (treize mille cent vingt-quatre livres sterling);

2) Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus;
3) Délégation de pouvoir; et
4) Divers.
IV. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de convertir en livres sterling (GBP) la devise du capital social de la Société actuellement

exprimée en dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD) sur la base du taux de change indiqué au 13 octobre 2015 sur le site
internet www.xe.com, selon lequel 1 USD (un dollar) correspond à 0,6562 GBP (zéro virgule six mille cinq cent soixante-
deux livres sterling). L'Associé Unique constate qu'en conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société est
établi à 13.124 GBP (treize mille cent vingt-quatre livres sterling) représenté par 13.124 (treize mille cent vingt-quatre)
parts sociales ayant une valeur nominale de 1 GBP (une livre sterling chacune).

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les changements intervenus ci-

dessus, de telle sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

119

L

U X E M B O U R G

« Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 13.124 GBP (treize mille cent vingt-quatre

livres sterling) et est représenté par 13.124 (treize mille cent vingt-quatre) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale
de 1 GBP (une livre sterling).»

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de donner pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement

sous sa seule signature pour le compte de la Société, de procéder aux changements intervenus ci-dessus au montant et à la
devise du capital social ainsi que le nombre de parts sociales dans le registre de parts sociales et d'effectuer toute formalité
y afférente.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence de la présente augmentation de capital sont estimés approximativement à EUR 1.400 (mille quatre cents
euros). Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête du mandataire de ladite partie comparante, et en cas de
divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original

du présent acte.

Signé: A. de Bourcy et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 26 octobre 2015. Relation: 2LAC/2015/23997. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Référence de publication: 2015177487/126.
(150196870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Future Foncia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2111 Luxembourg, 1A, rue de Machault.

R.C.S. Luxembourg B 191.931.

Les comptes annuels du 12/11/2014 au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015177511/10.
(150197472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

A.R.S. Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 93.926.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 14 juillet 2015.

L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs, d'administrateurs-délégués de Messieurs Arthur et René

Schmit, ainsi que du mandat de commissaire aux comptes. Elle décide également d'accepter le remplacement de Madame
Anneliese  Spiegel  par  Monsieur  Mario  Schmit  au  poste  d'administrateur.  Tous  les  mandats  prendront  fin  à  l'issue  de
l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2021.

Sont à nouveau nommés administrateurs:
- Monsieur Arthur Schmit, demeurant à 7, Bohey L - 9647 Doncols, Monsieur René Schmit, demeurant à 19, Bohey

L-9647 Doncols

Démission de son poste d'administrateur:
- Madame Anneliese Spiegel, demeurant à L-9647 Doncols
Nomination au poste d'administrateur:
- Monsieur Mario Schmit, né le 08 juin 1975 à Malmedy (Belgique), demeurant à B-6900 Marche-en-Famenne, 33,

Campagnette.

Sont à nouveau nommés administrateurs-délégués:

120

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Arthur Schmit, demeurant à 7, Bohey L - 9647 Doncols, Monsieur René Schmit, demeurant à 19, Bohey

L-9647 Doncols

Est à nouveau nommée Commissaire aux comptes:
- Monsieur Alain Kohnen, demeurant à 61, Gruuss-Strooss L - 9991 Weiswampach

Doncols, le 14 juillet 2015.

Référence de publication: 2015178866/26.
(150199065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Garfunkelux Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 200.329.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2015.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015177516/14.
(150197532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

GMT Connect S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 176.987.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GMT Connect S.à r.l.
Mandataire

Référence de publication: 2015177533/11.
(150197479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Laguardia Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 93.203.

I. Par résolutions signées en date du 30 juillet 2014, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Gérard Sauthier, avec adresse au 11, rue de la Corraterie, 1204 Genève, Suisse
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social

se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;

2. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes d'Alter Domus Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 5,

rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui
statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015.

II. Par résolutions signées en date du 31 juillet 2015, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
3. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Gérard Sauthier, avec adresse au 11, rue de la Corraterie, 1204 Genève, Suisse pour une période venant à échéance

lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 et
qui se tiendra en 2016;

121

L

U X E M B O U R G

4. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes d'Alter Domus Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 5,

rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui
statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Référence de publication: 2015177645/29.
(150197373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Samera S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 201.120.

STATUTES

In the year two thousand fifteen, on the second of September.
Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

FREO Management Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated

under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6D, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, registrated with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B. 197.103,

here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, with professional address at L-1750 Luxembourg, 74, avenue

Victor Hugo,, by virtue of a proxy given in Senningerberg on 31 

st

 August, 2015.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated herein-above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (”société à responsabilité limitée”), which is hereby incorpo-
rated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (”société à responsabilité limitée”) under the name

“Samera S.à r.l." (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated August 10 

th

 , 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of

association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the
Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means
of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which shall be adopted in the manner
required for the amendment of the Articles.

2.2. Subsidiaries, branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

a resolution of the board of managers of the Company. In the event that the board of managers of the Company determines
that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments
or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communi-
cation  between  such  office  and  persons  abroad,  the  registered  office  may  be  temporarily  transferred  abroad  until  the
complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incor-
porated company.

Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such equity stake. The Company may in particular acquire by
subscription, purchase, and exchange or in any other way any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certi-
ficates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any
public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any com-
pany or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,

122

L

U X E M B O U R G

without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise
create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or the
obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company shall not carry out any regulated activities of the financial
sector.

3.3. The purpose of the Company includes in particular the acquisition, development, promotion, sale, management and/

or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to
immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having as
principal object the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial activities which it may deem useful in accom-

plishment of its purpose.

Art 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600) represented by twelve

thousand six hundred (12,600) shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1,-) each, all subscribed and
fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced on one or more occasions by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. The Company’s shares are indivisible as only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a

sole person as their representative in their dealings with the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior approval

of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. Prior to the transfer of all or part of his shares, any partner must notify such transfer to the Company. The general

meeting of partners may resolve that all or part of the offered shares shall be assigned, according to the terms and conditions
set for the proposed transfer:

a) to the Company, within the limits set forth by the law,
b) to other partner(s), or
c) to a designated third party
6.5. Shareholder may request the Company to redeem all or part of his shares. Any redemption request from a partner

shall be submitted to the prior approval of the general meeting of partners which may resolve that all or part of such shares
shall be assigned:

a) to the Company, within the limits set forth by the law,
b) to other shareholder(s), or
c) to a designated third party.
6.6. All or part of the shares of a shareholder may have to be redeemed by the company if such shares have been

transferred in violation of clause 6.3 or 6.4 above.

6.7. All and any shares redeemed in accordance with clause 6.5 or 6.6 above shall be cancelled forthwith and all rights

attached thereto shall be extinguished.

6.8. A share register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law

and may be examined by each shareholder who so requests.

6.9. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

123

L

U X E M B O U R G

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which set the term of their office. If there are more managers they are classified into class
A managers and class B managers. The manager(s) do not need to be shareholder(s).

7.2. The managers, and each of them, may be dismissed ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or

not, by the manager, or if there is more than one manager, by any manager of category A and any category B manager
acting jointly.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon the call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date set for such meeting, except in the case of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or

represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, or by facsimile or e-mail, of each member of the board
of managers of the Company.

9.4. Any manager of the Company may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another

manager of the Company as his proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members with at least one Category

A Manager is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes
cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented
at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by

any other similar means of communication allowing all persons taking part in the meeting to hear and speak to each other.
The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting. Not-
withstanding the previous sentence, all managers shall be physically present in Luxembourg in order to attend a meeting
of the board of managers at least once a year.

9.7. In lieu of a meeting of the managers, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in

the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or
on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters or by the sole signature of the

sole manager or in case of plurality of managers, by the joint signatures of any category A manager and any category B
manager or by the single or joint signature(s) of any person(s) to whom such signatory power has been validly delegated
in accordance with article 8.2. of these Articles

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate with its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all shareholders in writing, whether in original or by facsimile or e-mail. The

124

L

U X E M B O U R G

shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a
single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3. Notwithstanding article 13.2 of these Articles, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the

Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share
capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and end on the thirty-first

day of December. The first accounting year will end on 31 December 2015.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the board of managers must prepare the balance sheet

and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities, with an annex summarising all of the Company’s commitments and the indebtedness of the managers,
the statutory auditor(s) (if applicable) and shareholders to the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the prior financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and amounts to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders; and
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1 In the event of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of share-
holders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided in the resolution of the shareholder
(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the shareholder or, in the case of multiple shareholders, to the shareholders in proportion to the shares held by each
shareholder of the Company.

VII. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2015.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, FREO Management Holding S.à r.l., named and represented as stated above, declares to subscribe for twelve

thousand six hundred (12,600) shares in registered form, each with a par value of one euro (EUR 1,-), and to fully pay for
such shares by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600), so that such
amount of twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600) is at the disposal of the Company, as has been proved to the
undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-).

125

L

U X E M B O U R G

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety of

the subscribed share capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Erwan LE BERRE, Managing Director, born on November 17 

th

 , 1972 in Bourges, France, with business address

at L-2633 Senningerberg, 6d, route de Trèves, manager of the category A; and

- Mr Robert FABER, private employee, born on May 15 

th

 , 1964 in Luxembourg, residing professionally at 121, avenue

de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, manager of the category B.

2. The registered office of the Company is established at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version and in the case of divergence between the
English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn-up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, said proxyholder signed together with the

notary the present deed.

The German Translation follows

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am zweiten September.
Vor Uns, Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

FREO  Management  Holding  S.à  r.l.,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  (société  à  responsabilité  limitée),

gegründet nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, eingetragen im
Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B. 197.103,

hier vertreten durch Frau Isabel DIAS, Angestellte, mit Berufsadresse in L-1750 Luxemburg, 74, avenue Victor Hugo,

aufgrund von einer Vollmacht die in Senningerberg, am 31. August 2015 ausgestellt wurde.

Diese Vollmacht, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar “ne varietur” unterzeichnet wurde,

bleibt dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung beigebogen.

Welcher Komparent, handelnd wir vorstehend, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung (“société à responsabilité limitée”), die hiermit gegründet wird, wie folgt zu dokumentieren:

Bezeichnung - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Bezeichnung. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (“société à responsabilité limitée”) unter der

Bezeichnung “Samera S.à r.l.” (nachstehend die Gesellschaft) gegründet, die der Luxemburger Gesetzgebung unterliegt,
insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert (nachstehend das Gesetz),
sowie gegenwärtiger Satzung (nachstehend die Satzung).

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Niederanven, im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch einfachen

Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Des wei-
teren kann der Sitz durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß
der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg
verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder

im Ausland durch einen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft errichtet werden. Sollte der Verwaltungsrat der
Gesellschaft beschließen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder
vorauszusehen sind, und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft,
oder die Verbindung derselben mit dem Ausland behindern würden oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann
der Sitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse. Der-
artige provisorische Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz der provisorischen
Sitzverlegung des Gesellschaftssitzes eine Luxemburger Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Der Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in irgendwelcher Form an Luxemburger oder

ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Ge-
sellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, Rentenwerte, Geldmarkteinlagen und andere Schuldtitel aller
Art durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder sonstwie erwerben, und im Allgemeinen alle Wertschriften und Finanzin-
strumente,  die  von  öffentlichen  oder  privaten  Rechtspersönlichkeiten  jeder  Art  ausgegeben  werden.  Sie  kann  an  der
Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht aller Gesellschaften oder Unternehmen teilnehmen. Des Weiteren kann

126

L

U X E M B O U R G

sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Bestands von Patenten oder anderen geistigen Eigentumsrechten jeder Art
oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeder Art aufnehmen, außer auf dem Wege von öffentlichen Angeboten. Sie kann,

jedoch nur durch Privatplatzierung, Schuldscheine, Anleihen und Rentenwerte, sowie jede Art von Schuldtiteln und/oder
Dividendenpapieren ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel verleihen, einschließlich, ohne Begrenzung, die Erlöse
aus Kreditverbindlichkeiten und/oder Emissionen von Schuldoder Dividendenpapieren an ihre Zweigunternehmen, ange-
gliederte Gesellschaften und/oder jede andere Gesellschaft. Die Gesellschaft kann in Bezug auf ihr gesamtes oder teilweises
Vermögen ebenfalls Sicherheiten leisten; sie kann verpfänden, übertragen, belasten oder sonstwie Sicherheiten bestellen
und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und Vereinbarungen und/oder den Verpflichtungen und Vereinbarungen
jeder anderen Gesellschaft nachzukommen, und sie im Allgemeinen zu eigenem Nutzen und/oder zum Nutzen jeder anderen
Gesellschaft  oder  Person  abzusichern.  In  keinem  Fall  wird  die  Gesellschaft  regulierten  Aktivitäten  des  Finanzsektors
nachgehen.

3.3. Der Zweck der Gesellschaft umfasst insbesondere den Erwerb, die Entwicklung, Förderung, Verkauf, Verwaltung

und / oder Vermietung von Immobilien entweder im Großherzogtum Luxembourg oder im Ausland sowie alle Vorgänge
im Zusammenhang mit unbeweglichem Vermögen, einschließlich der direkte oder indirekte Beteiligung von Aktien in
Luxemburg oder ausländischen Gesellschaften, die als Hauptaufgabe der Erwerb, die Entwicklung, Förderung, Verkauf,
Verwaltung und /oder Vermietung von Immobilien.

3.4. Die Gesellschaft darf alle Handels-, Finanz- und Gewerbetätigkeiten, die dazu bestimmt sind, ihren Gesellschafts-

zweck zu fördern oder die sich auf ihren Gesellschaftszweck beziehen.

Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
4.2. Die Gesellschaft kann nicht aufgelöst werden wegen einem Sterbefall, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechts-

unfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder ähnlichen Vorkommnissen, die einen oder mehrere Gesellschafter betreffen.

II. Kapital - Gesellschaftsanteile

Art. 5. Kapital.
5.1.  Das  Kapital  der  Gesellschaft  ist  auf  zwölftausendsechshundert  Euro  (EUR  12.600)  festgelegt  und  besteht  aus

zwölftausendsechshundert (12.600) Namensanteilen mit einem Nennwert je Gesellschaftsanteil von ein Euro (EUR 1,-);
alle Gesellschaftsanteile sind gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann bei einem oder mehreren Anlässen durch einen Beschluss des Alleinge-

sellschafters oder, gegebenenfalls, durch die Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß der Art und Weise, wie sie für
Satzungsänderungen vorgesehen ist, erhöht oder vermindert werden.

Art. 6. Gesellschaftsanteile.
6.1. Jeder Gesellschaftsanteil erteilt dem Besitzer ein Anrecht auf einen Bruchteil der gemeinschaftlichen Vermögens-

werte und Gewinne der Gesellschaft in unmittelbarem Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Gesellschaftsanteile.

6.2. Die Anteile der Gesellschaft sind unteilbar, da je Gesellschaftsanteil nur ein Besitzer anerkannt wird. Gemein-

schaftliche Eigentümer haben eine einzige Person zu ihrem Vertreter für ihre Beziehungen mit der Gesellschaft zu ernennen.

6.3. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern oder, im Falle eines Alleingesellschafters, an Dritte frei übertragbar.

Falls die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat, unterliegt die Übertragung von Anteilen an Nicht-Gesellschafter
der vorherigen Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der
Gesellschaft vertreten.

Eine Anteilsübertragung bindet die Gesellschaft oder Dritte nur infolge einer Mitteilung an die, oder einer Billigung

seitens der Gesellschaft, gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Rechts.

Bezüglich aller anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des Gesetzes hingewiesen.
6.4. Vor der Übertragung der Gesamtheit oder eines Teils seiner Anteile muss jeder Gesellschafter dies der Gesellschaft

mitteilen. Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann beschließen, dass alle oder ein Teil der angebotenen Aktien
zugeteilt werden, gemäß den folgenden Bestimmungen und Bedingungen an,

a) die Gesellschaft unter Berücksichtigung der Einschränkungen durch das Gesetz
b) auf andere Gesellschafter oder
c) an einen bestimmten Dritten
6.5. Der Gesellschafter kann die Rücknahme alle oder einen Teil der seiner Aktien anfragen. Rücknahmeanträge eines

Gesellschafters benötigen die Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter, diese beschließen, dass alle oder
einen Teil der Aktien zugeordnet werden sollen.

a) an die Gesellschaft, unter Berücksichtigung der Einschränkung durch das Gesetz
b) auf andere Gesellschafter oder
c) zu einem bestimmten Dritten

127

L

U X E M B O U R G

6.6. Alle oder einen Teil der Anteile des Gesellschafters kann von der Gesellschaft zurückgenommen werden, wenn

diese Anteile mit Verletzung von Ziffer 6.3 oder 6.4 übertragen wurden.

6.7. Alle Anteile die gemäß Punkt 6.5 oder 6.6 eingelöst wurden können unverzüglich gelöscht werden und alle Rechte

erlöschen.

6.8. Am Sitz der Gesellschaft wird gemäß den Bestimmungen des Gesetzes ein Anteilsregister aufbewahrt, das von

jedem Gesellschafter, der dies verlangt, eingesehen werden kann.

6.9. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

III. Verwaltung - Vertretung

Art. 7. Verwaltungsrat.
7.1. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der aus einem oder mehreren Geschäftsführern zusam-

mengesetzt ist, welche als solche durch einen Beschluss der Gesellschafter, der ihre Amtszeit festlegt, bezeichnet werden.
Falls es mehrere Geschäftsführer gibt sind diese eingeteilt in Kategorie A Geschäftsführer und Kategorie B Geschäftsführer.

Der(die) Geschäftsführer müss(en) kein(e) Gesellschafter sein.
7.2. Die Geschäftsführer, und jeder einzelne von ihnen, können ad nutum vom Amt abgesetzt werden (ohne jeden Grund).

Art. 8. Vollmachten des Verwaltungsrates.
8.1. Alle Vollmachten, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung

der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen unter den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates, der alle Befugnisse hat,
um alle Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu bestätigen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft überein-
stimmen.

8.2. Besondere und begrenzte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten vom alleinigen Geschäftsführer,

oder im Falle von mehreren Geschäftsführern, von einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der
Kategorie B gemeinsam, an einen oder mehrere Vertreter übertragen werden, die keine Gesellschafter zu sein brauchen.

Art. 9. Vorgehensweise.
9.1. Der Verwaltungsrat tritt so oft am Ort, der in den Einberufungsschreiben angegeben ist, zusammen wie die Interessen

der Gesellschaft es verlangen, oder auf Einberufung eines Geschäftsführers.

9.2. Schriftliche Mitteilung über jede Verwaltungsratssitzung ergeht mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem

Tag der Sitzung an alle Geschäftsführer, außer in einem Notfall, in welchem Fall die Art dieser Umstände im Einberu-
fungsschreiben für die Verwaltungsratssitzung anzugeben ist.

9.3. Ein Einberufungsschreiben ist nicht erfordert wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft in einer

Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, über die Sitzung rechtmäßig informiert worden zu sein und die Ta-
gesordnung zu kennen. Es kann von jedem Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft per Brief, Faksimile oder Email
auf das Einberufungsschreiben verzichtet werden.

9.4. Jeder Geschäftsführer der Gesellschaft kann an jeder Verwaltungsratssitzung teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer der Gesellschaft zu seinem Vertreter bestellt.

9.5. Der Verwaltungsrat kann nur gültig tagen und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend sind,

mindestens aber ein Kategorie A Manager vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden gültig mit der Mehrheit
der Stimmen gefasst. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in Protokollen festgehalten, die von allen in der Sitzung
anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet sind.

9.6. Jeder Geschäftsführer kann über Telefon oder Videokonferenz oder durch jedwede andere, ähnliche Kommunika-

tionsmittel an einer Verwaltungsratssitzung teilnehmen, die allen Personen, die an der Sitzung teilnehmen, ermöglichen,
einander zu hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel ist gleich einer per-
sönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Ungeachtet des vorhergehenden Satzes haben alle Geschäftsführer in Luxemburg
mindestens einmal jährlich persönlich anwesend zu sein, um an einer Sitzung des Verwaltungsrates teilzunehmen.

9.7. In Dringlichkeitsfällen sind Zirkularbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind, ebenso gültig

und verbindlich wie Beschlüsse, die in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Sitzung gefasst wurden. Diese
Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Exemplaren eines gleichlautenden Beschlusses
geleistet, und schriftlich oder per Faksimile bescheinigt werden.

Art. 10. Vertretung. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft in allen Angelegenheiten durch die Unterschrift des al-

leinigen  Geschäftsführers  oder  im  Fall  von  mehreren  Geschäftsführern  durch  die  gemeinsame  Unterschrift  eines  Ge-
schäftsführers der A Kategorie und eines Geschäftsführers der B Kategorie oder durch die einzelne oder gemeinsame
Unterschrift  aller  vertretungsbefugten  Personen,  an  die  eine  solche  Zeichnungsvollmacht  gemäß  Abschnitt  8.2.  dieser
Satzung gültig übertragen wurde, rechtlich verpflichtet.

Art. 11. Verpflichtung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind durch ihr Amt nicht persönlich haftbar für Ver-

pflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft gültig eingegangen sind, unter der Bedingung, dass solche Verpflichtungen
in Übereinstimmung mit gegenwärtiger Satzung sowie den anwendbaren Bestimmungen des Gesetzes sind.

128

L

U X E M B O U R G

IV. Hauptversammlungen der Aktionäre

Art. 12. Vollmachten und Stimmrechte.
12.1. Der Alleingesellschafter übernimmt alle Vollmachten, die vom Gesetz der Hauptversammlung der Gesellschafter

übertragen werden.

12.2. Jeder Gesellschafter besitzt Stimmrechte, die im Verhältnis zur Anzahl seiner Anteile stehen.
12.3. Jeder Gesellschafter kann eine natürliche Person oder Rechtspersönlichkeit per Brief, Faksimile oder Email zu

seinem Bevollmächtigten bestellen um ihn bei den Hauptversammlungen der Gesellschafter zu vertreten.

Art. 13. Form - Beschlussfähige Anzahl - Mehrheit.
13.1. Falls die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können ihre Entscheidungen durch

Zirkularbeschluss  gefasst  werden,  dessen  Text  schriftlich,  sei  es  im  Original  oder  über  Faksimile  oder  Email,  an  alle
Gesellschafter geschickt wird. Die Gesellschafter geben ihre Stimme durch Unterzeichnung des Zirkularbeschlusses ab.
Die Unterschriften der Gesellschafter können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Exemplaren eines gleich-
lautenden Beschlusses geleistet werden, und per Brief oder per Faksimile bescheinigt werden.

13.2. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig, wenn sie von Gesellschaftern gefasst werden, die mehr als die Hälfte des

Stammkapitals besitzen.

13.3. Ungeachtet von Artikel 13.2. gegenwärtiger Satzung können Beschlüsse in Bezug auf Abänderungen der Satzung

oder in Bezug auf die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nur mit der Stimmenmehrheit der Gesellschafter, die
mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals der Gesellschaft besitzen, gefasst werden.

V. Jahresabschluss - Gewinnzuteilung

Art. 14. Geschäftsjahr.
14.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

Das erste Geschäftsjahr wird am 31. Dezember 2015 enden.

14.2. In Bezug auf das Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat jedes Jahr die Bilanz und die

Gewinnund Verlustkonten der Gesellschaft, sowie das Inventar, einschließlich der Angabe des Wertes der Aktiva und
Passiva der Gesellschaft, zu erstellen, mit einem Anhang, der alle Verpflichtungen der Gesellschaft zusammenfasst, und
die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer, des oder der Rechnungskommissare (falls anwendbar) und der Gesellschafter
der Gesellschaft zusammenfasst.

14.3. Jeder Gesellschafter kann das obengenannte Inventar und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 15. Gewinnverteilung.
15.1. Der in den Jahreskonten aufgeführte Bruttogewinn der Gesellschaft, nach Abzug der Allgemeinkosten, Tilgungen

und Kosten, stellt den Nettogewinn dar. Ein Betrag gleich fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns der Gesellschaft wird der
gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent (10 %) des Grundkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

15.2. Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann nach freiem Ermessen über den Überschuss verfügen. Insbeson-

dere kann sie den Gewinn zu einer Dividendenzahlung freigeben oder sie der Rücklage zuweisen oder auch als Saldo
vortragen.

15.3. Jederzeit können Zwischendividenden unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Kontenauszug oder ein Inventar oder Bericht wird vom Verwaltungsrat erstellt;
(ii) dieser Kontenauszug, dieses Inventar oder dieser Bericht zeigen, dass genügend Geldmittel zur Ausschüttung zur

Verfügung stehen; wohlverstanden darf der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres
realisierten Gewinne, zuzüglich der vorgetragenen Gewinne und der ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich der vor-
getragenen Verluste und der Beträge, die der gesetzlichen Rücklage zuzuführen sind, nicht übersteigen;

(iii) die Entscheidung zur Zahlung von Zwischendividenden wird vom einzigen Gesellschafter oder von der Hauptver-

sammlung der Gesellschafter getroffen, und

(iv) eine Zusicherung wurde gegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht gefährdet sind.

VI. Auflösung - Liquidation

16.1. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt,

die keine Gesellschafter zu sein brauchen, und die durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Hauptver-
sammlung der Gesellschafter ernannt werden, die ihre Vollmachten und Vergütung bestimmt. Falls in dem Beschluss des
oder der Gesellschafter, oder durch ein Gesetz, nichts Anderes vorgesehen ist, sind die Liquidatoren mit den weitgehendsten
Vollmachten für die Realisierung der Vermögenswerte und die Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft versehen.

16.2. Der Überschuss aus der Realisierung der Vermögenswerte und Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft wird

an den Gesellschafter gezahlt oder, im Falle mehrerer Gesellschafter, an die Gesellschafter im Verhältnis zu der Anzahl
der Anteile, die sie in der Gesellschaft besitzen.

129

L

U X E M B O U R G

VII. Allgemeine Bestimmung

17. Es wird auf die Bestimmungen des Gesetzes in Bezug auf alle Angelegenheiten verwiesen, die nicht ausdrücklich

in gegenwärtiger Satzung aufgeführt werden.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag dieser Urkunde und endet am 31. Dezember 2015.

<i>Zeichnung - Zahlung

Daraufhin erklärt FREO Management Holding S.à r.l., vorgenannt und vertreten wie vorstehend angegeben, zwölftau-

sendsechshundert (12.600) Gesellschaftsanteile in Namensform zu zeichnen, jede mit einem Nennwert von ein Euro (EUR
1,-), und diese Gesellschaftsanteile vollständig durch Barzahlung mit einem Betrag von zwölftausendsechshundert Euro
(EUR 12.600) einzuzahlen, so dass der genannte Betrag von zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600) somit zur
Verfügung der Gesellschaft steht, wie dem unterzeichneten Notar bescheinigt wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Auslagen jeder Art, die von der Gesellschaft aus Gründen ihrer Gründung zu

tragen sind, werden auf ungefähr eintausendvierhundert Euro (EUR 1.400.-) geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleingesellschafter der Gesellschaft, der das gesamte gezeichnete

Stammkapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
- Herr Erwan LE BERRE, Manager, geboren am 17. November 1972 in Bourges, (Frankreich), geschäftsansässig in

L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, Geschäftsführer der Kategorie A; und

- Herr Robert FABER, Privatangestellter, geboren 15. Mai 1964 in Luxemburg, geschäftsansässig in L-1511 Luxem-

bourg, 121 Avenue de la Faiencerie, Geschäftsführer der Kategorie B.

2. Der Sitz der Gesellschaft ist L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Antrag des vorste-

henden Komparenten gegenwärtige Urkunde auf Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer Fassung in deutscher Sprache,
und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung überwiegt.

WORÜBER, Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.
Und nach Verlesung an die Bevollmächtigte des Komparenten hat diese zusammen mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde

unterzeichnet.

Signé: M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 16 septembre 2015. Relation: 2LAC/2015/20698. Reçu soixante-quinze

euros Eur 75.-.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Référence de publication: 2015178720/466.
(150198613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Invista European RE Lutterberg PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 112.735.

<i>Extrait des résolutions prises par les gérants de la Société en date du 29 Septembre 2015

Les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 25C Boulevard Royal, L-2449 Lu-

xembourg, au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 Octobre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015177581/13.
(150197569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

130

L

U X E M B O U R G

Invista European RE Marseille PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 112.739.

<i>Extrait des résolutions prises par les gérants de la Société en date du 29 Septembre 2015

Les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 25C Boulevard Royal, L-2449 Lu-

xembourg, au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 Octobre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015177582/13.
(150197543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Janili S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 199.808.

<i>I. Transfert de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé et effectif en date du 14 octobre 2015, que l'associé de la

Société, AIM Services S.à r.l. a transféré la totalité des 12.500 parts sociales qu'il détenait dans la Société de la manière
suivante:

- 6.375 parts sociales à Tyrolese (789) Ltd., une Priva te limited Company, constituée et régie selon les lois du Royaume-

Uni, immatriculée auprès du Companies House sous le numéro 9348093, ayant son siège social à l'adresse suivante: 66
Lincoln's Inn Fields, WC2A 3LH Londres, Royaume-Uni;

- 6.125 parts sociales à Promethean UK Opportunities Fund II, L.P., une Limited Partnership, constituée et régie selon

les lois du Royaume-Uni, immatriculée auprès du Companies House sous le numéro LP 15672, ayant son siège social à
l'adresse suivante: c/o Shelley Stock Hutter LLP, 7-10 Chandos Street, W1 G 90Q Londres, Royaume-Uni.

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

Tyrolese (789) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.375 parts sociales
Promethean UK Opportunities Fund II, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.125 parts sociales

<i>II. Extrait des résolutions écrites prises par les associés de la Société en date du 14 octobre 2015

En date du 14 octobre 2015, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Olivier HAMOU de son mandat de gérant de la Société avec effet au 14 octobre

2015;

- de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet au 14 octobre 2015 et ce pour

une durée indéterminée:

* Monsieur Michael BURT, né le 1 

er

 janvier 1975 à Edimbourg, Royaume-Uni, ayant comme adresse professionnelle

la suivante: 7-10, Chandos Street, W1 G 9DQ Londres, Royaume-Uni;

* Monsieur Mark CLARKE, né le 14 avril 1964 à Whittlesey, Royaume-Uni, ayant comme adresse professionnelle la

suivante: 11, Lennox Gardens Mews, SW1X ODP Londres, Royaume-Uni.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Michael BURT, gérant
- Monsieur Mark CLARKE, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Janili S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2015177609/38.
(150197586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

131

L

U X E M B O U R G

L.M.I. Reconstruction Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 59a, Kohlenberg.

R.C.S. Luxembourg B 126.543.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions du gérant unique prises en date du 29/10/2015

Transfert de siège social

Le gérant unique décide de transférer avec effet au 1 

er

 novembre 2015, le siège social de la société de L-1320 Luxem-

bourg, 90, route de Cessange à L-1870 Luxembourg, 59a Kohlenberg

Mise à jour adresse du gérant unique
Il est à noter que l'adresse du gérant unique est L-1870 Luxembourg, 59a Kohlenberg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015177631/15.
(150196315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Golden Gate S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 51.143.

L'an deux mille quinze, le six octobre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «GOLDEN GATE S.A.», ayant son siège

social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 51 143, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg, le 9 mai 1995, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 397 du 19 août 1995, et dont les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 juillet 2015, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2216 du 19 octobre 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Madame Solange Wolter-Schieres, clerc

de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les TRENTE-DEUX MILLE (32.000) actions nominatives, repré-

sentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou
représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur
a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Décision de prononcer la dissolution de la Société
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la Société.

3.- Décharge au Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1 

er

 janvier 2015

jusqu'à la date de la mise en liquidation.

4.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de ses ou leurs pouvoirs.
L'assemblée ayant entendu l'ordre du jour, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la Société.

132

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'assemblée prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux comptes

actuellement en fonction pour la période du 1 

er

 janvier 2015 jusqu'au jour de la présente assemblée.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer liquidateur:
Monsieur Guido BANHOLZER, demeurant professionnellement à Stampfenbachstrasse 138, CH-8006 Zurich.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas

où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instru-

mentant le présent procès-verbal.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 14 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/32724. Reçu douze euros (12.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Référence de publication: 2015177534/66.
(150197078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

CBRE Global Investment Partners Fund Series S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 156.904.

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance du public que l'actionnaire unique de la Société a pris note de la démission de Monsieur

Stuart Savidge de ses fonctions de gérant de catégorie B, de la Société à partir du 23 Octobre 2015.

Il résulte d'une des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société, de nommer pour une durée illimitée, Monsieur

Paul Mundell, résidant britannique né le 7 juin 1977 à Bishop Auckland au Royaume-Uni et résident professionnellement
au troisième étage du One New Change, Londres EC4M 9AF, Royaume-Uni, au mandat de gérant de catégorie B de la
Société et ce à partir du 15 Octobre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 novembre 2015.

Référence de publication: 2015178178/17.
(150198213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Invista European RE Monbonnot HoldCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.078.055,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 119.879.

<i>Extrait des résolutions prises par les gérants de la Société, en date du 29 Septembre 2015

Les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 25C Boulevard Royal, L-2449 Lu-

xembourg, au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 Octobre 2015.

133

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015177583/13.
(150197617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Medtronic Ardian Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 158.983.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 1 

er

 octobre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (remplaçant la 1 

ère

 version

dont le numéro de dépôt initial est L150186888).

Beringen, le 14 octobre 2015.

Maître Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015177680/14.
(150197638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Orchis Inwest SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 201.084.

<i>Extrait du 27 octobre 2015 de la convention de société en commandite (la «convention») de Orchis Inwest SCSp, société

<i>en commandite spéciale.

1. Associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux. WMBS Inwest S.à.r.l.,

ayant son siège social au 25A, boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg («l'associé com-
mandité»). L'associé commandité a été constitué le 11.06.2015 en tant que société à responsabilité limitée («S.à.r.l.»), régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée de temps en temps (ci-après la «loi de 1915»), et a été enregistré sous le numéro B197965 auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (ci-après le «RCSL»).

2. Dénomination sociale, objet social, siège social, exercice.
(I) Dénomination sociale
La société en commandite spéciale aura le nom: «Orchis Inwest SCSp» (ci-après la «Société»).
(ii) Objet social
L'objet social de la Société est (i) la prise de participation sous forme d'intérêts et des droits de toute nature dans des

entités luxembourgeoises ou étrangères et/ ou sous forme d'autres arrangements et dans toute autre forme d'investissement,
(ii) l'acquisition par achat, souscription ou autre, ainsi que le transfert par vente, échange, ou autre, des titres de toute nature.

(iii) Siège social
La société demeure à 25A, boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
(iv) Exercice
L'exercice social de la société coïncide à l'année calendrier.

3. Nomination du gérant et de pouvoirs de signature. L'associé commandité est investi des pouvoirs les plus étendus

pour administrer et gérer la SCSp, conformément à la présente convention de société en commandite et aux lois en vigueur
au Grand-Duché de Luxembourg.

Dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente, l'associé commandité doit indiquer qu'il agit au nom de la

SCSp, et tous les actions entamés ci-après par l'associé commandité seront réputées être à ce titre, sauf indication contraire.

L'associé commandité a le pouvoir exclusif d'entamer toutes les décisions à l'égard de la SCSp, à condition qu'un tel

pouvoir  n'a  pas  été  délégué  ou  attribué  à  une  autre  entité  ou  prestataire  de  services  qui  seront  responsables  que  pour
l'exécution de leur mandat, conformément à la convention présente et à la Loi de 1915, en particulier la «sous-section 2. -
sociétés en commandite spéciale» de la Loi de 1915.

4. Date de commencement et durée de la société. La société est établie à partir du 27 octobre 2015, pour une durée

indéterminée.

Référence de publication: 2015177745/37.
(150197557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

134

L

U X E M B O U R G

ParisInvest III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 139.493.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Référence de publication: 2015177768/10.
(150197092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Afton Chemical EA Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 189.217.

In the year two thousand and fifteen, on the ninth day of October,
Before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Afton Chemical UK LLP, a limited liability partnership existing under the laws of England and Wales, whose registered

office is at London Road, Bracknell, Berkshire, RG12 2UW, England and registered with the Companies House under
number OC397050 (the “Sole Member”),

here represented by Ms Betty Kizimalé-Grant, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on October 7, 2015.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole member of Afton Chemical EA Holdings S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a private

limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B189217, incorporated pur-
suant to a deed of the undersigned notary dated 30 July 2014 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations on 6 October 2014 number 2751. The articles of association of the Company have been amended for the last
time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 31 October 2014 and published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations on 5 December 2014 number 3746.

The appearing party representing the entire share capital of the Company, requests the undersigned notary to act that

the agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of twenty thousand US dollar (USD 20,000) so as to

increase it from its current amount of forty thousand US dollar (USD 40,000.-) up to sixty thousand US dollar (USD 60,000)
through the issue of twenty thousand (20,000) new shares, each having a nominal value of one US dollar (USD 1.-), by
way of a contribution in kind;

2. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company; and
3. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the Sole Member takes, and requires the undersigned notary to enact,

the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Member decides to increase the Company's share capital by an amount of twenty thousand US dollar (USD

20,000) so as to increase it from its current amount of forty thousand US dollar (USD 40,000.-) up to sixty thousand US
dollar (USD 60,000) through the issue of twenty thousand (20,000) new shares, each having a nominal value of one US
dollar (USD 1.-).

The twenty thousand (20,000) new shares issued have been entirely subscribed by the Sole Member for the amount of

seven hundred and three million, two hundred sixty-two thousand, four hundred U.S. Dollar (USD 703,262,400).

The shares so subscribed by the Sole Member have been fully paid up by a contribution in kind having an aggregate

value of seven hundred and three million, two hundred sixty-two thousand, four hundred U.S. Dollar (USD 703,262,400)
and consisting of (i) ninety-three million five hundred thirteen thousand one hundred seventy-five (93,513,175) ordinary
shares having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each issued by Afton Chemical UK Holdings Limited, a
private company limited by shares existing under the laws of England and Wales, having its registered office at London
Road, Bracknell, Berkshire, RG12 2UW, England and registered with the Companies House under number 07119870

135

L

U X E M B O U R G

(“ACUKH”), and (ii) certain receivables amounting to ninety-two million, four hundred sixty-three thousand, eight hundred
seventy-six Pounds Sterling (GBP 92,463,876) in aggregate.

Proof of the existence and the aggregate value of the above-mentioned contribution have been produced to the under-

signed notary by certificate of valuation issued by the managers of the Company on October 8, 2015.

The contribution amounts to seven hundred and three million, two hundred sixty-two thousand, four hundred U.S. Dollar

(USD 703,262,400) out of which an amount of twenty thousand US dollar (USD 20,000) shall be allocated to the share
capital of the Company and an amount of seven hundred and three million, two hundred forty-two thousand, four hundred
U.S. Dollar (USD 703,242,400) shall be allocated to the share premium of the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Member decides to amend article 5.1 of the articles of association

of the Company which shall be enforced and now read as follows:

“ 5.1. The Company's share capital is set at sixty thousand US dollar (USD 60,000), represented by sixty thousand

(60,000) shares with a nominal value of one US dollar (USD 1) each.”.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at six thousand five hundred euro (EUR 6,500).

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the

appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same proxyholder
and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and

residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le neuvième jour du mois d'octobre.
Par devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Afton Chemical UK LLP, une limited liability partnership existante selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles,

ayant son siège social à London Road, Bracknell, Berkshire, RG12 2UW, Angleterre et immatriculée auprès de Companies
House sous le numéro OC397050 (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Madame Betty Kizimalé-Grant, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 7 octobre 2015.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'associé unique de Afton Chemical EA Holdings S.à r.l. (ci-après la “Société”), une société à res-

ponsabilité limitée, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B189217, constituée selon un acte du notaire soussigné en
date du 30 juillet 2014 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 6 octobre 2014 numéro 2751. Les
statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 31 octobre 2014 et
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 5 décembre 2014 numéro 3746.

La comparante représentant l'intégralité du capital social de la Société requiert le notaire soussigné de prendre acte que

l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000) pour le

porter de son montant actuel de quarante mille dollars américains (USD 40.000) à soixante mille dollars américains (USD
60.000), par l'émission de vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD
1) chacune, par le biais d'un apport en nature.

2. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société; et
3. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'Associé Unique adopte, et requiert le notaire

instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de vingt mille dollars américains (USD

20.000) pour le porter de son montant actuel de quarante mille dollars américains (USD 40.000) à soixante mille dollars

136

L

U X E M B O U R G

américains (USD 60.000), par l'émission de vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1) chacune.

Les vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par l'Associé Unique pour le montant

de sept cent trois millions deux cent soixante-deux mille quatre cents dollars américains (USD 703.262.400).

Les parts sociales ainsi souscrites par l'Associé Unique ont été intégralement payées par un apport en nature d'une valeur

totale de sept cent trois millions deux cent soixante-deux mille quatre cents dollars américains (USD 703.262.400) con-
sistant en (i) quatre-vingt-treize millions cinq cent treize mille cent soixante-quinze (93.513.175) actions ordinaires ayant
une valeur nominale d'une livre sterling chacune (GBP 1) émises par Afton Chemical UK Holdings Limited, une société
à responsabilité limitée existante selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à London Road,
Bracknell, Berkshire, RG12 2UW, Angleterre et immatriculée auprès de Companies House sous le numéro 07119870
(“ACUKH”), et (ii) certaines créances d'un montant total de quatre-vingt-douze millions quatre cent soixante-trois mille
huit cent soixante-seize livres sterling (GBP 92.463.876).

La preuve de l'existence et la valeur totale de l'apport susmentionné a été fournie au notaire soussigné par un certificat

d'évaluation émis par les gérants de la Société en date du 8 octobre 2015.

L'apport  global  s'élève  à  un  montant  de  sept  cent  trois  millions  deux  cent  soixante-deux  mille  quatre  cents  dollars

américains (USD 703.262.400), duquel un montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000) est affecté au capital
social  et  un  montant  de  sept  cent  trois  millions  deux  cent  quarante-deux  mille  quatre  cents  dollars  américains  (USD
703.242.400) est alloué à la prime d'émission.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société

qui aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à soixante mille dollars américains (USD 60.000), représenté par soixante

mille (60.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune.».

<i>Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est

évalué à environ six mille cinq cents euros (EUR 6.500).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande du mandataire de la comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande du même mandataire et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Kizimalé-Grant, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 14 octobre 2015. GAC/2015/8711. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. PIERRET.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 29 octobre 2015.

Référence de publication: 2015178002/138.
(150198198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

GOPERF, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 201.079.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt-deux octobre.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signé;

ONT COMPARU:

1) La société anonyme de droit luxembourgeois “SOCIETE FINANCIERE DES DEVELOPPEMENTS ET DES RE-

CHERCHES”, en abrégé “SOFIDER S.A.”, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 43, Boulevard Prince
Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 24699,

ici dûment représentée par un de ses administrateurs Monsieur Gilles COURREGE, qualifié ci-après;
2) Madame Catherine COURREGE, avocat, née à Lima (Pérou), le 12 août 1986, demeurant à L-2163 Luxembourg,

41, Avenue Monterey; et

137

L

U X E M B O U R G

3) Monsieur Gilles COURREGE, entrepreneur-dirigeant, né à Toulouse (France), le 8 octobre 1940, demeurant à L-2163

Luxembourg, 41, Avenue Monterey.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire d'arrêter comme suit les statuts

d'une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et les présents statuts.

Titre I 

er

 . Forme - Dénomination - Durée - Siège - Objet

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous le nom de “GOPERF” (ci-après la

“Société”) qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

générale des associés.

L'adresse du siège social peut-être déplacé à l'intérieure de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des succursales et des bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 4. La Société a pour objet l'activité d'entrepreneur de travail intérimaire.
La  Société  peut  effectuer  toutes  prestations  de  services  et  de  conseils  en  matière  de  management  et  de  ressources

humaines envers les sociétés du groupe - qu'il s'agisse de participations directes ou indirectes - ou envers des sociétés
tierces.

La Société pourra prendre des intérêts et des participations dans toutes sociétés commerciales, industrielles, artisanales,

financières, mobilières, immobilières.

La Société a aussi pour objet les activités d'une société de financement de groupe, et, en tant que telle, la fourniture de

tout type d'assistance financière à des sociétés du groupe.

La Société peut exercer toutes activités se rapportant à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, et la liquidation d'un

patrimoine mobilier et immobilier; elle peut notamment employer ses fonds à l'achat, la vente, l'échange, la location, la
transformation, l'aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits et biens mobiliers et im-
mobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son compte que pour le compte
d'autrui.

En outre elle peut réaliser toutes transactions, entreprises et opérations commerciales, industrielles et financières, mo-

bilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet et effectuer toutes opérations susceptibles
de favoriser directement ou indirectement son extension ou son développement; elle peut contracter des emprunts de toute
sorte et procéder à l'émission d'obligations et de titres de créance, sauf par voie d'émission publique et elle peut investir
dans l'acquisition de marques, brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit.

La Société pourra contracter des emprunts de toute sorte et procéder à l'émission d'obligations et de titres de créance,

sauf par voie d'émission publique et pourra également et accessoirement acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier
tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par cinq mille (5.000) parts

sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Art. 6. Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l'entièreté des associés

de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Sauf stipulation contraire contenue dans la loi, les décisions de l'assemblée générale dûment convoquée seront prises à

la majorité simple des présents et votants.

Le capital et d'autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être changés par l'associé unique ou par

la majorité des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital. Les associés peuvent changer la nationalité de
la Société par une décision unanime.

Si tous les associés sont présents ou représentés et s'ils confirment qu'ils ont été dûment informés de l'agenda de l'as-

semblée, l'assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 7. Chaque part donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La Société reconnaît une seule personne par part; si une part est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme en étant
le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif social et des bénéfices de la Société proportionnelle au nombre

des parts existantes.

138

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale.
Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine de l'alinéa 1 

er

 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies

par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal

ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 9. Si la Société compte au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas

fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayant droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les

biens et documents de la Société.

Titre III. Administration

Art. 12. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas être nécessairement associé de la Société.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Les gérants sont désignés et révoqués par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs, rémunération

et durée des mandats.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la signature individuelle d'un gérant.

Art. 14. Dans l'exécution de leur mandant, les gérants ne sont pas responsables personnellement des engagements de la

Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

Art. 15. L'année sociale commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. A la fin de chaque exercice, le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare les comptes

annuels qui sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction

cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'assemblée générale des associés, sur recommandation du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de

gérance, déterminera l'affectation des bénéfices nets annuels.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. des comptes intérimaires sont établis par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance,
2. ces comptes font apparaître un bénéfice y inclus les bénéfices reportés,
3. la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,
4. le paiement est effectué lorsque la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont pas

menacés.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être

des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des associés décidant de la dissolution
et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Art. 18. Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec la

loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2016.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cinq mille (5.000) parts sociales ont été souscrites par les associés,

à savoir:

- trois mille (3.000) parts souscrites et libérées entièrement moyennant un versement en numéraire de trente mille euros

(30.000,- EUR) par la société “SOCIETE FINANCIERE DES DEVELOPPEMENTS ET DES RECHERCHES”, en abrégé
“SOFIDER S.A.”, pré-désignée et représentée comme dit ci-avant;

- cinq cents (500) parts souscrites et libérées entièrement moyennant un versement en numéraire de cinq mille euros

(5.000,- EUR) par Madame Catherine COURREGE, pré-qualifiée;

- mille cinq cents (1.500) parts souscrites et libérées entièrement moyennant un versement en numéraire de quinze mille

euros (15.000,- EUR) par Monsieur Gilles COURREGE, pré-qualifié.

139

L

U X E M B O U R G

La totalité de la souscription, soit cinquante mille euros (50.000,- EUR), se trouve dès-à-présent à la libre disposition

de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la

loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

<i>Evaluation - Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de mille euros.

<i>Résolutions des associés

Les associés représentant l'intégralité du capital social souscrit ont pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé à L-1724 Luxembourg, 43, Boulevard Prince Henri.
2. Le nombre de gérants est fixé à 2 (deux).
3. Sont nommés gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Gilles COURREGE, entrepreneur-dirigeant, né à Toulouse (France), le 8 octobre 1940, demeurant à L-2163

Luxembourg, 41, Avenue Monterey, avec pouvoir d'engager valablement la Société par sa seule signature;

- Madame Catherine COURREGE, avocat, née à Lima (Pérou), le 12 août 1986, demeurant à L-2163 Luxembourg, 41,

Avenue Monterey, avec pouvoir d'engager valablement la Société par sa seule signature.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire par leur nom, prénom,

état civil et domicile, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. COURREGE, G. COURREGE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 27 octobre 2015. 2LAC/2015/24062. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Référence de publication: 2015177535/148.
(150197239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Medtronic Advanced Energy Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 164.592.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 1 

er

 octobre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (remplaçant la 1 

ère

 version

dont le numéro de dépôt initial est L150187023).

Beringen, le 14 octobre 2015.

Maître Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015177679/14.
(150197640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 79.540.

Par lettre datée du 21 octobre 2015, Monsieur Sven Olbrechts a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société

avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A.

Référence de publication: 2015177545/11.
(150197604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

140

L

U X E M B O U R G

Highgreen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 191.690.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales conclu en date du 30 octobre 2015, que M. Pierre Metzler, avocat à

la Cour, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, a cédé douze mille cinq
cents  (12.500)  parts  sociales  de  la  Société  représentant  la  totalité  du  capital  social  de  la  Société  à  la  société  STENA
Investment S.à r.l., ayant son siège social au 26B Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B112140.

La société STENA Investment S.à r.l. devient donc l'associé unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015177546/15.
(150197660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Hesperides Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 145.919.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 30 octobre 2015, que le conseil

a décidé de mettre fin au mandat de dépositaire des actions au porteur de Monsieur Christophe Antinori.

Le  conseil  d'administration  a  décidé  de  nommer  en  tant  que  nouveau  dépositaire  des  actions  au  porteur,  la  société

anonyme INITIUM CORPORATE SERVICES S.A., établie et ayant son siège social à L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean
l'Aveugle, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 152940.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015177549/15.
(150197701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Hyrule S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 24.500.000,00.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 188.042.

Il résulte d'une lettre adressée à la société la démission de Monsieur Romain GRAU, à la date du 3 juillet 2015, en tant

que gérant de catégorie B de la société HYRULE SARL.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un gérant

Référence de publication: 2015177560/13.
(150196890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

I.R.D.V. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 2, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 161.972.

Monsieur Jean-Christophe LANGLAIS, gérant et associé de la société I.R.D.V. SARL, a actuellement son adresse au

2, avenue Guillaume L-1650 Luxembourg

Pour avis sincère et conforme

Référence de publication: 2015177563/10.
(150197461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

141

L

U X E M B O U R G

Brass Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 183.411.

EXTRAIT

I/ Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 14 octobre 2015 que la personne suivante a démissionné,

avec effet au 1 

er

 septembre 2015, de sa fonction de gérant de catégorie A de la Société:

- Monsieur François le Cocq, né le 26 septembre 1963 à Savigny-sur-Orge, France, ayant son adresse professionnelle

à Tour Coupole, 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, France.

II/ Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a démissionné, avec effet au 15 octobre 2015, de

sa fonction de gérant de catégorie A de la Société:

- Monsieur Yves Cerf-Mayer, né le 13 février 1952 à Saigon, Vietnam, ayant son adresse professionnelle à Tour Coupole,

2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, France.

III/ Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet au 1 

er

 septembre 2015,

et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de catégorie A de la Société:

- Monsieur Philippe Daniel, né le 20 mai 1968 à Marseille, France, ayant son adresse professionnelle à Tour Coupole,

2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, France.

IV/ Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet au 15 octobre 2015, et

pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de catégorie A de la Société:

- Monsieur Oliver Matschke, né le 9 juillet 1963 à Frankfurt am Main, Allemagne, ayant son adresse professionnelle à

Tour Coupole, 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, France.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

<i>Gérants de catégorie A

- Monsieur Emmanuel Chapon, né le 23 janvier 1976 à Rouen, France, ayant son adresse professionnelle à Tour Coupole,

2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, France.

- Monsieur Maurice Guy, né le 15 février 1957 à Marseille, France, ayant son adresse professionnelle à Tour Coupole,

2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, France.

- Monsieur Philippe Daniel, prénommé,
- Monsieur Oliver Matschke, prénommé.

<i>Gérant de catégorie B

- Monsieur Frédéric Santoni, né le 18 avril 1967 à Paris, France, ayant son adresse professionnelle au 310, route d'Esch,

L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 2 novembre 2015.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2015178094/44.
(150198098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

VAP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5535 Remich, 4, Impasse Saint François.

R.C.S. Luxembourg B 201.132.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le seize octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

142

L

U X E M B O U R G

Monsieur Abderahim BOUMAAZA, gérant, né le 28 juin 1986 à Metz (France), demeurant à L-5535 Remich, 4, Impasse

Saint François.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsa-

bilité limitée qu'elle constitue:

Titre I 

er

 . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que

par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de «VAP S.à r.l.».

Art. 3. La société a pour objet la prestation de services administratifs en général, non spécialement réglementés ainsi

que la mise en relation commerciale de particuliers en tant qu'intermédiaire.

La société a également pour objet toutes activités commerciales, en accord avec les dispositions de la loi du 9 juillet

2004,  modifiant  la  loi  modifiée  du  28  décembre  1988  concernant  le  droit  d'établissement  et  réglementant  l’accès  aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu'à certaines professions libérales

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution

pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement

ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Remich.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de

tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat
des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par

l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter
aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal

ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

143

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci

ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés les cent (100) des parts sociales ont été souscrites par Monsieur Abderahim

BOUMAAZA, prénommé et toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme
de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou

qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-5535 Remich, 4, Impasse Saint François.
2.- Le nombre de gérants est fixé à deux.
Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Abderahim BOUMAAZA, gérant, né le 28 juin 1986 à Metz (France), demeurant à L-5535 Remich, 4,

Impasse Saint François.

- Madame Lilia BENZAAZA, épouse BOUMAAZA, gérante, née le 10 octobre 1988 à Metz (France), demeurant à

L-5535 Remich, 4, Impasse Saint François.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Abderahim BOUMAAZA, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 26 octobre 2015. Relation GAC/2015/9061. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2015178824/108.
(150198796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

144


Document Outline

Afton Chemical EA Holdings S.à r.l.

A.R.S. Immobilière S.A.

Brass Holdings S.à r.l.

Carre Invest S.A. SPF

CBRE Global Investment Partners Fund Series S.à r.l.

Finnery Acquisitions III S.à r.l.

Future Foncia S.A.

Garfunkelux Invest S.à r.l.

GMT Connect S.à r.l.

Golden Gate S.A.

GOPERF

Harry &amp; Cie

Hesperides Equity S.A.

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A.

Highgreen S.à r.l.

Hyrule S.à r.l.

Invista European RE Lutterberg PropCo S.à r.l.

Invista European RE Marseille PropCo S.à r.l.

Invista European RE Monbonnot HoldCo 1 S.à r.l.

I.R.D.V. S.à r.l.

Janili S.à r.l.

La Choral Notre Dame de Fatima A.s.b.l.

Laguardia Capital S.A.

L.M.I. Reconstruction Luxembourg

Medtronic Advanced Energy Luxembourg S.à r.l.

Medtronic Ardian Luxembourg S.à r.l.

Orchis Inwest SCSp

ParisInvest III S.A.

Samera S.à r.l.

Tulpen S.à r.l.

VAP S.à r.l.

ZAB Invest Co. S.à r.l.