This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3357
16 décembre 2015
SOMMAIRE
AG.IR S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161119
Argentarius Securisation Fund Management
S.a.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161090
Arran Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
161091
AZ Electronic Materials S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .
161126
BIM Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161127
BJR International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161129
BL Immo Franchising, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
161129
Blue Moon Consult S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
161121
BMS Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161123
Bone & Joint Research S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
161123
CarVal GCF Lux Sub Holdings S.à r.l. . . . . . .
161127
Casino Developpement Europe Sàrl . . . . . . . .
161097
Charleston Infrastructure III S.à r.l. . . . . . . . .
161124
China Fortune Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161097
Choeur de Chambre de Luxembourg . . . . . . .
161123
Chopin Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161129
Daniel Frères Immobilière S.à.r.l. . . . . . . . . . .
161101
Digital Services XLI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
161101
DRD S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161118
Euro Growth Investment S.A. . . . . . . . . . . . . .
161119
Evergreen Real Estate Partners Europe S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161130
Inside Project Management S.à r.l. . . . . . . . . .
161120
Investindustrial Development S.A. . . . . . . . . .
161136
Investindustrial Development S.A. . . . . . . . . .
161136
Investindustrial Industries S.A. . . . . . . . . . . . .
161136
LuxCap Taunus GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161120
Meigerhorn Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
161121
Philippines Internet Holding S.à r.l. . . . . . . . .
161101
Target, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161122
Telindus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161126
Thomas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161126
Thomas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161132
Thomas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161133
Thomas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161136
TNN Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161124
TransAtlantic Partner S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
161122
Transport Pinto & Silva S. à r.l. . . . . . . . . . . .
161124
Transwave S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161122
Tyco Electronics Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . .
161122
Vermillion Aviation Finance S.à r.l. . . . . . . . .
161133
Victoriosa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161091
Vocatus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161090
161089
L
U X E M B O U R G
Argentarius Securisation Fund Management S.a.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 180.434.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 29 septembre 2013, que l'associé unique de la Société, M.
Andreas Wölfl, 53, Lagerstraße, A-2441 Mitterndorf an der Fischa, a transféré 125 parts sociales qu'il détenait dans la
Société à:
Argentarius Securitisation Holding Establishment, une Anstalt, constituée et régie selon les lois de Liechtenstein, im-
matriculée auprès du Liechtenstein Handelsregister sous le numéro FL-0002.464.557-5, ayant son siège social à l'adresse
suivant: Austrasse 13, 9490 Vaduz, Liechtenstein.
Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:
Argentarius Securitisation Holding Establishment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2015.
Argentarius Securisation Fund Management S.a.r.l.
MMS Mercury Management Services S.A.
Götz SCHÖBEL
Référence de publication: 2015170885/21.
(150189624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
Vocatus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 137.157.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'an deux mille quinze, le 19/10/2015
S’est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «VOCATUS S.à r.l.», ayant son
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 30 Janvier 2008,
La société a été mise en liquidation suivant acte notarié du 22 Septembre 2015.
L'Assemblée se compose de:
1) Monsieur Roland RUF, représentés par procuration
2) Monsieur Wolfgang RUF, représentés par procuration
Ensuite les associés représentant l'intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
I. - L’Assemblée prend connaissance du rapport du liquidateur et approuve celui-ci.
II. - L'assemblée entend le rapport de Monsieur Gérard Reis sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion
du liquidateur.
Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et
entière, sans réserve ni restriction, à Monsieur Emile Wirtz, de sa gestion de liquidateur de la Société.
L'assemblée donne également décharge au commissaire-vérificateur pour l'exécution de son mandat.
III. - Clôture de la liquidation:
L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société VOCATUS S.à r.l. a définitivement cessé
d'exister.
L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à
partir d’aujourd'hui à 6, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
VOCATUS SARL
Signature
Référence de publication: 2015172200/33.
(150190529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
161090
L
U X E M B O U R G
Arran Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 180.232.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte des résolutions de l'associé unique (ci-après l'«Associé Unique») prises en date du 2 octobre 2015 que:
1. L'Associé Unique a décidé la clôture de la liquidation de la Société;
2. Les livres et documents sociaux de la Société resteront déposés et conservés pendant cinq ans au siège social de la
Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2015.
Pour avis sincère et conforme
Référence de publication: 2015170887/16.
(150190176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
Victoriosa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 200.813.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the eighth day of October.
Before us Maître Henri HELLINCKX notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
- Mr Carlo SAGRAMOSO, born in Milan (IT) on 17 July 1960, residing professionally in Via G. Bagutti 5 - CH-6900
Lugano - Switzerland,
here represented by Mr François Leynen, residing professionally in 106 Route d’Arlon, L-8210 Mamer - Grand-Duchy
of Luxembourg
by virtue of a proxy dated June 10, 2015 which will remain annexed to the present deed.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has decided to form a company in accordance with the following
Articles of Incorporation:
Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of “Victoriosa S.A.”
The registered office is established in Mamer.
It may be transferred within the boundaries of the municipality of Mamer by a resolution of the board of directors of
the Company or, in the case of a sole director by a decision of the Sole Director
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2. The object of the Company is to carry out any operation directly or indirectly related to the holding of partici-
pations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in
any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual property assets, industrial property
assets, stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development
and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
The Company may borrow in any form and may issue bonds, without a public offer, which may be convertible and may
issue debentures.
Within the limits set out by the amended law dated 10 August 1915 on commercial companies, the Company may grant
assistance, loan, advance or warranty to affiliated companies or to one or several shareholders.
In a general fashion it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
161091
L
U X E M B O U R G
The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions in
relation to real estate or in relation to tangible or intangible property and especially in relation with intellectual property or
industrial property.
Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-five thousand Euro (EUR 35,000.-) represented by one thousand four
hundred (1,400) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or more
shares.
The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the
opinion of the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, at the opinion of the Shareholders, subject to the
restrictions foreseen by Law.
In case of registered shares, a shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance
with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
All the bearer shares in issue must be deposited with a depositary appointed by the board of directors. The board of
directors has to inform the shareholders of such appointment and of every amendment regarding depositary. Resolutions
of appointment or acknowledgments of amendments regarding depositary must be registered and published in conformity
with article 11bis §1
er
, 3), d) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
A bearer shareholders’ register containing precise identification of every shareholder, indication of the number of bearer
shares or units held by him or her, information relevant to the date of deposit, transfers, cancellation or conversion of the
shares in registered form with indication of the effective date shall be open and kept by the depositary.
The ownership of a bearer share is established according to the registered entry in the bearer shareholders’ register.
Upon written request of each bearer shareholder, a certificate can be issued and delivered to him/her summarizing all the
entries in the bearer shareholders’ register regarding him/her. The Company recognizes only one single owner per share.
If one or more shares are jointly owned or if the title of ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all person
(s) claiming a right to such share(s) has/have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company.
The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s). The same rule shall apply
in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and
a pledgee.
A bearer shares’ transfer inter vivos becomes valid towards third parties and the Company following registration of such
transfer by the depositary in the bearer shareholders’ register made on the basis and upon receipt by the depositary of any
document or acknowledgement establishing the transfer of the ownership between the transferor and the transferee. A
notification of transfer causa mortis is validly made to the depositary provided no opposition exists, by presentation of the
death certificate, entry of death or affidavit issued by the district judge or notary.
The rights of bearer shares in issue which are not deposited neither duly registered in the bearer shareholders’ register
shall be deemed to be suspended until due deposit of the shares respectively registration in the share register.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not to
be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general
meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be
limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one share-
holder in the Company.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed by
general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's
object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another director
may preside over the meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between
directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may vote by
letter, telegram, telex or facsimile.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar
means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical cha-
racteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held
by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.
161092
L
U X E M B O U R G
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company
in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate
or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of
directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report
each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company
may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom
such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1)
member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.
Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed
for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 7. The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December
of the same year.
Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated
in the convening notices on the third Thursday of the month of May at 4 p.m
If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their
consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares
five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not
be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the corporation.
It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles
of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitional dispositionsi>
1.- The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2016.
2.- Exceptionally the first annual general meeting shall be held on 2 March 2017.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, the abovenamed party, represented as aforementioned,
declares to subscribe the one thousand four hundred (1,400) shares.
All these shares have been entirely paid up by payment in cash, so that the sum of thirty-five thousand Euro (EUR
35,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law
of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about EUR 1,500.-
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named person, representing the entire subscribed capital has passed the following resolutions:
1.- The number of directors is set at one (1) and that of the auditors at 1 (one).
2.- The following is appointed director:
Mr. Carlo SAGRAMOSO, born in Milan (Italy) one 17 July 1960, professionally residing in Via G. Bagutti 5, CH-6900
Lugano, Switzerland.
3.- Has been appointed auditor:
161093
L
U X E M B O U R G
FISCOGES S.à r.l., having its registered office at 4, rue de Kleinbettingen, L-8362 Grass.
4.- The mandates of the director and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2017.
5.- The registered office will be fixed at L-8210 Mamer, 106, Route d’Arlon.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames,
civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède
L’an deux mille quinze, le huit octobre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Carlo SAGRAMOSO, né à Milan (Italie), le 17 juillet 1960, demeurant professionnellement à Via G. Bagutti
5, CH-6900 Lugano, Suisse,
ici représenté par Monsieur François Leynen, demeurant professionnellement au 106, Route d’Arlon, L-8210 Mamer,
en vertu d’une procuration datée du 10 juin 2015, qui restera annexée au présent acte.
Lequel comparant, agissant comme il est dit, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «Victoriosa S.A.»
Le siège social est établi à Mamer.
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Mamer par simple décision du conseil d’administration de la
Société ou, dans le cas d'un administrateur unique par une décision de l'Administrateur Unique.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. L'objet de la Société est de réaliser toutes opérations directement ou indirectement liées à la prise de participations,
sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou
de toute autre manière ainsi que le transfert par vente, l'échange ou autrement d’actifs de propriété intellectuelle, actifs de
propriété industrielle, titres, obligations, débentures, billets et autres titres de toute nature, et de la détention, l'administration,
le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des partenariats.
La Société peut emprunter sous toute forme et émettre des obligations, sans offre publique, qui peuvent être convertibles
et peuvent émettre des débentures.
Dans les limites fixées par la loi modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, la Société peut accorder toutes
aides, prêts, avances ou garanties à des sociétés affiliées ou à un ou plusieurs actionnaires.
De manière générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qui
pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.
La Société pourra en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes trans-
actions en matière immobilière ou en matière de propriété corporelle ou incorporelle et spécifiquement en matière de
propriété intellectuelle ou industrielle.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille Euros (EUR 35.000,-), divisé en mille quatre cents (1.400) actions
ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix de l'Actionnaire
unique, ou en cas de pluralité d’actionnaires, au choix des Actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.
En cas d’actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société conformément aux
dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque actionnaire.
Tous les certificats au porteur émis devront être immobilisés auprès d’un dépositaire désigné par le conseil d’adminis-
tration. Le conseil d’administration informera les actionnaires de toute nomination de dépositaire ou de tout changement
le concernant. Les actes de nomination ou changement concernant les dépositaires devront être déposés et publiés confor-
mément à l'article 11bis §1
er
, 3), d) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
161094
L
U X E M B O U R G
Un registre des actions au porteur sera ouvert, lequel se trouvera auprès de dépositaire et renseignera la désignation
précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre des actions au porteur ou coupures détenues, la date du dépôt, les
transferts, l'annulation ou la conversion des actions en titres nominatifs avec leur date.
La propriété de l'action au porteur s’établie par l'inscription sur le registre des actions au porteur. A la demande écrite
de l'actionnaire au porteur, un certificat peut être lui délivré par le dépositaire constatant toutes les inscriptions le concernant
qui lui sera remis. La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement
détenues ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un
droit sur la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société.
L’omission d’une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même
règle est appliquée dans le cas d’un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.
Toute cession entre vifs est rendue opposable vis-à-vis des tiers et de la Société par un constat de transfert inscrit par
dépositaire sur le registre des actions au porteur sur base de tout document ou notification constatant le transfert de propriété
entre cédant et cessionnaire. La notification de transfert pour cause de mort est valablement faite à l'égard de dépositaire,
s’il n’y a opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat d’inscription et d’un acte de notoriété reçu par le
juge de paix ou par un notaire.
Les actions au porteur ne se trouvant pas en dépôt ou n’étant pas valablement inscrites dans le registre des actions au
porteur, verront leurs droits suspendus jusqu’à dépôt, respectivement inscription au registre.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,
lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté
que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un (1) membre
jusqu’à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d’un actionnaire.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nom-
més ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à
l'élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.
Le Conseil d’administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la
réunion sera conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs
peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Le Conseil d’administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents,
associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par
une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obli-
gation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quel-
conques alloués au délégué.
La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une
durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième jeudi du mois de mai à 16 heures à Luxembourg au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
161095
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont
pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit
en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne
ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites
par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.
2.- Exceptionnellement la première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le 2 mars 2017.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant, représenté comme il est dit déclare souscrire les mille
quatre cents (1.400) actions.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente-cinq mille
Euros (EUR 35.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.500,-
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).
2.- Est appelé aux fonctions d'administrateur:
Monsieur Carlo SAGRAMOSO, né à Milan (Italie), le 17 juillet 1960, demeurant professionnellement à Via G. Bagutti
5, CH-6900 Lugano, Suisse.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FISCOGES S. à r.l., ayant son siège social à L-8362 Grass, 4, Rue de Kleinbettingen.
4.- Les mandats de l'administrateur et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.
5.- Le siège social est fixé au 106, Route d’Arlon, L-8210 Mamer.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre
le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: F. LEYNEN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 12 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/32479. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 21 octobre 2015.
Référence de publication: 2015172190/308.
(150190593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
161096
L
U X E M B O U R G
Casino Developpement Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 11.198.491,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 140.408.
EXTRAIT
En date du 15 octobre 2015, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Monsieur Michaël Goosse, Gérant B, avec effet au 15 octobre 2015.
2. Nomination de Monsieur Nicolas Poncelet, né le 16 juin 1979 à Arlon (Belgique) et résidant professionnellement au
174, route de Longwy L-1940 Luxembourg en tant que Gérant B avec effet au 15 octobre 2015 et en fonction jusqu'au 15
octobre 2018.
En conséquence de la démission et la nomination ci-dessus, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes
suivantes:
1) Claude Poisson, gérant de classe A;
2) Yves de Rocquigny, gérant de classe A;
3) Benoît Bassi, gérant de classe A;
4) Davy Beaucé, gérant de classe B;
5) Christophe Gammal, gérant de classe B; et
6) Nicolas Poncelet, gérant de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015170979/23.
(150188990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
China Fortune Group, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1730 Luxembourg, 47, rue de l'Hippodrome.
R.C.S. Luxembourg E 5.751.
STATUTS
Art. 1
er
. Forme. Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être
ultérieurement une société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code civil.
Art. 2. Objet social. La société a pour objet: la construction, l'acquisition, la location et la gestion de tout bien immobilier
appartenant à la société ou amené à lui appartenir, ainsi que toutes opérations mobilières, immobilières ou financières de
caractère purement civil se rattachant directement ou indirectement à cet objet.
Art. 3. Dénomination. La société prend la dénomination de: CHINA FORTUNE GROUP
Art. 4. Durée. La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés, sauf en cas de prorogation ou dissolution anticipée.
Un an minimum avant la date d'expiration de la société, les associés doivent décider en assemblée générale, dans les
conditions prévues pour la modification des statuts, si la société doit être prorogée. À défaut, tout associé peut demander
au président du Tribunal de grande instance statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de
provoquer la décision ci-dessus prévue.
Art. 5. Siège social. Le siège de la société est fixé à l'adresse suivante: 47 rue de l'hippodrome, L-1730 LUXEMBOURG
Le siège social pourra être transféré en tout lieu sur décision extraordinaire des associés.
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile au siège social de la société.
Art. 6. Apports. Les apports faits à la société sont les suivants:
Monsieur Wentao XU né 28.12.1988 à ZHEJIANG CHINE, profession: société ROYALMATE gérant technique, de-
meurant à 47 rue de l'hippodrome, L-1730 LUXEMBOURG, nationalité: Luxembourgeoise. apporte en numéraire la somme
de à un million€;
Madame Baoqin YANG né 23.06.1983 à ANHUI CHINE, profession: société BEIJING TIME OVERSEA co.ltd gérant
général, demeurant room 1106, Wangtong Center C block, Chaowai grand avenue, Chaoyang district, BEIJING, 100020,
apporte en numéraire la somme de à un million;
Monsieur kebing CUI né: 23.02.1973 à SHAANXI CHINE, profession: gérant de la société en Chine, demeurant room
202, 3 block 4 building 3 disctrit Daceng road da ceng nanli, FEITAI district BEIJING, apporte en numéraire la somme de
à 500000€;
161097
L
U X E M B O U R G
Madame Jingjing YAO né: 07.08.1984 à BEIJING CHINE, profession Banker à banque chinoise à hongkong, demeurant
flat E 12 F Liberty mansion No 26 E jordan road HK. apporte en numéraire la somme de 500000 €.
Art. 7. Capital social. Le capital social de la société est fixé à la somme de trois million €, correspondant aux montants
des apports des associés.
Ce capital est divisé en 30000 parts sociales de 100 € chacune, numérotées de 1 à 30000 et réparties comme suit:
Monsieur Wentao XU né 28.12.1988, parts numérotées de 10000 parts; gérant technique et gérant administratif
Madame Baoqin YANG né 23.06.1983, parts numérotées de 10000 parts; associée
Monsieur kebing CUI né: 23.02.1973, parts numérotées de 5000 parts; associée
Madame Jingjing YAO né: 07.08.1984, parts numérotées de 5000 parts; associée
Les parts de chaque associé résultent uniquement des présents statuts, des actes modifiant le capital social ou des cessions
éventuelles régulièrement passés. Elles ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.
Art. 8. Modification de capital. Le capital social peut faire l'objet de modification dans les conditions suivantes:
Il peut être augmenté ou diminué suite à décision collective extraordinaire des associés selon les modalités prévues dans
les présents statuts.
En cas de création de parts, les futurs titulaires de ces parts, s'ils ne sont pas déjà associés, doivent faire l'objet d'un
agrément des associés dans les conditions prévues dans les présents statuts en cas de cession de parts.
Art. 9. Droits et obligations. Chaque part sociale donne droit dans la propriété de l'actif social, dans la répartition des
bénéfices et dans le boni de liquidation, proportionnellement au nombre de parts émises. L'éventuelle contribution aux
pertes ou au mali de liquidation est supportée dans les mêmes conditions. Chaque part sociale donne également le droit
d'être présent ou représenté aux assemblées générales, de participer aux décisions collectives des associés, et de voter au
prorata des parts détenues.
Les droits et obligations attachés à chaque part sociale la suivent en quelques mains qu'elle passe, que ce soit par cession
ou transmission.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, à leurs modifications ultérieures et aux
décisions collectives des associés ou de la société régulièrement prises.
Art. 10. Responsabilité des associés. Les associés sont indéfiniment tenus au passif de la société, à proportion de leur
part dans le capital social. Les créanciers ne peuvent toutefois poursuivre le paiement des dettes sociales qu'après mise en
demeure à la société restée infructueuse, et ce conformément aux prescriptions légales et réglementaires applicables en la
matière.
Art. 11. Indivisibilité des parts. Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société.
En cas de propriétaires indivis, ces derniers doivent se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux ou par
un mandataire désigné parmi les associés. À défaut d'accord sur l'identité du mandataire, la désignation se fait par décision
de justice, à la demande de tout intéressé.
Art. 12. Cession de parts. La cession n'est opposable à la société qu'après lui avoir été signifiée par acte extrajudiciaire
ou acceptée par elle dans un acte authentique. Elle n'est opposable aux tiers qu'après publication conformément aux pre-
scriptions réglementaires et légales applicables en la matière.
La cession de parts entre ascendants et descendants ou entre conjoints peut intervenir librement. Toute autre cession
nécessite l'agrément du cessionnaire proposé, par les associés se prononçant:
- à la majorité des deux tiers au moins.
Pour obtenir cet agrément, l'associé cédant doit faire parvenir cette demande à la société et aux autres associés par lettre
recommandée avec accusé de réception en précisant le nombre de parts à céder, l'identité du cessionnaire, sa nationalité,
sa profession et son domicile, ou, s'agissant d'une société, son numéro Siren, l'adresse de son siège social, le nom de son
représentant et son activité exercée à titre principal.
Dans le mois suivant la réception, la société demande aux associés de se prononcer sur l'agrément demandé. Cette
décision est notifiée au cédant dans un délai d'un mois dans les mêmes conditions.
En cas d'agrément, la cession est enregistrée et les statuts modifiés en assemblée générale.
En cas de refus d'agrément, les associés peuvent se porter acquéreurs. En cas de pluralité d'associés acquéreurs potentiels,
ils sont acquéreurs proportionnellement aux parts qu'ils détenaient antérieurement dans le capital social.
Si aucun associé ne se porte acquéreur ou si les offres des associés portent sur un nombre de parts inférieur à celui cédé,
la société peut faire acquérir tout ou partie des parts par un tiers agréé par les associés dans les conditions prévues précé-
demment, ou les acquérir elle-même en vue de leur annulation.
À défaut d'offre de rachat dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications de demande d'agrément,
l'agrément à la cession est réputé acquis sauf aux autres associés de décider, dans le même délai, par décision collective
extraordinaire, la dissolution anticipée de la société. Cette décision est notifiée dans les huit jours au cédant, par lettre
recommandée avec accusé de réception. À la demande de la société, ce délai de six mois peut être prorogé une seule fois
de trois mois au maximum. Dans le cas d'une décision de dissolution, le cédant peut rendre caduque cette décision, en
161098
L
U X E M B O U R G
faisant connaître à chacun de ses associés et à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans
le délai d'un mois, qu'il renonce à la cession.
Les dispositions précédentes s'appliquent à tous les cas de cession de parts entre vifs intervenant à titre onéreux ou
gratuit, et aux apports en société, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique sur décision de
justice.
Art. 13. Transmission de parts. Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession au profit des
héritiers en ligne directe de l'associé décédé et éventuellement de son conjoint survivant, lesquels ne seront par conséquent
pas tenus à l'agrément. Ils doivent justifier à la société de leur état civil, de leur qualité et de la propriété des parts sociales
du défunt par la production d'un certificat de propriété ou de tout autre justificatif.
Les autres héritiers doivent présenter toutes indications et justifications utiles sur leur état civil et leurs qualités, et
solliciter l'agrément des associés de la manière prévue à l'article 12 des présents statuts.
À défaut d'agrément et conformément à l'article 1870-1 du Code civil, les intéressés sont créanciers de la société et ne
peuvent prétendre qu'à la valeur des droits sociaux ou de leur part dans ces droits, déterminée dans les conditions fixées
par l'article 1843-4 du Code civil.
Art. 14. Perte de qualité d'associé. En cas de faillite personnelle, liquidation ou règlement judiciaire d'un des associés,
il est procédé au remboursement des droits sociaux de celui-ci. Il perd la qualité d'associé.
La valeur des droits sociaux sera à déterminer conformément à l'article 1843-4 du Code civil.
Art. 15. Droit de retrait. Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la
société après décision collective extraordinaire prise dans les conditions citées dans l'article 17 des présentes. Le retrait
peut être autorisé pour justes motifs par décision du président du Tribunal de grande instance territorialement compétent.
L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts sociales au jour du retrait. La valeur des parts
est déterminée par accord entre les associés ou, à défaut, à dire d'expert en application des dispositions de l'article 1843-4
du Code civil.
Les frais et honoraires d'expertise sont pris en charge par le retrayant.
Art. 16. Assemblée générale. Tous les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée,
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque associé de l'assemblée dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente de parts sans limitation. Tout associé
peut se faire représenter par un autre associé en lui donnant mandat.
L'assemblée est présidée par le gérant, à défaut par l'associé qui représente le plus grand nombre de parts sociales et
accepte ces fonctions.
Les délibérations prises par l'assemblée conformément aux statuts obligent chacun des associés même absents. Elles
sont constatées par un procès-verbal indiquant la date, le lieu, le nom et prénom et la qualité du président, les noms et
prénoms des associés présents ou représentés, et le nombre de parts détenues par chacun d'eux, ainsi qu'un résumé de vote.
Le procès-verbal est signé par le président de séance.
Art. 17. Décisions.
1. Décisions ordinaires
Les décisions ordinaires de l'assemblée générale sont des décisions de gestion courante. Elles concernent les questions
qui n'emportent pas modification des présents statuts.
Toutefois, la révocation du gérant entre dans le cadre des décisions ordinaires.
Ces décisions sont valablement prises à la majorité, donc par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du
capital social.
2. Décisions extraordinaires
Les décisions extraordinaires ont pour objet la modification des statuts dans toutes leurs dispositions, sauf pour la
révocation du gérant.
Ces décisions extraordinaires sont votées en assemblée générale:
- à la majorité des deux tiers au moins.
Toutefois, toute décision emportant changement de la nationalité de la société ou encore augmentation de la responsa-
bilité des associés à l'égard des tiers, doit être prise à l'unanimité.
Art. 18. Nomination du gérant et durée de la gérance. La société est administrée, en sa qualité de gérant, par Monsieur
Wentao XU société CHINA ROYAL, né 28.12.1988, indépendant, demeurant à 47 rue de l'hippodrome, L-1730 Luxem-
bourg, présent et acceptant.
Le gérant est nommé par décision ordinaire des associés, pour une durée illimitée.
Les fonctions du gérant cessent par le décès, l'interdiction, la faillite, la révocation ou la démission.
161099
L
U X E M B O U R G
Le gérant peut démissionner à la clôture d'un exercice après un préavis de six mois minimum, envoyé à chaque associé
en lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai peut être réduit, et même supprimé, par décision ordinaire des
associés.
Le gérant est révocable par décision ordinaire des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner
lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout
associé.
Le gérant-associé démissionnaire ou révoqué conserve la qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui y sont
attachés.
La nomination ou la cessation des fonctions de gérant sont publiées conformément aux prescriptions légales et régle-
mentaires. Le décès ou la cessation des fonctions n'entraîne pas la dissolution de la société.
Art. 19. Pouvoirs. Le gérant est investi, sous réserve des décisions relevant des associés, des pouvoirs les plus étendus
pour veiller à la bonne gestion de la société et permettre tout acte relatif à son objet social. Dans les rapports avec les tiers,
il engage la société par les actes entrant dans cet objet social.
Le gérant est responsable individuellement des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts.
Le gérant a le droit de signer tout seul pour toutes les acquisition d'un bien chez le notaire, la banque, l'avocat et tous
les autres institutions financières et judiciaire.
Art. 20. Exercice social. L'exercice social commence au 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice social comprend la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société et
le 31 décembre.
Art. 21. Comptes de la société. À la clôture de chaque exercice, le gérant établit les documents suivants:
le bilan de la société.
Les associés sont convoqués en assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice pour l'approbation des
comptes de l'exercice écoulé et l'affectation des résultats.
À cette occasion, le gérant rend compte de sa gestion aux associés.
Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'exercice
écoulé, comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Art. 22. Résultat, affectation et répartition. Les bénéfices nets sont constitués par la différence entre recettes et dépenses
d'exploitation de la période de référence, à savoir: frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions.
Le bénéfice net est distribué aux associés après diminution des pertes antérieures et augmentation des reports bénéfi-
ciaires. Il est réparti sous forme de dividendes entre les associés proportionnellement au nombre de parts de chacun.
Avant toute distribution, les associés peuvent décider de prélever une certaine somme à porter en fonds de réserves ou
à reporter, pour faire face à d'éventuelles dépenses exceptionnelles.
En cas de pertes, elles s'imputent en premier lieu sur les bénéfices non encore répartis, puis sur les réserves, puis sur le
capital. Le solde, s'il y a lieu, est supporté par les associés proportionnellement à leurs parts sociales.
Art. 23. Information des associés. Tout associé peut obtenir communication au siège social des livres comptables et des
documents sociaux.
Tout associé a également le droit de poser des questions sur la gestion. Le gérant doit répondre dans un délai d'un mois
par écrit envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de l'associé demandeur.
Art. 24. Dissolution et liquidation. La société est en liquidation à compter de sa dissolution.
La dissolution produit ses effets à l'égard des tiers à la date de sa publication au registre du commerce et des sociétés.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de la procédure et des
comptes.
La liquidation est faite par un liquidateur parmi les associés, ou nommé par ordonnance du président du Tribunal de
grande instance.
Le liquidateur représente la société: il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, à l'amiable ou autrement, en
bloc ou isolément, et acquitter le passif.
Le produit net de la liquidation, ou les pertes éventuelles à supporter, sont à partager entre les associés proportionnel-
lement au nombre des parts.
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, tout intéressé
peut saisir le tribunal qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
Fait à Luxembourg, le 21.10.2015.
Référence de publication: 2015171808/193.
(150190958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
161100
L
U X E M B O U R G
Daniel Frères Immobilière S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5553 Remich, 28, Quai de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 50.149.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 2015.
Référence de publication: 2015171069/10.
(150189187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
Digital Services XLI S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Philippines Internet Holding S.à r.l.).
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 193.920.
In the year two thousand and fifteen, on the fourteenth day of October,
before us Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1. Asia Internet Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered
office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des
Sociétés) under number B 177038,
being the holder of fifteen thousand (15,000) shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Senningerberg,
by virtue of a proxy given under private seal in Berlin on 12
th
october 2015;
2. iCommerce Investments Pte. Ltd., a company incorporated under the laws of Singapore, registered with the Singapore
Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), with registration number 201505232M, having its registered
office at 100 Beach Road, #25-06, Shaw Towers, Singapore (189702), (“iCommerce”),
becoming the holder of seven thousand five hundred (7,500) shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal in Makati City, Philippines on 8
th
October 2015.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The party under 1. (the “Existing Shareholder”) is the sole shareholder of Digital Services XLI S.à r.l. (the “Company”),
a private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B
193.920, and incorporated pursuant to a deed of the notary Cosita Delvaux, residing in Luxembourg, on 7 January 2015,
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 585 dated 3 March 2015. The articles of asso-
ciation have not been amended since.
The Existing Shareholder represents the entire share capital and has waived any notice requirement. The general meeting
of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby iCommerce participates
and votes for the purpose of agenda point 5 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Amendment of the name of the Company from “Digital Services XLI S.à r.l.” to “Philippines Internet Holding S.à
r.l.” and subsequent amendment of article one (1) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth
read as follows:
“ Art. 1. Name.
There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Philippines Internet Holding
S.à r.l. (hereinafter the “Company”), which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.”
2. Amendment of article two (2) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:
“ Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
161101
L
U X E M B O U R G
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio, in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such
intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property
rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.”
3. Acceptance of iCommerce Investments Pte. Ltd., a company incorporated under the laws of Singapore, registered
with the Singapore Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), with registration number 201505232M,
having its registered office at 100 Beach Road, #25-06, Shaw Towers, Singapore (189702), as new shareholder of the
Company.
4. Increase of the Company's share capital by an amount of seven thousand five hundred euro (EUR 7,500) so as to raise
it from its current amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) to twenty-two thousand five hundred euro (EUR 22,500)
by issuing seven thousand five hundred (7,500) new shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5. Subsequent amendment of article five point one 5.1 of the articles of association of the Company, so that it shall
henceforth read as follows:
“ 5.1. The Company's share capital is set at twenty-two thousand five hundred Euros (EUR 22,500.00) represented by
twenty-two thousand five hundred (22,500) ordinary shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.”
6. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:
“A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name Philip-
pines Internet Holding S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio, in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such
intellectual and industrial property rights, and (Hi) the holding and the management of intellectual and industrial property
rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time with or without cause by a resolution of the general meeting of the shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may
be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the general meeting of the
shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
161102
L
U X E M B O U R G
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty-two thousand five hundred Euros (EUR 22,500.00) represented by
twenty-two thousand five hundred (22,500) ordinary shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are to
be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the unanimous approval of such transfer
given by all shareholders except for any transfers identified as such in any shareholders' agreement entered into between
the shareholders from time to time, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights
or drag-along rights contained in any shareholders' agreement entered into between the shareholders from time to time, it
being understood that the Super Majority (as defined below) consent will always be required.
7.5 Article 7.4 shall apply accordingly to the conclusion of fiduciary relationships, pledge agreements, the grant of sub-
participations, the assignment and setting off of claims and rights derived from shares in the Company, in particular, all
claims for payment of profits, except for the conclusion of pledge agreements with and the assignment of claims to banks
in connection with external financing agreements; these are subject to the voting agreement pursuant to 7.4 above.
7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by a majority of shareholders holding at least three quarters of the share capital (a “Super
Majority”) (which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased shareholder). Such approval is, however,
not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir
of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of the shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by applicable law and by
these articles of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of the shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote
in writing.
161103
L
U X E M B O U R G
8.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can also
be passed outside meetings in writing (including email) or telephone voting if such procedure is requested by a shareholder
and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board of managers of
the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing sentence the
votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from voting. Written
resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder without undue
delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has declaratory significance.
8.5 Unless a notarial record is made of the shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at general meetings of the shareholders (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue
delay, which must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The
written record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.
8.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of the
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of the shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of the shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of the shareholders.
9.1 General meetings of the shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time
as may be specified in the respective convening notices of meeting.
9.2 The general meeting of the shareholders is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery
or registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary general meetings of the shareholders and at least two (2) weeks for ex-
traordinary general meetings of the shareholders. The period of notice begins to run on the day following postage. The day
of the general meeting of the shareholders is not counted in the calculation of the period of notice.
9.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of the shareholders and have waived the convening
notice requirements, the meeting may be held without prior notice.
9.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at a general meeting of the shareholders by another
shareholder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.
9.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the general meeting of the shareholders, a written record must
be made concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state
the place and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the
shareholders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented at the general meeting
of the shareholders (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the
written record.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 A general meeting of the shareholders will only constitute a quorum if at least 80% of the share capital is represented
and if all shareholders of the Company have been duly notified of such general meeting of the shareholders in compliance
with Article 9. Unless otherwise provided for by the Law or these articles of association, collective decisions of the Com-
pany's shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If there is no quorum, a new general meeting of the shareholders with the same agenda must be called without
undue delay in compliance with Article 9.2. Such general meeting of the shareholders shall then constitute a quorum
regardless of the share capital represented, if this was pointed out in the notice calling such meeting and the decisions shall
be taken at the simple majority of the votes cast.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.
D. Board of managers - Advisory board
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
161104
L
U X E M B O U R G
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name and on behalf of the Company and to
take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved
by the Law or by these articles of association to the general meeting of the shareholders.
Art. 14. Election, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be elected and removed by the general meeting of the shareholders which shall determine
their remuneration and term of office.
14.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
14.3 The general meeting of the shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class
A managers and class B managers, provided that there can only be up to two class A managers and two class B managers
at any time. Any such Classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant shareholders'
resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next general meeting of the shareholders which shall resolve on
the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of the shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being suf-
ficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in
a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening notice requirements or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Board of Managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting, except as
otherwise provided by law, these articles of association or the rules of procedure for the board of managers. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of the shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers), any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented), except as otherwise provided by law, these articles of association or the rules of procedure for the
board of managers.
17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
17.8 The shareholders have adopted and issued rules of procedure for the board of managers.
161105
L
U X E M B O U R G
17.9 The managers shall require the written consent of the Advisory Board (as defined in Article 20.1 below) which
may be granted via facsimile or e-mail or in any other written way, for legal transactions and measures which are specified
from time to time in the rules of procedure for the board of managers adopted pursuant to Article 17.8 above. No consent
is required if such legal transactions and measures have in advance been specifically listed in and approved by an adopted
budget with the unanimous consent of the shareholders.
17.10 The general meeting of the shareholders or the Advisory Board may by unanimous resolution amend the rules of
procedure for the board of managers at any time (e.g. determining further transactions and measures requiring the consent
of the Advisory board). The Advisory Board may give its consent also in advance for certain groups and kinds of transactions
and measures.
17.11 Any amendments to the rules of procedure for the board of managers adopted in accordance with Article 17.10
will be effective as from their notification to the board of managers. Such amendments will be acknowledged, and to the
extent necessary approved by the board of managers at the occasion of its next meeting.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of the
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of the shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers) under the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of the shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signature or the sole signature of any
person (s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers, within the limits of such
delegation.
Art. 20. Advisory Board.
20.1 The Company shall have an advisory board (the “Advisory Board”). It shall be composed according to the rules
set out in Articles 20.2 and 20.3 below.
20.2 The general meeting of the shareholders of the Company shall appoint the members of the Advisory Board.
20.3 The general meeting of the shareholders may by way of a unanimous shareholders' resolution increase or decrease
the number of members of the Advisory Board. Each of the shareholders may nominate one or several non-voting member
(s) of the Advisory Board.
20.4 The general meeting of the shareholders shall only amend the adopted rules of procedure for the Advisory Board
by way of a unanimous shareholders' resolution.
20.5 Any amendments to the rules of procedure for the Advisory Board adopted in accordance with Article 20.4 will
be effective as from their notification to the Advisory Board. Such amendments will be acknowledged, and to the extent
necessary approved by the Advisory Board at the occasion of its next meeting.
20.6 The Advisory Board shall have a chairman and a vice-chairman. The rules of procedure for the Advisory Board
shall provide for further provisions in particular on the self-organisation of the Advisory Board.
20.7 The Advisory Board shall be competent for the granting of consents to any transactions and measures of the
managers which require the consent of the Advisory Board pursuant to (i) the rules of procedure for the Advisory Board,
(ii) the rules of procedure for the board of managers, (iii) respective shareholders' resolutions or (iv) in these articles of
association.
E. Audit and supervision
Art. 21. Auditor(s).
21.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of the shareholders shall
appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
21.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of the shareholders.
21.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
161106
L
U X E M B O U R G
21.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
21.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 22. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 23. Annual accounts and allocation of profits.
23.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
23.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
23.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
23.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
23.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
23.6 Dividend distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the
Company and as set out in any shareholders' agreement which may exist between them.
23.7 In addition to those rights to which they are entitled by application of law, the shareholders shall have such rights
of information as set out in any shareholders' agreement which may exist between them.
Art. 24. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
24.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a
reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.
24.2 Any interim dividends distributed by the board of managers in accordance with Article 24.1 will need to be con-
firmed by the ordinary general meeting of the shareholders on the basis of the annual accounts of the relevant financial
year.
24.3 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation.
25.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of the shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
25.2 The liquidation proceeds shall be allocated in accordance with the applicable provisions of any shareholders'
agreement entered into by and between the shareholders from time to time.
H. Final clauses
Art. 26. Governing law.
26.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any
shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles.
26.2 These articles of association are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between
the English and the German text, the English version shall prevail.
Art. 27. Severability.
27.1 In addition, the general legal requirements for companies shall apply.
27.2 These articles of association continue to be valid even if a provision hereof turns out to be invalid. The invalid
provision shall be supplemented or reinterpreted such that the economic purpose intended by the invalid provision will be
161107
L
U X E M B O U R G
achieved. The same applies if it turns out during the implementation of the articles of association that they contain a gap
that needs to be filled.”
7. Removal of (i) Mr Christian Senitz as class A manager of the Company, (ii) Mr Ulrich Binninger as class B manager
of the Company and (iii) Mr Julien De Mayer as class B manager of the Company, and subsequent appointment with
immediate effect of (i) Mr Julien De Mayer as class A manager of the Company for an unlimited period, (ii) Mr Hanno
Stegmann as class A manager of the Company for an unlimited period, as well as (iii) Mr Jose Benjamin S. Fernandez as
class B manager of the Company for an unlimited period.
8. Subsequently, decision to grant power to any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mrs
Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the share-
holders' register of the Company.
9. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting unanimously takes, and requires the undersigned
notary to enact, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend the name of the Company from “Digital Services XLI S.à r.l.”
to “Philippines Internet Holding S.à r.l.” and to amend article one (1) of the articles of association of the Company so that
it shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend article two (2) of the articles of association of the Company, so
that it shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to accept iCommerce, aforementioned, as new shareholder of the Com-
pany.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the Company's share capital by an amount of seven thousand
five hundred euro (EUR 7,500) so as to raise it from its current amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) to twenty-
two thousand five hundred euro (EUR 22,500) by issuing seven thousand five hundred (7,500) new shares, with a nominal
value of one euro (EUR 1 ) each.
<i>Subscriptioni>
The seven thousand five hundred (7,500) new shares have been entirely subscribed by iCommerce, aforementioned, for
the price of seven thousand five hundred euro (EUR 7,500).
<i>Paymenti>
The seven thousand five hundred (7,500) new shares subscribed by iCommerce, aforementioned, have been entirely
paid up through a contribution in cash in the amount of seven thousand five hundred euro (EUR 7,500).
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of seven thousand five hundred euro (EUR 7,500) is entirely allocated to the share
capital of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend article five point one (5.1) of the articles of association of the
Company, so that it shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Sixth Resolutioni>
Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders decides to fully restate the articles of association
of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Seventh Resolutioni>
The general meeting of shareholders acknowledges the resignation of Mr Christian Senitz as class A manager of the
Company with immediate effect, and resolves to grant him discharge for the exercise of his mandate.
The general meeting of shareholders also acknowledges the resignation of the following persons as class B managers
of the Company with immediate effect, and resolves to grant them discharge for the exercise of their mandates:
- Mr Ulrich Binninger; and
- Mr Julien De Mayer.
161108
L
U X E M B O U R G
Subsequently, the general meeting of shareholders resolves to appoint the following persons as managers of the Company
with immediate effect for an unlimited period:
- Mr Hanno Stegmann, born in Hamburg, Germany, on 24 October 1980, professionally residing at 03-10, Podium B,
Bestway Building, 12 Prince Edward Rd, Singapore 079212, Singapore, as class A manager of the Company;
- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium, on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, as class A manager of the Company; and
- Mr Jose Benjamin S. Fernandez, born in Manila, Philippines, on 22 October 1 961, professionally residing at 12/F
Anson's Building, 23 ADB Ave., Ortigas Center, Pasig City 1605, Philippines, as class B manager of the Company.
As a consequence of the foregoing resolution, the board of managers is composed as follows:
- Mr Hanno Stegmann, class A manager;
- Mr Julien De Mayer, class A manager; and
- Mr Jose Benjamin S. Fernandez, class B manager.
<i>Eighth Resolutioni>
The general meeting of shareholders hereby grants power to grant power to any manager of the Company, regardless
of his category, as well as
Mrs Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the
shareholders' register of the Company.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately two thousand two hundred euros (EUR 2,200.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same parties and in case of
divergences between the English and the German text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am vierzehnten Oktober,
vor der unterzeichnenden Notarin Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Asia Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz
in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet unter dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter
der Nummer B 177038,
Inhaberin von fünfzehntausend (15.000) Anteilen,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Senningerberg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 12. Oktober 2015, ausgestellt in Berlin;
2. iCommerce Investments Pte. Ltd., eine Gesellschaft gegründet unter dem Recht Singapurs, eingetragen bei der Sin-
gapore Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) unter der Eintragungsnummer 201505232M, mit Sitz in
100 Beach Road, #25-06, Shaw Towers, Singapur (189702), („iCommerce“),
zukünftige Inhaberin von siebentausendfünfhundert (7.500) Anteilen,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, vorbenannt, gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 8. Oktober
2015, ausgestellt in Makati City, Philippinen
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur para-
phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die Partei unter 1. (der „Bestehende Gesellschafter“) ist der alleinige Gesellschafter der Digital Services XLI S.à r.l.
(die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 5, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet unter dem Recht des Großherzogtums Lu-
xemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der
Nummer B 193.920, gegründet am 7. Januar 2015 gemäß einer Urkunde der Notarin Cosita Delvaux, mit Amtssitz in
Luxemburg, welche am 3. März 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 585 veröffentlicht wurde.
Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem nicht geändert.
Der Bestehende Gesellschafter vertritt das gesamte Gesellschaftskapital und verzichtet auf jegliche Ladungsformalitä-
ten. Die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende
161109
L
U X E M B O U R G
Tagesordnung verhandeln, wobei iCommerce ausschließlich für die Punkte 5 ff. der Tagesordnung teilnahmeund stimm-
berechtigt ist:
<i>Tagesordnungi>
1. Änderung des Namens der Gesellschaft von „Digital Services XLI S.à r.l.“ in „Philippines Internet Holding S.à r.l.“
und dementsprechende Änderung des Artikels eins (1) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Philippines Internet Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.“
2. Änderung des Artikels zwei (2) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.“
3. Aufnahme der iCommerce Investments Pte. Ltd., einer Gesellschaft gegründet unter dem Recht Singapurs, eingetragen
bei der Singapore Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) unter der Eintragungsnummer 201505232M,
mit Sitz in 100 Beach Road, #25-06, Shaw Towers, Singapur (189702), als neue Gesellschafterin der Gesellschaft.
4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünfzehntausend Euro (EUR
15.000) um einen Betrag von siebentausendfünfhundert Euro (EUR 7.500) auf einen Betrag von zweiundzwanzigtausend-
fünfhundert Euro (EUR 22.500) durch die Ausgabe von siebentausendfünfhundert (7.500) neuen Anteilen mit einem
Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
5. Dementsprechende Änderung des Artikels fünf Punkt eins (5.1) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie
folgt lautet:
„ 5.1. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zweiundzwanzigtausendfünfhundert Euro (EUR 22.500,00),
bestehend aus zweiundzwanzigtausendfünfhundert (22.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,-).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch
das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.“
6. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Philippines Internet Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
161110
L
U X E M B O U R G
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zweiundzwanzigtausendfünfhundert Euro (EUR 22.500,00), be-
stehend aus zweiundzwanzigtausendfünfhundert (22.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,-).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch
das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-
gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
161111
L
U X E M B O U R G
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der einstimmigen Zustimmung von allen
Gesellschaftern übertragen werden, außer bei Übertragungen, die als solche in Gesellschaftervereinbarungen, die mitunter
zwischen den Gesellschaftern eingegangen wurden, sofern vorhanden, bezeichnet wurden, insbesondere hinsichtlich Vor-
kaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten oder -pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen, die mitunter
zwischen den Gesellschaftern eingegangen wurden, wobei die Zustimmung der Qualifizierten Mehrheit (wie unten defi-
niert) selbstverständlich immer erforderlich ist.
7.5 Artikel 7.4 gilt entsprechend für den Abschluss von Treuhandverhältnissen, Pfandverträgen, die Erteilung von Un-
terbeteiligungen, die Abtretung von und Aufrechnung mit Ansprüchen und Rechten, die sich aus Gesellschaftsanteilen
ergeben und insbesondere mit Ansprüchen auf Gewinnauszahlung, mit Ausnahme des Abschlusses von Pfandverträgen
mit und der Abtretung von Ansprüchen an Banken in Verbindung mit externen Finanzierungsverträgen; diese unterliegen
dem Abstimmungsabkommen gemäß Artikel 7.4.
7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten
gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn eine Mehrheit von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte
Mehrheit“) einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschafters für diese Zwecke
nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen
oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters über-
tragen werden.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das anwendbare Recht und diese
Satzung ausdrücklich vorbehalten sind.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail)
oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter ersucht wird
und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen dieses Verfahren
gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen kein Widerspruch
gemäß dem vorstehenden Satz eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teilnehmenden Gesell-
schafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unterzeichnen und die
Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher Form gefasst
wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
8.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift an-
zufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
8.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung.
9.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in der
entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
9.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder Ein-
schreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
9.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungsfor-
malitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
161112
L
U X E M B O U R G
9.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine schrift-
liche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer mit einer
Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
9.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 80% des Gesellschaftskapitals
vertreten sind und wenn alle Gesellschafter der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 9 ordnungsgemäß über die Abhaltung
der Gesellschafterversammlung unterrichtet wurden. Sofern nicht durch das Gesetz von 1915 oder diese Satzung etwas
Gegenteiliges vorgesehen ist, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaf-
tern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit
Artikel 9.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterver-
sammlung ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die
Versammlung einberufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.
D. Rat der Geschäftsführer - Beirat
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese den Rat der Geschäftsführer.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen und für Rechnung der Ge-
sellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder
nützlich sind, mit Ausnahme der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung
vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt oder abberufen, welche ihre
Bezüge und Amtszeit festlegt.
14.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B, mit der Maßgabe, dass es
jederzeit höchstens zwei Geschäftsführer der Kategorie A und zwei Geschäftsführer der Kategorie B geben kann. Eine
solche Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbe-
schlüsse festgehalten und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-
punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
161113
L
U X E M B O U R G
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abge-
geben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des
Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der
Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 17. Rat der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-
führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Geschäftsführer sein muss und der für die
Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst, es sei denn, es wird durch das Gesetz, diese Satzung oder die
Geschäftsordnung für den Rat der Geschäftsführer etwas Gegenteiliges bestimmt. Der Vorsitzende des Rates der Ge-
schäftsführer, falls vorhanden, hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschaf-
terversammlung jedoch unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der
Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam
gefasst, wenn sie von der Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A
und eines Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden, es sei denn, es wird durch das Gesetz,
diese Satzung oder die Geschäftsordnung für den Rat der Geschäftsführer etwas Gegenteiliges bestimmt.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, per EMail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
17.8 Die Gesellschafter haben eine Geschäftsordnung für den Rat der Geschäftsführer beschlossen und bekannt gegeben.
17.9 Die Geschäftsführer benötigen die schriftliche Zustimmung des Beirats (wie in Artikel 20.1 definiert), welche per
Fax oder E-Mail oder in jeder anderen schriftlichen Form erteilt werden kann, für Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, welche
in der Geschäftsordnung für den Rat der Geschäftsführer gemäß Artikel 17.8 mitunter festgelegt werden. Eine Zustimmung
ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen im Voraus in einem bewilligten Haushaltsplan aus-
drücklich aufgeführt und mit der einstimmigen Zustimmung der Gesellschafter genehmigt wurden.
17.10 Die Gesellschafterversammlung oder der Beirat kann die Geschäftsordnung für den Rat der Geschäftsführer
jederzeit durch einstimmigen Beschluss ändern (durch die Festlegung weiterer Transaktionen und Maßnahmen, die der
Zustimmung des Beirats bedürfen). Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transakti-
onen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.
17.11 Änderungen der Geschäftsordnung für den Rat der Geschäftsführer, welche im Einklang mit Artikel 17.10 ge-
nehmigt wurden, gelten sobald der Rat der Geschäftsführer darüber unterrichtet wurde. Diese Änderungen werden vom
Rat der Geschäftsführer bei seiner nächsten Sitzung zur Kenntnis genommen und, soweit erforderlich, genehmigt.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls
vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) gemeinsam unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem
161114
L
U X E M B O U R G
Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäfts-
führer, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversamm-
lung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und
Geschäftsführer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A
und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) gemeinsam unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsame Unterschrift
mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Ver-
treter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine
Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
Art. 20. Beirat.
20.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat (der „Beirat“). Dieser ist im Einklang mit den in Artikel 20.2 und 20.3 aufgeführten
Regeln zusammenzusetzen.
20.2 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ernennt die Mitglieder des Beirats.
20.3 Die Gesellschafterversammlung kann durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss die Anzahl der Mitglieder
des Beirats erhöhen oder herabsetzen. Jeder der Gesellschafter kann einen oder mehrere nichtstimmberechtigte Mitglieder
des Beirats ernennen.
20.4 Die Gesellschafterversammlung kann die genehmigte Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einen einstim-
migen Gesellschafterbeschluss abändern.
20.5 Änderungen der Geschäftsordnung für den Beirat, welche im Einklang mit Artikel 20.4 genehmigt wurden, gelten
sobald der Beirat darüber unterrichtet wurde. Diese Änderungen werden vom Beirat bei seiner nächsten Sitzung zur
Kenntnis genommen und, soweit erforderlich, genehmigt.
20.6 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Die Geschäftsordnung des Beirats hat
weitere Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, zu enthalten.
20.7 Der Beirat ist für die Erteilung von Zustimmungen zu Transkationen und Maßnahmen der Geschäftsführer zu-
ständig, welche gemäß (i) der Geschäftsordnung für den Beirat, (ii) der Geschäftsordnung für den Rat der Geschäftsführer,
(iii) entsprechender Gesellschafterbeschlüsse oder (iv) dieser Satzung der Zustimmung des Beirats bedürfen.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 21. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
21.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
21.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
21.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte der
Gesellschaft.
21.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.
21.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 23. Jahresabschluss und Gewinne.
23.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-
klang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
161115
L
U X E M B O U R G
23.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
23.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-
falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
23.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
23.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
23.6 Ausschüttungen von Dividenden an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der
Gesellschaft gehaltenen Anteile und im Einklang mit möglichen Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaf-
tern.
23.7 Neben denjenigen Rechten, die ihnen gemäß dem Gesetz zustehen, haben die Gesellschafter zusätzlich diejenigen
Auskunftsrechte, die ihnen gemäß möglichen Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern zustehen.
Art. 24. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
24.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag soll gegebenenfalls verteilt werden und darf nicht die Summe der seit dem
Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und
ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage
zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
24.2 Abschlagsdividenden, die vom Rat der Geschäftsführer im Einklang mit Artikel 24.1 ausgeschüttet werden, müssen
von der ordentlichen Gesellschafterversammlung auf der Grundlage des Jahresabschlusses des jeweiligen Geschäftsjahres
bestätigt werden.
24.3 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-
mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation.
25.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
25.2 Der Liquidationserlös wird im Einklang mit den anwendbaren Bestimmungen von Gesellschaftervereinbarungen,
die die Gesellschafter mitunter miteinander eingehen, verteilt.
H. Schlussbestimmungen
Art. 26. Anwendbares Recht.
26.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter mitunter mit der Gesellschaft eingehen und durch die
bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten.
26.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Art. 27. Salvatorische Klausel.
27.1 Darüber hinaus gelten die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften für Gesellschaften.
27.2 Diese Satzung bleibt auch dann wirksam, wenn sich eine ihrer Bestimmungen als unwirksam erweist. Die unwirk-
same Bestimmung wird ergänzt oder uminterpretiert, so dass dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung
entsprochen wird. Dies gilt auch, wenn sich während der Anwendung der Satzung herausstellen sollte, dass diese eine
auszufüllende Regelungslücke enthält.“
7. Abberufung von (i) Herrn Christian Senitz als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft, (ii) Herrn Ulrich
Binninger als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft und (iii) Herrn Julien De Mayer als Geschäftsführer der
Kategorie B der Gesellschaft und anschließende Ernennung mit sofortiger Wirkung von (i) Herrn Julien De Mayer als
Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft für unbegrenzte Dauer, (ii) Herrn Hanno Stegmann als Geschäftsführer
der Kategorie A der Gesellschaft für unbegrenzte Dauer sowie von (iii) Herrn Jose Benjamin S. Fernandez als Geschäfts-
führer der Kategorie B der Gesellschaft für unbegrenzte Dauer.
161116
L
U X E M B O U R G
8. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie Frau
Magdalena Staniczek zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit un-
eingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
9. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse und ersucht die unterzeichnende Notarin, diese zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Namen der Gesellschaft von „Digital Services XLI S.à r.l.“ in „Philip-
pines Internet Holding S.à r.l.“ zu ändern und Artikel eins (1) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr
wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel zwei (2) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr
wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, iCommerce, vorbenannt, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft anzu-
nehmen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag
von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) um einen Betrag von siebentausendfünfhundert Euro (EUR 7.500) auf einen
Betrag von zweiundzwanzigtausendfünfhundert Euro (EUR 22.500) durch die Ausgabe von siebentausendfünfhundert
(7.500) neuen Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die siebentausendfünfhundert (7.500) neuen Anteilen wurden vollständig von iCommerce, vorbenannt, zum Preis von
siebentausendfünfhundert Euro (EUR 7.500) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die von iCommerce, vorbenannt, gezeichneten siebentausendfünfhundert (7.500) neuen Anteilen wurden vollständig
eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von siebentausendfünfhundert Euro (EUR 7.500).
Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde der unterzeichnenden Notarin
erbracht.
Die gesamte Einlage in Höhe von siebentausendfünfhundert Euro (EUR 7.500) wird vollständig dem Gesellschaftska-
pital der Gesellschaft zugeführt.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf Punkt eins (5.1) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher
nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der
Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Christian Senitz als Geschäftsführer der Kategorie A
der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung zur Kenntnis und beschließt, ihm Entlastung für die Ausführung seines Mandats
zu erteilen.
Die Gesellschafterversammlung nimmt zudem den Rücktritt der folgenden Personen als Geschäftsführer der Kategorie
B der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung zur Kenntnis und beschließt, ihnen Entlastung für die Ausführung ihrer Mandate
zu erteilen:
- Herr Ulrich Binninger; und
- Herr Julien De Mayer.
Anschließend beschließt die Gesellschafterversammlung, die folgenden Personen mit sofortiger Wirkung und für un-
begrenzte Dauer als Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen:
- Herr Hanno Stegmann, geboren am 24. Oktober 1980 in Hamburg, Deutschland, geschäftsansässig in 03-10, Podium
B, Bestway Building, 12 Prince Edward Rd, Singapur 079212, Singapur, als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesell-
schaft;
161117
L
U X E M B O U R G
- Herr Julien De Mayer, geboren am 9. April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft; und
- Herr Jose Benjamin S. Fernandez, geboren am 22. Oktober 1961 in Manila, Philippinen, geschäftsansässig in 12/F
Anson's Building, 23 ADB Ave., Ortigas Center, Pasig City 1605, Philippinen, als Geschäftsführer der Kategorie B der
Gesellschaft.
Infolge des vorangehenden Beschlusses setzt sich der Rat der Geschäftsführer wie folgt zusammen:
- Herr Hanno Stegmann, Geschäftsführer der Kategorie A;
- Herr Julien De Mayer, Geschäftsführer der Kategorie A; und
- Herr Jose Benjamin S. Fernandez, Geschäftsführer der Kategorie B.
<i>Achter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet
seiner Kategorie, sowie Frau Magdalena Staniczek, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und
mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare oder Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr zweitausendzweihundert Euro (EUR 2.200.-) geschätzt.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notarin mit Namen, Vorn-
amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten der erschienenen
Parteien unterzeichnet worden.
Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/32925. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 20. Oktober 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015172393/962.
(150190620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.
DRD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2412 Luxembourg, 36, Rangwee.
R.C.S. Luxembourg B 150.467.
<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle tenue le 16 octobre 2015i>
Nomination de Daniel PUPITA, né le 24 août 1962 à Esch-sur-Alzette et demeurant au 30, Cité op Hudelen, L-3863
Schifflange; Nello CUDA, né le 05 décembre 1972 à Funtani (Italie), demeurant au 1A rue de Schlammestee, L-3397
Roeser (Luxembourg); Erina GLOTOVA, née le 12 octobre 1972 à Persianovka (Russie), demeurant au 30, Cité op Hudelen,
L-3863 Schifflange, comme administrateurs de la société.
Nomination de ACCOUNTIS S.à r.l. (anciennement FJMF&CIE s.à r.l.), ayant son siège au 63-65, Rue de Merl à L-2146
Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le N° B60 219.
Tous les mandats viendront à échéance au cours de l'assemblée générale annuelle de 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
DRD S.A.
Référence de publication: 2015171086/18.
(150189752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
161118
L
U X E M B O U R G
Euro Growth Investment S.A., Société Anonyme de Titrisation.
R.C.S. Luxembourg B 133.616.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 15 octobre 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère
Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme EURO
GROWTH INVESTMENT s.a., dont le siège social à L-1510 Luxembourg, 38, rue de la Faïencerie, avait été dénoncé en
date du 1
er
octobre 2008, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B133616,
ordonnée en liquidation par jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, du 20 novembre
2014.
Pour extrait conforme
Me Anthony Préel
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015171122/17.
(150189361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
AG.IR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 179.704.
L'an deux mil quinze, le deux octobre,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
ont comparu:
Monsieur Alexandre POTY, gérant de société, né à Namur, Belgique, le 10 février 1972, demeurant à L-9838 Hosingen,
8A, Am Becherduerf, et
Madame Geneviève PIRET, gérante de société, née à Verviers, Belgique, le 08 février 1967, demeurant à B-4802
Verviers, 43, Jean Gôme,
représentés par Monsieur Florent REMOLU, comptable, demeurant à Thionville, en vertu de deux procurations sous
seing privé jointes.
Après avoir établi, au moyen de l'acte de constitution qu'ensemble ils possèdent toutes les 100 parts de la société à
responsabilité limitée AG.IR s.à r.l., dont le siège social se trouvait à L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves, inscrite
au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 179704,
constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 08
août 2013, publié au Mémorial C numéro 2544 du 12 octobre 2013,
et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés,
les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont requis le notaire d'acter comme suit les
résolutions suivantes:
Siège social:
Le siège de la société est transféré à L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.
La première phrase de l'article 5 des statuts est modifiée en conséquence comme suit:
«Le siège social est établi dans la Commune de Koerich.»
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, lesdits comparants
ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute, après s'être identifiés au moyen de leur carte d'identité.
Signé: F. Remolu, C. Mines.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 5 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/31728. Reçu soixante-quinze euros.
75,-€
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR COPIE CONFORME.
Capellen, le 15 octobre 2015.
Référence de publication: 2015171716/37.
(150190276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
161119
L
U X E M B O U R G
Inside Project Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9560 Wiltz, 118, rue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 183.760.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L-9560 Wiltz, le 30 août 2015.
Thierry TORDEURS
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2015171262/12.
(150189785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
LuxCap Taunus GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 193.465.
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am sechsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich.
Ist erschienen:
die Aktiengesellschaft LUXEMBURG CAPITAL VALUE mit Gesellschaftssitz in L-1470 Luxembourg, 7, route d‘Esch
und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B161590,
hier vertreten durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates Herr Fernand SASSEL, expert-comptable, und Herrn Mirko
FISCHER, Geschäftsführer, beide beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Welche Komparentin, den unterzeichneten Notar ersucht, Folgendes zu beurkunden:
Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, ist alleinige Teilhaberin der Gesellschaft "LuxCap Taunus GmbH" mit Sitz
in L-1470 Luxembourg, 7, route d‘Esch, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B193.465,
gegründet gemäß notarieller Urkunde am 23. Dezember 2014, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 399 vom 13. Februar 2015.
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR), eingeteilt in einhundert (100) Anteile
zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125.- EUR) vollständig eingezahlt.
Alsdann erklärt der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse zu dokumentieren:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung aufgelöst und liquidiert.
<i>Zweiter Beschlussi>
Zum Liquidator wird ernannt Herr Mirko FISCHER, Geschäftsführer, wohnhaft in L-1420 Luxembourg, 26, avenue
Gaston Diderich.
Der Liquidator hat sämtliche Befugnisse, die Artikel 144 und folgende des Luxemburgischen Gesetzes über die Han-
delsgesellschaften vom 10. August 1915 für einen Abwickler vorsehen mit der Maßgabe, dass er die in Artikel 145
angesprochenen Abwicklungs- und Rechtsgeschäfte ohne Genehmigung der Aktionäre vornehmen kann.
Der Liquidator ist nicht gehalten, Inventar vorzunehmen und kann sich auf die Bücher und Konten der Gesellschaft
berufen.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. SASSEL, M. FISCHER, Patrick SERRES.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 09 octobre 2015. Relation: GAC/2015/8600. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, erteilt.
Remich, den 20. Oktober 2015.
Référence de publication: 2015172006/42.
(150190066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
161120
L
U X E M B O U R G
Meigerhorn Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 117.988.
<i>Extrait des résolutionsi>
Il résulte d'une résolution de l'associé unique de la Société prise en date du 7 octobre 2015 que la société Pricewate-
rhouseCoopers, une société civile de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B 65.477, a été
nommée en tant que réviseur d'entreprise agrée de la Société, avec effet au 1
er
janvier 2014.
Le mandat de PricewaterhouseCoopers viendra à échéance lors de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels
2015 de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Senningerberg, le 19 octobre 2015.
Référence de publication: 2015171403/17.
(150189515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
Blue Moon Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 179.299.
L'an deux mil quinze, le vingt-quatre septembre.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange,
A comparu:
- Monsieur Frédéric ALBERT, consultant informatique, né le 10 novembre 1972, à Aye (Belgique), demeurant à B-6920
Wellin (Belgique), 177, rue de Beauraing.
Lequel comparant est l'unique associé de «BLUE MOON CONSULT S.à.r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité
limitée ayant son siège social à L-4963 Clémency, 9bis, rue Basse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 179.299, constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 3 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2359
du 25 septembre 2013, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.
Lequel comparant, représentant l'intégralité du capital social de la Société, agissant en lieu et place de l'assemblée
générale extraordinaire, a requis le notaire instrumentant d'acter l'unique résolution prise suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'associé unique décide de transférer le siège de la Société de L-4963 Clémency, 9bis, rue Basse, à L-2449 Luxembourg,
10, Boulevard Royal, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 5 des statuts comme suit:
« Art. 5. (alinéa 1
er
). Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
(...)».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à
sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à EUR 995,-.
Fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état
et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: ALBERT, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 05 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/31761. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 20 octobre 2015.
Référence de publication: 2015171761/37.
(150190090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
161121
L
U X E M B O U R G
TransAtlantic Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 90.477.
Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 2015.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2015171613/14.
(150189472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
Tyco Electronics Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 122.078.
Les comptes annuels au 26 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015171616/10.
(150188940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
Target, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3850 Schifflange, 29, avenue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 137.094.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour TARGET, S.à r.l.
i>Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2015171617/12.
(150189128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
Transwave S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
R.C.S. Luxembourg B 176.056.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 09 octobre 2015 que:
Le siège social de la société est transféré du 1, Place du Théâtre L-2613 Luxembourg au 3, rue de la Loge L-1945
Luxembourg.
L'adresse de la société YACHT REGISTRATION ASSOCIATES S.A. ainsi que celle de son représentant Madame
Nina MEYER et de la SOCIETE DE GESTION COMPTABLE SARL sont transférées également du 1, Place du Théâtre
L-2613 Luxembourg au 3, rue de la Loge L-1945 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 octobre 2015.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015171634/18.
(150189566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
161122
L
U X E M B O U R G
BMS Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7391 Blaschette, 14, rue de Fischbach.
R.C.S. Luxembourg B 119.214.
<i>Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 2015i>
L'Assemblée générale du 16 octobre 2015 a décidé de prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'accepter la démission du poste d'administrateur de:
- Monsieur Jean-Marie MATHGEN
- Madame Marianne SCHNELL
- Monsieur Andreas PERUZZI-SCHNELL
avec effet immédiat.
L'assemblée générale décide d'accepter la démission du poste d'administrateur-délégué de:
- Monsieur Jean-Marie MATHGEN
avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée générale décide de nommer:
- Monsieur David WEIS, économiste, né le 13 octobre 1977 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-1513 Luxembourg, 42,
boulevard Prince Félix,
- Monsieur Hervé SYBERTZ, ingénieur, né le 19 mai 1975 à Luxembourg, demeurant à L-1513 Luxembourg, 42,
boulevard Prince Félix,
- Madame Stéphanie HEUSCHLING, née le 23 février 1978 à Luxembourg, L-1513 Luxembourg, 42, boulevard Prince
Félix, au poste d'administrateur pour une durée de six ans c'est-à-dire jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire
se tenant en 2021.
Par ailleurs,
- Monsieur David WEIS, économiste, né le 13 octobre 1977 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-1513 Luxembourg, 42,
boulevard Prince Félix,
Est nommé au poste d'administrateur-délégué pour une durée de six ans c'est-à-dire jusqu'à la tenue de l'Assemblée
Générale Ordinaire se tenant en 2021.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 16 octobre 2015.
Référence de publication: 2015171762/34.
(150190596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
Bone & Joint Research S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 36.928.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2015.
GERARD Rachel.
Référence de publication: 2015171763/10.
(150189992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
Choeur de Chambre de Luxembourg, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2215 Luxembourg, 4, rue de Neuerburg.
R.C.S. Luxembourg F 9.760.
L'article 15 des statuts est modifié comme suit:
Le comité se compose de 5 à 8 membres, à savoir:
- un président
- un vice-président
- un secrétaire
- un trésorier
161123
L
U X E M B O U R G
à désigner par le comité au sein de ses membres
- 1-3 assesseurs,
- un directeur musical, qui s'adjoint d'office au comité et qui a droit de vote au comité.
Référence de publication: 2015171781/16.
(150190290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
Charleston Infrastructure III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 184.131.
<i>Extrait des résolutions des associés en date du 6 octobre 2015i>
Les associés de la Société ont décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Jens Hoellermann de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 15 octobre 2015.
- de nommer Andrea Pabst, née le 6 avril 1974 à Gladbeck, Allemagne et résidant professionnellement au 23, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, aux fonctions de gérante de la Société avec effet au 15
octobre 2015 et ce pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 15 octobre 2015.
Référence de publication: 2015171780/15.
(150190260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
TNN Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 68.364.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 07 septembre 2015
que:
- La démission de M. Alain LE JEUNE de son mandat de Commissaire aux comptes a été acceptée;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 septembre 2015.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015171628/15.
(150189760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
Transport Pinto & Silva S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4595 Differdange, 26, rue Kalekerbach.
R.C.S. Luxembourg B 200.788.
STATUTS
L'an deux mille quinze.
Le cinq octobre.
Pardevant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange.
A COMPARU
Madame Lurdes PEREIRA DA SILVA, femme de charge, né à Marvila Lisboa (Portugal), le 09 mars 1966, demeurant
à L-4595 Differdange, 26, rue Kalekerbach.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée
unipersonnelle, qu'elle déclare constituer.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:
Transport Pinto & Silva S. à r.l.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de transport routier national et international de marchan-
dises.
161124
L
U X E M B O U R G
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement.
Art. 3. Le siège de la société est établi dans la commune de Differdange.
Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-), représenté par CENT (100)
PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui détermi-
neront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la cession
entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous les associés.
La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts
des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas nécessaire
en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte,
requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des as-
semblées générales.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que l'associé
unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de
l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata
du nombre de leurs parts.
Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2015.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Madame Lurdes PEREIRA DA SILVA, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS
EUROS (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la société
en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENT EUROS (EUR 900,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les statuts de la société ainsi arrêtés, la comparante, unique associée de la société, se considérant comme réunie en
assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:
I.- Est nommée gérante de la société: Madame Lurdes PEREIRA DA SILVA, prénommée.
II.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante.
III.- Le siège social de la société se trouve à: L-4595 Differdange, 26, rue Kalekerbach.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Pereira da Silva, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 octobre 2015. Relation: EAC/2015/23445. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015171612/68.
(150190005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
161125
L
U X E M B O U R G
Telindus, Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 81-83, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 19.669.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1 i>
<i>eri>
<i> octobre 2015i>
Ad 1) Cooptation d'un nouvel administrateur.
Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de coopter à partir de ce jour Monsieur Steve WAMPACH, demeurant
à 34, an der Aa, L-6660 Bom, comme administrateur en remplacement de Monsieur Luc HELSEN. Monsieur WAMPACH
terminera le mandat de Monsieur Luc HELSEN.
Ad 10) Nomination d'un Fondé de Pouvoir.
Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer à partir de ce jour Madame Patricia BETTEMBOURG,
demeurant à 9, Grand' Rue, F-57570 BERG SUR MOSELLE, comme Fondé de Pouvoir. Madame BETTEMBOURG est
ajoutée aux personnes auxquelles fa gestion journalière de la société est confiée.
Pour extrait conforme
Armand MEYERS / Gerard HOFFMANN
<i>Administrateur-délégué / Président et Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2015171620/19.
(150189500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
AZ Electronic Materials S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 27.012.985,50.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 156.074.
Afin de bénéficier de l’exemption prévue à l’article 314 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée, d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion, la Société a déposé auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, à l’appui de ses comptes annuels clos au 31 décembre 2014, déposés préala-
blement au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg le 20 octobre 2015, les comptes consolidés, le rapport
consolidé de gestion ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle de ces comptes, pour l’exercice clos au 31
décembre 2014 de la société Merck KGaA (ci-après «Merck»), une société en commandite par actions (Kommanditge-
sellschaft auf Aktien), constituée selon le droit allemand, ayant son siège social à Frankfurter, Str. 250 D-64293 Darmstadt
(Allemagne), immatriculée au Registre de Commerce auprès du tribunal d’instance (Amtsgericht) de Darmstadt sous le
numéro HR B 6164 et consolidant la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2015.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015171744/21.
(150189919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
Thomas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 177, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 33.819.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour THOMAS S.A.
i>Société anonyme
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2015171622/12.
(150189343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
161126
L
U X E M B O U R G
CarVal GCF Lux Sub Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 185.828.
Die Gesellschafterin hat mit Datum vom 01. Oktober 2015 beschlossen:
1. Die Rücktritte von Herrn Mirko FISCHER und Frau Cécile GADISSEUR von ihren Ämtern als A-Geschäftsführer
der Gesellschaft werden mit sofortiger Wirkung angenommen.
2. Herr Alhard von KETELHODT, geboren am 27. Mai 1961 in D-Bochum, berufliche Anschrift in 196, rue de Beggen,
L-1220 Luxembourg, wird mit sofortiger Wirkung für eine unbestimmte Zeit als neuer A-Geschäftsführer der Gesellschaft
bestellt.
3. Die Rücktritte von Herrn David FRY, Herrn John BRICE und Herrn Peter VORBIRCH von ihren Ämtern als B-
Geschäftsführer der Gesellschaft werden mit sofortiger Wirkung angenommen.
4. Frau Françoise GOOSE, geboren am 3. Oktober 1967 in B-Bastogne, berufliche Anschrift in 196, rue de Beggen,
L-1220 Luxembourg, wird mit sofortiger Wirkung für eine unbestimmte Zeit als neuer B-Geschäftsführer der Gesellschaft
bestellt.
5. Der Sitz der Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung von L-1528 Luxembourg, 11-13 boulevard de la Foire, nach
L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen verlegt.
Référence de publication: 2015171775/20.
(150190531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
BIM Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 200.332.
L'an deux mille quinze, le neuvième jour du mois d'octobre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) des actionnaires de “BIM Luxembourg”, une société anonyme régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 200332, (la “Société”),
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 18 septembre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
L'Assemblée est présidée par Madame Carmen GEORGES, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Lu-
xembourg, 12, rue Jean Engling.
La Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian DOSTERT, clerc
de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social d'un montant de deux millions cent quarante-deux mille euros (EUR 2'142'000) de
manière à porter le capital social de son montant actuel de trente-et-mille euros (EUR 31'000) à un montant de deux millions
cent soixante-treize mille euros (EUR 2'173'000);
2. Émission de deux millions cent quarante-deux mille (2'142'000) nouvelles actions ordinaires d'une valeur nominale
d'un euro (EUR 1) chacune, entièrement libérées, ces nouvelles actions ayant les mêmes droits et privilèges que les actions
existantes et donnant droit à dividende à partir de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décidant de l'aug-
mentation de capital proposée;
3. Souscription et libération de deux millions cent quarante-deux mille (2'142'000) nouvelles actions, d'une valeur
nominale d'un euro (EUR 1) chacune, par un apport en nature d'un montant de deux millions cent quarante-deux mille euros
(EUR 2'142'000);
4. Modification subséquente de l'article 5, alinéa 1, des statuts;
5. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés
sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
161127
L
U X E M B O U R G
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux millions cent quarante-deux mille
euros (EUR 2'142'000) de manière à porter le capital social de son montant actuel de trente et mille euros (EUR 31'000) à
un montant de deux millions cent soixante-treize mille euros (EUR 2'173'000), par la création et l'émission de deux millions
cent quarante-deux mille (2'142'000) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1).
<i>Souscriptioni>
L'Assemblée reconnaît que les deux millions cent quarante-deux mille (2'142'000) actions nouvelles ont été souscrites
par l'associé unique.
<i>Libération de nouvelles actionsi>
L'Assemblée reconnaît que les deux millions cent quarante-deux mille (2'142'000) actions nouvelles souscrites ont été
entièrement libérées par des apports en nature plus amplement décrits dans la convention d'apport datée du 30 septembre
2015 (l'“Apport”).
L'Apport d'un montant de deux millions cent quarante-deux mille euros (EUR 2'142'000) est alloué au compte de capital
social de la Société.
<i>Evaluation - Rapport de l'apporti>
L'Apport a été évalué et décrit dans un rapport, daté du 24 septembre 2015, dressé par “FIDUCIAIRE TG EXPERTS
S.A.”, une société anonyme, avec siège social à L-4284 Ehlerange, Zone Zare Ouest agissant comme réviseur d'entreprises
agréé indépendant au Grand-Duché de Luxembourg, sous la signature de Monsieur Thierry GRUN, conformément aux
articles 26-1 et 32-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
La conclusion dudit rapport est la suivante:
<i>Conclusioni>
“Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des
apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie dans votre
société.”
Ledit rapport, après avoir été signé “ne varietur” par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent
acte afin d'être enregistré avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accepter lesdites souscriptions et lesdites libérations et d'attribuer les deux millions cent quarante-
deux mille (2'142'000) actions nouvelles à l'associé unique conformément au bulletin de souscription.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier l'article 5, alinéa 1, des Statuts afin
de lui donner la teneur suivante:
“ Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions cent soixante-treize mille euros (EUR 2'173'000,-), représenté par
deux millions cent soixante-treize mille (2.173.000) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.”
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, la Présidente a
ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à deux mille huit cents euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, C. GEORGES, C. WERSANDT.
161128
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 13 octobre 2015. 2LAC/2015/22921. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 20 octobre 2015.
Référence de publication: 2015171756/93.
(150190585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
BL Immo Franchising, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 2, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 80.573.
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de dissolution de société, reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date
du 29 septembre 2015, numéro 2015/2246 de son répertoire, enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 7 octobre 2015,
relation: 1LAC/2015/32040 de la société à responsabilité limitée "BL Immo Franchising, s.à r.l.", avec siège social à L-8399
Windhof, 2, rue d'Arlon, inscrite au RCS à Luxembourg sous le numéro B 80 573, constituée suivant acte reçu par Maître
Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 5 février 2001, publié au Mémorial C, numéro 777 du 19
septembre 2001, ce qui suit:
- la société «PORTER INVESTMENTS LIMITED» et Monsieur Mathias VON DER DECKEN, seuls associés, ont
déclaré procéder à la dissolution et à la liquidation de la société prédite, avec effet au 29 septembre 2015,
- la société dissoute n'a plus d'activités.
- les associés ont déclaré en outre que la liquidation de la prédite société a été achevée et qu'ils assument tous les éléments
actifs et passifs éventuels de la société dissoute.
- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années à l'adresse suivante:
L-8364 Hagen, 19, an de Wisen.
Bascharage, le 21 octobre 2015.
Pour extrait conforme
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2015171760/25.
(150190946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
BJR International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 134.743.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 Octobre 2015.
GERARD Rachel.
Référence de publication: 2015171759/10.
(150189993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
Chopin Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 173.919.
Les statuts coordonnés au 12/10/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20/10/2015.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015171782/12.
(150190385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
161129
L
U X E M B O U R G
Evergreen Real Estate Partners Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.999.950,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 121.655.
In the year two thousand and fifteen, on the eighth day of October.
Before Us, Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
- Evergreen Real Estate Partners LLC, a limited liability company established and existing under the laws of the State
of Delaware, United States of America, having its registered office c/o the Corporation Trust Company, Corporation Trust
Center, 1209, Orange street, Wilmington, New Castle, 19801 Delaware, United States of America and registered with the
Secretary of State of the State of Delaware under number 3925447, and
- Mr. Robert Jenner, born on June 5, 1976 in Rinteln, Germany, with personal address at Rua da Holanda 32, 8125-455
Vilamoura-Quarteira, Portugal,
here represented by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of two (2) proxies
given under private seal on 3 and 30 September 2015.
The said proxies, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing persons and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing persons, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)
established and existing under the laws of Luxembourg under the name of “Evergreen Real Estate Partners Europe S.à
r.l.” (the Company), with registered office at 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 121655, established pursuant to a deed
of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, GrandDuchy of Luxembourg, dated October 24, 2006,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2428, dated December 29, 2006, and which
articles of association have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated August 21, 2014, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2972, dated October 16, 2014.
II. The Company’s share capital is set at two million Euro (EUR 2.000.000,-) represented by eighty thousand (80.000)
shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25,-) each.
III. The agenda of the meeting is the following:
1. Repurchase by the Company of the two (2) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25,-) each, held
by Mr. Robert Jenner, prenamed (the RJ Shares).
2. Delegation of power to the board of managers of the Company to determine the modalities and conditions of the
repayment following the repurchase of the RJ Shares.
3. Decrease of the Company’s share capital by an amount of fifty Euro (EUR 50,-) from its current amount of two million
Euro (EUR 2.000.000,-) to one million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred fifty Euro (EUR 1.999.950,-) by
cancellation of the two (2) RJ Shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25,-) held by the Company pursuant
to the above resolutions.
4. Amendment of article 6 of the Company’s bylaws, which shall henceforth read as follows:
“ Art. 6. The share capital is fixed at one million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred fifty Euro (EUR
1.999.950,-), represented by seventy-nine thousand nine hundred ninety-eight (79.998) shares with a nominal value of
twenty-five Euro (EUR 25,-) each.”
IV. The shareholders, after deliberation, unanimously take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to proceed with the repurchase by the Company of the two (2) shares with a nominal value of
twenty-five Euro (EUR 25,-) each, held by Mr. Robert Jenner, prenamed (the RJ Shares).
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolve to empower the board of managers of the Company to determine the modalities and conditions
of the repayment following the repurchase of the RJ Shares.
The repayment may only take place in accordance with the respects of the rights of the eventual/existing creditors of
the Company.
<i>Third resolutioni>
Evergreen Real Estate Partners LLC, prenamed, being the sole shareholder of the Company further to the above reso-
lutions, resolves to decrease the Company’s share capital by an amount of fifty Euro (EUR 50,-) from its current amount
161130
L
U X E M B O U R G
of two million Euro (EUR 2.000.000,-) to one million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred fifty Euro (EUR
1.999.950,-) by cancellation of the two (2) RJ Shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25,-) each held by
the Company pursuant to the above resolutions.
<i>Fourth resolutioni>
Evergreen Real Estate Partners LLC, prenamed, resolves to amend article 6 of the Company’s bylaws, which shall
henceforth read as follows:
“ Art. 6. The share capital is fixed at one million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred fifty Euro (EUR
1.999.950,-), represented by seventy-nine thousand nine hundred ninety-eight (79.998) shares with a nominal value of
twenty-five Euro (EUR 25,-) each.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the
above resolutions are estimated at one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the
above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date first written above.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his full
name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le huitième jour du mois d’octobre.
Par-devant Nous, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
- Evergreen Real Estate Partners LLC, une société à responsabilité limitée établie et existante selon les lois de l’Etat du
Delaware, Etats-Unis, ayant son siège social au Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, New Castle County, DE 19801, Etats-Unis et enregistrée auprès du Secrétaire d’Etat de l’Etat du Delaware
sous le numéro 3925447, et
- Monsieur Robert Jenner, né le 5 juin 1976 à Rinteln, Allemagne, ayant son adresse personnelle à Rua da Holanda 32,
8125-455 Vilamoura-Quarteira, Portugal,
ici représentés par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de deux
(2) procurations données sous seing privé en le 3 et le 30 septembre 2015.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentaire,
demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.
Les comparants, représentés par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparants sont les associés de la société à responsabilité limitée établie et existante au Grand-Duché de Lu-
xembourg sous la dénomination «Evergreen Real Estate Partners Europe S.à r.l.» (la Société), ayant son siège social au
1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121655, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors
notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 24 octobre 2006, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 2428, en date du 29 décembre 2006, et dont les statuts ont été modifiés pour
la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 août 2014, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 2972, en date du 16 octobre 2014.
II. Le capital social de la Société est fixé à deux millions d’Euro (EUR 2.000.000,-), représenté par quatre-vingt-mille
(80.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Rachat par la Société des deux (2) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune,
détenues par M. Robert Jenner, prénommé (les Parts Sociales RJ).
2. Délégation au conseil de gérance de la Société du pouvoir de déterminer les modalités et les conditions du rembour-
sement suite au rachat des Parts Sociales RJ.
3. Réduction du capital social de la Société d’un montant de cinquante Euro (EUR 50,-) afin de le diminuer de son
montant actuel de deux millions d’Euro (EUR 2.000.000,-) à un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent
cinquante Euro (EUR 1.999.950,-) par annulation des deux (2) Parts Sociales RJ d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro
(EUR 25,-) détenues par la Société suite aux résolutions qui précèdent.
161131
L
U X E M B O U R G
4. Modification de l’article 6 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante Euro (EUR
1.999.950,-), représenté par soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (79.998) parts sociales d’une valeur
nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.»
IV. Les associés, après avoir délibéré, prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de procéder au rachat, par la Société, des deux (2) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-
cinq Euro (EUR 25,-) chacune, détenues par M. Robert Jenner, prénommé (les Parts Sociales RJ).
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de donner pouvoir au conseil de gérance de la Société de déterminer les modalités et les conditions
du remboursement suite au rachat des Parts Sociales RJ.
Le remboursement ne pourra s’effectuer qu'en respect des droits des créanciers existants/éventuels de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
Evergreen Real Estate Partners LLC, prénommé, étant l’associé unique de la Société suite aux résolutions qui précèdent,
décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de cinquante Euro (EUR 50,-) afin de le diminuer de son
montant actuel de deux millions d’Euro (EUR 2.000.000,-) à un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent
cinquante Euro (EUR 1.999.950,-) par annulation des deux (2) Parts Sociales RJ d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro
(EUR 25,-) détenues par la Société suite aux résolutions qui précèdent.
<i>Quatrième résolutioni>
Evergreen Real Estate Partners LLC, prénommé, décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société afin de lui donner
la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante Euro (EUR
1.999.950,-), représenté par soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (79.998) parts sociales d’une valeur
nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à la somme de mille cent Euro (EUR 1.100,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des com-
parants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par son nom et prénom, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 13 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/32600. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 16 octobre 2015.
Référence de publication: 2015172425/152.
(150191187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.
Thomas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 177, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 33.819.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
161132
L
U X E M B O U R G
<i>Pour THOMAS S.A.
i>Société anonyme
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2015171623/12.
(150189368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
Thomas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 177, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 33.819.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour THOMAS S.A.
i>Société anonyme
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2015171624/12.
(150189387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
Vermillion Aviation Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 191.853.
In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of October,
Before the undersigned, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg (the
"Notary"),
THERE APPEARED
Vermillion Aviation Holdings Limited, a private company limited by shares, governed by the laws of Hong Kong, whose
registered office is at 30
th
Floor, Jardine House, one Connaught Place, Central, Hong Kong and registered with the
Companies Registry of Hong Kong under the number 2162059 (the "Sole Shareholder"),
here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by
virtue of a proxy given on 6 October 2015 under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
I. The appearing party, represented as stated above, is currently the sole shareholder of Vermillion Aviation Finance S.à
r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limité) whose registered office is at 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 191853 (the "Company") incorporated pursuant to a deed of Maître Jean
Seckler, notary residing in Junglinster, dated 4 November 2014, whose articles of association (the "Articles") have been
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") on 4 December 2014, number 3710,
page 178059 and have been amended for the last time on 29 July 2015 pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary
residing in Junglinster, published in the Mémorial on 30 September 2015, number 2668, page 128042.
II. Article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended (the "1915 Law")
("Article 200-2") provides that the sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the
general meeting of shareholders of the company, and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn
up in writing.
III. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
(a) To increase the share capital of the Company by an amount of forty five thousand seven hundred twenty five US
Dollars (USD 45,725.-) so as to bring it from its current amount of two million five hundred seventy one thousand two
hundred and eight US Dollars (USD 2,571,208.-) to two million six hundred sixteen thousand nine hundred thirty three US
Dollars (USD 2,616,933.-) by creating and issuing forty five thousand seven hundred twenty five (45,725) new shares to
be fully subscribed and paid up by its Sole Shareholder through a contribution in cash for an aggregate amount of forty
five thousand seven hundred twenty five US Dollars (USD 45,725.-);
(b) To amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the above resolution;
(c) Miscellaneous.
161133
L
U X E M B O U R G
IV. The Sole Shareholder, acting in its capacity of sole existing shareholder of the Company, hereby passes the following
written resolutions in accordance with Article 200-2 before the Notary:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of forty five thousand
seven hundred twenty five US Dollars (USD 45,725.-) so as to bring it from its current amount of two million five hundred
seventy one thousand two hundred and eight US Dollars (USD 2,571,208.-) to two million six hundred sixteen thousand
nine hundred thirty three US Dollars (USD 2,616,933.-) by creating and issuing forty five thousand seven hundred twenty
five (45,725) new shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, having the same rights and
features as those attached to the existing shares (the "New Shares").
<i>Subscription and paymenti>
The Sole Shareholder declares to subscribe and fully pay in for the New Shares a total amount of forty five thousand
seven hundred twenty five US Dollars (USD 45,725.-) by a contribution in cash of an aggregate amount of forty five
thousand seven hundred twenty five US Dollars (USD 45,725.-) (the "Contribution").
The proof of the existence and of the value of the Contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
Further to the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, which shall now read
as follows:
" 5.1. The share capital of the Company is two million six hundred sixteen thousand nine hundred thirty three US Dollars
(USD 2,616,933.-) divided into two million six hundred sixteen thousand nine hundred thirty three (2,616,933) shares with
a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders" means the holders at
the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly."
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are assessed to EUR 1,300.-.
The contribution is valued at EUR 40,761.50-.
The present deed is drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this document.
The Notary who speaks and understands English and French, states herewith that the present deed is worded in English,
followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the Notary by name, first name,
civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the Notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le sept octobre,
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU
Vermillion Aviation Holdings Limited, société à responsabilité limitée, soumise aux lois de Hong Kong, ayant son siège
social au 30
th
Floor, Jardine House, one Connaught Place, Central, Hong Kong et immatriculée auprès du registre des
sociétés de Hong Kong sous le numéro 2162059 (1'"Associé Unique"),
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Lu-
xembourg, en vertu d'une procuration délivrée le 6 octobre 2015 sous seing privée.
Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera
attachée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.
I.- Laquelle partie comparante est l'associé unique de Vermillion Aviation Finance S.à r.l., une société à responsabilité
limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 191853, constituée par un acte notarié du notaire soussigné, en date du 4 novembre 2014 et dont les
statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") le 4 décembre
2014, numéro 3710, page 178059, et ont été modifiés pour la dernière fois le 29 juillet 2015 par un acte du notaire Maître
Jean Seckler, notaire résidant à Junglinster, publié au Mémorial le 30 septembre 2015, numéro2668, page 128042.
II.- L'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la "Loi
de 1915") ("Article 200-2") prévoit que l'associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de
l'assemblée générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès-
verbal ou rédigées par écrit.
161134
L
U X E M B O U R G
III.- L'agenda de l'assemblée est le suivant:
<i>Agendai>
(a) Augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de quarante-cinq mille sept cents vingt-cinq
Dollars des Etats-Unis (USD 45,725,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent soixante-et-onze
mille deux cent huit Dollars des Etats-Unis (USD 2,571,208,-) à deux millions six cent seize mille neuf cent trente-trois
Dollars des Etats-Unis (USD 2,616,933,-) par l'émission de quarante-cinq mille sept cents vingt-cinq (45,725) nouvelles
parts sociales émises et entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total de quarante-cinq mille sept
cents vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 45,725,-),
(b) Modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la résolution précédente,
(c) Divers.
IV- L'Associé Unique, agissant en sa capacité d'associé unique de la Société, requiert le Notaire d'acter les résolutions
suivantes prises conformément aux dispositions de l'article 200-2.
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de quarante-cinq mille
sept cents vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 45'725,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq
cent soixante-et-onze mille deux cent huit Dollars des Etats-Unis (USD 2'571'208,-) à un montant de deux millions six cent
seize mille neuf cent trente-trois Dollars des Etats-Unis (USD 2'616'933,-) par la création et l'émission de quarante-cinq
mille sept cents vingt-cinq (45'725) nouvelles parts sociales, chacune ayant une valeur nominale d'un Dollar des Etats Unis
(USD 1,-) et ayant les mêmes caractéristiques et droits tels que définis dans les Statuts (les "Nouvelles Parts Sociales").
<i>Souscription et libérationi>
L'Associé Unique déclare souscrire et entièrement libérer les Nouvelles Parts Sociales pour un montant total de quarante-
cinq mille sept cents vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 45'725,-) par un apport en numéraire d'un montant total de
quarante-cinq mille sept cents vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 45'725,-) (l"'Apport")
La preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport a été apportée au notaire soussigné.
<i>Seconde résolutioni>
Suite à la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, lequel sera désormais rédigé
comme suit:
Le capital social est fixé à deux millions six cent seize mille neuf cent trente-trois Dollars des Etats-Unis (USD
2'616'933,-) représenté par deux millions six cent seize mille neuf cent trente-trois (2'616'933) parts sociales ayant une
valeur nominale d'un Dollar US (USD 1,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents Statuts, "Associés" signifie les
détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associé" doit être interprété conformément".
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ 1.300,- EUR.
L'apport a été évalué à 40.761,50- EUR
Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise,
suivi d'une version française, à la requête de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Fait et passé à Junglinster, à la date figurant en tête des présents.
L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence,
le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 13 octobre 2015. Relation GAC/2015/8666. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Claire PIERRET.
Référence de publication: 2015172188/138.
(150190107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
161135
L
U X E M B O U R G
Thomas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 177, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 33.819.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 décembre 2013i>
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale nomme comme commissaire aux comptes Madame Marie-Laure MANTZ résidant 181, Grand-
Rue - F-57050 Lorry-Les-Metz en remplacement de BDO TAX & ACCOUNTING, qui accepte, pour une période de six
ans. L'exécution de son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire 2019 statuant sur l'exercice 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.
<i>POUR L'ASSEMBLEE GENERALE
i>THOMAS SA
Signature
Référence de publication: 2015171625/17.
(150189590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.
Investindustrial Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 172.686.
Le bilan au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2015171951/11.
(150190326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
Investindustrial Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 172.686.
Le bilan au 31 Décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2015171952/11.
(150190335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
Investindustrial Industries S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J. F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 187.868.
Le bilan au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2015171953/11.
(150190328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
161136
AG.IR S.à r.l.
Argentarius Securisation Fund Management S.a.r.l.
Arran Investment S.à r.l.
AZ Electronic Materials S.à.r.l.
BIM Luxembourg
BJR International S.A.
BL Immo Franchising, s.à r.l.
Blue Moon Consult S.à r.l.
BMS Immo S.A.
Bone & Joint Research S.A.
CarVal GCF Lux Sub Holdings S.à r.l.
Casino Developpement Europe Sàrl
Charleston Infrastructure III S.à r.l.
China Fortune Group
Choeur de Chambre de Luxembourg
Chopin Holdings S.à r.l.
Daniel Frères Immobilière S.à.r.l.
Digital Services XLI S.à r.l.
DRD S.A.
Euro Growth Investment S.A.
Evergreen Real Estate Partners Europe S.à r.l.
Inside Project Management S.à r.l.
Investindustrial Development S.A.
Investindustrial Development S.A.
Investindustrial Industries S.A.
LuxCap Taunus GmbH
Meigerhorn Properties S.à r.l.
Philippines Internet Holding S.à r.l.
Target, S.à r.l.
Telindus
Thomas S.A.
Thomas S.A.
Thomas S.A.
Thomas S.A.
TNN Capital S.A.
TransAtlantic Partner S.à r.l.
Transport Pinto & Silva S. à r.l.
Transwave S.A.
Tyco Electronics Holding S.à r.l.
Vermillion Aviation Finance S.à r.l.
Victoriosa S.A.
Vocatus S.à r.l.