logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3264

4 décembre 2015

SOMMAIRE

1741 Specialised Investment Funds SICAV  . .

156640

2 F Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156630

2 IH S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156630

2 IH S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156631

Agamemnon S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156672

Axius European CLO S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

156671

D'co S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156652

Dété Publicité & Communication S.à.r.l.  . . . .

156652

Electro-Team S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156631

First Atlas (IX) Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156631

FN International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156631

Fox III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156659

GP-2 Munich B LBC Vesta S.à r.l.  . . . . . . . . .

156655

GP-5 Berlin LBC Vesta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

156657

Groupe HALBERG S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156632

Holdinter Spf S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156627

ICG EFV Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

156663

International Audit Services S.à r.l.  . . . . . . . .

156627

Internationale Maklergesellschaft Luxemburg

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156627

JMW Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156652

Lark Corporation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156626

LBP Luxco GP 1-Hanover S.à r.l.  . . . . . . . . . .

156661

LinguaLux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156627

Loreca Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

156626

Lumasa SA SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156626

Marea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156640

Masterton S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156626

QU2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156645

Qubica Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156648

Roast S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156627

Telekabel Enterprise S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

156632

Tonic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156626

UBM CP Holdings No 4 S.à.r.l  . . . . . . . . . . . . .

156628

UBM IP Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

156627

UBS (Lux) Real Estate - Euro Core Feeder

Fund (CHF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156628

United Commonwealth Holdings S. à r.l.  . . . .

156628

Vasanta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156629

Vasanta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156629

Vasto Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156629

Vincent Vega S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156630

Waasserkraaft Wampach, s.à r.l. . . . . . . . . . . .

156629

Worms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156629

W-Treize SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156630

Yellow Sky S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156628

Zeta Tre Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156630

Zikostar Barbershop Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . .

156630

156625

L

U X E M B O U R G

Masterton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 179, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 167.817.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015168472/9.
(150185876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2015.

Lumasa SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 16.398.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUMASA SA SPF
Société Anonyme, Société de Gestion de Patrimoine Familial

Référence de publication: 2015168466/11.
(150185768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2015.

Lark Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 62.604.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LARK CORPORATION S.A.

Référence de publication: 2015168457/10.
(150185984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2015.

Loreca Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 173.429.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Loreca Investments S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015168450/11.
(150185605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2015.

Tonic S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 20.413.

Veuillez noter que le siège de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58545, se

situe désormais à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 12 octobre 2015.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour TONIC S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2015168064/13.
(150184618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

156626

L

U X E M B O U R G

LinguaLux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.

R.C.S. Luxembourg B 121.585.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 13 octobre 2015.

Référence de publication: 2015168444/10.
(150186022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2015.

Internationale Maklergesellschaft Luxemburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 140.725.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015168416/10.
(150185895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2015.

International Audit Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 75.354.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015168415/9.
(150185908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2015.

Holdinter Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 17.282.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2015.

HOLDINTER SPF S.A.
Marcus Jacobus Dijkerman
<i>Director

Référence de publication: 2015168388/13.
(150186089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2015.

UBM IP Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Roast S.à r.l.).

Capital social: USD 8.000.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 83.486.

L'adresse du Gérant, Monsieur Nick Perkins a changé et sera dès lors au 240 Blackfriars Road, London SE1 8BF,

Royaume-Uni.

Luxembourg, le 12 octobre 2015.

Pour avis sincère et conforme

Référence de publication: 2015168079/12.
(150184612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

156627

L

U X E M B O U R G

UBM CP Holdings No 4 S.à.r.l, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1224 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 192.802.

L'adresse du Gérant, Monsieur Nicholas Michael Perkins a changé et sera dès lors au 240 Blackfriars Road, London

SE1 8BF, Royaume-Uni.

Luxembourg, le 12 octobre 2015.

Pour avis sincère et conforme

Référence de publication: 2015168078/12.
(150184609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

UBS (Lux) Real Estate - Euro Core Feeder Fund (CHF), Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 144.181.

L'adresse du siège social de UBS (Lux) Real Estate - Euro Core Feeder Fund (CHF) SICAV-FIS a changé de 2-8 avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg avec date d'effet au 28 septembre 2015.

Luxembourg, le 12 octobre 2015.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Référence de publication: 2015168080/12.
(150184989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

United Commonwealth Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 216.713.300,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 96.558.

L'adresse du Gérant, Monsieur Nick Perkins a changé et sera dès lors au 240 Blackfriars Road, London SE1 8BF,

Royaume-Uni.

Luxembourg, le 12 octobre 2015.

Pour avis sincère et conforme

Référence de publication: 2015168077/12.
(150184611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Yellow Sky S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 183.076.

Il résulte de deux actes de cession du 22 septembre 2015:
- que 10% des parts sociales de la Société (i.e. 1.250) détenues par la société «INVENTA (Luxembourg) S.A.», ayant

son siège social au L-2520 Luxembourg, 51, Allée Scheffer, RCS B 57196 ont été cédées à la société «EICOM GmbH»,
ayant son siège social à D-63303 Dreieich, Alpenstrasse 2b, enregistrée au Registre de Commerce Offenbach am Main
sous le numéro HRB 45370;

- que 10% des parts sociales de la Société (i.e. 1.250) détenues par la société «INVENTA (Luxembourg) S.A.», ayant

son siège social au L-2520 Luxembourg, 51, Allée Scheffer, RCS B 57196 ont été cédées à la société «AKGK GmbH»,
ayant son siège social à D-60323 Frankfurt, Kronberger Strasse 19, enregistrée au Registre de Commerce Offenbach am
Main sous le numéro HRB 45423;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015168120/18.
(150184739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

156628

L

U X E M B O U R G

Waasserkraaft Wampach, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8710 Boevange-sur-Attert, 23, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 111.514.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour WAASSERKRAAFT WAMPACH SARL
Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2015168102/12.
(150184705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Worms, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.633.

Il est à noter que l'adresse de Mr. Nicholas Clive-Worms, administrateur de la Société, se trouve désormais au 12,

Promenade John-Berney, 1180 Rolle, Suisse.

Luxembourg, le 12 octobre 2015.

Luxembourg Corporation Company SA
Signature

Référence de publication: 2015168101/12.
(150185077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Vasto Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 132.147.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015168086/10.
(150185154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Vasanta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 175.130.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015168085/10.
(150185327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Vasanta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 175.130.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015168084/10.
(150185326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

156629

L

U X E M B O U R G

2 F Participations, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 118.581.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015168128/9.
(150184876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

2 IH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 166.153.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015168129/9.
(150185426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Zikostar Barbershop Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2157 Luxembourg, 2, rue 1900.

R.C.S. Luxembourg B 162.451.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015168127/9.
(150185213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Zeta Tre Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 146.347.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015168126/9.
(150185132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

W-Treize SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4178 Esch-sur-Alzette, 4-6, rue Pierre Goedert.

R.C.S. Luxembourg B 164.050.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015168100/9.
(150185517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Vincent Vega S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Jans.

R.C.S. Luxembourg B 131.162.

Le bilan au 30 juin 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015168094/9.
(150184805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

156630

L

U X E M B O U R G

FN International, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 10.380.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FN INTERNATIONAL
Un mandataire

Référence de publication: 2015168344/11.
(150185718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2015.

First Atlas (IX) Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame.

R.C.S. Luxembourg B 162.190.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2015.

Référence de publication: 2015168328/10.
(150185707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2015.

Electro-Team S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1726 Luxembourg, 34, rue Pierre Hentges.

R.C.S. Luxembourg B 103.573.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015168307/9.
(150185643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2015.

2 IH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 166.153.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 10 juin 2015

Sont nommés administrateurs, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2015:

<i>Administrateurs catégorie A:

- Monsieur Gérard MENUDIER, dirigeant de société, demeurant au 40, rue de l'Etraye, F - 88160 Ramonchamps, France,

Président;

- Monsieur Bernard LEHMANN, gérant de société, demeurant au 2, rue Salzmann, F - 67000 Strasbourg, France.

<i>Administrateurs catégorie B:

- Monsieur Gerdy ROOSE, ingénieur commercial et maître en gestion fiscale, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg;

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, L - 1653 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2015:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 9, rue du Laboratoire, L - 1911 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2015.

Référence de publication: 2015168130/24.
(150185435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

156631

L

U X E M B O U R G

Groupe HALBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 146.567.

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

de notre Société qui se tiendra le <i>30 décembre 2015 à 9:30 heures au siège à Luxembourg, 6, rue Heine.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et l'affectation des résultats au 31 décembre 2013 et au 31

décembre 2014;

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Question de la dissolution anticipée de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915;
5. Elections statutaires;
6. Divers.

Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes dans l'impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, vous

pouvez vous faire représenter par une personne de votre choix muni d'un pouvoir régulier.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015193159/20.

Telekabel Enterprise S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 10.000.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 153.938.

Teil I.

PrimaCom Holding GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftssitz: D-04356 Leipzig, Messe-Allee 2
Gezeichnetes Kapital: EUR 160.858,00
Amtsgericht Leipzig, HRB 28071
„übernehmende Gesellschaft“
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am siebenundzwanzigsten Tag des Monats November.
Sind vor Maître Jean Paul Meyers, Notar mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIENEN:

1. Der Geschäftsführer, handelnd für die Gesamtheit der Geschäftsführung der PrimaCom Holding GmbH, einer Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland, die im
Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter der Nummer HRB 28071 eingetragen ist und ihren Sitz in Leipzig hat,
Geschäftsanschrift: Messe-Allee 2, 04356 Leipzig, Deutschland,

hier vertreten durch Marie SINNIGER, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, handelnd auf-

grund einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben vom einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer der übertragenden
Gesellschaft, Herrn Frank POSNANSKI, am 5. November 2015. und

2. Die Geschäftsführer, handelnd für die Gesamtheit der Geschäftsführung der Telekabel Enterprise S.à r.l., einer Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend nach den Gesetzen des
Großherzogtums Luxemburg, die im Luxemburgischen Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der
Nummer B 153.938 eingetragen ist und ihren Sitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, hat,

hier vertreten durch Marie SINNIGER, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, handelnd auf der

Grundlage eines Beschlusses der Geschäftsführung der Übertragenden Gesellschaft.

Die Vollmacht und der Beschluss, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar „ne varietur“

unterzeichnet wurden, bleiben der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.

Die erschienenen Parteien, handelnd wie angegeben, ersuchten den Notar folgendes zu beurkunden:

Teil II. Verschmelzungsplan

Der Verschmelzungsplan ist gemäß (i) der Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.

Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten und gemäß (ii) dem

156632

L

U X E M B O U R G

Luxemburgischen Gesetz über die Handelsgesellschaften („loi concernant les sociétés commerciales“) vom 10. August
1915 in seiner jeweils anwendbaren Fassung (nachfolgend auch „1915-Gesetz“ genannt) sowie (iii) gemäß dem deutschen
Umwandlungsgesetz vom 28. Oktober 1994 in seiner jeweils gültigen Fassung (nachfolgend auch „UmwG“) abgefasst.

Die Geschäftsführungs- und Vertretungsorgane der Telekabel Enterprise S.à r.l. und die Geschäftsführungs- und Ver-

tretungsorgane der PrimaCom Holding GmbH (nachfolgend gemeinsam auch die „Geschäftsführungsorgane“ genannt)
schlagen einstimmig den gemeinsamen Verschmelzungsplan für die Verschmelzung der Telekabel Enterprise S.à r.l., einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend nach den Gesetzen des
Großherzogtums Luxemburg, die im Luxemburgischen Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der
Nummer B 153.938 eingetragen ist und ihren Sitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, hat auf die PrimaCom
Holding GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach den Gesetzen der Bundesre-
publik Deutschland, die im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter der Nummer HRB 28071 eingetragen ist und
ihren Sitz in Leipzig hat, Geschäftsanschrift: Messe-Allee 2, 04356 Leipzig, Deutschland durch Aufnahme vor.

Die Geschäftsführungsorgane bestätigen, dass die übernehmende Gesellschaft alleiniger Gesellschafter der übertragen-

den Gesellschaft ist und die Bestimmungen des Art. 278 ff. des 1915-Gesetzes auf die Verschmelzung (wie unten definiert)
Anwendung finden.

Die Geschäftsführungsorgane bestätigen darüber hinaus, dass
- es sich bei der Verschmelzung um eine grenzüberschreitende Verschmelzung handelt, so dass eine Zustimmung des

Gesellschafters der übertragenden Gesellschaft gemäß Art. 279 Abs. 2 des 1915-Gesetzes sowie gemäß § 122g Abs. 2
UmwG entbehrlich ist, und dass

- die Anteilsinhaber der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften auf einige ihrer Rechte wie in § 13 dieser

Urkunde dargestellt, verzichtet haben bzw. verzichten werden.

DARAUFHIN ERKLÄREN DIE GESCHÄFTSFÜHRUNGSORGANE WAS FOLGT:

§ 1. Vermögensübertragung.
(1) Die übertragende Gesellschaft überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten ohne Abwicklung

im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die übernehmende Gesellschaft; die übernehmende Gesellschaft übernimmt das
Vermögen der übertragenden Gesellschaft durch Aufnahme (nachfolgend auch die „Verschmelzung“ genannt). In Folge
der Verschmelzung erlischt die übertragende Gesellschaft ohne Abwicklung.

(2) Die übernehmende Gesellschaft beabsichtigt, das gesamte Vermögen der übertragenden Gesellschaft durch Über-

nahme aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten ohne Liquidation und ohne Ausgabe neuer Anteile zu über-
nehmen. Die Verschmelzung findet gemäß § 54 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UmwG ohne Kapitalerhöhung bei der übernehmenden
Gesellschaft statt, da diese Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft ist. Gemäß § 122c Abs. 3 UmwG entfallen
deshalb Angaben i. S. v. § 122c Abs. 2 Nr. 2, 3 und 5 UmwG in diesem Vertrag. Die derzeit von der übernehmenden
Gesellschaft gehaltenen Anteile werden gelöscht.

(3) Die Anteile der übertragenden Gesellschaft sind frei von Pfandrechten und sonstigen Belastungen und Rechten

Dritter und nicht mit Sicherungsrechten belastet.

§ 2. Auswirkungen der Verschmelzung auf Arbeitnehmer und ihre Vertretungen.
(1) Mit Ausnahme der jeweiligen Geschäftsführer hat weder die übertragende noch die übernehmende Gesellschaft

Beschäftigte. Eine Arbeitnehmervertretung auf Betriebsebene besteht weder bei der übertragenden noch der übernehmen-
den  Gesellschaft.  Ein  mitbestimmter  Aufsichtsrat  ist  ebenfalls  weder  bei  der  übertragenden  noch  der  übernehmenden
Gesellschaft gebildet; auch nach der Verschmelzung besteht eine Pflicht zur Mitbestimmung auf Unternehmensebene nicht.

(2) Die Verschmelzung hat somit keine Folgen für Arbeitnehmer oder deren Vertretungen; ein Verfahren zur Beteiligung

von Arbeitnehmern oder deren Vertretungen ist nicht zu beachten. Die Voraussetzungen von § 5 MgVG (Gesetz über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung) bzw. Artikel 16 der Richtlinie 2005/56/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften
aus verschiedenen Mitgliedstaaten sind nicht gegeben.

(3) Folgen im Sinne von §§ 5 Abs. 1 Nr. 9; 122a, 122c Abs. 2 Nr. 4, 324 UmwG sowie § 613a BGB (Bürgerliches

Gesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland) ergeben sich aus der Verschmelzung nicht.

§ 3. Verschmelzungsstichtag und Wirksamwerden der Verschmelzung.
(1) Die Übernahme des Vermögens der übertragenden Gesellschaft erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung zum Ablauf,

24.00  Uhr,  des  30.  Juni  2015.  Vom  Beginn  des  1.  Juli  2015,  0:00  Uhr  an  gelten  alle  Handlungen  und  Geschäfte  der
übertragenden Gesellschaft als für Rechnung und Risiko der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen („Verschmel-
zungsstichtag“).

(2) Gegenüber Dritten wird die Verschmelzung wirksam mit ihrer Eintragung in das Handelsregister der übernehmenden

Gesellschaft. Dieser Zeitpunkt wird nachfolgend mit „Wirksamwerden der Verschmelzung“ bezeichnet.

§ 4. Unterlagen zur Einsichtnahme. Die Anteilsinhaber der am Verschmelzungsvorgang beteiligten Gesellschaften sind

berechtigt, während einer Frist von einem (1) Monat vor der Versammlung der Gesellschafter der übernehmenden Gesell-
schaft, die über die Zustimmung zu der Verschmelzung beschließt, am Sitz beider am Verschmelzungsvorgang beteiligten

156633

L

U X E M B O U R G

Gesellschaften kostenfrei in sämtliche Unterlagen i.S.d. Art. 267 Abs. 1 Buchstabe a, b und c des 1915-Gesetzes Einsicht
zu nehmen und kostenfrei Kopien der vorgenannten Dokumente anzufordern.

§ 5. Entlastung. Den Mitgliedern der Geschäftsführung der übertragenden Gesellschaft wird Entlastung erteilt werden.

§ 6. Nichtbestehen und Nichtgewährung besonderer Rechte. Besondere Rechte einzelner Anteilsinhaber der am Versch-

melzungsvorgang beteiligten Gesellschaften oder einzelner Inhaber von anderen Wertpapieren als Gesellschaftsanteilen
oder besonderer Rechte werden nicht gewährt und sind daher nicht auszugleichen. Es sind auch keine besonderen Maßnah-
men für diese Personen vorgeschlagen oder vorgesehen.

§ 7. Nichtgewährung besonderer Vorteile. Besondere Rechte oder Vorteile werden weder einem Mitglied eines Ver-

waltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgans der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften, noch einem
Abschlussprüfer, Sachverständigen oder sonstigen Prüfer gewährt. Es sind auch keine besonderen Maßnahmen für diese
Personen vorgeschlagen oder vorgesehen.

§ 8. Gesellschaftsvertrag der übernehmenden Gesellschaft. Der vollständige Wortlaut des Gesellschaftsvertrags der

übernehmenden Gesellschaft ist diesem Verschmelzungsplan als Anlage 1 beigefügt.

§ 9. Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens. Die übernehmende Gesellschaft wird handelsrechtlich

die in der Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft angesetzten Werte der auf die übernehmende Gesellschaft über-
gehenden Aktiva und Passiva übernehmen und fortführen (Buchwertfortführung).

§ 10. Stichtagsbilanz. Der Verschmelzung der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende wird die Bilanz der

übertragenden Gesellschaft zum 30. Juni 2015, 24:00 Uhr, als Schlussbilanz zugrunde gelegt.

§ 11. Gläubigerschutz.
(1) Gläubiger der übertragenden Gesellschaft werden Gläubiger der übernehmenden Gesellschaft.
(2) Gläubigerschutzrechte nach luxemburgischem Recht:
Gemäß Artikel 268 Abs. 1 des 1915-Gesetzes können Gläubiger der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften,

deren Forderungen zu einem Zeitpunkt vor dem Tag der Veröffentlichung der Notariellen Bestätigung in Mémorial C,
Recueil des Sociétés et des Association begründet wurden, ungeachtet gegenteiliger Vereinbarungen innerhalb von zwei
(2) Monaten ab dieser Veröffentlichung bei dem Richter, der den Vorsitz über die Kammer des Kreisgerichts (Tribunal
d’Arrondissement) führt, welches in dem Bezirk, in dem die Schuldnergesellschaft ihren Sitz hat, und der für Handelssachen
im Eilverfahren zuständig ist, einen Antrag auf Bestellung von Sicherheiten für fällige oder noch nicht fällige Verbind-
lichkeiten stellen, sofern die Verschmelzung einen solchen Schutz erforderlich macht.

(3) Gläubigerschutzrechte nach deutschem Recht:
Gemäß § 122a Abs. 2 UmwG in Verbindung mit § 22 UmwG ist den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten

Rechtsträger, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register
des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren
Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen kön-
nen. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, daß durch die Verschmelzung die
Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Die Gläubiger sind in der Bekanntmachung der jeweiligen Eintragung auf dieses
Recht hinzuweisen.

Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vor-

zugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und
staatlich überwacht ist.

§ 12. Gesellschaftsunterlagen.
(1) Die übertragende Gesellschaft wird ihre Gründungsurkunden und Gesellschaftsunterlagen sowie Geschäftsbücher,

Buchführungsunterlagen und sonstigen Nachweise über Eigentumsrechte und sämtliche sonstigen Dokumente, die ihre
Aktiva und Passiva betreffen, an die übernehmende Gesellschaft aushändigen.

(2) Sämtliche Gesellschaftsdokumente, Bücher und Register der übertragenden Gesellschaft werden während des ge-

setzlich festgesetzten Zeitraums am Gesellschaftssitz der übernehmenden Gesellschaft aufbewahrt.

§ 13. Verzichtserklärungen.
(1) Die Anteilsinhaber der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften werden auf die Aufstellung eines Versch-

melzungsberichts für die übertragende Gesellschaft gem. Art. 265 Abs. 3 des 1915-Gesetzes verzichten.

(2) Die Vertretungsorgane der übernehmenden Gesellschaft werden einen Verschmelzungsbericht gemäß §§ 122a Abs.

2, 122e und 8 UmwG erstatten.

(3) Eine Verschmelzungsprüfung und ein Bericht über die Verschmelzungsprüfung sind gemäß Art. 278 i.V.m. Art. 266

des 1915-Gesetzes sowie gemäß §§ 122f S. 1, 9 Abs. 2 und 3, 8 Abs. 3 und 12 Abs. 3 UmwG nicht erforderlich, da sich
alle Anteile der übertragenden Gesellschaft in der Hand der übernehmenden Gesellschaft befinden und die Anteilsinhaber
der  an  der  Verschmelzung  beteiligten  Gesellschaften  auf  die  Prüfung  der  Verschmelzung  sowie  die  Erstellung  eines
Verschmelzungsprüfungsberichts mit notariell beurkundeter Verzichtserklärung verzichten werden.

156634

L

U X E M B O U R G

§ 14. Kosten, Steuern, Gebühren. Sämtliche mit dem vorliegenden Verschmelzungsplan und seiner Ausführung ver-

bundenen Kosten, Steuern und Gebühren einschließlich des Zustimmungsbeschlusses trägt die übernehmende Gesellschaft.
Sollte die Verschmelzung nicht wirksam werden, tragen die Kosten des vorliegenden Verschmelzungsplans die an der
Verschmelzung beteiligten Gesellschaften zu gleichen Teilen; alle übrigen Kosten trägt die jeweils betroffene Gesellschaft
allein.

§ 15. Salvatorische Klausel. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder ein später in ihn aufgenommene Bestimmung

ganz oder teilweise nichtig sein oder werden oder sollte sich eine Lücke in diesem Vertrag oder seinen Ergänzungen
herausstellen, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Den Parteien ist die Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs bekannt, wonach eine salvatorische Erhaltensklausel lediglich die Beweislast umkehrt. Es ist je-
doch der ausdrückliche Wille der Parteien, die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen unter allen Umständen
aufrechtzuerhalten und damit § 139 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches insgesamt abzubedingen. An Stelle der
nichtigen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke ist diejenige wirksame und durchführbare Regelung zu vereinbaren,
die rechtlich und wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinne und Zweck
des Vertrages und seiner späteren eventuellen Ergänzungen gewollt hätten, wenn sie diesen Punkt beim Abschluss der
Verträge bedacht hätten. Beruht die Nichtigkeit einer Bestimmung auf einem darin festgelegten Maß der Leistung oder der
Zeit (Frist oder Termin), so ist die Bestimmung mit einem dem ursprünglichen Maß am nächsten kommenden rechtlich
zulässigen Maß zu vereinbaren.

§  16.  Sonstiges.  Die  übernehmende  Gesellschaft  wird  sämtlichen  formellen  Verpflichtungen  nachkommen,

einschließlich von sich aus dem 1915-Gesetz ergebenden Publikationspflichten und sonstigen Verwaltungsformalitäten,
die für die Durchführung der Verschmelzung und den Übergang des Aktiv- und Passivvermögens von der übertragenden
Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft erforderlich oder nützlich sind.

Teil III. Hinweise und Belehrungen

Die Geschäftsführungsorgane erklären, dass die Verschmelzung unter der Bedingung der Ausstellung einer notariellen

Bestätigung (nachfolgend auch „Notarielle Bestätigung“ genannt) durch den luxemburgischen Notar steht, in welcher er
bestätigt, dass die Voraussetzungen des Art. 281 des 1915-Gesetzes vorliegen.

Der beurkundende Notar wies [die/den Erschienene/n] darauf hin, dass mit der Eintragung der Verschmelzung in das

Handelsregister der übernehmenden Gesellschaft

1. das Vermögen der übertragenden Gesellschaft einschließlich der Verbindlichkeiten kraft Gesetzes auf die überneh-

mende Gesellschaft übergeht;

2. die übertragende Gesellschaft erlischt, vorausgesetz dass das Luxemburgischen Handelsregister (Registre de Com-

merce et des Sociétés) von dieser Eintragung gemäßArt. 273ter des 1915-Gesetzes in Kenntnis gesetzt wird;

3. Mängel der Verschmelzung die Wirkung der Eintragung unberührt lassen;
4. Der Notar hat die Beteiligten darauf hingewiesen, dass Gläubigern der beteiligten Gesellschaften auf Anmeldung und

Glaubhaftmachung ihrer Forderung nach Maßgabe des § 22 UmwG und Art. 268 des 1915-Gesetzes Sicherheit zu leisten
ist.

Teil IV.

Von dieser Urkunde erhalten die Parteien beglaubigte Abschriften.

Teil V. Notarielle Schlussformel

(1) Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg

aufgenommen wurde.

(2) Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschie-

nenen Partei(en) vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden
Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: M. SINNIGER, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27949. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Amédé SANTIONI.

Annexe

SATZUNG DER PRIMACOM HOLDING GMBH

§ 1. Firma, Sitz und Geschäftsjahr.
1.1 Die Firma der Gesellschaft lautet:
PrimaCom Holding GmbH
1.2 Der Sitz der Gesellschaft ist in Leipzig.
1.3 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

156635

L

U X E M B O U R G

§ 2. Unternehmensgegenstand.
2.1 Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten sowie Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesell-

schaften, die Telekommunikationsdienstleistungen erbringen oder in verwandten Geschäftsbereichen tätig sind, sowie die
Wahrnehmung  von  Beratungsaufgaben  und  die  Erbringung  anderer  Dienstleistungen  für  diese  Gesellschaften  mit  der
Maßgabe, dass hiervon keine Tätigkeiten erfasst werden, die in den Anwendungsbereich des Kreditwesengesetzes fallen.

2.2 Die Gesellschaft kann im In- und Ausland ähnliche oder andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen

beteiligen sowie Vertretungen und Zweigniederlassungen errichten.

2.3 Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Geschäftszweck

dienlich und förderlich sind.

§ 3. Stammkapital.
3.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 160.858 (in Worten: einhundertsechzigtausendachthundertach-

tundfünfzig Euro).

3.2 Das Stammkapital der Gesellschaft ist in 160.858 Geschäftsanteile mit den laufenden Nr. 3 - 160.860 eingeteilt.
3.3 Das Stammkapital ist vollständig eingezahlt.
3.4 Wenn und soweit die Gesellschafterversammlung nach dem Tag des Inkrafttretens dieses Absatzes 3.4 in dieser

Fassung die Ausschüttung von Dividenden beschließt, stehen diese zunächst bis zu einem Betrag von insgesamt EUR
110.000.400 unter Ausschluss der Inhaber der Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 152.818 - 160.860 ("Hürde")
den Inhabern der Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern Nr. 3 bis 152.8 17 jeweils im Verhältnis der Nennbeträge
ihrer Geschäftsanteile zu. Erst die diesen Betrag übersteigenden Dividenden stehen den Inhabern der Geschäftsanteile mit
den laufenden Nummern 3 bis 160.860 jeweils im Verhältnis der Nennbeträge ihrer Geschäftsanteile zu.

3.5 Von einem Liquidationserlös ist unter Ausschluss der Inhaber der Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern

152.818 - 160.860 ("Hürde") an die Inhaber der Geschäftsanteile mit der laufenden Nummern Nr. 3 bis 152.817, jeweils
im Verhältnis der Nennbeträge ihrer Geschäftsanteile, zunächst ein Betrag von bis zu EUR 110.000.400 abzüglich aller
seit dem in Absatz 3.4 bezeichneten Zeitpunkt ausbezahlten Dividenden zu zahlen. Erst der diesen Betrag übersteigende
Liquidationserlös steht den Inhabern der Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 3 bis 160.860 jeweils im Verhältnis
der Nennbeträge ihrer Geschäftsanteile zu.

3.6 Im Übrigen gewähren die Geschäftsanteile mit der laufenden Nummer 3 bis 160.860 gleiche Rechte.

§ 4. Geschäftsführung und Vertretung.
4.1 Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
4.2 Die Geschäftsführer haben die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz, diesem Gesell-

schaftsvertrag, den Gesellschafter- oder Beiratsbeschlüssen sowie jeglichen von der Gesellschafter- oder der Beiratsver-
sammlung beschlossenen internen Anweisungen zu führen. Die Gesellschafterversammlung kann insbesondere jederzeit
durch Aufstellung interner Regelungen für die Geschäftsführung beschließen, dass bestimmte Geschäfte und Maßnahmen
der Zustimmung der Gesellschafterversammlung oder der Beiratsversammlung bedürfen.

4.3 Falls nur ein Geschäftsführer bestellt ist, wird die Gesellschaft von diesem allein vertreten. Sind mehrere Geschäfts-

führer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

4.4 Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB können erteilt werden.

§ 5. Beirat.
5.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat. Dieser ist nicht als Aufsichtsrat im Sinne von § 52GmbHG zu qualifizieren;

gesetzliche Vorschriften für Aufsichtsräte finden keine entsprechende Anwendung.

5.2 Die Anzahl der Beiratsmitglieder wird durch Gesellschafterbeschluss (ausdrücklich oder konkludent durch Bestel-

lung oder Abberufung von Beiratsmitgliedern) bestimmt.

5.3 Der Beirat wählt einen Vorsitzenden, der die Beiratsversammlungen einberuft, vorbereitet und leitet.
5.4 Sitzungen des Beirats, sei es physisch oder per Telefon- oder Videokonferenz oder im Wege anderer elektronischer

Mittel der Echtzeitkommunikation, finden monatlich sowie auf Ersuchen eines jeden Gesellschafters statt. Sitzungen sind
vom Vorsitzenden schriftlich (per EMail, Brief oder Fax) mit einer Frist von 10 Arbeitstagen (wobei unter Arbeitstag jeder
Tag zu verstehen ist, an dem die Banken in New York, London, Amsterdam und Berlin für all gemeine Bankgeschäfte
geöffnet sind) gegenüber jedem Beiratsmitglied einzuberufen (wobei die Veröffentlichung eines Terminplans für Beirats-
sitzungen als Einberufungsmitteilung genügt, sofern dieser den Beiratsmitgliedern mindestens 10 Arbeitstage vor den ersten
so anberaumten Termin mitgeteilt wird), es sei denn

a) mindestens ein Beiratsmitglied oder ein Gesellschafter ist der Auffassung, dass eine Beiratsversammlung dringlich

erforderlich ist, um eine wesentliche zeitkritische Entscheidung in Bezug auf die Gesellschaft oder deren Geschäftstätigkeit
zu beraten oder zu beschließen, woraufhin dieses Beiratsmitglied oder dieser Gesellschafter eine Beiratsversammlung durch
Mitteilung an die (anderen) Beiratsmitglieder unter Wahrung einer Frist von 24 Stunden einberufen kann; oder

b) alle Beiratsmitglieder verzichten auf dieses Erfordernis (wobei die Anwesenheit eines Beiratsmitglieds bei einer

Beiratsversammlung einen solchen Verzicht darstellt).

156636

L

U X E M B O U R G

5.5 Der Vorsitzende soll mindestens 5 Arbeitstage vor jeder Beiratsversammlung (oder im Falle des § 5.4a) gleichzeitig

mit der Einberufungsmitteilung) eine angemessen detaillierte Tagesordnung (per EMail, Brief oder Fax) an jedes Beirats-
mitglied zirkulieren, die

a) darlegt, ob Maßnahmen, die der Zustimmung des Beirates bedürfen, behandelt werden; und
b) ein Informationspaket (einschließlich aller relevanter Hintergrundpapiere) enthält.
5.6 Der oder die Geschäftsführer der Gesellschaft sollen den Beiratsversammlungen beiwohnen; sie sollen eine Bei-

ratsversammlung zeitweise oder dauerhaft verlassen, wenn zwei oder mehr Beiratsmitglieder dies verlangen.

5.7 Der Beirat kann die Geschäftsführer dazu auffordern, die Teilnahme von leitenden Angestellten der Gesellschaft an

den Beiratsversammlungen zu veranlassen

5.8 Zu Beginn einer jeden Beiratsversammlung soll die Geschäftsführung einen Überblick über die Geschäftstätigkeit

der Gesellschaft sowie der direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, an denen die Gesellschaft mehr als fünfzig (50)
Prozent des wirtschaftlichen und/oder stimmberechtigten Stammkapitals (oder ein entsprechendes Eigentumsrecht) hält,
geben und sachdienliche Rückfragen beantworten.

5.9 Ungeachtet jeglicher aufgrund Gesellschafterbeschluss erteilter Weisungen, kann der Beirat der Geschäftsführung

Weisungen erteilen, insbesondere dahingehend

a) bestimmte Maßnahmen oder Entscheidungen, die nicht bereits eine zustimmungspflichtige Maßnahme oder Ent-

scheidung darstellen, nicht ohne vorherige Zustimmung des Beirates zutreffen mit der Folge, dass diese Maßnahmen und
Entscheidungen zukünftig der Zustimmung des Beirates bedürfen, und

b) eine vom Beirat für die Geschäftsführung erlassene Geschäftsordnung einzuhalten.
5.10  Beschlüsse  des  Beirats  bedürfen  der  Zustimmung  der  Mehrheit  aller  Beiratsmitglieder.  Beschlüsse  können  in

physischen Versammlungen oder per Telefon- oder Videokonferenz oder im Wege anderer elektronischer Mittel der Ech-
tzeitkommunikation sowie, sofern alle Beiratsmitglieder zustimmen, schriftlich (einschließlich per Fax oder E-Mail) gefasst
werden und stehen Beschlüssen, die in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Beiratsversammlung gefasst wer-
den, gleich. Wenn ein Beiratsmitglied innerhalb von 10 Arbeitstagen ab dem Tag, an dem der Umlaufbeschluss zugegangen
ist (oder als zugegangen gilt), nicht reagiert, bleibt die Stimme dieses Beiratsmitglieds bei der Mehrheitsberechnung un-
berücksichtigt.

5.11 Jeder Gesellschafter kann verlangen, dass der Vorsitzende bestimmte Personen als Beisitzer zu den Beiratsitzungen

benennt, woraufhin den vorgeschlagenen Beisitzern gleichzeitig mit der Einberufungsmitteilung eine entsprechende Mit-
teilung  zuzuleiten  ist,  die  vorgeschlagenen  Beisitzern  zu  den  jeweiligen  Sitzungen  zuzulassen  und  mit  den  gleichen
Informationen auszustatten sind, welche die Beiratsmitglieder erhalten

5.12 Eine Vergütung ist an diejenigen Beiratsmitglieder zu zahlen, für welche dies durch Gesellschafterbeschluss, in

dem zugleich die Höhe der Vergütung festlegt wird, vorgesehen ist. Zusätzlich haben die Beiratsmitglieder und sofern
vorhanden die Beisitzer einen Anspruch auf Ersatz ihrer angemessenen Auslagen (einschließlich Reise-, Beherbergungs-
und Verpflegungs kosten).

§ 6. Informationsrechte. Den Gesellschaftern steht das Informationsrecht aus § 51 a GmbHG zu, insbesondere sind sie

berechtigt:

a) in die Bücher, Schriften und Konten der Gesellschaft Einsicht zu nehmen,
b) weitere Informationen im Besitz oder Zugriff der Gesellschaft zu erhalten, die sich auf die Geschäftstätigkeit oder

die finanzielle Lage der Gesellschaft oder einer direkten oder indirekten Tochtergesellschaft beziehen, an der die Gesell-
schaft mehr als fünfzig (50) Prozent des wirtschaftlichen und /oder stimmberechtigten Stammkapitals (oder ein entspre-
chendes Eigentumsrecht) hält.

§ 7. Verfügung über Geschäftsanteile. Verfügungen über Geschäftsanteile oder Teile davon (einschließlich individueller

Gesellschafterrechte) sowie jegliche diesbezüglichen Vereinbarungen bedürfen der vorherigen Zustimmung aller Gesell-
schafter. Der vorstehende Satz findet keine Anwendung im Falle von Verfügungen im Zusammenhang mit der Bestellung
oder Verwendung von Pfandrechten an den Geschäftsanteilen zugunsten von Gläubigern der Gesellschaft oder Tochte-
runternehmen.

§ 8. Sonstiges.
8.1 Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.
8.2 Die Kosten der Gründung der Gesellschaft einschließlich aller Notarkosten sowie der Kosten im Zusammenhang

mit der Anmeldung und der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister trägt die Gesellschaft bis zu einer Höhe von
EUR 1.500,00 (in Worten: eintausendfünfhundert)

8.3 Die Satzung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
8.4 Ausschließlich die deutsche Fassung dieser Satzung ist verbindlich. Der englische Text ist nur zu Informationsz-

wecken aufgeführt und wurde nicht mit beurkundet.

156637

L

U X E M B O U R G

Übersetzung / Convenience translation

ARTICLES OF ASSOCIATION OF PRIMACOM HOLDING GMBH

§ 1. Name, Registered Office and Financial Year.
1.1 The Company shall have the name:
PrimaCom Holding GmbH
1.2 The registered office of the Company is in Leipzig.
1.3 The financial year (Geschäftsjahr) of the Company is the calendar year

§ 2. Objects of Business.
2.1 The objects of the Company's business are the acquisition, holding and administration of participations in other

companies which are engaged in the field of telecommunication Services or related business sectors as well as performing
consultancy and other services for such companies, except for services which fall within the scope of the German Banking
Act (KWG).

2.2 The Company may establish, acquire or participate in similar or other enterprises, and may establish agencies or

branches, within the Federal Republic of Germany and abroad.

2.3 The Company may enter into all transactions and take all measures which are useful, appropriate and conductive

for and to the afore- said objects.

§ 3. Share Capital.
3.1 The share capita l of the Company amounts to EUR 160,858 (one hundred sixty-thousand eight hundred fifty-eight

Euro)

3.2 The share capital in the Company conists of 160,858 shares with the consecutive numbers 3 to 160,860
3.3 The share capital has been fully paid in.
3.4 If and to the extent that after the date on which this para. 3.4 in this version has become effective the shareholders

resolve on the distribution of any dividends, the holders of the shares with the consecutive numbers 3 to 152,817 (to the
exclusion of the holders of the shares with the consecutive numbers 152,818 to 160,860 ("hurdle") are, each in proportion
to the nominal value of their shares, entitled to dividends of up to a total amount of EUR 110,000,400. Only dividends
exceeding this amount shall be distributed to the shareholders of the shares with the consecutive number 3 to 160,860 in
proportion to the nominal value of their shares.

3.5 The shareholders of the shares with the consecutive number 3 to 152,817 (to the exclusion of the holders of the

shares with the consecutive numbers 152,818 to 160,860 ("hurdle") are, each in proportion to the nominal value of their
shares, entitled to Liquidation proceeds of up to EUR 110,000,400, less any dividends received since the date referred to
in para. 3.4. Only any Liquidation proceeds in excess of such amount shall be distributed to the shareholders of the shares
with the consecutive numbers 3 to 160,860 in proportion to the nominal value of their shares.

3.6 Subject to the limitations set forth in this § 3, the shares with the consecutive numbers 3 to 160,860 confer the

identical rights.

§ 4. Managing Directors and Representation.
4.1 The Company shall have one or several managing directors.
4.2 The managing directors shall manage the business of the Company in accordance with the law, these articles of

association, the shareholders' resolutions or advisory board's resolutions and any internal rules for the management of the
Company resolved by the shareholders' meeting or the advisory board meeting. In particular, the shareholders' meeting
may, at any time, decide that certain transactions shall be subject to the consent of the shareholders' meeting or the advisory
board meeting by setting up internal rules for the management.

4.3 If only one managing director has been appointed, the Company shall be represented solely by this managing director.

If several managing directors have been appointed, the Company shall be represented by two managing directors jointly
or by one managing director jointly with an authorised representative (Prokurist).

4.4 Individual power to represent the Company and release from the restrictions under section 181 of the German Civil

Code (BGB) may be granted.

§ 5. Advisory Board.
5.1 The Company shall have an advisory board (Beirat). Such advisory board shall not be deemed a supervisory board

(Aufsichtsrat) in the meaning of section 52 of the German Limited Liability Companies Act (GmbHG); statutory provisions
on supervisory boards shall not apply accordingly.

5.2 The advisory board shall consist of such number of members as may be determined by shareholders' resolution

(expressly or impliedly by electing additional or removing members).

5.3 The advisory board elects a chairman to convene, prepare and chair its meetings.
5.4 Sessions of the advisory board, be it as physical meetings, by telephone or video conference or by other electronic

means of real time communication, are to be held each month and in any event upon the request of any shareholder. At

156638

L

U X E M B O U R G

least 10 business days' written notice (with a business day being any day on which banks are open for general banking
business in New York, London, Amsterdam and Berlin) shall be given (by e-mail, courier or fax) by the chairman to each
of the advisory board members of all advisory board meetings (whereby the publication of a timetable of such meetings
shall constitute appropriate notice, provided that it is provided to the advisory board members at least 10 business days in
advance of the first such meeting), except where:

a) at least one of the advisory board members or one of the shareholders believes that an advisory board meeting is

required urgently to consider, or take, a materially time sensitive decision in relation to the Company or the Company's
business, in which case such advisory board member or such share- holder may call a meeting of the advisory board,
provided that not less than 24 hours' notice of such meeting is given to the other advisory board members; or

b) such requirement is waived with the consent of each advisory board member (and the presence of an advisory board

member at a meeting of the advisory board shall constitute a waiver of notice).

5.5 At least 5 business days before a meeting of the advisory board (or if Section 5.4a) applies, at the same time as notice

of an advisory board meeting is given), the chairman shall circulate a reasonably detailed agenda (by e-mail, courier or
fax) to each of the advisory board members which shall:

a) specify whether any matters requiring the consent of the advisory board are to be considered; and
b) be accompanied by an information pack (including all relevant background papers).
24 hours' notice of such meeting is given to the other advisory board members; or
5.6 The managing director(s) of the Company is/are required to attend the meetings of the advisory board provided that

upon the request of two or more members of the advisory board one or more of the managing director(s) shall withdraw
from the relevant meeting temporarily or permanently, as per such request.

5.7 The advisory board may request the managing director(s) to cause members of the Company's senior staff to attend

advisory board meetings.

5.8 At the beginning of each advisory board meeting, the managing director(s) shall give an overview on the business

carried on by the Company,and any company or entity directly or indirectly controlled by the Company in which the
Company holds more than fifty (50) percent of the economic and/or voting share capital (or equivalent right of ownership
of such company or entity), and shall answer pertinent queries.

5.9 The advisory board may give directions to the managing director(s), without prejudice to any directions given by

way of a shareholders' resolution , in particular

a) not to take certain action or decision that is not already a reserved matter without the prior consent of the advisory

board such that such action also becomes an advisory board consent matter, and

b) to abide by such rules of the procedure as the Advisory Board may from time to time determine.
5.10 The advisory board adopts its resolutions with the consent of the simple majority of its existing members from time

to  time.  Resolutions  other  than  physical  meetings  can  be  validly  taken  by  telephone  or  video  conference  or  by  other
electronic means of real time communication and also if approved in writing (including by fax letter and e-mail) by all
members of the advisory board and shall be as effective as if passed in a meeting duly convened and held. If no response
has been received from an advisory board member within 10 business days of the date on which such circular resolution
is received (or deemed received) by that advisory board member, such advisory board member shall not be included in
calculating whether a resolution has been adopted.

5.11 Any shareholder may request that the chairman notifies those individuals as observers of the sessions of the advisory

board as are named in such request, upon which request such notice is to be given to the proposed observers at the same
time at which the sessions are convened, the proposed observers are to be admitted to such sessions and are to be furnished
any information as is provided to the members of the advisory board.

5.12 A remuneration shall be payable to each advisory board member as to whom a shareholders‘ resolution so provides,

determining the amount of such remuneration. In addition, the advisory board member and the observers, if any, are entitled
to reimbursement of reasonable out-of-pocket expenses (including travel, accommodation and subsistence expenses rea-
sonably incurred).

§ 6. Information Rights. The shareholders are entitled to all information according to section 51a of the German Law

on Limited Liability Companies (GmbHG), in particular they are entitled to:

a) examine the books, records and accounts to be kept by the Company,
b) receive such other information in the possession or control of the Company relating to the business carried on by, or

the financial condition and operations of, the Company or any company or entity directly or indirectly controlled by the
Company in which the Company holds more than fifty (50) percent of the economic and/or voting share capital (or equiv-
alent right of ownership of such company or entity).

§ 7. Transfer and Disposal of Shares. The disposal of shares or of any part thereof (including individual shareholders'

rights) as well as any agreements thereon require the prior consent of all shareholders. The preceding sentence shall not
apply in case of any disposals made in connection with any share pledges or realisation of share pledges in favour of
creditors of the Company or its subsidiaries.

156639

L

U X E M B O U R G

§ 8. Miscellaneous.
8.1 Announcements of the company shall be published in the Federal Gazette (Bundesanzeiger).
8.2 The costs of Formation of the Company, including any notarial fees and fees in connection with the application and

registration of the Company with the commercial register, of a maximum of EUR 1,500.00 (in words: one thousand five
hundred Euros) shall be borne by the Company.

8.3 These articles of association shall be governed by the laws of the Federal Rupublic of Germany
8.4 Only the German version of these articles of association is binding. The English text is quoted for information

purposes only and has not been notarised.

AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE, Ausgestellt auf Stempelfreiem Papier zwecks Ein-

tragung beim Gesellschaftsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, den 27. November 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015194627/437.
(150217915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Marea, Société Anonyme.

Siège social: L-4519 Differdange, 46, Cité Breitfeld.

R.C.S. Luxembourg B 138.011.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1 

<i>er

<i> octobre 2015

1. la démission de Madame Pia Hansen, demeurant au 46, Cité Breitfeld à L -4519 Differdange de son mandat d'admi-

nistrateur, avec effet au 1 

er

 octobre 2015, est acceptée.

2. la nomination de la société MH Participations S.A., avec siège social au 46, Cité Breitfeld à L-4519 Differdange,

Luxembourg, représenté par Monsieur Marochi Jean Rico, né le 09 janvier 1964 à Differdange, Luxembourg, demeurant
au 46 Cité Breitfeld, L-4519 Differdange, Luxembourg comme administrateur à été acceptée à partir du 1 

er

 octobre 2015.

Son mandat viendra à échéance en 2017.

Differdange, le 1 

er

 octobre 2015.

Certifié sincère et conforme
Marea S.A.

Référence de publication: 2015167853/17.
(150184786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

1741 Specialised Investment Funds SICAV, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 159.528.

In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of November,
before Us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of 1741 Specialised Investment Funds SICAV, a

société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé having its
registered office at 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B159528 (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in
Luxembourg, on 4 March 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"),
Number 524 of 21 March 2011. The articles of incorporation have been amended for the last time on 3 August 2012 by
deed of Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, published in the Mémorial number 2328 of 19
September 2012.

The Meeting is opened at 11:00 a.m. by Mr Olivier Lansac, employee, professionally residing in Luxembourg, in the

chair (the "Chairman").

The Chairman appointed as secretary Mrs Caroline Ney, employee, professionally residing in Luxembourg and the

Meeting elected as scrutineer Mrs Caroline Ney, employee, professionally residing in Luxembourg.

The bureau of the Meeting (the “Bureau”) having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary

to state:

I.- That the agenda of the Meeting is the following:

156640

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

With effect from 20 November 2015, amendments of the articles of incorporation (the "Articles") of the Company as

detailed hereafter:

- Amendment of the first paragraph of article 4 of the Articles, in order to change the address of the registered office of

the Company from the city of Bertrange to Luxembourg City;

- Amendment of the article 23 of the Articles in order to reflect the involvement of the alternative investment manager

of the Company in the calculation of the net asset value of the shares;

- Amendment of the article 28 of the Articles in order to the reflect the relevant provisions of the law of 12 July 2013

on alternative investment fund managers, (the “AIFM Law”) relating to the possibility for the depositary bank to discharge
its liability in certain circumstances; and

- Insertion of new articles 30 and 31 (following current article 29) of the Articles, reflecting certain requirements of the

AIFM Law in relation to i) preferential treatment of investors and ii) the information to be made available to investors.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares

are shown on an attendance list; this attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the represented
shareholders and by the Bureau, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

III. The present Meeting has been convened by registered letters send to the shareholders on 6 November 2015.
IV. It appears from the attendance list that, out of the one hundred eighty thousand two hundred forty-eight point forty-

five (180,248.45) shares in issue, one hundred seventy-four thousand four hundred sixteen (174, 416.00) shares are present
or represented at the Meeting. The Chairman declares that the present Meeting was regularly convened, that the quorum
required by article 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended is reached, and that the Meeting
is therefore regularly constituted and can deliberate on all the sole item of the above named agenda.

After deliberation, the Meeting requests the undersigned notary to document the following sole resolution:

<i>Sole resolution

The Meeting resolves to amend, with effect as from 20 November 2015, the following articles of the articles of incor-

poration (the "Articles") of the Company as follows:

- Amendment of the first paragraph of article 4, in order to change the address of the registered office of the Company

from city of Bertrange to Luxembourg City , so as to read as follows:

“The registered office of the Fund is established in Luxembourg, in the Grand-Duchy of Luxembourg. Wholly-owned

subsidiaries, branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of
directors of the Fund (the "Board of Directors")”;

- Amendment of the article 23 in order to reflect the involvement of the alternative investment fund manager of the

Company in the determination of the net asset value of the shares, so as to read as follows:

“ Art. 23. The Net Asset Value of shares of each class of shares in the Fund shall be expressed in the reference currency

of the relevant class (and/or in such other currencies as the Board of Directors shall from time to time determine) as a per
share figure and shall be determined in respect of any Valuation Date by dividing the net assets of the Fund corresponding
to each class of shares, being the value of the assets of the Fund corresponding to such class less the liabilities attributable
to such class, by the number of shares of the relevant class outstanding adjusted to reflect any dealing charges or fiscal
charges which the Board of Directors considers appropriate to take into account and as disclosed in the sales documents
and by rounding the resulting sum to at least the nearest smallest unit of the currency concerned.

The subscription and redemption price of a share of each class shall be expressed in the reference currency of the relevant

class (and/or in such other currencies as the Board of Directors shall from time to time determine) as a per share figure and
shall be determined in respect of any Valuation Date based on the Net Asset Value per share of that class calculated in
respect of such Valuation Date adjusted by any dealing charges or fiscal charges which the Board of Directors considers
appropriate to take into account, if any, determined by the Board in accordance with all applicable law and regulations.
The subscription and redemption price shall be rounded upwards and downwards respectively as shall be determined from
time to time by the Board.

If an equalisation account is being operated an equalisation amount is payable.
The valuation of the Net Asset Value of the different classes of shares shall be made in the following manner:
A. The assets of the Fund shall be deemed to include:
a) all cash in hand or receivable or on deposit, including accrued interest;
b) all bills and notes payable on demand and any amounts due (including the proceeds of securities sold but not collected);
c) all securities, shares, bonds, debentures, options or subscription rights, futures contracts, warrants and other invest-

ments and securities belonging to the Fund;

d) all dividends and distributions due to the Fund in cash or in kind to the extent known to the Fund (the Fund may

however adjust the valuation to fluctuations in the market value of securities due to trading practices such as trading ex-
dividends or ex-rights);

156641

L

U X E M B O U R G

e) all accrued interest on any securities held by the Fund except to the extent such interest is comprised in the principal

thereof;

f) the preliminary expenses of the Fund insofar as the same have not been written off, provided that such preliminary

expenses may be written off directly from the capital of the Fund; and

g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
a) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash

dividends and interest declared or accrued and not yet received is deemed to be the full amount thereof, unless in any case
the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after making such discount
as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof.

b) The value of transferable securities, money market instruments and any financial liquid assets listed or dealt in on a

stock exchange or on a regulated market are generally valued at the last available known price in the relevant market prior
to the time of valuation. Fixed income securities not traded on such markets are generally valued at the last available price
or yield equivalents obtained from one or more dealers or pricing services approved by the Board of Directors and/or the
Fund’s alternative investment fund manager (the “AIFM”) within the meaning of the Law of 12 July on the Alternative
Investment Fund Managers, as amended from time to time (the “AIFM Law”). If such prices are not representative of their
value, such securities are stated at market value or otherwise at the fair value at which it is expected they may be resold,
as may be determined in good faith by or under the direction of the Board of Directors and/or the AIFM.

c) The liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on a stock exchange or on regulated markets

shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the Board of Directors and/or the
AIFM, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The value of futures, forward or options
contracts traded on a stock exchange or on regulated markets shall be based upon the last available settlement or closing
prices as applicable to these contracts on a stock exchange or on regulated markets on which the particular futures, forward
or options contracts are traded on behalf of the Fund; provided that if a future, forward or options contract could not be
liquidated on the day with respect to which assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of
such contract shall be such value as the Board of Directors and/or the AIFM may deem fair and reasonable.

d) All other transferable securities, money market instruments and other financial liquid assets, including equity and

debt securities, for which prices are supplied by a pricing agent but are not deemed to be representative of market values,
but excluding money market instruments with a remaining maturity of ninety days or less and including restricted securities
and securities for which no market quotation is available, are valued at fair value as determined in good faith pursuant to
procedures established by the Board of Directors and/or the AIFM. Money market instruments held by the Fund with a
remaining maturity of 12 months or less will be valued by the amortized cost method, which approximates market value.
Under this valuation method, the relevant investments are valued at their acquisition cost as adjusted for amortisation of
premium or accretion of discount rather than at market value.

e) Interest rate swaps will be valued on the basis of their market value established by reference to the applicable interest

rate curve. Credit default swaps and total return swaps will be valued at fair value under procedures approved by the Board
of Directors and/or the AIFM. As these swaps are not exchange-traded, but are private contracts into which the Fund and
a swap counterparty enter as principals, the data inputs for valuation models are usually established by reference to active
markets. However it is possible that such market data will not be available for credit default swaps and total return swaps
near the date on which valuation is undertaken. Where such markets inputs are not available, quoted market data for similar
instruments (e.g. a different underlying instrument for the same or a similar reference entity) will be used provided that
appropriate adjustments be made to reflect any differences between the credit default swaps and total return swaps being
valued and the similar financial instrument for which a price is available. Market input data and prices may be sourced
from exchanges, a broker, an external pricing agency or a counterparty. If no such market input data are available, credit
default swaps and total return swaps will be valued at their fair value pursuant to a valuation method adopted by the Board
of Directors which shall be a valuation method widely accepted as good market practice (i.e. used by active participants
on setting prices in the market place or which has demonstrated to provide reliable estimate of market prices) provided that
adjustments that the Board of Directors and/or the AIFM may deem fair and reasonable be made. The Fund’s approved
statutory auditor will review the appropriateness of the valuation methodology used in valuing credit default swaps and
total return swaps. In any event, the Fund will always value credit default swaps and total return swaps at arm’s length
basis. All other swaps will be valued at fair value as determined in good faith pursuant to procedures established by the
Board of Directors and/or the AIFM.

f) Units or shares of open-ended UCIs will be valued at their last determined and available net asset value or, if such

price is not representative of the fair market value of such assets, then the price shall be determined by the Fund on a fair
and equitable basis. Units or shares of a closed-ended UCI will be valued at their last available stock market value.

g) The valuation of all other eligible assets (including securities not listed on a stock exchange or traded on a regulated

market) is based on their probable realisation price determined with care and in good faith by or under the supervision of
the Board of Directors and/or the AIFM.

The Board of Directors and/or the AIFM may, in its discretion, permit some other method of valuation to be used if it

believes that such other method provides a valuation, which more accurately reflects the fair value of any asset of the Fund.

156642

L

U X E M B O U R G

Any such valuation shall be based on the probable realisable value which must be estimated with care and in good faith.
In the event that any such change in valuation method is permanent and/or materially affects the net asset valuation of a
class of shares, the Board of Directors shall be obliged to provide adequate notice to the shareholders.

The assets of a given class of shares may be valued by reference to a financial model as described in the sales documents.
B. The liabilities of the Fund shall be deemed to include:
a) all borrowings, bills and other amounts due;
b) all administrative and other operative expenses due or accrued including all fees payable to the investment adviser

(s), the dépositary and any other representatives and agents of the Fund;

c) all known liabilities due or not yet due, including the amount of dividends declared but unpaid;
d) an appropriate amount set aside for taxes due on the date of valuation and other provisions or reserves authorised and

approved by the Board of Directors covering among others liquidation expenses; and

e) all other liabilities of the Fund of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the Fund. In

determining the amount of such liabilities, the Board of Directors shall take into account all expenses payable by the Fund
which shall comprise formation expenses, fees payable to its investment advisers or investment managers, accountants,
dépositary, domiciliary, registrar and transfer agents, any paying agent and permanent representatives in places of regis-
tration,  any  other  agent  employed  by  the  Fund,  fees  for  legal  and  auditing  services,  reasonable  expenses  incurred  by
Directors for attending meetings of the Board of Directors, insurance for Directors, promotional, printing, reporting and
publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and printing of prospectuses, explanatory memoranda
or registration statements, taxes or governmental charges, and all other operation expenses, including the cost of buying
and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Board of Directors may calculate
administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in
advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

For the purposes of the valuation of its liabilities, the Board of Directors may duly take into account all administrative

and other expenses of a regular or periodical character by valuing them for the entire year or any other period and by
dividing the amount concerned proportionately for the relevant fractions of such period.

C. There shall be established one pool of assets for each class of shares in the following manner:
a) the proceeds from the issue of each class shall be applied in the books of the Fund to the pool of assets established

for that class of shares, and the assets, and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied to
such pool subject to the provisions of this Article.

b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Fund to the

same pool of assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in value shall
be applied to the relevant pool.

c) where the Fund incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any actions taken in connection

with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool.

d) in the case where any asset or liability of the Fund cannot be considered as being attributable to a particular pool,

such asset or liability shall be allocated pro rata to all the pools on the basis of the net asset value of the total number of
shares of each pool outstanding provided that any amounts which are not material may be equally divided between all
pools. The Board of Directors may allocate material expenses, after consultation with the approved statutory auditor of the
Fund, in a way considered to be fair and reasonable having regard to all relevant circumstances.

e) upon the record date for the determination of the person entitled to any dividend declared on any class of shares, the

Net Asset Value of such class of shares shall be reduced or increased by the amount of such dividends depending on the
distribution policy of the relevant class.

If there have been created, as more fully described in Article five hereof, within the same class of shares two or more

sub-classes, the allocation rules set above shall apply, mutatis mutandis, to such sub-classes.

D. Each pool of assets and liabilities shall consist of a portfolio of securities and other assets in which the Fund is

authorised to invest, and the entitlement of each class of shares within the same pool will change in accordance with the
rules set out below.

In addition there may be held within each pool on behalf of one specific or several specific classes of shares, assets

which are class specific and kept separate from the portfolio which is common to all classes related to such pool and there
may be assumed on behalf of such class or classes specific liabilities.

The proportion of the portfolio which shall be common to each of the classes related to a same pool and which shall be

allocable to each class of shares shall be determined by taking into account issues, redemptions, distributions, as well as
payments of class specific expenses or contributions of income or realisation proceeds derived from class specific assets,
whereby the valuation rules set out below shall be applied mutatis mutandis.

The percentage of the net asset value of the common portfolio of any such pool to be allocated to each class of shares

shall be determined as follows:

a) initially the percentage of the net assets of the common portfolio to be allocated to each class shall be in proportion

to the respective number of the shares of each class at the time of the first issuance of shares of a new class;

156643

L

U X E M B O U R G

b) the issue price received upon the issue of shares of a specific class shall be allocated to the common portfolio and

result in an increase of the proportion of the common portfolio attributable to the relevant class;

c) if in respect of one class the Fund acquires specific assets or pays specific expenses (including any portion of expenses

in excess of those payable by other share classes) or makes specific distributions or pays the redemption price in respect
of shares of a specific class, the proportion of the common portfolio attributable to such class shall be reduced by the
acquisition cost of such class specific assets, the specific expenses paid on behalf of such class, the distributions made on
the shares of such class or the redemption price paid upon redemption of shares of such class;

d) the value of class specific assets and the amount of class specific liabilities are attributed only to the share class to

which such assets or liabilities relate and this shall increase or decrease the net asset value per share of such specific share
class.

E. For the purpose of valuation under this Article:
a) shares of the Fund to be redeemed under Article twenty-one hereto shall be treated as existing and taken into account

until immediately after the time specified by the Board of Directors on the Valuation Date on which such valuation is made,
and from such time and until paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Fund;

b) shares of the Fund in respect of which subscription has been accepted but payment has not yet been received shall

be deemed to be existing as from the close of business on the Valuation Date on which they have been allotted and the
price therefore, until received by the Fund, shall be deemed a debt due to the Fund;

c) all investments, cash balances and other assets of the Fund expressed in currencies other than the reference currency

in which the Net Asset Value per share of the relevant class is calculated shall be valued after taking into account the market
rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value of the relevant class of
shares; and

d) effect shall be given on any Valuation Date to any purchases or sales of securities contracted for the Fund on such

Valuation Date to the extent practicable”;

- Amendment of the article 28 in order to the reflect the relevant provisions of the law of 12 July 2013 on alternative

investment fund managers, (the “AIFM Law”) relating to the possibility for the depositary bank to discharge its liability
in certain circumstances, so as to read as follows:

“ Art. 28. The Fund shall appoint a depositary which shall satisfy the requirements of the Law of 2007 and the AIFM

Law which shall be responsible for the safekeeping of the assets of the Fund and shall hold the same itself or through its
agents.

Where the law of a non-EU member country requires that certain financial instruments are held in custody by a local

entity and there are no local entities that satisfy the delegation requirements laid down in Article 19, paragraph 11 (d) (ii)
of the AIFM Law, the Company’s depositary can discharge itself of liability provided that the conditions laid down in
Article 19, paragraph 14, of the AIFM Law are met.”;

and
- Insertion of the following new articles 30 and 31 (following current article 29), reflecting the relevant provisions of

the AIFM Law in relation to i) preferential treatment of shareholders and ii) the information to be made available to investors
and therefore renumbering of the current articles 30 and 31 in articles 32 and 33, respectively:

“ Art. 30. To the extend applicable, the Board of Directors takes into account the need to treat shareholders fairly in all

procedures put in place in accordance with the AIFM Law (and notably in the inducement and conflict of interest policy).
Nevertheless, it cannot be excluded that the Board of Directors grants (during the life of the Fund) preferential treatment
to some shareholders (through side letters or other arrangements). In such case, information about any preferential treatment
granted to certain shareholders will be made available to the extent and as required by the AIFM Law.

Art. 31. Any information to be provided to investors in the Fund in order to comply with the AIFM Law and any other

applicable laws and regulations will be made available in the manner and at the time indicated in the sales documents of
the Fund, including inter alia by way of disclosure on the Fund or its AIFM’s website and/or at the registered office of the
Fund  or  of  its  AIFM  and/or  in  the  financial  reports  of  the  Fund,  a  letter  to  the  shareholders  or  any  other  appropriate
document.”

The Meeting noted that the French translation of the present deed is not required in accordance with article 26 (2) of the

law of 13 February 2007 on specialised investment funds, as amended.

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 2,000.-.

Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English.

156644

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the persons appearing, all known by the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Signé: O. LANSAC, C. NEY, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/36595. Reçu soixante-quinze

euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015193933/266.
(150216847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2015.

QU2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 191.892.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth October.
Before us, Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held

the extraordinary general meeting of the shareholders of QU2 S.A., a société anonyme incorporated and existing under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 191892, having its registered office at 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
and  incorporated  by  deed  of  Maître  Jean  Seckler,  notary  residing  in  Junglinster,  Grand  Duchy  of  Luxembourg  on  10
November 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial C”), number 3730
dated 5 December 2014. The articles of association of the said company have not been amended since (the “Company”).

The meeting was opened and presided by Ms. Stessie Soccio, professionally residing in Luxembourg (the “Chairman”).
The Chairman appointed as secretary and scrutineer, Ms. Hortense Epaulard, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to

record the following:

I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares

are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxyholder of the represented shareholders,
the board of the meeting and the undersigned notary shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

II. Pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders present or

represented declare that they have had notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and that thus no
convening notices were necessary.

III. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
IV. The agenda of the present meeting is the following:

<i>Agenda

1. Reduction of the par value of each of the shares of the Company from thirty-one euro (EUR 31.-) down to five euro

(EUR 5.-) each;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of four million five hundred nineteen thousand eight

hundred euro (EUR 4,519,800.-) from its current amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by six
thousand two hundred (6,200) shares up to an amount of four million five hundred fifty thousand eight hundred euro (EUR
4,550,800.-) through the issuance of nine hundred three thousand nine hundred sixty (903,960) new shares of the Company
through a conversion of part of the existing available reserves into the share capital of the Company;

3. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company; and
4. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires

the notary to enact, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders decides to reduce the par value of each of the shares of the Company from

thirty-one euro (EUR 31.-) down to five euro (EUR 5.-) each.

156645

L

U X E M B O U R G

Accordingly, the share capital of the Company shall be set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by

six thousand two hundred (6,200) shares with a par value of five euro (EUR 5.-) each.

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders decides to increase the Company’s share capital by an amount of four million

five hundred nineteen thousand eight hundred euro (EUR 4,519,800.-) from its current amount of thirty-one thousand euro
(EUR 31,000.-) represented by six thousand two hundred (6,200) shares up to an amount of four million five hundred fifty
thousand eight hundred euro (EUR 4,550,800.-) through the issuance of nine hundred three thousand nine hundred sixty
(903,960) new shares of the Company, with a par value of five euro (EUR 5.-) through a conversion of part of the existing
available reserves into the share capital of the Company.

The new shares issued are entirely paid up through the conversion of an amount of four million five hundred fifty

thousand eight hundred euro (EUR 4,519,800.-) out of the existing available reserves into the share capital of the Company.

The general meeting of the shareholders expressly and unanimously confirm their agreement with the issue of:
- five hundred forty-two thousand three hundred seventy-six (542,376) shares with a par value of five euro (EUR 5.-)

each to Argos S.p.A. società Fiduciaria e di Revisione representing an aggregate amount of two million seven hundred
eleven thousand eight hundred eighty euro (EUR 2,711,880.-); and

- three hundred sixty-one thousand five hundred eighty-four (361,584) shares with a par value of five euro (EUR 5.-)

each to Lancelot-Consultoria E Marketing LDA representing an aggregate amount of one million eight hundred seven
thousand nine hundred twenty euro (EUR 1,807,920.-);

through the conversion of the aforementioned EUR 4,519,800.- out of the existing available reserves into the share

capital of the Company.

The total value of the conversion of the amount of four million five hundred fifty thousand eight hundred euro (EUR

4,519,800) out of the existing available reserves into the share capital of the Company which the shareholders expressly
approve and which has been confirmed (i) by the interim balance sheet of the Company as of 29 September 2015 as approved
by the shareholders and (ii) by a certificate from the directors of the Company dated 28 October 2015.

The above mentioned interim balance sheet dated 29 September 2015 and the certificate of the directors dated 28 October

2015 have been produced to the undersigned notary which will remain annexed to the present deed.

The appearing parties have, inter alia, waived any transfer restrictions, preemptive rights, rights of first refusal, tag-

along rights, drag-along rights and/or any other rights that may exist with respect to the Company to which the appearing
shareholders are a party in connection with the extraordinary general meeting.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the general meeting of the shareholders decides to amend article 5 of

the articles of association of the Company which shall be enforced and now read as follows:

Art. 5. The share capital is set at four million five hundred fifty thousand eight hundred euro (EUR 4,550,800.-), repre-

sented by nine hundred ten thousand one hundred sixty (910,160) shares with a par value of five euro (EUR 5.-) each.”

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,

followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le trente octobre.
Par-devant nous, Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard, Grand-

Duché de Luxembourg.

A été tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de QU2 S.A., une société anonyme, constituée et régie selon les

lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché
du Luxembourg, et constituée par acte de Maître Jean Seckler, notaire résidant à Junglinster, Grand-Duché du Luxembourg
du 10 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C»), numéro 3730 en
date du 5 décembre 2014. Les statuts de ladite société n’ont pas été modifiés depuis lors (la «Société»).

L’assemblée a été ouverte et présidée par Mlle Stessie Soccio, résidant professionnellement à Luxembourg (le «Prési-

dent»).

Le Président a désigné comme secrétaire et scrutateur Melle Hortense Epaulard, résidant professionnellement à Lu-

xembourg.

156646

L

U X E M B O U R G

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter ce qui

suit:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires
présents, le mandataire des actionnaires représentés, le bureau de l’assemblée et le notaire susmentionné, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Les procurations, paraphées ne varietur par les comparantes et par le notaire, resteront annexées au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.

II. Il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital social de la Société est présent ou représenté et que tous

les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour bien avant la présente assemblée et que par conséquent il n’y avait pas besoin d’envoyer des avis de
convocation.

III. La présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés

à l’ordre du jour.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Réduction de la valeur nominale de chacune des actions de la Société d’un montant de trente et un euros (EUR 31,-)

à cinq euros (EUR 5,-);

2. Augmentation du capital social de la Société par un montant de quatre millions cinq cent dix-neuf mille huit cents

euros (EUR 4.519.800,-) afin de l’augmenter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté
par six mille deux cents (6.200) actions jusqu’au montant de quatre millions cinq cent cinquante mille huit cents euros
(EUR 4.550.800,-) par l’émission de neuf cent trois mille neuf cent soixante (903.960) nouvelles actions de la Société par
l’incorporation d’une partie de ses réserves disponibles actuelles dans le capital social de la Société;

3. Modification de l’article 5 des statuts de la Société; et
4. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l’ordre du jour, l’assemblée générale des actionnaires adopte à

l’unanimité, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de réduire la valeur nominale de chacune des actions de la Société de

trente et un euros (EUR 31,-) à cinq euros (EUR 5,-) chacune.

Ainsi, le capital social de la Société doit être fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par six mille deux

cents (6.200) actions ayant une valeur nominale cinq euros (EUR 5,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de quatre

millions cinq cent dix-neuf mille huit cents euros (EUR 4.519.800,-) afin de l’augmenter de son montant actuel de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par six mille deux cents (6.200) actions jusqu’au montant de quatre millions
cinq cent cinquante mille huit cents euros (EUR 4.550.800,-) par l’émission de neuf cent trois mille neuf cent soixante
(903.960,-) nouvelles actions de la Société, avec une valeur nominale de cinq euros (EUR 5.-) par l’incorporation d’une
partie de ses réserves disponibles actuelles dans le capital social de la Société.

Les actions nouvellement émises sont entièrement libérées par l’incorporation dans le capital de la Société d’un montant

de quatre millions cinq cent dix-neuf mille huit cents euros (EUR 4.519.800,-) issu de ses réserves disponibles actuelles.

L’assemblée générale des actionnaires confirme expressément et unanimement leur accord pour l’émission de:
- cinq cent quarante-deux mille trois cent soixante-seize (542.376) actions d’une valeur nominale de cinq euros (EUR

5,-) chacune à Argos S.p.A. società Fiduciaria e di Revisione représentant un montant total de deux millions sept cent onze
mille huit cent quatre-vingt euros (EUR 2.711.880,-); et

- trois cent soixante et un mille cinq cent quatre-vingt-quatre (361.584) actions d’une valeur nominale de cinq euros

(EUR 5,-) chacune à Lancelot-Consultoria E Marketing LDA représentant un montant total de un million huit cent sept
mille neuf cent vingt euro (EUR 1.807.920,-);

par l’incorporation dans le capital de la Société d’un montant susmentionné de EUR 4.519.800 issu de ses réserves

disponibles actuelles.

La  valeur  totale  de  l’incorporation  du  montant  de  quatre  millions  cinq  cent  dix-neuf  mille  huit  cents  euros  (EUR

4.519.800,-) de ses réserves disponibles est approuvée par les actionnaires de la Société et a été confirmée par (i) un bilan
intérimaire de la Société en date du 29 septembre 2015 tel qu’approuvé par les actionnaires et (ii) un certificat des admi-
nistrateurs de la Société en date du 28 octobre 2015.

Le bilan intérimaire en date du 29 septembre 2015 et le certificat des administrateurs en date du 28 octobre 2015 visés

ci-dessus ont été présentés au notaire soussigné et seront annexés au présent acte.

156647

L

U X E M B O U R G

Les comparantes ont, inter alia, renoncé à toutes restrictions de transfert, droits de préemption, droits de premier refus,

droits de sortie conjointe, obligations de sortie conjointe, et/ou n’importe quels autres droits qui pourraient exister à l’égard
de la Société dont les actionnaires présents sont parties à la présente assemblée générale extraordinaire.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précédent, l’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article 5 des

statuts de la Société qui devra être exécuté et lu comme suit:

«  Art. 5.  Le  capital  social  est  fixé  à  quatre  millions  cinq  cent  cinquante  mille  huit  cents  euros  (EUR  4.550.800,-),

représenté par neuf cent dix mille cent soixante (910.160) actions avec une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-)
chacune.»

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu’à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire des comparantes, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Stessie Soccio, Hortense Epaulard, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 novembre 2015. Relation: EAC/2015/25735. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Monique Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 05 novembre 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015193757/177.
(150216775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2015.

Qubica Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.550.800,00.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 108.598.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth October.
Before us, Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

(i) Phyllis V. Ciniello Trust 11-11-1996, a B.V.I. existing under the laws of the United States of America, having its

registered office at 70, Southport Cove, USA - 34134 Bonita Springs, Florida;

(ii) Argos S.p.A. società Fiduciaria e di Revisone, a company existing under the laws of Italy, having its registered office

at 6, Via Paleocapa, I-20121, Milan, Italy registered with the Register on Companies of Italy under number 1624733;

(iii) Gestion LRO (1997) Inc., a company existing under the laws of Canada, having its registered office at 103, Abbé

Ruelland, CDN - G1ESL4 Beauport, Québec, registered with Industry Canada under number 1146820767;

(iv) Lancelot Consultoria E Marketing LDA, a company existing under the laws of Portugal, having its registered office

at P-9000 176 Funchal, Madère, 6, rua dos llhéus registered with Conservatória do Registo Comercial da Zona Franca da
Madeira, under the number 511 155 212;

(v) Mrs. Eileen Iovine, residing at 22271, Foutain Lakes Boulevard, 314 Estero, USA - 33928 Florida;
(vi) Mr. Roberto Vaioli, residing at 20/A Via S. Andrea, I - 40064 Ozzano dell’Emilia, Italy;
(vii) Mrs. Carol Simard, residing at 264, ST-Gustave, CDN - G0A1E0 Beaupré, Canada;
(viii) Mr. Flavio Taddia, residing at 9/B, Via Cesare Pavese, I-40018 San Pietro in Casale, Italy;
(ix) Mr. Emanuele Govoni, residing at 2, Via Degli Olmi, I-40010 San Matteo della Decima, Italy;
(x) Mr. Luca Drusiani, residing at 6, Via XX Aprile, I-40011 Anzola Dell’Emiglia, Italy;
(xi) Mr. Michael Massey, residing at 4516, Spring Moss Circle, USA - 23059, Glen Allen (Virginia), USA;
(xii) Mr. Patrick Ciniello, residing at 21504, Belhaven Way, USA 33928 Estero (Florida);
(xiii) Mr. Richard Steven Albright, residing at 4516, Spring Moss Circle, USA - 23059, Glen Allen (Virginia), USA;
(xiv) Mr. Sergio Sgarzi, residing at 337/E, Via Saint’Agnese, I-40018 San Pietro in Casale, Italy;
(xv) Mr. Guido Sorba, residing at 74/G, Via Mercadante, I-10154 Turin, Italy; and
(xvi) Mr. Stéphane Asselin, residing at 306, Royale, CDN-G0A4J0 Saint Title des Caps (Québec), Canada;

156648

L

U X E M B O U R G

here all duly represented by Mrs. Stessie Soccio, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxies, given

under private seal.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are all the shareholders entitled to vote of Qubica Lux S.à r.l., (hereinafter the “Company”), a

société à responsabilité limitée, with a share capital of EUR 28,628,127.-, having its registered office at 16, Allée Marconi,
L-2120 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 108598, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, on 7 June 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, number 1142 on 3
November 2005. The articles of association of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of the
aforementioned notary, on 6 June 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, number 1642
on 30 August 2006.

The appearing parties representing all the shareholders entitled to vote declare having waived any notice requirement,

the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following
agenda:

<i>Agenda

1. Reduction of the share capital through the cancellation of the fifty-three thousand seven hundred fifty (53,750) shares

owned by the Company;

2. Reduction of the nominal value of each of the shares of the Company from twenty-nine euro seventy cent (EUR 29.70)

down to five euro (EUR 5.-) each and acknowledgement of the reduction of the share capital of the Company from its
current amount of twenty-eight million six hundred twenty-eight thousand one hundred twenty-seven (EUR 28,628,127.-)
down to four million five hundred fifty thousand eight hundred euro (EUR 4,550,800.-);

3. Amendment of article 7 of the articles of association of the Company; and
4. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires

the notary to enact, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders, having reviewed the interim financial statements of the Company, resolves to

reduce the share capital of the Company so as to bring it from its current amount of twenty-eight million six hundred twenty-
eight thousand one hundred twenty-seven (EUR 28,628,127.-) down to twenty-seven million thirty-one thousand seven
hundred fifty-two euro (EUR 27,031,752.-) through the cancellation of the fifty-three thousand seven hundred fifty (53,750)
shares owned by the Company.

The general meeting of the shareholders resolves to decrease the number of shares from nine hundred sixty-three thou-

sand nine hundred ten (963,910) shares down to nine hundred ten thousand one hundred sixty (910,160) shares for an
aggregate amount of one million five hundred ninety-six thousand three hundred seventy-five euro (EUR 1,596,375.-).

Each and all the shareholders of the Company agree on the above mentioned cancellation of shares and acknowledge

that further to such cancellation of shares, the Company will not hold any of its own shares.

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders decides to reduce the nominal value of each of the shares of the Company from

twenty-nine euro seventy cent (EUR 29.70) down to five euro (EUR 5.-) each.

Accordingly, the share capital of the Company shall be set at four million five hundred fifty thousand eight hundred

euro (EUR 4,550,800.-), represented by nine hundred ten thousand one hundred sixty (910,160) shares with a nominal
value of five euro (EUR 5.-) each.

The amount of twenty-four million seventy-seven thousand three hundred twenty-seven euro (EUR 24,077,327.-) re-

sulting from the reduction will be allocated as follows:

-  An  amount  of  eighteen  million  one  hundred  sixty-seven  thousand  seven  hundred  ten  euro  and  forty  cent  (EUR

18,167,710.40) to the results to be carried forward by the Company (the “Reported Results”); and

- An amount of five million nine hundred nine thousand six hundred sixteen euro and sixty cent (EUR 5,909,616.60) to

the share premium account of the Company.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the general meeting of the shareholders decides to amend article 7 of

the articles of association of the Company which shall be enforced and now read as follows:

Art. 7. The share capital is set at four million five hundred fifty thousand eight hundred euro (EUR 4,550,800.-), repre-

sented by nine hundred ten thousand one hundred sixty (910,160) shares with a nominal value of five euro (EUR 5.-) each--

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

156649

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le trente octobre.
Par-devant nous, Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard, Grand-

Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

(i) Phyllis V. Ciniello Trust 11-11-1996, une B.V.I. constituée et régie selon le droit des Etats-Unis d’Amérique, ayant

son siège social au 70, Southport Cove, USA - 34134 Bonita Springs, Florida;

(ii) Argos S.p.A. società Fiduciaria e di Revisone, une société constituée et régie selon le droit de l’Italie, ayant son

siège social au 6, Via Paleocapa, I-20121, Milan, Italie, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de
l’Italie sous le numéro 1624733;

(iii) Gestion LRO (1997) Inc., une société constituée et régie selon le droit du Canada, ayant son siège social au 103,

Abbé Ruelland, CDN - G1ESL4 Beauport, Québec, immatriculée auprès du registre de l’Industrie du Canada sous le numéro
1146820767;

(iv) Lancelot Consultoria E Marketing LDA, une société constituée et régie selon le droit du Portugal, ayant son siège

social au P-9000 176 Funchal, Madère, 6, rua dos llhéus immatriculée auprès du registre Conservatória do Registo Come-
rcial da Zona Franca da Madeira, sous le numéro 511 155 212;

(v) Mrs. Eileen Iovine, domiciliée au 22271, Foutain Lakes Boulevard, 314 Estero, 33928 Floride, Etats-Unis d’Amé-

rique;

(vi) Mr. Roberto Vaioli, domicilié au 20/A Via S. Andrea, I - 40064 Ozzano dell’Emilia, Italie;
(vii) Mrs. Carol Simard, domiciliée au 264, ST-Gustave, CDN - G0A1E0 Beaupré, Canada;
(viii) Mr. Flavio Tadio, domicilié au 9/B, Via Cesare Pavese, I-40018 San Pietro in Casale, Italie;
(ix) Mr. Emanuele Govoni, domicilié au 2, Via Degli Olmi, I-40010 San Matteo della Decima, Italie;
(x) Mr. Luca Drusiani, domicilié au 6, Via XX Aprile, I-40011 Anzola Dell’Emiglia, Italie;
(xi) Mr. Michael Massey, domicilié au 4516, Spring Moss Circle, 23059, Glen Allen (Virginia), Etats-Unis d’Amérique;
(xii) Mr. Patrick Ciniello, domicilié au 21504, Belhaven Way, 33928 Estero (Floride), Etats-Unis d’Amérique;
(xiii) Mr. Richard Steven Albright, domicilié au 4516, Spring Moss Circle, 23059, Glen Allen (Virginie), Etats-Unis

d’Amérique;

(xiv) Mr. Sergio Sgarzi, domicilié au 337/E, Via Saint’Agnese, I-40018 San Pietro in Casale, Italie;
(xv) Mr. Guido Sorba, domicilié au 74/G, Via Mercadante, I-10154 Turin, Italie; and
(xvi) Mr. Stéphane Asselin, domicilié au 306, Royale, CDN-G0A4J0 Saint Title des Caps (Québec), Canada;
ici tous représentés par Melle Stessie Soccio, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé.

Les procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire, resteront annexées au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.

Les comparants sont tous les associés habilités à voter de Qubica Lux S.à r.l. (ci-après la “Société”), une société à

responsabilité limitée, avec un capital social de EUR 28.628.127,- , ayant son siège social au 16, Allée Marconi, L-2120
Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 108598, constituée selon acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg en date du 7 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1142 en date
du 3 novembre 2005. Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 6
juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1642 en date du 30 août 2006.

Les comparants représentant tous les associés habilités à voter déclarent avoir renoncé à toute formalité de convocation.

L’assemblée  générale  des  associés  est  ainsi  régulièrement  constituée  et  peut  valablement  délibérer  sur  tous  les  points
figurant à l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Réduction du capital social par l’annulation de cinquante-trois mille sept cent cinquante euros (EUR 53.750) parts

sociales détenues par la Société;

2. Réduction de la valeur nominale de chaque part sociale de la Société de vingt-neuf euros et soixante-dix centimes

(EUR 29,70) à cinq euros (EUR 5.-) chacune et reconnaissance de la réduction du capital social de la Société de son montant

156650

L

U X E M B O U R G

actuel de vingt-huit millions six cent vingt-huit mille cent vingt-sept euros (EUR 28.628.127,-) à quatre millions cinq cent
cinquante mille huit cents euros (EUR 4.550.800,-);

3. Modification de l’article 7 des statuts de la Société; et
4. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l’ordre du jour, l’assemblée générale des associés adopte à l’una-

nimité, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés, après avoir revu les comptes intermédiaires de la Société, décide de réduire le capital

social de la Société afin de le réduire de son montant actuel de vingt-huit millions six cent vingt-huit mille cent vingt-sept
euros (EUR 28.628.127,-) à un montant de vingt-sept millions trente et un mille sept cent cinquante-deux euros (EUR
27.031.752,-) par l’annulation de cinquante-trois mille sept cent cinquante euros (EUR 53.750) parts sociales détenues par
la Société.

L’assemblée générale des associés décide de diminuer le nombre de parts sociales de neuf cent soixante-trois mille neuf

cent dix (963.910) parts sociales à neuf cent dix mille cent soixante (910.160) parts sociales pour un montant total de un
million cinq cent quatre-vingt-seize mille trois cent soixante-quinze euros (EUR 1.596.375,-).

Tous les associés de la Société acceptent l’annulation des parts sociales telle que mentionnée ci-dessus et reconnaissent

que suivant cette annulation, la Société ne détiendra plus aucune de ses parts sociales.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des associés décide de diminuer la valeur nominale de chaque part sociale de la Société de vingt-

neuf euros et soixante-dix centimes (EUR 29,70) à cinq euros (EUR 5.-) chacune.

Ainsi, le capital social de la Société devra être fixé à quatre millions cinq cent cinquante mille huit cents euros (EUR

4.550.800,-) représenté par neuf cent dix mille cent soixante (910.160) parts sociales d’une valeur nominale de cinq euros
(EUR 5.-) chacune.

Le montant de vingt-quatre millions soixante-dix-sept mille trois cent vingt-sept euros (EUR 24.077.327,-) résultant de

la réduction sera alloué comme suit:

- Un montant de dix-huit millions cent soixante-sept mille sept cent dix euros et quarante centimes (EUR 18.167.710,40)

retenu par la Société (les «Résultats Reportés»); et

- Un montant de cinq millions neuf cent neuf mille six cent seize euros et soixante centimes (EUR 5.909.616,60) à la

prime d’émission de la Société.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précédent, l’assemblée générale des associés décide de modifier l’article 7 des statuts

de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 7. Le capital social est fixé à un montant de quatre millions cinq cent cinquante mille huit cents euros (EUR

4.550.800) représenté par neuf cent dix mille cent soixante (910.160) actions ayant une valeur nominale de cinq euros
(EUR 5.-) chacune.»

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Stessie Soccio, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 novembre 2015. Relation: EAC/2015/25734. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Monique Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 05 novembre 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015193756/190.

(150216742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2015.

156651

L

U X E M B O U R G

JMW Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 89.722.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015167763/9.
(150184860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

D'co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 102.708.

Dété Publicité &amp; Communication S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 57.905.

L'an deux mille quinze, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU

1.- La société à responsabilité limitée DéTé PUBLICITE &amp; COMMUNICATION S.à r.l., ayant son siège social à L-1741

Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
57.905,

dûment représentée par deux de ses gérants, à savoir:
- Monsieur Dan THILL, conseiller en communication, demeurant à L-8084 Bertrange, 56, rue de la Pétrusse, et
- Monsieur Claude NESSER, publicitaire, demeurant à L-8137 Bridel, 3, rue des Hêtres,
(ci-après la Société Absorbée),
2.- La société à responsabilité limitée D'co S.à r.l., ayant son siège social à L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.708,

dûment représentée par deux de ses gérants, à savoir:
- Monsieur Dan THILL, prénommé, et
- Monsieur Claude NESSER, prénommé,
(ci-après la Société Absorbante)

<i>Données et objectifs de la fusion projetée

Les organes de gestion de la Société Absorbante et de la Société Absorbée (ensemble les «Sociétés») proposent de

fusionner les Sociétés et ont arrêté le présent projet de fusion.

<i>Dispositions du projet de fusion

Description des sociétés à fusionner:
1. Société Absorbée
La société à responsabilité limitée DéTé PUBLICITE &amp; COMMUNICATION S.à r.l., ayant son siège social à L-1741

Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
57.905, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Christine DOERNER, de résidence à Bettembourg, en date du 20
janvier 1997, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 230 du 9 mai 1997, et dont les statuts ont
été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le notaire Jacques DELVAUX, alors de résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre 1999,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 264 du 7 avril 2000,

- suivant acte reçu par le notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, en date du 9 décembre 2003, publié au

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 157 du 7 février 2004,

- suivant acte reçu par le notaire Tom METZLER, alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 23 septembre

2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1215 du 26 novembre 2004,

- suivant acte reçu par le même notaire Tom METZLER, en date du 21 janvier 2009, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations numéro 532 du 11 mars 2009,

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 novembre 2012, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 3084 du 24 décembre 2012.

156652

L

U X E M B O U R G

Le capital social s'élève à QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (€ 90.000.-), représenté par trois mille six cents

(3.600) parts sociales de VINGT-CINQ EUROS (€ 25.-) chacune, lesquelles parts sont détenues comme suit:

1.- La société anonyme D.T. FINANCE S.A., ayant son siège social à L-8084 Bertrange, 56, rue de la Pétrusse,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 102.705, mille cinq cent
soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.560
2.- Monsieur Claude NESSER, publicitaire, demeurant à L-8137 Bridel, 3, rue des Hêtres, sept cent
soixante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

765

3.- Monsieur Dan THILL, conseiller en communication, demeurant à L-8084 Bertrange, 56, rue de la Pétrusse,
trois cent soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360

5.- Monsieur Christophe ROYEN, employé privé, demeurant à L-7216 Bereldange, 2, rue Bour, sept cent
soixante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

765

6.- Monsieur Patrick KEMPER, employé privé, demeurant à B-6700 Waltzing, 19, rue Rentertkapell, cent
cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

Total: trois mille six cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600

2.- Société Absorbante
La société à responsabilité limitée D'co S.à r.l., ayant son siège social à L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.708, a été constituée suivant acte
reçu par le notaire Tom METZLER, alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 31 août 2004, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1124 du 9 novembre 2004, et dont les statuts ont été modifiés
comme suit:

- suivant acte reçu par le même notaire Tom METZLER, en date du 21 janvier 2009, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations numéro 419 du 25 février 2009,

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 novembre 2012, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 3065 du 20 décembre 2012.

Le capital social s'élève à DOUZE MILLE SIX CENTS EUROS (€ 12.600.-), représenté par trois cent soixante (360)

parts sociales de TRENTE-CINQ EUROS (€ 35.-) chacune, lesquelles parts sont détenues comme suit:

1.- La société anonyme D.T. FINANCE S.A., préqualifiée, cent cinquante-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . 156
2.- Monsieur Claude NESSER, prénommé, soixante-seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

3.- Monsieur Dan THILL, prénommé, trente-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

5.- Monsieur Christophe ROYEN, prénommé, soixante-dix-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

6.- Monsieur Patrick KEMPER, prénommé, quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Total: trois cent soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

<i>Modalités de la Fusion

1. Il est prévu que la société D'co S.à r.l. absorbe la société DéTé PUBLICITE &amp; COMMUNICATION S.à r.l. au moyen

d'une fusion par absorption conformément aux articles 261 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales («loi de 1915»). Les organes de gestion de chacune des Sociétés ont décidé de proposer cette fusion lors de
leurs réunions respectives en date du 27 novembre 2015.

2. Les associés des Sociétés ont décidé en conformité avec l'article 266 alinéa (5) de la loi de 1915 de renoncer à l'examen

du projet commun de fusion par des experts indépendants et au rapport d'expert.

3. Rapport d'échange - Modalité d'attribution des parts
Conformément aux articles 259 et suivants de la Loi Luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

telle que modifiée, la société DéTé PUBLICITE &amp; COMMUNICATION S.à r.l. (ci-après «la Société Absorbée») fera
apport de tous ses actifs et passifs à la société D'co S.à r.l. (ci-après «la Société Absorbante»).

Sur base de la valeur nette comptable de la société Absorbante et de la société Absorbée le rapport d'échange est le

suivant:

Actif Net de la société D'co S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 265.824,75
Nombre de parts émises: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360

Valeur nette par part: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 738,40

Actif Net de la société DéTé PUBLICITE &amp; COMMUNICATION S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 569.253,96
Nombre de parts émises: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3600

Valeur nette par part: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 158,13

Sur base de la valeur nette comptable de la Société Absorbante et de la Société Absorbée, le rapport d'échange est le

suivant:

738,40 / 158,13 = 4,67

156653

L

U X E M B O U R G

c'est-à-dire 4,67 parts de la Société Absorbée DéTé PUBLICITE &amp; COMMUNICATION S.à r.l. contre 1 part de la

société Absorbante D'co S.à r.l..

Aucune difficulté particulière n'a été rencontrée dans la détermination de la valeur nette comptable des sociétés et du

rapport d'échange.

Il y a lieu de procéder, dans le cadre de la fusion, à une augmentation de capital dans le cadre de la société absorbante

D'co S.à r.l. (Société Absorbante).

Il résulte du rapport d'échange ci-dessus arrêté que les associés de la Société Absorbée devront recevoir au prorata de

leur participation dans le capital social, en échange de leurs 3600 parts détenues dans la société absorbée DéTé PUBLICITE
&amp; COMMUNICATION S.à r.l. 771 parts nouvelles dans la société absorbante D'co S.à r.l..

En échange de cet apport, la société D'co S.à r.l. augmentera dès lors son capital, qui est à l'heure actuelle de douze mille

six cents Euros (EUR 12.600.-), représenté par trois cent soixante (360) parts sociales d'un montant de vingt-six mille neuf
cent quatre-vingt-cinq Euros (EUR 26.985.-) par l'émission de sept cent soixante-et-onze (771) parts sociales pour le porter
au montant de trente-neuf mille cinq cent quatre-vingt-cinq Euros (EUR 39.585.-).

Un montant de cinq cent quarante-deux mille deux cent soixante-huit Euros quatre-vingt-seize Cents (EUR 542.268,96)

sera alloué au compte de prime de fusion de la Société.

Les nouvelles parts sociales émises auront les mêmes droits et avantages que les 360 parts sociales existantes de la

société D'co S.à r.l..

Elles donneront droit de participer aux bénéfices de la Société Absorbante à partir du 1 

er

 janvier 2016.

4. L'échange sera effectué le jour où la fusion des Sociétés sera décidée par leurs assemblées générales respectives à

tenir devant notaire.

5. Les parts sociales détenues par les associés de la Société Absorbante dans la Société Absorbée seront annulées lors

de la réalisation de la fusion.

<i>Date de prise d'effet sur le plan comptable et juridique

La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront, à des fins comptables, traitées comme étant

réalisées au nom de la Société Absorbante est fixée au 1 

er

 janvier 2016.

<i>Respect des droits particuliers

Il n'y a pas d'associés ayant des droits spéciaux ou de porteurs de titres ayant des droits spéciaux dans aucune des Sociétés.

<i>Attribution d'avantages particuliers

Aucun avantage particulier n'est attribué aux associés et aux gérants des Sociétés à l'occasion de la fusion.

<i>Conséquences de la Fusion

La fusion entraînera de plein droit le transfert des actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante

conformément à l'art 274 de la loi de 1915. Néanmoins le transfert des droits immobiliers ne sera opposable aux tiers
qu'après leur transcription aux bureaux des hypothèques compétents.

Les créanciers des Sociétés qui fusionnent et dont la créance est antérieure à la date de la publication du projet de fusion

prévue à l'article 262 peuvent nonobstant toute convention contraire dans les deux mois de cette publication demander au
Magistrat présidant la Chambre du Tribunal d'Arrondissement dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social
siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûreté pour des créances échues et non-
échues au cas où l'opération de fusion réduirait les gages de ces créanciers.

Les mandats des gérants de la Société Absorbée prennent fin à la date de la fusion.

<i>Information

Tous les associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont le droit, pendant un mois à compter de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du projet de fusion, de prendre connaissance au siège
social de la Société Absorbante des documents suivants:

a. Le Projet de fusion
b. Les comptes annuels des exercices 2013, 2014 ainsi qu'une situation comptable arrêtée au 30 septembre 2015 des

sociétés D'co S.à r.l. et DéTé PUBLICITE &amp; COMMUNICATION S.à r.l..

Des copies pourront être obtenues par tout associé sans frais et sur simple demande.
Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société Absorbante.
La Société Absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la cession

de tous les avoirs et obligations de la Société Absorbée.

Pour tout point non prévu ci-dessus, les Sociétés Fusionnantes se réfèrent à la Loi sur les Sociétés.
Les coûts et les frais de la fusion seront supportés par la Société Absorbante.
Modifications au projet de fusion:

156654

L

U X E M B O U R G

Un ou plusieurs points du présent projet de fusion pourra toujours être modifié ou complété par l'Assemblée Générale

Extraordinaire.

Modifications statutaires:
Dans le cadre de la fusion définitive, il est prévu de procéder aux modifications statutaires suivantes:
1) le capital social de la société absorbante sera augmenté du montant de quatre-vingt-six mille quatre cent quinze Euros

(EUR 86.415.-) pour le porter du montant de trente-neuf mille cinq cent quatre-vingt-cinq Euros (EUR 39.585.-) au montant
de cent vingt-six mille Euros (EUR 126.000.-) par l'émission de deux mille quatre cent soixante-neuf (2.469) parts sociales
nouvelle de trente-cinq Euros (EUR 35.-) chacune, moyennant incorporation d'une partie du compte de prime de fusion;

2) la refonte des statuts de la société absorbante.

<i>Certification

Le notaire soussigné certifie par les présentes l'existence et la légalité du Projet de Fusion et de tous actes, documents

et formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes conformément à la Loi sur les Sociétés.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, ceux-ci ont signé avec le

notaire le présent acte.

Signé: D. THILL, C. NESSER, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 1 

er

 décembre 2015. Relation: GAC/2015/10476. Reçu douze euros 12,00

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 1 

er

 décembre 2015.

Référence de publication: 2015194889/174.
(150217625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

GP-2 Munich B LBC Vesta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.281.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second of October.
Before Us, Maître Roger Arrensdorff, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

GP-6 Resi LBC Vesta S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and

existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653  Luxembourg,  and  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Register,  section  B,  under  number
132.279;

here represented by Norbert Porcsin, with professional address at l-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, by

virtue of a power of attorney established on 15 October 2015.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée")

existing in Luxembourg under the name of "GP-2 Munich B LBC Vesta S.à r.l.", having its registered office at 2, Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B,
under number 132.281, incorporated by a deed of the notary Martine Schaeffer in Luxembourg of 12 September 2007,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2520 of 7 November 2007 whose articles have
been amended for the last time by a deed of the notary Joseph Elvinger in Luxembourg on 12 january 2009, published in
the said Mémorial C, under number 567 on 16 March 2009.

II. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by ten

thousand (10,000) shares with a nominal value of one Euro and twenty-five Euro Cent (EUR 1.25) each.

III. The sole shareholder resolves to dissolve the Company anticipatively and to put it into liquidation.
IV. The sole shareholder resolves to appoint GP-6 Resi LBC Vesta S.à r.l., prenamed, as liquidator of the Company.
The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148 bis of the Luxembourg companies law.

He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required by law.

156655

L

U X E M B O U R G

All powers are granted to the liquidator to represent the Company for all operations being a matter of liquidation purpose

to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the Company to the sole shareholder, in
kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all

either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case arises,
grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries, gar-
nishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages
and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments,
remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce
remedies at law or acquired rights of prescription.

V. The sole shareholder resolves to give full discharge to the members of the Board of Managers of the Company for

the accomplishment of their mandate unless the liquidation reveals faults in the execution of their duty.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the present sole shareholder's meeting are estimated at seven hundred Euro (EUR 700.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English

version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Surname,

Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GP-6 Resi LBC Vesta S.à r.l., une société à responsabilité limitée existante sous les lois luxembourgeoises, dont le siège

social est au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 132.279;

ici représentée par Norbert Porcsin, demeurant au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée le 15 octobre 2015.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Le comparant est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

"GP-2 Munich B LBC Vesta S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Lu-
xembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 132.281,
constituée suivant acte du notaire Martine Schaeffer de Luxembourg reçu en date du 12 septembre 2007, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2520 du 7 novembre 2007 et dont les articles ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte du notaire Joseph Elvinger de Luxembourg en date du 12 janvier 2009, publié au dit Mémorial
C, numéro 567 du 16 mars 2009.

II. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par dix mille (10.000) parts sociales

d'une valeur nominale de un euro et vingt-cinq Euro cents (EUR 1,25) chacune.

III. L’associé unique décide la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation volontaire.
IV. L’associé unique décide de nommer GP-6 Resi LBC Vesta S.à r.l., préqualifiée, comme liquidateur de la Société.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commerciales.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle
est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la

liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux associés, en nature ou en
numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui suit soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles

qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et
actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des
hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs

156656

L

U X E M B O U R G

d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes;
transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des
prescriptions acquises.

V. L’associé unique décide de donner décharge aux membres du Conseil de Gérance de la Société, sauf si la liquidation

fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombaient.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cents euros (EUR 700,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant représenté

par son mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et

demeure, il a signé avec nous notaire, le présent acte.

Signé: PORCSIN, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 octobre 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 33704. Reçu douze euros 12,00

<i>Le Receveur (signe): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Référence de publication: 2015185383/110.
(150206950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

GP-5 Berlin LBC Vesta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.502.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second of October.
Before Us, Maître Roger Arrensdorff, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

GP-6 Resi LBC Vesta S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and

existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653  Luxembourg,  and  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Register,  section  B,  under  number
132.279;

here represented by Norbert Porcsin, with professional address at l-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, by

virtue of a power of attorney established on 15 October 2015.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée")

existing in Luxembourg under the name of "GP-5 Berlin LBC Vesta S.à r.l.", having its registered office at 2, Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B,
under number 132.502, incorporated by a deed of the notary Martine Schaeffer de Luxembourg of 12 September 2007,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2570 of 12 November 2007, whose articles have
been amended for the last time by a deed of the notary Joseph Elvinger in Luxembourg on 12 january 2009, published in
the said Mémorial C, under number 540 on 12 March 2009.

II. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by ten

thousand (10,000) shares with a nominal value of one Euro and twenty-five Euro Cent (EUR 1.25) each.

III. The sole shareholder resolves to dissolve the Company anticipatively and to put it into liquidation.
IV. The sole shareholder resolves to appoint GP-6 Resi LBC Vesta S.à r.l., prenamed, as liquidator of the Company.
The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148 bis of the Luxembourg companies law.

He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required by law.

156657

L

U X E M B O U R G

All powers are granted to the liquidator to represent the Company for all operations being a matter of liquidation purpose

to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the Company to the sole shareholder, in
kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all

either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case arises,
grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries, gar-
nishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages
and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments,
remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce
remedies at law or acquired rights of prescription.

V. The sole shareholder resolves to give full discharge to the members of the Board of Managers of the Company for

the accomplishment of their mandate unless the liquidation reveals faults in the execution of their duty.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the present sole shareholder's meeting are estimated at seven hundred Euro (EUR 700.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English

version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Surname,

Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GP-6 Resi LBC Vesta S.à r.l., une société à responsabilité limitée existante sous les lis luxembourgeoises, dont le siège

social est au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 132.279;

ici représentée par Norbert Porcsin, demeurant au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée le 15 octobre 2015.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Le comparant est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

"GP-5 Berlin LBC Vesta S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 132.502, constituée
suivant acte du notaire Martine Schaeffer de Luxembourg reçu en date du 12 septembre 2007, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 2570 du 12 novembre 2007 et dont les articles ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte du notaire Joseph Elvinger de Luxembourg en date du 12 janvier 2009, publié au dit Mémorial C, numéro
540 du 12 mars 2009.

II. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par dix mille (10.000) parts sociales

d'une valeur nominale de un euro et vingt-cinq Euro cents (EUR 1,25) chacune.

III. L’associé unique décide la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation volontaire.
IV. L’associé unique décide de nommer GP-6 Resi LBC Vesta S.à r.l., préqualifiée, comme liquidateur de la Société.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commerciales.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle
est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la

liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux associés, en nature ou en
numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui suit soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles

qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et
actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des
hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs

156658

L

U X E M B O U R G

d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes;
transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des
prescriptions acquises.

V. L’associé unique décide de donner décharge aux membres du Conseil de Gérance de la Société, sauf si la liquidation

fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombaient.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cents euros (EUR 700,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant représenté

par son mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et

demeure, il a signé avec nous notaire, le présent acte.

Signé: PORCSIN, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 octobre 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 33705. Reçu douze euros 12,00

<i>Le Receveur (signe): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Référence de publication: 2015185384/110.
(150207020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Fox III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 123.154.

In the year two thousand and fifteen, on the the twenty-second of October.
Before Us, Maître Roger Arrensdorff, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Fox Luxco S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under

the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxem-
bourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 123.515;

here represented by Norbert Porcsin, with professional address at l-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, by

virtue of a power of attorney established on 15 October 2015.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée")

existing in Luxembourg under the name of "Fox III S.à r.l.", having its registered office at 2 Avenue Charles de Gaulle,
L-1653  Luxembourg,  and  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Register,  section  B,  under  number
123.154, incorporated by a deed of the notary Joseph Elvinger in Luxembourg of 19 December 2006, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 236 of 23 February 2007, whose articles have been amended
for the last time by a deed of the notary Joseph Elvinger in Luxembourg on 12 january 2009, published in the said Mémorial
C, under number 707 on 1 

st

 April 2009.

II. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to dissolve the Company anticipatively and to put it into liquidation.
IV. The sole shareholder resolves to appoint Fox Luxco S.à r.l., prenamed, as liquidator of the Company.
The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148 bis of the Luxembourg companies law.

He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required by law.

156659

L

U X E M B O U R G

All powers are granted to the liquidator to represent the Company for all operations being a matter of liquidation purpose

to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the Company to the sole shareholder, in
kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all

either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case arises,
grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries, gar-
nishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages
and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments,
remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce
remedies at law or acquired rights of prescription.

V. The sole shareholder resolves to give full discharge to the members of the Board of Managers of the Company for

the accomplishment of their mandate unless the liquidation reveals faults in the execution of their duty.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the present sole shareholder's meeting are estimated at seven hundred euros (EUR 700,-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English

version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Surname,

Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Fox Luxco S.à r.l., une société à responsabilité limitée existante sous les lois luxembourgeoises, dont le siège social est

au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 123.515;

ici représentée par Norbert Porcsin, demeurant au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée le 15 octobre 2015.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Le comparant est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

"Fox III S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 123.154, constituée suivant
acte du notaire Joseph Elvinger de Luxembourg reçu en date du 19 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 236 du 23 févier 2006 et dont les articles ont été modifiés pour la dernière fois suivant
acte du notaire Joseph Elvinger de Luxembourg en date du 12 janvier 2009, publié au dit Mémorial C, numéro 707 du 1

er

 avril 2009.

II. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.

III. L’associé unique décide la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation volontaire.
IV. L’associé unique décide de nommer Fox Luxco S.à r.l., préqualifiée, comme liquidateur de la Société.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commerciales.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle
est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la

liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux associés, en nature ou en
numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui suit soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles

qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et
actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des
hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs

156660

L

U X E M B O U R G

d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes;
transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des
prescriptions acquises.

V. L’associé unique décide de donner décharge aux membres du Conseil de Gérance de la Société, sauf si la liquidation

fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombaient.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cents euros (EUR 700,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant représenté

par son mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et

demeure, il a signé avec nous notaire, le présent acte.

Signé: PORCSIN, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 octobre 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 33707. Reçu douze euros 12,00

<i>Le Receveur (signe): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Référence de publication: 2015185348/109.
(150207274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

LBP Luxco GP 1-Hanover S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.518.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second of October.
Before Us, Maître Roger Arrensdorff, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

LBP Luxco GP 3-Condo S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and

existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653  Luxembourg,  and  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Register,  section  B,  under  number
120.706;

here represented by Norbert Porcsin, with professional address at l-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, by

virtue of a power of attorney established on 15 October 2015.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée")

existing in Luxembourg under the name of "LBP Luxco GP 1-Hanover S.à r.l.", having its registered office at 2, Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B,
under number 120.518, incorporated by a deed of the notary Joseph Elvinger in Luxembourg on 7 September 2006, pu-
blished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2243 of 30 November 2006, whose articles
have been amended for the last time by a deed of the said notary Elvinger on 12 january 2009, published in the said Mémorial
C, under number 581 on 17 March 2009.

II. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to dissolve the Company anticipatively and to put it into liquidation.
IV. The sole shareholder resolves to appoint LBP Luxco GP 3-Condo S.à r.l., prenamed, as liquidator of the Company.
The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148 bis of the Luxembourg companies law.

He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required by law.

156661

L

U X E M B O U R G

All powers are granted to the liquidator to represent the Company for all operations being a matter of liquidation purpose

to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the Company to the sole shareholder, in
kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all

either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case arises,
grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries, gar-
nishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages
and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments,
remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce
remedies at law or acquired rights of prescription.

V. The sole shareholder resolves to give full discharge to the members of the Board of Managers of the Company for

the accomplishment of their mandate unless the liquidation reveals faults in the execution of their duty.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the present sole shareholder's meeting are estimated at seven hundred Euro (EUR 700.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English

version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Surname,

Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LBP Luxco GP 3-Condo S.à r.l., une société à responsabilité limitée existante sous les lois luxembourgeoises, dont le

siège social est au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120.706;

ici représentée par Norbert Porcsin, demeurant au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée le 15 octobre 2015.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Le comparant est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

"LBP Luxco GP 1-Hanover S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Lu-
xembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 120.518,
constituée suivant acte du notaire Joseph Elvinger de Luxembourg reçu en date du 7 septembre 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2243 du 30 novembre 2006 et dont les articles ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte dudit notaire Elvinger en date du 12 janvier 2009, publié au dit Mémorial C, numéro 581 du 17
mars 2009.

II. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25.-) chacune.

III. L’associé unique décide la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation volontaire.
IV. L’associé unique décide de nommer LBP Luxco GP 3-Condo S.à r.l., préqualifiée, comme liquidateur de la Société.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commerciales.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle
est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la

liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux associés, en nature ou en
numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui suit soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles

qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et
actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des
hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs

156662

L

U X E M B O U R G

d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes;
transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des
prescriptions acquises.

V. L’associé unique décide de donner décharge aux membres du Conseil de Gérance de la Société, sauf si la liquidation

fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombaient.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cents euros (EUR 700,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant représenté

par son mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et

demeure, il a signé avec nous notaire, le présent acte.

Signé: PORCSIN, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 octobre 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 33702. Reçu douze euros 12,00

<i>Le Receveur (signe): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 12 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184786/110.
(150205601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

ICG EFV Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 163.939.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth of September.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of ICG EFV Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company

(société à responsabilité limitée), having its registered office at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy
of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 163.939 (the “Com-
pany”),  incorporated  by  a  notarial  deed  on  1  September  2011,  published  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations, number 2882 of 25 November 2011, page 138290 (the "Company").

The articles of association of the Company have been amended for the last time by a notarial deed of March 28, 2013,

published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated June 28, 2013, number 1550.

The meeting was opened with Mrs Gwendoline Boone, employee, professionally residing in Hesperange, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Agathe Kahn, employee, professionally residing in Hesperange.

The meeting elected as scrutineer Mr Emmanuel Gilson de Rouvreux, employee, professionally residing in Hesperange.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
1. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Transfer of the registered office of the Company, as from 1 

st

 January 2016, from 33, rue de Gasperich, L-5826

Hesperange to 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Amendment to the first and fourth paragraphs of Article 5 of the articles of association in order to reflect the change

of the registered office. The first and fourth paragraphs to be reworded respectively as follows:

“The registered office is established in Hesperange. As from the 1 

st

 January 2016, the registered office of the Company

will be established in Luxembourg.”

“The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.”

156663

L

U X E M B O U R G

2. The appearing parties are shown on an attendance list, signed ne varietur by the proxyholder of the represented parties,

the member of the bureau and the undersigned notary, which will remain annexed to the present deed. The proxies of the
shareholders will also remain annexed to the present deed.

3. As a result of the aforementioned attendance list, all the existing shares (parts sociales) in issue are represented at the

present General Meeting, which is consequently validly constituted and may validly deliberate and decide on the items of
the agenda.

4. The appearing parties represented at the meeting declares (i) to waive the convening notice for the meeting and (ii)

to be fully aware of all the items of the agenda.

The appearing parties requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution:

The general meeting RESOLVED to transfer the registered office of the Company, as from 1 

st

 January 2016, from 33,

rue de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Second resolution:

The general meeting RESOLVED to amend the first and fourth paragraphs of Article 5 of the articles of association of

the Company in order to reflect the change of the registered office.

The articles of association of the Company shall henceforth read as follows:

Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will

be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated 10 

th

 August,

1915, on commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the articles of association (hereafter the
“Articles”), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Lu-

xembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities and assets of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion the Company may grant assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise to group

companies as well as to any other entity that is or will be investing in group companies and to any other entity it is interested
in, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accom-
plishment and development of its purposes. For the purpose of this article, the notion of group shall include all parent
companies of the Company, subsidiaries and entities in which the parent companies or their subsidiaries hold a direct or
indirect participation (each hereafter referred to as a "Group Company").

The Company may in particular (a) borrow money in any form and raise funds through, including but not limited to,

the issue of bonds, notes, and other debt instruments, convertible or not, within the limits of the law, including borrowing
from Group Companies, (b) advance, lend or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Group Company,
with or without a security interest and (c) enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance
of any contracts or obligations of the Company or of any Group Company.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination “ICG EFV Luxembourg S.à r.l.”.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in Hesperange. As from the 1 

st

 January 2016, the registered

office of the Company will be established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary

general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in

case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 - Subscribed and authorised share capital
The Company's corporate capital is fixed at EUR 2,460,855.- (two million four hundred and sixty thousand eight hundred

and fifty-five Euros) represented by 2,460,855 (two million four hundred and sixty thousand eight hundred and fifty-five)
shares (parts sociales) of EUR 1,- (one Euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.

156664

L

U X E M B O U R G

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among
others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and
the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders’

meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.

6.3 - Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in existence.
6.4 - Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the

requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters

of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of
Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Stapling of shares
The shares may be stapled to convertible instruments in accordance with the terms and conditions of the concerned

convertible instruments.

Any shareholder who transfers one or more of his shares in the capital of the Company to a third party is obligated to

transfer a same proportion of his convertible instruments, if any, to that same third party, in accordance with the applicable
terms and conditions of the concerned convertible instruments.

In the event of any shareholder holding share(s) surrenders one or more shares in the capital of the Company pursuant

to a redemption, such shareholder is obligated to surrender the same proportion of convertible instruments which are issued
in reference to such shares, if any, to the Company and the latter is obligated to redeem the said convertible instruments,
if any, in accordance with the terms and conditions of the concerned convertible instruments.

6.7 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in accordance

with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management.
7.1 - Appointment and removal
The Company is managed by one (1) or more managers. The manager(s) need not be shareholder(s).
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.
The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same.
7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.3 - Representation and signatory power
Subject to the provisions of Article 7.3 §2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will

have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint

signature of any two (2) managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman.
It may also choose a secretary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the

meetings of the board of managers and of the shareholders.

156665

L

U X E M B O U R G

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the managers and by the

chairman and the secretary if any, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the

chairman, by the secretary or by any manager.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a simple majority of managers present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 - Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders’ meeting. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’

meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him. Collective
decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of shareholders does not exceed

twenty-five (25). In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders’ meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), an annual

general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the
Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15 

th

 day of the month

of June, at 11 am. If such day is not a bank business day in the Grand Duchy of Luxembourg, the annual general meeting
shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute
and final judgment of the board of managers, exceptional circumstances so require.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be

supervised by one (1) or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder.
If there is more than one (1) statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.
11.1 - Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1 

st

 of April and ends on the 31 

st

 of March of following year, with the exception

of the first year, which shall being on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31 

st

 of March

2012.

11.2 - Annual accounts
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office, the

above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-
up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits. The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general

expenses, amortization and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until

and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the

Company.

Within the limits as set out by law, interim dividends may be distributed upon resolution of the board of managers, at

any time and once or several times during a given fiscal year, subject to the satisfaction of the following conditions:

i. statutory accounts of the previous fiscal year must have been approved by the shareholder(s);

156666

L

U X E M B O U R G

ii. interim accounts not older than one (1) month preceding the distribution date must be prepared by the board of

managers;

iii. such interim dividends may only be paid out of the interim profits of the current fiscal year plus any distributable

reserves, plus any profits carried forward minus any losses carried forward.

Interim dividends may be paid in cash or in kind at the discretion of the board of managers.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to
the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le trente septembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés (l’«Assemblée Générale») de ICG EFV Luxembourg S.à r.l, une

société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.939, constituée
par acte notarié du 1 

er

 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2882 du 25

Novembre 2011, page 138290 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié du 28 mars 2013, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 28 juin 2013, numéro 1550.

La réunion a été ouverte sous la présidence de Madame Gwendoline Boone, employée, demeurant professionnellement

à Hesperange, qui désigne comme secrétaire Madame Agathe Kahn, employée, demeurant professionnellement à Hesper-
gange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Emmanuel Gilson de Rouvreux, employé, demeurant professionnel-

lement à Hesperange.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:
1. L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Transfert du siège social avec effet au 1 

er

 janvier 2016 du 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange au 60, avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Modification du premier et du quatrième paragraphe de l’article 5 des statuts pour refléter le changement du siège

social. Le premier et le quatrième alinéa auront la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Hesperange. A compter du 1 

er

 janvier 2016 le siège social de la Société sera établi à

Luxembourg.»

«La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.»
2. Les comparants sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par le mandataire des parties représentées,

les membres du bureau et le notaire instrumentant, qui demeurera annexée au présent acte. Les procurations des associés
représentés resteront également annexées au présent acte.

3. Il résulte de la suite de la liste de présence que toutes les parts sociales existantes émises sont représentées à la présente

assemblée générale, qui est par conséquent valablement constituée et peut valablement délibérer et décider sur les points
de l’ordre du jour.

4. Les parties comparantes, représentées à la réunion déclarent (i) renoncer à la convocation à l’assemblée et (ii) être

pleinement informés de tous les éléments de l’ordre du jour.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

156667

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution:

L’Assemblée décide de transférer le siège social 1 

er

 janvier 2016 du 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange au 60,

avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution:

L’Assemblée décide de modifier le premier et le quatrième alinéa de l’article 5 des statuts pour refléter la modification

du siège social.

Les statuts auront désormais la teneur suivante:

Art. 1 

er

 . Forme sociale.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après

la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
«Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et
11.2, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert
par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres et avoirs de quelque
forme que ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en
outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être convertibles

(à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.

D'une façon générale, la Société peut accorder une assistance au moyen de prêts, garanties ou par tout autre moyen aux

sociétés du groupe ainsi qu’à toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés du groupe et à toute autre
entité à laquelle elle s’intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui
pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

Dans le cadre de cet article, la notion de groupe inclura toutes les sociétés mères de la Société, leurs filiales et les entités

dans lesquelles les entreprises mères ou leurs filiales détiennent une participation directe ou indirecte (chacune de celles-
ci étant ci-après reprise sous le vocable «Société du Groupe»).

La Société peut notamment: (a) emprunter des fonds sous toute forme et lever des fonds comprenant sans y être limité

au moyen d’une émission de titres, obligations ou autres instruments de dette, convertibles ou non, dans les limites de la
loi, y compris les emprunts des Sociétés du Groupe; (b) avancer, prêter, souscrire à ou acheter tout instrument de dette émis
par toute Société du Groupe, avec ou sans sûreté; et (c) octroyer toute garantie, gage, hypothèque ou toute autre forme de
sûreté dans le cadre de l’exécution de tout contrat ou obligation à charge de la Société ou d’une Société du Groupe.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction

sur des biens mobiliers ou immobiliers.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: «ICG EFV Luxembourg S.à r.l.».

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Hesperange. A compter du 1 

er

 janvier 2016 le siège social de la Société

sera établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée générale

extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à EUR 2.460.855 (deux millions quatre cent soixante mille huit cent cinquante-cinq Euros)

représenté 2.460.855 (deux millions quatre cent soixante mille huit cent cinquante-cinq) parts sociales d'une valeur nominale
d’un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de
la Loi trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de

l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article 199
de la Loi.

156668

L

U X E M B O U R G

6.3 - Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre

des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des actions
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les  part  sociales  ne  peuvent  être  transmises  inter  vivos  à  des  tiers  non-associés  qu’après  approbation  préalable  en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être

opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation
sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6.6 - Parts sociales rattachées
Les parts sociales peuvent être rattachées à des instruments convertibles en conformité avec les conditions générales

des instruments convertibles visés.

Tout associé qui transfère une ou plusieurs de ses parts sociales du capital de la Société à un tiers est tenu de transférer

la même proportion de ses instruments convertibles, le cas échéant, à ce même tiers, en conformité avec les conditions
générales des instruments convertibles visés.

Dans l’éventualité où un associé détenant une ou plusieurs parts sociales renonce à une ou plusieurs parts sociales du

capital de la Société suite à une vente, cet associé est obligé de renoncer à la même proportion d’instruments convertibles
qui ont été émis en en fonction de ces parts sociales, le cas échéant, à la Société et ce dernier est tenu de racheter les dits
instruments convertibles, le cas échéant, en conformité avec les conditions générales des instruments convertibles visés.

6.7 - Enregistrement de parts
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Actionnaires conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 7. Management.
7.1 - Nomination et révocation
La Société est gérée par un (1) ou plusieurs gérants. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).
Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum.
7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et en

toute circonstance et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social sous réserve du
respect des termes de l’alinéa 2 du présent article 7.3 ci-dessous.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant, et, en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe de deux (2) gérants.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opérations

spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes
de ce mandat.

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président.
Il peut aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil

de gérance et des assemblées générales des associés.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par les gérants et le cas

échéant par le président et le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le

président, le secrétaire ou par un gérant.

156669

L

U X E M B O U R G

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les gérants présents

ou représentés à ladite réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision prise

à une réunion du conseil de gérance. Une telle approbation pourra tenir en ou plusieurs documents séparés.

Chaque  gérant  et  tous  les  gérants  peuvent  participer  aux  réunions  du  conseil  de  gérance  par  “conference  call”  via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en
personne à la réunion.

7.5 - Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des

associés.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel un

vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins les
trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25).

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son
vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), une assemblée

générale des associés doit être tenue, conformément à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre
endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l’assemblée, le 15 

ème

 jour du mois de juin à 11 heures. Si

ce jour devait être un jour non ouvrable au Luxembourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale pourra se tenir à l’étranger, si de l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances excep-
tionnelles le requièrent

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société

sont contrôlés par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un (1) commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1 - L'exercice social

L’année social commence le 1 

er

 avril et se termine le 31 mars de l’année suivante, à l’exception de la première année

qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 mars 2012.

11.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les
renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaires
constitué conformément à l’article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des

frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi longtemps

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

Dans les limites légales, des dividendes intérimaires peuvent être distribués suite à une résolution du conseil de gérance,

à tout moment et une ou plusieurs fois durant un exercice social donné, lorsque sont satisfaites les conditions suivantes:

i. les comptes statutaires de l’exercice social précédent doivent avoir été approuvés par le(s) associé(s);

156670

L

U X E M B O U R G

ii. les comptes intérimaires, arrêtés à une date non antérieure à un mois avant la date de distribution doivent être préparés

par le conseil de gérance;

iii. un tel dividende intérimaire peut seulement être payé sur les profits intérimaires de l’exercice social en cours plus

toute réserve distribuable, plus tout bénéfice reporté moins toute perte reportée.

Les dividendes intérimaires peuvent être payés en espèce ou en nature à la discrétion du conseil de gérance.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,

de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution
de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui
détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s'en

réfèrent aux dispositions de la Loi.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate qu'à la requête des parties comparantes, cet acte a été

rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes comparants la version anglaise fera
foi en cas de divergence entre les textes français et anglais.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire soussigné, le

présent acte.

Signé: G. BOONE, A. KAHN, E. GILSON DE ROUVREUX et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 2 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/31681. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 9 octobre 2015.

Référence de publication: 2015167743/440.
(150184358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Axius European CLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 110.995.

Les décisions suivantes ont été prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du

5 octobre 2015:

- acceptation de la démission de Monsieur Erik van Os en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat;
- nomination, en tant que nouvel administrateur de la Société, de Monsieur Lukasz Malecki, né le 26 octobre 1982 à

Bialystok (Pologne) et ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Son mandat
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2021;

- confirmation que le conseil d'administration de la Société est depuis le 5 octobre 2015 composé des administrateurs

suivants:

* Madame Marketa Stranska;
* Madame Maud Meyer; and
* Monsieur Lukasz Malecki.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2015.

<i>Pour la Société
Marketa Stranska
<i>Administrateur

Référence de publication: 2015168178/23.
(150186296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2015.

156671

L

U X E M B O U R G

Agamemnon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 3.750.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 164.827.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 17 juillet 2015 et avec effet au 8 octobre 2015, que

les trois associés de la société, K Agamemnon S.à r.l., RESOLUTION III HOLDINGS S.à r.l. et Globecastle Limited, ont
transféré la totalité de leurs parts sociales qu'il détenait dans la Société à:

- SML Alpha S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, immatriculée auprès du RCSL sous le numéro B198310, ayant son siège social à l'adresse suivante: 2-4, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg.

En conséquence, la totalité des 31.250 parts sociales de la Société sont désormais détenues par le nouvel associé unique,

SML Alpha S.à r.l..

<i>Extrait des résolutions circulaires unanimes prises par le conseil de gérance de la Société en date du 8 octobre 2015

En date du 8 octobre 2015, le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 28,

Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, avec effet immédiat.

<i>Extrait des résolutions écrites adoptées par l'associé unique de la Société en date du 8 octobre 2015

En date du 8 octobre 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter les démissions de Mesdames Severine DESNOS et Valerie INGELBRECHT de leur mandat respectif de

gérant de la Société avec effet au 8 octobre 2015;

- de nommer Monsieur Paul LAWRENCE, né le 25 mai 1970 à Rotherham, Royaume-Uni, résidant professionnellement

à l'adresse suivante: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au
8 octobre 2015 et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Monsieur Michel THILL, né le 8 juin 1965 à Arlon, Belgique, résidant professionnellement à l'adresse

suivante: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 8 octobre
2015 et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Madame Margaretha Natalia WIDJAJA, née le 20 décembre 1981 en Indonésie, résidant professionnel-

lement à l'adresse suivante: #06-00 Golden Agri Plaza, 108 Pasir Panjang Road, 118535 Singapour, Singapour, en tant que
nouveau gérant de la Société avec effet au 8 octobre 2015 et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Monsieur Cédric FRISCH, né le 5 janvier 1982 à Messancy, Belgique, résidant professionnellement à

l'adresse suivante: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au
8 octobre 2015 et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Monsieur Jérôme LETSCHER, né le 21 mai 1973 à Luxembourg, résidant professionnellement à l'adresse

suivante: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 8 octobre
2015 et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Monsieur Robin NG CHENG JIET, né le 16 septembre 1974 à Singapour, Singapour, résidant profes-

sionnellement à l'adresse suivante: #06-00 Golden Agri Plaza, 108 Pasir Panjang Road, 118535 Singapour, Singapour, en
tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 8 octobre 2015 et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Monsieur Ferdinand SADELI, né le 8 octobre 1973 à Jakarta, Indonésie, résidant professionnellement à

l'adresse suivante: #06-00 Golden Agri Plaza, 108 Pasir Panjang Road, 118535 Singapour, Singapour, en tant que nouveau
gérant de la Société avec effet au 8 octobre 2015 et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer MOORE STEPHENS Audit S.A.R.L., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les

lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 2-4, rue Château d'Eau, L-3364 Leudelange
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B155334 en tant que
réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2015.

Agamemnon S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015167435/52.
(150184880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

156672


Document Outline

1741 Specialised Investment Funds SICAV

2 F Participations

2 IH S.A.

2 IH S.A.

Agamemnon S.à r.l.

Axius European CLO S.A.

D'co S.à r.l.

Dété Publicité &amp; Communication S.à.r.l.

Electro-Team S.à r.l.

First Atlas (IX) Lux S.A.

FN International

Fox III S.à r.l.

GP-2 Munich B LBC Vesta S.à r.l.

GP-5 Berlin LBC Vesta S.à r.l.

Groupe HALBERG S.A.

Holdinter Spf S.A.

ICG EFV Luxembourg S.à r.l.

International Audit Services S.à r.l.

Internationale Maklergesellschaft Luxemburg S.à r.l.

JMW Luxembourg S.A.

Lark Corporation S.A.

LBP Luxco GP 1-Hanover S.à r.l.

LinguaLux

Loreca Investments S.à r.l.

Lumasa SA SPF

Marea

Masterton S.à r.l.

QU2 S.A.

Qubica Lux S.à r.l.

Roast S.à r.l.

Telekabel Enterprise S.à r.l.

Tonic S.A.

UBM CP Holdings No 4 S.à.r.l

UBM IP Luxembourg S.à r.l.

UBS (Lux) Real Estate - Euro Core Feeder Fund (CHF)

United Commonwealth Holdings S. à r.l.

Vasanta S.A.

Vasanta S.A.

Vasto Investment S.à r.l.

Vincent Vega S.A.

Waasserkraaft Wampach, s.à r.l.

Worms

W-Treize SA

Yellow Sky S.à r.l.

Zeta Tre Finance S.A.

Zikostar Barbershop Sàrl