logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3262

3 décembre 2015

SOMMAIRE

Alexanderplatz D4 Zweite Verwaltungsgesell-

schaft S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156538

Ararat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156554

Arden Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

156537

Aredilux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156537

Brain Centred Training  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156534

BR Empire S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156534

Brolis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156533

Calico Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156535

CBP Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156535

CEHTRA - Consultancy for Environmental

and Human Toxicology and Risk Assessment
S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156535

CEHTRA - Consultancy for Environmental

and Human Toxicology and Risk Assessment
S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156536

CEHTRA - Consultancy for Environmental

and Human Toxicology and Risk Assessment
S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156536

Cellmedia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156534

Chemical Investments Luxembourg S.A. SPF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156535

Christinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156534

CMC Biologics S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156535

CMC Biologics S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156554

CMP Intermediate Holdings S.à r.l.  . . . . . . . .

156536

CNA Trading Appliances Limited  . . . . . . . . . .

156536

Cogeart, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156536

Compagnie du Cap S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

156530

Compagnie Financière Européenne S.A. SPF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156530

Compagnie Financière Européenne S.A. SPF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156530

Connected Diet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156530

Cottyn-Kieffer S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156573

CPP Investment Board Europe S.à.r.l.  . . . . . .

156560

Criboi S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156537

Crossroads Property Investors S.A.  . . . . . . . .

156537

C.S.N. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156534

CS Promotions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156537

Cyclon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156576

CYW Ventures S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156576

CYW Ventures S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156576

Deutsche Oel & Gas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

156563

Deutsche Oel & Gas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

156566

Deutsche Oel & Gas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

156568

Deutsche Real Estate Funds Advisor S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156570

Dred-Real Estate Deutschland GP S.à r.l.  . . .

156575

D&S Asia Green Property Fund II, S.A. SIF-

SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156576

GCP Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156531

Gefco Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156532

Geninvest Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156532

Gerges S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156532

Goodyear  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156531

Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.  . . . .

156531

Gopark SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156532

GT Global Invest (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

156531

Holmby Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

156530

IFR Lux Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156532

Immobilière des Crèches . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156533

Industrielogistik Entwicklung S.à r.l.  . . . . . . .

156533

Innovation and Technology Systems G.m.b.H.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156533

Invest Control-Services Administratifs S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156533

Metal Oxides S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156538

156529

L

U X E M B O U R G

Compagnie du Cap S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 168.780.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015167536/10.
(150184928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Compagnie Financière Européenne S.A. SPF, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 1, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 114.928.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015167537/9.
(150185108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Compagnie Financière Européenne S.A. SPF, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 1, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 114.928.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015167538/9.
(150185111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Connected Diet, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 105.260,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 180.922.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015167539/9.
(150184773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Holmby Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 160.096.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 9 octobre 2015.

<i>Résolutions:

L'assemblée décide de réduire à trois le numéro des administrateurs et de les élire pour la période expirant à l'assemblée

générale qui se tiendra en 2019 comme suit:

M. Alfio Riciputo, résident professionnellement au 89A rue Pafebruch, L-8308 Capellen, Administrateur et Président;
M. Gregory Centurione, résident professionnellement au 89A rue Pafebruch, L-8308 Capellen, Administrateur;
Mme Annick Mayon, résident professionnellement au 89A rue Pafebruch, L-8308 Capellen, Administrateur.

Pour extrait conforme
Holmby Investments S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2015167715/17.
(150185240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

156530

L

U X E M B O U R G

Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R.C.S. Luxembourg B 71.219.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 12 octobre 2015.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2015167701/12.
(150185105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Goodyear, Société Anonyme.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R.C.S. Luxembourg B 4.441.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 12 octobre 2015.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2015167702/12.
(150185106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

GCP Europe, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 22.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 131.815.

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance tenu en date du 23 septembre 2015

Les membres du conseil de gérance de la Société ont décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la Société du 21-25, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la

Foire, L - 1528 Luxembourg et ce, avec effet au 1 

er

 octobre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2015.

Référence de publication: 2015167696/14.
(150184628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

GT Global Invest (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 127.042.

EXTRAIT

Suite aux résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 23 septembre 2015, le gérant Monsieur Alan

Botfield a été remplacé par la personne suivante:

- Monsieur Petr Klimo, résidant professionnellement au 51 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015167710/16.
(150185149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

156531

L

U X E M B O U R G

Gopark SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5576 Remich, 40, chemin des Vignes.

R.C.S. Luxembourg B 115.948.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2015167703/10.
(150184745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Gerges S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 60, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 173.796.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015167699/9.
(150185248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Geninvest Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 149.344.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2015167698/10.
(150185012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Gefco Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 69.580.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015167697/9.
(150185037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

IFR Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.403.000,00.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 84.798.

<i>Extrait des décisions prises par l'Actionnaire Unique en date du 8 octobre 2015

<i>Résolution unique:

Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Lu-

xembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg a été nommé au poste de gérant de la société pour une
période indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IFR LUX S.à r.l.
Société à Responsabilité Limitée

Référence de publication: 2015167745/16.
(150185148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

156532

L

U X E M B O U R G

Immobilière des Crèches, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 182.937.

La version abrégée des comptes annuels au 30 septembre 2014 a été déposée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2015167747/11.
(150184579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Industrielogistik Entwicklung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 168.822.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015167749/10.
(150185207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Innovation and Technology Systems G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 20, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 80.819.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015167750/11.
(150184576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Invest Control-Services Administratifs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 23.230.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015167752/10.
(150184748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Brolis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5855 Hesperange, 1, rue Jos Sunnen.

R.C.S. Luxembourg B 88.824.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12.10.2015.

V. IAMPOLSKI
<i>Gérant

Référence de publication: 2015167526/12.
(150185529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

156533

L

U X E M B O U R G

BC Training, Brain Centred Training, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 96, Duerfstroos.

R.C.S. Luxembourg B 163.017.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015167506/9.
(150185271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

BR Empire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 149.757.

EXTRAIT

Suite à la réception de la lettre de démission de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. datée du 11 septembre 2015, il y a lieu

de noter que PricewaterhouseCoopers S.à r.l. a démissionné de sa fonction de réviseur d'entreprises agrée et ce avec effet
au 11 septembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015167521/15.
(150185100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

C.S.N. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3562 Dudelange, 21, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 70.795.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015167529/9.
(150185015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Christinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 11, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 48.133.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015167561/9.
(150184767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Cellmedia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 75.417.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2015.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2015167557/12.
(150184664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

156534

L

U X E M B O U R G

Calico Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 32.251.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015167543/10.
(150184753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

CBP Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3526 Dudelange, 87, rue des Minières.

R.C.S. Luxembourg B 110.345.

Je vous prie de prendre acte, avec effet immédiat, de ma démission de mes fonctions de administrateur-délégué et

président du conseil d'administration dans la société anonyme C.B.P Lux, sise à L-3526 Dudelange, 87, Rue des Minières
inscrite au registre de commerce sous le numéro B 110345.

Bettembourg, le 18 septembre 2015.

Comptabilité STC SARL
41, Rue de Kleinsch
L-3250 Bettembourg
Amado Figueiredo Maria De Fatima
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015167547/16.
(150185059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

CEHTRA - Consultancy for Environmental and Human Toxicology and Risk Assessment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 92.844.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015167554/9.
(150184887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Chemical Investments Luxembourg S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 53.973.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015167559/9.
(150184842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

CMC Biologics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 134.356.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2015.

Référence de publication: 2015167564/10.
(150185073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

156535

L

U X E M B O U R G

CNA Trading Appliances Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 158.915.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2015.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015167567/12.
(150185352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

CMP Intermediate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.270.877.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 87.730.

L'adresse du Gérant, Monsieur Nick Perkins a changé et sera dès lors au 240 Blackfriars Road, London SE1 8BF,

Royaume-Uni.

Le siège social de l'associe Roamingtarget Limited a changé et sera dès lors au 240 Blackfriars Road, London SE1 8BF,

Royaume-Uni.

Luxembourg, le 12 octobre 2015.

Pour avis sincère et conforme

Référence de publication: 2015167566/14.
(150184621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Cogeart, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5576 Remich, 40, chemins des Vignes.

R.C.S. Luxembourg B 104.212.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2015167571/10.
(150184764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

CEHTRA - Consultancy for Environmental and Human Toxicology and Risk Assessment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 92.844.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015167555/9.
(150184888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

CEHTRA - Consultancy for Environmental and Human Toxicology and Risk Assessment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 92.844.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015167556/9.
(150184889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

156536

L

U X E M B O U R G

Aredilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5252 Sandweiler, 30, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 156.528.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015167491/9.
(150185034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Arden Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 167.936.

Monsieur Eric Vandekerken a démissionné de sa fonction d'administrateur de la société en date du 10 août 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015167490/10.
(150184865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Criboi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 101.392.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 1 

<i>er

<i> octobre 2015

Le 1 

er

 octobre 2015, l'Associé unique de la société, a pris les résolutions suivantes:

- L'Associé unique accepte la démission de Stéphane BIVER de son mandat de gérant de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2015.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015167581/15.
(150184619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Crossroads Property Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 56.208.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015167582/10.
(150185309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

CS Promotions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 66.892.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/10/2015.

Référence de publication: 2015167583/10.
(150184992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

156537

L

U X E M B O U R G

Metal Oxides S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, Allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 79.711.

<i>Décision du conseil d'administration de la société prise en date du 6 octobre 2015 en application des articles 12 c) et 15

<i>b) des statuts de la société.

<i>Administrateurs:

Monsieur Didier McGaw
Monsieur Jean-Benoît Lachaise
Les administrateurs renonçant à leur droit à être dûment convoqués, ont pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Le Conseil d'Administration constate la démission de M. Simon Bliss avec adresse au 220, Queenmead Avenue, GB-

KT17 3EQ, Epsom, Surrey, né le 14 juillet 1969 à Londres, Royaume-Uni, et décide de pourvoir à son remplacement par
la nomination de M. Tom Leader, né le 14 septembre 1964 à Gibraltar, ayant pour adresse professionnelle, Portland House,
Suite 1924, Bressenden Place, London SW1E 5RS.

Le Conseil d'Administration
Didier McGaw / Jean-Benoît Lachaise
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015167858/21.
(150185050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Alexanderplatz D4 Zweite Verwaltungsgesellschaft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 200.604.

STATUTES

In the year two thousand fifteen, on twenty-second day of September.
Before US Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

- Hines immobilien GmbH, a limited liability company, founded and existing according to the laws of the Federal

Republic of Germany, with seat in Berlin, Germany, registered in the Commercial Register of the Local Court of Char-
lottenburg, Germany, under HRB 37913 B (the “Minority Shareholder”), holder of one (1) share, with a par value of one
thousand three hundred Euros (EUR 1,300), out of the two (2) shares issued by the Company (as defined below) and

- Hines Alexanderplatz Holdings LLC, a limited liability company established and existing under the laws of the State

of Delaware, United States of America, with business address in 2008 Post Oak Boulevard, Suite 4800, Houston, Texas
77056, United States of America (the “Majority Shareholder”), holder of the remaining one (1) share, with a par value of
twenty-three thousand seven hundred Euros (EUR 23,700), out of the two (2) shares issued by the Company (as defined
below);

together referred hereafter as the “Shareholders” or the “Persons Appearing”;
here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary’s clerk, with professional address at 13, route de Lu-

xembourg,  L-4761  Petange,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  by  virtue  of  proxies  given  respectively  by  the  Minority
Shareholder on July 23 / 27, 2015 and by the Majority Shareholder on August 13, 2015.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the Persons Appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such Persons Appearing are currently the only Shareholders of Alexanderplatz D4 Zweite Verwaltungsgesellschaft

GmbH, a limited liability company, established and existing under the laws of the Federal Republic of Germany with its
registered seat in Berlin, Germany, registered with the Commercial Register of the Local Court of Charlottenburg, Germany,
under HRB 79266 B (regardless of its legal form, the “Company”).

That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1) Consider waiving the convening formalities;
2) Consider the acknowledgement and, ratification of the decisions of the Shareholders taken on 18 May 2015 (deed-

roll no. 166 / 2015 of the notary Dr. Klaus Knipschild in Eschborn, Germany) deciding to convert the Company into a

156538

L

U X E M B O U R G

Luxembourg private limited liability (“Société à responsabilité limitée”), by way of simultaneously (i) transferring the
registered office of the Company from Berlin, Germany, to Luxembourg, the Grand-Duchy of Luxembourg, in accordance
with the laws of Germany and of the Grand-Duchy of Luxembourg, and (ii) adopting the form of a Luxembourg private
limited liability company (“Société à responsabilité limitée”), and (iii) consequently changing the nationality of the Com-
pany from a German nationality governed by the laws of the Federal Republic of Germany to a Luxembourg nationality
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, without the Company being dissolved and with full corporate
continuance (together the "Conversion");

3) Consider confirmation that the legal personality of the Company continues in Luxembourg, the Grand Duchy of

Luxembourg, under the form of a Luxembourg private limited liability company (“Société à responsabilité limitée”) with
the name “Alexanderplatz D4 Zweite Verwaltungsgesellschaft S.à r.l.”, without the Company being dissolved, liquidated
or newly incorporated and with full corporate continuance;

4) Consider dividing the share capital into twenty-five thousand (25,000) shares of one Euro (EUR 1) each;

5) Consider amending and fully restating the articles of association of the Company so as to make them comply with

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and determination of the corporate purpose of the Company to give the
following content:

“ Art. 3. Purpose.

3.1 The Company’s purpose is the acquisition, creation, development, holding, and realisation of a portfolio of real

estate assets, consisting of real property or contractual rights to property, building rights and of securities, interests and
rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities,
whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange
of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as
well as the administration and control of such portfolio.

3.2 The Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds

a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms
part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of
any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any
other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which

the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,

the Company may especially:

-  raise  funds  through  borrowing  in  any  form  or  by  issuing  any  securities  or  debt  instruments,  including  bonds,  by

accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad;

and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or

foreign entities.”

6) Consider approval of the interim balance sheet of the Company as of June 30, 2015 and acknowledgement of the

statement of value of the directors of the Company;

7) Consider (i) resignation of Alexander Möll, born in Reutlingen, on September 09, 1970, Germany and Christoph

Reschke, born in Hamburg, on October 10, 1966, Germany, as directors of the Company and granting them full discharge
and (ii) appointment of the following individuals as managers of the Company for an unlimited period of time:

- Mark Sears, born in Delaware, United States of America, on August 11, 1953, with professional address at 205, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg;

- Damian Pons, born in Madrid, Spain, on May 28, 1977, with professional address at 205, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg;

- Kenneth MacRae, born in Richmond, United Kingdom, on May 30, 1962, with professional address at 205, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg;

8) Consider establishing the registered office of the Company at 205 route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duchy

of Luxembourg;

9) Miscellaneous.

That, on basis of the agenda, the Shareholders take the following resolutions:

156539

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present extraordinary general shareholders’ meeting, the Sha-

reholders waive the convening notice, as they consider having been duly convened and declare having perfect knowledge
of the Agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders acknowledge and, ratify the resolutions of the Shareholders taken on 18 May 2015 (deed-roll no. 166 /

2015 of the notary Dr. Klaus Knipschild in Eschborn, Germany) deciding on the Conversion based on (i) German laws,
(ii) Luxembourg laws and (iii) case law of the Court of Justice of the European Union, particularly: sixteen December two
thousand eight in case C-210/06, Cartesio Oktató és Szolgáltató bt; twelve July two thousand twelve in case C-378/10,
VALE Építési kft.

The Conversion shall immediately be effective.

<i>Third resolution

The Shareholders confirm that the legal personality of the Company continues in Luxembourg, the Grand Duchy of

Luxembourg, under the form of a Luxembourg private limited liability company (“Société à responsabilité limitée”) with
the name “Alexanderplatz D4 Zweite Verwaltungsgesellschaft S.à r.l.”, without the Company being dissolved, liquidated
or newly incorporated and with full corporate continuance.

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to restate the number of shares representing the Company’s share capital and their par value,

so that henceforth the share capital of the Company amounts to twenty-five thousand Euros (EUR 25,000) represented by
twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the Minority Shareholder holding one
thousand three hundred (1,300) shares of the Company, and the Majority Shareholder holding twenty-three thousand seven
hundred (23,700) shares of the Company.

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to amend and fully restate and renumber the articles of association of the Company so as to

comply with the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg on the occasion of the Conversion. The restated and renumbered
articles of association of the Company shall now read as follows:

“A. Name - Duration - Purpose - Registered Office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in

the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of “ALEXANDERPLATZ D4
ZWEITE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.À R.L.” (the “Company”).

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.

Art. 3. Purpose.
3.1 The Company’s purpose is the acquisition, creation, development, holding, and realisation of a portfolio of real

estate assets, consisting of real property or contractual rights to property, building rights and of securities, interests and
rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities,
whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange
of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as
well as the administration and control of such portfolio.

3.2 The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds

a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms
part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of
any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any
other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which

the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,

the Company may especially:

-  raise  funds  through  borrowing  in  any  form  or  by  issuing  any  securities  or  debt  instruments,  including  bonds,  by

accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;

156540

L

U X E M B O U R G

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad;

and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or

foreign entities.

Art. 4. Registered office.
4.1 The Company’s registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the Company’s registered office may be transferred by a resolution of the board of

managers.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the

general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and transfer of shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000), consisting of twenty-five thousand

(25,000) shares having a par value of one euro (EUR 1) each.

5.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company’s share capital may be increased or reduced by a

resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of
association.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise

provided by law.

6.3 A shareholder’s right in the Company’s assets and profits shall be proportional to the number of shares held by him/

her/it in the Company’s share capital.

6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as the

case may be, or any other shareholder shall not cause the Company’s dissolution.

6.5 The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed shares

be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.6 The Company’s shares are in registered form.

Art. 7. Register of shareholders.
7.1 A register of shareholders will be kept at the Company’s registered office, where it will be available for inspection

by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence
or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the date of notification
to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as any security rights
granted on shares.

7.2  Each  shareholder  will  notify  the  Company  by  registered  letter  his/her/its  address  and  any  change  thereof.  The

Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and transfer of shares.
8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shareholders.

Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the board of
managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the expense of the
relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must

designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been designated.

8.3 The Company’s shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, representing
in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the shares may
not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders representing in the
aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4 Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or in

notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties upon
notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member of the
board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

156541

L

U X E M B O U R G

8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer

referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor’s and the transferee’s consent.

C. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of

the Company’s corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term “sole shareholder” is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the “general meeting of shareholders” used in these articles of association is
to be construed as being a reference to the “sole shareholder”.

9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

9.4 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of

holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms and
conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general meetings
of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers, by

the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company’s share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.

10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the

municipality where the Company’s registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of
such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from closing
the Company’s accounts.

10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,

date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.

10.4 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - vote by resolution in writing.
11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary

and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be share-
holders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held
in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3 Quorum and vote
- Each share entitles to one (1) vote.
- Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly passed

when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company’s share capital on first call. If
such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second time. On
second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion of capital
represented.

11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,

as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.

11.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by

any other means of communication which allow such shareholder’s identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles

of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of share-
holders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

156542

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the

members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of
its members or by the sole manager, as the case may be.

D. Management

Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In

case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company’s management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term “sole manager” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of
managers” used in these articles of association is to be construed as being a reference to the “sole manager”.

14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the

corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder(s).

14.3 The Company’s daily management and the Company’s representation in connection with such daily management

may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent of
the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone

or jointly as agents of the Company.

Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a chairman

of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board
of managers.

Art. 16. Election and removal of managers and term of the office.
16.1 Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and

term of the office.

16.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own revocation.

16.3 Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for suc-

cessive terms.

Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated

in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of commu-
nication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in
the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile, electronic
mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a
convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution
adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of
managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions in writing pursuant
to these articles of association.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence,

the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

18.2 Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of its members is present or represented at a

meeting of the board of managers.

18.3 Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting of

the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.

18.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its proxy

in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.

156543

L

U X E M B O U R G

18.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

any other means of communication which allow such manager’s identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be
present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means of
communication is deemed to be held at the Company’s registered office.

18.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions

passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

18.7 Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the

board of managers which conflicts with the Company’s interest, must inform the board of managers of such conflict of
interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager may not
take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole manager and
the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the sole manager
and the Company, which conflicts with the Company’s interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes
recording the relevant transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered into under normal
conditions.

Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board

of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
19.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager,
as the case may be.

Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

joint signatures of at least two (2) managers or, as the case may be, (ii) by the signature of the sole manager or (iii) by the
sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated. The Company will be bound towards
third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company’s daily management has been
delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.

E. Supervision

Art. 21. Statutory auditor(s) - independent auditor(s).
21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or

several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall

fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general
meeting of shareholders.

21.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of

shareholders.

21.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Com-

pany.

21.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company’s books and accounts. Such

expert must be approved by the Company.

21.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from

among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory auditor.
Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these articles of
association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

21.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the law

of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of undertakings
for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by one or several
independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d’entreprises, to be appointed by the general
meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 22. Financial year. The Company’s financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on

thirty-first December of the same year.

156544

L

U X E M B O U R G

Art. 23. Profits.
23.1 From the Company’s annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company’s legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company’s reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

23.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation.

23.3 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.4 Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the general

meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company’s annual net profits will be used in accordance
with the law and these articles of association.

Art. 24. Interim dividends - Share premium.
24.1 The board of managers may proceed to the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim

accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed
total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits
carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be
placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of association and (iii) the Company’s auditor,
if any, has stated in his/her report to the board of managers that the first two conditions have been satisfied.

24.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or

of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. In the event of the Company’s dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company’s
dissolution which shall determine the liquidators’/liquidator’s powers and remuneration.

H. Governing law

Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by

Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law
of August 10 

th

 , 1915 governing commercial companies, as amended.”

<i>Sixth resolution

It results from a statement of value of the directors of the Company dated September 8 

th

 , 2015 that based on its fair

market value, the net worth of the Company is estimated to be at least equal to the amount of the subscribed share capital,
being twenty-five thousand Euros (EUR 25,000).

The Shareholders approve the balance sheet of the Company as of June 30, 2015.

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolve to accept the resignation of Alexander Möll, born in Reutlingen, on September 09, 1970,

Germany and Christoph Reschke, born in Hamburg, on October 10, 1966, Germany, as directors of the Company and
granting them full discharge for the exercise of their mandate.

The Shareholders further resolve to appoint the following individuals as managers of the Company with immediate

effect and for an unlimited period of time:

- Mark Sears, born in Delaware, United States of America, on August 11, 1953, with professional address at 205, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg;

- Damian Pons, born in Madrid, Spain, on May 28, 1977, with professional address at 205, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg;

- Kenneth MacRae, born in Richmond, United Kingdom, on May 30, 1962, with professional address at 205, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

<i>Eighth resolution

The Shareholders resolve to establish the new registered office of the Company at 205 route d’Arlon, L-1150 Luxem-

bourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that on request of the Persons

Appearing, the present deed is worded in English followed by a German translation and on the request of the Persons
Appearing in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the day specified at the beginning of this document.

156545

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the proxyholder of the Persons Appearing, the said proxy holder signed together with

the notary the present deed.

Follows the German translation of the preceding text:

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, dem zweiundzwanzigsten September.
Vor Maître Jacques Kesseler, Notar mit Sitz in Petange, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

- Hines Immobilien GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend nach dem Recht der

Bundesrepublik Deutschland, mit Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlot-
tenburg unter HRB 37913 B (die „Minder-heitsgesellschafterin“), Inhaberin eines (1) Geschäftsanteils im Nennbetrag von
eintausend-unddreihundert Euro (EUR 1.300), von insgesamt zwei (2) von der Gesellschaft (wie nachstehend definiert)
ausgegebenen Geschäftsanteilen, und

- Hines ALexanderplatz Holdings LLC, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend nach dem

Recht des Staates Delaware, USA, mit Geschäftsadresse in 2008 Post Oak Boulevard, Suite 4800, Houston, Texas 77056,
USA (die „Mehrheitsgesellschafterin“), Inhaberin des weiteren einen (1) Geschäftsanteils im Nennbetrag von dreiund-
zwanzigtausend-siebenhundert  Euro  (EUR  23.700),  von  insgesamt  zwei  (2)  von  der  Gesellschaft  (wie  nachstehend
definiert) ausgegebenen Geschäftsanteilen;

im Folgenden zusammen bezeichnet als die „Gesellschafter“ oder die „Erschienenen“;
hier vertreten von Frau Sofia Afonso-Da Chao Conde, Notarangestellte, mit Geschäftsadresse in 13, route de Luxem-

bourg, L-4761 Petange, Großherzogtum Luxemburg, auf Grund von Vollmachten, jeweils erteilt von der Minderheitsge-
sellschafterin am 23. / 27. Juli 2015 und der Mehrheitsgesellschafterin am 13. August 2015.

Die  vorbezeichneten  Vollmachten,  unterzeichnet  ne  varietur  von  den  Bevollmächtigten  der  Erschienenen  und  dem

unterzeichnenden  Notar,  werden  als  Anlagen  zu  dieser  Urkunde  genommen,  um  mit  dieser  bei  den  Registerbehörden
eingereicht zu werden.

Die Erschienenen sind zum jetzigen Zeitpunkt die alleinigen Gesellschafter der Alexanderplatz D4 Zweite Verwal-

tungsgesellschaft  GmbH,  einer  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung,  gegründet  und  bestehend  nach  dem  Recht  der
Bundesrepublik Deutschland, mit Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlot-
tenburg, Deutschland, unter HRB 79266 B (unabhängig von ihrer Rechtsform, die „Gesellschaft“).

Die Tagesordnung der Versammlung ist die Folgende:

<i>Tagesordnung

1) Erörterung des Verzichts auf die für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschriften;
2) Erörterung der Anerkennung und Bestätigung der von den Gesellschaftern gefassten Beschlüsse vom 18. Mai 2015

(Urkundenrolle Nr. 166 / 2015 des Notars Dr. Klaus Knipschild in Eschborn, Deutschland) mit der Entscheidung, die
Gesellschaft  in  eine  Luxemburger  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  (“Société  à  responsabilité  limitée”)  formzu-
wechseln,  durch  gleichzeitige  (i)  Verlegung  des  Sitzes  der  Gesellschaft  von  Berlin,  Deutschland,  nach  Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, in Übereinstimmung mit dem Recht Deutschlands und des Großherzogtums Luxemburg, und
(ii) Annahme der Rechtsform einer Luxemburger Gesellschaft mit beschränkter Haftung (“Société à responsabilité limi-
tée”), (iii) mit der Konsequenz des Wechsels der Nationalität der Gesellschaft von Deutschland, dem Recht der Bundes-
republik  Deutschland  unterliegend,  nach  Luxemburg,  dem  Recht  des  Großherzogtums  Luxemburg  unterliegend,  ohne
Auflösung und unter voller Beibehaltung ihrer Rechtspersönlichkeit (zusammen der „Formwechsel“);

3) Erörterung der Bestätigung, dass die Gesellschaft unter Beibehaltung ihrer rechtlichen Identität in Luxemburg, Groß-

herzogtum  Luxemburg,  weiterbesteht,  in  der  Rechtsform  einer  Luxemburger  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung
(“Société à responsabilité limitée”) unter der Firma “Alexanderplatz D4 Zweite Verwaltungsgesellschaft S.à r.l.”, ohne
dass die Gesellschaft aufgelöst, liquidiert oder neu gegründet wird, und unter voller Beibehaltung ihrer Rechtspersönlich-
keit;

4)  Erörterungen  der  Aufteilung  des  Stammkapitals  in  fünfundzwanzigtausend  (25.000)  Geschäftsanteile  zu  jeweils

einem Euro (EUR 1);

5) Erörterungen der Änderung und vollständigen Neufassung der Satzung der Gesellschaft zur Einhaltung des Rechts

des Großherzogtums Luxemburg und Festlegung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft mit dem folgenden Inhalt:

„ Art. 3. Zweck.
3.1 Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Schaffung, die Entwicklung, das Halten und die Verwertung eines

Portfolios  von  Immobilienvermögenswerten,  bestehend  aus  Grundbesitz  oder  vertraglichen  Rechten  auf  Grundbesitz,
Baurechten und Sicherheiten, Anrechten und Rechten jeder Art und jeder anderen Form von Investment in Unternehmen
des Großherzogtums Luxemburg und in ausländische Unternehmen, gleich ob diese Unternehmen existieren oder zu er-
richten sind, im Besonderen durch Zeichnung, Erwerb durch Kauf, Verkauf oder Austausch von Sicherheiten oder Rechten
jedweder Art, wie zum Beispiel Eigenkapitalinstrumente, Schuldurkunden, Patente und Lizenzen, sowie die Verwaltung
und die Kontrolle dieses Portfolios.

156546

L

U X E M B O U R G

3.2 Die Gesellschaft kann weiterhin:
- jede Form der Sicherheit für die Erfüllung von Verpflichtungen der Gesellschaft oder eines Unternehmens gewähren,

bei dem sie einen direkten oder indirekten Anteil oder ein Recht irgendeiner Art hält, oder in welches die Gesellschaft in
irgendeiner anderen Weise investiert hat, oder das Teil der gleichen Gruppe von Unternehmen wie die Gesellschaft ist,
oder eines Directors oder eines anderen leitenden Angestellten oder Bevollmächtigten des Unternehmens oder eines Un-
ternehmens, bei dem sie einen direkten oder indirekten Anteil oder ein Recht irgendeiner Art hält, oder in welches die
Gesellschaft in irgendeiner anderen Weise investiert hat, oder das Teil der gleichen Gruppe von Unternehmen wie die
Gesellschaft ist; und

- Geldmittel verleihen oder anderweitig ein Unternehmen unterstützen, bei dem sie einen direkten oder indirekten Anteil

oder ein Recht irgendeiner Art hält, oder in welches die Gesellschaft in irgendeiner anderen Weise investiert hat, oder das
Teil der gleichen Gruppe von Unternehmen wie die Gesellschaft ist.

3.3 Die Gesellschaft kann alle Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Im Rahmen

dieses Zwecks kann die Gesellschaft im Besonderen:

- Geldmittel aufbringen durch Kreditaufnahme in irgendeiner Form oder durch die Ausgabe von Sicherheiten oder

Schuldurkunden, einschließlich von Schuldverschreibungen, durch die Annahme einer anderen Form des Investments oder
durch die Gewährung von Rechten jedweder Art, vorbehaltlich der rechtlichen Bestimmungen;

- sich an der Gründung, der Entwicklung und/oder der Kontrolle von Unternehmen im Großherzogtum Luxemburg oder

im Ausland beteiligen; und

- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für die Schulden und Verpflichtungen von

Unternehmen Luxemburgs oder des Auslands handeln.“

6) Erörterungen der Zustimmung zur Zwischenbilanz der Gesellschaft vom 30. Juni 2015 und Bestätigung der Wert-

haltigkeitserklärung der Direktoren der Gesellschaft;

7) Erörterungen (i) der Amts-niederlegungen und vollständigen Entlastung von Alexander Möll, geboren in Reutlingen,

Deutschland, am 9. September 1970, und Christoph Reschke, geboren in Hamburg, Deutschland, am 10. Oktober 1966,
als Geschäftsführer der Gesellschaft und (ii) Bestellung der folgenden Personen zu Geschäftsführern der Gesellschaft auf
unbestimmte Zeit:

- Mark Sears, geboren in Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, am 11. August 1953, mit Geschäftsadresse in 205,

route d’Arlon, L-1150 Luxemburg;

- Damian Pons, geboren in Madrid, Spanien, am 28. Mai 1977, mit Geschäftsadresse in 205, route d’Arlon, L-1150

Luxemburg;

- Kenneth MacRae, geboren in Richmond, Vereinigtes Königreich, am 30. Mai 1962, mit Geschäftsadresse in 205, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg;

8) Erörterungen der Bestimmung des registrierten Sitzes der Gesellschaft in der 205 route d’Arlon, L-1150 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg;

9) Verschiedenes
Auf Grundlage der Tagesordnung fassen die Gesellschafter die folgenden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Da das gesamte Stammkapital der Gesellschaft bei dieser außerordentlichen Gesellschafterversammlung vertreten ist,

verzichten die Gesellschafter auf die Mitteilung zur Einberufung, da sie der Auffassung sind, ordnungsgemäß eingeladen
worden zu sein und erklären, dass sie vollkommene Kenntnis der Tagesordnung haben, welche ihnen im Voraus übermittelt
worden ist.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter erkennen die von den Gesellschaftern gefassten Beschlüsse vom 18. Mai 2015 (Urkundenrolle Nr.

166 / 2015 des Notars Dr. Klaus Knipschild in Eschborn, Deutschland), basierend auf (i) Deutschem Recht, (ii) Luxem-
burger Recht und (iii) Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, insbesondere vom 16. Dezember 2008
in der Rechtssache C-210/06, Cartesio Oktató és Szolgáltató bt und vom 12. Juli 2012 in der Rechtssache C-378/10, VALE
Építési kft, an und bestätigen diese.

Der Formwechsel soll sofort wirksam werden.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter bestätigen, dass die Gesellschaft unter Beibehaltung ihrer rechtlichen Identität in Luxemburg, Groß-

herzogtum Luxemburg, in der Rechtsform einer luxemburger Gesellschaft mit beschränkter Haftung (“Société à respon-
sabilité limitée”) unter der Firma “Alexanderplatz D4 Zweite Verwaltungsgesellschaft S.à r.l.” weiterbesteht, ohne dass
die Gesellschaft aufgelöst, liquidiert oder neu gegründet wird, und unter voller Beibehaltung ihrer Rechtspersönlichkeit.

156547

L

U X E M B O U R G

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, die Anzahl der Geschäftsanteile, die das Stammkapital der Gesellschaft ausmachen und

deren Nennwert neu festzustellen, so dass nunmehr das Stammkapital der Gesellschaft fünfundzwanzigtausend Euro (EUR
25.000) beträgt, aufgeteilt in fünfundzwanzigtausend Geschäfts-anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR
1), wobei die Minderheitsgesellschafterin eintausendunddreihundert (1.300) und die Mehrheitsgesellschafterin dreiund-
zwanzigtausendundsiebenhundert (23.700) Geschäftsanteile der Gesellschaft hält.

<i>Fünfter Beschluss

Aus Anlass des Formwechsels beschließen die Gesellschafter zur Einhaltung des Rechts des Großherzogtums Luxem-

burg die Satzung der Gesellschaft zu ändern und unter Neunummerierung vollständig neuzufassen. Die neu festgestellte
und neu nummerierte Satzung der Gesellschaft lautet nunmehr wie folgt:

„A. Name - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz

Art. 1. Name. Hiermit besteht zwischen den gegenwärtigen Inhaber der Gesellschaftsanteile und/oder jedem, der in

Zukunft ein Gesellschafter sein mag, eine Gesellschaft in der Form einer Société à responsabilité limitée unter dem Namen
„Alexanderplatz D4 Zweite Verwaltungsgesellschaft S.à r.l.“ (die „Gesellschaft“).

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet. Sie kann zu jedem Zeitpunkt und ohne Grund

durch einen Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst werden, beschlossen in der Art und Weise, die für eine Änderung
dieser Satzung erforderlich ist.

Art. 3. Zweck.
3.1 Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Schaffung, die Entwicklung, das Halten und die Verwertung eines

Portfolios  von  Immobilienvermögenswerten,  bestehend  aus  Grundbesitz  oder  vertraglichen  Rechten  auf  Grundbesitz,
Baurechten und Sicherheiten, Anrechten und Rechten jeder Art und jeder anderen Form von Investment in Unternehmen
des Großherzogtums Luxemburg und in ausländische Unternehmen, gleich ob diese Unternehmen existieren oder zu er-
richten sind, im Besonderen durch Zeichnung, Erwerb durch Kauf, Verkauf oder Austausch von Sicherheiten oder Rechten
jedweder Art, wie zum Beispiel Eigenkapitalinstrumente, Schuldurkunden, Patente und Lizenzen, sowie die Verwaltung
und die Kontrolle dieses Portfolios.

3.2 Die Gesellschaft kann weiterhin:
- jede Form der Sicherheit für die Erfüllung von Verpflichtungen der Gesellschaft oder eines Unternehmens gewähren,

bei dem sie einen direkten oder indirekten Anteil oder ein Recht irgendeiner Art hält, oder in welches die Gesellschaft in
irgendeiner anderen Weise investiert hat, oder das Teil der gleichen Gruppe von Unternehmen wie die Gesellschaft ist,
oder eines Directors oder eines anderen leitenden Angestellten oder Bevollmächtigten des Unternehmens oder eines Un-
ternehmens, bei dem sie einen direkten oder indirekten Anteil oder ein Recht irgendeiner Art hält, oder in welches die
Gesellschaft in irgendeiner anderen Weise investiert hat, oder das Teil der gleichen Gruppe von Unternehmen wie die
Gesellschaft ist; und

- Geldmittel verleihen oder anderweitig ein Unternehmen unterstützen, bei dem sie einen direkten oder indirekten Anteil

oder ein Recht irgendeiner Art hält, oder in welches die Gesellschaft in irgendeiner anderen Weise investiert hat, oder das
Teil der gleichen Gruppe von Unternehmen wie die Gesellschaft ist.

3.3 Die Gesellschaft kann alle Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Im Rahmen

dieses Zwecks kann die Gesellschaft im Besonderen:

- Geldmittel aufbringen durch Kreditaufnahme in irgendeiner Form oder durch die Ausgabe von Sicherheiten oder

Schuldurkunden, einschließlich von Schuldverschreibungen, durch die Annahme einer anderen Form des Investments oder
durch die Gewährung von Rechten jedweder Art, vorbehaltlich der rechtlichen Bestimmungen;

- sich an der Gründung, der Entwicklung und/oder der Kontrolle von Unternehmen im Großherzogtum Luxemburg oder

im Ausland beteiligen; und

- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für die Schulden und Verpflichtungen von

Unternehmen Luxemburgs oder des Auslands handeln.

Art. 4. Eingetragener Sitz.
4.1 Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann innerhalb der gleichen Stadtgemeinde durch einen Beschluss des Ge-

schäftsführerrats verlegt werden.

4.3 Er kann in jede andere Stadtgemeinde im Großherzogtum Luxemburg durch einen Beschluss der Hauptversammlung

verlegt werden, angenommen in der Art und Weise, die für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

4.4 Zweigniederlassungen oder andere Büros können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch

einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.

156548

L

U X E M B O U R G

B. Stammkapital - Gesellschaftsanteile - Register der Gesellschafter - Besitz und Übertragung von Gesellschafts-

anteilen

Art. 5. Stammkapital.
5.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (25.000,00 EUR), bestehend aus fünfund-

zwanzigtausend (25.000) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (1,00 EUR).

5.2 Im Rahmen der durch das Gesetz vorgegebenen Bestimmungen kann das Stammkapital der Gesellschaft durch einen

Beschluss der Hauptversammlung, angenommen in der Art und Weise, die für eine Änderung dieser Satzung erforderlich
ist, erhöht oder verringert werden.

Art. 6. Gesellschaftsanteile.
6.1 Das Stammkapital der Gesellschaft ist in Gesellschaftsanteile aufgeteilt, wobei jeder derselben den gleichen Nenn-

wert hat.

6.2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, mit einer maximalen Anzahl von vierzig (40), falls

nicht anderweitig durch das Gesetz vorgegeben.

6.3 Das Anrecht eines Gesellschafters auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zur Anzahl der

von ihm/ihr/ihm am Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

6.4 Der Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, der Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis in Bezug auf

den alleinigen Gesellschafter bzw. eines anderen Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

6.5 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile zurückkaufen oder einziehen, unter der Bedingung, dass die

zurückgekauften oder eingezogenen Gesellschaftsanteile sofort für verfallen erklärt werden und das Stammkapital ent-
sprechend verringert wird.

6.6 Die Gesellschaftsanteile der Gesellschaft liegen in registrierter Form vor.

Art. 7. Register der Gesellschafter.
7.1 Ein Register der Gesellschafter wird am eingetragenen Sitz der Gesellschaft geführt, wo es für die Einsichtnahme

durch jeden Gesellschafter verfügbar ist. Dieses Register der Gesellschafter enthält im Einzelnen den Namen jedes Ge-
sellschafters, seinen/ihren/seinen Wohnsitz oder den eingetragenen oder Hauptsitz, die Anzahl von Gesellschaftsanteilen,
die von diesem Gesellschafter gehalten werden, jede Übertragung von Gesellschaftsanteilen, das Datum der Mitteilung an
die Gesellschaft über die Übertragung oder der Annahme derselben durch die Gesellschaft gemäß dieser Satzung sowie
von Sicherungsrechten, die auf Gesellschaftsanteile gewährt werden.

7.2 Jeder Gesellschafter teilt der Gesellschaft per Einschreiben seine/ihre/seine Anschrift und jede Änderung derselben

mit. Die Gesellschaft kann sich auf die letzte von ihr erhaltene Anschrift eines Gesellschafters verlassen.

Art. 8. Besitz und Übertragung von Gesellschaftsanteilen.
8.1 Der Nachweis des Besitzes von Gesellschaftsanteilen kann durch die Eintragung eines Gesellschafters im Register

der Gesellschafter erbracht werden. Bescheinigungen der Eintragungen im Register der Gesellschafter werden durch den
Vorsitzenden des Geschäftsführerrats, durch jeweils zwei seiner Mitglieder bzw. durch den alleinigen Geschäftsführer auf
Ersuchen und auf Kosten des entsprechenden Gesellschafters ausgestellt und unterzeichnet.

8.2 Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Gesellschaftsanteil an. Wenn ein Gesellschaftsanteil im Eigentum

mehrerer Personen ist, müssen diese eine einzelne Person bestimmen, die als der alleinige Eigentümer jenes Gesellschafts-
anteils im Verhältnis zur Gesellschaft zu betrachten ist. Die Gesellschaft hat das Recht, die Ausübung aller Rechte, die mit
einem Gesellschaftsanteil verbunden sind, der durch mehrere Inhaber gehalten wird, auszusetzen, bis ein Besitzer bestimmt
worden ist.

8.3 Die Gesellschaftsanteile der Gesellschaft sind frei zwischen vorhandenen Gesellschaftern übertragbar. Inter vivos

können sie nur auf neue Gesellschafter übertragen werden, vorbehaltlich der Genehmigung dieser Übertragung, die von
den Gesellschaftern, einschließlich des Übertragenden, erteilt wird, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75
%) des Stammkapitals vertreten. Falls nicht anderweitig durch das Gesetz vorgegeben, können die Gesellschaftsanteile
nicht aufgrund von Ableben auf Nicht-Gesellschafter übertragen werden, außer mit der Genehmigung von Gesellschaftern,
die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75 %) der Stimmrechte der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.

8.4 Jede Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist durch eine schriftliche Übertragungsvereinbarung unter privatrecht-

lichem  Siegel  bzw.  in  notariell  beurkundeter  Form  zu  dokumentieren,  und  diese  Übertragung  wird  gegenüber  der
Gesellschaft und gegenüber Dritten bei Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder bei Annahme der Übertragung
durch die Gesellschaft wirksam, woraufhin jedes Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung im Register der Ge-
sellschafter verzeichnen kann.

8.5 Die Gesellschaft kann durch jeden ihrer Geschäftsführer ebenfalls eine Übertragung, auf welche in einem Schrift-

wechsel oder in einem anderen Dokument, welches die Einwilligung des Übertragenden und des Übertragungsempfängers
festlegt, akzeptieren und in das Register von Gesellschaftern eintragen.

156549

L

U X E M B O U R G

C. Hauptversammlung

Art. 9. Rechte der Hauptversammlung.
9.1 Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte auf der Hauptversammlung aus, die eines der Organe der Gesell-

schaft darstellt.

9.2 Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Gesellschafter die Rechte der Hauptversammlung

aus. In diesem Fall und im anwendbaren Maße und wenn der Begriff "alleiniger Gesellschafter“ nicht ausdrücklich in dieser
Satzung erwähnt wird, ist eine Bezugnahme auf die „Hauptversammlung“, die in dieser Satzung verwendet wird, als eine
Bezugnahme auf den „alleinigen Gesellschafter“ auszulegen.

9.3 Die Hauptversammlung ist mit den Rechten ausgestattet, die ausdrücklich für sie durch das Gesetz und durch diese

Satzung vorbehalten sind.

9.4 Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, und wenn die Anzahl der Gesellschafter nicht fünfundzwanzig (25)

übersteigt, können die Gesellschafter ebenfalls anstelle der Abhaltung von Hauptversammlungen durch schriftlichen Be-
schluss abstimmen, vorbehaltlich gesetzlicher Bestimmungen. Soweit anwendbar, gelten die Bestimmungen dieser Satzung
in Bezug auf Hauptversammlungen ebenfalls in Bezug auf diese Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.

Art. 10. Einberufung von Hauptversammlungen.
10.1  Die  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  kann  zu  jeder  Zeit  durch  den  Geschäftsführerrat,  durch  den/die  Ab-

schlussprüfer, so vorhanden, bzw. durch Gesellschafter, die insgesamt mehr als fünfzig Prozent (50 %) des Stammkapitals
der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, abzuhalten an dem Ort und an dem Datum, die in der Ankündigung
dieser Versammlung angegeben sind.

10.2 Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine Jahres-Hauptversammlung in

der Stadtgemeinde abgehalten werden, wo sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an einem anderen Ort,
der in der Ankündigung dieser Versammlung angegeben sein kann. Die Jahres-Hauptversammlung muss innerhalb eines
Zeitraums von sechs (6) Monaten nach dem Rechnungsabschluss der Gesellschaft einberufen werden.

10.3 Die Einberufungsankündigung für jede Hauptversammlung muss die Tagesordnung der Versammlung, den Ort,

das Datum und die Uhrzeit der Versammlung enthalten, und diese Ankündigung ist jedem Gesellschafter per Einschreiben
mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum zuzusenden.

10.4 Wenn alle Gesellschafter auf einer Hauptversammlung anwesend sind oder vertreten werden, und wenn sie erklären,

dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Hauptversammlung ohne vorherige
Ankündigung abgehalten werden.

Art. 11. Abhaltung von Hauptversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.
11.1 Ein Vorsitz der Versammlung wird auf jeder Hauptversammlung gebildet, bestehend aus einem Vorsitzenden,

einem Schriftführer und einem Stimmenauszähler. Jeder von ihnen wird durch die Hauptversammlung bestellt, und es ist
nicht erforderlich, dass sie Gesellschafter oder Mitglieder des Geschäftsführerrats sind. Der Vorsitz der Versammlung soll
insbesondere gewährleisten, dass die Versammlung gemäß den geltenden Vorschriften und in Übereinstimmung mit den
Vorschriften zu Einberufung, Mehrheitserfordernissen, Stimmenauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehal-
ten wird.

11.2 Eine Anwesenheitsliste muss auf jeder Hauptversammlung geführt werden.
11.3 Beschlussfähige Anzahl und Abstimmung
- Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zu einer (1) Stimme.
- Falls es nicht anderweitig durch das Gesetz oder diese Satzung vorgesehen ist, sind Beschlüsse der Gesellschafter

rechtsgültig, wenn sie durch Gesellschafter angenommen werden, die bei erster Aufforderung mehr als fünfzig Prozent (50
%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit nicht bei der ersten Aufforderung erreicht
worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert. Bei der zweiten Aufforderung sind die
Beschlüsse rechtsgültig, die mit einer Mehrheit von gültig abgegebenen Stimmen angenommen wurden, ungeachtet des
Anteils des vertretenen Kapitals.

11.4 Ein Gesellschafter kann auf jeder Hauptversammlung durch die Bestellung einer anderen Person, Gesellschafter

oder nicht, als sein/ihr/sein Stimmrechtsvertreter, schriftlich, durch ein unterzeichnetes Dokument, übermittelt per Brief,
Fax, E-Mail oder durch ein anderes Kommunikationsmittel, handeln, wobei eine Abschrift dieser Bestellung ausreichender
Nachweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.

11.5 Jeder Gesellschafter, der an einer Hauptversammlung über Telefonkonferenz, Video-Konferenz oder über andere

Kommunikationsmittel teilnimmt, welche die Identifizierung dieses Gesellschafters gestatten, und es ermöglichen, dass
alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, einander kontinuierlich hören können und wirksam an der Versamm-
lung teilnehmen können, gilt für die Berechnung der beschlussfähigen Anzahl und der Mehrheit als anwesend.

Art. 12. Änderung der Satzung. Vorbehaltlich der durch das Gesetz vorgegebenen Bestimmungen kann diese Satzung

durch einen Beschluss der Hauptversammlung geändert werden, angenommen durch eine (i) Mehrheit der Gesellschafter,
die (ii) insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75 %) des Stammkapitals repräsentieren.

156550

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Protokoll der Hauptversammlungen.
13.1 Der Vorsitz einer Hauptversammlung erstellt ein Protokoll der Versammlung, welches durch die Mitglieder des

Vorsitzes sowie durch jeden Gesellschafter, der dies wünscht, unterzeichnet wird.

13.2 Der alleinige Gesellschafter erstellt und unterzeichnet entsprechend ebenfalls ein Protokoll seiner/ihrer/seiner Be-

schlüsse.

13.3 Jede Abschrift und jeder Auszug dieses Originalprotokolls, die bei Gerichtsverfahren vorzulegen sind, oder an

einen Dritten zu übergeben sind, sind als in Übereinstimmung mit dem Original stehend durch den Notar zu bescheinigen,
der die Originalurkunde in seiner Obhut hatte, falls die Versammlung in einer notariellen Urkunde protokolliert wurde,
oder sie sind durch den Vorsitzenden des Geschäftsführerrats, durch jeweils zwei seiner Mitglieder bzw. durch den allei-
nigen Geschäftsführer zu unterzeichnen.

D. Geschäftsführung

Art. 14. Vollmachten des Geschäftsführerrats.
14.1 Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, wobei es nicht erfor-

derlich  ist,  dass  sie  Gesellschafter  der  Gesellschaft  sind.  Im  Fall  einer  Mehrzahl  von  Geschäftsführern  bilden  die
Geschäftsführer ein Geschäftsführerrat, welches das Organ ist, das für die Geschäftsführung der Gesellschaft und deren
Vertretung zuständig ist. Die Gesellschaft kann mehrere Klassen von Geschäftsführern haben. Soweit anwendbar und wenn
der Begriff „alleiniger Geschäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung erwähnt wird, ist eine Bezugnahme auf den
„Geschäftsführerrat“, wie in dieser Satzung verwendet, so auszulegen, dass es eine Bezugnahme auf den „alleinigen Ge-
schäftsführer“ ist.

14.2 Der Geschäftsführerrat ist mit den umfassendsten Vollmachten zur Ergreifung von Maßnahmen ausgestattet, die

erforderlich oder nützlich für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks sind, mit Ausnahme der Maßnahmen, die kraft Ge-
setzes oder durch diese Satzung dem Gesellschafter/den Gesellschaftern vorbehalten sind.

14.3 Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser

täglichen Geschäftsführung kann auf einen oder auf mehrere Geschäftsführer delegiert werden, oder auf eine andere Person,
Gesellschafter oder nicht, die allein oder gemeinsam als Bevollmächtigte der Gesellschaft handeln. Ihre Bestellung, ihre
Abberufung und ihre Vollmachten werden durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats festgelegt.

14.4 Die Gesellschaft kann ebenfalls Personen, die allein oder gemeinsam als Bevollmächtigte der Gesellschaft handeln,

Sondervollmachten durch notariell beglaubigte Stimmrechtsvollmacht oder persönliche Urkunde gewähren.

Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seinen Mitgliedern einen Vorsit-

zenden des Geschäftsführerrats auswählen. Er kann ebenfalls einen Schriftführer auswählen, wobei es nicht erforderlich
ist, dass dieser ein Gesellschafter oder ein Mitglied des Geschäftsführerrats ist.

Art. 16. Wahl und Abberufung von Geschäftsführern und Amtszeit.
16.1 Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung gewählt, die deren Vergütung und Amtszeit bestimmt.
16.2 Jeder Geschäftsführer kann durch die Hauptversammlung zu jedem Zeitpunkt, ohne Ankündigung und ohne zu-

reichenden Grund, abberufen werden. Ein Geschäftsführer, der ebenfalls Gesellschafter der Gesellschaft ist, ist nicht von
der Abstimmung über seine/ihre/seine eigene Abberufung auszuschließen.

16.3 Jeder Geschäftsführer nimmt sein Amt wahr, bis sein/sein/ihr Nachfolger gewählt worden ist. Jeder Geschäftsführer

kann auch für aufeinanderfolgende Amtszeiten wiedergewählt werden.

Art. 17. Einberufung von Meetings des Geschäftsführerrats.
17.1  Der  Geschäftsführerrat  tagt  nach  Aufforderung  durch  seinen  Vorsitzenden  oder  durch  jeweils  zwei  (2)  seiner

Mitglieder, an dem Ort, der in der Ankündigung des Meetings, wie im nächsten Absatz beschrieben, angegeben ist.

17.2 Eine schriftliche Ankündigung eines Meetings des Geschäftsführerrats muss den Geschäftsführern mindestens

vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Datum, welches für das Meeting anberaumt ist, übermittelt werden, durch Brief,
Fax, E-Mail oder andere Kommunikationsmittel, außer bei einem Notfall, wobei die Art und die Gründe dieses Notfalls in
der Ankündigung angegeben werden müssen. Diese Einberufungsankündigung ist nicht erforderlich im Falle der schrift-
lichen  Zustimmung  jedes  Geschäftsführers  durch  Brief,  Fax,  EMail  oder  andere  Kommunikationsmittel,  wobei  eine
Abschrift dieses unterzeichneten Dokuments einen ausreichenden Nachweis dafür darstellt. Eine Einberufungsankündi-
gung ist ebenfalls nicht erforderlich für ein Board Meeting, das zu einem Zeitpunkt und an einem Ort stattfinden soll, die
in einem zuvor vom Geschäftsführerrat angenommenen Beschluss festgelegt wurden. Weiterhin ist eine Einberufungsan-
kündigung nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem Meeting des Geschäftsführerrats
anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von schriftlichen Beschlüssen gemäß dieser Satzung.

Art. 18. Leitung von Meetings des Geschäftsführerrats.
18.1 Der Vorsitzende des Geschäftsführerrats hat den Vorsitz bei allen Meetings des Geschäftsführerrats. In seiner/ihrer/

seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als Vorsitzenden pro tempore benennen.

18.2 Beschlussfähige Anzahl

156551

L

U X E M B O U R G

Der Geschäftsführerrat kann nur beraten oder rechtsgültig handeln, wenn eine Mehrheit seiner Mitglieder bei einem

Meeting des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten ist.

18.3 Abgabe von Stimmen
Beschlüsse werden mit der Zustimmung einer Mehrheit von Stimmen der Mitglieder gefasst, die auf einem Meeting des

Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind. Der Vorsitzende hat keine ausschlaggebende Stimme.

18.4 Jeder Geschäftsführer kann auf einem Meeting des Geschäftsführerrat handeln, indem er einen anderen Geschäfts-

führer schriftlich als seinen/ihren/seinen Stimmrechtsvertreter per Brief, Fax, E-Mail oder durch ein anderes Kommuni-
kationsmittel bestellt, wobei eine Abschrift der Bestellung ausreichender Nachweis dafür ist. Jeder Geschäftsführer kann
einen oder mehrere seiner/ihrer/seiner Kollegen vertreten.

18.5 Jeder Geschäftsführer, der an einem Meeting des Geschäftsführerrat über Telefonkonferenz, Video-Konferenz oder

über andere Kommunikationsmittel teilnimmt, die die Identifizierung dieses Geschäftsführers gestatten, und die ermögli-
chen, dass alle Personen, die an dem Meeting teilnehmen, einander kontinuierlich hören und wirksam an dem Meeting
teilnehmen können, gilt für die Berechnung der beschlussfähigen Anzahl und der Mehrheit als anwesend. Es wird davon
ausgegangen, dass ein Meeting des Geschäftsführerrats, welches über solche Kommunikationsmittel abgehalten wird, am
eingetragenen Sitz der Gesellschaft abgehalten wird.

18.6 Der Geschäftsführerrat kann einstimmig Beschlüsse schriftlich fassen, welche die gleiche Wirkung haben wie

Beschlüsse, die auf einem Meeting des Geschäftsführerrats gefasst werden, das ordnungsmäßig einberufen und abgehalten
wurde. Diese schriftlichen Beschlüsse sind gefasst, wenn sie von allen Geschäftsführern auf einem einzigen Dokument
oder auf mehrfachen Ausfertigungen datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Abschrift einer Unterschrift, die
per Brief, Fax, E-Mail oder über ein anderes Kommunikationsmittel übermittelt worden ist, einen ausreichenden Nachweis
dafür darstellt. Das einzige Dokument, das alle Unterschriften aufweist bzw. die Gesamtheit der unterzeichneten Ausfer-
tigungen stellt das Dokument dar, welches die Annahme der Beschlüsse nachweist, und das Datum dieser Beschlüsse ist
das Datum der zuletzt angebrachten Unterschrift.

18.7  Jeder  Geschäftsführer,  der,  direkt  oder  indirekt,  ein  Eigeninteresse  an  einer  Transaktion  hat,  welche  dem  Ge-

schäftsführerrat  zu  dessen  Genehmigung  vorgelegt  wird,  das  mit  dem  Interesse  der  Gesellschaft  kollidiert,  muss  dem
Geschäftsführerrat diesen Interessenkonflikt mitteilen und muss seine/ihre/seine Erklärung im Protokoll des Meetings des
Board aufnehmen lassen. Der betroffene Geschäftsführer darf nicht an den Diskussionen über die betreffende Transaktion
teilnehmen und darf nicht über diese abstimmen. Wenn die Gesellschaft einen alleinigen Geschäftsführer hat, und der
alleinige Geschäftsführer, direkt oder indirekt, ein Eigeninteresse an einer Transaktion hat, die zwischen dem alleinigen
Geschäftsführer und der Gesellschaft eingegangen wird, welche mit dem Interesse der Gesellschaft kollidiert, muss dieses
kollidierende Interesse im Protokoll, welches über die betreffende Transaktion angefertigt wird, offenbart werden. Dieser
Artikel 18.7 findet keine Anwendung auf laufende Transaktionen, die unter normalen Bedingungen getätigt werden.

Art. 19. Protokoll der Meetings des Geschäftsführerrats.
19.1 Der Schriftführer, oder, wenn kein Schriftführer ernannt worden ist, der Vorsitzende, erstellt das Protokoll eines

Meetings des Geschäftsführerrats, das durch den Vorsitzenden bzw. durch den Schriftführer unterzeichnet wird.

19.2 Der alleinige Geschäftsführer kann entsprechend ebenfalls das Protokoll seiner/ihrer/seiner Beschlüsse anfertigen

und unterzeichnen.

19.3 Jede Abschrift und jeder Auszug dieses Originalprotokolls, die bei Gerichtsverfahren vorzulegen sind, oder an

einen Dritten zu übergeben sind, sind durch den Vorsitzenden des Geschäftsführerrats, durch jeweils zwei seiner Mitglieder
bzw. durch den alleinigen Geschäftsführer zu unterzeichnen.

Art. 20. Umgang mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen gebunden durch (i) die

gemeinsamen Unterschriften von mindestens zwei (2) Geschäftsführern bzw. durch (ii) die Unterschrift des alleinigen
Geschäftsführers oder durch (iii) die alleinige Unterschrift einer Person/von Personen, denen diese Unterzeichnungsvoll-
macht  übertragen  worden  ist.  Die  Gesellschaft  wird  gegenüber  Dritten  gebunden  durch  die  Unterschrift  eines/von
Bevollmächtigten, auf welche die Vollmacht in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft übertragen wor-
den ist, allein oder gemeinsam handelnd, vorbehaltlich der Regelungen und der Grenzen dieser Übertragung.

E. Aufsicht

Art. 21. Abschlussprüfer - Einzelprüfer.
21.1 Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Transaktionen durch einen

oder mehrere Abschlussprüfer beaufsichtigt, die Gesellschafter sein können oder auch nicht.

21.2 Die Hauptversammlung bestimmt die Anzahl der Abschlussprüfer, sie bestellt diese und legt deren Vergütung und

Amtszeit fest. Ein ehemaliger oder gegenwärtiger Abschlussprüfer kann durch die Hauptversammlung erneut bestellt wer-
den.

21.3 Ein Abschlussprüfer kann durch die Hauptversammlung zu jedem Zeitpunkt, ohne Ankündigung und ohne zu-

reichenden Grund, abberufen werden.

21.4 Die Abschlussprüfer haben ein uneingeschränktes Recht auf ständige Aufsicht und Kontrolle der gesamten Ge-

schäftstätigkeit der Gesellschaft.

156552

L

U X E M B O U R G

21.5 Die Abschlussprüfer können durch einen Sachverständigen bei der Prüfung der Bücher und der Abschlüsse der

Gesellschaft unterstützt werden. Dieser Sachverständige muss durch die Gesellschaft bestätigt werden.

21.6 Im Falle mehrerer Abschlussprüfer bilden diese ein Board der Abschlussprüfer, der aus seinen Mitgliedern einen

Vorsitzenden auswählen muss. Er kann ebenfalls einen Schriftführer auswählen, der weder ein Gesellschafter noch ein
Abschlussprüfer sein muss. Hinsichtlich der Einberufung und der Abhaltung von Meetings des Boards der Abschlussprüfer
gelten die Vorschriften, die in dieser Satzung in Bezug auf die Einberufung und die Abhaltung von Meetings des Ge-
schäftsführerrats vorgegeben sind.

21.7 Wenn die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) Kriterien, gemäß dem ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom

19. Dezember 2002 in Bezug auf das Handels- und Gesellschaftenregister und die Rechnungslegung und Jahresabschlüsse
von Unternehmungen für den Zeitraum, wie er in Artikel 36 des gleichen Gesetzes vorgesehen ist, überschreitet, werden
die  Abschlussprüfer  durch  einen  oder  mehrere  Einzelprüfer  ersetzt,  die  aus  den  Mitgliedern  des  Institut  des  réviseurs
d’entreprises ausgewählt werden und durch die Hauptversammlung, welche die Dauer seiner/ihrer/ihrer Amtszeit festlegt,
zu bestellen sind.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am einund-

dreißigsten Dezember des gleichen Jahres.

Art. 23. Gewinne.
23.1 Aus dem Jahresreingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) in die gesetzliche Rücklage der

Gesellschaft eingestellt. Diese Einstellung hört auf, zwingend zu sein, sobald und solange wie der Gesamtbetrag der Rück-
lage der Gesellschaft sich auf zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft beläuft.

23.2 Beträge, die durch einen Gesellschafter in die Gesellschaft eingebracht werden, können ebenfalls in die gesetzliche

Rücklage eingestellt werden, wenn der den Beitrag leistende Gesellschafter dieser Einstellung zustimmt.

23.3 Im Falle einer Verringerung des Stammkapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft anteilmäßig so

verringert werden, dass sie zehn Prozent (10%) des Stammkapitals nicht übersteigt.

23.4 Im Rahmen der Bedingungen, die kraft Gesetzes vorgegeben sind, und auf Empfehlung des Geschäftsführerrats,

legt die Hauptversammlung fest, wie der Restbetrag des Jahresreingewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz und dieser
Satzung verwendet wird.

Art. 24. Zwischendividenden - Geschäftsanteilsagio.
24.1 Der Geschäftsführerrat oder die Hauptversammlung kann die Zahlung von Zwischendividenden vornehmen, unter

dem Vorbehalt, dass (i) Zwischenabschlüsse erstellt worden sind, die ausweisen, dass ausreichende Geldmittel vorhanden
sind, dass (ii) der auszuschüttende Betrag nicht die Gesamtgewinne übersteigt, die seit dem Ende des letzten Geschäfts-
jahres, für welches der Jahresabschluss bestätigt worden ist, erzielt wurden, plus vorgetragene Gewinne und Beträge, die
aus für diesen Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, minus vorgetragene Verluste und Beträge, die gemäß
den Erfordernissen des Gesetzes oder dieser Satzung in die Rücklage einzustellen sind, und dass (iii) der Prüfer der Ge-
sellschaft, so vorhanden, in seinem/ihrem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt hat, dass die ersten zwei Bedingungen
erfüllt worden sind.

24.2 Aufgeld, so vorhanden, kann frei an den/die Gesellschafter durch einen Beschluss des/der Gesellschafter oder des/

der Geschäftsführer ausgeschüttet werden, vorbehaltlich von gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Unveräußerlichkeit
des Stammkapitals und der gesetzlichen Rücklage.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-

toren  vorgenommen,  Einzelpersonen  oder  Rechtspersönlichkeiten,  bestellt  durch  die  Hauptversammlung,  welche  die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Vollmachten und die Vergütung der Liquidatoren/des Liquidators festlegt.

H. Massgebendes Recht

Art. 26. Maßgebendes Recht. Diese Satzung ist nach dem Recht Luxemburgs auszulegen und zu interpretieren, und sie

unterliegt diesem Recht. Alle Angelegenheiten, welche durch diese Satzung nicht geregelt werden, werden gemäß dem für
Handelsunternehmen angewendeten Gesetz vom 10. August 1915 in seiner geltenden Fassung geregelt.

<i>Sechster Beschluss

Es ergibt sich aus der Werthaltigkeitserklärung der Geschäftsführer der Gesellschaft vom 8. September 2015, dass, unter

Zugrundelegung ihres Verkehrswertes das Reinvermögen der Gesellschaft mindestens dem festgesetzten Stammkapital
der Gesellschaft entspricht, welches fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) beträgt, entspricht.

Die Gesellschafter bestätigen die Bilanz der Gesellschaft zum 30. Juni 2015.

156553

L

U X E M B O U R G

<i>Siebter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Amtsniederlegungen von Alexander Möll, geboren in Reutlingen, Deutschland, am

9. September 1970, und Christoph Reschke, geboren in Hamburg, Deutschland, am 10. Oktober 1966, als Geschäftsführer
der Gesellschaft anzunehmen und ihnen für ihre Amtsausübung vollständig Entlastung zu erteilen.

Die Gesellschafter beschließen weiterhin,
die folgenden Personen mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern der Gesellschaft zu

bestellen:

- Mark Sears, geboren in Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, am 11. August 1953, mit Geschäftsadresse in 205,

route d’Arlon, L-1150 Luxemburg;

- Damian Pons, geboren in Madrid, Spanien, am 28. Mai 1977, mit Geschäftsadresse in 205, route d’Arlon, L-1150

Luxemburg;

- Kenneth MacRae, geboren in Richmond, Vereinigtes Königreich, am 30. Mai 1962, mit Geschäftsadresse in 205, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

<i>Achter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, dass der neue registrierte Sitz der Gesellschaft in der 205 route d’Arlon, L-1150 Lu-

xemburg, Großherzogtum Luxemburg, ist.

Nachdem keine weiteren Geschäfte zu besorgen sind, ist die Versammlung geschlossen.
Der unterzeichnende Notar, welcher Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Verlangen der

Erschienenen die vorliegende Urkunde auf Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst wird, und auf Ver-
langen der Erschienen im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische
Fassung bindend sein soll.

Worüber Urkunde in Pétange erstellt wurde, an dem zu Beginn dieses Dokuments genannten Tag.
Das Dokument wurde der Bevollmächtigten der Erschienenen vorgelesen, und die besagte Bevollmächtigte unterzeich-

nete gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 septembre 2015. Relation: EAC/2015/21953. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015167439/883.
(150185508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Ararat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 21.184.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015167487/9.
(150184877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

CMC Biologics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 71.105,57.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 134.356.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of September.
In front of Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary, residing in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg.

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of “CMC Biologics S.à r.l.”, a Luxembourg “société à responsabilité

limitée”, having its registered office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 134.356 (the “Company”), incorporated by a deed
enacted by Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on 27 November 2007,
published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 95 dated 14 January 2008 and lastly amended

156554

L

U X E M B O U R G

by a deed enacted on 30 June 2010 by Maître Martine Schaeffer, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations” number 1799 dated 2 September 2010.

The meeting is presided by Mrs Lucile ARNOUX, lawyer, residing professionally at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453

Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Marilyn KRECKÉ, private employee, residing professionally at 74, avenue

Victor Hugo, L-1750 Luxembourg and the meeting elects as scrutineer Mrs Isabel DIAS, private employee, residing pro-
fessionally at the same address.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list. That

list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain attached hereto to be registered with these
minutes.

II.- As appears from the attendance list 7,080,774 (seven million eighty thousand seven hundred seventy-four) shares

out of 7,110,557 (seven million one hundred ten thousand five hundred fifty-seven) shares with a par value of EUR 0.01
(one cent), representing 99,5% of the share capital and held by a majority of the shareholders of the Company, are present
or represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholders expressly
state that they have been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Amendment of article 9.3 of the articles of association of the Company and the definitions' section of the articles of

association of the Company;

2. Amendment of article 22.4 (vii) of the articles of association of the Company relating to the number of economic

shares allocated to each shareholder and article 23.4 of the articles of association of the Company relating to the distribution
of the Balance (as defined therein) in case of dissolution-liquidation;

3. Amendment of article 12.1 and article 12.2 of the articles of association of the Company relating to the number of

managers of the Company; and

4. Decision regarding the approbation of the profits of the Company made during the financial year ended 31 December

2014 according to the standalone annual accounts of the Company; and

5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is noted that the table referred to under article 9.3 of the articles of association of the Company (the “AoA”) and

evidencing the Closing Date Price Per Share (the “Table”) omitted to refer to the Class A3 Preferred Shares (as defined in
the AoA).

It is proposed to complete the Table with the reference to the Class A3 Preferred Shares and amend article 9.3 of the

AoA, to subsequently read as follows, the rest of the article remaining unchanged:

“Table: Closing Date Price Per Share

Class A1 Preferred Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 10 (ten euro)

Class A2 Preferred Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 15.75 (fifteen euro and seventy-five euro cents)
Class A3 Preferred Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 15.75 (fifteen euro and seventy-five euro cents)
Class B Common Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 100 (one hundred euro)

Class X1 Preferred Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 10 (ten euro)

Class X2 Preferred Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 15.75 (fifteen euro and seventy-five euro cents)
Class X3 Preferred Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 100 (one hundred euro)”.

It is thereafter proposed to amend the definitions' section of the AoA to include a new definition of EEP under the AoA.
As a consequence of the foregoing, it is proposed to amend the definitions' section of the AoA to henceforth read as

follows, the rest of the said section shall remain unchanged:

“EEP shall mean EEP Managers Limited and the shareholders of the Company for which EEP Managers Limited acts

as the managing general partner or the discretionary fund manager.”

VOTES: 7.066.685 of the votes cast resolve to vote in favour of this resolution.
14.089 of the votes cast resolve to vote against this resolution.
The resolution is therefore adopted.

<i>Second resolution:

It is noted that part (vii) of article 22.4 of the AoA relating to the number of economic shares of the Company currently

states that, “Each Warrant issued upon the issuance of Class X of Preferred Shares and vested at the date of profit allocation
shall count as 1 Economic Share.”

156555

L

U X E M B O U R G

It is proposed to (i) remove reference to part (vii) of article 22.4 of the AoA as no longer necessary, (ii) insert a reference

to Class A3 Preferred Shares and the number of the corresponding economic shares and, subsequently, (iii) amend article
22.4 of the AoA (the other paragraphs shall remain unchanged), which shall read as follows:

“The number of Economic Shares allocated to each shareholder shall be calculated as follows:

(i) Each Class A1 Preferred Share shall count as 1/10 

th

 Economic Share;

(ii) Each Class A2 Preferred Share shall count as 1/6.349 

th

 Economic Share;

(iii) Each Class A3 Preferred Share shall count as 1/6.349 

th

 Economic Share;

(iv) Each Class B Common Share shall count as 1 Economic Share;

(v) Each Class X1 Preferred Share shall count as 1/10 

th

 Economic Share;

(vi) Each Class X2 Preferred Share shall count as 1/6.349 

th

 Economic Share;

(vii) Each Class X3 Preferred Share shall count as 1 Economic Share.”
It is also noted that it is wished to authorize and give the Company the possibility to implement an incentive program

with any appropriate type of instrument of any nature whatsoever to the attention of key managers of the CMC Biologics
group of companies.

It is proposed to accordingly amend article 23.4 of the AoA relating to the distribution of the Balance (as defined therein)

in case of dissolution-liquidation to read as follows, the rest of the article 23 remaining unchanged:

“ 23.4. Finally, if any Distributable Amount remains after the payments provided for under items 23.3 (i) and (ii) above

(the Balance), such Balance shall, subject to any further provision of (a) any agreement concluded from time to time between
the shareholders as the case may be and/or (b) any incentive scheme that the board of managers of the Company may have
implemented as the case may be, be distributed between all the shareholders pro rata, on the basis of the number of Economic
Shares attributable to each of them pursuant to article 22.4 of these Articles.”

VOTES: 7.066.685 of the votes cast resolve to vote in favour of this resolution.
14.089 of the votes cast resolve to vote against this resolution.
The resolution is therefore adopted.

<i>Third resolution:

It is proposed that the Company increase the number of the class C managers up to 4 (four) managers (the “Increase of

C Managers”) and clarify the functioning of the appointment and removal of the class A managers, class B managers and
class C managers (the “Functioning Amendment”).

As a consequence of the Increase of C Managers and the Functioning Amendment, it is proposed to restructure and

amend articles 12.1 and 12.2 of the AoA to henceforth read as follows, the rest of the article 12 shall remain unchanged:

“ 12.1. The Company is managed by a board of managers (the “Board”) composed of 4 (four) A managers, 2 (two) B

managers and 4 (four) C managers each, appointed and designated as A manager, B manager or C manager by a resolution
of the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to be shareholder(s).

The appointment and removal of any A manager, B manager or C manager proposed by the respective shareholders

entitled thereto shall be notified in writing by the latter to the other shareholders and to the Company.”

“ 12.2. Appointments.
12.2.1 A managers - The MCP Investors are entitled to propose candidates for the appointment of 4 (four) A managers

by the general meeting of shareholders of the Company.

12.2.2 B managers - maximum of 2 (two)
12.2.2.1 EEP is entitled to propose candidates for the appointment of 1 (one) B manager by the general meeting of

shareholders of the Company.

12.2.2.2 All Class B Common Shareholders who each hold, 1 (one) sole Class B Common Share, are entitled, altogether,

to propose candidates for the appointment of 1 (one) B manager by the general meeting of shareholders of the Company.

12.2.3 C managers - maximum of 4 (four)
12.2.3.1 All Class B Common Shareholders, holding more than 1 (one) sole Class B Common Share (but excluding

EEP), are entitled to propose candidates for the appointment of 2 (two) C managers by the general meeting of shareholders
of the Company.

12.2.3.2 In addition, the shareholders of the Company may elect up to an additional 2 (two) C managers from a list of

persons which such shareholders may request from the A managers and B managers.”

VOTES: 7.066.685 of the votes cast resolve to vote in favour of this resolution.
14.089 of the votes cast resolve to vote against this resolution.
The resolution is therefore adopted.

156556

L

U X E M B O U R G

<i>Fourth resolution:

It is proposed to approve that the profits of the Company made during the financial year ended 31 December 2014

according to the standalone annual accounts of the Company, an amount of EUR 97,883,449, shall be reported for in full
and added to the results brought forward of the Company.

VOTES: 7.066.685 of the votes cast resolve to vote in favour of this resolution.
14.089 of the votes cast resolve to vote against this resolution.
The resolution is therefore adopted.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this meeting, have been estimated at about EUR 1,400.- (one thousand four hundred Euro).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the proxy holder of the

above appearing parties, the present deed in English is followed by a French translation. On request of the same proxy
holder and in case of discrepancies between the French and English and text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the same signed together with us, the notary,

the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le trentième jour du mois de septembre.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des associés de «CMC Biologics S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.356 (la «Société»), constituée
par acte notarié de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 27
novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 95 en date du 14 janvier 2008 et
modifié pour la dernière fois par un acte notarié de Maître Martine Schaeffer le 30 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1799 en date du 2 septembre 2010.

La réunion est présidée par Madame Lucile ARNOUX, juriste, demeurant professionnellement à 2-4, rue Eugène Rup-

pert, L-2453 Luxembourg.

Le président désigne Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxem-

bourg, 74, avenue Victor Hugo, comme secrétaire, et l'assemblée élit Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant
professionnellement à la même adresse, comme scrutatrice.

Le président prie le notaire d'acter ce qui suit:
I.- Les associés de la Société présents ou représentés et le nombre de parts sociales détenues par eux figurent sur la liste

de  présence.  La  liste  de  présence  et  les  procurations,  après  avoir  été  signées  par  les  parties  comparantes  et  le  notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II.- Il apparaît sur la liste de présence que 7.080.774 (sept millions quatre-vingt mille sept cent soixante-quatorze) sur

les 7.110.557 (sept millions cent dix mille cinq cent cinquante-sept) parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 EUR
(un centime), représentant 99,5% du capital social et détenues par une majorité des associés de la Société, sont présentes
ou représentées de telle sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont les
associés déclarent expressément avoir été dûment informés par avance.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Agenda

1. Modification de l'article 9.3 des statuts de la Société et de la section des définitions des statuts de la Société;
2. Modification de l'article 22.4 (vii) des statuts de la Société relatif au nombre des parts économiques attribuées à chacun

des associés et de l'article 23.4 des statuts de la Société relatif à la distribution du Solde (tel qu'il y est défini) en cas de
dissolution-liquidation;

3. Modification de l'article 12.1 et de l'article 12.2 des statuts de la Société relatifs au nombre de gérants de la Société;
4. Décision concernant l'approbation des bénéfices réalisés par la Société durant l'exercice clôturé le 31 décembre 2014

d'après les comptes annuels de la Société; et

5. Divers.

156557

L

U X E M B O U R G

Suite à l'approbation de ce qui précède par les associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

Il est noté que le tableau de l'article 9.3 des statuts de la Société (les «Statuts») mentionnant le Prix par Part à la Date

du Closing (le “Tableau”) omet de se référer aux Parts Sociales Privilégiées de Catégorie A3 (telles que définies dans les
Statuts).

Il est proposé de compléter le Tableau avec la référence aux Parts Sociales Privilégiées de Catégorie A3 et modifier

l'article 9.3 des Statuts, afin de lui donner la teneur suivante, le reste de l'article restant inchangé:

«Tableau: Prix par Part à la Date du Closing

Parts Sociales Privilégiées de Catégorie A1 . . . . . . . .

EUR 10 (dix euros)

Parts Sociales Privilégiées de Catégorie A2 . . . . . . . . EUR 15,75 (quinze euros et soixante-quinze centimes d'euros)
Parts Sociales Privilégiées de Catégorie A3 . . . . . . . . EUR 15,75 (quinze euros et soixante-quinze centimes d'euros)
Parts Ordinaires de Catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 100 (cent euros)

Parts Sociales Privilégiées de Catégorie X1 . . . . . . . .

EUR 10 (dix euros)

Parts Sociales Privilégiées de Catégorie X2 . . . . . . . . EUR 15,75 (quinze euros et soixante-quinze centimes d'euros)
Parts Sociales Privilégiées de Catégorie X3 . . . . . . . .

EUR 100 (cent euros).»

Il est, en conséquence, proposé de modifier la section des définitions des Statuts afin d'insérer dans le Statuts une nouvelle

définition de EEP.

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de modifier la section des définitions des Statuts afin de lui donner la

teneur suivante, le reste de ladite section restant inchangé:

«EEP désigne EEP Managers Limited et les associés de la Société pour le compte desquels EEP Managers Limited agit

comme associé gérant commandité ou comme gestionnaire de fonds jouissant d'un pouvoir discrétionnaire.»

VOTES: 7.066.685 des votes ont été émis en faveur de cette résolution.
14.089 des votes ont émis contre cette résolution.
La résolution est ainsi adoptée.

<i>Deuxième résolution:

Il est noté que le point (vii) de l'article 22.4 des statuts de la Société relatif au nombre de parts économiques de la Société

indique actuellement que, «Chaque Garantie (Warrant) émise dès l'émission des Parts Privilégiées de Catégorie X et acquise
à la date de l'affectation du bénéfice sera assimilée à 1 Part Economique.»

Il est proposé de (i) enlever la référence au point (vii) de l'article 22.4 des Statuts puisque jugée inutile, (ii) insérer une

référence aux Parts Sociales Privilégiées de Catégorie A3 et au nombre de parts économiques correspondantes et, puis, (iii)
modifier l'article 22.4 des Statuts (les autres paragraphes restant inchangés), qui aura la teneur suivante:

“Le nombre de Parts Economiques attribuées à chaque associé sera calculé de la façon suivante:

(i) Chaque Part Privilégiée de Catégorie A1 sera assimilée à 1/10 

ème

 de Part Economique;

(ii) Chaque Part Privilégiée de Catégorie A2 sera assimilée à 1/6,349 

ème

 de Part Economique;

(iii) Chaque Part Privilégiée de Catégorie A3 sera assimilée à 1/6,349 

ème

 de Part Economique;

(iv) Chaque Part Ordinaire de Catégorie B sera assimilée à 1 Part Economique;

(iv) Chaque Part Privilégiée de Catégorie X1 sera assimilée à 1/10 

ème

 de Part Economique;

(v) Chaque Part Privilégiée de Catégorie X2 sera assimilée à 1/6,349 

ème

 de Part Economique;

(vi) Chaque Part Privilégiée de Catégorie X3 sera assimilée à 1 Part Economique.»
Il est également noté qu'il est souhaité autoriser la Société et lui donner la possibilité de mettre en oeuvre un plan

d'intéressement basé sur un type d'instrument approprié de quelque nature que ce soit au profit des gérants-clés du groupe
de sociétés CMC Biologics.

Il est proposé de modifier en conséquence l'article 23.4 des Statuts relatif à la distribution du Solde (tel qu'il y est défini)

en cas de dissolution-liquidation, afin de lui donner la teneur suivante, le reste de l'article 23 restant inchangé:

« 23.4. Enfin, s'il reste un Montant Distribuable après les paiements prévus aux points 23.3 (i) et (ii) ci-dessus (le Solde),

ce Solde, sous réserve le cas échéant des dispositions quelconques (a) de tout accord passé de temps en temps entre les
associés le cas échéant et/ou (b) de tout plan d'intéressement que le conseil de gérance de la Société pourrait avoir mis en
place le cas échéant, sera distribué entre tous les associés au pro rata, sur la base du nombre de Parts Economiques attri-
buables à chacun d'entre eux en vertu de l'article 22.4 des présents Statuts.»

VOTES: 7.066.685 des votes ont été émis en faveur de cette résolution.
14.089 des votes ont émis contre cette résolution.
La résolution est ainsi adoptée.

156558

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution:

Il est proposé d'augmenter le nombre des gérants de classe C à 4 (quatre) (l'«Augmentation du Nombre des Gérants C»)

et de clarifier la procédure de nomination et révocation des gérants A, des gérants B et des gérants C (la «Modification de
la Procédure»).

Suite à l'Augmentation du Nombre des Gérants C et à la Modification de la Procédure, il est décidé [à l'unanimité] de

réorganiser et modifier les articles 12.1 et 12.2 des Statuts afin de leur donner la teneur suivante, le reste de l'article 12
restant inchangé:

« 12.1. La Société est dirigée par un conseil d'administration (le «Conseil») composé de 4 (quatre) gérants A, 2 (deux)

gérants  B  et  4  (quatre)  gérants  C,  nommés  et  désignés  comme  gérant  A,  gérant  B  ou  gérant  C  par  une  résolution  de
l'assemblée générale des associés qui fixe les conditions de leur mandat. Le ou les gérant(s) ne sont pas nécessairement
des associés.

La nomination et révocation de tout gérant A, gérant B ou gérant C proposée par les associés qui y sont respectivement

habilités est notifiée par écrit par ces associés aux autres associés et à la Société.» «

12.2. Nominations.
12.2.1 Gérants A - Les Investisseurs MCP ont le droit de proposer des candidats en vue de la nomination des 4 (quatre)

gérants A par l'assemblée générale des associés de la Société.

12.2.2 Gérants B - maximum de 2 (deux)
12.2.2.1 EEP a le droit de proposer des candidats en vue de la nomination de 1 (un) gérant B par l'assemblée générale

des associés de la Société.

12.2.2.2 Tous les Associés Ordinaires de Catégorie B, dont chacun détient 1 (une) seule Part Ordinaire de Catégorie B,

ont le droit de proposer ensemble des candidats en vue de la nomination d'1 (un) gérant B par l'assemblée générale des
associés de la Société.

12.2.3 Gérants C - maximum de 4 (quatre)
12.2.3.1 A Tous les Associés Ordinaires de Catégorie B, dont chacun détient plus qu'une seule Part Ordinaire de Caté-

gorie B (EEP étant exclu), ont le droit de proposer ensemble des candidats en vue de la nomination de 2 (deux) gérants C
par l'assemblée générale des associés de la Société.

12.2.3.2 De surcroît, les associés de la Société ont le droit de nommer un maximum de 2 (deux) gérants C supplémentaires

à partir d'une liste de personnes que ces associés pourraient demander aux gérants A et gérants B.»

VOTES: 7.066.685 des votes ont été émis en faveur de cette résolution.
14.089 des votes ont émis contre cette résolution.
La résolution est ainsi adoptée.

<i>Quatrième résolution:

Il est proposé d'accepter que les bénéfices réalisés par la Société durant l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 d'après

les comptes annuels de la Société, qui s'élèvent à un montant de 97.883.449 EUR, soient reportés dans leur totalité et
s'ajoutent aux résultats reportés de la Société.

VOTES: 7.066.685 des votes ont été émis en faveur de cette résolution.
14.089 des votes ont émis contre cette résolution.
La résolution est ainsi adoptée.
Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été levée.

<i>Estimate of costs

Les coûts, frais et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par

elle en rapport avec cette assemblée, ont été estimés à mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande du mandataire des parties comparantes à

l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande du même mandataire
présent, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont Acte, le présent acte a été rédigé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte au mandataire des parties comparantes, le mandataire des parties comparantes a signé avec

Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Arnoux, M. Krecké, I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 5 octobre 2015. Relation: 2LAC/2015/22239. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

156559

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 12 octobre 2015.

Référence de publication: 2015167565/285.
(150185074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

CPP Investment Board Europe S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 118.556.125,00.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 111.828.

In the year two thousand and fifteen, on the sixth day of October.
Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), acting as replacement

of Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg), absent, the last-mentioned will
remain the depositary of the present deed,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of CPP Investment Board Europe S.à r.l., a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 10-12, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, Grand-Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 111.828, having a
share capital of one hundred sixteen million five hundred thirty-one thousand fifty Euro (EUR 116,531,050.-) (the Com-
pany), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on October 20,
2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on February 23, 2006 under number 398. The
articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary
residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg dated September 24, 2015, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.

THERE APPEARED:

CPPIB, Luxembourg Branch, having its registered office at 10-12, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, Grand-

Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 187.621,
being the Luxembourg branch of Canada Pension Plan Investment Board, a Canadian Crown corporation created by the
Canada Pension Plan Investment Board Act, c.40, 1997, in December 1997 and having its registered office at One Queen
Street East, Suite 2500, Toronto, ON M5C 2W5, Canada (the Sole Shareholder),

duly represented by Peggy Simon, employee, with professional address in L- 6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand-Duchy

of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the under-

signed notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record that:
I. the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. the agenda of the Meeting is as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of two million twenty-five thousand seventy-five Euro

(EUR 2,025,075.-) so as to bring it from its current amount of one hundred sixteen million five hundred thirty-one thousand
fifty  Euro  (EUR  116,531,050.-),  represented  by  four  million  six  hundred  sixty-one  thousand  two  hundred  forty-two
(4,661,242) shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each to the amount of one hundred eighteen
million five hundred fifty-six thousand one hundred twenty-five Euro (EUR 118,556,125.-) by way of the issuance of
eighty-one thousand and three (81,003) new shares in registered form having a nominal value of twenty-five Euro (EUR
25.-) each;

2. Subscription and payment of the share capital increase by way of a contribution in cash;
3. Amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the share

capital increase adopted under item 1 above;

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company to proceed for and on behalf of the Company with the registration of such
changes; and

5. Miscellaneous.
III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

156560

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two million twenty-five

thousand seventy-five Euro (EUR 2,025,075.-) so as to bring it from its current amount of one hundred sixteen million five
hundred thirty-one thousand fifty Euro (EUR 116,531,050.-), represented by four million six hundred sixty-one thousand
two hundred forty-two (4,661,242) shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each to the amount of
one hundred eighteen million five hundred fifty-six thousand one hundred twenty-five Euro (EUR 118,556,125.-) by way
of the issuance of eighty-one thousand and three (81,003) new shares in registered form having a nominal value of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription for, and full payment of, the share capital

increase as follows:

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for eighty-one

thousand and three (81,003) new shares in registered form, having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each,
and fully pays them up by way of a contribution in cash in an amount of twenty million two hundred fifty thousand seven
hundred fifty Euro (EUR 20,250,750.-) (the Contribution).

The Contribution shall be allocated as follows:
(i) two million twenty-five thousand seventy-five Euro (EUR 2,025,075.-) to the share capital of the Company; and
(ii) eighteen million two hundred twenty-five thousand six hundred seventy-five Euro (EUR 18,225,675.-) to the share

premium account of the Company.

The amount of twenty million two hundred fifty thousand seven hundred fifty Euro (EUR 20,250,750.-), being the

Contribution, is at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the undersigned notary who expressly
acknowledges it.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles, so that

it shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The share capital is set at one hundred eighteen million five hundred fifty-six thousand one hundred twenty-five

Euro  (EUR  118,556,125.-)  represented  by  four  million  seven  hundred  forty-two  thousand  two  hundred  forty-five
(4,742,245) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-
up.”

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed for and on behalf of
the Company with the registration of such changes.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of discrepancies between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing party, the proxyholder signed

together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le sixième jour d'octobre.
Par-devant  Maître  Jean  SECKLER,  notaire  de  résidence  à  Junglinster  (Grand-  Duché  de  Luxembourg)  agissant  en

remplacement de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel
dernier restera dépositaire du présent acte,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé de CPP Investment Board Europe S.à r.l., une société

à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi
au 10-12, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.828 et disposant d'un capital social de cent seize millions cinq
cent trente-et-un mille cinquante euros (EUR 116.531.050,-) (la Société), constituée suivant un acte de Maître Henri HEL-
LINCKX,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  le  20  octobre  2005,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et

156561

L

U X E M B O U R G

Associations le 23 février 2006 numéro 398. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte
de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach le 24 septembre 2015, qui n'est pas encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

A COMPARU:

CPPIB, Luxembourg Branch, dont le siège social se situe au 10-12, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.621,
qui est la succursale luxembourgeoise de Canada Pension Plan Investment Board, une société d'État canadienne constituée
par le Canada Pension Plan Investment Board Act, c.40, 1997, en décembre 1997, dont le siège social est établi au One
Queen Street East, Suite 2500, Toronto, ON M5C 2W5, Canada (l'Associé Unique),

dûment représenté par Peggy Simon, employée, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand-

Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux millions vingt-cinq mille soixante-quinze euros

(EUR 2.025.075,-) de sorte de le porter de son montant actuel de cent seize millions cinq cent trente-et-un mille cinquante
euros  (EUR  116.531.050,-),  représenté  par  quatre  millions  six  cent  soixante-et-un  mille  deux  cent  quarante-deux
(4.661.242) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune au montant de cent dix-huit
millions cinq cent cinquante-six mille cent vingt-cinq euros (EUR 118.556.125,-) par voie d'émission de quatre-vingt-un
mille trois (81.003) nouvelles parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune;

2. Souscription et libération de l'augmentation de capital social par voie d'apport en numéraire;
3. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation de capital social

mentionnée au point 1 ci-dessus;

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité

donnés à tout gérant de la Société pour procéder au nom et pour le compte de la Société à l'enregistrement desdits chan-
gements; et

5. Divers.
III. l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux millions vingt-cinq mille

soixante-quinze euros (EUR 2.025.075,-) de sorte de le porter de son montant actuel de cent seize millions cinq cent trente-
et-un mille cinquante euros (EUR 116.531.050,-), représenté par quatre millions six cent soixante-et-un mille deux cent
quarante-deux (4.661.242) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune au montant
de cent dix-huit millions cinq cent cinquante-six mille cent vingt-cinq euros (EUR 118.556.125,-) par voie d'émission de
quatre-vingt-un mille trois (81.003) nouvelles parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à, et la libération intégrale de l'augmentation

de capital social comme suit:

<i>Souscription - Libération

Sur ce, l'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à quatre-vingt-un mille trois

(81.003) nouvelles parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) cha-
cune, et accepte de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de vingt millions deux cent cinquante
mille sept cent cinquante euros (EUR 20.250.750,-) (l'Apport).

L'Apport sera affecté comme suit:
(i) deux millions vingt-cinq mille soixante-quinze euros (EUR 2.025.075,-) au capital social de la Société; et
(ii) dix-huit millions deux cent vingt-cinq mille six cent soixante-quinze euros (EUR 18.225.675,-) au compte de prime

d'émission de la Société.

Le montant de l'Apport de vingt millions deux cent cinquante mille sept cent cinquante euros (EUR 20.250.750,-) est à

la disposition de la Société, dont la preuve a été fournie au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

156562

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

En conséquence de la précédente résolution, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, de sorte qu'il

ait désormais la teneur suivante:

“  5.1.  Le  capital  social  est  fixé  à  cent  dix-huit  millions  cinq  cent  cinquante-six  mille  cent  vingt-cinq  euros  (EUR

118.556.125,-) représenté par quatre millions sept cent quarante-deux mille deux cent quarante-cinq (4.742.245) parts
sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.”

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus

avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder au nom et pour
le compte de la Société à l'enregistrement desdits changements.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-

dessus, le présent acte est libellé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et
français, la version anglaise prévaudra.

EN FOI DE QUOI, le présent acte est passé à Junglinster, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire agissant au nom de la partie comparante, le mandataire a signé avec nous le

notaire, le présent acte original.

Signé: P. SIMON, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 08 octobre 2015. Relation: GAC/2015/8588. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 12 octobre 2015.

Référence de publication: 2015167577/181.
(150185321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Deutsche Oel &amp; Gas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 179.408.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth of September.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr. Liridon ELSHANI, private employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg

pursuant to a resolution of the Directors of the Company passed on September 24 

th

 , 2015

A copy of the minutes of the board of directors, having been signed “ne varietur” by the appearing party and by the

notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party declared and requested the notary to act that:
I. The Company Deutsche Oel &amp; Gas S.A., a public limited company (Société Anonyme) under Luxembourg law, having

its registered office at 26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, registered with the register of commerce and companies
of Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés) under the Number B 179.408 (the «Company»), was incorporated
before the notary Francis Kessler, on 29 July 2013 such incorporation having been published in the Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations n° 2276 of 17 September 2013, which articles have been amended the last time by a deed of the
undersigned notary on 3 December 2014, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C n° 433 of 17
February 2015.

II. The share capital of the Company amounts to four hundred eighty million eighty-one thousand two hundred Euros

(EUR 480,081,200,-) divided into two hundred seventy million four hundred thirty million two hundred eighty-five thou-
sand six hundred ninety-two (270,435,692) Class A shares, one hundred ninety-nine million six hundred forty-five thousand
five hundred and eight (199,645,508) Class B shares and ten million (10,000,000) Class C shares, without nominal value.

III. Paragraph 2 of the Article 6 of the articles of association of the Company, which provides for an authorized capital,

reads as follows:

“The authorized capital of the Company is limited to the maximum of 1,500,000,000.- EUR (one billion and five hundred

million Euro). For a period of five (5) years commencing upon the date of this notarial deed, to board of directors is entitled

156563

L

U X E M B O U R G

to issue additional shares, share classes and any other securities one or more times pursuant to the terms and conditions
that it determines in its sole discretion and, in particular, without being required to reserve a preferential right of subscription
to existing shareholders in respect of such new shares or other securities, but within at all times the maximum amount of
authorized capital. In the event that the board of directors, pursuant to the foregoing authorization, carries out such issues
without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued, it shall draw
up a special report to the general meeting, in conformity with article 32-3 (5) of the Luxembourg companies law of August
10, 1915. The board of directors may delegate to any duly-authorized director or any other person duly authorized to enter
into subscriptions of the new shares or other securities on the Company’s behalf, to receive payment therefor representing
all or a part of the amount of the capital increase or in payment of other securities, and to record each such capital increase
by way of notarial deed and update the shareholders register accordingly. The board of directors shall inform the share-
holders ordinary annual general meeting each year of the transactions carried out pursuant to this article”

IV. By circular board resolutions dated on September 24 

th

 , Directors of the Company decided to proceed to the increase

of the share capital by an amount of EUR 19,918,800,- (nineteen million nine hundred eighteen thousand eight hundred
Euros) so as to raise it from its current amount of four hundred eighty million eighty-one thousand two hundred Euros
(EUR 480,081,200,-) divided into two hundred seventy million four hundred thirty million two hundred eighty-five thou-
sand six hundred ninety-two (270,435,692) Class A shares, one hundred ninety-nine million six hundred forty-five thousand
five hundred and eight (199,645,508) Class B shares and ten million (10,000,000) Class C shares, without nominal value,
to the total amount of EUR 500,000,000.- (five hundred million Euros) by the creation and issuing of 19,918,800 (nineteen
million nine hundred eighteen thousand eight hundred) new B class shares entirely subscribed and paid in by the existing
shareholders.

Subscription and payment of the issued 19,918,800 (nineteen million nine hundred eighteen thousand eight hundred)

new B class shares was made by way of (i) a cash contribution for a total amount of EUR 18.026.567,41 and (ii) contribution
in kind through debt compensation for a total amount of EUR 1.892.232,59.

The board of the Company has within a decision dated 24 September 2015 that is attached to the present deed expressly

confirmed the existence of the aforementioned contributions in cash and in kind and their total amounts and identified their
amounts on a per individual shareholder basis. The board has further expressly decided to take the full and entire respon-
sibility for the truth and accurateness of the aforementioned information and figures as appendixes to the board decision.
In particular, the board of the Company has in said board decision confirmed that capital contributions of shareholders
through compensation with debt owed towards them by the Company qualify as contribution other than in cash within the
meaning of Article 26-1 (3ter) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies, that the conditions mentioned

in aforementioned article 26-1 (3ter) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies are entirely fulfilled

regarding said contribution, and that no fair value opinion by an approved statutory auditor (réviseur d’entreprise agréé) is
required regarding the contributions consisting in debt compensations.

V. As a consequence of such increase of capital, the Directors decided to amend The first phrase Company’s article 5

(Capital) shall be amended into the following:

“ Art. 5. The issued capital of the Company is set at EUR 500,000,000.- (five hundred million Euro) divided into two

hundred  seventy  million  four  hundred  thirty  million  two  hundred  eighty-five  thousand  six  hundred  ninety-two
(270,435,692) Class A shares, two hundred nineteen million five hundred sixty-four thousand and three hundred and eight
(219,564,308) Class B shares and ten million (10,000,000) Class C shares, without nominal value

<i>Expenses

The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of the

present deed are valued at approximately six thousand seven hundred Euro (EUR 6,700.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Es Folgt die Deutsche Übersetzung

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am fünfundzwanzigsten September.
Vor uns, Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Liridon ELSHANI, Privatangestellter, beruflich ansässig in 74, Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, handelnd als

Bevollmächtigter der Gesellschaft gemäß einer Beschlussfassung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft vom 25.
November 2014.

156564

L

U X E M B O U R G

Eine Kopie der Beschlussfassungen des Verwaltungsratsmitglieder wird, nach „ne variatur“ Unterzeichnung durch die

erschienene Partei und den Notar, anliegend an dieser Urkunde verbleiben um mit letzterer den Registrierungsbehörden
zugeleitet zu werden.

Die erschienene Partei erklärt und ersucht den Notar wie folgt aufzunehmen dass:
I. Die Gesellschaft Deutsche Oel &amp; Gas S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 26, Boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg (Registre de Commerce
et des Sociétés) unter der Nummer B 179.408 (die «Gesellschaft»), vor dem Notar Francis Kessler am 29 Juli 2013 gegründet
worden ist, welche Gründung veröffentlicht wurde im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations n° 2276 vom 17.
September 2013, deren Satzung demletzt abgeändert wurden durch dem unterzeichnenden Notar am 23. Dezember 2014,
im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C n°433 des 17. Februar 2015 veröffentlicht.

II. Das Aktienkapital der Gesellschaft ist auf vierhundert achtzig Millionen einundachtzig tausend zweihundert Euros

(EUR 480.081.200) festgelegt, aufgeteilt auf zwei hundert siebzig Millionen vier hundert fünf und dreißig tausend sechs
hundert zwei und neunzig (270.435.692) Aktien der Klasse A, ein hundert neun und neunzig Millionen sechshundert fünf
und vierzig tausend fünf hundert und acht (199.645.508) Aktien der Klasse B und zehn Millionen (10.000.000) Aktien der
Klasse C. Aktien der Klasse A, der Klasse B und der Klasse C haben keinen Nominalwert.

III. Absatz 2 der Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft, folgende genehmigte Kapital beträgt:
„Das genehmigte Kapital ist limitiert auf einen Höchstbetrag von 1.500.000.000 EUR (eine Milliarde und fünf hundert

Millionen Euro). Während einer Dauer von fünf (5) Jahren ab dem Datum dieses notariellen Aktes ist der Verwaltungsrat
ermächtigt, weitere Aktien, Aktienklasse und jegliche anderen Finanzinstrumente auch mehrmals auszugeben gemäß Be-
dingungen und Konditionen die er eigenmächtig festlegt, und insbesondere ohne dass jegliche Vorzugsrechte hinsichtlich
der Zeichnung der Aktien oder der Finanzinstrumente existierenden Aktionären zugestanden werden müssten, wobei der
Verwaltungsrat aber stets die Grenze des Höchstbetrags des genehmigten Kapitals respektieren muss. Soweit der Verwal-
tungsrat  gemäß  der  vorgenannten  Ermächtigung  solche  Ausgaben  ohne  Gewährung  von  Vorzugsrechten  zu  Gunsten
bestehender Aktionäre unternimmt, muss er gemäß Artikel 32-3 (5) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften einen Spezialbericht an die Aktionärshauptversammlung kommunizieren. Der Verwaltungsrat kann jegliche
dafür ermächtigte Verwalter oder jegliche andere ermächtigte Personen damit beauftragen, für die Gesellschaft die Ausgabe
von neuen Aktien oder anderen Finanzinstrumenten zu unternehmen und abzuwickeln, Zahlungen für die Kapitalerhö-
hungen  oder  für  andere  Finanzinstrumente  entgegenzunehmen,  und  all  solche  Kapitalerhöhungen  und  Ausgaben  von
Finanzinstrumenten notariell beurkunden zu lassen und sie dementsprechend im Aktienregister aufnehmen lassen. Der
Verwaltungsrat informiert die jährliche ordentliche Hauptversammlung über die im betreffenden Jahr so erfolgten Opera-
tionen.“

Gemäß Verwaltungsratsbeschluss vom 24. September 2015, hat der Verwaltungsrat beschlossen, das Aktienkapital der

Gesellschaft um einen Betrag von EUR 19.918.800,- (neunzehn Millionen neun hundert achtzehn Tausend achthundert
Euro) vom gegenwärtigen Kapital von vierhundert achtzig Millionen einundachtzig tausend zweihundert Euros (EUR
480.081.200) festgelegt, aufgeteilt auf zwei hundert siebzig Millionen vier hundert fünf und dreißig tausend sechs hundert
zwei und neunzig (270.435.692) Aktien der Klasse A, ein hundert neun und neunzig Millionen sechshundert fünf und
vierzig tausend fünf hundert und acht (199.645.508) Aktien der Klasse B und zehn Millionen (10.000.000) Aktien der
Klasse C. Aktien der Klasse A, der Klasse B und der Klasse C haben keinen Nominalwert, auf ein Kapital von EUR
500.000.000,- (fünf hundert Millionen Euro) durch die Emission von 19.918.800 (neunzehn Millionen neun hundert acht-
zehn tausend achthundert) B Klasse Aktien, gezeichnet durch die existierende Aktionäre.

Die  neu  emittierten  Aktien  wurden  gezeichnet  und  bezahlt,  und  zwar  durch  (i)  Barzahlung  i.H.v;  insgesamt  EUR

18.026.567,41 und (ii) Sacheinlage in der Form von Verrechnung mit Schulden der Gesellschaft gegenüber den jeweiligen
Aktionären i.H.v. insgesamt EUR 1.892.232,59.

Mit der angehangenen Verwaltungsratsbeschluss vom 24. September 2015 hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft die

Art und Höhe der obengenannten Einlagen in Bar und in anderer Form (Verrechnung) insgesamt sowie auf individueller
Basis pro Aktionär identifiziert und bestätigt. Der Verwaltungsrat hat weiterhin bestätigt und beschlossen, jegliche Haftung
für die Bewertung der eingelegten Ansprüche der Aktionäre bzw. der Verrechnungen sowie die Existenz und Höhe der
erfolgten obengenannten Bareinlagen zu übernehmen. Der Verwaltungsrat hat in seiner Entscheidung festgehalten und
vollumfänglich akzeptiert, dass die Beträge der vorgenannten Verrechnungen als Einlage von Aktiva i.S.des Artikel 26-1
(3ter) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften qualifizieren. Der Verwaltungsrat bestätigt in seinem
Beschluss ebenfalls, dass hinsichtlich der Verrechnungen die in Artikel 26-1 (3ter) des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften festgelegten Bedingungen erfüllt sind und dass aufgrund des Vorgenannten und gemäß Artikel 26-1
(3ter) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften für die vorgenannten Einlagen durch Verrechnung
nicht ein Bericht eines Wirtschaftsprüfers (réviseur d’entreprise agréé) i.S. des Artikel 26-1 (2) und (3) des Gesetzes vom
10. August 1915 benötigt und erstellt wird.

IV. Als Folge der Kapitalerhöhung beschließt der Verwaltungsrat der Gesellschaft, Satz 1 von Artikel 5 der Satzung

der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

„ Art. 5. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist auf EUR 500.000.000,- (fünf hundert Millionen Euro) festgelegt,

aufgeteilt  auf  zwei  hundert  siebzig  Millionen  vier  hundert  fünf  und  dreißig  tausend  sechs  hundert  zwei  und  neunzig

156565

L

U X E M B O U R G

(270.435.692) A-Klasse Aktien, zwei hundert neun zehn Millionen fünfhundert vier und sechzig tausend drei hundert und
acht (219.564.308) B-Klasse Aktien und zehn Millionen (10.000.000) C Klasse Aktien.“

<i>Kosten

Der Betrag der Aufwendungen, Auslagen und Kosten jedweder Art, zu zahlen durch die Gesellschaft als Folge dieser

Urkunde, wird auf sechstausendsiebenhundert Euro (EUR 6.700,-) festgelegt.

Der unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass auf Antrag der erschienenen Partei,

die vorliegende Urkunde in Englisch gefolgt von einer deutschen Version abgefasst ist; auf Antrag derselben erschienenen
Partei und im Fall von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Version, wird die englische Fassung
vorgehen.

Worüber die vorliegende Urkunde in Luxemburg aufgenommen wurde am Tage, welcher zu Beginn des Dokuments

genannt ist.

Nach Verlesung des Dokumentes vor der erschienenen Person, welche dem Notar mit Namen, Vornamen, Zivilstatus

und Wohnort bekannt ist, unterzeichnet die erschienene Person mit uns, dem Notar, die vorliegende Urkunde.

Signé: J. Konrad, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 5 octobre 2015. Relation: 2LAC/2015/22236. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 12 octobre 2015.

Référence de publication: 2015167599/164.
(150185032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Deutsche Oel &amp; Gas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 179.408.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth of September.
Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Shareholders Meeting”) of Deutsche Oel &amp; Gas S.A. a public

limited company (société anonyme) under Luxembourg law, having its registered office at 26, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, registered with the register of commerce and companies of Luxembourg (Registre de Commerce et des
Sociétés) under the Number B 179.408, incorporated before the notary Francis Kessler, on 29 July 2013 (the «Company»),
such incorporation having been published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations n° 2276 of 17 September
2013,  which  articles  have  been  amended  the  last  time  by  undersigned  notary,  on  3  December  2015,  published  in  the
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C, n°433, dated 17 February 2015.

The Shareholders Meeting was presided by Mr. Jens Konrad, avocat à la Cour, residing professionally at 55-57, rue de

Merl, L-2146 Luxembourg.

The chairman appointed as Secretary Mrs. Marilyn KRECKE, private employee, residing professionally at 74, avenue

Victor Hugo.

The Shareholders Meeting elected as scruteener (scrutateur) Mr. Jens Konrad, avocat à la Cour, prenamed.
The Board having thus been formed, the Chairman stated and asked the Notary to enact:
I. That Shareholder Meeting has been duly convened by the publication of the convening notice including the Agenda

of the meeting in both, the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations and the Luxemburger Wort, each on Tuesday
9. September 2015 and Wednesday 17. September 2015.

II. That the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Conversion of 150,000,000 A class shares into 150,000,000 B class shares
2. Corresponding amendment of article 5 (share capital - share and share certificates) of the articles of incorporation.
3. Miscellaneous.
III. The Shareholders present or represented at the Meeting are shown on an attendance list. This attendance list and the

proxies of the represented partners, signed “ne varietur”, by the bureau of the Meeting and the proxyholders, will remain
attached to the present minutes.

IV. That it results from that list that from 420,435,692 issued A class shares, issued 49,645,508 B class shares and issued

10,000,000 C class shares, are present or represented 99,96% of the share capital are attending at the Meeting, which
consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide upon the aforecited agenda of the meeting.

156566

L

U X E M B O U R G

<i>First Resolution

The General assembly decides the conversion of 150,000,000 (nine million eight hundred fifty thousand) A class shares

into 150,000,000 (nine million eight hundred fifty thousand) B class shares.

<i>Second Resolution

The general assembly decides to correspondingly amend the second phrase of the ¨first paragraph of article 5 (share

capital) of the Company as follows:

“The issued capital of the Company is set at EUR 480.081.200,- (four hundred eighty-one thousand two hundred Euro)

divided into two hundred seventy million four hundred thirty-five thousand and six hundred ninety-two (270.435.692)
Class A shares, one hundred ninety-nine million six hundred forty-five thousand five hundred-eight (199.645.508) Class
B shares and ten million (10,000,000) Class C shares without nominal value.”

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated,

are evaluated at approximately one thousand two hundred. Euro (EUR 1,200.-).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, duly represented, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, she signed together with us, the notary,

the present original deed.

Followed by the German version of the preceding:

Im Jahre zweitausend und fünfzehnten, am fünfundzwanzigsten September.

Ist erschienen

vor der Notarin Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg:
Es wurde abgehalten die außergewöhnliche Aktionärshauptversammlung (die „Hauptversammlung“) der Deutsche Oel

&amp; Gas S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
eingetragen beim Handelsund Gesellschaftsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der
Nummer  B  179.408,  gegründet  worden  vor  dem  Notar  Francis  Kessler  am  29  Juli  2013  (die  «Gesellschaft»),  welche
Gründung veröffentlicht wurde im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations n° 2276 vom 17. September 2013, deren
Stuaten demletzt abgeändert wurden durch einen Notarakt, verfasst durch Maître Schaeffer, vorgenannt, mit Amtssitz in
Luxemburg, am 25. November 2014, im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C, n°433, datiert zum 17. Februar
2015, veröffentlicht.

Die Hauptversammlung wurde präsidiert von Herrn Jens Konrad, avocat à la Cour, beruflich ansässig in 55-57, rue de

Merl, L-2146 Luxemburg.

Der Präsident ernannte als Sekretär Frau Marilyn KRECKE, Angestellte, beruflich ansässig in 74, Avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxemburg.

Wurde als Stimmzähler (scrutateur) ernannt Herr Jens Konrad, avocat à la Cour, vorgenannt.
Das Büro der Hauptversammlung wurde aufgestellt, und der Vorsitzende erklärte und bat den Notar Folgendes festzu-

halten:

I. Dass die Aktionäre ordentlich zur Hauptversammlung durch schriftliche Benachrichtigung der registrierten Gesell-

schafter einberufen worden sind und dieselbe informiert worden sind durch Veröffentlichung im Mémorial Recueil des
Sociétés et ssociations als auch im Luxemburger Wort, jeweils am Dienstag den 9. September 2015 und am Mittwoch den
17. September 2015.

II. Dass die Tagesordnung dieser ausserordentlichen Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Umwandlung von 150.000.000 A Klasse Aktien in 150.000.000 B Klasse Aktien.
2. Dementsprechende Abänderung der Artikel 5 (Kapital - Aktien und Aktienzertifikate) der Satzung der Gesellschaft.
3. Diverses.
III. Die bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschafter und die von ihnen gehaltenen Beteiligungen

sowie der Prozentsatz ihrer Kapitalzusage an die Gesellschaft werden auf der Anwesenheitsliste dargestellt. Diese Anwe-
senheitsliste und die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter werden nach deren Unterzeichnung „ne varietur" durch
die Versammlungsleitung und die Bevollmächtigten der vorliegenden Urkunde beigefügt.

IV. Aus der genannten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den 420.435.692 A Klasse Aktien, 49,645,508 B Klasse

Aktien und 10.000.000 C Klasse Aktien, anwesend oder vertreten sind, wobei letztere durch einen einzigen Eigentümer
gehalten werden. 99,96% der in Umlauf ausgegebenen Aktien vertreten und die Generalversammlung kann demzufolge
rechtsgültig über die Tagesordnung verhandeln und ist beschlussfähig.

156567

L

U X E M B O U R G

<i>Erster Beschluss:

Die Hauptversammlung der Gesellschaft beschließt die Umwandlung von 150.000.000 A Klasse Aktien in 150.000.000

B Klasse Aktien.

<i>Zweiter Beschluss:

Die Hauptversammlung der Gesellschaft beschließt, eine dementsprechende Abänderung vom ersten Absatz des Artikel

5 (Kapital - Aktien und Aktienzertifikate) der Satzung der Gesellschaft wie folgt:

„Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist auf EUR 480.081.200,- (vier hundert achtzig Millionen einundachtzig

Tausend zweihundert Euros) festgelegt, aufgeteilt auf zwei hundert siebzig Millionen fünf hundert vierundsechzig Tausend
dreihundert und acht (270.564.308) A-Klasse Aktien, einhundert neun und neunzig Millionen sechshundert fünf und vierzig
Tausend fünf hundert acht (199.645.508) B-Klasse Aktien und zehn Millionen (10.000.000) C Klasse Aktien.“

<i>Kosten

Die Kosten für diese Beurkundung werden geschätzt auf eintausendwzeihundert Euro (Euro 1.200,-).
Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anfrage der

vorgenannten, erschienenen Partei, welche rechtswirksam vertreten ist, die vorliegende Urkunde in Englisch erstellt und
auf Deutsch übersetzt wurde. Auf Anfrage der vorgenannten Person gilt im Zweifelsfalle die englische Fassung.

Die vorliegende notarielle Urkunde wurde in Luxemburg am obengenannten Tage erstellt.
Dieses Dokument wurde durch den Bevollmächtigten, agierend wie vorgenannt, vorgelesen und zusammen mit dem

Notar unterschrieben.

Signé: J. Konrad, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 5 octobre 2015. Relation: 2LAC/2015/22235. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 12 octobre 2015.

Référence de publication: 2015167600/115.
(150185032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Deutsche Oel &amp; Gas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 179.408.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth of September.
Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Shareholders Meeting”) of Deutsche Oel &amp; Gas S.A. a public

limited company (société anonyme) under Luxembourg law, having its registered office at 26, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, registered with the register of commerce and companies of Luxembourg (Registre de Commerce et des
Sociétés) under the Number B 179.408, incorporated before the notary Francis Kessler, on 29 July 2013 (the «Company»),
such incorporation having been published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations n° 2276 of 17 September
2013, which articles have been amended the last time by a deed of us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Lu-
xembourg,  on  3  December  2015,  published  in  the  Mémorial  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  C,  n°433,  dated  17
February 2015.

The Shareholders Meeting was presided by Mr. Jens Konrad, avocat à la Cour, residing professionally at 55-57, rue de

Merl, L-2146 Luxembourg.

The chairman appointed as Secretary Mrs. Marilyn KRECKE, private employee, residing professionally at 74, avenue

Victor Hugo.

The Shareholders Meeting elected as scruteener (scrutateur) Mr. Jens Konrad, avocat à la Cour, prenamed.
The Board having thus been formed, the Chairman stated and asked the Notary to enact:
I. That Shareholder Meeting has been duly convened by the publication of the convening notice including the Agenda

of the meeting in both, the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations and the Luxemburger Wort, each on Tuesday
8. September 2015 and Wednesday 16. September 2015.

II. That the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Conversion of 9.850.000 A class shares into 9.850.000 C class shares

156568

L

U X E M B O U R G

2. Corresponding amendment of article 5 (share capital - share and share certificates) of the articles of incorporation.
3. Miscellaneous.
III. The Shareholders present or represented at the Meeting are shown on an attendance list. This attendance list and the

proxies of the represented partners, signed “ne varietur”, by the bureau of the Meeting and the proxyholders, will remain
attached to the present minutes.

IV. That it results from that list that from 430.285.692 issued A class shares, issued 49.645.598 B class shares and issued

150.000 C class shares, are present or represented so that 99,96% of the share capital are attending at the Meeting, which
consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide upon the aforecited agenda of the meeting.

<i>First Resolution

The General assembly decides the conversion of 9.850.000 (nine million eight hundred fifty thousand) A class shares

into 9.850.000 (nine million eight hundred fifty thousand) C class shares.

<i>Second Resolution

The general assembly decides to correspondingly amend the second phrase of the ¨first paragraph of article 5 (share

capital) of the Company as follows:

“The issued capital of the Company is set at EUR 480.081.200.- (four hundred eighty million and eighty-one thousand

two hundred) divided into four hundred twenty million four hundred thirty-five thousand and six hundred ninety-two
(420.435.692) Class A shares, forty-nine million six hundred forty-five thousand five hundred eight (49.645.508) Class B
shares and ten million (10,000,000) Class C shares without nominal value.”

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated,

are evaluated at approximately one thousand two hundred. Euro (EUR 1,200.-).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, duly represented, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, she signed together with us, the notary,

the present original deed.

Followed by the German version of the preceding:

Im Jahre zweitausend und fünfzehn, am fünfundzwanzigsten September.

Ist erschienen

vor der Notarin Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg:
Es wurde abgehalten die außergewöhnliche Aktionärshauptversammlung (die „Hauptversammlung“) der Deutsche Oel

&amp; Gas S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
eingetragen beim Handelsund Gesellschaftsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der
Nummer  B  179.408,  gegründet  worden  vor  dem  Notar  Francis  Kessler  am  29  Juli  2013  (die  «Gesellschaft»),  welche
Gründung veröffentlicht wurde im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations n° 2276 vom 17. September 2013, deren
Stuaten demletzt abgeändert wurden durch einen Notarakt, verfasst durch Maître Schaeffer, vorgenannt, mit Amtssitz in
Luxemburg, am 25. November 2014, im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C, n°433, datiert zum 17. Februar
2015, veröffentlicht.

Die Hauptversammlung wurde präsidiert von Herrn Jens Konrad, avocat à la Cour, beruflich ansässig in 55-57, rue de

Merl, L-2146 Luxemburg.

Der Präsident ernannte als Sekretär Frau Marilyn KRECKE, Angestellte, beruflich ansässig in 74, Avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxemburg.

Wurde als Stimmzähler (scrutateur) ernannt Herr Jens Konrad, avocat à la Cour, vorgenannt.
Das Büro der Hauptversammlung wurde aufgestellt, und der Vorsitzende erklärte und bat den Notar Folgendes festzu-

halten:

I. Dass die Aktionäre ordentlich zur Hauptversammlung durch schriftliche Benachrichtigung der registrierten Gesell-

schafter einberufen worden sind und dieselbe informiert worden sind durch Veröffentlichung im Mémorial Recueil des
Sociétés et ssociations als auch im Luxemburger Wort, jeweils am Dienstag den 8. September 2015 und am Mittwoch den
16. September 2015.

Dass die Tagesordnung dieser ausserordentlichen Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Umwandlung von 9.850.000 A Klasse Aktien in 9.850.000 C Klasse Aktien.
2. Dementsprechende Abänderung der Artikel 5 (Kapital - Aktien und Aktienzertifikate) der Satzung der Gesellschaft.
3. Diverses.

156569

L

U X E M B O U R G

III. Die bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschafter und die von ihnen gehaltenen Beteiligungen

sowie der Prozentsatz ihrer Kapitalzusage an die Gesellschaft werden auf der Anwesenheitsliste dargestellt. Diese Anwe-
senheitsliste und die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter werden nach deren Unterzeichnung „ne varietur" durch
die Versammlungsleitung und die Bevollmächtigten der vorliegenden Urkunde beigefügt.

IV. Aus der genannten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den 430.285.692 A Klasse Aktien, 49.645.598B Klasse

Aktien und 150.000 C Klasse Aktien,. Somit sind 99,96% der in Umlauf ausgegebenen Aktien vertreten und die General-
versammlung kann demzufolge rechtsgültig über die Tagesordnung verhandeln und ist beschlussfähig.

<i>Erster Beschluss:

Die Hauptversammlung der Gesellschaft beschließt die Umwandlung von 9.850.000 A Klasse Aktien in 9.850.000 C

Klasse Aktien.

<i>Zweiter Beschluss:

Die Hauptversammlung der Gesellschaft beschließt, eine dementsprechende Abänderung vom ersten Absatz des Artikel

5 (Kapital - Aktien und Aktienzertifikate) der Satzung der Gesellschaft wie folgt:

„Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist auf EUR 480.081.200,- (vier hundert achtzig Millionen einundachtzig

tausend zweihundert Euros) festgelegt, aufgeteilt auf vier hundert zwanzig Millionen vier hundert fünfunddreißig Tausend
sechshundert zweiundneunzig (420.435.692) AKlasse Aktien, neunundvierzig Millionen sechshundertfünfundvierzig Tau-
send fünfhundertacht (49.645.508) B-Klasse Aktien und zehn Millionen (10.000.000) C Klasse Aktien.“

<i>Kosten

Die Kosten für diese Beurkundung werden geschätzt auf eintausendundzweihundert (Euro 1.200,-).
Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anfrage der

vorgenannten, erschienenen Partei, welche rechtswirksam vertreten ist, die vorliegende Urkunde in Englisch erstellt und
auf Deutsch übersetzt wurde. Auf Anfrage der vorgenannten Person gilt im Zweifelsfalle die englische Fassung.

Die vorliegende notarielle Urkunde wurde in Luxemburg am obengenannten Tage erstellt.
Dieses Dokument wurde durch den Bevollmächtigten, agierend wie vorgenannt, vorgelesen und zusammen mit dem

Notar unterschrieben.

Signé: J. Konrad, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 5 octobre 2015. Relation: 2LAC/2015/22234. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 12 octobre 2015.

Référence de publication: 2015167601/115.
(150185032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Deutsche Real Estate Funds Advisor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 181.403.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of September.
Before Us, Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

BC Investments LLC., a limited liability company, organized and governed under the laws of the State of Delaware,

having his its registered office at 2701, Centerville Road, 19808 New Castle County, Wilmington, Delaware, United States
of America, registered with the Registry of Delaware under the number 5321568,

SOMERSTON GSH LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of Jersey, having its registered

office at 45 Esplanade JE-JE2 3 QB Saint-Hélier, registered with the Registry of Jersey under the number 117820,

INTERNOS GLOBAL INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of United

Kingdom, having its registered office at 65 Grosvenor Street, GB-W1K 3JH London (UK), registered with the Registry of
United Kingdom under the number 07982302

TEMMES MANAGEMENT SERVICES MONACO SARL, a company incorporated and existing under the laws of

Monaco, having its registered office at 1 Rue du Ténao, MC-98000 Monte Carlo, registered with the Répertoire du Com-
merce et de l’Industrie of Monte Carlo under the number 12S05723,

All here represented by Mr. Fabien ROSSIGNOL-BURGOS LEON, employee, with professional address in Luxem-

bourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of four proxies given under private seal.

156570

L

U X E M B O U R G

Such proxies, after having been signed «ne varietur» by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purposes of registration.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
(i) That they are the current shareholders of Deutsche Real Estate Funds Advisor S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) organized and governed under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg,
having its registered office at L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B 181.403, incorporated pursuant to a notarial deed
on 22 October 2013, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations N° 3237 dated of 19 December 2013.
The articles of incorporation have been for the last time by a deed of Me Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem,
on 6 May 2014, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations N° 1880 dated of 18 July 2014.

(ii) That the Shareholders have taken unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to transfer the registered office of the Company from 33, rue du Puits Romain, L-8070 Ber-

trange, Grand-Duchy of Luxembourg, to 151, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
with immediate effect.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Shareholder resolve to restate the first paragraph of article 2 of the

articles of association of the Company, which should now read as follows:

« Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.»

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to appoint as new manager for the Company for an unlimited period:
Mr Stéphane WEYDERS, Director, born in Arlon (B) on 2 January 1972, residing professionally in L-1511 Luxembourg,

151, avenue de la Faïencerie.

<i>Four resolution

The Shareholders resolve to grant the following powers on the bank accounts of the Company opened with ING Lu-

xembourg:

- In favor of Mr Stéphane WEYDERS, prenamed, Mr Fabien ROSSIGNOL-BURGOS LEON, prenamed, Mr Jörg

WAGNER, employee, born on 22 October 1967 in Aumenau (Germany), residing professionally at D-65589 Hadamar,
45, Hohlstrasse and to have all powers on the above mentioned accounts by their joint signature.

- In favor of Mrs Andrea KLIEM, employee, born on 21 November 1958 in Berlin (Germany) residing professionally

at D-81373 Münschen, 50, Treffauerstrasse, to receive information only on the above mentioned accounts.

There being no further business, the meeting is closed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,

followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, known to the notary, by his surname, first

name, civil status and residence, said proxyholder, signed together with the undersigned notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le vingt-deuxiième jour du mois de septembre.
Par-devant nous, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

BC Investments LLC, une limited liability company constituée et régie selon les lois de l’Etat du Delaware, ayant son

siège social à 2701, Centerville Road, 19808 New Castle County, Wilmington, Delaware, Etats-Unis d’Amérique, inscrite
auprès du Registre du Delaware sous le numéro 5321568;

Somerston GSH Limited, une société régie par les lois de Jersey, ayant son siège social au 45 Esplanade, Saint-Hélier,

Jersey JE2 3QB, inscrite au registre de commerce de Jersey sous le numéro 117820;

Internos Global Investments Limited, une société régie par les lois de l’Angleterre et le pays de Galles, ayant son siège

social au 65, Grosvenor Street, Londres, Royaume-Uni W1K 3JH, inscrite au registre de commerce pour l’Angleterre et
le pays de Galles sous le numéro de société 07982302; et

Temmes Management Services Monaco S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Monaco, ayant

son principal établissement au 1, rue du Ténao, 98000 Monte Carlo, Monaco, inscrite au Répertoire du Commerce et de
l’Industrie de Monaco sous le numéro 12S05723,

156571

L

U X E M B O U R G

tous ici représentés par Monsieur Fabien ROSSIGNOL-BURGOS LEON, salarié, demeurant professionnellement à

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de quatre procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, paraphées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant,

demeureront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis du notaire soussigné d’acter ce qui suit:
(i) Qu’ils sont les associés actuels de Deutsche Real Estate Funds Advisor S.à r.l. une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois, ayant son siège social au L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain, Grand-Duché de Luxem-
bourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181.403, constituée par
acte notarié en date du 22 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3237 du 19
décembre 2013. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Me Jean-Joseph WAGNER, notaire de
résidence à Luxembourg en date du 6 mai 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1880
du 18 juillet 2014 (la «Société»).

(ii) Que les Associés ont adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident de transférer le siège social de la Société du 33, rue du Puits Romain L-8070 Bertrange, Grand-

Duché de Luxembourg, au 151, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet
immédiat.

<i>Deuxième résolution

En conséquence, les Associés décident de modifier, avec effet immédiat, le premier alinéa de l’article 2 des statuts de

la Société, pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. Siège social. Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de nommer un nouveau gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Stéphane WEYDERS, Directeur, né à Arlon (B) le 2 janvier 1972, demeurant professionnellement à L-1511

Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie.

<i>Quatrième résolution

Les Associés décident d’attribuer les pouvoirs suivants concernant le compte bancaire ouvert chez ING Luxembourg

au nom de la Société:

- pour Monsieur Stéphane WEYDERS, prénommé, Monsieur Fabien ROSSIGNOL-BURGOS LEON, prénommé et

Monsieur  Jörg  WAGNER,  salarié,  né  à  Aumenau  (Allemagne)  le  22  octobre  1967,  demeurant  professionnellement  à
D-65589 Hadamar (Allemagne), 45, Hohlstrasse, tous pouvoirs sur le compte mentionné ci-avant, agissant par leur signature
conjointe;

- pour Madame Andrea KLIEM, salariée, née le 21 novembre 1958 à Berlin (Allemagne) demeurant professionnellement

à D-81373 Munich, 50, Treffauerstrasse, le droit de recevoir uniquement des informations en relation avec le compte
mentionné ci-avant.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par ses

noms, prénom usuel, état et demeure, le mandataire des comparants a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Rossignol-Burgos Leon, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/30196. Reçu soixante-quinze

euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 2 octobre 2015.

Référence de publication: 2015167602/124.
(150184678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

156572

L

U X E M B O U R G

Cottyn-Kieffer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 13, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 103.943.

L'an deux mille quinze, le trente septembre.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

BIEBER IMMO S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-3895 Foetz, 13, rue de l’Industrie,

R.C.S. Luxembourg B112783,

représentée par son gérant unique Monsieur Claude BIEVER, demeurant professionnellement au 30, rue de Schifflange,

L-3316 Bergem, Grand-Duché de Luxembourg, lui-même ici représenté par Monsieur Georges THINNES, employé privé
à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que BIEBER IMMO S.à r.l., précitée détient les trois cent vingt (320) parts sociales d’une valeur nominale de cent

vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de COTTYN-KIEFFER Sàrl, une société
à responsabilité limitée ayant son siège social à L-3895 Foetz, 13, rue de l’Industrie, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce du Luxembourg sous le numéro B103943, ayant un capital social de quarante mille euros (EUR
40.000,-), constituée suivant un acte reçu par le notaire Blanche MOUTRIER, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du
10 novembre 2004, publié au Mémorial C n°57 du 20 janvier 2005 (la Société Absorbante), et dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu le 3 mai 2012 suivant acte de notaire Christine DOERNER, de résidence à Bettembourg, publié
au Mémorial C n°1797 du 17 juillet 2012.

II. Que les points suivants sont à l’ordre du jour:
1) Renonciation aux formalités de convocation préalable;
2) Présentation du projet de fusion par absorption par COTTYNKIEFFER Sàrl (la Société Absorbante) de TUBALUX

S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 11, rue de l’Industrie à L-3895
Foetz, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 103935 (la Société Absorbée);

3) Constatation que l’associé unique commun de la Société Absorbante et de la Société Absorbée a renoncé à un examen

du projet commun de fusion par un expert indépendant ainsi qu'à un rapport d'expert en accord avec l’article 266(5) de la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et a également renoncé à l’établissement du
rapport par la gérance en accord avec l’article 265(3) de la Loi;

4) Décision d'approuver le projet de fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante tel que

publié et décision d'accomplir la fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante;

5) Rémunération du transfert de l’ensemble des actifs et passifs sans exception ni réserve de la Société Absorbée à la

Société Absorbante moyennant inscription dans le bilan de la Société Absorbante d'une prime de fusion calculée sur base
de l’actif net comptable de la Société Absorbée tel qu'il résulte de sa situation comptable arrêtée au 31 décembre 2014;

6) Prise d'acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée seront traitées comme si elles

avaient été exécutées pour le compte de la Société Absorbante et ce à compter du 1 

er

 janvier 2015 et (ii) que la fusion

prendra effet (a) entre les sociétés qui fusionnent, à la date des décisions concordantes de l’associé unique des sociétés qui
fusionnent approuvant la fusion et (b) vis-à-vis des tiers, après la publication du procès-verbal des résolutions de l’associé
unique des sociétés des sociétés qui fusionnent conformément à l’article 9 de la Loi;

7) Prise d'acte que le personnel salarié de la Société Absorbée sera repris par la Société Absorbante conformément aux

dispositions des articles L. 127-1 et suivants du Code du Travail actuellement en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg;

8)  Décision  de  conserver  les  documents  sociaux  durant  la  période  légale  de  cinq  ans  au  siège  social  de  la  Société

Absorbante;

9) Délégation des pouvoirs pour exécuter tous contrats ou documents et d'accomplir toutes les actions et les formalités

nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la fusion;

10) Adaptation de l’objet social de la Société absorbante et en conséquence de l’article 3 de ses statuts en lui donnant

la teneur suivante:

« Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de couvreur-ferblantier, charpentier, installateur chauf-

fage-sanitaire, fumiste-ramoneur, monteur d’échafaudages, ainsi que toutes activités et la vente d’articles se rapportant aux
branches.

La société a en outre pour objet la vente et la commercialisation de matériaux de construction, la fabrication et vente de

gaines de ventilation, la vente et l’installation de poêles à bois et/ou pellets avec ou sans raccordement au système de
chauffage, les travaux de ramonage et de fumisterie, la vente et l’installation de systèmes de chauffage central, la vente et
l’installation d'inserts et feux ouverts, la vente de barbecues avec accessoires, la vente et l’installation de poêles et inserts
au bioéthanol et au gaz naturel ainsi que toute activité liée à la branche.

156573

L

U X E M B O U R G

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant

directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ou le développement.».

III. Que l’Associé unique représentant l’intégralité du capital de la Société constituée en assemblée a pris les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé  unique  décide  de  renoncer  aux  formalités  de  convocation  préalable,  celui-ci  déclarant  avoir  une  parfaite

connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué à l’avance.

<i>Deuxième résolution

L'Associé unique constate que le projet de fusion par absorption entre la Société Absorbante et la Société Absorbée a

été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg, n° 1713 du 11 juillet
2015.

Conformément aux articles 257 et suivants de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, la fusion s'opère par le transfert

à la valeur comptable, suite à la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée, de l’ensemble des actifs et passifs de
la Société Absorbée à la Société Absorbante.

Le projet du fusion prévoit, qu'étant donné que la Société Absorbante et la Société Absorbée ont le même associé unique,

à savoir BIEBER IMMO S.à r.l., précitée, qu'un rapport d'échange ne sera pas établi et que la fusion se réalisera moyennant
transfert de l’ensemble des actifs et passifs sans exception ni réserve de la Société Absorbée à la Société Absorbante et de
rémunérer ce transfert moyennant inscription dans le bilan de la Société Absorbante d'une prime de fusion calculée sur
base de l’actif net comptable de la Société Absorbée tel qu'il résulte de sa situation comptable arrêtée au 31 décembre 2014
(et non au 31 décembre 2015 comme erronément indiqué dans le projet de fusion).

<i>Troisième résolution

L'Associé unique agissant en qualité d'associé unique de la Société Absorbée ainsi que de la Société Absorbante déclare

avoir renoncé à un examen du projet commun de fusion par un expert indépendant, à un rapport d'expert conformément à
l’article 266(5) de la Loi ainsi qu'à l’établissement du rapport par la gérance conformément à l’article 265(3) de la Loi.

La situation comptable arrêtée au 31 décembre 2014 de la Société Absorbée ainsi qu’une balance générale de la Société

Absorbante au 24 septembre 2015 resteront annexées au présent acte.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique, déclarant avoir pris connaissance des documents susmentionnés et des pièces visées à l’article 267

de la loi applicable en l’espèce dans les délais légaux et constatant que toutes les formalités légales ont été accomplies,
décide d'agréer le projet commun de fusion et de procéder à la fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société
Absorbante, avec prise d'effet à la date de ce jour, sous réserve de l’approbation du même projet par l’associé unique de la
Société Absorbée.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique, compte tenu des décisions qui précèdent, décide de réaliser la fusion moyennant transfert de l’en-

semble des actifs et passifs sans exception ni réserve de la Société Absorbée à la Société Absorbante et de rémunérer ce
transfert moyennant inscription dans le bilan de la Société Absorbante d'une prime de fusion calculée sur base de l’actif
net comptable de la Société Absorbée tel qu'il résulte de sa situation comptable arrêtée au 31 décembre 2014.

Il est spécifié que, conformément aux termes du projet de fusion, le patrimoine de la Société Absorbée transmis de plein

droit à la Société Absorbante comprend notamment tous droits relatifs aux marques, dont «Tubalux, poêles et cheminées»,
et que l’enseigne commerciale «Tubalux» peut être utilisée par Cottyn-Kieffer S. à r.l..

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique décide de prendre acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée

seront traitées comme si elles avaient été exécutées pour le compte de la Société Absorbante et ce à compter du 1 

er

 janvier

2015 et (ii) que la fusion prendra effet (a) entre les sociétés qui fusionnent, à la date des décisions concordantes de l’associé
unique des sociétés qui fusionnent approuvant la fusion et (b) vis-à-vis des tiers après la publication du procès-verbal des
décisions concordantes de l’associé unique des sociétés qui fusionnent approuvant la fusion à l’article 9 de la Loi.

<i>Septième résolution

L'Associé Unique décide de prendre acte que le personnel salarié de la Société Absorbée sera repris par la Société

Absorbante conformément aux dispositions des articles L. 127-1 et suivants du Code du Travail actuellement en vigueur
au Grand-Duché de Luxembourg. Dès lors, les droits et obligations qui résultent, pour la Société Absorbée, des contrats
de travail ou des relations de travail existantes au jour de la publication du projet de fusion entre la Société Absorbée et la
Société Absorbante, sont transférés à la Société Absorbante à compter de la date effective de ladite fusion.

156574

L

U X E M B O U R G

<i>Huitième résolution

L'Associé Unique décide que les livres, archives, dossiers et autres documents de la Société Absorbée seront conservés

durant la période légale de cinq ans au siège social de la Société Absorbante.

<i>Neuvième résolution

L'Associé Unique décide de donner pouvoir et d'autoriser le gérant unique de la Société Absorbante, avec plein pouvoir

de substitution, afin d'exécuter tous contrats ou documents et d'accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires,
appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la fusion.

<i>Dixième résolution

Pour permettre à la Société Absorbante de continuer les activités de la Société Absorbée, l’Associé Unique décide de

modifier son objet social en donnant la teneur suivante à l’article 3 de ses statuts:

« Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de couvreur-ferblantier, charpentier, installateur chauf-

fage-sanitaire, fumisteramoneur, monteur d’échafaudages, ainsi que toutes activités et la vente d’articles se rapportant aux
branches.

La société a en outre pour objet la vente et la commercialisation de matériaux de construction, la fabrication et vente de

gaines de ventilation, la vente et l’installation de poêles à bois et/ou pellets avec ou sans raccordement au système de
chauffage, les travaux de ramonage et de fumisterie, la vente et l’installation de systèmes de chauffage central, la vente et
l’installation d'inserts et feux ouverts, la vente de barbecues avec accessoires, la vente et l’installation de poêles et inserts
au bioéthanol et au gaz naturel ainsi que toute activité liée à la branche.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant

directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ou le développement.»

<i>Déclarations

Le notaire soussigné déclare conformément à l’article 271 (2) de la Loi avoir vérifié et certifie l’existence et la légalité

de tous actes et formalités incombant à la Société Absorbante et du projet de fusion. Le notaire soussigné par ailleurs a
rendu attentif le comparant au rapport d'échange manquant. L’Associé Unique a reconnu expressément que les pièces et
documents énumérés à l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales ont été mis à sa disposition au siège social un
mois au moins avant la date de l’approbation de la fusion et qu’il a pu en prendre connaissance.

<i>Pouvoirs

Le comparant donne pouvoir à tous clercs et employés de l’étude du notaire soussigné, à l’effet de faire dresser et signer

tous actes rectificatifs des présentes concernant des fautes de «frappe».

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

Absorbante ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à environ EUR 2.500 (deux mille cinq cents euros).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date susmentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par noms, prénoms, état et

demeure, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. THINNES, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/31596. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 octobre 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015167576/154.
(150184778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Dred-Real Estate Deutschland GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 198.915.

AUSZUG

Aus den Beschlüssen der alleinigen Gesellschafterin der Gesellschaft vom 28. September 2015 geht hervor, dass das

Mandat von Herrn Matthias Kath-Burdack, geboren am 29. September 1970 in Jena, Deutschland als Geschäftsführer der
Gesellschaft mit Wirkung zum 28. September 2015 beendet wurde.

156575

L

U X E M B O U R G

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 08. Oktober 2015.

<i>Für die Gesellschaft
Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2015167618/15.

(150185227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

CYW Ventures S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 153.757.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015167588/10.

(150185253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

CYW Ventures S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 153.757.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015167589/10.

(150185254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

D&amp;S Asia Green Property Fund II, S.A. SIF-SICAV, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 175.124.

Les comptes annuels au 31 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015167592/10.

(150185296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Cyclon S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 98.470.

Les comptes annuels au 31.03.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015167584/10.

(150185091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

156576


Document Outline

Alexanderplatz D4 Zweite Verwaltungsgesellschaft S.à r.l.

Ararat S.A.

Arden Management S.à r.l.

Aredilux S.à r.l.

Brain Centred Training

BR Empire S.à r.l.

Brolis S.à r.l.

Calico Immobilière S.A.

CBP Lux S.A.

CEHTRA - Consultancy for Environmental and Human Toxicology and Risk Assessment S.A.

CEHTRA - Consultancy for Environmental and Human Toxicology and Risk Assessment S.A.

CEHTRA - Consultancy for Environmental and Human Toxicology and Risk Assessment S.A.

Cellmedia S.A.

Chemical Investments Luxembourg S.A. SPF

Christinvest S.A.

CMC Biologics S.à r.l.

CMC Biologics S.à r.l.

CMP Intermediate Holdings S.à r.l.

CNA Trading Appliances Limited

Cogeart, s.à r.l.

Compagnie du Cap S.à r.l.

Compagnie Financière Européenne S.A. SPF

Compagnie Financière Européenne S.A. SPF

Connected Diet

Cottyn-Kieffer S.à r.l.

CPP Investment Board Europe S.à.r.l.

Criboi S.à r.l.

Crossroads Property Investors S.A.

C.S.N. S.A.

CS Promotions S.A.

Cyclon S.A.

CYW Ventures S.à.r.l.

CYW Ventures S.à.r.l.

Deutsche Oel &amp; Gas S.A.

Deutsche Oel &amp; Gas S.A.

Deutsche Oel &amp; Gas S.A.

Deutsche Real Estate Funds Advisor S.à r.l.

Dred-Real Estate Deutschland GP S.à r.l.

D&amp;S Asia Green Property Fund II, S.A. SIF-SICAV

GCP Europe

Gefco Consulting S.à r.l.

Geninvest Group S.A.

Gerges S.à r.l.

Goodyear

Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.

Gopark SA

GT Global Invest (Lux) S.à r.l.

Holmby Investments S.A.

IFR Lux Sàrl

Immobilière des Crèches

Industrielogistik Entwicklung S.à r.l.

Innovation and Technology Systems G.m.b.H.

Invest Control-Services Administratifs S.à r.l.

Metal Oxides S.A.