This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3204
26 novembre 2015
SOMMAIRE
Cabinet Comptable et Fiscal du Sud S.A. . . . .
153788
Cafina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153788
Cam Luxembourg G.m.b.h. . . . . . . . . . . . . . . .
153789
CAP Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153789
Caribbean Property Investing S.A. . . . . . . . . .
153789
Cela Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153790
Châtelet Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . .
153790
Châtelet Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . .
153791
Cibo Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153791
CIM Vision S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153791
Clamartone S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153791
Congra Software S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153758
Consorts EICH S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153772
Continent 8 (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . .
153772
ContourGlobal Power Holdings S.A. . . . . . . . .
153772
ContourGlobal Spain Holding S.à r.l. . . . . . . .
153787
Cooperstown S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153787
Corum Group International S.à r.l. . . . . . . . . .
153787
Creavicab S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153746
Crescent Point Energy Lux S.à r.l. . . . . . . . . .
153788
CRH Cities Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . .
153746
CSC Computer Sciences Luxembourg SA . . .
153789
Cummingsville Fund S.A., SICAV-SIF . . . . . .
153788
Delegation Management Corporate Sàrl . . . .
153749
Des Glory Investments (Luxembourg), S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153749
DevStrat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153747
DeZaRo S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153748
DIH/HMD Investco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
153776
Domolux Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153778
D.S. Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153746
East-West United Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153792
Empé Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153757
European Hotels and Leisure Sàrl . . . . . . . . . .
153757
Evoleco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153773
EZC Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153773
Fairfield 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153773
FF Investment Luxembourg 2 S.à r.l. . . . . . . .
153774
FFP Capital Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
153774
FLASHiZ S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153781
Formula Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153780
Frides S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153781
Hansteen Germany Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
153790
IEE Management S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153778
IK Small Cap Management . . . . . . . . . . . . . . .
153780
J. Safra Holdings Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
153780
KPS Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153781
PEP ESP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153792
PEP GCO Co-Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
153792
Perform S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153792
Wallis Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153790
153745
L
U X E M B O U R G
Creavicab S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1480 Luxembourg, 8, boulevard Paul Eyschen.
R.C.S. Luxembourg B 180.484.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015165326/10.
(150182174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
CRH Cities Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 198.290.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2015.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2015165327/11.
(150181953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
D.S. Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 14, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 64.802.
L’an deux mille quinze, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «D.S. LUX S.A.» , une société anonyme, régie par le droit
luxembourgeois ayant son siège social au 14, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 64802, constituée suivant acte notarié en date du 27 mai 1998, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 616 du 27 août 1998 (ci-après «la Société»). Les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 10 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueils des Sociétés
et Associations, numéro 441 du 18 février 2015.
L'assemblée est présidée par Madame Chantal Hagen-De Mulder, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Carole Coïs, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Frédérique Mignon, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification du deuxième alinéa l’article 2 des statuts.
2. Modification du premier alinéa de l’article 7 des statuts comme suit: «Les actions sont et resteront nominatives.».
3. Modification du premier alinéa de l’article 18 des statuts relatif à la date de tenue de l’assemblée générale annuelle.
4. Changement de l’exercice social dorénavant fixé du 1
er
janvier au 31 décembre, clôture de l’exercice en cours le 31
décembre 2015, et modification afférente du premier alinéa de l’article 25 des statuts.
5. Divers.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes
ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs
153746
L
U X E M B O U R G
avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des
convocations d'usage.
IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 2 des statuts qui sera désormais conçu comme suit:
Art. 2. (deuxième alinéa). «Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une
décision du conseil d'administration.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 7 des statuts qui sera désormais conçu comme suit:
Art. 7. (premier alinéa). «Les actions sont et resteront nominatives.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le deuxième mercredi
du mois de mai à onze heures (11.00).
L’assemblée générale annuelle se tiendra à cette date pour la première fois en 2016.
En conséquence, l’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 18 des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
Art. 18. (premier alinéa). «L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mercredi du mois de mai à dix heures
(10.00) au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de changer l’exercice social, actuellement allant du 1
er
octobre au 30 septembre, pour le faire courir
désormais du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
A titre exceptionnel, l’exercice en cours commencé le 1
er
octobre 2014 se terminera donc le 31 décembre 2015, soit un
exercice d’une durée totale de 15 (quinze) mois.
L'Assemblée décide de modifier les statuts de la Société pour les conformer aux décisions prises, et de donner par
conséquent la teneur suivante au premier alinéa de l’article 25:
Art. 25. (premier alinéa). «L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci a été clôturée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ceux-ci ont signé le présent acte avec Nous notaire.
Signé: C. HAGEN-DE MULDER, C. COÏS, F. MIGNON, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 septembre 2015. Relation: EAC/2015/22515. Reçu soixante-quinze Euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2015165329/72.
(150182758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
DevStrat S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 180.583.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 octobre 2015.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2015165335/11.
(150182040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
153747
L
U X E M B O U R G
DeZaRo S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 77.081.
Im Jahre zweitausendfünfzehn, den fünfundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jacques CASTEL, mit dem Amtswohnsitz zu Grevenmacher.
Ist erschienen:
Uwe von Zabiensky, geboren am 15. Juli 1961, wohnhaft in D-47506 Neukirchen-Vluyn, Hochstraße 1i
Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersucht folgendes zu beurkunden.
Herr Uwe von Zabiensky erklärt zu handeln in seiner Eigenschaft als einziger Gesellschafter der Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung „ DeZaRo S.à r.l.“, mit Sitz in L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare, gegründet am 31. Juli 2000 gemäß
Urkunde aufgenommen durch den damals in Luxemburg-Bonnevoie amtierenden Notar Maître Léon Thomas genannt Tom
METZLER, veröffentlicht im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) am 28. De-
zember 2000, Nummer 914.
Die Satzungen wurden zuletzt am 4. November 2003 geändert, gemäß notarieller Urkunde des Notars Henri BECK, mit
dem Amtswohnsitz in Echternach, veröffentlicht im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations) am 5. Dezember 2003, Nummer 1296.
Der alleinige Gesellschafter erklärt zu handeln anstelle einer Gesellschafterversammlung der Gesellschaft und ersucht
den amtierenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Tagesordnung:i>
- Bestätigung der Verfügbarkeit aller erforderten Dokumente in den Räumlichkeiten der Gesellschaft gemäß Artikeln
267 und 278 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften sowie geändert.
- Zustimmung der grenzüberschreitenden Verschmelzung zwischen der Gesellschaft DeZaRo Sàrl und der Gesellschaft
EnRec Energie & Recycling GmbH sowie sie im anbei beigelegten Verschmelzungsplan beschrieben ist.
- Zustimmung des Berichts der Geschäftsführung über den Verschmelzungsplan.
- Verschiedenes.
Gemäß dem gemeinsamen Grenzüberschreitenden Verschmelzungsplan aufgenommen am 30. April 2015 durch den
amtierenden Notar, veröffentlicht im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) am 18.
Mai 2015, Nummer 1277, ist die Gesellschaft DeZaRo Sàrl als Übernommene Gesellschaft von der EnRec Energie &
Recycling GmbH (die Übernehmende), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend unter den
Gesetzen Deutschlands und mit eingetragenem Gesellschaftssitz in der Hopfenstrasse 1e, D-47441 Moers, Nordrhein-
Westfalen, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Kleve unter der Nummer HRB 5598 zu
betrachten.
Der alleinige Gesellschafter ersucht den amtierenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter erklärt dass er gemäß Artikel 267 und 279 das Gesellschaftsgesetzes wenigstens einen
Monat vor der außerordentlichen Generalversammlungen die über die Verschmelzung beschließt die folgende Dokumente
zu Verfügung hatte:
- Der Bericht über die Verschmelzung,
- Die Jahresabschlüsse am 31. Dezember der letzten drei rechnungspflichtigen Jahre und
- Den gemeinsamen Verschmelzungsplan.
<i>Zweiter Beschlussi>
Nachdem der alleinige Gesellschafter alle Dokumente aufmerksam geprüft hat, stimmt er der grenzüberschreitenden
Verschmelzung wie sie im Verschmelzungsplan im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations) am 18. Mai 2015, Nummer 1277 veröffentlicht ist zu.
Die Zustimmung des grenzüberschreitenden Verschmelzungsplans, der die Aufnahme der DeZaRo Sàrl von der EnRec
Energie & Recycling GmbH beinhalted, bewirkt die Rechtsgültigkeit dieser Verschmelzung, ab dem Datum der Regis-
trierung beim zuständigen Handelsregisters, der übernehmenden Gesellschaft, in diesem Fall das Amtsgericht KLEVE.
Ab diesem Datum wird die Gesellschaft Energie & Recycling GmbH allein die Tätigkeiten der beiden verschmelzenden
Gesellschaften fortsetzen.
<i>Dritter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter stimmt dem gemeinsamen Verschmelzungsbericht vom 30. April 2015 der Geschäftsfüh-
rung der EnRec Energie & Recycling GmbH und der DeZaRo Sàrl, welcher die Gründe der Verschmelzung, die
153748
L
U X E M B O U R G
voraussichtliche Entwicklung der Aktivitäten, sowie die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen der Fu-
sion darlegt, zu.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort
bekannten Komparent, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: U.v. Zabiensky und J. Castel.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 26 juin 2015. Relation: GAC/2015/5389. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-
€
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): Schlink.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister
sowie zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
Grevenmacher, den 6. Oktober 2015.
J. Castel
<i>Der Notari>
Référence de publication: 2015165336/72.
(150182725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
Delegation Management Corporate Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 180.802.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015165345/10.
(150182399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
Des Glory Investments (Luxembourg), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Aldophe.
R.C.S. Luxembourg B 200.496.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen on the second day of October
Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).
There appeared:
“D. E. Shaw Special Opportunities Fund II, L.P.”, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having
its registered office at c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cay-
man, KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Companies Register of Cayman Islands, under number IT-80292.
Duly represented by Mr Geoffrey AREND, employee, professionally residing in Luxembourg by virtue of a proxy given
under private seal.
The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxyholder and the notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing person, acting in the above capacity, has requested the notary to draw up the articles of incorporation of
a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which is established as follows:
Art. 1. Form. A société à responsabilité limitée (private limited liability company) (the "Company") governed by the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and by these articles of incorporation (the "Articles of
Incorporation"), is hereby established by the founding shareholder.
The Company may at any time have one or several shareholders, as a result of the transfer of shares or the issue of new
shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.
Art. 2. Corporate name. The Company will exist under the corporate name of “DES Glory Investments (Luxembourg),
S.à r.l.”, société à responsabilité limitée.
153749
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Corporate objects. The purposes for which the Company is formed are all operations or transactions pertaining
directly or indirectly to the taking of participating interests in any companies or enterprises in whatever form, as well as
the administration, the management, the control and the development of such participating interests.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities, financial instruments, bonds, treasury bills, equity participation, stocks and patents
of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of con-
tribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents,
realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.
The Company may also enter into the following transactions (it being understood that the Company will not enter into
any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as regulated activity of the
financial sector):
- to grant every assistance and any financial support, whether by way of loans, advances or otherwise to its direct and
indirect subsidiaries affiliates and/or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial and/or
entities belonging to its Group, the Group being referred to as the group of companies which includes the direct and indirect
shareholders of the Company as well as their direct and indirect subsidiaries;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present and future) or by all or any such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its direct and indirect subsidiaries, affiliates and/
or entities belonging to its Group, within the limits of and in accordance with the provisions of Luxembourg laws.
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited
to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial
derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any
Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
The Company may invest in real estate that is exclusively used for investment purposes and not for the own use of the
Company.
In general, the Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever, which
are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the
shareholders, as the case may be.
Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the
manager(s).
The manager(s) may establish subsidiaries and branches in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 6. Capital. The capital is set at TWENTY-FIVE THOUSAND US DOLLARS (USD 25,000.-), and is represented
by ONE THOUSAND (1,000) shares of a par value of TWENTY-FIVE US DOLLARS (USD 25.-) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share
is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the shareholder(s).
The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities
in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of
any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of
doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.
All shares will have equal rights.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.
Art. 7. Changes to the capital. The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the
law regarding commercial companies.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of
the Company and to one vote at the general meetings of the shareholders. If the Company has only one shareholder, the
latter exercises all powers which are granted by law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the sole share-
holder or of the shareholders, as the case may be.
The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever reason,
request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions of the sole shareholder
or of the shareholders, as the case may be.
153750
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
Art. 10. Transfer of shares. Shares are freely transferable among shareholders. The share transfer inter vivos to non
shareholders is subject to the consent of at least seventy-five per cent (75%) of the Company's capital. In case of death of
a shareholder, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of no less than seventy-five per cent (75%)
of the votes of the surviving shareholders. In any event the remaining shareholders have preemption right which has to be
exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non shareholder.
Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.
Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Art. 13. Managers. The Company is managed by one or more manager(s), who need not be shareholders, appointed by
decision of the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, for a limited or an unlimited period.
Managers are eligible for reelection. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the sole
shareholder or of the shareholders at a single majority. Each manager may as well resign.
While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their tenure
and the powers and competence of the manager(s).
The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.
If more than one manager is appointed, the managers shall form a board of managers and articles 14, 15 and 16 shall
apply.
Art. 14. Bureau. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to
attend, his functions will be taken by one of the managers present at the meeting.
The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need
not be members of the board of managers.
Art. 15. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by any manager. The meetings
are held at the place, the day and the hour specified in the notice.
The board of managers may only proceed to business if any two of its members are present or represented. Managers
unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to vote in their name.
Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or email.
Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting. A manager
having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board, shall be obliged to
inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may not take part in the
relevant proceedings of the board.
In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority
of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.
At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall be
informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.
In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference
calls.
Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.
Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.
Art. 16. Minutes - Resolutions. All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by
at least two managers or in circular resolutions as provided in the preceding paragraph. Any power of attorneys will remain
attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman.
The above minutes and resolutions shall be kept in the Company's books at its registered office.
Art. 17. Powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is vested with the broadest
powers to perform all acts of management and disposal in the Company's interest. All powers not expressly reserved by
law or the present articles to shareholders fall within the competence of the board of managers.
Art. 18. Delegation of powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may appoint
agents with specific powers, and revoke such appointment at any time.
Art. 19. Representation of the Company. The Company shall be bound towards third parties by (i) the sole signature of
any of the managers and (ii) the sole signature or the joint signature of any persons to whom the daily management of the
Company has been delegated by the managers, within the limits of such powers.
153751
L
U X E M B O U R G
Art. 20. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting
a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.
Art. 21. Liability of the managers. No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation
in relation to the commitments taken on behalf of the Company. A manager is only liable for the performance of his duties.
Art. 22. Decisions of the shareholders.
1. If the Company has only one shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of
shareholders.
Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915 are not applicable in such a situation.
2. If the Company has more than one shareholder, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting or,
if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which
has been sent by the manager(s) to the shareholders by registered mail.
In the latter case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company, within
fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.
If the Company has more than one shareholder, no decision may validly be taken, unless it is approved by shareholders
representing together at least one half of the corporate capital. All amendments to the Articles of Incorporation have to be
approved by a majority of shareholders representing together at least three quarters of the corporate capital.
Art. 23. Minutes. The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are documented in
writing, recorded in a register and kept by the manager(s) at the registered office of the Company. The powers-ofattorney
are attached to the minutes.
Art. 24. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty first day of December
of each year.
Art. 25. Financial statements - Statutory auditor. Each year, on the last day of the financial year, the accounts are closed,
the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in
accordance with the law. The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or to the
shareholders, as the case may be, for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company
pursuant to article 198 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Should the Company have more than twenty-five shareholders, or otherwise as required by law, the general meeting of
shareholders shall appoint a statutory auditor as provided in article 200 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended. In all other cases, the general meeting of shareholders is free to appoint a statutory auditor or an
external auditor at its discretion.
Art. 26. Allocation of profits. Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this
allocation is no longer mandatory when and as long as the reserve amounts to ten percent of the capital.
The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders, as
the case may be. The manager(s) may decide on the declaration and payment of interim dividends.
Art. 27. Dissolution - liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation
will be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders or not, appointed by the sole shareholder or
by the shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).
Art. 28. Matters not provided. All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in accordance
with applicable laws.
<i>Subscription and paymenti>
All the ONE THOUSAND (1,000) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash as follows:
Shareholder
Subscribed
capital
Number
of shares
D. E. Shaw Special Opportunities Fund II, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 25,000.-
1,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 25,000.-
1,000
The amount of TWENTY FIVE THOUSAND US DOLLARS (USD 25,000.-) is thus as from now being made available
to the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended, have been observed.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year starts on this date and ends on 31 December 2015.
153752
L
U X E M B O U R G
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand euros.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The founding shareholder, representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to adopt the following
resolutions as sole shareholder of the Company pursuant to article 200-2 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended:
I. Resolved to set at two (2) the number of managers and further resolved to appoint the following as managers for an
undetermined period and with immediate effect:
a) Mr Godfrey ABEL, Independent Manager, born on July 2, 1960 in, Brixworth, United Kingdom with professional
address at 30, rue de Crécy, L-1364 Luxembourg; and
b) “D. E. Shaw Special Opportunities Fund II, L.P.”, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands,
United Kingdom, having its registered office at c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue,
George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Companies Register of Cayman Islands,
under number IT-80292.
The managers will be entrusted with the powers set forth in article 19 of the Articles of Incorporation and the Company
is bound towards third parties by the sole signature of any of the managers.
II. The registered office of the Company shall be set at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Whereof, the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, this deed is
worded in English followed by a French version; and that in case of any differences between the English text and the French
text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, that person signed this original deed together with, the undersigned notary.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le deux octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
“D. E. Shaw Special Opportunities Fund II, L.P.”, une société constituée selon le droit des Îles Cayman, ayant son siège
social à c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005,
Îles Cayman, enregistrée auprès du registre des sociétés des Îles Cayman, sous le numéro IT-80292.
dûment représentée par Monsieur Geoffrey AREND, employée privé, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe,
L-1116 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Cette procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins de
formalisation.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'il est constitué comme suit:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par le comparant ci-avant une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission
de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts.
Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de «DES Glory Investments (Luxembourg), S.à r.l.»,
société à responsabilité limitée.
Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes opérations ou transactions permettant directement ou indirectement la prise
de participations dans toute société ou entreprise de quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions et brevets de toute
origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de sou-
scription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente,
de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes (étant entendu qu'elle n'entrera dans aucune opération
qui aurait pour conséquence de l'engager dans une activité considérée comme une activité réglementée du secteur financier):
153753
L
U X E M B O U R G
- apporter toute assistance ou soutien financier, que ce soit sous forme de prêts, d'avances ou autrement à ses filiales
directes et indirectes, aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, aux
sociétés liées ou entités appartenant à son Groupe, c'est-à-dire au groupe de sociétés comprenant les associés directs et
indirects de la Société ainsi que de leurs filiales directes ou indirectes;
- accorder toute garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou parties de ses avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de ses filiales directes et indirectes, des sociétés dans
lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, ou encore des sociétés liées ou entités
appartenant à son Groupe dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment,
par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital ou utiliser
des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments de
dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt de la
Société;
La Société pourra investir dans des opérations immobilières uniquement à des fins d'investissement et non par pour
l'utilisation personnelle de la société.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d'une décision des gérants.
Le(s) gérant(s) pourra(ont) établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à VINGT-CINQ MILLE US DOLLARS (25.000,- USD), représenté par
MILLE (1.000) parts sociales d'une valeur de VINGT-CINQ US DOLLARS (25.- USD) chacune.
Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute part sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés, selon le cas.
La Société pourra, sans limite aucune, accepter tout apport de fonds propres ou toute autre contribution sans émission
de Parts Sociales ou autres titres en contrepartie de l'apport, et pourra créditer ces apports sur un ou plusieurs comptes. Les
décisions quant à l'utilisation de ces comptes devront être prises par l'(les) Associé(s) et seront régies par la Loi de 1915 et
les présents statuts. Afin d'éviter toute équivoque, chacune de ces décisions pourra, sans caractère obligatoire, allouer tout
montant apporté à l'apporteur.
Toutes les parts sociales donnent droit à des droits égaux.
La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues
par l'article 199 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans
les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés. Si la Société comporte
un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des associés.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou de
la collectivité des associés, selon le cas.
Les créanciers et successeurs de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons
que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur les
actifs et documents de la Société ou qu'un inventaire de l'actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l'exercice de leurs
droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant
le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun désigné parmi eux ou en dehors d'eux.
Art. 10. Cession de parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées
entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute
153754
L
U X E M B O U R G
hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du
refus de cession à un non-associé.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement
similaire affectant l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés par
une décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée déterminée ou
indéterminée.
Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés
pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement dé-
missionner de ses fonctions.
Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la durée
de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).
L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Si plus d'un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance et les articles 14, 15 et 16 trouveront à
s'appliquer.
Art. 14. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses
fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d'autres mandataires sociaux, associés ou non associés.
Art. 15. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux
membres du conseil.
Les réunions sont tenues à l'endroit, au jour et à l'heure mentionnés dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsqu'au moins deux de ses membres sont présents ou représentés.
Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et voter
en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion.
Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l'approbation du conseil doit en informer le
conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations
du conseil.
En cas d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des autres
membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.
A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans
lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.
Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l'ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors
d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs écrits
séparés ayant le même contenu.
Art. 16. Procès verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des procès
verbaux signés par au moins deux gérants ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l'alinéa qui précède. Les
procurations resteront annexées aux procès verbaux. Les copies et extraits de ces procès verbaux seront signés par le
président.
Ces procès verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.
Art. 17. Pouvoirs. Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dispose des pouvoirs les plus
étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont
pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.
Art. 18. Délégation de pouvoirs. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut/peuvent nommer
des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.
Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par (i) la seule signature d'un des gérants
et (ii) par la signature individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui les pouvoirs de signature ont été délégués par le
conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 20. Événements affectant la gérance. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire
affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution
de la Société.
153755
L
U X E M B O U R G
Art. 21. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution
de son mandat.
Art. 22. Décisions de l'associé ou des associés.
1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité
des associés.
Dans ce cas, les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
2. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale ou, s'il y a moins
de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) gérant(s) aux associés
par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de
quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
En cas de pluralité d'associés, aucune décision n'est valablement prise si elle n'est pas approuvée par des associés
représentant ensemble au moins la moitié du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée par
une majorité des associés représentant ensemble au moins les trois quarts du capital social.
Art. 23. Procès-verbaux. Les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas, seront docu-
mentées par écrit et consignées dans un registre tenu par le(s) gérant(s) au siège social de la Société. Les procurations y
seront annexées.
Art. 24. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 25. Bilan - Conseil de surveillance. Chaque année, le dernier jour de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et le
gérant dresse un inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la
loi. Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des associés.
Tout associé, ou son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents comptables,
conformément à l'article 198 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Lorsque la société a plus de vingt-cinq associés, ou dans les autres cas prévus par la loi, l'assemblée générale des associés
doit nommer un conseil de surveillance comme prévu à l'article 200 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée. Dans tous les autres cas, l'assemblée générale des associés est libre, à sa discrétion de nommer un conseil
de surveillance ou un réviseur d'entreprises.
Art. 26. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la
constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale représente dix pour cent (10%) du capital social.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés. Les gérant
(s) pourra (pourront) procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 27. Dissolution - Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce
soit, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 28. Dispositions générales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Souscription et paiementi>
Toutes les MILLE (1.000) parts ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire comme suit:
Associé
Capital souscrit Nombre
de parts
sociales
D. E. Shaw Special Opportunities Fund II, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000,- USD
1.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000,- USD
1.000
La somme de VINGT-CINQ MILLE US DOLLARS (25.000,- USD) se trouve partant dès maintenant à la disposition
de la Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2015.
153756
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à mille euros.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital souscrit, a immédiatement pris les résolutions suivantes comme
associé unique de la Société conformément à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée:
I Décide de fixer à deux (2), le nombre de gérants et décide par ailleurs de nommer comme gérants pour une durée
indéterminée et avec effet immédiat.
a) Monsieur Godfrey ABEL, gérant indépendant, né le 2 juillet 1960 à Brixworth, Royaume Uni, ayant son adresse
professionnelle au 30, rue de Crécy, L-1364 Luxembourg; et
b) “D. E. Shaw Special Opportunities Fund II, L.P.”, une société constituée selon le droit des Îles Cayman, Royaume
Unis, ayant son siège social à c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand
Cayman, KY1-9005, Îles Cayman, enregistrée auprès du registre des sociétés des Îles Cayman, sous le numéro IT-80292.
Les gérants se voient confier les pouvoirs prévus à l'article 19 des statuts de la Société et la société est valablement
engagée par la seule signature d'un des gérants.
II Le siège social de la société est fixé au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous le notaire le présent acte.
Signé: G. AREND, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 6 octobre 2015. Relation: EAC/2015/23146. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2015165349/429.
(150182427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
Empé Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6350 Dillingen, 3, rue de la Sûre.
R.C.S. Luxembourg B 83.215.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>L'administrateuri>
Référence de publication: 2015165367/11.
(150181866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
European Hotels and Leisure Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 113.810.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015165382/10.
(150182253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
153757
L
U X E M B O U R G
Congra Software S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 11.358.550,00.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 162.896.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third of September.
Before Us Maître Alex WEBER, notary, residing in Bascharage (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held
an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of Congra Software S.à r.l., a Luxembourg “société
à responsabilité limitée”, previously known as Hybrid Europe Software S.A. (société anonyme), having a share capital of
three hundred seventy five thousand Euro (EUR 375,000.-), with its registered office at L-1255 Luxembourg, 48 rue de
Bragance, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 162.896 (the “Company”). The
Company has been incorporated as a société anonyme on 3 August 2011, pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT,
notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, number 2542 of 20 October 2011 and its Articles of Asso-
ciation have been amended pursuant to a deed dated 23 May 2012, of Maître Cosita DELVAUX, notary then residing in
Redange-sur-Attert published in the Mémorial C, number 1648 of 23 May 2012 and, subsequently, pursuant to a deed of
the undersigned notary dated 4 August 2015 following which the Company was transformed in a société à responsabilité
limitée.
The Meeting is chaired by Guido Van der Schueren, professionally residing at 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg
(the “Chairman”), who appoints Joachim Van Hemelen, professionally residing at de Burburestraat 6-8, 2000 Antwerp,
Belgium as secretary (the “Secretary”).
The Meeting elects Ingrid Hoolants, professionally residing in 80 rue des Romains, L-8041 Strassen, Luxembourg as
scrutineer (the “Scrutineer”).
The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the “Bureau”.
The shareholders of the Company present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated
on an attendance list, which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of
the shareholders and the members of the Bureau.
The proxies from the shareholders of the Company represented at the Meeting, after having been signed “ne varietur”
by the appearing persons and the undersigned notary, shall also remain attached to the present deed to be filed with such
deed with the registration authorities.
The Bureau having thus been validly constituted, the Chairman requests the notary to record:
I. That it appears from the attendance list that all of the 750.- (seven hundred and fifty) shares, having a par value of
five hundred Euro (EUR 500.-) each, representing the entire subscribed share capital of the Company are present or duly
represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on the agenda hereinafter repro-
duced, the partners represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
(1) Split of the shares issued by the Company pursuant to a split factor determined at hundred for one (100-for-1), thereby
creating hundred (100) shares for every existing share;
(2) Elimination of the nominal value of the shares issued by the Company and all and any references to the nominal
value of the shares from the Articles of Association;
(3) Increase of the share capital of the Company by an amount of ten million nine hundred and eighty-three thousand
five hundred and fifty Euro (EUR 10,983,550.-) by issuing two hundred and seventy-seven thousand two hundred and
thirty-four (277,234) new ordinary shares without nominal value (the “Increase of Capital”), so as to raise it from its current
amount of three hundred and seventy-five thousand Euro (EUR 375,000.-) to eleven million three hundred and fifty-eight
thousand five hundred and fifty Euro (EUR 11,358,550.-).
The Increase of Capital will be effected by the issuance of new ordinary shares without nominal value as follows:
(a) issuance of fifty thousand and seven hundred and thirty-five (50,735) new ordinary shares without nominal value
(the “New Shares 1”), in consideration for the Contribution 1 (as defined hereafter);
(b) issuance of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) new ordinary shares without nominal
value (the “New Shares 2”), in consideration for the Contribution 2 (as defined hereafter);
(c) issuance of thirty-six thousand nine hundred and nine (36,909) new ordinary shares without nominal value (the “New
Shares 3”), in consideration for the Contribution 3 (as defined hereafter);
(d) issuance of eighty thousand eight hundred and seventy-nine (80,879) new ordinary shares without nominal value
(the “New Shares 4”), in consideration for the Contribution 4 (as defined hereafter)
(4) Insertion in the Articles of Association of the Company of provisions regarding the issuance of “profit certificates”;
153758
L
U X E M B O U R G
(5) Amendment to the “Drag-Along Clause” as set out in Article 7 of the Articles of Association of the Company, so as
to increase the relevant threshold from thirty percent (30%) to fifty-one (51%);
(6) Subsequent amendments to the Articles of Association of the Company;
(7) Miscellaneous.
III. That the Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to split the shares issued by the Company pursuant to a split factor determined at hundred for one
(100-for-1), thereby creating hundred (100) shares out of every existing share, increasing the total amount of shares from
seven hundred and fifty (750) to seventy-five thousand (75,000).
Pursuant to this resolution, the Articles of Association of the Company shall be amended as detailed hereafter under the
sixth resolution.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to eliminate the nominal value of the shares issued by the Company and all and any references to
the nominal value of the shares from the Articles of Association. Pursuant to this resolution, the Articles of Association of
the Company shall be amended as detailed hereafter under the sixth resolution.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to proceed with the Increase of Capital, and therefore to issue the New Shares 1, the New Shares
2, the New Shares 3 and the New Shares 4, together defined as the “New Shares”.
The New Shares are subscribed and fully paid up by way of the following contributions in kind:
(A) Contribution in kind of twenty-seven thousand (27,000.-) shares without a nominal value issued by NiXPS NV, a
limited liability company (“naamloze vennootschap”) incorporated and existing under Belgian law, having a share capital
of two hundred and seventy thousand Euro (EUR 270,000.-), with its registered office at Guldensporenpark 18, 9820
Merelbeke, Belgium, registered with the Crossroads Bank for Enterprises (“Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen
- KBO”) under number 0889.922.639 (“NiXPS”), representing the entire share capital of NiXPS, transferred and accepted
by the Company at a value of two million and three hundred thousand Euro (EUR 2,300,000.-), in exchange for fifty
thousand seven hundred and thirty-five (50,735) New Shares 1 as detailed below:
- sixteen thousand nine hundred and twelve (16,912) out of fifty thousand seven hundred and thirty-five (50,735) New
Shares 1 are subscribed and fully paid up by De Roeck Software Engineering BVBA, a closed limited liability company
(“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”) incorporated and existing under Belgian law, having a share
capital of eighteen thousand six hundred Euro (EUR 18,600.-), with its registered office at New-Yorkstraat 2/N, 9000
Ghent, Belgium, registered with the Crossroads Bank for Enterprises (“Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen -
KBO”) under number 0471.372.686, by the contribution in kind of nine thousand (9,000) shares issued by NiXPS,
transferred and accepted by the Company at a value of seven hundred and sixty-six thousand six hundred eightytwo Euro
(EUR 766,682.-);
- thirty-three thousand eight hundred and twenty-three (33,823) New Shares 1 out of fifty thousand seven hundred and
thirty- five (50,735) New Shares 1 are subscribed and fully paid up by Nexus Investments NV, a limited liability company
(“naamloze vennootschap”) incorporated and existing under Belgian law, having a share capital of eighty-five thousand
Euro (EUR 85,000.-), with its registered office at Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem, Belgium, registered with the Crossroads
Bank for Enterprises (“Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen - KBO”) under number 0810.044.525, by the con-
tribution in kind of eighteen thousand (18,000) shares issued by NiXPS, transferred to and accepted by the Company at a
value of one million five hundred and thirty-three thousand three hundred and eighteen Euro (EUR 1,533,318.-),
all of the above, the “Contribution 1”;
(B) Contribution in kind of ninety-eight point five seven one percent (98,5710%) of the partnership interests in Hybrid
Integration LLC, a partnership organized and existing under the law of the state of Pennsylvania (United States of America),
with its registered office at 1709 Langhorne Newtown Road Suite 6, Langhorne, PA 19047, United States of America,
registered with the Pennsylvania Department of State under number 579056 (“Hybrid US”), representing ninety-eight point
five seven one percent (98,5710%) of the capital of Hybrid US, transferred to and accepted by the Company at a value of
four million nine hundred and twenty-eight thousand five hundred and fifty Euro (EUR 4,928,550.-), in exchange for issuing
one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New Shares 2 as detailed below:
(i) seven thousand one hundred and sixteen (7,116) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven
(108,711) New Shares 2 are subscribed and fully paid by Bucks Ventures, a Limited Liability Corporation incorporated
and existing under Pennsylvania law, with its registered office at 1558 River Road, New Hope, PA 18938, United States
of America, Employer identification Number EIN: 27-4194269, by the contribution in kind of its participation in Hybrid
US, representing 6,45% of the partnership interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of
three hundred and twenty-two thousand five hundred and ninety-three Euro (EUR 322,593.-);
(ii) seven thousand one hundred and ninety (7,190) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven
(108,711) New Shares 2 are subscribed and fully paid up by Mr. Naren Mehta, American citizen, born in Calcutta (India)
153759
L
U X E M B O U R G
on October 29
th
, 1954, residing at 41 Greenbriar Lane, Newtown, PA 18940, United States of America, SOCIAL SE-
CURITY NUMBER 170-62-2155, by the contribution in kind of his participation in Hybrid US, representing 6,52% of the
partnership interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of three hundred and twenty-five
thousand nine-hundred and forty-seven Euro (EUR 325,947.-);
(iii) twelve thousand eight hundred and twenty-five (12,825) out of one hundred and eight thousand seven hundred and
eleven (108,711) New Shares 2 are subscribed and fully paid up by Mr. Michael A. Rottenborn, American citizen, born in
Waynesboro,Virginia (USA) on June 5
th
, 1967, residing at 431 Ramsey Road, Yardley, PA 19067, United States of
America, SOCIAL SECURITY NUMBER 226-90-2907, by the contribution in kind of his participation in Hybrid US,
representing 11,63% of the partnership interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of five
hundred and eighty-one thousand four hundred and one Euro (EUR 581,401.-);
(iv) four hundred and four (404) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New Shares
2 are subscribed and fully paid up by Mr. Andy Balto, American citizen, born in Baltimore, Maryland (USA) on August
26
th
, 1967, residing at 2500 Rochelle Drive, Fallston, MD 21047, United States of America, SOCIAL SECURITY
NUMBER 220-78-6914, by the contribution in kind of his participation in Hybrid US, representing 0,37% of the partnership
interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of eighteen thousand three hundred and fifteen
Euro (EUR 18,315.-);
(v) four hundred and four (404) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New Shares
2 are subscribed and fully paid up by Ms. Anne Balto, American citizen, born in Waynesboro, Virginia (USA) on April 4
th
, 1971, residing at 2500 Rochelle Drive, Fallston, MD 21047, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER
226-90-2936, by the contribution in kind of her participation in Hybrid US, representing 0,37% of the partnership interests,
which is transferred to and accepted by the Company at a value of eighteen thousand three hundred and fifteen Euro (EUR
18,315.-);
(vi) four hundred and four (404) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New Shares
2 are subscribed and fully paid up by Mr. Joseph Demharter, American citizen, born in Natrona Heights, Pennsylvania
(USA) on September 2
nd
, 1947, residing at 5 Carriage Path, Chadds Ford, PA 19317, United States of America, SOCIAL
SECURITY NUMBER 168-38-9195, by the contribution in kind of his participation in Hybrid US, representing 0,37% of
the partnership interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of eighteen thousand three hundred
and fifteen Euro (EUR 18,315.-);
(vii) four thousand and forty-two (4,042) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711)
New Shares 2 are subscribed and fully paid up by Kielvest 3 LLC, a Limited Liability Corporation incorporated and existing
under Delaware law, with its registered office at 3411 Silverside Road, Hanby Bldg. #101, Wilmington, DE 19810, United
States of America, Tax Identification Number TIN: 45-0585558, by the contribution in kind of its participation in Hybrid
US, representing 3,67 % of the partnership interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of
one hundred and eighty-three thousand two hundred and thirty-eight Euro (EUR 183,238.-);
(viii) four hundred and four (404) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New
Shares 2 are subscribed and fully paid up by Mr. Bharat Mehta, American citizen, born in Calcutta (India) on September
24
th
, 1952, residing at 4320 Tiffany Drive, Easton, PA 18045, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER
173-60-6561, by the contribution in kind of his participation in Hybrid US, representing 0,37% of the partnership interests,
which is transferred to and accepted by the Company at a value of eighteen thousand three hundred and fifteen Euro (EUR
18,315.-);
(ix) four hundred and four (404) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New Shares
2 are subscribed and fully paid up by The Juan A. Proano Revocable Trust, with address at 9 Bartons Mill Drive, Washington
Crossing, PA 18977, United States of America, by the contribution in kind of its participation in Hybrid US, representing
0,37% of the partnership interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of eighteen thousand
three hundred and fifteen Euro (EUR 18,315.-);
(x) four hundred and four (404) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New Shares
2 are subscribed and fully paid up by The Luisa A. Proano Revocable Trust, with address at 9 Bartons Mill Drive, Wash-
ington Crossing, PA 18977, United States of America, by the contribution in kind of its participation in Hybrid US,
representing 0,37% of the partnership interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of eighteen
thousand three hundred and fifteen Euro (EUR 18,315.-);
(xi) four hundred and four (404) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New Shares
2 are subscribed and fully paid up by Mr. John Rottenborn, American citizen, born in Waynesboro, Virginia (USA) on
September 1
st
, 1981, residing at One 26
th
St. SW, Roanoke, VA 24014, United States of America, SOCIAL SECURITY
NUMBER 224-23-3091, by the contribution in kind of his participation in Hybrid US, representing 0,37% of the partnership
interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of eighteen thousand three hundred and fifteen
Euro (EUR 18,315.-);
(xii) seven hundred and forty-nine (749) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711)
New Shares 2 are subscribed and fully paid up by Mr. Edward Sager, American citizen, born in Newark, New Jersey (USA)
on May 10
th
, 1947, residing at 570 Nottingham Drive, Yardley, PA 19067, United States of America, SOCIAL SECURITY
153760
L
U X E M B O U R G
NUMBER 144-40-9431, by the contribution in kind of his participation in Hybrid US , representing 0,68% of the partnership
interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of thirty-three thousand nine hundred and fifty-
five Euro (EUR 33,955.-);
(xiii) sixty-four thousand three hundred and thirty-two (64,332) out of one hundred and eight thousand seven hundred
and eleven (108,711) New Shares 2 are subscribed and fully paid up by Parana Management Corporation BVBA, a closed
limited liability company (“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”) incorporated and existing under Bel-
gian law, having a share capital of eighteen thousand five hundred and fifty euro (18,550.-), with its registered office at
Zuylenveld 10, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgium, registered with the Crossroads Bank for Enterprises (“Kruispuntbank
van Belgische Ondernemingen - KBO”) under number 0862.414.528, by the contribution in kind of its participation in
Hybrid US, representing 58,33% of the partnership interests, which is transferred to and accepted by the Company at a
value of two million nine hundred and sixteen thousand six hundred and ninety-two Euro (EUR 2,916,692.-);
(xiv) three hundred and seventy two (372) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711)
New Shares 2 are subscribed and fully paid up by Big Friend NV, a limited liability company (“naamloze vennootschap”),
incorporated and existing under Belgian Law, having a share capital of nine hundred and twelve thousand Euro (EUR
912,000.-), with its registered offices at Kustlaan 15, 8300 Knokke-Heist, Belgium, registered with the Crossroads Bank
for Enterprises (“Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen - KBO”) under number 0431.535.578, by the contribution
in kind of its participation in Hybrid US, representing 0,34% of the partnership interests, which is transferred to and accepted
by the Company at a value of sixteen thousand eight hundred and sixty-four Euro (EUR 16,864.-);
(xv) seventy-four (74) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New Shares 2 are
subscribed and fully paid up by Mr. Stéphane Denis Georges, born in Saint-Avold, France on 27 December 1971, residing
in 13 rue de la Chasse, 67115 Plobsheim, France, by the contribution in kind of his participation in Hybrid US, representing
0,07% of the partnership interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of three thousand three
hundred and fifty-five Euro (EUR 3,355.-);
(xvi) eight hundred and ninety-four (894) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711)
New Shares 2 are subscribed and fully paid up by Mr. Christopher Martin Graf, born in Offenburg, Germany, on 30 April
1967, residing at Silberbachstrasse 27, 79100 Freiburg im Breisgau, Germany, by the contribution in kind of his partici-
pation in Hybrid US, representing 0,81% of the partnership interests, which is transferred to and accepted by the Company
at a value of forty thousand five hundred and twenty eight Euro (EUR 40,528.-);
(xvii) seventy-four (74) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New Shares 2 are
subscribed and fully paid up by Ms. Hannah Suzanna E. Van der Schueren, born in Ghent, Belgium on 28 April 1987,
residing in Zuylenveld 10, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgium, by the contribution in kind of her participation in Hybrid
US, representing 0,07% of the partnership interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of
three thousand three hundred and fifty-five Euro (EUR 3,355.-);
(xviii) seventy-four (74) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New Shares 2 are
subscribed and fully paid up by Ms. Sarah Julienne G. Van der Schueren, born in Ghent, Belgium on 31 October 1983,
residing in Koperstraat 14 / bus 3, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgium, by the contribution in kind of her participation in
Hybrid US, representing 0,07% of the partnership interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value
of three thousand three hundred and fifty-five Euro (EUR 3,355.-);
(xix) seventy-four (74) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New Shares 2 are
subscribed and fully paid up by Mr. Tom Simon Julien Van der Schueren, born in Sint-Amandsberg, Belgium on 29 April
1975, residing in Varendries 12, 9820 Merelbeke, Belgium, by the contribution in kind of his participation in Hybrid US,
representing 0,07% of the partnership interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of three
thousand three hundred and fifty-five Euro (EUR 3,355.-);
(xx) one thousand three hundred and twenty-eight (1,328) out of one hundred and eight thousand seven hundred and
eleven (108,711) New Shares 2 are subscribed and fully paid up by Mr. Michael Agness, American citizen, born in Camden,
New Jersey (USA) on August 18
th
, 1972, residing at 14 Pine Street, Kearny, NJ 07032, United States of America, SOCIAL
SECURITY NUMBER 143-76-8413 by the contribution in kind of his participation in Hybrid US, representing 1,20% of
the partnership interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of sixty thousand two hundred
and three Euro (EUR 60,203.-);
(xxi) one hundred and sixty-nine (169) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New
Shares 2 are subscribed and fully paid up by Mr. David Bolduc, American citizen, born in Peekskill, New York (USA) on
July 30
th
, 1976, residing at 2035 Pemberton St, Philadelphia, PA 19146, United States of America, SOCIAL SECURITY
NUMBER 052-62-4447, by the contribution in kind of his participation in Hybrid US, representing 0,15% of the partnership
interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of seven thousand six hundred and sixty-one Euro
(EUR 7,661.-);
(xxii) seventy-four (74) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New Shares 2 are
subscribed and fully paid up by Mr. Rob Wexler, American citizen, born in Wynnewood, Pennsylvania (USA) on August
5
th
, 1957, residing at 870 Skyline Dr., Erdenheim, PA 19038, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER
206-50-4262, by the contribution in kind of his participation in Hybrid US, representing 0,07% of the partnership interests,
153761
L
U X E M B O U R G
which is transferred to and accepted by the Company at a value of three thousand three hundred and fifty-five Euro (EUR
3,355.-);
(xxiii) two hundred twenty-five (225) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New
Shares 2 are subscribed and fully paid up by Mr. Ryan Godfrey, American citizen, born in Provo, Utah (USA) on August
27
th
, 1971, residing at 4811 Beaumont Ave., Philadelphia, PA 19143, United States of America, SOCIAL SECURITY
NUMBER 535-96-2725 by the contribution in kind of his participation in Hybrid US, representing 0,20% of the partnership
interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of ten thousand two hundred Euro (EUR 10,200.-);
(xxiv) fifty-six (56) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New Shares 2 are
subscribed and fully paid up by Mr. Ehrich Grein, American citizen, born in Springfield, Massachusets (USA) on October
1
st
, 1966, residing at 2625 Hirst Terrace, Havertown, PA 19083, United States of America, SOCIAL SECURITY NUM-
BER 044-70-4733, by the contribution in kind of his participation in Hybrid US, representing 0,05% of the partnership
interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of two thousand five hundred and thirty-nine
Euro (EUR 2,539.-);
(xxv) one thousand two hundred and fifty-three (1,253) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven
(108,711) New Shares 2 are subscribed and fully paid up by Mr. Oleh Kornyev, American citizen, born in Chernovtsy
(Ukraine) on October 11
th
, 1979, residing at 111 Windy Knoll Drive, Richboro, PA 18954, United States of America,
SOCIAL SECURITY NUMBER 197-82-4284, by the contribution in kind of his participation in Hybrid US, representing
1,14% of the partnership interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of fifty-six thousand
eight hundred and three Euro (EUR 56,803.-);
(xxvi) one hundred and forty (140) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New
Shares 2 are subscribed and fully paid up by Mr. James Lawlor, American citizen, born in Media, Pennsylvania (USA) on
April 10
th
, 1967, residing at 113 Cornell Ave., Claremont, CA 91711, United States of America, SOCIAL SECURITY
NUMBER 159-52-6818, by the contribution in kind of his participation in Hybrid US, representing 0,13% of the partnership
interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of six thousand three hundred and forty-seven
Euro (EUR 6,347.-);
(xxvii) one hundred and twelve (112) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New
Shares 2 are subscribed and fully paid up by Mr. Robb Lutton, American citizen, born in Ann Arbor, Michigan (USA) on
January 18
th
, 1950, residing at 7807 Louise Lane, Glenside, PA 19038, United States of America, SOCIAL SECURITY
NUMBER 536-54-5959, by the contribution in kind of his participation in Hybrid US, representing 0,10% of the partnership
interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of five thousand and seventy-seven Euro (EUR
5,077.-);
(xxviii) two thousand two hundred and forty-eight (2,248) out of one hundred and eight thousand seven hundred and
eleven (108,711) New Shares 2 are subscribed and fully paid up by Mr. Alexander McKnight, American citizen, born in
Philadelphia, Pennsylvania (USA) on April 3
rd
, 1965, residing at 816 Stoneybrook Drive, W. Norriton, PA 19403, United
States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER 223-23-1200, by the contribution in kind of his participation in Hybrid
US, representing 2,04% of the partnership interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of one
hundred and one thousand nine hundred and ten Euro (EUR 101,910.-);
(xxix) two thousand two hundred and forty-eight (2,248) out of one hundred and eight thousand seven hundred and
eleven (108,711) New Shares 2 are subscribed and fully paid up by Mr. George McKnight, American citizen, born in Upper
Darby, Pennsylvania (USA) on January 7
th
, 1967 , residing at 821 Forrest Street, Lansdale, PA 19446, United States of
America, SOCIAL SECURITY NUMBER 223-23-1199, by the contribution in kind of his participation in Hybrid US,
representing 2,04% of the partnership interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of one
hundred and one thousand nine hundred and ten Euro (EUR 101,910.-);
(xxx) one hundred forty (140) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New Shares
2 are subscribed and fully paid up by Mr. Brian Meyer, American citizen, born in Winterset, Indiana (USA) on September
15
th
, 1968, residing at 6311 Stanmore Ct, Johnston, IA 50131, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER
484-86-9069, by the contribution in kind of his participation in Hybrid US, representing 0,13% of the partnership interests,
which is transferred to and accepted by the Company at a value of six thousand three hundred and forty-seven Euro (EUR
6,347.-);
(xxxi) seventy-four (74) out of one hundred and eight thousand seven hundred and eleven (108,711) New Shares 2 are
subscribed and fully paid up by Ms. Chelsea Paul, American citizen, born in Lower Merion, Pennsylvania (USA) on October
23
rd
, 1968, residing at 1700 Bulter Pike, Conshohocken, PA 19428, United States of America, SOCIAL SECURITY
NUMBER 173-70-4806, by the contribution in kind of her participation in Hybrid US, representing 0,07% of the partnership
interests, which is transferred to and accepted by the Company at a value of three thousand three hundred and fifty-five
Euro (EUR 3,355.-) ,
all of the above, the “Contribution 2”;
(C) Contribution in kind of the following claims arising from the subordinated bonds issued by the Company on 9 April
2015 for a global principal value of one million two hundred and fifty-five thousand Euro (EUR 1,255,000.-) (the “Sub-
153762
L
U X E M B O U R G
ordinated Bonds”), which are transferred to and accepted by the Company at a value of one million two hundred and fifty-
five thousand Euro (EUR 1,255,000.-), in exchange for issuing thirty-six thousand nine hundred and nine (36,909) New
Shares 3, as detailed below:
(i) ten thousand one hundred and forty-four (10,144) out of thirty-six thousand nine hundred and nine (36,909) New
Shares 3 are subscribed and fully paid up by Parana Management Corporation BVBA, a closed limited liability company
(“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”) incorporated and existing under Belgian law, having a share
capital of eighteen thousand five hundred and fifty euro (18,550.-), with its registered office at Zuylenveld 10, 9830 Sint-
Martens-Latem, Belgium, registered with the Crossroads Bank (“Kruispuntbank voor Belgische Ondernemingen - KBO”)
under number 0862.414.528, by the contribution in kind of a claim arising from three hundred and forty five (345.-)
Subordinated Bonds, equal to 27,49% of the nominal value of the Subordinated Bonds, valued at three hundred and forty-
five thousand Euro (EUR 345,000.-);
(ii) two thousand nine hundred and forty-one (2,941) out of thirty-six thousand nine hundred and nine (36,909) New
Shares 3 are subscribed and fully paid up by Mr. Christopher Martin Graf, German citizen, born in Offenburg, Germany,
on April 30
th
, 1967, residing at Silberbachstrasse 27, 79100 Freiburg im Breisgau, Germany, by the contribution in kind
of a claim arising from one hundred (100.-) Subordinated Bonds, equal to 7.97% of the nominal value of the Subordinated
Bonds valued at one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-);
(iii) four thousand four hundred and twelve (4,412) out of thirty-six thousand nine hundred and nine (36,909) New
Shares 3 are subscribed and fully paid up by Big Friend NV, a limited liability company (“naamloze vennootschap”),
incorporated and existing under Belgian Law, having a share capital of nine hundred and twelve thousand Euro (EUR
912,000.-), with its registered offices at Kustlaan 15, 8300 Knokke-Heist, Belgium, registered with the Crossroads Bank
(“Kruispuntbank voor Belgische Ondernemingen - KBO”) under number 0431.535.578, by the contribution in kind of a
claim arising from one hundred and fifty (150.-) Subordinated Bonds, equal to 11.95% of the nominal value of the Sub-
ordinated Bonds valued at one hundred and fifty thousand Euro (EUR 150,000.-);
(iv) seven thousand three hundred and fifty-three (7.353) out of thirty-six thousand nine hundred and nine (36,909) New
Shares 3 are subscribed and fully paid up by Brand Quadergy NV, a limited liability company (“naamloze vennootschap”)
incorporated and existing under Belgian law, having a share capital of one hundred and fifty thousand Euro (EUR 150,000.-),
with its registered office at Blancefloerlaan 179-A, 2050 Antwerp, Belgium, registered with the Crossroads Bank (“Kruis-
puntbank voor Belgische Ondernemingen - KBO”) under number 0423.174.079, by the contribution in kind of a claim
arising from two hundred and fifty (250.-) Subordinated Bonds, equal to 19.92% of the nominal value of the Subordinated
Bonds, valued at two hundred and fifty thousand Euro (EUR 250,000.-);
(v) one thousand six hundred and eighteen (1,618) out of thirty-six thousand nine hundred and nine (36,909) New Shares
3 are subscribed and fully paid up by Mr. Pierre Victor M. Cottenie, born in Ghent, Belgium on September 21
st
, 1954,
residing in Driesstraat 54, 9090 Melle, Belgium, by the contribution in kind of a claim arising from fifty-five (55.-) Sub-
ordinated Bonds, equal to 4.38% of the nominal value of the Subordinated Bonds, valued at fifty-five thousand Euro (EUR
55,000.-);
(vi) two thousand two hundred and six (2,206) out of thirty-six thousand nine hundred and nine (36,909) New Shares
3 are subscribed and fully paid up by Mr. Patrick Albert M. Coussement, born in Menen, Belgium on November 15
th
,
1964, residing in Nieuwe Weg 10, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgium, by the contribution in kind of a claim arising from
seventy-five (75.-) Subordinated Bonds, equal to 5.98% of the nominal value of the Subordinated Bonds, valued at seventy-
five thousand Euro (EUR 75,000.-);
(vii) seven thousand three hundred and fifty-three (7,353) out of thirty-six thousand nine hundred and nine (36,909)
New Shares 3 are subscribed and fully paid up by Keyware Smart Card Division NV, a limited liability company (“naamloze
vennootschap”) incorporated and existing under Belgian law, having a share capital of two million three hundred thousand
(2,300,000.-), with its registered office at Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem, Belgium, registered with the KBO under number
0449.832.253, by the contribution in kind of a claim arising from two hundred and fifty (250,-) Subordinated Bonds, equal
to 19.92% of the nominal value of the Subordinated Bonds, valued at two hundred and fifty thousand Euro (EUR 250,000.-);
(viii) eight hundred and eighty-two (882) out of thirty-six thousand nine hundred and nine (36,909) New Shares 3 are
subscribed and fully paid up by Portolani NV, a limited liability company (“naamloze vennootschap”) incorporated and
existing under Belgian law, having a share capital of two hundred and ten thousand Euro (EUR 210,000.-), with its registered
office at de Burburestraat 6-8, 2000 Antwerp, Belgium, registered with the KBO under number 0877.600.669, by the
contribution in kind of a claim arising from thirty (30,-) Subordinated Bonds, equal to 2.39% of the nominal value of the
Subordinated Bonds, valued at thirty thousand Euro (EUR 30,000.-).
(D) Contribution in kind of a claim of two million and five hundred thousand Euro (EUR 2,500,000) arising from a
portion of the loans granted by Parana Management Corporation BVBA, as detailed before, to the Company (the “Con-
tribution 4”) in exchange for issuing eighty thousand eight hundred and seventy-nine (80,879) shares 4. The New Shares
4 are subscribed and fully paid up by Parana Management Corporation BVBA by the contribution in kind of the Contribution
4, which is transferred to and accepted by the Company at a value of two million five hundred thousand Euro (EUR
2,500,000).
With regards to the Contribution 1, the Contribution 2, the Contribution 3 and the Contribution 4, each contributor listed
above declares that he/she/it is the unrestricted owner of the respective contributed assets, which are freely transferable to
153763
L
U X E M B O U R G
the Company and free of any encumbrances (pre-emption right, charge, lien, security interest, pledge, guarantee, usufruct
and purchase option by virtue of which a third party could request that the contributed assets or part of them be transferred
to it) and all further formalities in the country of location of the contributed assets shall be completed in order to duly carry
out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and towards any third party.
Proof of the existence, the value and the free transferability of the assets contributed to the Company pursuant to the
Contribution 1, the Contribution 2, the Contribution 3 and the Contribution 4 have been given to the undersigned notary
by the declarations signed from each contributor listed above and by the Company in respect of all assets contributed under
the Contribution 1, the Contribution 2, the Contribution 3 and the Contribution 4, which will remain attached to the present
minutes under Annexes 1 to 5 (the “Declarations”).
In particular, it appears from the Declarations that:
(i) the Contribution 1 has been valued at least at two million and three hundred thousand Euro (EUR 2,300,000), which
therefore is worth at least the value of the New Shares 1 issued in consideration without nominal value, and it has been
justified to the undersigned notary;
(ii) the Contribution 2 has been valued at least at four million nine hundred and twenty-eight thousand five hundred and
fifty Euro (EUR 4,928,550.-), which therefore is worth at least the value of the New Shares 2 issued in consideration without
nominal value, and it has been justified to the undersigned notary;
(iii) the Contribution 3 has been valued at least at one million two hundred and fifty-five thousand Euro (EUR
1,255,000.-), which therefore is worth at least the value of the New Shares 3 issued in consideration without nominal value,
and it has been justified to the undersigned notary;
(iv) the Contribution 4 has been valued at least at two million five hundred Euro (EUR 2,500,000), which therefore is
worth at least the value of the New Shares 4 issued in consideration without nominal
Pursuant to this resolution and to the Contribution 1, the Contribution 2, the Contribution 3 and the Contribution 4, the
Articles of Association of the Company shall be amended as detailed hereafter under the sixth resolution.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to issue twenty-seven thousand one hundred and thirty-six (27,136.-) profit certificates to Parana
Management Corp. BVBA, a closed limited liability company (“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”)
incorporated and existing under Belgian law, having a share capital of eighteen thousand five hundred and fifty euro
(18,550.-), with its registered office at Zuylenveld 10, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgium, registered with the Crossroads
Bank (“Kruispuntbank voor Belgische Ondernemingen - KBO”) under number 0862.414.528. Pursuant to this resolution,
the Articles of Association of the Company shall be amended as detailed hereafter under the sixth resolution.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the “Drag-Along Clause” as set out in Article 7 of the Articles of Association of the
Company , so as to increase the relevant threshold from thirty percent (30%) to fifty-one (51%); pursuant to this resolution,
the Articles of Association of the Company shall be amended as detailed hereafter under the sixth resolution.
<i>Sixth resolutioni>
Pursuant to the first, second, third, fourth and fifth resolutions above, the Meeting resolves to amend as follows the
Articles of Association of the Company:
(a) Article 5, first paragraph, of the Articles of Association of the Company is replaced by the following:
“ Art. 5. Share Capital. The share capital is set at eleven million three hundred and fifty-eight thousand five hundred
and fifty Euro (EUR 11,358,550.-) represented by three hundred and fifty-two thousand two hundred and thirty-four
(352,234.-) shares without nominal value”;
(b) Article 7.7, second paragraph, of the Articles of Association of the Company is replaced by the following:
“If one or more shareholder(s) wish to transfer to any bona fide third party a number of shares that totals more than fifty-
one percent (51%) of all outstanding shares of the Company (the “Drag-Along Seller”), the Drag-Along-Seller may require
the other holders of the shares (the “Dragged-Along-Seller”) to sell to these third parties nominated by the Drag-Along
Seller (the “Drag-Along-Buyer”) all of their shares”;
(c) The following provisions are inserted at the end of Article 8 of the Articles of Association of the Company:
“In addition to the shares, the Company grants twenty-seven thousand one hundred and thirty-six (27,136.-) profit
certificates to Parana Management Corp. BVBA. Such profit certificates do not represent the share capital of the Company
and are in registered form.
Each profit certificate entitles its owner to the same economic rights as a share (including, without limitation, dividend
rights and entitlement to reserves and liquidation proceeds).
As an exception to article 24 paragraph 2 of the Articles, any resolution of the general meeting amending the rights
attached to the profit certificates provided under this article shall be resolved upon by a majority in number of shareholders
representing at least three quarters of the share capital and the absolute majority of the holders of profit certificates.
153764
L
U X E M B O U R G
Each profit certificate shall entitle its holder to the same voting rights as a share to the maximum extent permitted by
Luxemburg law.
Profit certificates may only be transferred subject to the approval of shareholders representing at least seventy-five
percent (75%) of the share capital, given at the general meeting of shareholders.”
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting resolves to authorize each manager of the Company to execute and deliver, under his sole signature, on
behalf of the Company, any documents necessary or useful in connection with the filing and registration required by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg regarding the above resolutions and, in particular, to register the New Shares in
the share register of the Company.
<i>Expensesi>
The expenses incurred in connection with the present deed are estimated to be approximately EUR 7,000.- (seven
thousand Euro).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Bascharage, on the day named at the beginning.
The document having been read to the appearing parties, the latter signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le vingt-trois septembre.
Par-devant Nous, Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’«Assemblée») des associés de la société à responsabilité limitée de droit lu-
xembourgeois Congra Software S.à r.l., précédemment connue sous le nom de Hybrid Software Europe S.A., ayant un
capital social de trois cent soixante-quinze mille euros (EUR 375.000,-) et ayant son siège social au 48, rue de Bragance,
L-1255 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.896
(la «Société»). La Société a été constituée sous la forme d’une société anonyme en date du 3 août 2011, par acte de Maître
Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, numéro 2542 du 20 octobre 2011 et ses
Statuts ont été modifiés suivant acte de Maître Cosita DELVAUX, alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 23
mai 2012, publié au Mémorial C, numéro 1648 du 23 mai 2012 et, par la suite, suivant un acte notaire soussigné en date
du 4 août 2015 suivant lequel la société a été transformée en société à responsabilité limitée.
L’Assemblée est présidée par Guido Van der Schueren, résidant professionnellement au 48 rue de Bragance, L-1255
Luxembourg (le “Président”), qui désigne Joachim Van Hemelen, résidant professionnellement à Burburestraat, 6-8, 2000
Anvers, Belgique, comme secrétaire (le «Secrétaire»).
L’Assemblée élit Ingrid Hoolants, résidant professionnellement au 80 rue des Romains, L-8041 Strassen, Luxembourg,
comme scrutateur (le «Scrutateur»).
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont ensemble dénommés ci-après le «Bureau».
Les actionnaires de la Société présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent
sont indiqués sur une liste de présence, qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par les représentants des
actionnaires et les membres du Bureau.
Les procurations des associés de la Société représentés à la réunion, après avoir été signées «ne varietur» par les com-
parants et le notaire instrumentaire, resteront également annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui aux
formalités d’enregistrement.
Le Bureau ayant ainsi été valablement constitué, le Président prie le notaire d’acter:
I. Qu’il ressort de la liste de présence que l’ensemble des 750.- (sept cent cinquante) parts sociales, ayant une valeur
nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, représentant la totalité du capital social souscrit de la Société est présent
ou dûment représenté à l’Assemblée, qui est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du
jour reproduit ci-après, les associés représentés à l’Assemblée ayant accepté de se réunir après examen de l’ordre du jour.
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
(1) Division des parts sociales émises par la Société conformément à un facteur de division de cent pour un (100-pour-1),
créant ainsi cent (100) parts sociales pour chaque part sociale existante;
(2) Suppression de la valeur nominale des parts sociales émises par la Société et de toute référence à la valeur nominale
des parts sociales dans les Statuts de la Société;
153765
L
U X E M B O U R G
(3) Augmentation du capital social de la Société d’un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt-trois mille cinq
cent cinquante euros (EUR 10.983.550,-) par l’émission de deux cent soixante-dix-sept mille deux cent trente-quatre
(277.234,-) nouvelles parts sociales ordinaires sans valeur nominale (l’«Augmentation du Capital»), de manière à le porter
de son montant actuel de trois cent soixante-quinze mille euros (EUR 375.000,-) à onze millions trois cent cinquante-huit
mille cinq cent cinquante euros (EUR 11.358.550,-).
L'augmentation du capital sera réalisée par l’émission de nouvelles parts sociales ordinaires sans valeur nominale comme
suit:
(a) émission de cinquante mille sept cent trente-cinq (50.735,-) nouvelles parts sociales ordinaires sans valeur nominale
(les «Nouvelles Parts Sociales 1»), en contrepartie de l’Apport 1 (tel que défini ci-après);
(b) émission de cent et huit mille sept cent onze (108.711,-) nouvelles parts sociales ordinaires sans valeur nominale
(les «Nouvelles Parts Sociales 2»), en contrepartie de l’Apport 2 (tel que défini ci-après);
(c) émission de trente-six mille neuf cent neuf (36.909,-) nouvelles parts sociales ordinaires sans valeur nominale (les
«Nouvelles Parts Sociales 3»), en contrepartie de l’Apport 3 (tel que défini ci-après);
(d) émission de quatre-vingt mille huit cent soixante-dix-neuf (80.879) nouvelles parts sociales ordinaires sans valeur
nominale (les «Nouvelles Parts Sociales 4»), en contrepartie de l’Apport 4 (tel que défini ci-après);
(4) Insertion au sein des Statuts de la Société de stipulations relatives à l’émission de parts bénéficiaires;
(5) Modification de la clause de «Drag-Along» telle que définie à l’article 7 des Statuts de la Société, de manière à
augmenter le seuil pertinent de trente pour cent (30%) à cinquante et un pourcent (51%);
(6) Modifications subséquentes des Statuts de la Société;
(7) Divers.
III. Que la présente Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de diviser les parts sociales émises par la Société conformément à un facteur de division de cent
(100) pour un (1), augmentant ainsi le nombre total de parts sociales de sept cent cinquante (750) à soixante-quinze mille
(75.000). Conformément à cette résolution, les Statuts de la Société sont modifiés comme détaillé ci-après sous la sixième
résolution.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales émises par la Société ainsi que toute référence
à la valeur nominale des parts sociales dans les Statuts de la Société. Conformément à cette résolution, les Statuts de la
Société sont modifiés comme détaillé ci-après sous la sixième résolution.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de procéder à l’Augmentation du Capital, et donc d’émettre les Nouvelles Parts Sociales 1, les
Nouvelles Parts Sociales 2, les Nouvelles Parts Sociales 3 et les Nouvelles Parts Sociales 4 définies ensemble en tant que
les «Nouvelles Parts Sociales».
Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites et entièrement libérées suite aux apports en nature suivants:
(A) Apport en nature de vingt-sept mille actions (27.000,-) émises par NiXPS NV, une société anonyme («naamloze
vennootschap») de droit belge, ayant un capital social de deux cent soixante-dix mille euros (EUR 270.000,-), ayant son
siège social au 18 Guldensporenpark, 9820 Merelbeke, Belgique, enregistré auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises
(«BCE») sous le numéro 0889.922.639 («NiXPS»), sans valeur nominale, représentant la totalité du capital social de NiXPS,
transféré et accepté par la Société pour une valeur de deux millions trois cent mille euros (EUR 2.300.000,-), en contrepartie
de cinquante mille sept cent trente-cinq euros (EUR 50.735,-) Nouvelles Parts Sociales 1 comme détaillé ci-dessous:
- seize mille neuf cent douze (16.912,-) sur cinquante mille sept cent trente-cinq (50.735,-) Nouvelles Parts Sociales 1
sont souscrites et entièrement libérées par De Roeck Software Engineering BVBA, une société à responsabilité limitée
(«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid») de droit belge, ayant un capital social de dix-huit mille six cent
euros (EUR 18.600,-), ayant son siège social au New-Yorkstraat 2/N, 9000 Gand, Belgique, enregistrée auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0471.372.686, par l’apport en nature de neuf mille (9.000,-) actions émises par
NiXPS, transférées vers et acceptées par la Société pour une valeur de sept cent soixante-six mille six cent quatre-vingt-
deux euros (EUR 766.682,-);
- trente-trois mille huit cent vingt-trois (33.823,-) Nouvelles Parts Sociales 1 sur cinquante mille sept cent trente-cinq
(50.735,-) Nouvelles Parts Sociales 1 sont souscrites et entièrement libérées par Nexus Investments NV, une société ano-
nyme («naamloze vennootschap») de droit belge, ayant un capital social de quatre-vingtcinq mille euros (EUR 85.000,-),
ayant son siège social au Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem, Belgique, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entre-
prises sous le numéro 0810.044.525, par l’apport en nature de dix-huit mille (18.000,-) actions émises par NiXPS,
transférées vers et acceptées par la Société pour une valeur d’un million cinq cent trente-trois mille trois cent dix-huit euros
(EUR 1.533.318,-), Ensemble, l’«Apport 1»;
153766
L
U X E M B O U R G
(B) Apport en nature de quatre-vingt-dix-huit pourcents et cinq cent soixante-et-onze centièmes (98,5710 %) des parts
d’intérêts dans Hybrid Integration LLC, un partenariat («partnership») soumise au droit de l’État de Pennsylvanie, ayant
son siège social au 1709 Langhorne Newtown Road Suite 6, Langhorne, PA 19047, les États-Unis d’Amérique, enregistrée
auprès du Département de l’État de Pennsylvanie sous le numéro 579056 («Hybrid US»), représentant la totalité du capital
social de Hybrid US, transférées et acceptées par la Société pour une valeur de quatre millions neuf cent vingt-huit mille
cinq cent cinquante euros (EUR 4.928.550) en contrepartie de cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts
Sociales 2 comme détaillé ci-dessous:
(i) sept mille cent seize (7.116,-) sur cent-huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites
et entièrement libérées par Bucks Ventures, une société à responsabilité limitée incorporée et existant sous la loi de Penn-
sylvania, avec adresse à 1558 River Road, New Hope, PA 18938, United States of America, Numéro d’identification
employeur EIN: 27-4194269, par l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 6,45% des parts
d’intérêts, transférées vers et acceptées par la Société pour une valeur de trois cent vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-
treize euros (EUR 322.593,-).
(ii) sept mille cent quatre-vingt-dix (7.190,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2
sont souscrites et entièrement libérées par M. Naren Mehta, Americain, né le 29 octobre 1954 à Calcutta (Inde), demeurant
à 41 Greenbriar Lane, Newtown, PA 18940, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER 170-62-2155, par
l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 6,52% des parts d’intérêts, transférées vers et acceptées
par la Société pour une valeur de trois cent vingt-cinq mille neuf cent quarante-sept euros (EUR 325.947,-);
(iii) douze mille huit cent vingt-cinq (12.825,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales
2 sont souscrites et entièrement libérées par M. Michael A. Rottenborn, Américain, né le 5 juin 1967 à Waynesboro, Virginia
(USA), demeurant à 431 Ramsey Road, Yardley, PA 19067, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER
226-90-2907, par l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 11,63% des parts d’intérets, transférées
vers et acceptées par la Société pour une valeur de cinq cent quatre-vingt-un mille quatre cent un euros (EUR 581.401,-);
(iv) quatre cent quatre (404,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites
et entièrement libérées par M. Andy Balto, Américain, né le 26 août 1967 à Baltimore, Maryland (USA), demeurant à 2500
Rochelle Drive, Fallston, MD 21047, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER 220-78-6914, par l’apport
en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 0,37% des parts d’intérêts, transférées vers et acceptées par la
Société pour une valeur de dix-huit mille trois cent quinze euros (EUR 18.315,-);
(v) quatre cent quatre (404,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites et
entièrement libérées par Mme Anne Balto, Américaine, née le 4 avril 1971 à Waynesboro, Virginie (USA), demeurant à
2500 Rochelle Drive, Fallston, MD 21047, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER 226-90-2936, par
l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 0.37% des parts d’intérêts, transférées vers et acceptées
par la Société pour une valeur de dix-huit mille trois cent quinze euros (EUR 18.315,-);
(vi) quatre cent quatre (404,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites
et entièrement libérées par M. Joseph Demharter, né le 2 septembre 1947 à Natrona Heights, Pennsylvania (USA), de-
meurant à 5 Carriage Path, Chadds Ford, PA 19317, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER
168-38-9195, par l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 0,37% des parts d’intérêts, transférées
vers et acceptées par la Société pour une valeur de dix-huit mille trois cent quinze euros (EUR 18.315,-);
(vii) quatre mille quarante-deux (4.042,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont
souscrites et entièrement libérées par Kielvest 3 LLC, une société à responsabilité limitée, incorporée et existant sous la
loi du Delaware, ayant son siège social à 3411 Silverside Road, Hanby Bldg. #101, Wilmington, DE 19810, United States
of America, enregistré sous le numéro fiscal 45-0585558, par l’apport en nature de sa participation dans US Hybrid,
représentant 3.67% des parts d’intérêts, transférées vers et acceptées par la Société pour une valeur de cent quatre-vingt-
trois mille deux cent trente-huit euros (EUR 183.238,-);
(viii) quatre cent quatre (404,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites
et entièrement libérées par M. Bharat Mehta, Américain, né le 24 septembre 1952 à Calcutta (Inde), demeurant à 4320
Tiffany Drive, Easton, PA 18045, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER 173-60-6561, par l’apport
en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 0,37% des parts d’intérêts, transférées vers et acceptées par la
Société pour une valeur de dix-huit mille trois cent quinze euros (EUR 18.315,-);
(ix) quatre cent quatre (404,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites
et entièrement libérées par The Juan A. Proano Revocable Trust, ayant son siège à 9 Bartons Mill Drive, Washington
Crossing, PA 18977, United States of America, par l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant
0,37% des parts d’intérêts, transférées vers et acceptées par la Société pour une valeur de dix-huit mille trois cent quinze
euros (EUR 18.315,-);
(x) quatre cent quatre (404,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites et
entièrement libérées par The Luisa A. Proano Revocable Trust, ayant son siège à 9 Bartons Mill Drive, Washington Cross-
ing, PA 18977, United States of America, par l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 0,37%
des parts d’intérêts, transférées vers et acceptées par la Société pour une valeur de dix-huit mille trois cent quinze euros
(EUR 18.315,-);
153767
L
U X E M B O U R G
(xi) quatre cent quatre (404,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites
et entièrement libérées par M. John Rottenborn, Américain, né le 1
er
septembre 1981 à Waynesboro, Virginie (USA),
demeurant à One 26
th
St. SW, Roanoke, VA 24014, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER
224-23-3091, par l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 0,37% des parts d’intérêts, transférées
vers et acceptées par la Société pour une valeur de dix-huit mille trois cent quinze euros (EUR 18.315,-);
(xii) sept cent quarante-neuf (749,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont
souscrites et entièrement libérées par M. Edward Sager, Américain, né le 10 mai 1947 à Newark, New Jersey (USA),
demeurant à 570 Nottingham Drive, Yardley, PA 19067, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER
144-40-9431, par l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 0,68% des parts d’intérêts, transférées
vers et acceptées par la Société pour une valeur de trente-trois mille neuf cent cinquante-cinq euros (EUR 33.955,-);
(xiii) soixante-quatre mille trois cent trente-deux (64.332,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles
Parts Sociales 2 sont souscrites et entièrement libérées par Parana Management Corporation BVBA, une société à respon-
sabilité limitée (“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”) de droit belge, ayant un capital social de dix-
huit mille cinq cent cinquante euros (EUR 18.550,-) et ayant son siège social au Zuylenveld 10, 9830 Sint-Martens-Latem,
Belgique, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0862.414.528 par l’apport en nature
de sa participation dans Hybrid US, représentant 58.33% des parts d’intérêts, transférées vers et acceptées par la Société
pour une valeur de deux millions neuf cent seize mille six cent quatre-vingt-douze euros (EUR 2.916.692);
(xiv) trois cent soixante-douze (372,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont
souscrites et entièrement libérées par Big Friend NV, une société anonyme (“naamloze vennootschap”) de droit belge,
ayant un capital social de neuf cent douze mille euros (EUR 912.000,-), ayant son siège social à Kustlaan 15, 8300 Knokke-
Heist, Belgique, enregistré auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0431.535.578, par l’apport en
nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 0,34% des parts d’intérêts, transférées vers et acceptées par la
Société pour une valeur de seize mille huit cent soixante-quatre euros (EUR 16.864,-);
(xv) soixante-quatorze (74) sur cent huit mille sept cent onze (108.711) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites et
entièrement libérées par M. Stéphane Denis Georges, de nationalité française, né le 27 décembre 1971 à Saint-Avold,
France, demeurant à 13 rue de la Chasse, 67115 Plobsheim, France, par l’apport en nature de sa participation dans Hybrid
US, représentant 0,07% des parts d’intérêts, transférées vers et acceptées par la Société pour une valeur de trois mille trois
cent cinquantecinq euros (EUR 3.355);
(xvi) huit cent quatre-vingt-quatorze (894) sur cent huit mille sept cent onze (108.711) Nouvelles Parts Sociales 2 sont
souscrites et entièrement libérées par M. Christopher Martin Graf, de nationalité allemande, né le 30 avril 1967 à Offenburg,
Allemagne, demeurant à Silberbachstrasse 27, 79100 Freiburg im Breisgau, Allemagne, par l’apport en nature de sa par-
ticipation dans Hybrid US, représentant 0,81% des parts d’intérêts, transférées vers et acceptées par la Société pour une
valeur de quarante mille cinq cent vingt-huit euros (EUR 40.528,-);
(xvii) soixante-quatorze (74,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites
et entièrement libérées par Mme Hannah Suzanna E. Van der Schueren, de nationalité belge, née le 28 avril 1987 à Gand,
Belgique, demeurant à Zuylenveld 10, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgique, par l’apport en nature de sa participation dans
Hybrid US, représentant 0,07% des parts d’intérêts, transférées vers et acceptées par la Société pour une valeur de trois
mille trois cent cinquante-cinq euros (EUR 3.355);
(xviii) soixante-quatorze (74,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites
et entièrement libérées par Mme Sarah Julienne G. Van der Schueren, de nationalité belge, née le 31 octobre 1983 à Gand,
Belgique, demeurant à Koperstraat 14 / bus 3, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgique, par l’apport en nature de sa participation
dans Hybrid US, représentant 0,07% des parts d’intérêts, transférées vers et acceptées par la Société pour une valeur de
trois mille trois cent cinquante-cinq euros (EUR 3.355);
(xix) soixante-quatorze (74,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites
et entièrement libérées par M. Tom Simon Julien Van der Schueren, de nationalité belge, né le 29 avril 1975 à Sint-
Amandsberg, Belgique, demeurant à Varendries 12, 9820 Merelbeke, Belgique, par l’apport en nature de sa participation
dans Hybrid US, représentant 0,07% des parts d’intérêts, transférées vers et acceptées par la Société pour une valeur de
trois mille trois cent cinquante-cinq euros (EUR 3.355);
(xx) mille trois cent vingt-huit (1,328,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont
souscrites et entièrement libérées par M. Michael Agness, Américain, né le 18 août 1972 à Camden, New Jersey (USA),
demeurant à 14 Pine Street, Kearny, NJ 07032, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER 143-76-8413,
par l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 1,20% des parts d’intérêts, transférées vers et
acceptées par la Société pour une valeur de soixante mille deux cent trois euros (EUR 60.203,-);
(xxi) cent soixante-neuf (169,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites
et entièrement libérées par M. David Bolduc, Américain, né le 30 juillet 1976 à Peekskill, New York (USA), demeurant à
2035 Pemberton St, Philadelphia, PA 19146, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER 052-62-4447,
par l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 0,15% des parts d’intérêts, transférées vers et
acceptées par la Société pour une valeur de sept mille six cent soixante-et-un euros (EUR 7.661,-);
(xxii) soixante-quatorze (74,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites
et entièrement libérées par M. Rob Wexler, Américain, né le 5 août 1957 à Wynnewood, Pennsylvania (USA), demeurant
153768
L
U X E M B O U R G
à 870 Skyline Dr., Erdenheim, PA 19038, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER 206-50-4262, par
l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 0,07% des parts d’intérêts, transférées vers et acceptées
par la Société pour une valeur de trois mille trois cent cinquante-cinq euros (EUR 3.355);
(xxiiii) deux cent vingt-cinq (225,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont
souscrites et entièrement libérées par M. Ryan Godfrey, Américain, né le 27 août 1971 à Provo, Utah (USA), demeurant
à 4811 Beaumont Ave., Philadelphia, PA 19143, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER 535-96-2725,
par l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 0,20% des parts d’intérêts, transférées vers et
acceptées par la Société pour une valeur de dix mille deux cent euros (EUR 10.200,-);
(xxiv) cinquante-six (56,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites et
entièrement libérées par M. Ehrich Grein, Américain, né le 1
er
octobre 1966 à Springfield, Massachusets (USA), demeurant
à 2625 Hirst Terrace, Havertown, PA 19083, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER 044-70-4733,
par l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 0,05% des parts d’intérêts, transférées vers et
acceptées par la Société pour une valeur de deux mille cinq cent trente-neuf euros (EUR 2.539,-);
(xxv) mille deux cent cinquante-trois (1.253,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales
2 sont souscrites et entièrement libérées par M. Oleh Kornyev, Américain, né le 11 octobre 1979 à Chernovtsy (Ukraine),
demeurant à 111 Windy Knoll Drive, Richboro, PA 18954, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER
197-82-4284, par l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 1,14% des parts d’intérêts, transférées
vers et acceptées par la Société pour une valeur de cinquante-six mille huit cent trois euros (EUR 56.803,-) (xxvi) cent
quarante (140,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites et entièrement
libérées par M. James Lawlor, Américain, né le 10 avril 1967 à Media, Pennsylvanie, demeurant à 113 Cornell Ave.,
Claremont, CA 91711, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER 159-52-6818, par l’apport en nature de
sa participation dans Hybrid US, représentant 0.13% des parts d’intérêts, transférées vers et acceptées par la Société pour
une valeur de six mille trois cent quarante-sept euros (EUR 6.347,-);
(xxvii) cent douze (112,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites et
entièrement libérées par M. Robb Lutton, Américain, né le 18 janvier 1950 à Ann Arbor, Michigan (USA), demeurant à
7807 Louise Lane, Glenside, PA 19038, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER 536-54-5959, par
l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 0,10% des parts d’intérêts, transférées vers et acceptées
par la Société pour une valeur de cinq mille soixante-dix-sept euros (EUR 5.077,-);
(xxviii) deux mille deux cent quarante-huit (2.248,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts
Sociales 2 sont souscrites et entièrement libérées par M. Alexander McKnight, Américain, né le 3 avril 1965 à Philadelphie,
Pennsylvanie (USA), demeurant à 816 Stoneybrook Drive, W. Norriton, PA 19403, United States of America, SOCIAL
SECURITY NUMBER 223-23-1200, par l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 2.04% des
parts d’intérêts, transférées vers et acceptées par la Société pour une valeur de cent un mille neuf cent dix euros (EUR
101.910,-);
(xxix) deux mille deux cent quarante-huit (2.248,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales
2 sont souscrites et entièrement libérées par M. George McKnight, Américain, né le 7 janvier 1967 à Upper Darby, Penn-
sylvanie (USA), demeurant à 821 Forrest Street, Lansdale, PA 19446, United States of America, SOCIAL SECURITY
NUMBER 223-23-1199, par l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 2,04% des parts d’intérêts,
transférées vers et acceptées par la Société pour une valeur de cent un mille neuf cent dix euros (EUR 101.910,-);
(xxx) cent quarante (140,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites et
entièrement libérées par M. Brian Meyer, Américain, né le 15 septembre 1968 à Winterset, Indiana (USA), demeurant à
6311 Stanmore Ct, Johnston, IA 50131, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER 484-86-9069, par
l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 0.13% des parts d’intérêts, transférées vers et acceptées
par la Société pour une valeur de six mille trois cent quarante-sept euros (EUR 6.347,-);
(xxxi) soixante-quatorze (74,-) sur cent huit mille sept cent onze (108.711,-) Nouvelles Parts Sociales 2 sont souscrites
et entièrement libérées par Mme Chelsea Paul, Américaine, née le 23 octobre 1968 à Lower Merion, Pennsylvanie (USA),
demeurant à 1700 Bulter Pike, Conshohocken, PA 19428, United States of America, SOCIAL SECURITY NUMBER
173-70-4806, par l’apport en nature de sa participation dans Hybrid US, représentant 0,07% des parts d’intérêts, transférées
vers et acceptées par la Société pour une valeur de trois mille trois cent cinquante-cinq euros (EUR 3.355);
Ensemble, l’«Apport 2»;
(C) Apport en nature des droits suivants attachés aux obligations subordonnées émises par la Société le 9 avril 2015
pour une valeur nominale principale totale d’un million deux cent cinquante-cinq mille euros (EUR 1.255.000,-) (les
«Obligations Subordonnées»), transférées vers et acceptées par la Société pour une valeur d’un million deux cent cinquante-
cinq mille euros (EUR 1.255.000,-), en contrepartie de trente-six mille neuf cent neuf (36.909) Nouvelles Parts Sociales
3, comme détaillé ci-dessous:
(i) dix mille cent quarante-quatre (10.144,-) sur trente-six mille neuf cent neuf (36.909,-) Nouvelles Parts Sociales 3
sont souscrites et entièrement libérées par Parana Management Corporation BVBA, une société à responsabilité limitée
(“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”) de droit belge, ayant un capital social de dix-huit mille cinq cent
cinquante euros (EUR 18.550,-) et ayant son siège social au Zuylenveld 10, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgique, enregistrée
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0862.414.528 par l’apport en nature des droits attachés à
153769
L
U X E M B O U R G
trois cent quarante-cinq (345,-) Obligations Subordonnées, représentant 27,49% de la valeur nominale totale des Obliga-
tions Subordonnées pour une valeur de trois cent quarante-cinq mille euros (EUR 345.000,-);
(ii) deux mille neuf cent quarante et un (2.941) sur trente-six mille neuf cent neuf (36.909) Nouvelles Parts Sociales 3
sont souscrites et entièrement libérées par M. Christopher Martin Graf, par l’apport en nature des droits attachés à cent
(100) Obligations Subordonnées, représentant 7,97% de la valeur nominale totale des Obligations Subordonnées pour une
valeur de cent mille euros (EUR 100.000,-);
(iii) quatre mille quatre cent douze (4.412,-) sur trente-six mille neuf cent neuf (36.909,-) Nouvelles Parts Sociales 3
sont souscrites et entièrement libérées par Big Friend NV, une société anonyme (“naamloze vennootschap”) de droit belge,
ayant un capital social de neuf cent douze mille euros (EUR 912.000,-), ayant son siège social à Kustlaan 15, 8300 Knokke-
Heist, Belgique, enregistré auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0431.535.578, par l’apport en
nature des droits attachés à cent cinquante (150) Obligations Subordonnées, représentant 11,95% de la valeur nominale
totale des obligations subordonnées pour une valeur de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-);
(iv) sept mille trois cent cinquante-trois (7.353,-) sur trente-six mille neuf cent neuf (36.909,-) Nouvelles Parts Sociales
3 sont souscrites et entièrement libérées par Brand Quadergy NV, une société anonyme («naamloze vennootschap») de
droit belge, ayant un capital social d’un montant de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), ayant son siège social à
Blancefloerlaan 179-A, 2050, Anvers, Belgique, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0423.174.079, par l’apport en nature des droits attachés à deux cent cinquante (250,-) Obligations Subordonnées, repré-
sentant 19,92% de la valeur nominale totale des Obligations Subordonnées pour une valeur de deux cent cinquante mille
euros (EUR 250.000,-);
(v) mille six cent dix-huit (1.618,-) sur trente-six mille neuf cent neuf (36.909,-) Nouvelles Parts Sociales 3 sont souscrites
et entièrement libérées par M. Pierre Victor M. Cottenie, né le 21 septembre 1954 à Gand, Belgique, résidant à Driesstraat
54, 9090 Melle, Belgique, par l’apport en nature des droits attachés à cinquante-cinq (55,-) Obligations Subordonnées,
représentant 4,38% de la valeur nominale totale des Obligations Subordonnées pour une valeur de cinquante-cinq mille
euros (EUR 55.000,-);
(vi) deux mille deux cent six (2.206,-) sur trente-six mille neuf cent neuf (36.909,-) Nouvelles Parts Sociales 3 sont
souscrites et entièrement libérées par M. Patrick Albert M. Coussement, né le 15 novembre 1964 à Menen, Belgique,
résidant à Nieuwe Weg 10, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgique, par l’apport en nature des droits attachés à soixante-quinze
(75,-) Obligations Subordonnées, représentant 5,98% de la valeur nominale totale des Obligations Subordonnées pour une
valeur de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-);
(vii) sept mille trois cent cinquante-trois (7.353,-) sur trente-six mille neuf cent neuf (36.909,-) Nouvelles Parts Sociales
3 sont souscrites et entièrement libérées par Keyware Smart Card Division NV, une société anonyme («naamloze ven-
nootschap») de droit belge, ayant un capital social d’un montant de deux millions trois cent mille euros (EUR 2.300.000,-),
ayant son siège social à Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem, Belgique, enregistrée à la BCE sous le numéro 0449.832.253, par
l’apport en nature des droits attachés à deux cent cinquante (250,-) Obligations Subordonnées, représentant 19,92% de la
valeur nominale des Obligations Subordonnées pour une valeur de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-);
(viii) huit cent quatre-vingt-deux (882,-) sur trente-six mille neuf cent neuf (36.909) Nouvelles Parts Sociales 3 sont
souscrites et entièrement libérées par Portolani NV, une société anonyme («naamloze vennootschap») de droit belge, ayant
un capital social d’un montant de deux cent dix mille euros (EUR 210.000,-), ayant son siège social à de Burburestraat 6-8,
2000, Anvers, Belgique, enregistrée à la BCE sous le numéro 0877.600.669, par l’apport en nature des droits attachés à
trente (30,-) Obligations Subordonnées, représentant 2,39% de la valeur nominale totale des Obligations Subordonnées
pour valeur de trente mille euros (EUR 30.000,-).
(D) Apport en nature d’une créance de deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000) résultant d’une partie des
prêts accordés par Parana Management Corporation BVBA, tel que détaillé ci-dessus, à la Société (l’«Apport 4») en
contrepartie de quatre-vingt mille huit cent soixante-dix-neuf (80.879) Nouvelles Parts Sociales 4. Les Nouvelles Parts
Sociales 4 sont souscrites et intégralement libérées par Parana Management Corporation BVBA par l’apport en nature de
l’Apport 4, qui est transféré vers et accepté par la Société pour une valeur de deux millions cinq cent mille euros (EUR
2.500.000,-).
En ce qui concerne l’Apport 1, l’Apport 2, l’Apport 3 et l’Apport 4, chaque apporteur énuméré ci-dessus déclare qu’il/
elle est le plein propriétaire des actifs respectifs apportés, qu’ils sont librement cessibles à la Société et qu’ils sont libérés
de toute charge (droit de préemption, charge, privilège, sûreté, gage, garantie, usufruit ou option d’achat en vertu de laquelle
un tiers pourrait prétendre au transfert d’une partie ou de la totalité des actifs) et qu’il sera procédé à toutes les autres
formalités imposées par le droit du pays où sont situés les actifs apportés afin d’effectuer et de formaliser le transfert et de
le rendre opposable à l’encontre de tout tiers quelle que soit la juridiction.
Les preuves de l’existence, de la valeur et de la libre négociabilité des actifs apportés à la Société en vertu de l’Apport
1, l’Apport 2, l’Apport 3 et de l’Apport 4 ont été données au notaire soussigné par les déclarations signées de chaque
apporteur énuméré ci-dessus et par la Société à l’égard de tous les actifs apportés en vertu de l’Apport 1, l’Apport 2, l’Apport
3 et de l’Apport 4 et sont attachées aux présentes aux Annexes 1à 5 (les «Déclarations»).
En particulier, il ressort des Déclarations que:
153770
L
U X E M B O U R G
(i) L’Apport 1 a été évalué à au moins deux millions et trois cent mille euros (EUR 2.300.000,-), ce qui représente donc
au moins la valeur des Nouvelles Parts Sociales 1 émises en contrepartie, sans valeur nominale, tel qu’il en a été justifié
au notaire soussigné;
(ii) L’Apport 2 a été évalué à au moins quatre millions neuf cent vingt-huit mille cinq cent cinquante euros (EUR
4.928.550,-), ce qui représente donc au moins la valeur des Nouvelles Parts Sociales 2 émises en contrepartie, sans valeur
nominale, tel qu’il en a été justifié au notaire soussigné;
(iii) L’Apport 3 a été évalué à au moins un million deux cent cinquante-cinq mille euros (1.255.000,-), ce qui représente
donc au moins la valeur des Nouvelles Parts Sociales 3 émises en contrepartie, sans valeur nominale, tel qu’il en a été
justifié au notaire soussigné;
(iv) L’Apport 4 a été évalué à au moins deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-), ce qui représente donc
au moins la valeur des Nouvelles Parts Sociales 4 émises en contrepartie, sans valeur nominale, tel qu’il en a été justifié
au notaire soussigné.
Conformément à cette résolution et à l’Apport 1, l’Apport 2, l’Apport 3 et l’Apport 4, les Statuts de la Société sont
modifiés comme détaillé ci-après sous la sixième résolution.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de l’émission par la Société de vingt-sept mille cent trente-six (27.136,-) parts bénéficiaires au
profit de Parana Management Corp. BVBA. Conformément à cette résolution, les Statuts de la Société sont modifiés comme
détaillé ci-après sous la sixième résolution.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier la clause de «Drag-Along» telle que définie à l’article 7 des Statuts de la Société, de
manière à augmenter le seuil pertinent de trente pourcent (30%) à cinquante et un pour cent (51%); conformément à cette
résolution, les Statuts de la Société sont modifiés comme détaillé ci-après sous la sixième résolution.
<i>Sixième résolutioni>
Conformément aux première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième résolutions qui précèdent, l’Assemblée dé-
cide de modifier comme suit les Statuts de la Société:
(a) l’article 5, premier alinéa, des Statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:
« Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à onze millions trois cent cinquante-huit mille cinq cent cinquante euros
(EUR 11.358.550,-) représenté par trois cent cinquante-deux mille deux cent trente-quatre (352.234) parts sociales sans
valeur nominale»;
(b) l’article 7.7, deuxième alinéa, des Statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:
«Si un ou plusieurs associé(s) souhaite(nt) transférer, à tout tiers de bonne foi, un nombre de parts sociales qui totalise
plus de cinquante et un pourcent (51%) de toutes les parts restantes de la Société (le «Cédant du Drag-Along Right») le
Cédant du Drag-Along Right peut exiger des Autres Détenteurs de parts (l’«Autre Cédant du Drag-along Right») de vendre
toutes leurs parts à ces tierces parties (l’«Acheteur du Drag-along Right») désignées par le Cédant du Drag-along Right»;
(c) Les stipulations suivantes sont insérées à la fin de l’article 8 des Statuts de la Société:
«En plus des parts sociales, la Société émet vingt-sept mille cent trente-six (27.136) parts bénéficiaires au profit de
Parana Management Corp. BVBA. Ces parts bénéficiaires ne sont pas représentatives du capital social de la Société et ont
la forme nominative.
Chaque part bénéficiaire confère à son propriétaire les mêmes droits économiques qu’une part sociale (y compris,
notamment, le droit aux dividendes, réserves et boni de liquidation).
Par exception à l’article 24 alinéa 2 des Statuts, toute résolution de l’assemblée générale modifiant les droits attachés
aux parts bénéficiaires aux termes du présent article doit être votée par une majorité des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social ainsi que par la majorité absolue des propriétaires des parts bénéficiaires.
Chaque part bénéficiaire confère à son propriétaire les mêmes droits de vote qu’une part sociale, dans les limites permises
par le droit luxembourgeois.
Les parts bénéficiaires ne peuvent être transférées qu’avec l’agrément des associés représentant au minimum soixante-
quinze pour cent (75%) du capital social donné en assemblée générale.»
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée décide d’autoriser chaque gérant de la Société à signer et à remettre sous sa seule signature, au nom de la
Société, tous les documents nécessaires ou utiles en rapport avec le dépôt et l’enregistrement requis par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg concernant les résolutions ci-dessus et, en particulier, d’enregistrer les Nouvelles Parts Sociales au
registre des parts sociales de la Société.
<i>Fraisi>
Les dépenses engagées dans le cadre du présent acte s’élèvent approximativement à EUR 7.000,- (sept mille euros).
153771
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l’ont requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête des mêmes parties et en cas de divergences entre
le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Bascharage, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux personnes comparantes, celles-ci ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: VAN DER SCHUEREN, VAN HEMELEN, HOOLANTS, VANDERVELDE, ROTTENBORN, GRAF, A.
WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/30933. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): FRISING.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.
Bascharage, le 5 octobre 2015.
Référence de publication: 2015165298/819.
(150182782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
Consorts EICH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 3, rue de Remich.
R.C.S. Luxembourg B 138.522.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Consorts EICH S.à r.l.
i>Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2015165300/12.
(150182099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
Continent 8 (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 118.750,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 147.798.
Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
Continent 8 (Luxembourg) S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015165302/12.
(150182498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
ContourGlobal Power Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 164.238.
Les comptes annuels de la société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2015.
Référence de publication: 2015165303/11.
(150181841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
153772
L
U X E M B O U R G
Evoleco, Société Anonyme.
Siège social: L-9905 Toisvièrges, 74, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 153.308.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 octobre 2015.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2015165412/11.
(150182045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
EZC Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 140.949.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015165413/10.
(150182302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
Fairfield 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 79.052,60.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 185.390.
1. Suite à la cession de parts intervenue en date du 10 juin 2015 entre Fairfield 2014 Employee Benefit Trust représentée
par son trustee Appleby Trust (Jersey) Limited et Sir Nigel Sheinwald, les parts sociales de la Société sont désormais
détenues comme suit:
- Sir Nigel Sheinwald, né le 26 juin 1953 à Londres, Royaume-Unis, ayant pour adresse professionnelle le 5, Gloucester
Circus, SE10 8RX Londres, Royaume-Unis, détient
* 830 parts sociales de catégorie B1;
* 830 parts sociales de catégorie B2;
* 830 parts sociales de catégorie B3;
* 830 parts sociales de catégorie B4.
2. Suite à la cession de parts intervenue en date du 24 septembre 2015 entre Andrew Michael Copson et Fairfield 2014
Employee Benefit Trust représentée par son trustee Appleby Trust (Jersey) Limited, les parts sociales de la Société sont
désormais détenues comme suit:
- Andrew Michael Copson ne détient désormais plus aucune part sociale dans la Société.
3. Suite à la cession de parts intervenue en date du 24 septembre 2015 entre George Wilson Allan et Fairfield 2014
Employee Benefit Trust représentée par son trustee Appleby Trust (Jersey) Limited, les parts sociales de la Société sont
désormais détenues comme suit:
- George Wilson Allan ne détient désormais plus aucune part sociale dans la Société.
4. Suite à la cession de parts intervenue en date du 25 septembre 2015 entre Fairfield 2014 Employee Benefit Trust
représentée par son trustee Appleby Trust (Jersey) Limited et Mark Robertshaw, les parts sociales de la Société sont
désormais détenues comme suit:
- Mark Robertshaw détient
* 359 parts sociales de catégorie A1;
* 359 parts sociales de catégorie A2;
* 359 parts sociales de catégorie A3;
* 359 parts sociales de catégorie A4;
* 9,498 parts sociales de catégorie B1;
* 9,498 parts sociales de catégorie B2;
* 9,498 parts sociales de catégorieB3;
* 9,498 parts sociales de catégorie B4;
153773
L
U X E M B O U R G
* 43,040 parts sociales de catégorie C.
- Fairfield 2014 Employee Benefit Trust représentée par son trustee Appleby Trust (Jersey) Limited détient
* 9,530 parts sociales de catégorie B1;
* 9,530 parts sociales de catégorie B2;
* 9,530 parts sociales de catégorie B3;
* 9,530 parts sociales de catégorie B4.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jacob Mudde
<i>Gérant de catégorie Ai>
Référence de publication: 2015165414/46.
(150182786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
FF Investment Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 184.497.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FF Investment Luxembourg 2 S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015165427/11.
(150182434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
FFP Capital Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 164.040.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the first day of October.
Before the undersigned, Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
FFAM Inc., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at 33 Porter
Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, registered with the trade and companies’ register of Road Town
under the number 1568779 (the Sole Shareholder),
here represented by Aurore Guerini, a private employee with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, this
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested that the undersigned notary record that:
- the Sole Shareholder holds all of the shares in FFP Capital Partners S.à r.l., a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
164.040 (the Company);
- the Company was incorporated on 21 September 2011, pursuant to a deed drawn up by Maître Francis KESSELER,
then notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the Mémorial) under number 2950, page 141561 of 2 December 2011. The Company’s articles of asso-
ciation (the Articles) have not been amended since its incorporation;
- the Company’s share capital is set at fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-), represented by one hundred and fifty
(150) shares in registered form, having a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, all entirely subscribed and fully
paid up;
- the Sole Shareholder has full and complete knowledge of the Articles and of the Company’s financial situation;
- the Sole Shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put it into liquidation (liquidation
volontaire);
153774
L
U X E M B O U R G
- the Sole Shareholder resolves to act as liquidator of the Company;
- the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, declares that:
(i) the activity of the Company has ceased;
(ii) the liquidation accounts have been prepared and show that all the known liabilities of the Company have been settled
or fully provided for;
(iii) it will receive all the outstanding assets of the Company; and
(iv) it will assume all hidden or unknown liabilities (if any).
- the Sole Shareholder approves the liquidation accounts of the Company dated 30 September 2015.
- the Sole Shareholder waives the appointment of a liquidation auditor;
- the Sole Shareholder resolves to grant full discharge for the performance of their mandate and in connection with the
liquidation accounts to each of the managers of the board of managers of the Company;
- the Sole Shareholder resolves to confirm that the Company is hereby liquidated and the liquidation is closed;
- the Sole Shareholder resolves to keep the books, documents and records of the Company at 6, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg for a period of five (5) years after the publication of this deed in the Mémorial and to pay any and all
costs associated with the liquidation;
- the Sole Shareholder resolves to grant power to any employee of Intertrust (Luxembourg) S.à r.l. and of Maître Jean-
Paul MEYERS, each of them acting individually:
(i) to carry-out and perform any formalities necessary to complete and file any outstanding tax returns of the Company
(including, but not limited to, tax returns relating to financial years 2014 and 2015); and
(ii) to undertake any formalities necessary in connection with filing the Company’s annual accounts and closing the
Company’s liquidation,
these powers expiring one year after the closing of the Company’s liquidation.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the Sole Shareholder that this deed
is drawn up in English and French, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
This notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date first stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder’s authorised representative.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le premier jour d’octobre.
Par-devant le soussigné Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
A COMPARU:
FFAM Inc., une société en commandite par actions régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social
se situe au 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, inscrite au Registre du commerce et des sociétés
de Road Town sous le numéro 1568779 (l’Associé Unique),
représenté par Aurore Guerini, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l’Associé Unique et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- l’Associé Unique détient la totalité des parts sociales de FFP Capital Partners S.à r.l., une société à responsabilité
limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 164.040 (la Société);
- la Société a été constituée le 21 septembre 2011, suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, alors notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associa-
tions (le Mémorial) numéro 2950 du 2 décembre 2011. Les statuts de la société (les Statuts) n’ont pas été modifiés depuis
sa constitution;
- le capital social de la Société est fixé à quinze mille Euros (EUR 15.000,-) représenté par cent cinquante (150) parts
sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, toutes entièrement souscrites
et libérées;
- l’Associé Unique a pris connaissance des Statuts et connait parfaitement la situation financière de la Société;
- l’Associé Unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation;
- l’Associé Unique décide d’agir en tant que liquidateur de la Société;
153775
L
U X E M B O U R G
- l’Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que:
(i) l’activité de la Société a cessé;
(ii) les comptes de liquidation ont été préparés et montrent que l’ensemble du passif connu de la Société a été payé ou
provisionné;
(iii) qu'il va recevoir tous les actifs restants de la Société; et
(iv) qu'il prendra à sa charge, le cas échéant, tout le passif caché ou inconnu à ce jour.
- l’Associé Unique approuve les comptes de liquidation de la Société datés 30 septembre 2015.
- l’Associé Unique renonce à la nomination d’un commissaire à la liquidation;
- l’Associé Unique décide de donner pleine et entière décharge pour l’exercice de leurs mandats en relation avec les
comptes de la liquidation aux gérants de la Société;
- l’Associé Unique décide de confirmer que la Société est par conséquent liquidée et sa liquidation est clôturée;
- l’Associé Unique décide de conserver les livres, documents et registres de la Société au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg durant une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent acte au Mémorial et de payer tous
les frais en rapport avec la liquidation;
- l’Associé Unique décide de donner pouvoir à tout employé d’Intertrust (Luxembourg) S.à r.l. et de Maître Jean-Paul
MEYERS, chacun d’eux agissant individuellement:
(i) de faire et d’exécuter toutes les formalités nécessaires afin de compléter et d’enregistrer les déclarations fiscales
manquantes de la Société y compris, mais non limitativement, les déclarations fiscales relatives aux exercices sociaux 2014
et 2015; et
(ii) de faire tout ce qui est requis en relation avec la clôture de la liquidation de la Société, ces pouvoirs expirant une (1)
année après la clôture de la liquidation de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la demande de l’Associé Unique, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l’Associé Unique.
Signé: A. Guerini, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 2 octobre 2015. Relation: EAC/2015/22950. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): Amédé SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 2 octobre 2015.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2015165429/121.
(150182392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
DIH/HMD Investco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 110.458.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second of September.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned;
THERE APPEARED:
DIH Finanz und Consult GmbH, a “Gesellschaft mit beschränkter Haftung- incorporated and existing under the laws
of Germany, having its registered office at Rossertstraße 18, D-60323 Frankfurt am Main, Germany registered with the
Trade Register of Frankfurt am Main under number HRB 47603, being the owner of 100 shares of the Company, repre-
senting 100 % of the Company’s issued share capital (the “Sole Shareholder”),
here duly represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, professionally residing in Junglinster, Grand-Duchy of Lu-
xembourg by virtue of a proxy given under private seal.
Said power after being signed “ne varietur” by the empowered and the officiating notary shall remain attached to the
present deed.
Such appearing party, acting in his capacity, declares and requests the notary to act:
153776
L
U X E M B O U R G
1.- That the private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) “DIH/HMD InvestCo S.à r.l.” duly
incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13,
Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500 and registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register of Luxembourg (“Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg”), section B, under the number 110.458 (hereinafter referred to as the “Company”) has been incorporated pursuant
to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, of 16 August
2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 100 of 1 January 2006. The articles
of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of Maître Carlo Wersandt, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 5 December 2011, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations under number 143 of 18 January 2012.
2.- That the share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.) divided into one
hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.-) each.
3.- That the Sole Shareholder, represented as mentioned above, is the sole owner of all the shares of the Company.
4.- That the Sole Shareholder, represented as mentioned above, acting as Sole Shareholder of the Company declares the
dissolution of the Company with immediate effect.
5.- That the Sole Shareholder, represented as mentioned above, appoints itself as liquidator of the Company; and in its
capacity as liquidator of the Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make
any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed and confirms having
provided the extraordinary general meeting with the liquidator report dated as of today.
6.- That the Sole Shareholder, represented as mentioned above, and in its capacity as liquidator of the Company declares
that he irrevocably undertakes to settle any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved company.
7.- That the Sole Shareholder, represented as mentioned above, declares that it takes over all the assets of the Company,
and that it will assume any existing debt of the Company pursuant to section 6.
8.- That the Sole Shareholder, represented as mentioned above, declares that the liquidation of the Company is closed
and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.
9.- That discharge is given to all of the managers of the Company.
10.- That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least in Luxembourg at 6,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
<i>Costsi>
The amount of costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and
charged to it by reason of the present deed is therefore estimated at one thousand Euro (EUR 1,000.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The present notarial deed was drawn up in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the person appearing, they signed the present deed together with the notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-deux septembre.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;
A COMPARU:
DIH Finanz und Consult GmbH, une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le loi d’Allemagne, ayant
son siège social au Rossertstraße 18, D-60323 Frankfurt am Main, Allemagne, immatriculée au Registre du société en
Frankfurt am Main sous le numéro HRB 47603, propriétaire de 100 parts sociales de la Société représentant 100% du
capital social émis la Société («L’Associé Unique»),
dûment représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement au Junglinster, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
aux présentes.
Laquelle partie comparante déclare et requiert, par son mandataire, le notaire instrumentant d'acter:
1.- Que la société à responsabilité limitée «DIH/HMD InvestCo S.à r.l.», constituée sous les lois de la Grand-Duché de
Luxembourg ayant son siège social à 13, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec un capital social de 12.500 EUR et
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 110.458, (ci-après dénommée la
"Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de
153777
L
U X E M B O U R G
Luxembourg le 16 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 100 le 1 janvier
2006. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suite à un acte de Maitre Carlo Wersandt, notaire de
résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, du 5 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations sous le numéro 143 le 18 janvier 2012.
2.- Que le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts
sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euro (EUR 125,-) chacune.
3.- Que L’Associé Unique, représenté comme dit ci-avant, est seul propriétaire de toutes les parts sociales de la Société.
4.- Que L’Associé Unique, représenté comme dit ci-avant, agissant comme associé unique, prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat.
5.- Que L’Associé Unique, représenté comme dit ci-avant, se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins
pouvoirs d’établir, signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est
nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte et confirme avoir fourni le assemblée générale
extraordinaire le rapport de liquidateur à la date d'aujourd'hui.
6.- Que L’Associé Unique, représenté comme dit ci-avant, déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif présent
et futur de la société dissoute.
7.- Que L’Associé Unique, représenté comme dit ci-avant, déclare qu’il reprend tout l’actif de la Société et qu’il s’en-
gagera à régler tout le passif de la Société indiqué à la section 6.
8.- Que L’Associé Unique, représenté comme dit ci-avant, déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que
tous les registres de la Société relatifs à l’émission de parts sociales ou de tous autres titres seront annulés.
9.- Que décharge est donnée aux gérants de la Société.
10.- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à 6, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à
raison de cet acte, est dès lors évalué à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont Acte était passé à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 24 septembre 2015. Relation GAC/2015/8136. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Claire PIERRET.
Référence de publication: 2015165353/110.
(150182711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
Domolux Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 187.289.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015165356/10.
(150181964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
IEE Management S.C., Société Civile.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg E 5.669.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 28 septembre 2015i>
En date du 28 septembre 2015 l'assemblée générale extraordinaire de la Société à pris les résolutions suivantes:
- d'accepter les personnes suivantes en tant que nouveaux associés de la Société:
153778
L
U X E M B O U R G
1. Aloyse Schoos, né le 28 novembre 1953 à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 11, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
2. Michel Hartmann, né le 7 juillet 1962 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 11, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
3. Clemens Damschen, né le 17 août 1967 à Wesel, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 11,
rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
4. Ciaus Kedenburg, né le 13 mars 1966 à Berlin-Charlottenburg, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse
suivante: 11, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
5. Manfred Boeffgen, né le 5 septembre 1957 à Trèves, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse suivante:
11, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
6. Hans-Joachim Sommer, né le 25 juillet 1974 à Goettingen, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse
suivante: 11, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
7. Frank Althaus, né le 21 avril 1971 à Neunkirchen, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 11,
rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
8. Werner Bieck, né le 7 février 1961 à Lambrecht, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 11,
rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
9. Thierry Goniva, né le 15 janvier 1971 à Esch-sur-AIzette, Grand-Duché de Luxembourg, résidant professionnellement
à l'adresse suivante: 11, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
10. Thomas Gruenen, né le 18 juillet 1965 à Trèves, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 11,
rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
11. Stefan Habermehl, né le 4 janvier 1970 à Worms, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 11,
rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
12. Hans-Richard Johanns, né le 17 mars 1970 à Bitburg, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse suivante:
11, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
13. Paul-Henri Kayser, né le 27 décembre 1969 à Arlon, Belgique, résidant professionnellement à l'adresse suivante:
11, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
14. Christophe Keiser, né le 28 novembre 1973 à Phalsbourg, France, résidant professionnellement à l'adresse suivante:
11, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
15. Peter Knips, né le 31 mai 1974 à Koblenz, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 11, rue
Edmond Reuter, L-5326 Contern;
16. Laurent Lamesch, né le 4 septembre 1971 à Petange, Grand-Duché de Luxembourg, résidant professionnellement
à l'adresse suivante: 11, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
17. Albert Meiers, né le 25 février 1967 à Neuerburg, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse suivante; 11,
rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
18. Alain Molitor, né le 22 août 1964 à Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 11, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
19. Kai Pabelick, né le 20 juillet 1973 à Cologne, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 11, rue
Edmond Reuter, L-5326 Contern;
20. Alain Schumacher, né le 12 novembre 1964 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant professionnel-
lement à l'adresse suivante: 11, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
21. Christian Theiss, né le 4 octobre 1977 à Eupen, Belgique, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 11, rue
Edmond Reuter, L-5326 Contern;
22. Martin Thinnes, né le 18 décembre 1965 à Saarbruecken, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse sui-
vante: 11, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
23. Walter Thyssen, né le 19 octobre 1973 à Eupen, Belgique, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 11, rue
Edmond Reuter, L-5326 Contern;
24. Weiguo Zhan, né le 29 septembre 1973 à Nei Mongol, Chine, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 11,
rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
25. Stefan Goebel, né le 29 octobre 1965 à Trèves, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 11,
rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;
26. Seung-Hoon Song, né le 13 octobre 1963 à Seoul, Corée du Sud, résidant professionnellement à l'adresse suivante:
11, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern; et
27. Joerg Weisgerber, né le 2 février 1971 à Saarlouis, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse suivante:
11, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern.
- d'augmenter le capital de la Société d'un montant de trois millions cinq cent quatre-vingt-un mille neuf cent trente-six
euros (EUR 3.581.936) de son montant actuel de deux euros (EUR 2) à trois millions cinq cent quatre-vingt-un mille neuf
cent trente-huit euros (EUR 3.581.938);
153779
L
U X E M B O U R G
- de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:
Art. 6. The issued capital of the Company is set at three million five hundred eighty-one thousand nine hundred thirty-
eight euro (EUR 3,581,938) divided into three million five hundred eighty-one thousand nine hundred thirty-eight
(3,581,938) shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each.
The issued capital of the Company may be increased by successive payments by the shareholders or the admission of
new shareholders. Any amendment of the issued capital is of the competence of general meeting of shareholders which
shall resolve at the majority set forth at article 14 of the present articles."
Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à la somme de trois millions cinq cent quatre-vingt-un mille neuf cent trente-
huit euros (EUR 3.581.938) divisé en trois millions cinq cent quatre-vingt-un mille neuf cent trente-huit (3.581.938) parts
sociales d'un euro (EUR 1) chacune.
Le capital social souscrit de la Société est susceptible d'augmentation par versements successifs des associés ou l'ad-
mission d'associés nouveaux. Toute modification du capital social souscrit relève de la compétence de l'assemblée générale
des associés qui statuera à la majorité prévue à l'article 14 des présents statuts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2015.
IEE Management S.C.
Signature
Référence de publication: 2015165522/84.
(150182095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
IK Small Cap Management, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Pouderie.
R.C.S. Luxembourg B 195.447.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2015.
Référence de publication: 2015165524/10.
(150181916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
J. Safra Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 575.680.838,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 144.056.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 31 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
° 253 du 5 février 2009.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Safra Holdings Luxembourg S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015165540/15.
(150181958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
Formula Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 65.487.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015165440/9.
(150181874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
153780
L
U X E M B O U R G
FLASHiZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 161.979.
Veuillez prendre note des changements suivants suite à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui
s'est tenue en date de 19 juin 2015:
- A compter du 01 mai 2015, le siège social de la société se situe au REGUS Business Center, 26 Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg.
1. Renouvellement du mandat de Monsieur Gavin O'Neill jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.
2. Renouvellement du mandat de Monsieur Dermot O'Shea jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.
3. Renouvellement du mandat de Monsieur Pascal Brasseur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.
4. Renouvellement du mandat de Monsieur Chung Yaw Tan jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.
5. Renouvellement du mandat de «Ernst & Young S.A.» comme commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale
qui se tiendra en l'année 2016.
Veuillez prendre note des changements suivants suite au conseil d'administration de la Société qui s'est tenu en date du
29 mai 2015:
- Nomination de Monsieur Denis McCarthy, né le 23 juin 1978 à Cork, Irlande et ayant pour adresse professionnelle
Iveragh Road, Killorglin, County Kerry, Irlande, en qualité d'Administrateur de la Société, jusqu'à l'assemblée générale
qui se tiendra en l'année 2016 à compter du 19 juin 2015.
- Démission de Monsieur Walter Brazil en qualité d'Administrateur de la Société à compter du 19 juin 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
Référence de publication: 2015165438/26.
(150182018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
Frides S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 73.923.
<i>Extrait de la résolution prise par l’actionnaire unique en date du 05 octobre 2015i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 octobre 2015.
<i>Pour Frides S.A.
L'administrateur uniquei>
Référence de publication: 2015165445/13.
(150182057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
KPS Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 194.961.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth of September.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
Was held
an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of “KPS Holding S.A.”, a public limited company
(“société anonyme”) incorporated and existing under Luxembourg laws, having its registered office in L-1466 Luxembourg,
4, rue Jean Engling, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under the number 194961
(the “Company”), incorporated on February 11, 2015 pursuant to a deed of Me Henri HELLINCKX, notary residing in
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 968 of April 10, 2015. The articles
of incorporation of the Company (the “Articles”) have been amended on August 7, 2015 pursuant to a deed of the officiating
notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Meeting was opened at 2.30 p.m. CET, with Mrs Carine GRUNDHEBER, employee, residing professionally in
Luxembourg, being in the chair (the “Chairman”).
153781
L
U X E M B O U R G
The Chairman appointed as secretary and the Meeting elected as scrutineer Mrs Maria TKACHENKO, company director,
residing professionally in Luxembourg.
The Chairman, the secretary and the scrutineer composing together the “Board”.
The Board of the Meeting having been validly constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the Meeting is as follows (the “Agenda”):
<i>Agendai>
1. Amendment to Article 5.2 and 6. of the Company’s articles of association in order to read as follows:
Art. 5.2. Authorized share capital.
5.2.1 The Company’s authorized share capital, excluding the issued share capital, is fixed at two million five hundred
thousand US Dollar (USD 2,500,000.-), consisting of two thousand five hundred (2.500,-) shares having a par value of one
thousand US Dollar (USD 1,000.-) per share, with such rights and terms and conditions attached thereto as determined by
the Board, whether they be mandatory redeemable preference share (the "MRPS") or ordinary shares (the "Ordinary Shares",
and together with the MRPS, the "Shares") or such other class or tranche of shares as the Board of Directors may deem
appropriate, each of which may relate to a separate portfolio of assets constituting a separate investment bearing in mind
that the aggregate amount of MRPS, regardless of their class or tranche, shall at all times represent less than (and at most)
half of the Company's share capital, in compliance with article 44 of the Law of 10 August 1915 governing commercial
companies, as amended.
5.2.2 The Board of Directors, is authorised, during a period ending five years ending on September 28, 2020 to:
- realise any increase of the subscribed share capital within the limits of the authorised share capital in one or several
times, by the issuing of new Shares regardless of their tranche, against payment in cash or in kind, by conversion of claims,
by the increase of the par value of existing Shares or in any other manner;
- determine the terms and conditions of any such increase and, more specifically, but not limited to, the place and date
of the issue or the successive issues, the issue price, the amount of new Shares to be issued, whether the new Shares are to
be issued and subscribed, with or without an issue premium and the terms and conditions of the subscription of and paying
up of the new Shares (in cash or in kind);
- limit or waive the preferential subscription right reserved to the then existing shareholder(s) in case of issue of Shares
against payment in cash.
5.2.3 After each increase of the subscribed share capital according to the above, articles 5.1.1 and 5.2.1 shall be amended
to reflect such increase.
5.2.4 This authorization may be renewed once or several times by a resolution of the general meeting of shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time for a period not exceeding five
(5) years.
5.2.5 The Company’s authorized share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of
shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”
“ Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2 The Company may have one or several shareholders.
6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by him/
her/it as the case may be in the same class or tranche of shares in the Company's share capital.
6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as the
case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.
6.5 The Company may, to the extent and under the terms and conditions provided by law, repurchase or redeem its own
shares.
6.6 The Company's shares are in registered form and may not be converted into shares in bearer form.
6.7 Fractional shares shall have the same rights on a fractional basis as whole shares, provided that shares shall only be
able to vote if the number of fractional shares may be aggregated into one or more whole shares. If there are fractions that
do not aggregate into a whole share, such fractions shall not be able to vote.
6.8 Classes of Shares - The Board of Directors may from time to time create different Classes of Shares, the subscription
proceed of which shall be invested in an individualised sub-portfolio of Investments, essentially allocated to a particular
Class of Shares, and entitling their holders to distributions essentially received by the Company and deriving from this sub-
portfolio of Investments. The losses, debt and liabilities incurred by the Company in relation with a particular Class of
Shares and the management of the sub-portfolio of Investments allocable to that Class of Shares shall be discharged in
priority out of the assets allocated to that Class of Shares.
However, if the losses exceed the value of the assets composing that sub-portfolio, this excess will be borne by the other
Classes of Shares pro rata of their participation in the aggregate Capital of all Classes of Shares within the Company, unless
a particular creditor has expressly agreed to limit its potential recourses against the sole assets of the Company that relate
153782
L
U X E M B O U R G
to the particular Class of Shares to which its claims are related. These provisions do not segregate the assets of the Company
into compartments enforceable in relation to third parties.”
II. The represented sole shareholder, the proxyholder of the represented sole shareholder and the number of its shares
are shown on an attendance list, which, signed “ne varietur” by the proxyholder of the represented sole shareholder, the
members of the Board of the Meeting and by the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at
the same time by the registration authority.
The proxy given by the represented sole shareholder, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the
represented sole shareholder, the members of the Board of the Meeting and by the officiating notary will also remain
annexed to the present deed.
III. It appears from the attendance list that the entire share capital of the Company is represented at the present extraor-
dinary general meeting, so that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the
agenda.
After deliberation, the following resolution was taken unanimously by the Meeting:
<i>Sole resolutioni>
The Meeting resolved to amend Article 5.2 and 6 of the Company’s articles of association which will henceforth read
as follows:
Art. 5.2. Authorized share capital.
5.2.1 The Company’s authorized share capital, excluding the issued share capital, is fixed at two million five hundred
thousand US Dollar (USD 2,500,000.-), consisting of two thousand five hundred (2.500,-) shares having a par value of one
thousand US Dollar (USD 1,000.-) per share, with such rights and terms and conditions attached thereto as determined by
the Board, whether they be mandatory redeemable preference share (the "MRPS") or ordinary shares (the "Ordinary Shares",
and together with the MRPS, the "Shares") or such other class or tranche of shares as the Board of Directors may deem
appropriate, each of which may relate to a separate portfolio of assets constituting a separate investment bearing in mind
that the aggregate amount of MRPS, regardless of their class or tranche, shall at all times represent less than (and at most)
half of the Company's share capital, in compliance with article 44 of the Law of 10 August 1915 governing commercial
companies, as amended.
5.2.2 The Board of Directors, is authorised, during a period ending five years ending on September 28, 2020 to:
- realise any increase of the subscribed share capital within the limits of the authorised share capital in one or several
times, by the issuing of new Shares regardless of their tranche, against payment in cash or in kind, by conversion of claims,
by the increase of the par value of existing Shares or in any other manner;
- determine the terms and conditions of any such increase and, more specifically, but not limited to, the place and date
of the issue or the successive issues, the issue price, the amount of new Shares to be issued, whether the new Shares are to
be issued and subscribed, with or without an issue premium and the terms and conditions of the subscription of and paying
up of the new Shares (in cash or in kind);
- limit or waive the preferential subscription right reserved to the then existing shareholder(s) in case of issue of Shares
against payment in cash.
5.2.3 After each increase of the subscribed share capital according to the above, articles 5.1.1 and 5.2.1 shall be amended
to reflect such increase.
5.2.4 This authorization may be renewed once or several times by a resolution of the general meeting of shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time for a period not exceeding five
(5) years.
5.2.5 The Company’s authorized share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of
shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”
“ Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2 The Company may have one or several shareholders.
6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by him/
her/it as the case may be in the same class or tranche of shares in the Company's share capital.
6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as the
case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.
6.5 The Company may, to the extent and under the terms and conditions provided by law, repurchase or redeem its own
shares.
6.6 The Company's shares are in registered form and may not be converted into shares in bearer form.
6.7 Fractional shares shall have the same rights on a fractional basis as whole shares, provided that shares shall only be
able to vote if the number of fractional shares may be aggregated into one or more whole shares. If there are fractions that
do not aggregate into a whole share, such fractions shall not be able to vote.
153783
L
U X E M B O U R G
6.8 Classes of Shares - The Board of Directors may from time to time create different Classes of Shares, the subscription
proceed of which shall be invested in an individualised sub-portfolio of Investments, essentially allocated to a particular
Class of Shares, and entitling their holders to distributions essentially received by the Company and deriving from this sub-
portfolio of Investments. The losses, debt and liabilities incurred by the Company in relation with a particular Class of
Shares and the management of the sub-portfolio of Investments allocable to that Class of Shares shall be discharged in
priority out of the assets allocated to that Class of Shares.
However, if the losses exceed the value of the assets composing that sub-portfolio, this excess will be borne by the other
Classes of Shares pro rata of their participation in the aggregate Capital of all Classes of Shares within the Company, unless
a particular creditor has expressly agreed to limit its potential recourses against the sole assets of the Company that relate
to the particular Class of Shares to which its claims are related. These provisions do not segregate the assets of the Company
into compartments enforceable in relation to third parties.”
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing persons,
this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing persons and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L’an deux mille quinze, le vingt-huit septembre,
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) des actionnaires de “KPS Holding S.A.”, une société anonyme
constituée sous et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 4, rue
Jean Engling, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 194961
(la “Société”), constituée le 11 février 2015 suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 968 du 10 avril 2015. Les statuts de la
Société (les “Statuts”) ont été modifies le 7 août 2015 suivant acte du notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'Assemblée a été ouverte à 14 heures 30 (CET) sous la présidence de Madame Carine GRUNDHEBER, employée
demeurant professionnellement à Luxembourg (le "Président").
Le Président a désigné comme secrétaire et l'Assemblée a élu comme scrutateur, Madame Maria TKACHENKO, ad-
ministrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président, le secrétaire et le scrutateur composent ensemble le bureau de l'Assemblée (le "Bureau").
Le Bureau valablement constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire d'établir:
I. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant (l' "Ordre du Jour"):
<i>Ordre du jouri>
1. Modification des articles 5.2 et 6. des statuts de la Société pour leur donner la teneur suivante:
Art. 5.2. Capital social autorisé.
5.2.1 Le capital autorisé de la Société, à l'exclusion du capital social souscrit, est fixé à deux millions cinq cent mille
US Dollar (USD 2.500.000, -), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions ayant une valeur nominale de mille US
Dollar (USD 1,000.-) chacune, ayant les droits et les conditions qui y sont attachés tel que le Conseil d’Administration
pourra le décider, qu'il s’agisse d’actions privilégiées obligatoirement rachetables (“APR”) ou d’actions ordinaires (les
«Actions Ordinaires», et avec les APR, les «Actions») ou relevant de telle classe ou tranche d'actions que le Conseil
d'administration jugera appropriée, traçant un portefeuille d'actifs distinct, en veillant toutefois à ce que le nombre total des
APR, quelle que soit leur classe ou tranche, n’excède jamais la moitié du capital social de la Société, conformément à
l'article 44 de la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
5.2.2 Le Conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 28 septembre 2020, à:
- réaliser toute augmentation du capital souscrit dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs fois, par l'émission
d’Actions nouvelles, quelle que soit de leur tranche, contre paiement en espèces ou en nature, par conversion de créances,
par l'augmentation de la valeur nominale des Actions existantes ou de toute autre manière;
153784
L
U X E M B O U R G
- déterminer les modalités et conditions d'une telle augmentation, et plus particulièrement, mais sans s'y limiter, le lieu
et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, le montant des nouvelles Actions à émettre, si les
nouvelles Actions seront émises et souscrites avec ou sans prime d'émission, et les termes et conditions de la souscription
et de la libération des nouvelles Actions (en numéraire ou en nature);
- limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires existant lors d'émission d'Actions
contre paiement en numéraire.
5.2.3 Après chaque augmentation du capital social souscrit en conformité avec ce qui précède, les articles 5.1.1 et 5.2.1
devront être adaptés afin de refléter ladite augmentation.
5.2.4 Cette autorisation pourra être renouvelée une ou plusieurs fois par une décision de l’assemblée générale des
actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts, pour une période qui, à chaque fois,
ne peut dépasser cinq (5) ans.
5.2.5 Le capital social autorisé de la Société pourra être augmenté ou diminué par une décision de l’assemblée générale
des actionnaires, statuant aux conditions requises pour une modification des présents statuts.”
“ Art. 6. Actions.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en actions ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaire(s).
6.3 Le droit d'un actionnaire dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre d’actions qu'il
détient, le cas échéant, dans une classe ou une tranche particulière d’actions, dans le capital social de la Société.
6.4 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre événement similaire concernant tout actionnaire ou
l'actionnaire unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.
6.5 La Société pourra, aux conditions et termes prévus la loi, racheter ou retirer ses propres actions.
6.6 Les actions de la Société sont émises sous forme nominative et ne peuvent être converties en actions au porteur.
6.7 Les fractions d’actions auront les mêmes droits que les actions entières sur une base proportionnelle, étant entendu
qu’une ou plusieurs actions ne pourront voter que si le nombre des fractions d’actions peut être réuni en une ou plusieurs
actions. Dans le cas où des fractions d’actions ne pourront pas être réunies en une action entière, de telles fractions d’actions
ne pourront pas voter.
6.8 Classes d’actions - Le Conseil d'administration peut, de temps à autre, créer différentes classes d'actions, dont le
prix de souscription sera investi dans un portefeuille individualisé d’investissements et attaché à une Classe particulière
d'Actions, et donnant droit à leur propriétaire aux distributions de l'essentiel des revenus et produits revenant à la Société
au titre de ce portefeuille d'investissements. Les pertes, dettes et autres passifs encourus par la Société en relation avec une
Classe particulière d'Actions et par la gestion du portefeuille particulier d’investissements attribuable à cette Classe parti-
culière d'Actions, seront mis en priorité à charge des actifs relevant de cette Classe d'Actions.
Toutefois, si les pertes dépassent la valeur des actifs composant ce portefeuille, cet excédant sera supporté par les autres
Classes d'Actions au prorata de leur participation dans le capital global de la Société, toutes Classes d'Actions confondues,
à moins qu'un créancier particulier n’ait expressément accepté de limiter ses recours contre les seuls actifs de la Société
attribuables à la Classe particulière d'Actions à laquelle ses créances sont liées. Ces dispositions ne ségrégent pas les actifs
de la Société en compartiments opposables aux tiers.”
II. L’actionnaire unique représenté, le mandataire de l’actionnaire unique représenté et le nombre d’actions qu'il possède
sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de l’actionnaire
unique représenté, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
les besoins de l’enregistrement.
Restera également annexée aux présentes, la procuration de l’actionnaire unique représenté, après avoir été signée “ne
varietur” par le mandataire de l’actionnaire unique représenté, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instru-
mentant.
III. Il ressort de la liste de présence que l’intégralité du capital social de la Société est représentée à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur
les points portés à l’ordre du jour.
Après délibération, l’Assemblée a pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’Assemblée a décidé de modifier les articles 5.2. et 6 des statuts de la Société, qui devront désormais être lus comme
suit:
Art. 5.2. Capital social autorisé.
5.2.1 Le capital autorisé de la Société, à l'exclusion du capital social souscrit, est fixé à deux millions cinq cent mille
US Dollar (USD 2.500.000, -), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions ayant une valeur nominale de mille US
Dollar (USD 1,000.-) chacune, ayant les droits et les conditions qui y sont attachés tel que le Conseil d’Administration
pourra le décider, qu'il s’agisse d’actions privilégiées obligatoirement rachetables (“APR”) ou d’actions ordinaires (les
«Actions Ordinaires», et avec les APR, les «Actions») ou relevant de telle classe ou tranche d'actions que le Conseil
153785
L
U X E M B O U R G
d'administration jugera appropriée, traçant un portefeuille d'actifs distinct, en veillant toutefois à ce que le nombre total des
APR, quelle que soit leur classe ou tranche, n’excède jamais la moitié du capital social de la Société, conformément à
l'article 44 de la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
5.2.2 Le Conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 28 septembre 2020, à:
- réaliser toute augmentation du capital souscrit dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs fois, par l'émission
d’Actions nouvelles, quelle que soit de leur tranche, contre paiement en espèces ou en nature, par conversion de créances,
par l'augmentation de la valeur nominale des Actions existantes ou de toute autre manière;
- déterminer les modalités et conditions d'une telle augmentation, et plus particulièrement, mais sans s'y limiter, le lieu
et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, le montant des nouvelles Actions à émettre, si les
nouvelles Actions seront émises et souscrites avec ou sans prime d'émission, et les termes et conditions de la souscription
et de la libération des nouvelles Actions (en numéraire ou en nature);
- limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires existant lors d'émission d'Actions
contre paiement en numéraire.
5.2.3 Après chaque augmentation du capital social souscrit en conformité avec ce qui précède, les articles 5.1.1 et 5.2.1
devront être adaptés afin de refléter ladite augmentation.
5.2.4 Cette autorisation pourra être renouvelée une ou plusieurs fois par une décision de l’assemblée générale des
actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts, pour une période qui, à chaque fois,
ne peut dépasser cinq (5) ans.
5.2.5 Le capital social autorisé de la Société pourra être augmenté ou diminué par une décision de l’assemblée générale
des actionnaires, statuant aux conditions requises pour une modification des présents statuts.”
“ Art. 6. Actions.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en actions ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaire(s).
6.3 Le droit d'un actionnaire dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre d’actions qu'il
détient, le cas échéant, dans une classe ou une tranche particulière d’actions, dans le capital social de la Société.
6.4 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre événement similaire concernant tout actionnaire ou
l'actionnaire unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.
6.5 La Société pourra, aux conditions et termes prévus la loi, racheter ou retirer ses propres actions.
6.6 Les actions de la Société sont émises sous forme nominative et ne peuvent être converties en actions au porteur.
6.7 Les fractions d’actions auront les mêmes droits que les actions entières sur une base proportionnelle, étant entendu
qu’une ou plusieurs actions ne pourront voter que si le nombre des fractions d’actions peut être réuni en une ou plusieurs
actions. Dans le cas où des fractions d’actions ne pourront pas être réunies en une action entière, de telles fractions d’actions
ne pourront pas voter.
6.8 Classes d’actions - Le Conseil d'administration peut, de temps à autre, créer différentes classes d'actions, dont le
prix de souscription sera investi dans un portefeuille individualisé d’investissements et attaché à une Classe particulière
d'Actions, et donnant droit à leur propriétaire aux distributions de l'essentiel des revenus et produits revenant à la Société
au titre de ce portefeuille d'investissements. Les pertes, dettes et autres passifs encourus par la Société en relation avec une
Classe particulière d'Actions et par la gestion du portefeuille particulier d’investissements attribuable à cette Classe parti-
culière d'Actions, seront mis en priorité à charge des actifs relevant de cette Classe d'Actions.
Toutefois, si les pertes dépassent la valeur des actifs composant ce portefeuille, cet excédant sera supporté par les autres
Classes d'Actions au prorata de leur participation dans le capital global de la Société, toutes Classes d'Actions confondues,
à moins qu'un créancier particulier n’ait expressément accepté de limiter ses recours contre les seuls actifs de la Société
attribuables à la Classe particulière d'Actions à laquelle ses créances sont liées. Ces dispositions ne ségrégent pas les actifs
de la Société en compartiments opposables aux tiers.”
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, lesdits com-
parants ont signé avec Nous, le notaire, la présente minute.
Signé: C. GRUNDHEBER, M. TKACHENKO, C. WERSANDT.
153786
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 01 octobre 2015. 2LAC/2015/21955. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Référence de publication: 2015165574/302.
(150182484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.
ContourGlobal Spain Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 186.508.
Les comptes annuels de la société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2015.
Référence de publication: 2015164478/11.
(150181742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Cooperstown S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 160.725.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société, par décision du 24 septembre 2015, a décidé d'accepter la démission de Jabir Chakib en
tant que gérant de la Société, avec effet au 30 septembre 2015.
L'associé unique a décidé de nommer la personne suivante en tant que gérant de la Société avec effet au 30 septembre
2015 et pour une durée indéterminée:
- Juliette Caliste, résidant professionnellement au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Cooperstown S.à r.l.i>
Référence de publication: 2015164479/16.
(150181497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Corum Group International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 76.784.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale des Associés tenue en date du 2 octobre 2015, a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Aleksandra Teresa Lipinski-Hauck, en tant que gérant B, est constatée avec effet au 21 août 2015;
- La nomination de Salvatore Rosato, en tant que gérant B; avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg, est acceptée avec effet au 21 août 2015 et pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 2 octobre 2015.
Référence de publication: 2015164480/15.
(150181484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
153787
L
U X E M B O U R G
Cabinet Comptable et Fiscal du Sud S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 37, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 56.464.
<i>Extrait d’acte du 06 octobre 2015i>
- Démission de l’administrateur délégué
Madame BIAGIONI Liviana - Comptable - demeurant 22 Rue des Erables L-4423 SOLEUVRE démissionne de son
poste d’administrateur et administrateur déléguée à compter de ce jour.
Fait à Esch/Alzette, le 06.10.2015.
BIAGIONI Liviana / GAMMAITONI Stefano.
Référence de publication: 2015164483/12.
(150181678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Crescent Point Energy Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 3.000.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 168.820.
EXTRAIT
La Société prend acte du changement de nom de Madame Marina LEBRUN, gérant de catégorie B de la Société. Elle
se nomme désormais Madame Marina KERNEUR.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2015.
Référence de publication: 2015164481/13.
(150181343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Cummingsville Fund S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 194.090.
Il est porté à la connaissance de tous que Vanessa MOLLOY, avec adresse au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxem-
bourg, a démissionné de sa fonction d’Administrateur de la Société avec effet au 30 Septembre 2015.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015164482/13.
(150181338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Cafina, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 50.317.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2015i>
Le mandat du réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers (B 65477), 2 rue Gerhard Mercator - L2182 Luxembourg,
est reconduit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes au 30 juin 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015164484/12.
(150180973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
153788
L
U X E M B O U R G
CSC Computer Sciences Luxembourg SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, Cloche d'Or, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 125.901.
<i>Extrait des résolutions prises par l’actionnaire unique en date du 22 septembre 2015i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire devant approuver les
comptes au 31 mars 2016:
- Monsieur H. C. Charles DIAO, demeurant au 900 North Stuart, #907 Arlington, Virginia 22203, États-Unis d'Amé-
rique, Président
- Monsieur Marc HEEREN, directeur général adjoint, demeurant 6, Sint-Michielsstraat, B-3020 Herent
- Monsieur Philippe JAEKEN, directeur général adjoint, demeurant 254 rue Grandchamp, B-1150 Woluwe-Saint-Pierre
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 6 octobre 2015.
Référence de publication: 2015164520/16.
(150181360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Cam Luxembourg G.m.b.h., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-7374 Bofferdange, 241, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 136.202.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUDWIG & MALDENER SARL
<i>EXPERTS COMPTABLES - FIDUCIAIRE
i>31, OP DER HECKMILL - L-6783 GREVENMACHER
Signature
Référence de publication: 2015164486/13.
(150181574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
CAP Communication, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.400.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 183.159.
Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015164489/9.
(150181480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Caribbean Property Investing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 96.560.
<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 octobre 2015i>
Ayant constaté le décès d’un administrateur, Monsieur Michel Lamy, les deux administrateurs ont procédé à la nomi-
nation provisoire par cooptation avec effet immédiat de la société @conseils S.à r.l, RCS B. 79257 avec siège social à
L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard Prince Henri dont le gérant est Monsieur Jean Bernard Zeimet résidant à L-2146
Luxembourg, 53 rue de Merl. Le mandat de la société @conseils Sà r.l prendra fin à l’Assemblée Générale annuelle de
2015.
Référence de publication: 2015164491/13.
(150181261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
153789
L
U X E M B O U R G
Hansteen Germany Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 108.365.
Veuillez prendre note du changement de l’adresse des associés suivants:
Hansteen Luxembourg S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 151 826
Hansteen Luxembourg Investments S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 151 825
Luxembourg, le 06 Octobre 2015.
<i>Pour Hansteen Germany Holdings S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2015164692/19.
(150181446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Cela Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 29, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 71.042.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015164493/9.
(150181418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Châtelet Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 81.099.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 octobre 2015 a nommé comme nouvel administrateur de la
société:
- Madame Nicole Thommes, née à Arlon (Belgique) le 28 octobre 1961, domiciliée professionnellement au 18 rue de
l'Eau, L-1449 Luxembourg;
en remplacement de Monsieur Sébastien Gravière.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2018.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015164495/15.
(150181277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Wallis Holding, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.172.844,00.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 174.216.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 28 septembre 2015i>
1. L’assemblée prend acte de la démission de la société Pylos Europe N.V., représentée par son représentant permanent
Monsieur Tom Deckers, de ses fonctions de gérant de catégorie A de la société, à compter du 31 août 2015.
2. L’assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant de catégorie A à compter du 31 août 2015 et ce pour une
durée indéterminée, Monsieur Patrick Vincent Boutens, né le 07 juin 1968 à Ostende (Belgique), demeurant profession-
nellement au 2A Populierendreef, B-2800 Mechelen (Belgique).
153790
L
U X E M B O U R G
L’assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant de catégorie B à compter du 31 août 2015 et ce pour une durée
indéterminée, Monsieur Edward De Nève, né le 21 décembre 1971 à Bruxelles, demeurant professionnellement au 51,
Groenstraat, B-1702 Groot-Bijgaarden (Belgique).
3. L’assemblée note le changement d’adresse du gérant de catégorie A, Vincent Boutens Sprl, domiciliée à présent au
2A, Populierendreef, B-2800 Mechelen (Belgique), et de son représentant permanent, Monsieur Patrick Vincent Boutens,
lui aussi domicilié professionnellement au 2A, Populierendreef, B-2800 Mechelen (Belgique)
A compter du 31 août 2015, le conseil de gérance se compose comme suit:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- Vincent Boutens Sprl, représentée par son représentant permanent, Monsieur Patrick Vincent Boutens
- Monsieur Patrick Vincent Boutens
<i>Gérants de catégorie B:i>
- RAMKO Sprl, représentée par son représentant permanent, Monsieur Edward De Nève
- Monsieur Edward De Nève
Luxembourg, le 6 octobre 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015165128/30.
(150181244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Châtelet Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 81.099.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015164496/9.
(150181278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Cibo Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 67.460.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015164499/9.
(150180900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
CIM Vision S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 115.381.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015164500/9.
(150180903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Clamartone S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 117.498.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
153791
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Luxembourg Corporation Company SA.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015164502/13.
(150181135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
East-West United Bank, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 10, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 12.049.
EXTRAIT
La liste des signatures autorisées de la banque datée du 2 octobre 2015 a été déposée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2015.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015164573/14.
(150181581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
PEP ESP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 149.395.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015164959/10.
(150181151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
PEP GCO Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 111.764.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015164960/10.
(150181222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Perform S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 76.182.
<i>Extrait du Conseil d’Administration du 4 mai 2015i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 4 mai 2015, que le siège social
est transféré au:
- 117, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg.
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2015164962/12.
(150181196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
153792
Cabinet Comptable et Fiscal du Sud S.A.
Cafina
Cam Luxembourg G.m.b.h.
CAP Communication
Caribbean Property Investing S.A.
Cela Sàrl
Châtelet Investissements S.A.
Châtelet Investissements S.A.
Cibo Finance S.A.
CIM Vision S.A.
Clamartone S.à r.l.
Congra Software S.à r.l.
Consorts EICH S.à r.l.
Continent 8 (Luxembourg) S.à r.l.
ContourGlobal Power Holdings S.A.
ContourGlobal Spain Holding S.à r.l.
Cooperstown S.à r.l.
Corum Group International S.à r.l.
Creavicab S.A.
Crescent Point Energy Lux S.à r.l.
CRH Cities Luxembourg Sàrl
CSC Computer Sciences Luxembourg SA
Cummingsville Fund S.A., SICAV-SIF
Delegation Management Corporate Sàrl
Des Glory Investments (Luxembourg), S.à r.l.
DevStrat S.A.
DeZaRo S.à.r.l.
DIH/HMD Investco S.à r.l.
Domolux Europe S.A.
D.S. Lux S.A.
East-West United Bank
Empé Immo S.A.
European Hotels and Leisure Sàrl
Evoleco
EZC Group S.A.
Fairfield 1 S.à r.l.
FF Investment Luxembourg 2 S.à r.l.
FFP Capital Partners S.à r.l.
FLASHiZ S.A.
Formula Partners S.A.
Frides S.A.
Hansteen Germany Holdings S.à r.l.
IEE Management S.C.
IK Small Cap Management
J. Safra Holdings Luxembourg S.à r.l.
KPS Holding S.A.
PEP ESP S.à r.l.
PEP GCO Co-Invest S.à r.l.
Perform S.A.
Wallis Holding