logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3167

21 novembre 2015

SOMMAIRE

Batiart S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152002

Batiglobal S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152003

Beauty Light S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152002

Besti's S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152004

Best of Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

152004

Best of Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

152004

BHS Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152005

Biochar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152005

BP Caplux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152005

Broker Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152006

Bryson SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152006

BTX Management S.à r.l. & Partners S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152007

Caetano S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152009

Camon Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152010

Capitole Development S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

152011

Cap Lounge S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152010

Care Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152006

Cartayat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152011

CC Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152012

CDCL S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152012

Central European Realty Corporation S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152008

Centuria Capital Luxembourg S.A. . . . . . . . . .

152009

Cheniclem S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152012

Chinto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152013

Climate Change Capital Carbon Fund II S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152005

CL Management SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152013

Corolla Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152014

Crawford Industries S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

152014

Creabois S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152014

Dana Manufacturing Luxembourg S.à r.l.  . . .

152015

Darmisa SPF, S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152008

Deloitte Audit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152010

Dixor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152016

D-VB Finapa S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152015

F.A.H. Invest S.A. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152004

firewall Management Hard Equity S.A.  . . . . .

151970

First Business Parks Holdings II S.à r.l.  . . . . .

151991

Gebäudereinigung Peifer S. à r.l.  . . . . . . . . . . .

152006

HSBC Trinkaus & Burkhardt (International)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152002

Impexsolar Company  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152010

New Way S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152013

Sentinel Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151997

Solver S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152016

Solver S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152016

SpongeVest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152015

151969

L

U X E M B O U R G

firewall Management Hard Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 200.413.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth of the month of September,
Before us, Maître Eduard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Firewall Investments S.A, a public limited company (société anonyme), incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg Trade and Companies Register under number B 191.622, having
its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Julia Szafranska, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Luxembourg, on 25 September 2015.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited company

(société anonyme) which they wish to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a public limited company (société anonyme) under the name Firewall Mana-

gement Hard Equity S.A. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds

a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities

or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of directors.

It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of directors.

4.4 In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000), represented by three million one

hundred thousand (3,100,000) shares having nominal value of one euro cent (EUR 0,01) each split as follows:

(a) one hundred thousand (100,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”);

151970

L

U X E M B O U R G

(b) three hundred thousand (300,000) class A redeemable shares (the “Class A Shares”);
(c) three hundred thousand (300,000) class B redeemable shares (the “Class B Shares”);
(d) three hundred thousand (300,000) class C redeemable shares (the “Class C Shares”);
(e) three hundred thousand (300,000) class D redeemable shares (the “Class D Shares”);
(f) three hundred thousand (300,000) class E redeemable shares (the “Class E Shares”);
(g) three hundred thousand (300,000) class F redeemable shares (the “Class F Shares”);
(h) three hundred thousand (300,000) class G redeemable shares (the “Class G Shares”);
(i) three hundred thousand (300,000) class H redeemable shares (the “Class H Shares”);
(j) three hundred thousand (300,000) class I redeemable shares (the “Class I Shares”); and
(k) three hundred thousand (300,000) class J redeemable shares (the “Class J Shares”)(the Class J Shares together with

Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H
Shares, Class I Shares, are collectively called the “Classes”).

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association or as set out in article 6 hereof.

5.3 Subject to Article 7, any new shares shall be offered by preference to the existing shareholders within the same Class

and/or holders of the Ordinary Shares, as the case may be. In case of plurality of shareholders, such shares shall be offered
to the shareholders in proportion to the number of shares held in each Class and/or the number of the Ordinary Shares held
by them in the Company’s share capital. The board of directors shall determine the period of time during which such
preferential subscription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch
of a registered letter sent to the shareholder(s) announcing the opening of the subscription period. The general meeting of
shareholders may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner required
for an amendment of these articles of association.

5.4 The Company shall establish separate equity contribution accounts for the Ordinary Shares and the Classes (the

"Premium Accounts"), on which any share premium paid on the respective class, as well as any assimilated premium
resulting from contributions to the Company without issuance of shares by holders of such class which were declared to
be made to such Premium Account shall be accounted for. Notwithstanding anything to the contrary herein, any distributions
of such amounts may only be made pro rata to the holders of the respective class.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 No Shares in a particular Class may be converted into shares of a different Class.
6.6 The shares of the Classes are redeemable shares in the sense of article 49-8 of the Law. Any redemption is subject

to the provisions of the Law and the following conditions:

- only fully paid up shares may be redeemed;
- the conditions set out in articles 6.7 to 6.12 of these articles of association are respected;
- the redemption can only be made by using sums available for distribution in accordance with Article 72-1 of the Law

or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption;

- an amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the par value, of all the shares redeemed must be

included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a capital reduction of the share
capital; such reserve may only be used to increase the issued share capital by capitalisation of reserves (such reserve is not
required in case of a redemption using the proceeds of a new issue made with a view to carry out such redemption); and

- the redemption is published in accordance with the Law.
6.7 The share capital of the Company may be reduced through the redemption and cancellation of one or more Classes,

in whole but not in part, consisting of the redemption and cancellation of all shares in issue in such Class.

6.8  A  reduction  of  share  capital  through  the  redemption  and  cancellation  of  a  Class  may  only  be  made  within  the

respective Class Periods (as defined below):

i. The period for the Class A Shares is the period starting on the date of the notarial deed of 28 September 2015 and

ending no later than on 31 December 2016 (the “Class A Period”).

ii. The period for the Class B Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on no later

than 31 December 2017 (the “Class B Period”).

iii. The period for the Class C Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending no later than

on 31 December 2018 (the “Class C Period”).

151971

L

U X E M B O U R G

iv. The period for the Class D Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending no later than

on 31 December 2019 (the “Class D Period”).

v. The period for the Class E Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on no later

than 31 December 2020 (the “Class E Period”).

vi. The period for the Class F Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on no later

than 31 December 2021 (the “Class F Period”).

vii. The period for the Class G Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on no later

than 31 December 2022 (the “Class G Period”).

viii. The period for the Class H Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending no later than

on 31 December 2023 (the “Class H Period”).

ix. The period for the Class I Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no later than

on 31 December 2024 (the “Class I Period”).

x. The period for the Class J Shares is the period starting on the day after the Class I Period and ending no later than on

31 December 2025 (the “Class J Period”).

6.9 Where a Class has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the redemption and can-

cellation of such Class(es) can be made during a new period (the “New Period”) which shall start on the date after the last
Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately preceding New Period of another class) and
end no later than one year after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the day after the Class
J Period and the Class(es) not repurchased and not cancelled in their respective Class Period shall come in the order from
class A to class J (to the extent not previously repurchased and cancelled).

6.10 For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a Class shall take place prior to the

last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period (or as the case may
be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such Class and shall continue to end on the
day such as initially defined in the Articles above.

6.11 Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount will become due

and payable by the Company to the Shareholder(s) pro-rata to their holding in such class(es). For the avoidance of doubt
the Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.

6.12 For the purposes of these articles, the following capitalised terms shall have the following meanings:
“Available Amount” shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)

increased by (i) any freely distributable reserves (taking into account article 5.4 hereof) and (ii) as the case may be, by the
amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class to be cancelled but reduced by (i) any losses
(included carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requi-
rements of Law or of the articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt,
any double counting), (iii) any dividends to which the holders of the Ordinary Shares and the Founder Shares are entitled
pursuant to the articles and (iv) any Profit Entitlement so that:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR + OD + PE)
Whereby:
AA = Available Amount.
NP = net profits (including carried forward profits).
P = any freely distributable reserves.
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled.
L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive.
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the articles.
OD = any dividends to which the holders of the Ordinary Shares and the Founder Shares are entitled pursuant to the

articles.

PE = Profit Entitlement.
The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed by

the board of directors in good faith and with the view to the Company’s ability to continue as a going concern.

“Available Liquidities” shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining

maturity  exceeding  six  (6)  months),  (ii)  any  readily  marketable  money  market  instruments,  bonds  and  notes  and  any
receivable which in the opinion of the board of directors will be paid to the Company in the short term less any indebtedness
or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating
to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of
other kind held by the Company.

“Cancellation Amount” shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period

(or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available Liquidities
relating to the relevant Class Period (or New Period). The Cancellation Amount shall be determined by the board of directors
in the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, the holders of the Founder Shares shall only be

151972

L

U X E M B O U R G

entitled to the amounts in accordance with these articles, in particular described in section 28.7 and 30.2. The board of
directors can choose at its sole discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount the freely
distributable reserves either in part or in totality (always subject to taking into account article 5.4 hereof).

“Class Period” shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period, the

Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I Period and the Class J Period.

“Interim Accounts” shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
“Interim Account Date” shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before the

date of the repurchase and cancellation of the relevant Class.

“Profit Entitlement” shall mean the fixed preferred dividend amounts payable to the holders of Classes in accordance

with article 28.6 hereof.

Art. 7. Authorised capital.
7.1 The authorised capital, excluding the share capital, is set at two million two hundred thousand euro (EUR 2,200,000)

represented by two hundred twenty million (220,000,000) shares having nominal value of one cent (EUR 0.01) (excluding
the issued share capital), consisting of:

(a) twenty million (20.000.000) Ordinary Shares;
(b) twenty million (20.000.000) Class A Shares;
(c) twenty million (20.000.000) Class B Shares;
(d) twenty million (20.000.000) Class C Shares;
(e) twenty million (20.000.000) Class D Shares;
(f) twenty million (20.000.000) Class E Shares;
(g) twenty million (20.000.000) Class F Shares;
(h) twenty million (20.000.000) Class G Shares;
(i) twenty million (20.000.000) Class H Shares;
(j) twenty million (20.000.000) Class I Shares; and
(k) twenty million (20.000.000) Class J Shares.
During a period of time of five (5) years from the date of the publication of these articles of association or, as the case

may be, of the resolution to renew or to increase the authorised capital pursuant to this article, the board of directors is
hereby authorised to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible
into shares within the limits of the authorised capital to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically
to proceed to such issue without reserving a preferential right to subscribe to the shares issued for the existing shareholders
in accordance with any shareholders agreement. Such authorisation may be renewed through a resolution of the general
meeting of the shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time
for a period not exceeding five (5) years.

7.2 The authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders adopted in the manner required for amendments of these articles of association.

Art. 8. Founder shares.
8.1 The Company has issued one hundred thousand (100,000) founder shares (parts bénéficiaires), each having a nominal

value of one cent (EUR 0.01) which do not represent the share capital of the Company and which do not confer any rights
to the holders thereof save for the ones set out in these articles in particular in articles 8, 13, 14 and 15 as well as in sections
11.4, 20.4, 28.7 and 30.2 (the “Founder Shares”).

8.2 The Founder Shares are issued in registered form. The number of the Founder Shares issued shall be registered in

a register of the Founder Shares held at the registered office of the Company, which will show the name and residence of
the holders of the Founder Shares as well as the number of the Founder Shares held by them. Ownership of the Founder
Shares is established by registration in said register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the
expense of the relevant holder with such certificates, however, not serving as evidence of ownership. Any such certificate
of the Founder Shares shall be signed by any director of the Company.

8.3 All notices and announcements to holders of the Founder Shares shall be sent to the address detailed in the above

mentioned register. In the event that a holder of a Founder Share does not provide an address, the Company may permit a
note to this effect to be entered in the register and the holder of the Founder Share’s address will be deemed to be at the
registered office of the Company or at such other address as may be so inscribed in the register by the Company from time
to time, until another address shall be provided to the Company by the holder of the Founder Share.

8.4 Holders of the Founder Shares shall be entitled to participate in any general meeting of shareholders and be convened

in the same manner as shareholders. Notwithstanding anything to the contrary herein, the Founder Shares are required to
be present for any quorum of any general meetings of shareholders. The Founder Shares shall carry two point thirty-three
(2.33) times (pro rata among the Founder Shares, and rounded to the full numbers) the number of votes of all Ordinary
Shares and the Classes issued from time to time for every proposed resolution of the Company taken in any ordinary or
extraordinary general meeting of shareholders of the Company.

151973

L

U X E M B O U R G

8.5 Articles 12.3, 12.4, 12.5 apply mutatis mutandis.

Art. 9. Register of shares - Transfer of shares.
9.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of shares is established
by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of the
relevant shareholder.

9.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

9.3 Subject to the transfer rules (i.e. mandatory transfer, tag-along rights and drag-along rights) in any shareholders

agreement, the shares are freely transferable in accordance with the provisions of the Law.

9.4 Any transfer of registered shares shall become effective (opposable) towards the Company and third parties either

(i) through a declaration of transfer recorded in the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee
or their representatives, or (ii) upon notification of a transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company.

C. General meetings of shareholders

Art. 10. Powers of the general meeting of shareholders.
10.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted

general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The
general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of
association.

10.2 If the Company has only one shareholder, any reference made herein to the “general meeting of shareholders” shall

be construed as a reference to the “sole shareholder”, depending on the context and as applicable and powers conferred
upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

Art. 11. Convening of general meetings of shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or, as

the case may be, by the internal auditor(s).

11.2 It must be convened by the board of directors or the internal auditor(s) upon written request of one or several

shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting of
shareholders shall be held within a period of one (1) month from the receipt of such request.

11.3 The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of

the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of ten (10) days, and ten
(10) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper.
Notices by mail shall be sent ten (10) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this formality
has been complied with need be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by
registered letter only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days before the date
scheduled for the meeting.

11.4 If all of the shareholders and holders of the Founder Shares are present or represented at a general meeting of

shareholders and have waived any convening requirements, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 12. Conduct of general meetings of shareholders.
12.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on 15 

th

 of April at 10

AM. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other
meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices.

12.2 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary

and a scrutineer who need neither be shareholders nor members of the board of directors. The board of the meeting shall
especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the
rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

12.3 An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.
12.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing

or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even
all shareholders.

12.5 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile

or any other means of communication to the Company’s registered office or to the address specified in the convening notice.
The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of
the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal three
boxes allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate box.

151974

L

U X E M B O U R G

12.6 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the

proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account
voting forms received prior to the general meeting to which they relate.

Art. 13. Quorum and vote.
13.1 Each share entitles to one (1) vote per share in general meetings of shareholders.
13.2 For the avoidance of doubt, the Founder Shares entitle their holders to the rights and carry the number of votes as

listed in article 8.4 in general meetings of shareholders.

13.4 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of sha-

reholders duly convened shall not require any presence quorum (except for the presence of the holders of Founder Shares),
and shall be adopted at a simple majority of the votes validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions
and nil votes shall not be taken into account.

Art. 14. Amendments of the articles of association. Except as otherwise provided herein, these articles of association

may be amended by a majority of at least two thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of
more than half of the Company’s share capital and the Founder Shares are present or represented. If no quorum is reached
in a meeting, a second meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of association which may
deliberate regardless of the quorum (except that the presence of the holders of the Founder Shares is required) and at which
resolutions are taken at a majority of at least two thirds of the votes validly cast. Abstentions and nil votes shall not be
taken into account.

Art. 15. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent

(including the consent of the holders of Founder Shares).

Art. 16. Adjournment of general meeting of shareholders. Subject to the provisions of the Law, the board of directors

may adjourn any general meeting of shareholders for four (4) weeks. The board of directors shall do so at the request of
shareholders representing at least twenty percent (20%) of the share capital of the Company. In the event of an adjournment,
any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.

Art. 17. Minutes of general meetings of shareholders.
17.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by

the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.

17.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case
the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors or by any two
of its members.

D. Management

Art. 18. Composition and powers of the board of directors.
18.1 The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) and up to six (6) members.

However, where the Company has been incorporated by a single shareholder or where it appears at a shareholders’ meeting
that all the shares issued by the Company are held by a sole shareholder, the Company may be managed by a sole director
until the next general meeting of shareholders following the increase of the number of shareholders. In such case, to the
extent applicable and where the term “sole director” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference
to the “board of directors” used in these articles of association is to be construed as a reference to the “sole director”.

18.2 The board of directors is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfill the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or
by these articles of association to the general meeting of shareholders.

18.3 The Company grants a power of attorney to EPIC I GP S.à r.l., a private limited liability company (société à

responsabilité limitée), incorporated and exiting under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
address at 1, Boulevard de la Foire, L- 1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with Luxembourg
Company and Trade Register under number B 186.222 (the “Proxyholder”), acting individually and with full power of
substitution, to act on behalf of and represent the Company at any shareholders or interest holders’ meeting or resolution
in writing of any company, corporation, partnership or any other entity and/or any subsidiary thereof in which the Company
holds directly or indirectly shares, interests or any other participation in respect of (and only in this respect) (i) the ap-
pointment or dismissal of directors, managers or other members of any managing, governing and/or supervisory body for
which the Company is entitled to vote, and (ii) the amendment of the articles, partnership agreement or bylaws, as the case
may be, with respect to the appointment or dismissal of directors, managers or other members of any managing, governing
and/or supervisory body for which the Company is entitled to vote.

Art. 19. Daily management.
19.1 The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with such daily

management may, in accordance with article 60 of the Law, be delegated to one or more directors, officers or other agents,

151975

L

U X E M B O U R G

acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the board of
directors.

19.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 20. Appointment, removal and term of office of directors.
20.1 The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

20.2 The term of office of a director may not exceed six (6) years. Directors may be re-appointed for successive terms.
20.3 Each director is appointed by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.
20.4 Any director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of shareholders

at a simple majority of the votes validly cast, taking into account the voting rights of the Founder Shares set out in these
articles.

20.5 If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a private individual as

permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity
may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a
permanent representative of one (1) director of the Company and may not be a director of the Company at the same time.

Art. 21. Vacancy in the office of a director.
21.1 In the event of a vacancy in the office of a director because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced director by the remaining directors until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment in compliance with the applicable legal provisions and article 20.3.

21.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole director, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders in compliance with article 20.3.

Art. 22. Convening meetings of the board of directors.
22.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman, or by any director. Meetings of the board of directors

shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

22.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four (24) hours at least

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient
proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of directors which has been communicated to all directors.

22.3 No prior notice shall be required in case all the members of the board of directors are present or represented at a

board meeting and waive any convening requirements or in the case of resolutions in writing approved and signed by all
members of the board of directors.

Art. 23. Conduct of meetings of the board of directors.
23.1 The board of directors shall elect among its members a chairman. It may also choose a secretary who does not need

to be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.

23.2 The chairman shall chair all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may

appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority of directors present at any such meeting.

23.3 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing,

or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient
proof thereof. A director may represent one or more, but not all of the other directors.

23.4 Meetings of the board of directors may also be held by conference call or video conference or by any other means

of communication allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

23.5 The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or represented

at a meeting of the board of directors.

23.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. The chairman

shall not have a casting vote.

23.7 Save as otherwise provided by the Law, any director who has, directly or indirectly, an interest in a transaction

submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company’s interest, must inform the board of
directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant
director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest
must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item.

23.8 Where the Company comprises a single director, transactions made between the Company and the director having

an interest conflicting with that of the Company is only mentioned in the resolution of the sole director.

151976

L

U X E M B O U R G

23.9 The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of directors or the sole director relates

to current operations entered into under normal conditions.

23.10 The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each director may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.

23.11 The majority of the meetings of the board of directors shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg at the

registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such
meeting.

Art. 24. Minutes of the meeting of the board of directors - Minutes of the decisions of the sole director.
24.1 The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

chairman pro tempore, or by any two (2) directors. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial
proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by any two (2) directors.

24.2 Decisions of the sole director shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole director. Copies or

excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the sole director.

Art. 25. Dealing with third parties.
25.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the signature of the sole director, or,

if the Company has several directors, by the joint signature of any two (2) directors or by (ii) the signature of any person
(s) to whom such power may have been delegated by the board of directors within the limits of such delegation.

25.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of

any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits
of such delegation.

E. Audit and supervision

Art. 26. Auditor(s).
26.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general

meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office, which may not exceed
six (6) years.

26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

26.3 The internal auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the general meeting of shareholders of the Company appoints one or more independent auditor(s) (réviseur(s)

d’entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies
register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is sup-
pressed.

26.5  An  independent  auditor  may  only  be  removed  by  the  general  meeting  of  shareholders  with  cause  or  with  his

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 27. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 28. Annual accounts and allocation of profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors draws up an inventory of the

Company’s assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

28.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.

28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

28.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

28.5 Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

28.6 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid in the following order:
First to:
i. the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a dividend equal to 1% (one percent) of the nominal value of

the Class A Shares (rounded, if necessary);

151977

L

U X E M B O U R G

ii. the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a dividend equal to 2% (two percent) of the nominal value of

the Class B Shares (rounded, if necessary);

iii. the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a dividend equal to 3% (three percent) of the nominal value

of the Class C Shares (rounded, if necessary);

iv. the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a dividend equal to 4% (four percent) of the nominal value of

the Class D Shares (rounded, if necessary);

v. the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to 5% (five percent) of the nominal value of

the Class E Shares (rounded, if necessary);

vi. the holder(s) of the Class F Shares shall be entitled to a dividend equal to 6% (six percent) of the nominal value of

the Class F Shares (rounded, if necessary);

vii. the holder(s) of the Class G Shares shall be entitled to a dividend equal to 7% (seven percent) of the nominal value

of the Class G Shares (rounded, if necessary);

viii. the holder(s) of the Class H Shares shall be entitled to a dividend equal to 8% (eight percent)of the nominal value

of the Class H Shares (rounded, if necessary);

ix. the holder(s) of the Class I Shares shall be entitled to a dividend equal to 9% (nine percent) of the nominal value of

the Class I Shares (rounded, if necessary);

x. the holder(s) of the Class J Shares shall be entitled to a dividend equal to 10% (ten percent) of the nominal value of

the Class J Shares (rounded, if necessary);

Second to:
xi. the holder(s) of the Ordinary Shares shall be entitled to a dividend equal to 11% (eleven percent) of the nominal

value of the Ordinary Shares (rounded, if necessary)

Third to:
xii. the balance (less any amounts paid to the holders of the Founder Shares) shall be allocated to the holder(s) of the

Class Shares pursuant to a decision taken by the general meeting of shareholders.

28.7 In case of distribution, the holders of Founder Shares shall be entitled pro rata to zero point zero one per cent (0.01

%) of the Company’s annual net profits it being provided that such distribution shall be capped at ten (10) times of the
aggregate nominal value of the Founder Shares.

Art. 29. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
29.1 The board of directors may proceed to the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law and

these articles of association.

29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation.
30.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators  shall  have  the  most  extensive  powers  for  the  realisation  of  the  assets  and  payment  of  the  liabilities  of  the
Company.

30.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders as follows:

i. first each holder of the Classes shall receive an amount corresponding to the contribution (apport) of the Classes;
ii. second the holders of the Ordinary Shares and the holder of the Founder Shares shall receive an amount corresponding

to the nominal value of the Ordinary Shares and the nominal value of the Founder Shares respectively;

iii. out of the remaining surplus, the holders of the Ordinary Shares shall receive an amount corresponding to the higher

of 0.60% of the nominal value of the Ordinary Shares (rounded, if necessary), or twenty-five thousand euro (EUR 25,000);

iv. the remainder shall be distributed to holders of the Classes in proportion to the number of shares of the Company

held by them.

For the avoidance of doubt, the holders of the Founder Shares shall not be entitled to any distribution as described in

this article 30.2 (ii) and (iii).

H. Final clause - Governing law

Art. 31. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the Law and any agreement among shareholders. Inter partes any agreement among shareholders shall prevail to the extent
permitted by law.

151978

L

U X E M B O U R G

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2016.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2017.
3. Interim dividends may also be distributed during the Company’s first financial year.

<i>Subscription and payment

The three million one hundred thousand (3,100,000) shares divided into one hundred thousand (100,000) Ordinary

Shares; three hundred thousand (300,000) Class A Shares; three hundred thousand (300,000) Class B Shares; three hundred
thousand (300,000) Class C Shares; three hundred thousand (300,000) Class D Shares; three hundred thousand (300,000)
Class E Shares; three hundred thousand (300,000) Class F Shares; three hundred thousand (300,000) Class G Shares; three
hundred thousand (300,000) Class H Shares; three hundred thousand (300,000) Class I Shares; and three hundred thousand
(300,000) Class J Shares, have been subscribed by Firewall Investments S.A., aforementioned, for the price of thirty one
thousand euro (EUR 31,000).

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of thirty-one thousand

euro (EUR 31,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) is entirely allocated to the share capital.
The one hundred thousand (100,000) Founder Shares have been subscribed by Firewall Investments S.A., aforemen-

tioned, for the price of one thousand euro (EUR 1000). The Founder Shares so subscribed have been fully paid up by a
contribution in cash so that the amount of one thousand euro (EUR 1,000) is as of now available to the Company, as it has
been justified to the undersigned notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares that he has verified the existence of the conditions provided for or referred

to in articles 26 of the Law and expressly states that they have been complied with.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne

by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR
1,200,-).

<i>Resolutions of the shareholders

The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, have passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 1, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg;
2. The following person is appointed as independent auditor until the general meeting of shareholders convened to

approve the Company’s annual accounts for the first financial year:

Ernst &amp; Young Luxembourg, a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Company and trade Register under number B
88019, having its registered office at 7, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

The incorporating shareholder, represented by EPIC I GP S.à r.l., a private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée), incorporated and exiting under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address
at 1, Boulevard de la Foire, L- 1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with Luxembourg Company
and Trade Register under number B 186.222, here represented by Julia Szafranska, attorney-at-law, professionally residing
in Luxembourg, by virtue of a proxy, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has passed the following resolutions:

3. The following persons are appointed as directors of the Company until the annual meeting of shareholders of the

Company which will be held in year 2021:

Dan, Arendt, born in on 15 May 1961 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg residing at 42, op Fankenacker,

L-3265 Bettembourg;

Hubert Jacobs, Van Merlen, born on 27 August 1953 in Buenos- Aires, Argentina residing at 3 rue Belair, L-5318

Contern;

François, Pauly, born on 30 June 1964 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg residing at 57, rue Jean Schoetter,

L-2523 Luxembourg; and

Michael, Phillips, born in in St. Louis, USA on 1 February 1962, residing at 13, Possard Strasse, D-81679 München.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified in the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing parties and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

151979

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am achtundzwanzigsten September,
Vor uns, Maître Eduard Delosch, Notar mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Firewall Investments S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und bestehend unter dem Recht des

Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 191.622,
mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

hier vertreten durch Julia Szafranska, attorney-at-law, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom

25. September 2015, ausgestellt in Luxemburg.

Besagte Vollmacht, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem Notar ne varietur paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Aktiengesellschaft (société anonyme) zu

beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen wollen:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit dem Namen Firewall Management

Hard Equity S.A. (im Folgenden die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1  Zweck  der  Gesellschaft  ist  das  Halten  von  Beteiligungen  jeglicher  Art  an  luxemburgischen  und  ausländischen

Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher

Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen
und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie

solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke för-
derlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst

werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt wer-

den. Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art
und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Verwaltungsrates im Großher-

zogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Verwaltungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklun-

gen  aufgetreten  sind  oder  unmittelbar  bevorstehen,  welche  die  gewöhnlichen  Aktivitäten  der  Gesellschaft  an  ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen  Umstände  vorübergehend  ins  Ausland  verlegt  werden;  solche  vorübergehenden  Maßnahmen  haben  keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000), bestehend aus drei Millionen einhun-

derttausend (3.100.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01), welche wie folgt aufgeteilt sind:

151980

L

U X E M B O U R G

(a) einhunderttausend (100.000) Stammaktien (die „Stammaktien“);
(b) dreihunderttausend (300.000) rückkaufbare Aktien der Kategorie A (die „Aktien der Kategorie A“);
(c) dreihunderttausend (300.000) rückkaufbare Aktien der Kategorie B (die „Aktien der Kategorie B“);
(d) dreihunderttausend (300.000) rückkaufbare Aktien der Kategorie C (die „Aktien der Kategorie C“);
(e) dreihunderttausend (300.000) rückkaufbare Aktien der Kategorie D (die „Aktien der Kategorie D“);
(f) dreihunderttausend (300.000) rückkaufbare Aktien der Kategorie E (die „Aktien der Kategorie E“);
(g) dreihunderttausend (300.000) rückkaufbare Aktien der Kategorie F (die „Aktien der Kategorie F“);
(h) dreihunderttausend (300.000) rückkaufbare Aktien der Kategorie G (die „Aktien der Kategorie G“);
(i) dreihunderttausend (300.000) rückkaufbare Aktien der Kategorie H (die „Aktien der Kategorie H“);
(j) dreihunderttausend (300.000) rückkaufbare Aktien der Kategorie I (die „Aktien der Kategorie I“); und
(k) dreihunderttausend (300.000) rückkaufbare Aktien der Kategorie J (die „Aktien der Kategorie J“) (die Aktien der

Kategorie J zusammen mit den Aktien der Kategorie A, Aktien der Kategorie B, Aktien der Kategorie C, Aktien der
Kategorie D, Aktien der Kategorie E, Aktien der Kategorie F, Aktien der Kategorie G, Aktien der Kategorie H und Aktien
der Kategorie I die „Kategorien“).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für eine

Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, oder im Einklang mit Artikel 6 dieser Satzung erhöht oder
herabgesetzt werden.

5.3 Vorbehaltlich des Artikels 7 werden alle neuen Aktien bevorzugt den bestehenden Aktionären innerhalb der gleichen

Kategorie und/oder, je nach Fall, den Inhabern der Stammaktien angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Aktionären werden
diese Aktien den Aktionären im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen in der jeweiligen Kategorie gehaltenen Aktien und/
oder der Anzahl der von ihnen am Gesellschaftskapital gehaltenen Stammaktien angeboten. Der Verwaltungsrat bestimmt
den Zeitraum in dem dieses Vorzugsrecht ausgeübt werden kann und welcher nicht weniger als dreißig (30) Tage vom
Datum der Absendung eines an die Aktionäre gesendeten Einschreibens, welches die Eröffnung der Zeichnungsfrist an-
kündigt, beträgt. Die Hauptversammlung der Aktionäre kann das Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre durch einen
Beschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, begrenzen oder aufheben.

5.4 Die Gesellschaft errichtet für die Stammaktien und die Kategorien ein gesondertes Konto für Eigenkapitaleinlagen

(die „Agiokonten“), in welches jedes Agio für die jeweilige Kategorie, sowie alle anderen Kapitalreserven aus Einlagen
in die Gesellschaft ohne Ausgabe von Aktien durch die Inhaber der besagten Kategorie, die auf dieses Agiokonto erfolgen
sollten, eingestellt werden. Unbeschadet gegenteiliger Bestimmungen in dieser Satzung können Ausschüttungen solcher
Beträge nur anteilig an die Inhaber der jeweiligen Kategorie erfolgen.

Art. 6. Aktien.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Aktien mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Aktionär betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Aktien einer bestimmten Kategorie können nicht in Aktien einer anderen Kategorie umgewandelt werden.
6.6 Die Aktien der Kategorien sind rückkaufbare Aktien im Sinne des Artikels 49-8 des Gesetzes von 1915. Jeder

Rückkauf unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und den folgenden Bedingungen:

- nur vollständig eingezahlte Aktien können zurückgekauft werden;
- die Bedingungen in Artikel 6.7 bis 6.12 dieser Satzung sind einzuhalten;
- der Rückkauf kann nur mit Hilfe von Mitteln erfolgen, die nach Artikel 72-1 des Gesetzes von 1915 ausgeschüttet

werden dürfen, oder mit Erträgen aus einer Ausgabe neuer Aktien, die zum Zwecke dieses Rückkaufs ausgegeben werden;

- ein Betrag in Höhe des Nominalwerts oder, wenn ein Nominalwert nicht vorhanden ist, des Nennwertes aller zurück-

gekauften Aktien ist in eine Rücklage einzustellen, die, außer im Falle der Herabsetzung des Gesellschaftskapitals, nicht
an die Aktionäre ausgeschüttet werden darf; diese Rücklage darf nur dazu verwendet werden, durch Umwandlung von
Rücklagen das ausgegebene Gesellschaftskapital zu erhöhen (diese Rücklage ist nicht notwendig bei einem Rückkauf mit
Hilfe von Erträgen aus einer Ausgabe neuer Aktien, die zum Zwecke dieses Rückkaufs ausgegeben werden); und

- der Rückkauf wird im Einklang mit dem Gesetz von 1915 veröffentlicht.
6.7 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann nur durch Rückkauf und Einziehung einer oder mehrerer Kategorien

als Ganzes, aber nicht teilweise, herabgesetzt werden, was durch Rückkauf und Einziehung aller ausgegebenen Aktien
dieser Kategorie geschieht.

6.8 Eine Kapitalherabsetzung durch den Rückkauf und die Einziehung einer Kategorie kann nur innerhalb der dafür

vorgesehenen jeweiligen Laufzeit der Kategorie (wie unten definiert) erfolgen:

i. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie A ist die Laufzeit, die am Ausstellungstag der notariellen Urkunde am 28.

September 2015 beginnt und nicht später als am 31. Dezember 2016 endet (die „Laufzeit der Kategorie A“).

151981

L

U X E M B O U R G

ii. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie B ist die Laufzeit, die am Tag nach der Laufzeit der Kategorie A beginnt

und nicht später als am 31. Dezember 2017 endet (die „Laufzeit der Kategorie B“).

iii. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie C ist die Laufzeit, die am Tag nach der Laufzeit der Kategorie B beginnt

und nicht später als am 31. Dezember 2018 endet (die „Laufzeit der Kategorie C“).

iv. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie D ist die Laufzeit, die am Tag nach der Laufzeit der Kategorie C beginnt

und nicht später als am 31. Dezember 2019 endet (die „Laufzeit der Kategorie D“).

v. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie E ist die Laufzeit, die am Tag nach der Laufzeit der Kategorie D beginnt

und nicht später als am 31. Dezember 2020 endet (die „Laufzeit der Kategorie E“).

vi. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie F ist die Laufzeit, die am Tag nach der Laufzeit der Kategorie E beginnt

und nicht später als am 31. Dezember 2021 endet (die „Laufzeit der Kategorie F“).

vii. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie G ist die Laufzeit, die am Tag nach der Laufzeit der Kategorie F beginnt

und nicht später als am 31. Dezember 2022 endet (die „Laufzeit der Kategorie G“).

viii. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie H ist die Laufzeit, die am Tag nach der Laufzeit der Kategorie G beginnt

und nicht später als am 31. Dezember 2023 endet (die „Laufzeit der Kategorie H“).

ix. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie I ist die Laufzeit, die am Tag nach der Laufzeit der Kategorie H beginnt

und nicht später als am 31. Dezember 2024 endet (die „Laufzeit der Kategorie I“).

x. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie J ist die Laufzeit, die am Tag nach der Laufzeit der Kategorie I beginnt und

nicht später als am 31. Dezember 2025 endet (die „Laufzeit der Kategorie J“).

6.9 Wenn eine Kategorie nicht innerhalb der jeweiligen Laufzeit der Kategorie zurückgekauft und eingezogen wurde,

können den Rückkauf und die Einziehung einer solchen Kategorie während einer neuen Laufzeit (die „Neue Laufzeit“)
erfolgen, welche am Tag nach der letzten Laufzeit der Kategorie beginnt (oder, je nach Fall, am Tag nach dem Ende der
direkt vorangegangenen Neuen Laufzeit einer anderen Kategorie) und nicht später als ein Jahr nach dem Beginn dieser
Neuen Laufzeit endet. Die erste Neue Laufzeit beginnt am Tag nach der Laufzeit der Kategorie J und die in ihrer jeweiligen
Laufzeit der Kategorie noch nicht zurückgekaufte(n) und eigezogene(n) Kategorie(n) richten sich nach der Reihenfolge
von Kategorie A bis Kategorie J (soweit sie zuvor noch nicht zurückgekauft und eingezogen wurden).

6.10 Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass für den Fall, dass ein Rückkauf und eine Einziehung einer Kategorie

einen Tag vor dem letzten Tag der jeweiligen Laufzeit der Kategorie (oder, je nach Fall, Neuen Laufzeit) stattfindet, die
sich anschließende Laufzeit der Kategorie (oder, je nach Fall, Neue Laufzeit) am Tag nach dem Rückkauf und der Ein-
ziehung dieser Kategorie beginnt und weiterhin am Tage enden soll, wie in den Artikeln zuvor bestimmt.

6.11 Der Einziehungsbetrag wird für die Gesellschaft an die Gesellschafter anteilig zu ihrem Anteil an der jeweiligen

Kategorie(n) nach Rückkauf und Einzug der gesamten jeweiligen Kategorie(n) fällig und zahlbar. Zur Klarstellung wird
darauf hingewiesen, dass die Verbindlichkeit der Gesellschaft durch Aufrechnung, Bar- oder Sachzahlung erlischt.

6.12 Für den Zweck dieser Satzung haben die folgenden Begriffe die folgende Bedeutung:
„Verfügbarer Betrag“ meint den Gesamtbetrag des Nettogewinns der Gesellschaft (einschließlich Gewinnvorträgen)

erhöht durch (i) jede frei ausschüttbare Rücklage (unter Berücksichtigung des Artikels 5.4 dieser Satzung) und (ii) je nach
Fall, um den Betrag der Kapitalherabsetzung und Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage hinsichtlich der einzuziehenden
Kategorie, aber herabgesetzt um (i) jegliche Verluste (einschließlich Verlustvorträgen) dargestellt als Pluswert, (ii) jegliche
Beträge, die gemäß der jeweiligen Zwischenabschlüsse entsprechend dem Gesetz von 1915 oder der Satzung in die Rück-
lage eingestellt werden müssen (zur Klarstellung, ohne doppelte Buchführung), (iii) jegliche Dividenden, die den Inhabern
der Stammaktien und der Gründeraktien gemäß der Satzung zustehen und (iv) jegliche Gewinnbeteiligung, so dass gilt:

AA = (NP + P + CR) - (L + LR + OD + PE)
Wobei:
AA = Verfügbarer Betrag.
NP = Nettogewinn (einschließlich Gewinnvorträgen).
P = jede frei ausschüttbare Rücklage.
CR = der Betrag der Kapitalherabsetzung und Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage hinsichtlich der einzuziehenden

Aktienkategorien.

L = Verluste (einschließlich Verlustvorträge), dargestellt als Pluswert.
LR = jegliche Beträge, die gemäß dem Gesetz von 1915 oder der Satzung in die Rücklage einzustellen sind.
OD = jegliche Dividenden, die den Inhaber(n) der Stammaktien und der Gründeraktien gemäß der Satzung zustehen.
PE = Gewinnbeteiligung.
Der Verfügbare Betrag muss in den Zwischenabschlüssen für die jeweilige Laufzeit der Kategorie festgelegt werden

und soll vom Verwaltungsrat in gutem Glauben und mit Blick auf die Unternehmensfortführung bewertet werden.

„Verfügbare Liquide Mittel“ meinen (i) das gesamte Bargeld der Gesellschaft (mit Ausnahme von Bargeld in Termin-

einlagen  mit  einer  Restlaufzeit  von  mehr  als  sechs  (6)  Monaten),  (ii)  jegliche  marktgängige  Geldmarktinstrumente,
Anleihen und Schuldverschreibungen und jede Forderung, welche nach Ansicht des Verwaltungsrats innerhalb naher Zu-
kunft an die Gesellschaft gezahlt werden, abzüglich jeglicher Verschuldung oder anderen Schulden der Gesellschaft, welche

151982

L

U X E M B O U R G

auf Grundlage des Zwischenabschlusses in Bezug auf die jeweilige Laufzeit der Kategorie (oder Neue Laufzeit, je nach
Fall) innerhalb von weniger als sechs (6) Monaten zu zahlen sind und (iii) alle Vermögenswerte wie Anteile, Aktien oder
Wertpapiere anderer Art, die von der Gesellschaft gehalten werden.

„Einziehungsbetrag“  meint  einen  Betrag,  welcher  den  Verfügbaren  Betrag  in  Bezug  auf  die  jeweilige  Laufzeit  der

Kategorie (oder Neue Laufzeit, je nach Fall) nicht übersteigt, mit der Maßgabe, dass dieser Einziehungsbetrag nicht höher
sein kann als die Verfügbaren Liquiden Mittel in Bezug auf die jeweiligen Laufzeit der Kategorie (oder Neue Laufzeit).
Der Einziehungsbetrag ist vom Verwaltungsrat im besten Interesse der Gesellschaft festzulegen. Zur Klarstellung wird
darauf hingewiesen, dass die Inhaber der Gründeraktien nur zu den Beträgen berechtigt sind, welche ihnen im Einklang
mit dieser Satzung, insbesondere mit den Artikeln 28.7 und 30.2, zustehen. Der Verwaltungsrat kann die frei ausschüttbaren
Rücklagen bei seiner Bestimmung des Einziehungsbetrags nach eigenem Ermessen ganz oder teilweise aufnehmen oder
nicht (immer unter Berücksichtigung des Artikels 5.4 dieser Satzung).

„Laufzeit der Kategorie“ meint jeweils die Laufzeit der Kategorie A, die Laufzeit der Kategorie B, die Laufzeit der

Kategorie C, die Laufzeit der Kategorie D, die Laufzeit der Kategorie E, die Laufzeit der Kategorie F, die Laufzeit der
Kategorie G, die Laufzeit der Kategorie H, die Laufzeit der Kategorie I und die Laufzeit der Kategorie J.

„Zwischenabschluss“ meint Zwischenanschlüsse der Gesellschaft am jeweiligen Zwischenabschlussdatum.
„Zwischenabschlussdatum“ meint das Datum, welches nicht früher als dreißig (30) Tage, aber nicht später als zehn (10)

Tage vor dem Tag des Rückkaufs und Einziehung der jeweiligen Kategorie liegt.

„Gewinnbeteiligung“ meint die festgelegten Beträge der Vorzugsdividenden, die den Inhabern von Kategorien im Ein-

klang mit Artikel 28.6 dieser Satzung auszuzahlen sind.

Art. 7. Genehmigtes Kapital.
7.1 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt, ausschließlich des Gesellschaftskapitals, zwei Millionen zwei-

hunderttausend  Euro  (EUR  2.200.000),  aufgeteilt  in  zweihundertzwanzig  Millionen  (220.000.000)  Aktien  mit  einem
Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (ausschließlich des ausgegebenen Gesellschaftskapitals), bestehend aus:

(a) zwanzig Millionen (20.000.000) Stammaktien;
(b) zwanzig Millionen (20.000.000) Aktien der Kategorie A;
(c) zwanzig Millionen (20.000.000) Aktien der Kategorie B;
(d) zwanzig Millionen (20.000.000) Aktien der Kategorie C;
(e) zwanzig Millionen (20.000.000) Aktien der Kategorie D;
(f) zwanzig Millionen (20.000.000) Aktien der Kategorie E;
(g) zwanzig Millionen (20.000.000) Aktien der Kategorie F;
(h) zwanzig Millionen (20.000.000) Aktien der Kategorie G;
(i) zwanzig Millionen (20.000.000) Aktien der Kategorie H;
(j) zwanzig Millionen (20.000.000) Aktien der Kategorie I; und
(k) zwanzig Millionen (20.000.000) Aktien der Kategorie J.
Der Verwaltungsrat ist während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung dieser Satzung

oder, soweit anwendbar, eines Beschlusses, das genehmigte Kapital gemäß dieses Artikels zu erneuern oder zu erhöhen,
im Rahmen dieses genehmigten Kapitals ermächtigt, Aktien auszugeben, Aktienbezugsoptionen zu gewähren und jedes
andere in Aktien umwandelbare Wertpapier auszugeben, wobei die Ausgabe an solche Personen und unter solchen Be-
dingungen  erfolgt,  die  der  Verwaltungsrat  für  sinnvoll  hält  und  insbesondere  ohne  den  bestehenden  Aktionären  ein
Vorzugsrecht zur Zeichnung der neu auszugebenden Aktien zu gewähren, und dies im Einklang mit beliebigen Aktionärs-
vereinbarungen.  Diese  Ermächtigung  kann  einmal  oder  mehrmals  durch  einen  Beschluss  der  Hauptversammlung  der
Aktionäre erneuert werden, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst
wird, und zwar jeweils für einen Zeitraum, der nicht mehr als fünf (5) Jahre beträgt.

7.2 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher

in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 8. Gründeraktien.
8.1 Die Gesellschaft hat einhunderttausend (100.000) Gründeraktien ausgegeben (parts bénéficiaires), mit einem No-

minalwert von je einem Cent (EUR 0,01). Diese ergeben nicht das Gesellschaftskapital der Gesellschaft und verleihen dem
Inhaber keine weitergehenden Rechte, als die in dieser Satzung, insbesondere in den Artikeln 8, 13, 14 und 15 sowie in
den Abschnitten 11.4, 28.7 und 30.2 festgelegten Rechte (die „Gründeraktien“).

8.2 Die Gründeraktien sind Namensaktien. Die Anzahl der ausgegebenen Gründeraktien werden in einem am Sitz der

Gesellschaft geführten Register der Gründeraktien eingetragen. Dieses soll auch die Namen und Adressen der Inhaber,
sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Gründeraktien umfassen. Das Eigentum an Gründeraktien entsteht durch Ein-
tragung im besagten Register. Zertifikate über die Eintragung werden auf Antrag und auf Kosten des jeweiligen Inhabers
herausgegeben, ohne aber als Beweis für das Eigentum zu dienen. Zertifikate über Gründeraktien bedürfen der Unterschrift
eines Verwaltungsratsmitglieds der Gesellschaft.

151983

L

U X E M B O U R G

8.3 Jegliche Mitteilungen und Bekanntmachungen an die Inhaber von Gründeraktien werden an die im obengenannten

Register eingetragenen Adressen versandt. Sollte ein Inhaber einer Gründeraktie keine Adresse angegeben haben, gilt der
Sitz der Gesellschaft oder jede andere Adresse als die Adresse des Inhabers der Gründeraktie, wobei die Gesellschaft diesen
Umstand im Register eintragen lassen kann. Dies gilt solange wie der Gesellschaft gegenüber keine andere Adresse seitens
des Inhabers bekanntgemacht worden ist.

8.4 Inhaber von Gründeraktien haben das Recht zur Teilnahme an jeder Hauptversammlung der Aktionäre und werden

auf dem gleichem Wege wie Aktionäre geladen. Unbeschadet gegenteiliger Bestimmungen dieser Satzung müssen Grün-
deraktien zur Beschlussfähigkeit der Hauptversammlungen der Aktionäre anwesend sein. Die Gründeraktien genießen die
zwei Komma dreiunddreißigfache (2,33) (anteilig zwischen den Gründeraktien und auf volle Zahlen gerundet) Anzahl an
Stimmen aller mitunter ausgegebenen Stammaktien und Kategorien für jeden Beschlussvorschlag der Gesellschaft in einer
ordentlichen oder außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft.

8.5 Die Artikel 12.3, 12.4 und 12.5 gelten entsprechend.

Art. 9. Aktienregister - Übertragung von Aktien.
9.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches von den Aktionären eingesehen werden kann.

Dieses Aktienregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Der Nachweis über das Eigentum
an Aktien kann durch die Eintragung eines Aktionärs im Aktienregister erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten
des betreffenden Aktionärs werden Zertifikate über die Eintragung ausgegeben.

9.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Sofern eine Aktie von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt,  die  Ausübung  aller  Rechte  im  Zusammenhang  mit  einer  derartigen  Aktie  auszusetzen,  bis  eine  Person  als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

9.3 Vorbehaltlich der Übertragungsbedingungen (d.h. obligatorische Übertragung, Mitverkaufsrechte und -pflichten)

von Aktionärsvereinbarungen sind die Aktien im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 frei übertragbar.

9.4 Jede Übertragung von Aktien wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten durch (i) Eintragung einer vom Zedenten

und vom Zessionar oder deren Vertretern datierten und unterschriebenen Übertragungserklärung im Aktienregister oder
(ii) Eintragung einer von der Gesellschaft datierten und unterschriebenen Übertragungserklärung im Aktienregister, nach-
dem sie von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder dieser zugestimmt hat, wirksam.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 10. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.
10.1  Die  Aktionäre  üben  ihre  gemeinsamen  Rechte  in  der  Hauptversammlung  der  Aktionäre  aus.  Jede  regelmäßig

einberufene Hauptversammlung der Aktionäre repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Die Haupt-
versammlung der Aktionäre hat die ihr durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen Befugnisse.

10.2 Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär, so ist jeder Bezug auf die „Hauptversammlung der Aktionäre“ in der

vorliegenden Satzung, je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, als Bezug auf den „alleinigen Aktionär“ zu verstehen
und alle Befugnisse der Hauptversammlung werden vom alleinigen Aktionär ausgeübt.

Art. 11. Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre.
11.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit durch den Verwaltungsrat oder, soweit vorhanden, durch

den/die Rechnungsprüfer einberufen werden.

11.2 Sie muss auf schriftliche Aufforderung von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens 10 Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals halten, vom Verwaltungsrat oder vom Rechnungsprüfer/den Rechnungsprüfern einberufen
werden. In einem derartigen Fall muss die Hauptversammlung der Aktionäre innerhalb eines (1) Monats ab Zugang des
Ersuchens abgehalten werden.

11.3 Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung der Aktionäre muss das Datum, die Uhrzeit, den Ort und die Tages-

ordnung der Versammlung enthalten und zweimal in Form einer Einberufung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations und in einer Luxemburger Tageszeitung mit einem Zeitabstand von mindestens zehn (10) Tagen und zehn
(10) Tage vor dem für die Hauptversammlung anberaumten Datum erfolgen. Einberufungen per Post sind zehn (10) Tage
vor dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Inhaber von Namensaktien zu versenden, wobei kein Beweis
der Einhaltung dieser Formvorschrift erbracht werden muss. Handelt es sich bei allen Aktien um Namensaktien, so kann
die Einberufung ausschließlich durch Einschreiben erfolgen, die mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung
anberaumten Datum an jeden Aktionär zu versenden sind.

11.4 Falls alle Aktionäre und Inhaber der Gründeraktien in einer Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder

vertreten sind und auf Ladungsformalitäten verzichtet haben, kann die Hauptversammlung auch ohne vorherige Einladung
oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 12. Durchführung der Hauptversammlung der Aktionäre.
12.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird in Luxemburg am Gesellschaftssitz der Gesellschaft, oder an

einem anderen in der Einberufung bestimmten Ort in Luxemburg am 15. April um 10:00 Uhr abgehalten. Ist dieser Tag
ein gesetzlicher Feiertag, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am darauf folgenden Werktag abzuhalten.

151984

L

U X E M B O U R G

Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre können an dem in der Einberufung bestimmten Ort zu der darin angegebenen
Zeit abgehalten werden.

12.2 In jeder Hauptversammlung der Aktionäre wird ein Rat der Versammlung bestimmt, der aus einem Vorsitzenden,

einem Schriftführer und einem Stimmzähler besteht, die weder Aktionäre, noch Mitglieder des Verwaltungsrats sein müs-
sen. Der Rat der Versammlung soll sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und vor allem
im Einklang mit den Regeln betreffend die Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Akti-
onären abgehalten wird.

12.3 In jeder Hauptversammlung wird eine Anwesenheitsliste geführt.
12.4 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person durch ein

unterzeichnetes Dokument, das per Post, Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt
wird, schriftlich bevollmächtigt. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Aktionäre vertreten.

12.5 Jeder Aktionär kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Aktionäre durch eine unterzeichnete Stimmkarte

abgeben, welche per Post, E-Mail, Fax oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den Sitz der Gesellschaft oder
an die in der Einberufung genannte Adresse gesendet wird. Die Aktionäre können nur solche Stimmkarten verwenden, die
von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung,
die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Aktionären
ermöglichen, seine Stimme für oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das
entsprechende Kästchen ankreuzt.

12.6 Stimmkarten, die für einen vorgeschlagenen Beschluss nicht nur (i) eine Stimme für oder (ii) eine Stimme gegen

den vorgeschlagenen Beschluss oder (iii) eine Enthaltung beinhalten, sind in Bezug auf diesen Beschluss ungültig. Die
Gesellschaft wird nur Stimmkarten berücksichtigen, die sie vor der entsprechenden Hauptversammlung der Aktionäre
erhalten hat.

Art. 13. Quorum und Stimmrecht.
13.1 Jede Aktie gewährt eine (1) Stimme pro Aktie in Hauptversammlungen der Aktionäre.
13.2 Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die Gründeraktien ihre Inhaber zu den in Artikel 8.4 aufgelisteten

Rechten und der darin vorgesehenen Stimmanzahl in Hauptversammlungen der Aktionäre berechtigen.

13.3 Sofern sich nicht aus dem Gesetz von 1915 oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in

einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre ohne Erfordernis eines Anwesenheitsquorums (au-
ßer für die Anwesenheit der Inhaber von Gründeraktien) mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst,
unabhängig von dem dabei vertretenen Anteil am Gesellschaftskapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der
Berechnung nicht berücksichtigt.

Art. 14. Änderungen der Satzung. Vorbehaltlich anderer Regelungen in dieser Satzung erfordert die Änderung der

Satzung einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3) der
abgegebenen gültigen Stimmen, in der mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals und der Gründeraktien anwesend
oder vertreten ist. Falls die zweite Bedingung nicht erfüllt ist, kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und dieser Satzung eine zweite Hauptversammlung der Aktionäre einberufen werden, die unabhängig von einem
Anwesenheitsquorum beschlussfähig ist (es sei denn, die Anwesenheit der Inhaber der Gründeraktien ist erforderlich) und
in welcher Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst
werden. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Aktionäre können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig (und mit der

Zustimmung der Inhaber der Gründeraktien) ändern.

Art. 16. Vertagung von Hauptversammlungen der Aktionäre. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 1915

kann der Verwaltungsrat eine Hauptversammlung der Aktionäre um vier (4) Wochen vertagen. Der Verwaltungsrat muss
eine Hauptversammlung der Aktionäre vertagen, wenn dies von Aktionären, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des
Gesellschaftskapitals halten, gefordert wird. Durch derartige Vertagung wird jeder bereits gefasste Beschluss in dieser
Versammlung annulliert.

Art. 17. Protokoll von Hauptversammlungen der Aktionäre.
17.1 Der Rat der Versammlung nimmt ein Protokoll jeder Versammlung auf, welches vom Rat der Versammlung sowie

von jedem Aktionär, der dies ersucht, unterzeichnet wird.

17.2 Kopien und Auszüge dieser Protokolle, die in Gerichtsverfahren verwendet oder Dritten zugänglich gemacht wer-

den sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die
Originalurkunde verwahrt, beglaubigt werden, oder ansonsten vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei beliebigen
Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 18. Zusammensetzung und Befugnisse des Verwaltungsrates.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet, der sich aus mindestens drei (3) und höchstens sechs

(6) Mitgliedern zusammensetzt. Sollte die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionären gegründet worden sein oder wird

151985

L

U X E M B O U R G

in einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionären hat, so kann
die Gesellschaft bis zu der Hauptversammlung der Aktionäre durch ein einziges Verwaltungsratsmitglied geleitet werden,
die auf die Feststellung folgt, dass es wieder mehr als einen Aktionär gibt. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und
wo der Begriff „einziges Verwaltungsratsmitglied“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung
auf den „Verwaltungsrat“ als Verweis auf das „einzige Verwaltungsratsmitglied“ auszulegen.

18.2 Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle

Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der
durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Befugnisse.

18.3 Die Gesellschaft bevollmächtigt die EPIC I GP S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à

responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard
de la Foire, L-1528 Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der
Nummer B 186.222 (die „Bevollmächtigte“) die Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneingeschränkter Befugnis
zur Unterbevollmächtigung, in ihrem Namen bei jeder Versammlung der Aktionäre oder Interesseninhaber oder schriftli-
chen Beschlüssen von Gesellschaften, Unternehmen, Personengesellschaften oder anderen juristischen Personen und/oder
Tochtergesellschaften, an denen die Gesellschaft direkt oder indirekt Aktien, Interessen oder andere Beteiligungen hält, in
Bezug auf (und nur in Bezug auf) (i) die Ernennung und Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern, Geschäftsführern
oder anderen Mitgliedern von führenden, beherrschenden oder überwachenden Organen, an deren Entscheidung die Ge-
sellschaft mitzuwirken hat, und (ii) Änderungen der Satzung, von Gesellschaftsverträgen oder Geschäftsordnungen, je nach
Fall, welche die Ernennung oder Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern, Geschäftsführern oder anderen Mitgliedern
von führenden, beherrschenden oder überwachenden Organen betreffen und an deren Entscheidung die Gesellschaft mit-
zuwirken hat, zu vertreten.

Art. 19. Tägliche Geschäftsführung.
19.1 Gemäß Artikel 60 des Gesetzes von 1915 können die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung

der Gesellschaft einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten oder anderen Personen, mit
gemeinsamer oder Einzelvertretungsbefugnis übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden
durch einen Verwaltungsratsbeschluss bestimmt.

19.2 Die Gesellschaft kann durch notarielle Urkunden oder privatschriftlich Spezialvollmachten erteilen.

Art. 20. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern.
20.1 Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

20.2 Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten. Jedes Verwaltungsratsmit-

glied kann wiederernannt werden.

20.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied wird durch einfache Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen in einer Hauptver-

sammlung ernannt.

20.4 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit und ohne Grund mit einfacher Mehrheit der in einer Hauptversamm-

lung der Aktionäre gültig abgegebenen Stimmen, unter Berücksichtigung der Stimmrechte der Gründeraktien gemäß dieser
Satzung, abberufen werden.

20.5 Wird eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt, so muss diese eine rechtsfähige Person als ihren

ständigen Vertreter benennen, die ihr Mandat in ihrem Namen und für ihre Rechnung ausübt. Die betreffende juristische
Person kann nur dann ihren ständigen Vertreter abberufen, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernennt. Eine natürliche
Person kann nur ständiger Vertreter eines (1) Verwaltungsratsmitglieds und nicht gleichzeitig persönlich Verwaltungs-
ratsmitglied sein.

Art. 21. Vakanz des Amtes eines Verwaltungsratsmitglieds.
21.1 Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen

Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten Haupt-
versammlung der Aktionäre vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit des zu ersetzenden Verwaltungsrats-
mitglieds nicht übersteigenden Zeitraum bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre ausgefüllt werden, welche im
Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften und Artikel 20.3 über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

21.2 Für den Fall, dass das einzige Verwaltungsratsmitglied aus seinem Amt scheidet, muss die frei gewordene Stelle

unverzüglich durch die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit Artikel 20.3 neu besetzt werden.

Art. 22. Einladung zu Verwaltungsratssitzungen.
22.1 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung des Vorsitzenden oder eines beliebigen Verwaltungsrats-

mitglieds. Die Verwaltungsratssitzungen finden, soweit in der Einladung nicht anders bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft
statt.

22.2 Die Verwaltungsratsmitglieder werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anbe-

raumten Datum zu jeder Sitzung des Verwaltungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, wenn alle Verwaltungs-
ratsmitglieder schriftlich, per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung

151986

L

U X E M B O U R G

abgegeben  haben,  wobei  eine  Kopie  einer  solchen  unterzeichneten  Zustimmung  ein  hinreichender  Nachweis  ist.  Eine
Einladung zu Sitzungen des Verwaltungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Verwaltungsrats bestimmt worden sind, welcher allen Verwaltungsratsmitgliedern übermittelt wurde.

22.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und diese

alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des
Verwaltungsrats diesen zugestimmt und sie unterzeichnet haben.

Art. 23. Durchführung von Verwaltungsratssitzungen.
23.1 Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden aus. Der Verwaltungsrat kann auch einen

Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Verwaltungsrats sein muss und der für die Protokollfüh-
rung der Verwaltungsratssitzungen verantwortlich ist.

23.2 Verwaltungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats geleitet. In dessen Abwesenheit

kann der Verwaltungsrat ein anderes Mitglied des Verwaltungsrats durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder
vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

23.3 Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an einer Verwaltungsratssitzung teilnehmen, indem es ein anderes Mit-

glied  des  Verwaltungsrats  schriftlich,  per  Fax,  E-Mail  oder  ein  anderes  vergleichbares  Kommunikationsmittel  bevoll-
mächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied des Verwaltungsrats
kann ein oder mehrere, aber nicht alle anderen Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

23.4 Eine Verwaltungsratssitzung kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kom-

munikationsmittel  abgehalten  werden,  welches  es  allen  Teilnehmern  ermöglicht,  einander  durchgängig  zu  hören  und
tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleich-
bedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft
abgehalten erachtet.

23.5 Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mit-

glieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

23.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Verwaltungsratssitzung teilnehmenden

oder  vertretenen  Verwaltungsratsmitglieder  gefasst.  Der  Vorsitzende  des  Verwaltungsrats  hat  nicht  die  entscheidende
Stimme.

23.7 Vorbehaltlich gegenteiliger Regelungen im Gesetz von 1915 muss jedes Verwaltungsratsmitglied, welches an

einem Geschäft, das dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein Interesse hat, welches den
Interessen der Gesellschaft entgegensteht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenskonflikt informieren; die Erklärung
wird im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen. Das betreffende Verwaltungsratsmitglied darf weder an der
Beratung über das in Frage stehende Geschäft teilnehmen, noch darüber abstimmen. Die nächste Hauptversammlung der
Aktionäre  muss  von  derartigen  Interessenkonflikten  informiert  werden,  bevor  Beschlüsse  zu  anderen  Tagesordnungs-
punkten gefasst werden.

23.8 Hat die Gesellschaft nur ein einziges Verwaltungsratsmitglied, so werden Geschäfte zwischen der Gesellschaft und

dem Verwaltungsratsmitglied, welches daran ein der Gesellschaft entgegenstehendes Interesse hat, nur im Beschluss des
einzigen Verwaltungsratsmitglieds erwähnt.

23.9 Regeln zum Interessenkonflikt finden keine Anwendung, sofern sich die Entscheidung des Verwaltungsrats oder

des einzigen Verwaltungsratsmitglieds auf gängige Geschäfte bezieht, die unter normalen Bedingungen eingegangen wur-
den.

23.10 Der Verwaltungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Fax,

E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Zustim-
mung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

23.11 Der Großteil aller Verwaltungsratssitzungen werden am eingetragenen Sitz der Gesellschaft im Großherzogtum

Luxemburg abgehalten oder an jedem anderen Ort in Luxemburg, der in der Ladung zur Sitzung angegeben ist.

Art. 24. Protokoll von Verwaltungsratssitzungen - Protokoll der Entscheidungen des einzigen Verwaltungsratsmitglieds.
24.1 Das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder, im Falle seiner

Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore oder von zwei (2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder anderweitig vorzulegen sind, werden vom
Vorsitzenden oder von zwei (2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

24.2 Die Entscheidungen des einzigen Verwaltungsratsmitglieds werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom

einzigen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom einzigen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.

Art. 25. Geschäfte mit Dritten.
25.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift des einzigen Verwal-

tungsratsmitglieds oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Verwaltungsratsmitglieder hat, durch die gemeinsame

151987

L

U X E M B O U R G

Unterschrift von zwei (2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch (ii) die Unterschrift jedweder Person(en),
der/denen eine solche Befugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist, im Rahmen dieser Befugnis verpflichtet.

25.2 Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder

Einzelunterschrift der Person(en), der/denen diese Vollmacht übertragen wurde, im Rahmen dieser Befugnis verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft

Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)).

Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest, die sechs (6) Jahre nicht
überschreiten darf.

26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.
26.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Prüfung und Kontrolle aller Geschäfte der

Gesellschaft.

26.4 Wenn die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom

19. Dezember 2002 betreffend das Handels- und Gesellschaftsregister sowie zur Buchhaltung und zum Jahresabschluss
von Unternehmen in seiner geänderten Fassung einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d‘entreprises
agréé(s)) ernennt, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.

26.5  Ein  unabhängiger  Wirtschaftsprüfer  darf  nur  aus  berechtigtem  Grund  oder  mit  seiner  Zustimmung  durch  die

Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abeschlagsdividenden

Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Verwaltungsrat erstellt im Einklang mit

den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

28.3 Durch einen Aktionär erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Aktionärs ebenfalls der

gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

28.5 Auf Vorschlag des Verwaltungsrates bestimmt die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit dem Gesetz

von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden
soll.

28.6 Im Falle einer Dividendenausschüttung wird die Dividende in der folgenden Reihenfolge verteilt und ausgeschüttet:
Erstens:
i. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie A sind zu einer Dividende von 1% (einem Prozent) des Nominalwerts

der Aktien der Kategorie A (gegebenenfalls gerundet) berechtigt;

ii. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie B sind zu einer Dividende von 2% (zwei Prozent) des Nominalwerts

der Aktien der Kategorie B (gegebenenfalls gerundet) berechtigt;

iii. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie C sind zu einer Dividende von 3% (drei Prozent) des Nominalwerts

der Aktien der Kategorie C (gegebenenfalls gerundet) berechtigt;

iv. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie D sind zu einer Dividende von 4% (vier Prozent) des Nominalwerts

der Aktien der Kategorie D (gegebenenfalls gerundet) berechtigt;

v. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie E sind zu einer Dividende von 5% (fünf Prozent) des Nominalwerts

der Aktien der Kategorie E (gegebenenfalls gerundet) berechtigt;

vi. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie F sind zu einer Dividende von 6% (sechs Prozent) des Nominalwerts

der Aktien der Kategorie F (gegebenenfalls gerundet) berechtigt;

vii. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie G sind zu einer Dividende von 7% (sieben Prozent) des Nominalwerts

der Aktien der Kategorie G (gegebenenfalls gerundet) berechtigt;

viii. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie H sind zu einer Dividende von 8% (acht Prozent) des Nominalwerts

der Aktien der Kategorie H (gegebenenfalls gerundet) berechtigt;

ix. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie I sind zu einer Dividende von 9% (neun Prozent) des Nominalwerts

der Aktien der Kategorie I (gegebenenfalls gerundet) berechtigt;

151988

L

U X E M B O U R G

x. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie J sind zu einer Dividende von 10% (zehn Prozent) des Nominalwerts

der Aktien der Kategorie J (gegebenenfalls gerundet) berechtigt;

Zweitens:
xi. der bzw. die Inhaber der Stammaktien sind zu einer Dividende von 11% (ein Prozent) des Nominalwerts der Stamm-

aktien (gegebenenfalls gerundet) berechtigt;

Drittens:
xii. der Rest (abzüglich der an die Inhaber der Gründeraktien gezahlten Beträge) wird an den bzw. die Inhaber der in

einem Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre beschlossenen Aktienkategorie ausgeschüttet.

28.7 Im Falle einer Ausschüttung erhalten die Inhaber von Gründeraktien anteilig null Komma null eins Prozent (0,01%)

des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft, mit der Maßgabe, dass diese Ausschüttung auf das Zehnfache (10) des
gesamten Nominalwerts der Gründeraktien begrenzt ist.

Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Verwaltungsrat kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung Ab-

schlagsdividenden auszahlen.

29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-

mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation.
30.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die über
die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts
anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte
und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

30.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an

die Aktionäre wie folgt verteilt:

i. zunächst erhält jeder Inhaber der Kategorien einen Betrag, welcher der Einbringung der Kategorien entspricht;
ii. danach erhalten die Inhaber der Stammaktien und der Inhaber der Gründeraktien einen Betrag, welcher dem Nomi-

nalwert der Stammaktien und dem Nominalwert der Gründeraktien jeweils entspricht;

iii. von dem verbleibenden Überschuss erhalten die Inhaber der Stammaktien einer Betrag, welcher dem höheren der

folgenden Beträge entspricht: 0,60% des Nominalwerts der Stammaktien (gegebenenfalls gerundet), oder fünfundzwan-
zigtausend Euro (EUR 25.000);

iv. der Restbetrag wird an die Inhaber der Kategorien proportional zu der von ihnen gehaltenen Anzahl an Aktien der

Gesellschaft verteilt.

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die Inhaber der Gründeraktien zu einer Ausschüttung gemäß diesem

Artikel 30.2 (ii) und (iii) nicht berechtigt sind.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht

Art. 31. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915 und jeder Vereinbarung zwischen den Aktionären. Inter partes ist eine Vereinbarung zwischen den
Aktionären, soweit gesetzlich zulässig, vorrangig.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2016.

2. Die erste Jahreshauptversammlung der Aktionäre soll im Jahre 2017 abgehalten werden.
3. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die  drei  Millionen  einhunderttausend  (3.100.000)  Aktien,  aufgeteilt  in  einhunderttausend  (100.000)  Stammaktien;

dreihunderttausend (300.000) Aktien der Kategorie A; dreihunderttausend (300.000) Aktien der Kategorie B; dreihun-
derttausend (300.000) Aktien der Kategorie C; dreihunderttausend (300.000) Aktien der Kategorie D; dreihunderttausend
(300.000) Aktien der Kategorie E; dreihunderttausend (300.000) Aktien der Kategorie F; dreihunderttausend (300.000)
Aktien der Kategorie G; dreihunderttausend (300.000) Aktien der Kategorie H; dreihunderttausend (300.000) Aktien der
Kategorie I; und dreihunderttausend (300.000) Aktien der Kategorie J, wurden von Firewall Investments S.A., vorbenannt,
zum Preis von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) gezeichnet.

Die Einlage für die so gezeichneten Aktien wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ab sofort ein

Betrag in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar
nachgewiesen wurde.

151989

L

U X E M B O U R G

Die gesamte Einlage in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital

zugeführt.

Die einhunderttausend (100.000) Gründeraktien wurden von Firewall Investments S.A., vorbenannt, zum Preis von

eintausend Euro (EUR 1.000) gezeichnet. Die Einlage für die so gezeichneten Gründeraktien wurde vollständig in bar
erbracht, so dass der Gesellschaft ab sofort ein Betrag in Höhe von eintausend Euro (EUR 1.000) zur Verfügung steht, was
dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar erklärt hiermit, dass er die Einhaltung der Vorschriften, die in Artikel 26 des Gesetzes von

1915 aufgeführt sind und auf die verwiesen wird, geprüft hat und erklärt, dass diese erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

oder Auslagen werden auf eintausend zweihundert Euro (EUR 1.200,-) geschätzt.

<i>Beschlüsse der Aktionäre

Die Gründungsaktionäre, welche das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren und welche auf eine formelle Einbe-

rufung verzichten, haben folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Großherzogtum Luxemburg;
2. Die folgende Person wird als unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zur Hauptversammlung der Akti-

onäre, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das erste Geschäftsjahr verabschiedet, ernannt:

Ernst &amp; Young Luxembourg, eine Aktiengesellschaft (société anonyme), gegründet und bestehend unter dem Recht des

Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 88019,
mit Sitz in 7, rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach.

Der Gründungsaktionär, vertreten durch EPIC I GP S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à res-

ponsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard
de la Foire, L-1528 Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, unter der
Nummer B 186.222, hier vertreten durch Julia Szafranska, attorney-at-law, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer
Vollmacht, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle Einberufung verzichtet,
hat folgende Beschlüsse gefasst:

3. Die folgenden Personen werden bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahre 2021 abgehalten wird,

als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ernannt:

Dan Arendt, geboren am 15. Mai 1961 in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, wohnhaft in 42, op Fankenacker,

L- 3265 Bettembourg;

Hubert Jacobs, Van Merlen, geboren am 27. August 1953 in Buenos-Aires, Argentinien, wohnhaft in 3 rue Belair,

L-5318 Contern;

François Pauly, geboren am 30. Juni 1964 in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, wohnhaft in 57, rue Jean Schoet-

ter, L-2523 Luxemburg; und

Michael Phillips, geboren am 1. Februar 1962 in St. Louis, USA, wohnhaft in 13, Possard Strasse, D-81679 München.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Ersuchen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen wurde, welche dem Notar mit

Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat die Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: J. SZAFRANSKA, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 30 septembre 2015. Relation: DAC/2015/16027. Reçu soixante-quinze (75.-)

euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 1 

er

 octobre 2015.

Référence de publication: 2015162085/1168.
(150179643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

151990

L

U X E M B O U R G

First Business Parks Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 200.412.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third of September.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Crossroads II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under

Luxembourg law, having its registered seat at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 195286,

First Business Parks Management S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established

and existing under Luxembourg law, having its registered seat at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 195332,

here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 13 route de Luxem-

bourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of two (2) proxies given on September 9, 2015. The said
proxies, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing persons and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the deed of

establishment of a private limited liability company with the following articles of association:

Art. 1. There exists a private limited liability company under the name of First Business Parks Holdings II S.à r.l.

(hereinafter, the Company), which shall be governed by the laws pertaining to such an entity and in particular by the law
of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles of
association (hereinafter, the Articles).

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests

in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of such partici-
pating interests, in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio

consisting of any securities and intellectual property rights of whatever origin and participate in the creation, development
and control of any enterprises. It may also acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to
purchase and any other way whatsoever, any type of securities and intellectual property rights, have them developed and
realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or

other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company
belongs (such as, but not limited to, shareholders or affiliated entities).

In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transactions,

take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purpose or which promote its development.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give guarantees
and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies
or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or some
of its assets.

Art. 3. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 4. The Company’s registered office is established in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the Sole

Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the general
meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

The Company may have offices and branches, both in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 5. The Company’s subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) represented

by twelve thousand five hundred (12.500) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles.

151991

L

U X E M B O U R G

The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders’

meeting.

Art. 6. Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company. In case of plurality of owners per share, the
Company may suspend the rights attached to this share until a single owner has been designated to the Company.

Art. 7. In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In case of a plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with

article 189 of the Law.

Art. 8. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the sole shareholder or of any of the shareholders.

Art. 9. The Company is managed by one (hereinafter, the Sole Manager) or more managers. If several managers have

been appointed, they constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers).

The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a

resolution of the sole shareholder or of the shareholders holding more than half of the share capital.

Art. 10. The Sole Manager or the Board of Managers is invested with the broadest powers to perform all acts necessary

or useful to realise the Company’s object, with the exception of the powers reserved by the Law or the Articles to the
general meeting of shareholders.

Towards third parties, the Company shall be bound by the signature of the Sole Manager or, in case of plurality of

managers, by the joint signature of any two (2) managers

The Sole Manager or the Board of Managers shall have the right to grant special proxies for determined matters to one

or more proxy holders, either managers or not, either shareholders or not.

The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders on the basis of a

statement of accounts showing that sufficient profits are available for distribution, it being understood that the amount to
be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits
and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established
according to the Law or these Articles.

Art. 11. The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the daily management of the Company to one or

several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager’s or agent’s responsibilities and remuneration (if any), the
duration of representation and any other relevant conditions of this agency.

Art. 12. The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present,

his place shall be taken by election among the managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.
The Board of Managers shall meet as often as the Company’s interest so requires. The meetings of the Board of Managers

are convened by the chairman, the secretary or by any manager at the place indicated in the convening notice.

Written notice of any meeting of the Board of Managers shall be given to all the managers, whether in original, by

facsimile or by electronic mail (e-mail), at least twenty-four (24) hours in advance of the date and time set for such meeting,
except in case of emergency.

No such convening notice is required if all members of the Board of Managers are present or represented at the meeting

and if they state to have been duly informed on the agenda of the meeting. The notice may also be waived by consent in
writing, whether in original, by facsimile or by electronic mail (e-mail), of each member of the Board of Managers. Separate
notice shall not be required for meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution
of the Board of Managers.

A manager may be represented at the Board of Managers by another manager, and a manager may represent several

managers.

The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented

by proxies. Any decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority of the members of the Board of
Managers.

Any manager may participate in a meeting by way of telephone or video conference call or by any other similar means

of communication enabling the persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such parti-
cipation  shall  be  deemed  equal  to  a  physical  presence  at  the  meeting.  The  decisions  taken  at  such  meeting  may  be
documented in a single document or in several separate documents having the same content and signed by all the members
having participated.

Resolutions in writing, approved and signed by all the managers, shall have the same effect as resolutions passed at a

Board of Managers' meeting which was duly convened and held. Such resolutions may be documented in a single document
or in several separate documents having the same content and signed by all the managers.

151992

L

U X E M B O U R G

Art. 13. The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commitment

validly made by her/him/them in the name of the Company.

Art. 14. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles and other specific decisions as defined by the Law may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, in accordance with the
provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the

same year.

Art. 16. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established and the Sole Manager or the Board

of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.
This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital

but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, the ten
percent (10%) threshold is no longer met.

The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their

shareholding in the Company.

Art. 18. The Company may be dissolved by a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders. The

liquidation shall be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall
determine their powers and remuneration.

At the time of the liquidation of the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with

the last paragraph of Article 17.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on December 31, 2015.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, all the shares have been subscribed and fully paid up at nominal

value by contribution in cash as follows:

Subscriber

Shares

Payment

Crossroads II S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000 EUR 10.000,00

First Business Parks Management S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500

EUR 2.500,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500 EUR 12.500,00

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) has been fully paid up in cash and is now available

to the Company.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the above resolutions are estimated at 1,500.- euro.

<i>Resolutions of the shareholders

The shareholders have taken the following resolutions:
The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:
- Mr. Alexander Hoff, born on February 3, 1963, in Koblenz, Germany, having his professional address at Gartenstrasse

2, G-61476 Kronberg, Germany;

- Mr. Christophe Gaul, born on April 3, 1977, in Messancy, Belgium, having his professional address at 7, rue Robert

Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Olivier Remacle, born on June 15, 1970, in Messancy, Belgium, having his professional address at 1B, rue Heien-

haff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

151993

L

U X E M B O U R G

The address of the registered office of the Company is fixed at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the

appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who is known to the notary by her full

name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour de septembre.
Par-devant Nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

Crossroads II S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et existante sous les lois du Luxembourg, ayant son

siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, un capital social de douze mille
cinq cents Euro (EUR 12.500,00) et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 195286,

First Business Parks Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et existante sous les lois du Lu-

xembourg, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, un capital
social de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,00) et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 195332,

ici représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 13 route

de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de deux (2) procurations données le 9 septembre
2015. Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-
mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Les comparants, représentés par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination First Business Parks Holdings II S.à r.l.

(ci-après, la Société), régie par les lois relatives à une telle entité et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).

Art. 2. La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.

La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, et participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise. Elle peut également acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire mettre en valeur
et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités

dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (notamment
par exemple, ses associés ou entités liées).

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou im-

mobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement
ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, uniquement

par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts, con-
vertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes
afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut
en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré à toute autre adresse à l’intérieur de la même commune ou dans une autre commune par décision

du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), respectivement par une
résolution de l’assemblée générale des associés, suivant les dispositions en vigueur de la Loi.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.

151994

L

U X E M B O U R G

Art. 5. Le capital social souscrit de la Société s’élève à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,00) représenté par

douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,00) chacune.

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.
Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 6. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. En cas de pluralité
de propriétaires d’une part sociale, la Société peut suspendre les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'un seul propriétaire
soit désigné.

Art. 7. Dans l’hypothèse où il n’y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-

sibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que conformément à l’article 189 de la Loi.

Art. 8. La Société n’est pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 9. La Société est gérée par un gérant unique (ci-après, le Gérant Unique) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants

sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance).

Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment,

avec ou sans motif, par une décision de l’associé unique ou des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Art. 10. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les

actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la Société, à l’exception de ceux que la Loi ou les Statuts
réservent à l’assemblée générale des associés.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de

gérants, par les signatures conjointes de deux (2) gérants.

Le  Gérant  Unique  ou  le  Conseil  de  Gérance  a  le  droit  de  déléguer  certains  pouvoirs  déterminés  à  un  ou  plusieurs

mandataires, gérants ou non, associés ou non.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état

comptable  préparé  par  le  Gérant  Unique  ou  le  Conseil  de  Gérance  duquel  il  ressort  que  des  bénéfices  suffisants  sont
disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des
pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

Art. 11. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs

gérant(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires,
la durée de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

Art. 12. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un

remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.
Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. Les réunions du Conseil de Gérance

sont convoquées par le président, le secrétaire ou par tout gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Il est donné à tous les gérants un avis écrit, soit en original, par téléfax ou courrier électronique, de toute réunion du

Conseil de Gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date et heure prévues pour la réunion, sauf en cas d’urgence.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Gérance sont

présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et de son ordre
du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque membre du Conseil de Gérance, par écrit donné soit
en original, soit par téléfax ou courrier électronique. Une convocation spéciale n’est pas requise pour toute réunion se tenant
à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Tout gérant peut être représenté au Conseil de Gérance par un autre gérant, et un gérant peut représenter plusieurs gérants.
Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est

présente ou représentée par procurations. Toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple des membres
du Conseil de Gérance.

Tout gérant peut participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de

communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation
équivaut à une présence physique à la réunion. Les décisions prises à une telle réunion peuvent être documentées dans un
document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Des résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants, produisent effet au même titre que des résolutions

prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Ces résolutions peuvent être documentées dans

151995

L

U X E M B O U R G

un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par chacun les membres du Conseil
de Gérance.

Art. 13. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) à raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du
capital social.

Toutefois,  les  résolutions  modifiant  les  Statuts  ou  autres  résolutions  spécifiques  définies  par  la  loi  ne  peuvent  être

adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescrip-
tions de la Loi.

Art. 15. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique, ou le

Conseil de Gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.

Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais

doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net peut être distribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la

Société.

Art. 18. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés. La liquidation

est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l’(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs
et rémunération.

Au moment de la liquidation de la Société, toute distribution aux associés se fait en application du dernier alinéa de

l’Article 17.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2015.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, toutes les parts sociales ont été souscrites et intégralement libérées à

valeur nominale par apport en numéraire comme suit:

Souscripteur

Parts

sociales

Libération

Crossroads II S.à r.l., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000 EUR 10.000,00

First Business Parks Management S.à r.l., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500

EUR 2.500,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500 EUR 12.500,00

Le montant de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,00) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à

présent à la libre disposition de la Société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués à la somme de 1.500,- euros.

<i>Décisions des associés

Les associés ont pris les résolutions suivantes:
Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Alexander Hoff, né le 3 février 1963, à Koblenz, Allemagne, ayant son adresse professionnelle Gartenstrasse 2,

G-61476 Kronberg, Allemagne;

- M. Christophe Gaul, né le 3 avril 1977, à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Robert

Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

151996

L

U X E M B O U R G

- M. Olivier Remacle, né le 15 juin 1970, à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 1B, rue Heienhaff,

L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

L’adresse  du  siège  social  de  la  Société  est  fixée  au  7,  rue  Robert  Stümper,  L-2557  Luxembourg,  Grand-Duché  de

Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des

personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des personnes comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 septembre 2015. Relation: EAC/2015/21963. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015162086/343.
(150179615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Sentinel Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 112.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 179.838.

In the year two thousand and fifteen, on the second day of September,
before us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, (the “Notary”),

acting in replacement of her colleague Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Lu-
xembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present deed,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Sentinel Holdings S.à r.l. (hereinafter the "Company"), a Lu-

xembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 179.838, incorporated by a notarial deed drawn up by
Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, on 9 August 2013 and whose articles of association (the "Articles")
have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2586 on 17 October
2013.

The Articles have been amended for the last time on 10 February 2014 pursuant to a deed of Maître Cosita Delvaux,

notary then residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial number 1066 on 26
April 2014.

The meeting is opened at 12.00 a.m..
Ms Khadigea Klingele, senior legal counsel, whose professional address is in Mondorf-les-Bains, acted as chairman of

the meeting with the consent of the meeting (the "Chairman").

The Chairman appointed Ms Marilyn Krecké, employee, whose professional address is in Luxembourg, to act as se-

cretary (the "Secretary").

The meeting elected Ms Khadigea Klingele, prenamed, to act as scrutineer (the "Scrutineer").
These appointments having been made, the Chairman declared that:
I. The names of the shareholders present or represented at the meeting by proxies (the "Shareholders") and the number

of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list, signed by or on behalf of the Shareholders,
the Notary, the Chairman, Scrutineer and Secretary, together with the proxy forms, signed ne varietur by the Shareholders
represented at the meeting by proxyholders, the Notary and the Chairman, Scrutineer and Secretary, shall remain annexed
to the present deed and shall be registered with it.

II. The attendance list shows that the Shareholders holding 100% of the share capital of the Company carrying voting

rights are present or represented at the meeting by proxies. All the Shareholders have declared that they have been suffi-
ciently informed of the agenda of the meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities.
The meeting is therefore properly constituted and can validly consider all items of the agenda.

III. The agenda of the meeting is the following:

151997

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. Decision to decrease the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500.-) in order to bring it from its current amount of one hundred twenty-five thousand euros (EUR 125,000.-) to one
hundred twelve thousand five hundred euros (EUR 112,500.-) through the cancellation of one million two hundred fifty
thousand (1,250,000) class J shares, of one euro cent (EUR 0.01) each, which have been repurchased by the Company on
19 August 2015;

2. Subsequent amendment of articles 6 &amp; 12 of the articles of association of the Company to reflect the above resolution;
3. Miscellaneous.
After due and careful deliberation, the following resolutions were passed unanimously:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to decrease the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five hundred

euros  (EUR  12,500.-)  in  order  to  bring  it  from  its  current  amount  of  one  hundred  twenty-five  thousand  euros  (EUR
125,000.-) to one hundred twelve thousand five hundred euros (EUR 112,500.-) through the cancellation of one million
two hundred fifty thousand (1,250,000) class J shares of one euro cent (EUR 0.01) each which were repurchased by the
Company on 19 August 2015.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to amend articles 6 and 12 the Articles to reflect the above resolution such that article 6.1. and

article 12.7 shall now read as follows:

6.1. Subscribed Share Capital.
6.1.1 The Company's corporate capital is fixed at one hundred twelve thousand five hundred euros (EUR 112,500)

represented by eleven million two hundred fifty thousand (11,250,000) shares (parts sociales) divided into Classes as
follows:

CLASS OF SHARES

NUMBER

OF SHARES

Class A Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,250,000

Class B Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,250,000

Class C Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,250,000

Class D Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,250,000

Class E Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,250,000

Class F Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,250,000

Class G Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,250,000

Class H Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,250,000

Class I Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,250,000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,250,000

each share with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01), all fully subscribed and entirely paid up and with such

rights and obligations as set out in the present Articles.

6.1.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium

paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
Shareholder(s) subject to the Law and these Articles.

6.1.3 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation

of one or more entire Classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such Class(es).
In case of repurchases and cancellations of Classes of shares such cancellations and repurchases of shares shall be made
in reverse alphabetical order (starting with Class I).

6.1.4 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of shares (in the

order provided for in article 6.1.3), such Class of shares gives right to the holder thereof pro rata to their holding in such
Class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the general
meeting of shareholders) and the holders of shares of the repurchased and cancelled Class of shares shall receive from the
Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant Class held by them and
cancelled.

6.1.5 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number

of shares in issue in the Class of shares to be repurchased and cancelled.

6.1.6 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of directors of the Company and

approved by the general meeting of shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation
Amount for each of the Classes I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the time
of the cancellation of the relevant Class unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner

151998

L

U X E M B O U R G

provided for an amendment to the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher
than such Available Amount.

6.1.7 Upon repurchase and cancellation of the shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will become

due and payable by the Company.

6.1.8 At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among
others, will apply, this entailing that each decision of the single shareholder and each contract concluded between him and
the Company represented by him shall have to be established in writing."

The article 12.7 shall now read as follows:

12.7. In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid (or accrued) as follows:
12.7.1 an amount equal to 0.50% of the aggregate nominal value of the Class A shares in issue shall be distributed (or

provisioned) equally to the holders of the Class A shares pro rata to their Class A shares, then

12.7.2 an amount equal to 0.45% of the aggregate nominal value of the Class B shares in issue shall be distributed (or

provisioned) equally to the holders of the Class B shares pro rata to their Class B shares, then

12.7.3 an amount equal to 0.40% of the aggregate nominal value of the Class C shares in issue shall be distributed (or

provisioned) equally to the holders of the Class C shares pro rata to their Class C shares, then

12.7.4 an amount equal to 0.35% of the aggregate nominal value of the Class D shares in issue shall be distributed (or

provisioned) equally to the holders of the Class D shares pro rata to their Class D shares, then

12.7.5 an amount equal to 0.30% of the aggregate nominal value of the Class E shares in issue shall be distributed (or

provisioned) equally to the holders of the Class E shares pro rata to their Class E shares, then

12.7.6 an amount equal to 0.25% of the aggregate nominal value of the Class F shares in issue shall be distributed (or

provisioned) equally to the holders of the Class F shares pro rata to their Class F shares, then

12.7.7 an amount equal to 0.20% of the aggregate nominal value of the Class G shares in issue shall be distributed (or

provisioned) equally to the holders of the Class G shares pro rata to their Class G shares, then

12.7.8 an amount equal to 0.15% of the aggregate nominal value of the Class H shares in issue shall be distributed (or

provisioned) equally to the holders of the Class H shares pro rata to their Class H shares, then

12.7.10 the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class in

reverse alphabetical order (i.e. first Class I shares, then if no Class I shares are in existence, Class H shares and in such
continuation until only Class A shares are in existence)."

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent on the Company and charged to it by

reason of the present deed are assessed at two thousand five hundred euros (EUR 2,500.-).

There being no further business, meeting is closed at 12.15 p.m..

The present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English, followed

by a French version; of the request of the appearing parties and in case of divergences between the English and the French
texts, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing parties, all known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, the said the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le deux septembre,
par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (le «Notaire»)

agissant en remplacement de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
momentanément absent, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés de Sentinel Holdings S.à r.l. (ci-après la "Société"), une société à

responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179.838,
constituée par un acte notarié établi par Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, le 9 août 2013, et dont
les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le "Mémorial")
numéro 2586 en date du 17 octobre 2013.

Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 10 février 2014, par un acte du notaire Maître Cosita Delvaux,

notaire alors de résidence à Redange-sur-Attert, publié au Mémorial numéro 1066 en date du 26 avril 2014.

L'assemblée est ouverte à 12.00 heures.

151999

L

U X E M B O U R G

Madame Khadigea Klingele, juriste sénior, dont l'adresse professionnelle est à Mondorf-les-Bains, a agi en tant que

président de l'assemblée avec l'accord de l'assemblée (le "Président").

Le Président a nommé Mademoiselle Marilyn Krecké, employé(e), dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg,

pour agir en tant que secrétaire (le "Secrétaire").

L'assemblée a élu Madame Khadigea Klingele, prénommée, pour agir en tant que scrutateur (le "Scrutateur").
Ces nominations ayant été effectuées, le Président a déclaré que:
I. Les noms des associés présents ou représentés à l'assemblée en vertu des procurations (les "Associés") et le nombre

de parts sociales détenues par eux sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, signée par et au nom
des Associés, le Notaire, le Président, le Scrutateur et le Secrétaire, ensemble avec les formulaires de procuration, signés
ne varietur par les Associés représentés à l'assemblée par des mandataires, le Notaire et le Président, le Scrutateur et le
Secrétaire, devront rester annexés au présent acte et devront être enregistrés avec cet acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les associés détenant 100 % du capital social de la Société ayant des droits de

vote sont présents ou représentés à l'assemblée par des mandataires. Tous les Associés ont déclaré avoir été suffisamment
informés de l'ordre du jour de l'assemblée en avance et ont renoncé aux exigences et formalités de convocation. L'assemblée
est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Décision de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de douze mille cinq cents euro (12.500,-

EUR) afin de le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille euro (125.000,-EUR) à cent douze mille cinq cents
euro (112.500,- EUR) par l'annulation d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de catégorie J, d'un
centime d'euro (0,01 EUR) chacune, qui ont été rachetées par la Société le 19 août 2015.

2. Modification subséquente des articles 6 et 12 des Statuts afin de refléter la résolution précédente.
3. Divers
Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

<i>Première résolution

Les Associés décident de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant douze mille cinq cents euros

(12.500,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) à cent douze mille
cinq cents euros (112.500,- EUR) par l'annulation d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de
catégorie J, d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune, qui ont été rachetées par la Société le 19 août 2015.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de modifier des articles 6 et 12 des Statuts afin de refléter la résolution précédente tels que l'article

6.1 et l'article 12.7 auront désormais la teneur suivante:

6.1. Capital Souscrit et Libéré.
6.1.1 Le capital social est fixé à 112.500,- EUR (cent douze cinq cents euros) représenté par 11.250.000 (onze millions

deux cent cinquante mille) parts sociales divisées en Catégories comme suit:

CATEGORIES DE PARTS SOCIALES

NOMBRES

DE PARTS

SOCIALES

Parts sociales de Catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250.000

Parts sociales de Catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250.000

Parts sociales de Catégorie C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250.000

Parts sociales de Catégorie D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250.000

Parts sociales de Catégorie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250.000

Parts sociales de Catégorie F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250.000

Parts sociales de Catégorie G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250.000

Parts sociales de Catégorie H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250.000

Parts sociales de Catégorie I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.250.000

chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR), toutes entièrement souscrites et inté-

gralement libérées et ayant les droits et obligations énoncés dans les présents Statuts.

6.1.2 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime

d'émission payée sur toute part sociale sera transférée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission
doivent être prises par l'(les) Associé(s) sous réserve de la Loi et des présents Statuts.

6.1.3 Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de parts sociales, y compris par l'annulation d'une

ou plusieurs Catégories entières de parts sociales par le rachat et l'annulation de la totalité des parts sociales émises dans

152000

L

U X E M B O U R G

cette (ces) Catégorie(s). Dans le cas de rachats et d'annulations de Catégories de parts sociales, ces annulations et rachats
de parts sociales seront effectués dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par la Catégorie I).

6.1.4 Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Catégorie de parts sociales (dans

l'ordre prévu à l'article 6.1.3), cette Catégorie de parts sociales donnera droit à son détenteur au prorata de sa détention dans
cette Catégorie au Montant Disponible (dans les limites toutefois du Montant Total d'Annulation tel que déterminé par
l'assemblée générale des associés) et les détenteurs de parts sociales de la Catégorie de Parts Sociales rachetée et annulée
recevront de la Société un montant équivalent à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque part sociale de la
Classe concernée détenue et annulée.

6.1.5 La Valeur d'Annulation par Part Sociale est calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de

parts sociales émises dans la Catégorie de parts sociales devant être rachetée et annulée.

6.1.6 Le Montant Total d'Annulation est un montant déterminé par le conseil de gérance de la Société et approuvé par

l'assemblée générale des associés sur base des Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour cha-
cune des Catégories I, H, G, F, E, D, C, B et A correspond au Montant Disponible de la Catégorie concernée au moment
de l'annulation de la Catégorie concernée, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés délibérant de la
manière prévue en matière de modification des Statuts, étant entendu toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit
jamais supérieur à ce Montant Disponible.

6.1.7 Au moment du rachat et de l'annulation des parts sociales de la Catégorie concernée, la Valeur d'Annulation par

Part Sociale deviendra due et exigible par la Société.

6.1.8 A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par
lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit."

L'article 12.7 aura désormais la teneur suivante:

12.7. En cas de déclaration de dividendes, ces derniers seront alloués et payés (ou accumulés) comme suit:
12.7.1 un montant équivalent à 0,50 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie A émises sera

distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie A au prorata de leurs parts
sociales de Catégorie A, ensuite

12.7.2 un montant équivalent à 0,45 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie B émises sera

distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie B au prorata de leurs parts
sociales de Catégorie B, ensuite

12.7.3 un montant équivalent à 0,40 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie C émises sera

distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie C au prorata de leurs parts
sociales de Catégorie C, ensuite

12.7.4 un montant équivalent à 0,35 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie D émises sera

distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie D au prorata de leurs parts
sociales de Catégorie D, ensuite

12.7.5 un montant équivalent à 0,30 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie E émises sera

distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie E au prorata de leurs parts
sociales de Catégorie E, ensuite

12.7.6 un montant équivalent à 0,25 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie F émises sera

distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie F au prorata de leurs parts
sociales de Catégorie F, ensuite

12.7.7 un montant équivalent à 0,20 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie G émises sera

distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie G au prorata de leurs parts
sociales de Catégorie G, ensuite

12.7.8 un montant équivalent à 0,15 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie H émises sera

distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie H au prorata de leurs parts
sociales de Catégorie H, ensuite

12.7.10 le solde du montant total distribué sera intégralement alloué aux détenteurs de la dernière Catégorie dans l'ordre

alphabétique inversé (c'est-à-dire en commençant par les parts sociales de Catégorie I, puis s'il n'existe pas de parts sociales
de Catégorie I, les parts sociales de Catégorie H et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des parts sociales de
Catégorie A)."

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison du présent acte, sont estimés à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

Plus rien étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12.15 heures.

Dont acte, cet acte notarié a été dressé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

152001

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné qui parle et comprend l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, connues du notaire par nom, prénom, état civil

et demeure, lesdites parties comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. Klingele, M. Krecké, M. Schaeffer.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 4 septembre 2015. GAC/2015/7531. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 2 octobre 2015.

Référence de publication: 2015162491/271.
(150179395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Batiart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4392 Pontpierre, 1, rue de Schifflange.

R.C.S. Luxembourg B 194.711.

Par la présent, moi, Andrade Madureira Paulo Sergio, suis au regret de vous informer, à la date d'aujourd'hui, que je

vous présent ma démission comme administrateur unique de la Firme Batiart S.A (numéro de registre de la société: B.
194711).

A partir du 1 

er

 octobre de 2015, je suis plus l'administrateur

Bascheleiden, le 17 août 2015.

Andrade Madureira Paulo Sergio.

Référence de publication: 2015161916/12.
(150179865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Beauty Light S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 184.774.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du

18 février 2014 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1112 du 2 mai 2014

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015161919/11.
(150178768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt (International) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 14.543.

AUSZUG

- Es ist zu vermerken, dass die Mandate von Herr Nigel Fielding, Herr Dr. Olaf Huth, Herr Paul Hagen, Frau Christiane

Lindenschmidt und Frau Carola Gräfin Von Schmettow als Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft mit der ordentlichen
Gesellschafterversammlung endeten.

- Aus dem Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft vom 30. April 2015 geht hervor,

dass die folgenden Personen mit sofortiger Wirkung in den Aufsichtsrat der Gesellschaft bestellt wurden:

* Dr. Andreas Wilhelm Kamp, geboren am 9. Februar 1976 in Geldern, Deutschland wohnhaft in Am Nussbaum 25,

D-40470, Düsseldorf, Deutschland;

* Herr Carsten Hennies, geboren am 14. April 1975 in Marl, Deutschland wohnhaft in Bergesweg 4, D-40489, Düssel-

dorf, Deutschland; und

* Herr Heiko Schröder, geboren am 25. Juni 1954 in Jever Landkreis Friesland, Deutschland, wohnhaft in Sonnenstraße

3, D-41564 Kaarst, Deutschland.

Die Dauer der Mandate der Aufsichtsratsmitglieder endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres

2016.

- Aus den Beschlüssen des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 30. April 2015 geht hervor, dass Herr Nigel Fielding,

geboren am 1. April 1962 in Manchester, Großbritannien, wohnhaft in 3, rue Marie Curie, L-5049 Strassen, Großherzogtum

152002

L

U X E M B O U R G

Luxemburg, mit sofortiger Wirkung und bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2017 in den Vorstand der
Gesellschaft bestellt wurde.

- Aus den Beschlüssen des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 9. September 2015 geht hervor, dass Herr Lars Ingemar

Rejding, geboren am 21. September 1965 in Råsunda, Sweden, wohnhaft in 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, mit sofortiger Wirkung und bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2017 in den
Vorstand der Gesellschaft bestellt wurde.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. Oktober 2015.

Référence de publication: 2015162161/31.
(150179772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Batiglobal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-7213 Béreldange, 21, Am Becheler.

R.C.S. Luxembourg B 103.315.

L’an deux mille quinze, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

ont comparu:

1) Monsieur Jean-Paul SCHNEIDER, salarié, demeurant à L-7209 Walferdange, 4, rue Grande-Duchesse Charlotte;
2) La société anonyme «SCHNEIDER SOPARFI S.A.», ayant son siège social à L-7209 Walferdange, 4, rue Grande-

Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
81.626,

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jean-Paul Schneider, habilité à engager ladite société par sa

signature individuelle,

agissant en leurs qualités de seuls associés de la société à responsabilité limitée BÂTIGLOBAL S.à r.l., avec siège social

à L-1933 Luxembourg, 43, rue Siggy vu Lëtzebuerg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro B 103 315,

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 30 septembre 2004,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1239 du 3 décembre 2004, dont les statuts en ont été
modifiés en dernier suivant acte reçu par le notaire Henri Beck, de résidence à Echternach, en date du 1 

er

 février 2012,

publié au Mémorial C numéro 719 du 19 mars 2012.

Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire

et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-1933 Luxembourg, 43, rue Siggy vu Lëtzebuerg, à

L-7213 Béreldange, 21, Am Becheler.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’adapter le premier alinéa de l’article 2 des statuts au changement de siège intervenu pour lui

donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 2. (Alinéa 1). Le siège social est établi dans la commune de Walferdange».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq cents euros (EUR 500.-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J.-P. SCHNEIDER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 28 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/30864. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

152003

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 2 octobre 2015.

Référence de publication: 2015161917/44.
(150179083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

F.A.H. Invest S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 82-86, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 50.426.

Le Bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05/07/2015.

Signature.

Référence de publication: 2015162076/10.
(150179016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Best of Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 156.917.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2015161921/11.
(150179502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Best of Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 156.917.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2015161922/11.
(150179513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Besti's S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 185.197.

<i>Décisions prises par le conseil d’administration lors de sa réunion du 1 

<i>er

<i> octobre 2015

- Le Conseil d’Administration, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Giovanni Spasiano de sa fonction

d’administrateur, décide d’accepter cette démission avec effet immédiat.

- Le Conseil d’Administration décide de coopter comme nouvel administrateur et président, avec effet immédiat, Mon-

sieur Cédric Finazzi, demeurant professionnellement au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, son mandat
ayant comme échéance celui de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BESTI'S S.A.
Société anonyme
Signature

Référence de publication: 2015161923/17.
(150179431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

152004

L

U X E M B O U R G

Climate Change Capital Carbon Fund II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 117.930.

Il résulte d’un transfert de parts sociales daté du 28 septembre 2015 que la société Monument Trustees Limited a cédé

l’intégralité de ses parts sociales (500 parts sociales) à la société Bunge Emissions Limited, une société à responsabilité
limitée  constituée  dans  les  Iles  Vierges  Britanniques,  immatriculée  auprès  du  Registre  du  Commerce  sous  le  numéro
BC1065110 et ayant son siège social à Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2015.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour Climate Change Capital Carbon Fund II S.à r.l.

Référence de publication: 2015161950/15.
(150179270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

BHS Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 195.362.

<i>Extrait de résolution du conseil d‘administration du 12 août 2015

Le conseil d’administration de la société anonyme BHS SERVICES S.A,, a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège

de la société de 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg à l’adresse suivante:

L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 12/08/2015.

Référence de publication: 2015161924/13.
(150179131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Biochar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 152.006.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 29 juillet 2015

<i>4 

<i>ème

<i> Résolution:

L'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat les mandats des Administrateurs et du Commissaire

aux comptes, à savoir:

- Monsieur Pierre GALAND, Administrateur et Président du Conseil d'Administration;
- Madame Josette BLAKE, Administrateur;
- Monsieur Philippe RICHELLE, Administrateur;
- H.R.T. REVISION S.A., Commissaire aux comptes;
Leurs mandats sont valables jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2021.

<i>Pour BIOCHAR S.A.

Référence de publication: 2015161929/17.
(150179497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

BP Caplux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8309 Capellen, Aire de Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 72.864.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société tenue en date du 29 juin 2015 que:
1) La société Ernst &amp; Young, établie et ayant son siège social à L-5365 MUNSBACH - 7, rue Gabriel Lippmann - Parc

d’Activité Syrdall, RCS Luxembourg No B47771, est nommée en tant que réviseur d'entreprises agrée jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.

152005

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 30 septembre 2015.

<i>POUR LE CONSEIL DE GERANCE
Par mandat
Nico SCHAEFFER

Référence de publication: 2015161935/16.
(150179374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Care Luxembourg S.A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 185.259.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 9 juin 2015, les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat

de réviseur d’entreprises agréé («zugelassener Wirtschaftsprüfer») de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 2, rue
Gerhard Mercator, L - 2182 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui
statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Référence de publication: 2015161945/13.
(150178735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Broker Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 71.854.

<i>Extrait des résolutions prises par le liquidateur de la société en date du 1 

<i>er

<i> octobre 2015

Le siège social de la Société est transféré de son ancienne adresse au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg à sa nouvelle

adresse: 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015161940/12.
(150179317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Bryson SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 193.805.

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2015

Ce jour, il a été décidé de la démission de Monsieur MARIN Giovanni au poste d’administrateur délégué avec effet

immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L’assemblée

Référence de publication: 2015161941/12.
(150179698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Gebäudereinigung Peifer S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 72B, Wäistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 113.792.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution de société, reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date

du 18 septembre 2015, numéro 2015/2111 de son répertoire, enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 septembre
2015, relation: 1LAC/2015/30910 de la société à responsabilité limitée "Gebäudereinigung Peifer s.à r.l.", avec siège social
à L-5445 Schengen, 72B, Wäistrooss, inscrite au RCS à Luxembourg sous le numéro B 113 792, constituée suivant acte
reçu par Maître Martine SCHAEFFER, alors notaire de résidence à Remich, en date du 16 janvier 2006, publié au Mémorial
C numéro 974 du 18 mai 2006, ce qui suit:

152006

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Rolf PEIFER, seul associé, a déclaré procéder à la dissolution et à la liquidation de la société prédite, avec

effet au 18 septembre 2015,

- la société dissoute n'a plus d'activités.
- l’associé a déclaré en outre que la liquidation de la prédite société a été achevée et qu'il assume tous les éléments actifs

et passifs éventuels de la société dissoute.

- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années à l’adresse suivante:

D-66663 Merzig, Im Holzhau 9A.

Bascharage, le 5 octobre 2015.

Pour extrait conforme
<i>Le notaire

Référence de publication: 2015162122/25.
(150179978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

BTX Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 167.043.

L’an deux mille quinze, le dix-huit du mois de septembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agis-

sant en remplacement de Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
laquelle dernière restera dépositaire de la présente minute.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «BTX Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.», une

société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167043 (ci-
après désignée la Société), constituée par acte de Maître Francis Kesseler, alors notaire de résidence à Esch/Alzette, en
date du 7 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 5 avril 2012, numéro 892,
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Francis Kesseler, prénommé, en date du 11 avril
2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1374 en date du 11 juin 2013.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mme Monique Drauth, salariée, ayant son adresse professionnelle à

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le  président  désigne  comme  secrétaire  et  comme  scrutateur  Mme  Rachida  El  Farhane,  salariée,  ayant  son  adresse

professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Tous les actionnaires ont été dûment convoqués en date du 9 septembre 2015, par courrier recommandé conformément

à l’article 13 des statuts de la société et ont eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

II. Les actionnaires présents ou représentés en vertu de deux (2) procurations données sous seing privé durant le mois

de septembre 2015, et le nombre d’actions qu'ils détiennent est renseigné sur une liste de présence, signée par le président,
le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui aux formalités de l’enregistrement.

III. Il apparaît de cette liste de présence que deux cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante-seize (279.676) actions

ordinaires de catégorie A, une (1) action ordinaire de catégorie B et une (1) action de commandité en circulation, représentant
ensemble cent pourcent (100,00 %) du capital social de la Société établi à deux cent soixante-dix-neuf mille six cent
soixante-dix-huit Couronnes Danoises (DKK 279.678,00), toutes entièrement libérées, sont présentes ou représentées à la
présente assemblée, de sorte que l’assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à son ordre du jour.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de la Société de 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Modification consécutive de l’article 4 paragraphe 1 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

“ Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.”
V. L’assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, municipalité de

Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

152007

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 4 paragraphe 1 des statuts de la Société afin

de lui donner la teneur suivante:

“ Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.”

En version anglaise

“ Art. 4. The Company will have its registered office in the municipality of Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.”

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués à la somme de huit cent cinquante Euro (EUR 850,-).

<i>Déclaration

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des personnes comparantes, connus du

notaire par leurs noms et prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Drauth, El Farhane, MOUTRIER agissant en remplacement de GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/30178. Reçu soixante-quinze

euros (75,00 €)

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2015.

Référence de publication: 2015161942/63.
(150179319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Central European Realty Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 170.831.

Il résulte de la résolution écrite des actionnaires de la Société prise le 1 

er

 juin 2015 que:

(i) Monsieur GÁBOR MURÁNYI (résidant à Horgász utca 6., 7461 Kaposvár, Hongrie) a été nommé en tant que gérant

de catégorie A, avec effet immédiat;

(ii) Monsieur FERENC MURÁNYI (Jr) (résidant à Horgász utca 6., 7461 Kaposvár, Hongrie) a été nommé en tant que

gérant de catégorie A, avec effet immédiat;

(iii) Monsieur GÁBOR KACSH (résidant professionnellement au 291, route d'Arlon, L-1150, Grand-Duché de Lu-

xembourg) a été nommé en tant que gérant de catégorie B, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015161946/17.
(150179223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Darmisa SPF, S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 164.967.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 septembre 2015

<i>Résolutions:

L’Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la Société au 50, route d’Esch, L-1470 Lu-

xembourg.

L’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, comme nouveaux Administrateurs:
- Madame Audrey Petrini, employée privée, demeurant professionnellement au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, en qualité d’Administrateur et de Président du Conseil d’Administration;

- Monsieur Denis Callonego, employé privé, demeurant professionnellement au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, en qualité d’Administrateur;

152008

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Martin Rutledge, employé privé, demeurant professionnellement au 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,

en qualité d’Administrateur.

Le mandat des Administrateurs ainsi nommés viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.
L’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, comme nouveau Commissaire aux Comptes, la société:
- Morwell Limited, ayant son siège social Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques et dont le certificat d’incor-

poration porte le numéro 350391.

Le mandat du Commissaire aux Comptes ainsi nommé, viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra

en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Darmisa SPF, S.A.
Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial
Signatures

Référence de publication: 2015162009/28.
(150179383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Centuria Capital Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 144.076.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue à Ledeulange en date du 1 

<i>er

<i> octobre 2015

L’Assemblée a pris la résolution suivante:
- L’Assemblée a décidé d’accepter la démission de:

* Madame Claudia Schweich, née le 1 

er

 Août 1979, à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 15, rue

Léon Laval, L-3372 Leudelange en qualité d’Administrateur et Administrateur-délégué avec effet au 1 

er

 octobre 2015;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Leudelange, le 1 

er

 octobre 2015.

<i>Pour Centuria Capital Luxembourg S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015161947/17.
(150179347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Caetano S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 38, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 154.685.

<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social d'Esch/Alzette le 30 septembre

<i>2015.

- En date du 30 septembre 2015, Mme Maria do Céu CORREIA GOMES CAETANO, demeurant à L-3855 SCHIF-

FLANGE, 49, Cité Emile Mayrisch, a cédé à Mme Pereira Ribeiro Ana Maria, demeurant à L-4260 ESCH/ALZETTE, 37,
rue du Nord 50 (cinquante) parts sociales de la société CAETANO S.A R.L.

Il résulte après cette cession de parts sociales que le capital social de la société prémentionnée est reparti de la façon

suivante:

Madame Maria do Céu CORREIA GOMES CAETANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts
Madame Ana Maria PEREIRA RIBEIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts

- Madame Maria do Céu CORREIA GOMES CAETANO, demeurant à L-3855 SCHIFFLANGE, 49, Cité Emile May-

risch est radier en tant que gérante administrative de la société CAETANO S.A R.L. prédésignée, avec effet immédiat.

- Madame Ana Maria PEREIRA RIBEIRO, demeurant à L-4260 ESCH/ALZETTE, 37, rue du Nord, est nommé gérante

administrative de la société CAETANO S.A R.L. prédésignée, avec effet immédiat.

Il résulte après cette décision, que le nombre des gérants est fixé à deux.
- Monsieur Joâo CAETANO MARQUES, demeurant à L-3855 SCHIFFLANGE, 49, Cité Emile Mayrisch,
* Gérant Technique pour une durée indéterminée.
- Madame Ana Maria PEREIRA RIBEIRO, demeurant à L-4260 ESCH/ALZETTE, 37, rue du Nord,

152009

L

U X E M B O U R G

* Gérante Administrative pour une durée indéterminée.

Esch/Alzette, le 30 septembre 2015.

Référence de publication: 2015161959/26.
(150179430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 35.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 67.895.

La liste des signataires autorisés a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2015.

Référence de publication: 2015162001/11.
(150179454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Camon Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.419.

<i>Dépôt des comptes annuels remplaçant le dépôt n°L150134601 du 24/07/2015

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2014 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2015161961/12.
(150177836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Cap Lounge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2159 Luxembourg, 18, rue de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 120.963.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait du procès-verbal des décisions des Associés du 30 septembre 2015

Il résulte du procès-verbal des décisions des Associés du 30 septembre 2015 que:
- Les Associés ont décidé à l’unanimité d'approuver le rapport du Liquidateur ainsi que les comptes de liquidation;
- Les Associés ont donné à l’unanimité décharge pleine et entière au Liquidateur et au Commissaire-Vérificateur;
- Les Associés ont décidé à l’unanimité que la société a définitivement cessé d'exister et ont décidé par conséquent de

prononcer la clôture de la liquidation de la Société;

- Les Associés ont décidé à l’unanimité que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq

ans  à  l’ancien  siège  de  la  société,  de  même  qu’y  resteront  consignés  les  sommes  et  valeurs  éventuelles  revenant  aux
créanciers ou aux associés et dont la remise n’aurait pu leur être faite.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2015.

CAP LOUNGE S.à r.l. en liquidation

Référence de publication: 2015161963/20.
(150180580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Impexsolar Company, Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 147.256.

EXTRAIT

Il résulte d’un procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Impexsolar Company S.A. qui s’est

tenue au siège social de la société le 10 juin 2015 que:

152010

L

U X E M B O U R G

- La société accepte les démissions de Monsieur Grégory DODEMONT, de Madame Elodie DE BORMAN et Madame

Isabelle TACHE de leur poste d’administrateur avec effet immédiat.

- Est nommé en tant qu’administrateur unique Monsieur Jean CACCIATORE, né le 03 décembre 1970 à Verviers

(Belgique), demeurant à 16, rue Nouvelle Route, B-4831 Bilstain, pour une durée de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale à
tenir en 2020.

- Est nommé en remplacement de FISCALAIS (Luxembourg) Sàrl en tant que commissaire aux comptes la société

Commercial Consulting Europe Ltd, ayant son siège au 6 London Street, 2nd floor, GB-WZHR London, immatriculée au
Companies House, sous le numéro 06645018, pour une durée de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2020.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 octobre 2015.

<i>Pour Impexsolar Company S.A.
LPL Expert-Comptable Sàrl

Référence de publication: 2015162189/22.
(150179316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Capitole Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 106.466.

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 18 septembre 2015 au siège social de la

<i>société.

Démission de Madame Elise Lethuillier en tant qu’administrateur de la société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Monsieur Emmanuel Manega, né le 20 novembre 1976 à Thionville (France), demeurant professionnel-

lement  au  16,  boulevard  Emmanuel  Servais  L-2535  Luxembourg,  en  remplacement  de  Madame  Elise  Lethuillier,
administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015161964/18.
(150179055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Cartayat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 57.432.

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 18 septembre 2015 au siège social de la

<i>société.

Démission de Madame Elise Lethuillier en tant qu’administrateur de la société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame maria Dos Santos, née 22 août 1976 à Metz (France), demeurant professionnellement au 16,

boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, en remplacement de Madame Elise Lethuillier, administrateur démis-
sionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015161966/18.
(150179134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

152011

L

U X E M B O U R G

Cheniclem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 62.863.

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 18 septembre 2015 au siège social de la

<i>société.

Démission de Madame Elise Lethuillier en tant qu’administrateur de la société et ce, avec effet immédiat.

Cooptation de Monsieur Jean-Marc Koltès, né 1 

er

 septembre 1968 à Algrange (France), demeurant professionnellement

au 16, boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, en remplacement de Madame Elise Lethuillier, administrateur
démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015161981/18.
(150179054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

CC Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 144.491.

Par la présente, nous vous informons de notre démission du poste de Commissaire aux Comptes de la Société.
Notre démission prendra effet le 25 septembre 2015.

Luxembourg, le 25 septembre 2015.

CAS Services SA
Signatures

Référence de publication: 2015161971/12.
(150178961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

CDCL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 21, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 16.861.

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie au siège de la société le 28 mai 2014 a renouvelé les mandats des administrateurs,

à l’exception de Monsieur Pierre Ahlborn, et du réviseur d’entreprises agrée pour un terme d’une année.

Le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Marc Assa
- Monsieur Jean-Marc Kieffer
- Monsieur Claude Didier
- Monsieur Jean Feyereisen
- Monsieur Carlo Walentiny
Le réviseur d’entreprises agréé est la société Ernst &amp; Young, ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippman L-5365

Munsbach, Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B47771.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2016.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 2 octobre 2015.

Référence de publication: 2015161972/21.
(150179651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

152012

L

U X E M B O U R G

New Way S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2555 Luxembourg-Merl, 62, rue de Strassen.

R.C.S. Luxembourg B 25.203.

Il résulte d’une cession de parts sociales de la société à responsabilité limitée NEW WAY S.à.r.l. signées le 10 septembre

2015 que les parts ont fait l'objet de la cession suivante:

1. La société F.I.L. Holding S.A., inscrit au RCSL sous le numéro B 101.861, ayant son siège social à L-4024 Esch-sur-

Alzette, 371, route de Belval a cédé la propriété de 10 parts sociales à Monsieur Tom Grün, demeurant à 14, domaine
Schmiseleck L-3373 Leudelange

Suite à cette cession de parts sociales, la répartition des parts sociales est modifiée comme suit:

- WEEKEND s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 parts

- DEMEC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 parts

- Monsieur Tom Grün . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 01/10/2015.

G.T. Experts Comptables S.à.r.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2015162365/21.
(150178773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Chinto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 78.846.

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 18 septembre 2015 au siège social de la

<i>société.

Démission de Madame Elise Lethuillier en tant qu’administrateur de la société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Maria Dos Santos, né le 22 août 1976 à Metz (France), demeurant professionnellement au 16,

boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, en remplacement de Madame Elise Lethuillier, administrateur démis-
sionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015161983/18.
(150179082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

CL Management SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 183.640.

Une liste des fondés de pouvoirs de la Société CL Management S.A. en fonction au 1 

er

 Octobre 2015 a été déposée au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CL Management S.A.
Signatures

Référence de publication: 2015161986/12.
(150179151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

152013

L

U X E M B O U R G

Corolla Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 88.309.

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 18 septembre 2015 au siège social de la

<i>société.

Démission de Madame Elise Lethuillier en tant qu’administrateur de la société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Eva Boehm, né le 28 novembre 1974 à Bonn (Allemagne), demeurant professionnellement au

16, boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, en remplacement de Madame Elise Lethuillier, administrateur
démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015161989/18.
(150179081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Crawford Industries S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 161.790.

<i>Extrait de la résolution prise par l’actionnaire unique de la société en date du 5 janvier 2015.

L’Actionnaire Unique a décidé de nommer un Conseil d’Administration composé de 3 membres et appelle en consé-

quence aux postes d’administrateurs:

- Monsieur Claude FAVRE, né le 22 septembre 1967 à Voiron (France), gérant, dont l'adresse professionnelle est au 38

avenue du X septembre, L-2550, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

- Monsieur Jean-Emmanuel SAUVEE, né le 21 juin 1964 à Suresnes (France), gérant, dont l'adresse est au 122 rue du

Commandant Rolland La cadenelle Chambord III, F-13008 Marseille, France.

Leurs mandats d’administrateurs viendront à échéance lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en

2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2015161993/19.
(150179435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Creabois S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 48.029.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Par jugement n° 896/15 rendu le 1 

er

 octobre 2015, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a déclaré closes, pour absence d'actif, les opérations de liquidation de la société anonyme
CREABOIS SA, avec siège social à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, dénoncé le 6 avril 2006.

Pour extrait conforme
Maître Thibault CHEVRIER
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2015161994/14.
(150178950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

152014

L

U X E M B O U R G

SpongeVest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 198.236.

1. L’associé CapVest Equity Partner III L.P., une société de droit de Jersey, ayant son siège social au 11 - 15 Seaton

Place, St. Helier, JE4 0QH, Jersey, a cédé 2.630.180 parts sociales de chacune des catégories A, B, C, D, E, F, G, H, I et
J de la société SpongeVest S.à r.l., une société de droit luxembourgeoise ayant son siège social à 7, rue Lou Hemmer,
L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg à la société CV Valvest III L.P., une société de droit de Jersey,
ayant son siège social au 11 - 15 Seaton Place, St. Helier, JE4 0QH, Jersey.

2. L’associé CapVest Equity Partner III B L.P., une société de droit de Jersey, ayant son siège social au 11 - 15 Seaton

Place, St. Helier, JE4 0QH, Jersey, a cédé 665.220 parts sociales de chacune des catégories A, B, C, D, E, F, G, H, I et J
de la société SpongeVest S.à r.l., une société de droit luxembourgeoise ayant son siège social à 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg à la société CV Valvest III L.P., une société de droit de Jersey, ayant
son siège social au 11 - 15 Seaton Place, St. Helier, JE4 0QH, Jersey.

3. L’associé CapVest Equity Partner III C L.P., une société de droit de Jersey, ayant son siège social au 11 - 15 Seaton

Place, St. Helier, JE4 0QH, Jersey, a cédé 221.740 parts sociales de chacune des catégories A, B, C, D, E, F, G, H, I et J
de la société SpongeVest S.à r.l., une société de droit luxembourgeoise ayant son siège social à 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg à la société CV Valvest III L.P., une société de droit de Jersey, ayant
son siège social au 11 - 15 Seaton Place, St. Helier, JE4 0QH, Jersey.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SpongeVest S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2015162502/27.
(150179387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

D-VB Finapa S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 150.778.

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 18 septembre 2015 au siège social de la

<i>société.

Démission de Madame Elise Lethuillier en tant qu’administrateur de la société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Monsieur Vincent Didier, né le 25 août 1980 à Châlons en Champagne (France), demeurant profession-

nellement  au  16,  boulevard  Emmanuel  Servais  L-2535  Luxembourg,  en  remplacement  de  Madame  Elise  Lethuillier,
administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015161997/18.
(150179080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Dana Manufacturing Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 199.057.

Il résulte des décisions prises par l’associé unique de la Société en date du 30 septembre 2015 que:
- Mr. Gérard Becquer a démissionné de ses fonctions de gérant de classe B de la Société avec au 3 octobre 2015;
- Mr. David Maréchal a démissionné de ses fonctions de gérant de classe B de la Société avec au 3 octobre 2015;

152015

L

U X E M B O U R G

- Mr. Tony Whiteman, né le 24 mai 1969 à Hamilton, Nouvelle Zélande, résidant au 14 rue Jean Mercatoris, L-7237

Luxembourg  a  été  nommé  nouveau  gérant  de  classe  B  de  la  Société  avec  effet  au  3  octobre  2015  et  pour  une  durée
indéterminée; et

- Mme. Valérie Warland, née le 9 mai 1972 à Namur, Belgique, résidant au 11 rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg

a été nommée nouveau gérant de classe B de la Société avec effet au 3 octobre 2015 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2015.

<i>Pour la Société
Un Mandataire

Référence de publication: 2015161998/20.

(150179707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Dixor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 114.254.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 1 

<i>er

<i> septembre 2015

Les administrateurs décident, conformément à l'article 6 des statuts et à l'article 51, paragraphe 4, de la loi modifiée du

10 Août 1915, concernant les sociétés commerciales, de coopter

Madame Emilie GALLAIS née le 3 mai 1978 à Coutances (France) avec adresse professionnelle au 50 rue Charles

Martel  L-2134  Luxembourg,  en  qualité  d'administrateur  en  remplacement  de  l'administrateur  démissionnaire  M.  Rob
SONNENSCHEIN.

Son mandat d’administrateur expirera lors de l’assemblée générale en 2017.

Extrait sincère et conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015162017/16.

(150178931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Solver S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 127.363.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015162538/9.

(150179752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Solver S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 127.363.

Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015162539/9.

(150179755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

152016


Document Outline

Batiart S.A.

Batiglobal S.à r.l.

Beauty Light S.A.

Besti's S.A.

Best of Luxembourg S.A.

Best of Luxembourg S.A.

BHS Services S.A.

Biochar S.A.

BP Caplux S.A.

Broker Invest S.A.

Bryson SA

BTX Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.

Caetano S.à r.l.

Camon Invest S.A.

Capitole Development S.A.

Cap Lounge S.à r.l.

Care Luxembourg S.A.

Cartayat S.A.

CC Real Estate S.A.

CDCL S.A.

Central European Realty Corporation S.à r.l.

Centuria Capital Luxembourg S.A.

Cheniclem S.A.

Chinto S.A.

Climate Change Capital Carbon Fund II S.à r.l.

CL Management SA

Corolla Holding S.A.

Crawford Industries S.A.

Creabois S.A.

Dana Manufacturing Luxembourg S.à r.l.

Darmisa SPF, S.A.

Deloitte Audit

Dixor S.A.

D-VB Finapa S.A., SPF

F.A.H. Invest S.A. - SPF

firewall Management Hard Equity S.A.

First Business Parks Holdings II S.à r.l.

Gebäudereinigung Peifer S. à r.l.

HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt (International) S.A.

Impexsolar Company

New Way S.à r.l.

Sentinel Holdings S.à r.l.

Solver S.A.

Solver S.A.

SpongeVest S.à r.l.