This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3104
13 novembre 2015
SOMMAIRE
Aerodynamics S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148949
AH Realty (Spain) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
148949
Alexandre Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
148949
AlgoQuest System S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148951
Aline Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148948
Allmende S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148947
Althyda International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
148946
Amenagement Commercial Grand-Rue . . . . .
148946
Amenoffice S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148946
Apollo BidCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148951
Apollo HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148947
aPRIVA S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148950
Art & Build s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148951
Audatex Holdings II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
148947
Augitherm Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148950
Bakapa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148948
BCD Travel Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
148948
Bensell Real Estate Holdings II Sàrl . . . . . . . .
148951
Boca S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148947
Bolton Square S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148948
Bombicht Carburants S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
148948
Cardboard International S.A. . . . . . . . . . . . . .
148992
CATBI Associates s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
148992
CHC Helicopter (3) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
148976
CityEl S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148987
Crystal Carmine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148992
Digital Services XXVII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
148947
DR Alésia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148949
DR Cap Corniche S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
148951
Eradius Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
148959
Glow Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148979
Glow Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148952
Grand City Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
148972
Hydraulique Service S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
148949
Immoshine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148956
Infor Lux Bond Company . . . . . . . . . . . . . . . . .
148985
J.J.R. GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148971
K.F. Invest SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148985
La Casa Moderna S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
148974
Lazur Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
148960
Logs Holdings Pledgeco S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
148960
LSREF3 GTC Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
148968
Magnate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148987
Nodeta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148946
Safety-Coach S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148985
SDE, système D énergie S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
148946
Vandenbroeck Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
148950
Vecchia Roma Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148950
Wap Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148977
Weblogistics S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148950
148945
L
U X E M B O U R G
Nodeta S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 166.475.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015160209/9.
(150176610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Amenoffice S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 76.100.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AMENOFFICE S.A.
Référence de publication: 2015159879/10.
(150176434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
SDE, système D énergie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9964 Huldange, 80, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 168.828.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015160307/10.
(150176346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Amenagement Commercial Grand-Rue, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 82, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 189.779.
<i>Dépôt des comptes annuels remplaçant le dépôt n°L150132781 du 23/07/2015i>
Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2014 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'Organe de Gestioni>
Référence de publication: 2015159878/12.
(150176069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Althyda International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 246, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 156.450.
EXTRAIT
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29/09/2015.
ALTHYDA INTERNATIONAL S.A.
<i>Le conseil d’Administrationi>
Référence de publication: 2015159875/13.
(150176723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
148946
L
U X E M B O U R G
Allmende S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 21.902.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159873/9.
(150176258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Apollo HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 172.233.
Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2015.
Référence de publication: 2015159861/10.
(150176775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Audatex Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 303.171.214,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 115.637.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Référence de publication: 2015159862/10.
(150176837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Boca S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 106.220.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BOCA S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015159901/11.
(150176915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Digital Services XXVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.467.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 18 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2514 du 17
septembre 2014.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Digital Services XXVII s.à r.l.
Référence de publication: 2015159964/14.
(150176509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
148947
L
U X E M B O U R G
BCD Travel Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 15, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 36.786.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159895/9.
(150176589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Bombicht Carburants S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 129.649.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BOMBICHT CARBURANTS SARL
Référence de publication: 2015159890/10.
(150176587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Aline Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 53.656.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015159871/10.
(150176338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Bakapa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3737 Rumelange, 29, rue Henri Luck.
R.C.S. Luxembourg B 129.740.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L-3737 Rumelange, le 24 septembre 2015.
Monsieur André Bousser
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015159894/12.
(150176457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Bolton Square S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 105.698.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2015159902/13.
(150176790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
148948
L
U X E M B O U R G
Alexandre Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2335 Luxembourg, 33, rue NS Pierret.
R.C.S. Luxembourg B 128.992.
Le bilan au 31 décembre 2014 et annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159870/9.
(150176278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Aerodynamics S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 102.118.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Référence de publication: 2015159864/10.
(150176832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
AH Realty (Spain) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 107.864.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015159867/10.
(150176744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Hydraulique Service S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 18, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 90.701.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, den 14. Januar 2015.
Référence de publication: 2015160086/10.
(150176466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
DR Alésia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 115.318.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, alors notaire de résidence à Mersch, en date
du 30 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1181 du 17 juin 2006.
Les comptes annuels de la Société au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DR Alésia S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2015159978/14.
(150176620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
148949
L
U X E M B O U R G
Weblogistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5423 Ersange, 19, rue du Village.
R.C.S. Luxembourg B 107.785.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159800/9.
(150175719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Vandenbroeck Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-3378 Livange, 251, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 179.909.
<i>Rectificatif au dépôt du 19/03/2015 n° L150050113i>
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159781/10.
(150174592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Vecchia Roma Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3717 Rumelange, 2, rue du Couvent.
R.C.S. Luxembourg B 106.403.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PINHEIRO Samantha.
Référence de publication: 2015159782/10.
(150175433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Augitherm Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9573 Wiltz, 32A, rue Michel Thilges.
R.C.S. Luxembourg B 173.748.
Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2014 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Derenbach, le 29/09/2015.
FRL SA
Signature
Référence de publication: 2015159884/12.
(150176843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
aPRIVA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 165.644.
Die Bilanz zum 31. Dezember 2014 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2014 abgelaufene
Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 29. September 2015.
<i>Für aPRIVA S.à r.l.
Ein Beauftragteri>
Référence de publication: 2015159847/13.
(150176791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
148950
L
U X E M B O U R G
Bensell Real Estate Holdings II Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 148.502.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159888/9.
(150176615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Apollo BidCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 172.247.
Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2015.
Référence de publication: 2015159860/10.
(150176774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Art & Build s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 153, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 144.894.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015159881/10.
(150176479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
AlgoQuest System S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 154.716.
Le bilan au 31 décembre 2013 (rectificatif du dépôt initial n°L140171080 enregistré en date du 29/09/14) a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015159856/11.
(150175492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
DR Cap Corniche S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 111.673.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, alors notaire de résidence à Mersch, en date
du 21 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 425 du 27 février 2006.
Les comptes annuels de la Société au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DR Cap Corniche S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2015159979/14.
(150176625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
148951
L
U X E M B O U R G
Glow Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 8.412.500,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 198.674.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of August,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
Glow Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having a share capital of seven million six hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 7,612,500.-), with registered
office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under number B 198.596,
hereafter referred to as the “Shareholder”,
hereby represented by Maître Stephan Weling, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on August 19, 2015.
The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Glow
Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a
share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Marc Loesch, notary residing
in Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg on 30 June 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
198.674 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To create two new classes of shares, namely the “Class A Ordinary Shares” and the “Class B Preferred Shares”.
2 To convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares into twelve thousand five hundred
(12,500) Class A Ordinary Shares.
3 To increase the issued capital of the Company by an amount of eight million four hundred thousand euro (EUR
8,400,000.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to an amount
of eight million four hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 8,412,500.-).
4 To issue seven million three hundred forty thousand six hundred twenty-five (7,340,625) new Class A Ordinary Shares
with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, and one million fifty-nine thousand three hundred seventy-five
(1,059,375) Class B Preferred Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share.
5 To accept subscription for these new Class A Ordinary Shares and Class B Preferred Shares by Glow Holding S.à r.l.,
and to accept payment in full of each such new Class A Ordinary Share and Class B Preferred Share by a contribution in
cash.
6 To amend paragraph 1 of article 5 as well as article 28 and article 29 of the articles of incorporation of the Company,
in order to reflect the foregoing agenda, and to define the respective financial rights of the Class A Ordinary Shares and
the Class B Preferred Shares.
7 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to create two new classes of shares, namely the “Class A Ordinary Shares” and the “Class B
Preferred Shares”.
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares into twelve
thousand five hundred (12,500) Class A Ordinary Shares.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to increase the issued capital of the Company by an amount of eight million four hundred
thousand euro (EUR 8,400,000.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) to an amount of eight million four hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 8,412,500.-).
148952
L
U X E M B O U R G
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved to issue seven million three hundred forty thousand six hundred twenty-five (7,340,625) new
Class A Ordinary Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, and one million fifty-nine thousand three
hundred seventy-five (1,059,375) Class B Preferred Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared the Shareholder represented as stated above.
The Shareholder declared to subscribe seven million three hundred forty thousand six hundred twenty-five (7,340,625)
new Class A Ordinary Shares and for one million fifty-nine thousand three hundred seventy-five (1,059,375) Class B
Preferred Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share and to fully pay in cash for these shares.
The amount of eight million four hundred thousand euro (EUR 8,400,000.-) was thus as from that moment at the disposal
of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Fifth resolutioni>
In view of the above, the Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5, and to restate article 28 and
article 29 of the articles of association of the Company so as to reflect the foregoing resolutions, and to define the respective
rights of the Class A Ordinary Shares and the Class B Preferred Shares.
As a result, paragraph 1 of article 5 shall from now on read as follows:
“ Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at eight million four hundred twelve thousand five
hundred euro (EUR 8,412,500.-) divided into seven million three hundred fifty-three thousand one hundred twenty-five
(7,353,125) Class A Ordinary Shares and one million fifty-nine thousand three hundred seventy-five (1,059,375) Class B
Preferred Shares, all with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.”
As a result, article 28 shall from now on read as follows:
“ Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year
be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s).
In respect of each distribution of dividends, the amount allocated to this effect shall be distributed as follows. First, the
Class B Preferred Shares shall entitle on a pro rata basis to a preferred cumulative dividend in an amount of eight percent
(8%) per annum of the aggregate nominal value of the Class B Preferred Shares and second, the Class A Ordinary Shares
shall entitle to any remaining dividend which shall be allocated pro rata among the Class A Ordinary Shares.
Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)
may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.”
As a result, article 29 shall from now read as follows:
“ Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by
half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may
be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compen-
sation.
In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:
(i) first, the creditors (whether by payment or the making of reasonable provision for payment thereof) for all the
Company’s debts and liabilities;
(ii) second, to the holders of Class B Preferred Shares for the repayment of the nominal value of their Class B Preferred
Shares and for an amount corresponding (and in no case exceeding) to the entitlement of these Class B Preferred Shares
to preferred dividends in accordance with Article 28, third paragraph, above, on a pro rata basis;
(iii) third, to the holders of Class A Ordinary Shares for the repayment of the nominal value of their Class A Ordinary
Shares and for an amount corresponding to the remaining assets and cash to be distributed, on a pro rata basis.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at four thousand three hundred euro (EUR 4,300.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the German texts, the English text will prevail.
148953
L
U X E M B O U R G
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, who is known to the undersigned notary
by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this
original deed.
Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am einundzwanzigsten Tag des Monats August,
vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, (Großherzogtum Luxemburg),
ist erschienen:
Glow Holding S.à r.l, eine nach dem luxemburgischen Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit
einem Gesellschaftskapital von sieben Millionen sechshundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 7.612.500.-) und Sitz
in 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxemburg-Findel, Großherzogtum Luxemburg, und eingetragen beim Handels- und Ge-
sellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 198.596,
hiernach der „Gesellschafter“ genannt,
hier vertreten durch Maître Stephan Weling, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
kraft einer privatschriftlichen am 19. August 2015 erteilten Vollmacht.
Die vorgenannte Vollmacht bleibt dieser Urkunde zum Zwecke der Eintragung dauerhaft beigefügt.
Der Gesellschafter hat den unterzeichnenden Notar gebeten anzugeben, dass er der alleinige Gesellschafter von Glow
Investment S.à r.l. ist, einer nach dem luxemburgischen Recht gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit
einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und Sitz in 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel, Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß einer Urkunde von Maître Marc Loesch, Notar mit
Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg vom 30. Juni 2015, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations veröffentlicht wurde, und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter
Nummer B 198.674 (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert.
Der Gesellschafter, vertreten wie oben dargestellt, erklärte über die Beschlüsse ausführlich informiert zu sein, welche
auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind:
<i>Tagesordnungi>
1. Schaffung von zwei neuen Anteilsklassen, namentlich die „Stammanteile der Klasse A“ und die „Vorzugsanteile der
Klasse B“.
2. Umwandlung der existierenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile in zwölftausendfünfhundert
(12.500) Stammanteile der Klasse A.
3. Erhöhung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals um einen Betrag von acht Millionen vierhunderttausend Euro (EUR
8.400.000.-), um das bestehende Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf acht Millionen vierhun-
dertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 8.412.500,-) zu erhöhen.
4. Schaffung von sieben Millionen dreihundertvierzigtausendsechshundertfünfundzwanzig (7.340.625) Stammanteilen
der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil, und von einer Million neunundfünfzig-
tausenddreihundertfünfundsiebzig (1.059.375) Vorzugsanteilen der Klasse B, mit einem Nennwert von jeweils einem Euro
(EUR 1,-) pro Anteil.
5. Zustimmung zur Zeichnung dieser neuen Stammanteile der Klasse A und dieser neuen Vorzugsanteile der Klasse B
durch Glow Holding S.à r.l., und Zustimmung zur vollständigen Zahlung dieser neuen Anteile in bar.
6. Neufassung des ersten Absatzes von Artikel 5 sowie von Artikel 28 und Artikel 29 der Satzung, um die oben genannten
Beschlüsse abzubilden und die jeweiligen finanziellen Rechte der Stammanteile der Klasse A und der Vorzugsanteile der
Klasse B festzulegen.
7. Verschiedenes.
und forderte daraufhin den unterzeichnenden Notar auf, die folgenden Beschlüsse festzuhalten:
<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschafter beschloss, zwei neue Anteilsklassen, namentlich die „Stammanteile der Klasse A“ und die „Vor-
zugsanteile der Klasse B“, zu schaffen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschloss, die existierenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile in zwölftausendfünf-
hundert (12.500) Stammanteile der Klasse A umzuwandeln.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschloss, das ausgegebene Gesellschaftskapital um einen Betrag von acht Millionen vierhundert-
tausend Euro (EUR 8.400.000.-) zu erhöhen, um das bestehende Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-)
auf acht Millionen vierhundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 8.412.500,-) zu erhöhen.
148954
L
U X E M B O U R G
<i>Vierter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschloss, sieben Millionen dreihundertvierzigtausendsechshundertfünfundzwanzig (7.340.625)
Stammanteile der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil, und von eine Million
neunundfünfzigtausenddreihundertfünfundsiebzig (1.059.375) Vorzugsanteile der Klasse B, mit einem Nennwert von je-
weils einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil auszugeben.
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
Daraufhin erschien der Gesellschafter vertreten wie vorgenannt.
Der Gesellschafter erklärte die Zeichnung von sieben Millionen dreihundertvierzigtausendsechshundertfünfundzwanzig
(7.340.625) Stammanteilen der Klasse A, und von einer Million neunundfünfzigtausenddreihundertfünfundsiebzig
(1.059.375) Vorzugsanteilen der Klasse B, mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil und die
vollständige Zahlung dieser neuen Anteile in bar.
Der Betrag von acht Millionen vierhunderttausend Euro (EUR 8.400.000.-) stand ab diesem Zeitpunkt der Gesellschaft
zur Verfügung, und der unterzeichnende Notar hat die notwendigen Dokumente dies belegend erhalten.
<i>Fünfter Beschlussi>
In Anbetracht der obigen Beschlüsse beschließt der Gesellschafter den ersten Absatz von Artikel 5 der Satzung der
Gesellschaft, sowie den Artikel 28 und den Artikel 29 der Satzung der Gesellschaft abzuändern und neu zu verfassen, um
diese Beschlüsse widerzuspiegeln und die jeweiligen finanziellen Rechte der Stammanteile der Klasse A und der Vor-
zugsanteile der Klasse B festzulegen.
Artikel 5 der Satzung wird wie folgt neu verfasst:
„ Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt acht Millionen vier-
hundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 8,412,500.-), und ist in sieben Millionen dreihundertdreiundfünfzigtausen-
deinhundertfünfundzwanzig (7,353,125) Stammanteile der Klasse A, und eine Million neunundfünfzigtausenddreihun-
dertfünfundsiebzig (1.059.375) Vorzugsanteile der Klasse B, mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) aufgeteilt.
Alle Anteile sind vollständig eingezahlt.“
Artikel 28 der Satzung wird wie folgt neu verfasst:
„ Art. 28. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%)
der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die „Rücklage“). Diese Verpflichtung entfällt, sobald und solange diese
Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter, wie der verbleibende jährliche Reinge-
winn verteilt werden soll, indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäfts-
jahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die
Gesellschafter ausschütten.
Die für die Ausschüttung der Dividenden vorgesehene Summe wird wie folgt aufgeteilt. Zuerst vermitteln die Vor-
zugsanteile der Klasse B, auf einer pro-rata Basis, Anrecht auf eine kumulative Dividende in Höhe der Summe von (i) acht
Prozent (8%) pro Jahr bezogen auf den Gesamtwert der Vorzugsanteile der Klasse B, und danach vermitteln die Stamm-
anteile der Klasse A Anrecht auf jegliche restlichen Dividenden, welche im pro rata Verhältnis zwischen den Stammanteilen
der Klasse A verteilt werden.
Vorbehaltlich der (gegebenenfalls) gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorste-
henden Bestimmungen können die Geschäftsführer eine Abschlagsdividende an die Gesellschafter auszahlen. Die Ge-
schäftsführer legen die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.“
Artikel 29 der Satzung wird wie folgt neu verfasst:
„ Art. 29. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der (des) Gesellschafter(s) aufgelöst
werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals
repräsentieren.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natürliche
oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt wer-
den.
Im Falle einer Liquidation werden alle Aktiva sowie die Barbestände der Gesellschaft in folgender Rangordnung aus-
geschüttet:
(i) zuerst, an die Gläubiger (durch Rückzahlung beziehungsweise durch angemessene Rückstellung zwecks Rückzah-
lung) für alle Schulden und Passiva der Gesellschaft;
(ii) dann, an die Gesellschafter, welche Vorzugsanteile der Klasse B halten, als Rückzahlung in Höhe des Nennwertes
dieser Vorzugsanteile der Klasse B, erhöht durch einen Betrag, der dem Wert des Anspruchs dieser Anteile auf die in den
in Artikel 28, Paragraph 3, erwähnten Vorzugsdividenden entspricht, und auf keinen Fall höher als dieser ist, pro rata;
148955
L
U X E M B O U R G
(iii) dann, an die Gesellschafter, welche Stammanteile der Klasse A halten, als Rückzahlung in Höhe des Nennwertes
dieser Stammanteile der Klasse A, erhöht durch einen Betrag, der den verbleibenden auszuschüttenden Aktiva und Bar-
geldbeständen entspricht.“
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde
entstehen, werden auf viertausenddreihundert Euro (EUR 4.300,-) geschätzt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärte hierbei, dass auf Anfrage der obigen
genannten Person das vorliegende Dokument in englischer und deutscher Sprache verfasst wurde; auf Anfrage derselben
Person und im Falle verschiedener Auslegungen zwischen dem englischen und deutschen Text soll der englische Text
Vorrang haben.
Worüber Urkunde Aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten
Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieser Bevollmächtigte vorliegende Urkunde mit dem
unterzeichnenden Notar unterzeichnet.
Signé: S. Weling, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 25 août 2015. GAC/2015/7282. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 25 septembre 2015.
Référence de publication: 2015158607/238.
(150175505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.
Immoshine S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 101.634.
L'an deux mille quinze, le dix-huit septembre,
Pardevant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg),
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois «IMMOSHINE
S.A.», établie et ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur, constituée originairement sous la forme
d’une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant pour dénomination «IMMOSHINE, S.à r.l.», suivant
acte reçu par le notaire Urbain THOLL, de résidence à Mersch, en date du 28 juin 2006, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 925 du 16 septembre 2005, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
prédit notaire Urbain THOLL en date du 28 mars 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
1288 du 4 juillet 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro
101.634.
L'assemblée est présidée par Madame Brigitte de LESCAZES demeurant à Luxembourg.
qui désigne comme secrétaire Madame Francine Koloma MOTO, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Patricia SAND, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, la Présidente expose et l'assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-
tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire
instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises
avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que les cent (100) actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, représentant l'inté-
gralité du capital social d’un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) étant présente ou représentée à la présente
assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Refonte intégrale des statuts.
148956
L
U X E M B O U R G
2. Constat que le mandat d’administrateur de Madame Brigitte DE LESCAZES a expiré et constat de sa démission en
tant qu'administrateur-délégué.
3. Révocation de deux administrateurs.
4. Constat que l’intégralité du capital est détenue par un seul et unique actionnaire.
5. Nomination d’un administrateur unique.
6. Révocation du commissaire.
7. Nomination d’un nouveau commissaire.
8. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions
suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée générale décide de refondre intégralement les statuts de la société, sans modifier pour autant son objet
social, sa forme juridique ou son capital social.
Par conséquent, les statuts prendront à compter de ce jour, la teneur suivante:
«Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «IMMOSHINE S.A.».
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale
au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière, comprenant l’achat, la vente et la location
d’immeubles pour le compte de la société ou pour le compte de tiers ainsi que la promotion immobilière.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature mobilière,
immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité ou à tous objets
similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.
Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou
entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opérations de
nature à favoriser la réalisation de son objet social.
Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés ou
tiers.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l’étranger.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille (EUR 31.000,00) euros, représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de trois cent dix (EUR 310,00) euros chacune.
Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, dans les conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour
un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à
tout moment par l'assemblée générale.
Lorsque la société n’a qu'un seul actionnaire, le conseil d’administration pourra être limité à un seul membre.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoirement,
et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
148957
L
U X E M B O U R G
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télé-
gramme, télex ou fax ou e-mail.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex, fax ou email.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de
disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'Article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur unique, ou par la
signature conjointe de deux membres du conseil d’administration, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'Article 10 des
statuts.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires
sociales à un ou plusieurs délégués à la gestion journalière et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées
à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre
et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-
cations, le deuxième mardi du mois de juin à dix heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour,
l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième (10%) du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait
été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Art. 16. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que
modifiée, et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé à procéder
à un versement d’acomptes sur dividendes.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.»
148958
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolution:i>
L’assemblée générale constate que le mandat d’administrateur de Madame Brigitte DE LESCAZES, née le 9 juillet
1960 à Verdun (France), demeurant à L-1526 Luxembourg, 33, Val Fleuri, a expiré.
L’assemblée générale constate également la démission intervenue en date de ce jour de Madame Brigitte DE LESCA-
ZES, préqualifiée, de ses fonctions d’administrateur-délégué.
Par conséquence, l’assemblée décide de lui donner pleine et entière décharge pour l’accomplissement de ses fonctions
d’administrateur et d’administrateur-délégué.
<i>Troisième résolution:i>
L’assemblée générale décide de révoquer, en date de ce jour, les deux administrateurs suivants et ce, avec pleine et
entière décharge:
- Madame Sandra WOLFF.
- Madame Olga MONTEIRO CORREIA DA COSTA.
<i>Quatrième résolution:i>
L’assemblée générale constate que l’intégralité du capital social, soit les cents (100) actions sont détenues par un ac-
tionnaire unique, à savoir Madame Brigitte DE LESCAZES, préqualifiée.
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de nommer un administrateur unique, à
savoir Madame Brigitte DE LESCAZES, préqualifiée, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
qui se tiendra en l'an deux mille vingt.
Conformément à l’article 9 des statuts, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de
l’administrateur unique.
<i>Sixième résolution:i>
L’assemblée générale décide de révoquer le commissaire aux comptes à compter de ce jour.
Est nommé commissaire Madame Sandra WOLFF, demeurant 9, Chemin d’Essingen, L-7463 à Pettingen.
Le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an
2020.
<i>Remarquesi>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des comparants sur la nécessité d'obtenir des
autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à
l'article 4 des présents statuts.
De plus, le notaire instrumentant a expressément attiré l’attention de l’administrateur unique ainsi que de l’actionnaire
unique de la société, sur le contenu et la portée de l’article 67-1 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. DE LESCAZES, F K. MOTO, P. SAND, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 21 septembre 2015. Relation: DAC/2015/15451. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Carlo RODENBOUR.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Redange-sur-Attert, le 25 septembre 2015.
Référence de publication: 2015158676/181.
(150174713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.
Eradius Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 87.319.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015160007/9.
(150176302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
148959
L
U X E M B O U R G
Lazur Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 90.336.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
Référence de publication: 2015160164/11.
(150176515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Logs Holdings Pledgeco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 200.239.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of the month of September.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Logs Holdings Topco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
in the process of being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg and having a share capital
of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500),
represented by Mr François-Xavier Joyeux, juriste, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated
17
th
September 2015 which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company “Logs Holdings Pledgeco S.à r.l.” (société à responsabilité limitée) which
is hereby established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Logs Holdings
Pledgeco S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.
The Company may further give guarantees (including up-stream and side-stream guarantees), grant security interests,
grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the
same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.
148960
L
U X E M B O U R G
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case
may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,
economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500)
represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty- five euros (EUR 25) each.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares
upon resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%)
of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business
of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to
act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
148961
L
U X E M B O U R G
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys’ fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the
board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of
the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal
to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed
by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in
the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
148962
L
U X E M B O U R G
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year, save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2015.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies;
in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Transitory dispositioni>
The first accounting year shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December 2015.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up in cash the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Subscription
price (EUR)
Logs Holdings Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12,500
Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles
of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
- BRE/Management 8 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at
35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Lu-
xembourg under number B 195.140.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,
the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the English
148963
L
U X E M B O U R G
language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between
the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn am achtzehnten Tag des Monats September,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen,
Logs Holdings Topco S.à r.l.., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxembur-
gischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünf-
hundert Euro (EUR 12.500) beträgt, und die dabei ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg eingetragen
zu werden,
hier vertreten durch Herrn François-Xavier Joyeux, juriste, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-
schriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 17. September 2015, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei
der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungssatzung
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "Logs Holdings Pledgeco S.à r.l." wie folgt
zu beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
"Logs Holdings Pledgeco S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die
gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und
durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Ver-
waltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben (einschließlich up-stream als auch side-stream Bürgschaften), Sicherheiten
leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt
oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-
geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder - Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-
liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und
alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-
denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
148964
L
U X E M B O U R G
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende
solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung
auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölf tausend fünf
hundert euros (EUR 12.500), eingeteilt in fünf hundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfund-
zwanzig euro (EUR 25).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung
vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesellschaftsanteile
durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht
anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die
keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
148965
L
U X E M B O U R G
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen
Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder
einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“
und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder
(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder
von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-
schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
148966
L
U X E M B O U R G
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember
2015 enden.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich
nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember 2015 enden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt
in bar eingezahlt und gezeichnet:
Einzahler
Zahl der
Geschäftsanteile
Einzahlungspreis
(EUR)
Logs Holdings Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.
<i>Außerordentliche Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
148967
L
U X E M B O U R G
- BRE/Management 8 S.A. eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 35, avenue
Monterey, L-2163 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer
B 195.140.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen
Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: F.- X. JOYEUX, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/30210. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 25. September 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015158746/453.
(150175249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.
LSREF3 GTC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.538.125,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 177.929.
In the year two thousand and fifteen on the eighteenth day of September,
before Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
Lone Star Capital Investments S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with a share capital of EUR 54,530,375.-
(fifty-four million five hundred thirty thousand three hundred seventy-five euro), having its registered office at Atrium
Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the
register of trade and companies of Luxembourg (registre de commerce et des sociétés de Luxembourg) (the “RCS”) under
number B 91796 (the “Sole Shareholder”),
represented by Peggy Simon, employee with professional address in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg on 17 September 2015.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the Sole Shareholder of the private limited liability
company (société à responsabilité limitée) LSREF3 GTC Holdings S.à r.l., registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 177929, having its
registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg
(the “Company”) and incorporated pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg,
dated 11 June 2013, under the initial name of LSF7 Lux Investments IX S.à r.l., published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the “Mémorial”) dated 1
st
August 2013, number 1861, which articles of incorporation have been
amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 10 September 2015, not yet published in the
Mémorial.
The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:
1. The entire issued share capital represented by 29,918 (twenty-nine thousand nine hundred eighteen) shares is held by
the Sole Shareholder.
2. The Sole Shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this
extraordinary decision of the Sole Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below
agenda.
3. The agenda of the meeting is as follows:
148968
L
U X E M B O U R G
A. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 1,105,625.- (one million one hundred five thousand
six hundred twenty-five euro) in order to raise it from its current amount of EUR 3,739,750.- (three million seven hundred
thirty-nine thousand seven hundred fifty euro) to an amount of EUR 4,845,375.- (four million eight hundred forty-five
thousand three hundred seventy-five euro) by the issuance of 8,845 (eight thousand eight hundred forty-five) new ordinary
shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each (the “New Shares”), in consideration of
a contribution in cash by the Sole Shareholder of an aggregate amount of EUR 1,105,669.01 (one million one hundred five
thousand six hundred sixty-nine euro and one cent) which shall be allocated (a) to the share capital of the Company for an
amount of EUR 1,105,625.-(one million one hundred five thousand six hundred twenty-five euro) and (b) to the share
premium account of the Company for an amount of EUR 44.01 (forty-four euro and one cent).
B. As a consequence, amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company as
follows:
" Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 4,845,375.- (four million eight hundred forty-five
thousand three hundred seventy-five euro) represented by 38,763 (thirty-eight thousand seven hundred sixty-three) shares
having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each."
C. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the change proposed above with power and
authority to any manager of the Company and/or any employee of the Sole Shareholder, to proceed, under his/her sole
signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company
and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.
The Sole Shareholder, represented as stated above, then asked the undersigned notary to record its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of EUR 1,105,625.-
(one million one hundred five thousand six hundred twenty-five euro) in order to raise it from its current amount of EUR
3,739,750.- (three million seven hundred thirty-nine thousand seven hundred fifty euro) to an amount of EUR 4,845,375.-
(four million eight hundred forty-five thousand three hundred seventy-five euro) by the issuance of 8,845 (eight thousand
eight hundred forty-five) New Shares with a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each in consi-
deration of a contribution in cash by the Sole Shareholder of an aggregate amount of EUR 1,105,669.01 (one million one
hundred five thousand six hundred sixty-nine euro and one cent).
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe for 8,845 (eight thousand eight hundred forty-
five) New Shares with a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) per share and to make payment in
full for such New Shares by a contribution in cash for a total subscription amount of EUR 1,105,669.01 (one million one
hundred five thousand six hundred sixty-nine euro and one cent) which shall be allocated (a) to the share capital of the
Company for an amount of EUR 1,105,625.-(one million one hundred five thousand six hundred twenty-five euro) and (b)
to the share premium account of the Company for an amount of EUR 44.01 (forty-four euro and one cent).
All the 8,845 (eight thousand eight hundred forty-five) New Shares issued are therefore fully subscribed and paid up in
cash by the Sole Shareholder so that the amount of EUR 1,105,669.01 (one million one hundred five thousand six hundred
sixty-nine euro and one cent) is at the free disposal of the Company as it has been proved to the undersigned notary who
expressly bears witness to it.
As a consequence of the above-resolved share capital increase, the Sole Shareholder now holds 38,763 (thirty-eight
thousand seven hundred sixty-three) ordinary shares of the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of
the articles of association of the Company to be read henceforth as follows:
" Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 4,845,375.- (four million eight hundred forty-five
thousand three hundred seventy-five euro) represented by 38,763 (thirty-eight thousand seven hundred sixty-three) shares
having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each."
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the change resolved above
with power and authority to any manager of the Company and/or any employee of the Sole Shareholder, to proceed, under
his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares in the share register of the Company
and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the proxyholder of the
above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall be prevailing.
148969
L
U X E M B O U R G
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, at the office of the under-
signed notary, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder appearing signed,
together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le dix-huit septembre,
par-devant Maître Henri BECK, notaire demeurant à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu
Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxem-
bourgeois ayant un capital social de EUR 54.530.375,- (cinquante-quatre million cinq cent trente mille trois cent soixante-
quinze euros), ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-
Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (le «RCS») sous
le numéro B 91796 (l'«Associé Unique»),
ici représentée par Peggy Simon, employée, ayant son adresse professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, le 17 septembre
2015.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée tel qu'indiqué ci-avant, a déclaré être l'Associé Unique de la société à responsabilité
limitée LSREF3 GTC Holdings S.à r.l., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 177929, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070
Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant un acte de Maître Marine SCHAEFFER, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 11 juin 2013 sous le nom initial de LSF7 Lux Investments IX S.à r.l., publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 1
er
août 2013, numéro 1861, lesquels statuts ont
été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné, du 10 septembre 2015, non encore publié au Mémorial.
La partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
1. La totalité du capital social, représentée par 29.918 (vingt-neuf mille neuf cent dix-huit) parts sociales, est détenu par
l'Associé Unique.
2. L'Associé Unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la Société
sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé Unique et toutes les décisions peuvent être valablement prises
sur tous les points de l'ordre du jour ci-après.
3. L'ordre du jour est le suivant:
A. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 1.105.625,- (un million cent cinq mille six cent
vingt-cinq euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 3.739.750,- (trois millions sept cent trente-neuf mille sept
cent cinquante euros) à un montant de EUR 4.538.125,- (quatre millions cinq cent trente-huit mille cent vingt-cinq euros)
par la création et l'émission de 8.845 (huit mille huit cent quarante-cinq) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de
EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»); souscription et paiement des Nouvelles Parts
Sociales par l'Associé Unique par un apport en numéraire pour un montant total de souscription de EUR 1.105.669,01 (un
million cent cinq mille six cent soixante-neuf euro et un cents) qui sera alloué (a) au capital social de la Société pour un
montant de EUR 1.105.625,- (un million cent cinq mille six cent vingt-cinq euros) et (b) au compte de prime d'émission
de la Société pour un montant de EUR 44,01 (quarante-quatre euros et un cents).
B. En conséquence, modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 4.538.125,- (quatre millions cinq cent trente-huit mille cent vingt-cinq euros),
représenté par 38.763 (trente-huit mille sept cent soixante-trois) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent
vingt-cinq euros) chacune.»
C. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter le changement proposé ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou tout employé de l'Associé Unique, afin d'effectuer, par sa seule
signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales dans le registre de parts sociales de
la Société et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.
L'Associé Unique, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.105.625,- (un million cent cinq mille
six cent vingt-cinq euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 3.739.750,- (trois millions sept cent trente-neuf
mille sept cent cinquante euros) à un montant de EUR 4.538.125,- (quatre millions cinq cent trente-huit mille cent vingt-
148970
L
U X E M B O U R G
cinq euros) par la création et l'émission de 8.845 (huit mille huit cent quarante-cinq) Nouvelles Parts Sociales d'une valeur
nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.
<i>Souscription - Paiementi>
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci avant, a déclaré souscrire 8.845 (huit mille huit cent quarante-cinq)
Nouvelles Parts Sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) par part sociale et libérer intégralement
ces Nouvelles Parts Sociales souscrites par un apport en numéraire pour un montant total de souscription de EUR
1.105.669,01 (un million cent cinq mille six cent soixante-neuf euro et un cents) qui sera alloué (a) au capital social de la
Société pour un montant de EUR 1.105.625,- (un million cent cinq mille six cent vingt-cinq euros) et (b) au compte de
prime d'émission de la Société pour un montant de EUR 44,01 (quarante-quatre euros et un cents).
L'ensemble des 8.845 (huit mille huit cent quarante-cinq) Nouvelles Parts Sociales émises sont donc intégralement
souscrites et libérées en numéraire par l'Associé Unique, de sorte que la somme de EUR 1.105.669,01 (un million cent cinq
mille six cent soixante-neuf euro et un cents) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
Suite à l'augmentation de capital décidée ci-dessus, l'Associé Unique détient maintenant 38.763 (trente-huit mille sept
cent soixante-trois) parts sociales ordinaires de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts
de la Société qui sera désormais lu comme suit:
« Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 4.538.125,- (quatre millions cinq cent trente-huit mille cent vingt-cinq euros),
représenté par 38.763 (trente-huit mille sept cent soixante-trois) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent
vingt-cinq euros) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter le changement effectué
ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et/ou tout employé de l'Associé Unique, afin
d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales dans le registre
de parts sociales de la Société ainsi que (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du mandataire de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des
présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 22 septembre 2015. Relation: GAC/2015/8055. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): N. DIEDERICH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 24 septembre 2015.
Référence de publication: 2015158787/185.
(150174643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.
J.J.R. GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9748 Eselborn, 6, Op der Spraet.
R.C.S. Luxembourg B 118.038.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29/09/2015.
G.T. Experts Comptables S.à r.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2015160117/12.
(150176848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
148971
L
U X E M B O U R G
Grand City Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 24, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 165.560.
In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth day of September.
Before the undersigned, Maître Henri HELLINCKX, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
The board of directors of Grand City Properties S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register on 23 December 2011 under number B 165.560, incorporated pursuant
to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary resident in Luxembourg, on 16 December 2011 and published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 287, p.13745 on 2 February 2012. The articles of association of the
Company have last been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on 11 September 2015, and not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
here represented by Thao Nguyen, professionally residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of
directors of Grand City Properties S.A. pursuant to a resolution of the board of directors taken on 16 September 2015.
An excerpt of the minutes of said board resolution, initialled “ne varietur” by the appearing person and the notary will
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxyholder of the appearing person, acting in the aforementioned capacity, has requested the undersigned notary
to state the following declarations:
1) Grand City Properties S.A. (hereinafter the “Company”) was incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary resident in Luxembourg, on 16 December 2011, and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register on 23 December 2011 and published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n° 287, p.13745 on 2 February 2012. The articles of association of the Company have
last been amended pursuant to a notarial deed on 11 September 2015, and not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
2) According to article 5.1 of the articles of association, the issued share capital of the Company is currently set at
thirteen million five hundred ninety-nine thousand three hundred and twenty-six euro and ten cents (EUR 13,599,326.10),
divided into one hundred thirty-five million nine hundred ninety-three thousand two hundred and sixty-one (135,993,261)
shares having a par value of EUR 0.10 each, all of which are fully paid up.
3) Pursuant to article 5.2 of the articles of association, the authorized share capital is set at twenty million euro (EUR
20,000,000) and the board of directors is authorised to issue shares within the limit of the authorised share capital, to such
persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed with such issue without reserving a preferential
subscription right for the existing shareholders.
4) The Company issued EUR 150,000,000 1.5% convertible bonds due 2019 on 24 February 2014 and EUR 125,000,000
1.5% convertible bonds due 2019 on 19 June 2014 (the “Series C Bonds”). The Company has received one conversion
notice from holders of the Series C Bonds from Joh. Berenberg, Gossler and Co. KG, dated 10 September 2015, in respect
of the conversion of 10 Series C Bonds with an aggregate principal amount of EUR 1,000,000 with a conversion price of
EUR 9.5957 (the “Conversion Notices”).
5) In its resolutions dated 16 September 2015, the board of directors of the Company has decided to increase the share
capital of the Company by an amount of ten thousand four hundred twenty-one euro and thirty cents (EUR 10,421.30) so
as to raise it from its current amount of thirteen million five hundred ninety-nine thousand three hundred and twenty-six
euro and ten cents (EUR 13,599,326.10) to thirteen million six hundred nine thousand seven hundred forty-seven euro and
forty cents (EUR 13,609,747.40) through the issuance of one hundred four thousand two hundred and thirteen (104,213)
new shares of the Company with a par value of ten cents (EUR 0.10).
In accordance with article 5.2 of the articles of association, the board of directors has decided to suppress the preferential
right of subscription of the existing shareholders in relation to this capital increase.
6) The newly issued shares have been issued for an aggregate price of one million euro (EUR 1,000,000) by the con-
version of the 10 Series C Bonds with an aggregate principal amount of EUR 1,000,000 (made sufficiently and
comprehensively known to the board by the Conversion Notices), so that out of the amount of one million euro (EUR
1,000,000), ten thousand four hundred twenty-one euro and thirty cents (EUR 10,421.30) are allotted to the corporate share
capital of the Company and the amount of nine hundred eighty-nine thousand five hundred seventy-eight euro and seventy
cents (EUR 989,578.70) is allotted to the share premium account. The supporting documents of the conversion have been
produced to the undersigned notary.
As a consequence of the aforementioned capital increase, the first paragraph of article 5.1 of the articles of association
shall be amended, which shall henceforth read as follows:
148972
L
U X E M B O U R G
“ 5.1. The subscribed capital of the Company is fixed at thirteen million six hundred nine thousand seven hundred forty-
seven euro and forty cents (EUR 13,609,747.40) represented by one hundred thirty-six million ninety-seven thousand four
hundred seventy-four (136,097,474) shares of a par value of ten cents (EUR 0.10) each.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are assessed to EUR 2,600.-
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le dix-sept septembre,
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Le Conseil d'Administration de Grand City Properties S.A., une société anonyme constituée et existante sous les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 23 décembre 2011 sous le numéro B 165.560, constituée
suivant un acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire résidant à Luxembourg, le 16 décembre 2011 et publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n° 287, p.13745, du 2 février 2012. Les statuts de la Société ont été modifiés pour
la dernière fois suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, le 11 septembre 2015, non encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations,
représenté ici par Thao Nguyen, résidant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de représentant du
conseil d'administration de Grand City Properties S.A. en vertu d'une résolution du conseil d'administration prise le 16
septembre 2015.
Un extrait du procès-verbal dudit conseil d'administration, paraphé «ne varietur» par la personne comparante et le notaire
instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le mandataire de la personne comparante, agissant en la capacité susmentionnée, a requis le notaire instrumentaire
d'acter les déclarations suivantes:
1) Grand City Properties S.A. (ci-après la «Société») a été constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg en
vertu d'un acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire résidant à Luxembourg, le 16 décembre 2011 et enregistré auprès le
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 23 décembre 2011 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n° 287, p.13745, du 2 février 2012. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant
acte notarié le 11 septembre 2015 et non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
2) Conformément à l'article 5.1 des statuts, le capital émis de la Société est actuellement fixé à treize millions cinq cent
quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent vingt-six euros et dix centimes (13.599.326,10 EUR), divisé en cent trente-trois
millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent soixante-et-un (133.599.261) actions ayant une valeur nominale
de dix centimes d'euro (0,10 EUR) chacune, toutes entièrement libérées.
3) En vertu de l'article 5.2 des statuts, le capital autorisé est fixé à vingt millions d'euros (20.000.000 EUR) et le conseil
d'administration est autorisé à émettre des actions endéans les limites du capital autorisé, au profit des personnes et dans
les conditions qu'il jugera appropriées, et spécifiquement de procéder à cette émission sans réserver un droit préférentiel
aux actionnaires existant.
4) La Société a émis 150.000.000 EUR 1,5% obligations convertibles en 2019 le 24 février 2014 et 125.000.000 EUR
1,5% obligations convertibles en 2019 le 19 juin 2014 (les «Obligations de Série C»). La Société a reçu un avis de conversion
des détenteurs des Obligations de Séries C de Joh. Berenberg, Gossler and Co. KG, daté du 10 septembre 2015, relatif à
la conversion de 10 Obligation Séries C d'un montant principal de 1.000.000 EUR avec un prix de conversion de 9,5957
EUR (les "Avis de Conversion").
5) Dans les résolutions datées du 16 septembre 2015, le conseil d'administration de la Société a décidé d'augmenter le
capital social de la Société d'un montant de dix mille quatre cent vingt-et-un euros et trente centimes (10.421,30 EUR) de
manière à le faire passer de son montant actuel de treize millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent vingt-six
euros et dix centimes (13.599.326,10 EUR) à treize millions six cent neuf mille sept cent quarante-sept euros et quarante
centimes (13.609.747,40 EUR) par l'émission de cent quatre mille deux cent treize (104.213) nouvelles actions de la Société
d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 EUR).
Conformément à l'article 5.2 des statuts, le conseil d'administration a décidé de supprimer le droit de souscription
préférentiel des actionnaires existant dans le cadre de l'augmentation de capital.
148973
L
U X E M B O U R G
6) Les actions nouvelles ont été émises pour un prix global d'un million euros (1.000.000 EUR) par la conversion de 10
Obligation Séries C d'un montant principal de 1.000.000 EUR (portée à la connaissance de façon suffisante et complète
du conseil par les Avis de Conversion), de telle sorte que du montant d'un million euros (1.000.000 EUR), dix mille quatre
cent vingt-et-un euros et trente centimes (10.421,30 EUR) sont alloués au capital social de la Société et le montant neuf
cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix centimes (989.578,70 EUR) est alloué au
compte de prime d'émission. Les documents relatifs à la conversion des obligations en actions ont été présentés au notaire
soussigné.
En conséquence de l'augmentation de capital susmentionnée, le premier paragraphe de l'article 5.1 des statuts est modifié,
lequel se lit désormais comme suit:
« 5.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à treize millions six cent neuf mille sept cent quarante-sept euros et
quarante centimes (13.609.747,40 EUR) représenté par cent trente-six millions quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent
soixante-quatorze (136.097.474) actions d'une valeur de dix centimes d'euro (0,10 EUR) chacune.»
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunération et charges de quelque forme que ce soit incombant à la Société et chargés à raison du
présent acte sont évalués à EUR 2.600.-
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande du mandataire de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparantes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: T. NGUYEN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 22 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/30150. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 25 septembre 2015.
Référence de publication: 2015158610/141.
(150174790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.
La Casa Moderna S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-7220 Walferdange, 94, route de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 200.249.
STATUTS
L’an deux mille quinze,
le dix-huit septembre.
Par-devant Nous Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxem-
bourg, laquelle minute restant en la détention et garde du notaire Jean-Joseph WAGNER,
a comparu:
Monsieur Thierry Massimo FACCIOLINI, directeur commercial, né à Villerupt (France), le 22 janvier 1965, demeurant
au 9, rue Kislowski, F-54135 Mexy (France).
Lequel comparant, ici personnellement présent, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts
d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par la présente.
Titre I
er
. - Objet - Raison Sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaire de
parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet principal l’achat et la vente de meubles.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pou-
vant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplis-
sement.
La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
148974
L
U X E M B O U R G
Art. 3. La société est établie pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de «LA CASA MODERNA S.à r.l.», société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12’500.- EUR) représenté par
cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.-EUR) chacune.
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique, Monsieur Thierry FACCIOLINI, prénommé,
et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12’500.-
EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les
parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente) jours
à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des
parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent
pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique ou
lorsqu’ils sont plusieurs, par la signature conjointe de deux (2) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité
des voix des associés.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assemblée
générale sont exercés par celui-ci.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
148975
L
U X E M B O U R G
Titre V. - Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2015.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à environ huit cents euros.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi au 94, route de Diekirch, L-7220 Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Thierry Massimo FACCIOLINI, directeur commercial, né à Villerupt (France), le 22 janvier 1965, demeurant
au 9, rue Kislowski, F-54135 Mexy (France).
Vis-à-vis des tiers la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant
unique.
3.- Le gérant unique préqualifié pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des parties constituantes sur la nécessité
d’obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme
objet social à l’article deux ci-avant.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois
et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante prémentionnée a
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: T. M. FACCIOLINI, B. MOUTRIER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 septembre 2015. Relation: EAC/2015/21724. Reçu soixante-quinze Euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2015158759/106.
(150175384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.
CHC Helicopter (3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 190.568.
Conformément à l'article 3 (1) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Intertrust (Luxembourg)
S.à r.l. informe de la fin de la convention de domiciliation conclue le 19 février 2015 pour une durée indéterminée entre
les deux sociétés:
<i>- Société domiciliée:i>
* CHC Helicopter (3) S.à r.l.
* Immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.568
* Dont le siège social sis au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg fait l'objet de la présente dénonciation
<i>- Agent domiciliataire:i>
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l. ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
et ce avec effet au 3 août 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2015.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2015158454/21.
(150175061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.
148976
L
U X E M B O U R G
Wap Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 131.693.
In the year two thousand and fifteen, on the tenth of September,
Before us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of WAP Holdings S.A., a Luxembourg public
limited liability company (société anonyme), having its registered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 131.693 (the Company).
The Company was incorporated on July 19, 2007, pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in
Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Me-
morial), number 2343, page 112423, and dated October 18, 2007. The articles of association of the Company (the Articles)
have been amended for the last time on January 11, 2008, pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in
Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Memorial, number 1307, page 62724, and dated May 28,
2008.
The Meeting is chaired by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster (the Chairman).
The Chairman appointed as secretary Mr Bob PLEIN, employee, residing professionally in Junglinster (the Secretary).
The Meeting elected as scrutineer Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster (the Scrutineer).
The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to as the Bureau of the Meeting.
The Bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and request the notary to record that:
I. The sole shareholder of the Company (the Sole Shareholder), present or represented at the Meeting and the number
of shares it holds are indicated on an attendance list. This list and the proxy, after having been signed by the representative
of the Sole Shareholder, the members of the Bureau and the notary, will remain attached to the present deed for registration
purposes.
II. As it appears from the attendance list, the fifty thousand (50,000) shares, having a par value of ten euro (EUR 10)
each, representing the entire share capital of the Company in an amount of five hundred thousand euro (EUR 500,000) are
duly represented at the present Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on
the agenda hereinafter reproduced.
III. The agenda of the Meeting is worded as follows:
(i) Waiver of convening notice;
(ii) Amendment of article 9 of the articles of association of the Company; and
(iii) Miscellaneous.
III. The Meeting hereby takes the following resolutions:
Now, therefore, the Meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions which were taken
unanimously after deliberation:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notice require-
ments, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 9 of the Articles, which shall henceforth read as follows:
“ Art. 9.
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by any director, acting individually, under its/his/her sole
signature.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special signatory powers
have been delegated by the Board of Directors.”
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand two hundred euros
(EUR1,200.-).
148977
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le dix septembre.
par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique de WAP Holdings S.A., une société ano-
nyme ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.693 (la Société).
La Société a été constituée le 19 juillet 2007, suivant un acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niede-
ranven, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Memorial), numéro
2343, page 112423, et daté du 18 octobre 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 11 janvier
2008, suivant un acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, publié
au Mémorial, numéro 1307, page 62724, et daté du 28 mai 2008.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster (le Pré-
sident).
Le Président a nommé comme secrétaire Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à Junglinster
(le Secrétaire).
L'Assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Jun-
glinster (le Scrutateur).
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur composent ensemble le Bureau de l'Assemblée.
Le Bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter que:
I. L'actionnaire unique de la Société (l'Actionnaire Unique) est présent ou représenté à l'Assemblée et le nombre d'actions
qu'il détient est mentionné sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, après avoir été signées par le mandataire
de l'Actionnaire Unique, les membres du Bureau et le notaire, resteront annexées au présent acte pour les formalités de
l'enregistrement.
II. Tel qu'il ressort de la liste de présence, les cinquante mille (50.000) actions, ayant une valeur nominale de dix euro
(EUR 10) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société d'un montant de cinq cent mille euros (EUR
500.000) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer
sur les points à l'ordre du jour qui sont reproduits ci-après.
III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
(i) Renonciation aux formalités de convocation;
(ii) Modification de l'article 9 des statuts de la Société; et
(iii) Divers.
Sur ce, l'Assemblée a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes ayant été prises à l'unanimité après
délibération:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Ac-
tionnaire Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir
une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 9 des Statuts, lequel se lit désormais comme suit:
« Art. 9.
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toute circonstance par un administrateur, agissant individuellement sous
sa seule signature.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs de signature
spéciaux ont été délégués par le conseil.»
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
148978
L
U X E M B O U R G
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille deux cent euros (EUR 1.200,-)
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête de la partie
comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, rédigé et passé à Junglinster, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes, ils ont signé avec le notaire instrumentant, le présent
acte.
Signé: Henri DA CRUZ, Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 15 septembre 2015. Relation GAC/2015/7746. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015159066/119.
(150174961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.
Glow Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.612.500,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 198.596.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of August,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
DBG Advisors VI GmbH & Co. KG, a company governed by the laws of Germany, having its registered office at
Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am Main, Germany, and registered with the commercial register of the local court of
Frankfurt am Main under number HRA 46856, acting through its general partner DBG Service Provider Verwaltungs
GmbH, a company governed by the laws of Germany, having its registered office at Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am
Main, Germany, and registered with the commercial register of the local court of Frankfurt am Main under number HRB
90813 (the “DBG Advisors VI”);
hereby represented by Maître Stephan Weling, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on August 18, 2015;
DBAG Fund VI Konzern (Guernsey) L.P., a limited partnership governed by the laws of Guernsey, having its registered
office at 1
st
Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey and registered with the Register
of Limited Partnerships of the Island of Guernsey under number 1695 acting through its general partner DBAG Fund VI
GP (Guernsey) L.P., a limited partnership governed by the laws of Guernsey, having its registered office at 1
st
Floor, La
Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey and registered with the Register of Limited Part-
nerships of the Island of Guernsey under number 1680 acting through its general partner DBG Management GP (Guernsey)
Limited, a limited company regulated by the Guernsey Financial Services Commission, having its registered office at 1
st
Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 1WG and registered with the Register of
Companies of the Island of Guernsey under number 55086 (the “Fund VI Konzern”);
hereby represented by Maître Stephan Weling, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on August 19, 2015;
DBAG Fund VI (Guernsey) L.P., a limited partnership governed by the laws of Guernsey and regulated by the Guernsey
Financial Services, having its registered office at 1
st
Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG,
Guernsey and registered with the Register of Limited Partnerships of the Island of Guernsey under number 1692, acting
through its general partner DBAG Fund VI GP (Guernsey) L.P., a limited partnership governed by the laws of Guernsey,
having its registered office at 1
st
Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey and
registered with the Register of Limited Partnerships of the Island of Guernsey under number 1680 acting through its general
partner DBG Management GP (Guernsey) Limited, a limited company governed by the laws of Guernsey and regulated
by the Guernsey Financial Services Commission, having its registered office at 1
st
Floor, La Plaiderie Chambers, La
Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 1WG and registered with the Register of Companies of the Island of Guernsey
under number 55086 (the “Fund VI”);
hereby represented by Maître Stephan Weling, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on August 19, 2015, hereafter collectively referred to as the “Shareholders”.
The above mentioned proxies shall be annexed to the present deed.
148979
L
U X E M B O U R G
The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are the sole shareholders of
Glow Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), with registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 198596 incorporated following a
deed of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg of 30 June 2015, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company"). The articles of association of the
Company have not yet been amended.
The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To increase the issued capital of the Company by an amount of seven million six hundred thousand euro (EUR
7,600,000.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to an amount
of seven million six hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 7,612,500.-).
2 To issue eighty-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-five (84,444,445) class A shares,
eighty-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-five (84,444,445) class B shares, eighty-four
million four hundred forty-four thousand four hundred forty-five (84,444,445) class C shares, eighty-four million four
hundred forty-four thousand four hundred forty-five (84,444,445) class D shares, eighty-four million four hundred forty-
four thousand four hundred forty-five (84,444,445) class E shares, eighty-four million four hundred forty-four thousand
four hundred forty-four (84,444,444) class F shares, eighty-four million four hundred forty-four thousand four hundred
forty-four (84,444,444) class G shares, eighty-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-four
(84,444,444) class H shares, and eighty-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-three (84,444,443)
class I shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share.
3 To accept subscription for these new shares by the Company’s shareholders, and to accept payment in full of each
such new share by contributions in cash.
4 To amend paragraph 1 of article 5 of the articles of association of the Company, in order to reflect the capital increase.
5 Miscellaneous.
have requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to increase the issued capital of the Company by an amount of seven million six hundred
thousand euro (EUR 7,600,000.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) to an amount of seven million six hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 7,612,500.-).
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolved to issue eighty-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-five
(84,444,445) class A shares, eighty-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-five (84,444,445)
class B shares, eighty-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-five (84,444,445) class C shares,
eighty-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-five (84,444,445) class D shares, eighty-four
million four hundred forty-four thousand four hundred forty-five (84,444,445) class E shares, eighty-four million four
hundred forty-four thousand four hundred forty-four (84,444,444) class F shares, eighty-four million four hundred forty-
four thousand four hundred forty-four (84,444,444) class G shares, eighty-four million four hundred forty-four thousand
four hundred forty-four (84,444,444) class H shares, and eighty-four million four hundred forty-four thousand four hundred
forty-three (84,444,443) class I shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared the Shareholders represented by the above mentioned proxies.
DBG Advisors VI, represented as stated above, declared to subscribe for one million fifty-five thousand five hundred
fifty-six (1,055,556) class A shares, one million fifty-five thousand five hundred fifty-six (1,055,556) class B shares, one
million fifty-five thousand five hundred fifty-six (1,055,556) class C shares, one million fifty-five thousand five hundred
fifty-six (1,055,556) class D shares, one million fifty-five thousand five hundred fifty-six (1,055,556) class E shares, one
million fifty-five thousand five hundred fifty-five (1,055,555) class F shares, one million fifty-five thousand five hundred
fifty-five (1,055,555) class G shares, one million fifty-five thousand five hundred fifty-five (1,055,555) class H shares, and
one million fifty-five thousand five hundred fifty-five (1,055,555) class I shares, each with a nominal value of one euro
cent (EUR 0.01), for a total amount of ninety-five thousand euro (EUR 95,000.-), and to fully pay in cash for these shares.
Fund VI Konzern, represented as stated above, declared to subscribe for fifteen million eight hundred forty-three thou-
sand eight hundred eighty-nine (15,843,889) class A shares, fifteen million eight hundred forty-three thousand eight
hundred eighty-nine (15,843,889) class B shares, fifteen million eight hundred forty-three thousand eight hundred eighty-
nine (15,843,889) class C shares, fifteen million eight hundred forty-three thousand eight hundred eighty-nine (15,843,889)
class D shares, fifteen million eight hundred forty-three thousand eight hundred eighty-nine (15,843,889) class E shares,
fifteen million eight hundred forty-three thousand eight hundred eighty-nine (15,843,889) class F shares, fifteen million
148980
L
U X E M B O U R G
eight hundred forty-three thousand eight hundred eighty-nine (15,843,889) class G shares, fifteen million eight hundred
forty-three thousand eight hundred eighty-nine (15,843,889) class H shares, and fifteen million eight hundred forty-three
thousand eight hundred eighty-eight (15,843,888) class I shares, each with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01),
for a total amount of one million four hundred twenty-five thousand nine hundred fifty (EUR 1,425,950.-), and to fully pay
in cash for these shares.
Fund VI, represented as stated above, declared to subscribe for sixty-seven million five hundred forty-five thousand
euro (67,545,000) class A shares, sixty-seven million five hundred forty-five thousand euro (67,545,000) class B shares,
sixty-seven million five hundred forty-five thousand euro (67,545,000) class C shares, sixty-seven million five hundred
forty-five thousand euro (67,545,000) class D shares, sixty-seven million five hundred forty-five thousand euro
(67,545,000) class E shares, sixty-seven million five hundred forty-five thousand euro (67,545,000) class F shares, sixty-
seven million five hundred forty-five thousand euro (67,545,000) class G shares, sixty-seven million five hundred forty-
five thousand euro (67,545,000) class H shares, and sixty-seven million five hundred forty-five thousand euro (67,545,000)
class I shares, each with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01), for a total amount of six million seventy-nine
thousand fifty euro (EUR 6,079,050.-), and to fully pay in cash for these shares.
The amount of seven million six hundred thousand euro (EUR 7,600,000.-) was thus as from that moment at the disposal
of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolved to accept the above subscriptions and payments, and to allot the new shares to the subscribers
as stated above.
<i>Fourth resolutioni>
In view of the above, the Shareholders resolved to amend paragraph 1 of article 5 of the articles of association of the
Company so as to reflect the foregoing resolutions.
As a result, the first paragraph of article 5 shall from now on read as follows:
“ Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at seven million six hundred twelve thousand five
hundred euro (EUR 7,612,500.-) divided into:
- one million two hundred forty-one thousand (1,241,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) with a nominal value
of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- eighty-four million four hundred forty-five thousand four hundred forty-five (84,445,445) class A shares (the “Class
A Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- eighty-four million four hundred forty-five thousand four hundred forty-five (84,445,445) class B shares (the “Class
B Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- eighty-four million four hundred forty-five thousand four hundred forty-five (84,445,445) class C shares (the “Class
C Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- eighty-four million four hundred forty-five thousand four hundred forty-five (84,445,445) class D shares (the “Class
D Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- eighty-four million four hundred forty-five thousand four hundred forty-five (84,445,445) class E shares (the “Class
E Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- eighty-four million four hundred forty-five thousand four hundred forty-four (84,445,444) class F shares (the “Class
F Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- eighty-four million four hundred forty-five thousand four hundred forty-four (84,445,444) class G shares (the “Class
G Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- eighty-four million four hundred forty-five thousand four hundred forty-four (84,445,444) class H shares (the “Class
H Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up; and
- eighty-four million four hundred forty-five thousand four hundred forty-three (84,445,443) class I shares (the “Class
I Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at three thousand nine hundred euro (EUR 3,900.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same persons and in case
of divergences between the English and the German texts, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, who is known to the undersigned notary
by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this
original deed.
148981
L
U X E M B O U R G
Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am einundzwanzigsten Tag des Monats August,
vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, (Großherzogtum Luxemburg),
sind erschienen:
DBG Advisors VI GmbH & Co. KG, eine nach dem deutschen Recht gegründete Gesellschaft, mit Sitz in der Börsen-
straße 1, D-60313 Frankfurt am Main, Deutschland, und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am
Main unter der Nummer HRA 46856, handelnd durch ihren Komplementär DBG Service Provider Verwaltungs GmbH,
eine nach dem deutschen Recht gegründete Gesellschaft, mit Sitz in der Börsenstraße 1, D-60313 Frankfurt am Main,
Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 90813 („DBG
Advisors“);
hier vertreten durch Maître Stephan Weling, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
kraft einer privatschriftlichen am 18. August 2015 erteilten Vollmacht.;
DBAG Fund VI Konzern (Guernsey) L.P., eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) gegründet nach dem Recht
von Guernsey, mit Sitz im ersten Stock des La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey, und
im Register der Limited Partnerships of the Island of Guernsey eingetragen, handelnd durch ihren Komplementär DBAG
Fund VI GP (Guernsey) L.P., eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) gegründet nach dem Recht von Guernsey,
mit Sitz im ersten Stock des La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey, und im Register der
Limited Partnerships of the Island of Guernsey eingetragen, handelnd durch ihren Komplementär DBG Management GP
(Guernsey) Limited, eine durch die Guernsey Financial Services Commission regulierte Aktiengesellschaft mit Sitz im
ersten Stock des La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey, und im Register der Limited
Partnerships of the Island of Guernsey unter Nummer 55086 registriert („Fund VI Konzern“);
hier vertreten durch Maître Stephan Weling, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
kraft einer privatschriftlichen am 18. August 2015 erteilten Vollmacht.;
DBAG Fund VI (Guernsey) L.P., eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) gegründet nach dem Recht von
Guernsey, mit Sitz im ersten Stock des La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey, und im
Register der Limited Partnerships of the Island of Guernsey registriert, handelnd durch ihren Komplementär DBAG Fund
VI GP (Guernsey) L.P., eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) gegründet nach dem Recht von Guernsey, mit
Sitz im ersten Stock des La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey, und im Register der
Limited Partnerships of the Island of Guernsey registriert, handelnd durch ihren Komplementär DBG Management GP
(Guernsey) Limited, eine durch die Guernsey Financial Services Commission regulierte Aktiengesellschaft mit Sitz im
ersten Stock des La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey, und im Register der Limited
Partnerships of the Island of Guernsey unter Nummer 55086 registriert („Fund VI“);
hier vertreten durch Maître Stephan Weling, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
kraft einer privatschriftlichen am 19. August 2015 erteilten Vollmacht.;
hiernach gemeinsam die „Gesellschafter“ genannt.
Die vorgenannten Vollmachten bleiben dieser Urkunde zum Zwecke der Eintragung dauerhaft beigefügt.
Die Gesellschafter haben den unterzeichnenden Notar gebeten anzugeben, dass sie die alleinigen Gesellschafter von
Glow Holding S.à r.l. sind, einer nach dem luxemburgischen Recht gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée), mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), mit
Sitz in 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxemburg-Findel, Großherzogtum Luxemburg, und eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 198.596, gegründet gemäß einer Urkunde von Maître Marc Loesch,
Notar mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg vom 30. Juni 2015, welche noch nicht im Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde noch
nicht abgeändert.
Die Gesellschafter, vertreten wie oben dargestellt, erklärten über die Beschlüsse ausführlich informiert zu sein, welche
auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind:
<i>Tagesordnungi>
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von sieben Millionen sechshunderttausend Euro (EUR
7.600.000,-), um das bestehende Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf sieben Millionen sechs-
hundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 7.612.500,-) zu erhöhen.
2. Ausgabe von vierundachtzig Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertfünfundvierzig (84.444.445)
Klasse A Anteilen, vierundachtzig Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertfünfundvierzig (84.444.445)
Klasse B Anteilen, vierundachtzig Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertfünfundvierzig (84.444.445)
Klasse C Anteilen, vierundachtzig Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertfünfundvierzig (84.444.445)
Klasse D Anteilen, vierundachtzig Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertfünfundvierzig (84.444.445)
Klasse E Anteilen, vierundachtzig Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertvierundvierzig (84.444.444)
Klasse F Anteilen, vierundachtzig Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertvierundvierzig (84.444.444)
148982
L
U X E M B O U R G
Klasse G Anteilen, vierundachtzig Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertvierundvierzig (84.444.444)
Klasse H Anteilen, und vierundachtzig Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertdreiundvierzig
(84.444.443) Klasse I Anteilen, mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,01) pro Anteil.
3. Annahme der Zeichnung dieser neuen Anteile durch die Gesellschafter, und Annahme der vollständigen Zahlung
dieser neuen Anteile in bar.
4. Neufassung des ersten Abschnitts von Artikel 5 der Satzung, um die oben genannten Beschlüsse abzubilden.
5. Verschiedenes.
und forderten daraufhin den unterzeichnenden Notar auf Folgendes festzuhalten:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschlossen, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von sieben Millionen sechshunderttausend
Euro (EUR 7.600.000,-) zu erhöhen, um das bestehende Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf
sieben Millionen sechshundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 7.612.500,-) zu erhöhen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschlossen, vierundachtzig Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertfünfundvierzig
(84.444.445) Klasse A Anteile, vierundachtzig Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertfünfundvierzig
(84.444.445) Klasse B Anteile, vierundachtzig Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertfünfundvierzig
(84.444.445) Klasse C Anteile, vierundachtzig Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertfünfundvierzig
(84.444.445) Klasse D Anteile, vierundachtzig Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertfünfundvierzig
(84.444.445) Klasse E Anteile, vierundachtzig Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertvierundvierzig
(84.444.444) Klasse F Anteile, vierundachtzig Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertvierundvierzig
(84.444.444) Klasse G Anteile, vierundachtzig Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertvierundvierzig
(84.444.444) Klasse H Anteile, und vierundachtzig Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertdreiundvierzig
(84.444.443) Klasse I Anteile, mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,01) pro Anteil, auszugeben.
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
Daraufhin erschienen die Gesellschafter gemäß der oben genannten Vertretungsvollmachten.
DBG Advisors VI erklärte die Zeichnung von einer Million fünfundfünfzigtausendfünfhundertsechsundfünfzig
(1.055.556) Klasse A Anteilen, einer Million fünfundfünfzigtausendfünfhundertsechsundfünfzig (1.055.556) Klasse B
Anteilen, einer Million fünfundfünfzigtausendfünfhundertsechsundfünfzig (1.055.556) Klasse C Anteilen, einer Million
fünfundfünfzigtausendfünfhundertsechsundfünfzig (1.055.556) Klasse D Anteilen, einer Million fünfundfünfzigtausend-
fünfhundertsechsundfünfzig (1.055.556) Klasse E Anteilen, einer Million fünfundfünfzigtausendfünfhundertfünfundfünf-
zig (1.055.555) Klasse F Anteilen, einer Million fünfundfünfzigtausendfünfhundertfünfundfünfzig (1.055.555) Klasse G
Anteilen, einer Million fünfundfünfzigtausendfünfhundertfünfundfünfzig (1.055.555) Klasse H Anteilen, und einer Million
fünfundfünfzigtausendfünfhundertfünfundfünfzig (1.055.555) Klasse I Anteilen, mit einem Nennwert von jeweils einem
Cent (EUR 0,01) und einem Gesamtwert von fünfundneunzigtausend Euro (EUR 95.000.-), und erklärte den Nennwert
dieser Anteile vollständig in bar einzuzahlen.
Fund VI Konzern erklärte die Zeichnung von fünfzehn Millionen achthundertdreiundvierzigtausendachthundertneu-
nundachtzig (15.843.889) Klasse A Anteilen, fünfzehn Millionen achthundertdreiundvierzigtausendachthundertneunun-
dachtzig (15.843.889) Klasse B Anteilen, fünfzehn Millionen achthundertdreiundvierzigtausendachthundertneunundacht-
zig (15.843.889) Klasse C Anteilen, fünfzehn Millionen achthundertdreiundvierzigtausendachthundertneunundachtzig
(15.843.889) Klasse D Anteilen, fünfzehn Millionen achthundertdreiundvierzigtausendachthundertneunundachtzig
(15.843.889) Klasse E Anteilen, fünfzehn Millionen achthundertdreiundvierzigtausendachthundertneunundachtzig
(15.843.889) Klasse F Anteilen, fünfzehn Millionen achthundertdreiundvierzigtausendachthundertneunundachtzig
(15.843.889) Klasse G Anteilen, fünfzehn Millionen achthundertdreiundvierzigtausendachthundertneunundachtzig
(15.843.889) Klasse H Anteilen, und fünfzehn Millionen achthundertdreiundvierzigtausendachthundertachtundachtzig
(15.843.888) Klasse I Anteilen, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01) und einem Gesamtwert von ein
Million vierhundertfünfundzwanzigtausendneunhundertfünfzig Euro (EUR 1.425.950.-), und erklärte den Nennwert dieser
Anteile vollständig in bar einzuzahlen.
Fund VI erklärte die Zeichnung von siebenundsechzig Millionen fünfhundertfünfundvierzigtausend (67.545.000) Klasse
A Anteilen, siebenundsechzig Millionen fünfhundertfünfundvierzigtausend (67.545.000) Klasse B Anteilen, siebenund-
sechzig Millionen fünfhundertfünfundvierzigtausend (67.545.000) Klasse C Anteilen, siebenundsechzig Millionen fünf-
hundertfünfundvierzigtausend (67.545.000) Klasse D Anteilen, siebenundsechzig Millionen fünfhundertfünfundvierzig-
tausend (67.545.000) Klasse E Anteilen, siebenundsechzig Millionen fünfhundertfünfundvierzigtausend (67.545.000)
Klasse F Anteilen, siebenundsechzig Millionen fünfhundertfünfundvierzigtausend (67.545.000) Klasse G Anteilen, sie-
benundsechzig Millionen fünfhundertfünfundvierzigtausend (67.545.000) Klasse H Anteilen, und siebenundsechzig Mil-
lionen fünfhundertfünfundvierzigtausend (67.545.000) Klasse I Anteilen, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent
(EUR 0,01) und einem Gesamtwert von sechs Millionen neunundsiebzigtausendfünfzig (EUR 6.079.050), und erklärte den
Nennwert dieser Anteile vollständig in bar einzuzahlen.
148983
L
U X E M B O U R G
Der Betrag von sieben Millionen sechshunderttausend Euro (EUR 7.600.000,-) stand ab diesem Zeitpunkt der Gesell-
schaft zur Verfügung, und der unterzeichnende Notar hat die notwendigen Dokumente dies belegend erhalten.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter erkennen die Zeichnung dieser neuen Anteile wie oben dargestellt an, und nehmen die vollständige
Zahlung dieser neuen Anteile in bar an.
<i>Vierter Beschlussi>
In Anbetracht der obigen Beschlüsse, beschließen die Gesellschafter den ersten Abschnitt von Artikel 5 der Satzung der
Gesellschaft abzuändern, um diese Beschlüsse widerzuspiegeln.
Der erste Abschnitt von Artikel 5 der Satzung wird wie folgt abgeändert:
„ Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt sieben Millionen sechs-
hundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 7.612.500,-), und ist wie folgt aufgeteilt:
- eine Million zweihunderteinundvierzigtausend (1.241.000) Stammanteile (die „Stammanteile“) mit einem Nennwert
von je einem Eurocent (EUR 0,01), welche vollständig eingezahlt sind;
- vierundachtzig Millionen vierhundertfünfundvierzigtausendvierhundertfünfundvierzig (84.445.445) Klasse A Anteile
(die „Klasse A Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), welche vollständig eingezahlt sind;
- vierundachtzig Millionen vierhundertfünfundvierzigtausendvierhundertfünfundvierzig (84.445.445) Klasse B Anteile
(die „Klasse B Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), welche vollständig eingezahlt sind;
- vierundachtzig Millionen vierhundertfünfundvierzigtausendvierhundertfünfundvierzig (84.445.445) Klasse C Anteile
(die „Klasse C Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), welche vollständig eingezahlt sind;
- vierundachtzig Millionen vierhundertfünfundvierzigtausendvierhundertfünfundvierzig (84.445.445) Klasse D Anteile
(die „Klasse D Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), welche vollständig eingezahlt sind;
- vierundachtzig Millionen vierhundertfünfundvierzigtausendvierhundertfünfundvierzig (84.445.445) Klasse E Anteile
(die „Klasse E Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), welche vollständig eingezahlt sind;
- vierundachtzig Millionen vierhundertfünfundvierzigtausendvierhundertvierundvierzig (84.445.444) Klasse F Anteile
(die „Klasse F Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), welche vollständig eingezahlt sind;
- vierundachtzig Millionen vierhundertfünfundvierzigtausendvierhundertvierundvierzig (84.445.444) Klasse G Anteile
(die „Klasse G Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), welche vollständig eingezahlt sind;
- vierundachtzig Millionen vierhundertfünfundvierzigtausendvierhundertvierundvierzig (84.445.444) Klasse H Anteile
(die „Klasse H Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), welche vollständig eingezahlt sind;
- vierundachtzig Millionen vierhundertfünfundvierzigtausendvierhundertdreiundvierzig (84.445.443) Klasse I Anteile
(die „Klasse I Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,01), welche vollständig eingezahlt sind.“
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde
entstehen, werden auf dreitausendneunhundert Euro (EUR 3.900,-) geschätzt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärte hierbei, dass auf Anfrage der obigen
genannten Personen das vorliegende Dokument auf englischer und deutscher Sprache verfasst wurde; auf Anfrage derselben
Personen und im Falle verschiedener Auslegungen zwischen dem englischen und deutschen Text soll der Englische Vorrang
haben.
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten
Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, hat dieser Bevollmächtigte vorliegende Urkunde mit
dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet.
Signé: S. Weling, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 25 août 2015. GAC/2015/7281. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 25 septembre 2015.
Référence de publication: 2015158606/316.
(150175609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.
148984
L
U X E M B O U R G
Infor Lux Bond Company, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 113.718.
Les comptes annuels au 31 mai 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015160093/10.
(150176382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
K.F. Invest SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.
R.C.S. Luxembourg B 90.064.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29/09/2015.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2015160134/12.
(150176864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Safety-Coach S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 2, rue J.P. Michels.
R.C.S. Luxembourg B 200.264.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le vingt-trois septembre
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussignée.
A comparu:
Monsieur Jean-Claude LEIFGEN, né le 23 mai 1956 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 2, Rue
J.P.Michels,
agissant en son nom personnel,
ci-après dénommé «l'associé».
Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée uni-personnelle à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée uni-personnelle sous la dénomination de:
"SAFETY-COACH S.à r.l.".
L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également
prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère uni-personnel de la société.
Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé.
Art. 3. La société a pour objet l'achat et la vente du matériels et de systèmes de gestion de la protection au travail.
La société peut faire toutes opérations commerciales ou financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente-et-un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) représenté par
CENTS (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.
148985
L
U X E M B O U R G
Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En présence de plusieurs associés, et pour toutes cessions de parts sociales, les associés bénéficieront d'un droit de
préemption.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition
de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers
et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession. Jusqu'au
partage des-dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront
l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.
En présence de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont
applicables.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe les pouvoirs.
Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé.
A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la
société en toutes circonstances.
L'associé unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché
qu'à l'étranger.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune obligation
personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 11. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon
suivante:
- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l'associé.
Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s'en réfère aux dispositions
légales.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les cents parts sont souscrites en numéraire par l'associé unique Monsieur Jean-Claude LEIFGEN, né le 23 mai
1956 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 2, Rue J.P.Michels.
L'associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en es-
pèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) se trouve dès-à-présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente-et-un décembre deux mille
quinze.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à environ mille cent euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Claude LEIFGEN, né le 23 mai 1956 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 2, Rue
J.P.Michels.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
148986
L
U X E M B O U R G
2. Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante: L-4243 Esch-sur-Alzette, 2, Rue J.P.Michels.
Le notaire a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée,
celui-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce
qui est expressément reconnu par le comparant.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
le comparant a signé avec moi, notaire, la présente minute.
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Jean-Claude Leifgen, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 septembre 2015. Relation: EAC/2015/21920. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2015.
Référence de publication: 2015158970/99.
(150175693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.
CityEl S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 104.358.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2015159919/13.
(150176855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Magnate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.166.666,66.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 189.985.
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of the month of September.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of “Magnate S.à r.l.” (the “Company”), a société à responsabilité
limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg on 5 August 2014 by deed of the undersigned
notary published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 3059 of 22 October
2014, with its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce
et des Sociétés in Luxembourg under number B 189.985.
The articles of association of the Company have been amended for the last time by deed of the undersigned notary on
27 March 2015, published in the Mémorial number 1731 of 14 July 2015.
The meeting was presided by Me Toinon Hoss, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and scrutineer Me Milène Drweski, maître en droit, professionally residing in
Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed
by the proxyholder, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to
the present deed to be filed with the registration authorities.
148987
L
U X E M B O U R G
As it appeared from said attendance list, all shareholders and all one hundred million (100,000,000) shares in issue in
the Company were represented at the meeting and the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge
of the agenda so that the meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items on the agenda.
II. The agenda of the meeting was as follows:
<i>Agendai>
- Increase of the issued share capital of the Company to one million one hundred sixty-six thousand six hundred sixty-
six USD and sixty-six USD cents (USD 1,166,666.66) by the issue of a total of sixteen million six hundred sixty-six
thousand six hundred sixty-six (16,666,666) shares of ten (10) different classes (being four hundred sixty-six thousand six
hundred sixty-six (466,666) shares of class A and one million eight hundred thousand (1,800,000) shares in each class B
to J) of a nominal value of one USD cent (USD 0.01) each (the “New Shares”) for a total subscription price of five hundred
thousand USD (USD 500,000) to TCP Magnate Holdings Ltd., an exempted company, incorporated in the Cayman Islands
with limited liability, having its registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue,
George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, and registered with the Registrar of Companies under number
IT-302499 (“TCP”) and Black Forest Structured Lending Master Fund LP, an exempted limited partnership organized
under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street,
George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands, and registered with the Registrar of Exempted Limited Part-
nerships under number 74157 (“Black Forest”) as set forth in the table below; subscription to the New Shares by way of a
contribution in kind of claims owed by to subscribers by the Company of an aggregate amount of five hundred thousand
USD (USD 500,000) (the “Contribution in Kind”); acknowledgment of a report of the board of managers on the valuation
of the Contribution in Kind and approval of the valuation of the Contribution in Kind at five hundred thousand USD (USD
500,000) and confirmation of the subscription to the New Shares and payment of the subscription price; allocation of the
total issue price as to the aggregate nominal value of the New Shares to the share capital, an amount equal to 10% of nominal
value of the New Shares to the legal reserve and the balance to the freely distributable share premium; and consequential
amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company in order to provide for the items above:
Subscribers
Class
Number
of Shares
subscribed
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
93,333
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
373,333
Total class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466,666
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
360,000
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
1,440,000
Total class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,800,000
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
360,000
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
1,440,000
Total class C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,800,000
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
360,000
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
1,440,000
Total class D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,800,000
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
360,000
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
1,440,000
Total class E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,800,000
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
360,000
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
1,440,000
Total class F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,800,000
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G
360,000
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G
1,440,000
Total class G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,800,000
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H
360,000
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H
1,440,000
Total class H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,800,000
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
360,000
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
1,440,000
Total class I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,800,000
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J
360,000
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J
1,440,000
148988
L
U X E M B O U R G
Total class J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,800,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,666,666
Thereupon the meeting passed the following decisions as a sole resolution:
<i>Sole resolutioni>
It is resolved to increase the issued share capital of the Company to one million one hundred sixty-six thousand six
hundred sixty-six USD and sixty-six USD cents (USD 1,166,666.66) by the issue of (and to issue) a total of sixteen million
six hundred sixty-six thousand six hundred sixty-six (16,666,666) shares of ten (10) different classes (being four hundred
sixty-six thousand six hundred sixty-six (466,666) shares of class A and one million eight hundred thousand (1,800,000)
shares per class B to J) of a nominal value of one USD cent (USD 0.01) each (the “New Shares”) for a total issue price of
five hundred thousand USD (USD 500,000) to the subscribers as set forth in the table in the agenda.
Thereupon, the subscription to the New Shares (as set forth in the table in the agenda) was confirmed by the subscribers,
each represented by Me Toinon Hoss, prenamed, pursuant to proxies which shall remain attached to the present deed to be
registered therewith.
The total issue price of the New Shares is fully paid by the Contribution in Kind in the aggregate amount of five hundred
thousand US Dollars (USD 500,000).
The value of the Contribution in Kind has been the subject of a valuation report by the board of managers of the Company
dated 18 September 2015 and the conclusion of which reads as follows:
“Nothing has come to the attention of the Board of Managers which would lead it to believe that the value of the
Contribution in Kind is not at least USD 500,000 being equal to the issue price of the 16,666,666 shares (of different classes)
to be issued by the Company”.
It was resolved to approve the value of the Contribution in Kind, the capital increase and the issue of the New Shares
as set forth above.
Evidence of the payment in kind was shown to the undersigned notary.
The meeting resolved to allocate the total issue price as to the aggregate nominal value of the New Shares to the share
capital, an amount equal to 10% of nominal value of the New Shares to the legal reserve and the balance to the freely
distributable share premium.
As a result of the above, the paragraph 1 of article 5 of the articles of association of the Company shall be amended to
read as follows:
“ 5.1. The issued share capital of the Company is set at one million one hundred sixty-six thousand six hundred sixty-
six USD and sixty-six USD cents (USD 1,166,666.66) divided into a total of one hundred sixteen million six hundred sixty-
six thousand six hundred sixty-six million (116,666,666) shares of different classes as follows:
- three million two hundred sixty-six thousand six hundred sixty-six (3,266,666) Class A shares,
- twelve million six hundred thousand (12,600,000) Class B shares,
- twelve million six hundred thousand (12,600,000) Class C shares,
- twelve million six hundred thousand (12,600,000) Class D shares,
- twelve million six hundred thousand (12,600,000) Class E shares,
- twelve million six hundred thousand (12,600,000) Class F shares,
- twelve million six hundred thousand (12,600,000) Class G shares,
- twelve million six hundred thousand (12,600,000) Class H shares,
- twelve million six hundred thousand (12,600,000) Class I shares, and
- twelve million six hundred thousand (12,600,000) Class J shares;
each share having a par value of one USD cent (USD 0.01) each and the rights and obligations as set forth in the present
articles of association.”
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated
at EUR 2,800.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French versions, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le dix-huit septembre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
148989
L
U X E M B O U R G
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire des associés de «Magnate S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité
limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg le 5 août 2014 suivant un acte reçu du notaire soussigné
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 3059 du 22 octobre 2014, ayant son
siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et étant immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 189.985. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte
du notaire soussigné le 27 mars 2015, publié au Mémorial numéro 1731 du 14 juillet 2015.
L'assemblée a été présidée par Me Toinon Hoss, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.
La présidente a nommé en tant que secrétaire et scrutateur Me Milène Drweski, maître en droit, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
La présidente a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. Les associés représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée
par le mandataire, le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste sera annexée au présent acte
afin d'être soumise aux formalités de l'enregistrement.
Il ressort de ladite liste de présence que tous les associés ainsi que l'ensemble des cent millions (100.000.000) de parts
sociales émises dans la Société étaient représentés à l'assemblée et les associés de la Société ont déclaré avoir eu connais-
sance au préalable de l'ordre du jour de sorte que l'assemblée était valablement constituée et en mesure de valablement
délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.
II. L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
- Augmentation du capital social émis de la Société à un million cent soixante-six mille six cent soixante-six dollars des
États-Unis et soixante-six centimes (1.166.666,66 USD) par l'émission d'un total de seize millions six cent soixante-six
mille six cent soixante-six (16.666.666) parts sociales de dix (10) classes différentes (à savoir quatre cent soixante-six mille
six cent soixante-six (466.666) parts sociales de classe A et un million huit cent mille (1.800.000) parts sociales dans
chacune des classes B à J) d'une valeur nominale d'un centime de dollar des États-Unis (0,01 USD) chacune (les «Nouvelles
Parts Sociales») pour un prix total de souscription de cinq cent mille USD (500.000 USD) à TCP Magnate Holdings Ltd.,
une exempted company with limited liability constituée aux îles Caïmans, ayant son siège social à Intertrust Corporate
Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Îles Caïmans, et immatriculée
auprès du Registrar of Companies sous le numéro IT-302499 («TCP») et Black Forest Structured Lending Master Fund
LP, un exempted limited partnership régi par les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social au P.O. Box 309, Ugland
House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Îles Caïmans, et immatriculée auprès du Registrar
of Exempted Limited Partnerships sous le numéro 74157 («Black Forest») tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous; sou-
scription aux Nouvelles Parts Sociales par un apport en nature composé de créances dues par aux souscripteurs par la
Société d'un montant total de cinq cent mille dollars des États-Unis (500.000 USD) (l'«Apport en Nature»); reconnaissance
d'un rapport du conseil de gérance sur l'évaluation de l'Apport en Nature et approbation de l'évaluation de l'Apport en
Nature à cinq cent mille dollars des États-Unis (500.000 USD) et confirmation de la souscription aux Nouvelles Parts
Sociales et paiement du prix de souscription; allocation du prix total de souscription en ce qui concerne la valeur nominale
totale des Nouvelles Parts Sociales au capital social, un montant égal à 10% de la valeur nominale des Nouvelles Parts
Sociales à la réserve légale et le solde à la prime d'émission librement distribuable; et modification en conséquence de
l'article 5.1 des statuts de la Société afin de prévoir les points ci-dessous:
Souscripteurs
Classe
Nombre
de Parts
Sociales
souscrites
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
93.333
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
373.333
Total classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466.666
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
360.000
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
1.440.000
Total classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.800.000
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
360.000
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
1.440.000
Total classe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.800.000
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
360.000
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
1.440.000
Total classe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.800.000
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
360.000
148990
L
U X E M B O U R G
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
1.440.000
Total classe E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.800.000
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
360.000
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
1.440.000
Total classe F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.800.000
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G
360.000
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G
1.440.000
Total classe G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.800.000
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H
360.000
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H
1.440.000
Total classe H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.800.000
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
360.000
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
1.440.000
Total classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.800.000
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J
360.000
Black Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J
1.440.000
Total classe J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.800.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.666.666
À la suite de quoi, l'assemblée a pris les décisions suivantes en une seule résolution:
<i>Résolution uniquei>
Il est décidé d'augmenter le capital social émis de la Société à un million cent soixante-six mille six cent soixante-six
dollars des États-Unis et soixante-six centimes (1.166.666,66 USD) par l'émission d'un (et d'émettre un) total de seize
millions six cent soixante-six mille six cent soixante-six (16.666.666) parts sociales de dix (10) classes différentes (à savoir
quatre cent soixante-six mille six cent soixante-six (466.666) parts sociales de classe A et un million huit cent mille
(1.800.000) parts sociales par classe B à J) d'une valeur nominale d'un centime de dollar des États-Unis (0,01 USD) chacune
(les «Nouvelles Parts Sociales») pour un prix total d'émission de cinq cent mille dollars des États-Unis (500.000 USD) aux
souscripteurs tel qu'indiqué dans le tableau dans l'ordre du jour.
À la suite de quoi, la souscription aux Nouvelles Parts Sociales (tel qu'indiqué dans le tableau dans l'ordre du jour) a été
confirmée par les souscripteurs, chacun représenté par Me Toinon Hoss, précitée, conformément aux procurations qui
devront rester annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Le prix total d'émission des Nouvelles Parts Sociales est intégralement payé par l'Apport en Nature d'un montant total
de cinq cent mille dollars des États-Unis (500.000 USD). La valeur de l'Apport en Nature a fait l'objet d'un rapport d'éva-
luation du conseil de gérance de la Société daté du 18 septembre 2015 et dont la conclusion est la suivante:
«Le Conseil de Gérance n'a rien relevé qui lui permettrait de croire que la valeur de l'Apport en Nature n'est pas d'au
moins 500.000 USD, soit une valeur égale au prix d'émission des 16.666.666 parts sociales (de classes différentes) devant
être émises par la Société.»
Il a été décidé d'approuver la valeur de l'Apport en Nature, l'augmentation de capital et l'émission des Nouvelles Parts
Sociales tel qu'indiqué ci-dessus.
Preuve du paiement en nature a été montrée au notaire soussigné.
L'assemblée a décidé d'allouer le prix total d'émission en ce qui concerne la valeur nominale globale des Nouvelles Parts
Sociales au capital social, un montant égal à 10% de la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales à la réserve légale,
et le solde à la prime d'émission librement distribuable.
En conséquence de ce qui précède, le paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la Société est modifié afin d'avoir la teneur
suivante:
« 5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à un million cent soixante-six mille six cent soixante-six dollars des
États-Unis et soixante-six centimes (1.166.666,66 USD) représenté par cent seize millions six cent soixante-six mille six
cent soixante-six (116.666.666) parts sociales de classes différentes comme suit:
- trois millions deux cent soixante-six mille six cent soixante-six (3.266.666) parts sociales de Classe A,
- douze millions six cent mille (12.600.000) parts sociales de Classe B,
- douze millions six cent mille (12.600.000) parts sociales de Classe C,
- douze millions six cent mille (12.600.000) parts sociales de Classe D,
- douze millions six cent mille (12.600.000) parts sociales de Classe E,
- douze millions six cent mille (12.600.000) parts sociales de Classe F,
- douze millions six cent mille (12.600.000) parts sociales de Classe G,
- douze millions six cent mille (12.600.000) parts sociales de Classe H,
148991
L
U X E M B O U R G
- douze millions six cent mille (12.600.000) parts sociales de Classe I, et
- douze millions six cent mille (12.600.000) parts sociales de Classe J;
chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un cent de dollar des États-Unis (0,01 USD) et les droits et obligations
énoncés dans les présents statuts.»
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incomberont à la Société sont estimés
à EUR 2.800,-
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,
le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction en langue française; à la demande de la même personne
comparante, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent procès-verbal, les membres du bureau et le notaire ont signé le présent acte.
Signé: T. HOSS, M. DRWESKI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/30159. Reçu soixante-quinze
euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 25 septembre 2015.
Référence de publication: 2015158793/265.
(150175589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.
CATBI Associates s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8391 Nospelt, 7, rue de l'Ecole.
R.C.S. Luxembourg B 105.208.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159933/9.
(150176653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Crystal Carmine S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 150.125.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
Référence de publication: 2015159927/11.
(150176539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Cardboard International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 53.051.
Le bilan de la société au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015159932/12.
(150176364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
148992
Aerodynamics S.A.
AH Realty (Spain) S.à r.l.
Alexandre Holding S.à.r.l.
AlgoQuest System S.A.
Aline Holding S.A.
Allmende S.A.
Althyda International S.A.
Amenagement Commercial Grand-Rue
Amenoffice S.A.
Apollo BidCo S.à r.l.
Apollo HoldCo S.à r.l.
aPRIVA S.à r.l.
Art & Build s.à r.l.
Audatex Holdings II S.à r.l.
Augitherm Sàrl
Bakapa S.à r.l.
BCD Travel Luxembourg S.A.
Bensell Real Estate Holdings II Sàrl
Boca S.à r.l.
Bolton Square S.A.
Bombicht Carburants S.à r.l.
Cardboard International S.A.
CATBI Associates s.à r.l.
CHC Helicopter (3) S.à r.l.
CityEl S.à r.l.
Crystal Carmine S.A.
Digital Services XXVII S.à r.l.
DR Alésia S.à r.l.
DR Cap Corniche S.à r.l.
Eradius Immobilière S.A.
Glow Holding S.à r.l.
Glow Investment S.à r.l.
Grand City Properties S.A.
Hydraulique Service S.àr.l.
Immoshine S.A.
Infor Lux Bond Company
J.J.R. GmbH
K.F. Invest SA
La Casa Moderna S.à r.l.
Lazur Investment S.à r.l.
Logs Holdings Pledgeco S.à r.l.
LSREF3 GTC Holdings S.à r.l.
Magnate S.à r.l.
Nodeta S.A.
Safety-Coach S.à r.l.
SDE, système D énergie S.A.
Vandenbroeck Lux S.à r.l.
Vecchia Roma Sàrl
Wap Holdings S.A.
Weblogistics S.à r.l.