This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3094
12 novembre 2015
SOMMAIRE
Anetorre SOCIMI Holdo S.à r.l. . . . . . . . . . . .
148499
B C L (Business Central Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148470
Cheapside S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148469
Circle Moment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148469
Clorin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148466
Day After . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148466
Djedefre S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148470
Dunchurch Holdings Group S.à r.l. . . . . . . . . .
148466
Duva SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148469
ECommerce Taxi (GP) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
148467
Eden Roc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148467
Eden Roc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148467
EPF Garden Towers S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
148468
E.S.L. Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148470
Farringdon Street (Luxembourg) S.à r.l. . . . .
148466
Financière 3P S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148469
Frans S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148470
Fritz Neuhöfer Fourrage Exclusif S.A. . . . . . .
148466
Gläsener Transports S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . .
148466
Global Emergency Services S.à r.l. . . . . . . . . .
148474
Gold Ocean S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148469
Holdinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148471
ISM Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148471
Lasting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148471
Levita S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148471
LFH Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
148467
Logs Holdings Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
148478
Lux Star International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
148512
Minit International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148470
Molandi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148471
Parker Hannifin Partnership S.C.S. . . . . . . . .
148501
Ramillies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148468
Robert Half Holding S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . .
148468
Rucio Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148468
Saphilux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148486
Shire Luxembourg Finance S.à r.l. . . . . . . . . .
148495
Silver Diamond TEHB24 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
148468
SOF-10 Starlight 16 GBP S.à r.l. . . . . . . . . . . .
148476
Starlyst UK Investments Lux S.à r.l. . . . . . . . .
148476
Swisscanto Asset Management International
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148467
Tin Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148499
TrefilARBED Grembergen S.A. . . . . . . . . . . .
148499
Vidar Shipowning S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148472
148465
L
U X E M B O U R G
Day After, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7447 Lintgen, 4, route de Fischbach.
R.C.S. Luxembourg B 157.995.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159302/9.
(150175500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Clorin S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1473 Luxembourg, 2A, rue Jean-Baptiste Esch.
R.C.S. Luxembourg B 144.679.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159273/9.
(150175754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Dunchurch Holdings Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 173.141.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159321/9.
(150176062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Farringdon Street (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 1.761.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 161.301.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159357/9.
(150175926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Fritz Neuhöfer Fourrage Exclusif S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach, 3, rue Henri Tudor.
R.C.S. Luxembourg B 146.716.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159376/9.
(150176044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Gläsener Transports S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.
R.C.S. Luxembourg B 139.944.
Der Jahresabschluss auf den 31.12.2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159382/9.
(150175673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
148466
L
U X E M B O U R G
LFH Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2229 Luxembourg, 2-4, rue du Nord.
R.C.S. Luxembourg B 144.560.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015158772/9.
(150175298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.
Eden Roc S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 105.125.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2015159339/10.
(150176127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Eden Roc S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 105.125.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2015159340/10.
(150176128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
ECommerce Taxi (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 180.457.
Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2014 de la Société (rectificatif des comptes déposés en date du 18 août
2015 sous la référence L150153032) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ECommerce Taxi (GP) S.à r.l.
Référence de publication: 2015159337/11.
(150174568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Swisscanto Asset Management International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 121.904.
Le bilan au 30 juin 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2015.
<i>Pour SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
i>Société anonyme
RBC Investor Services Bank S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2015159752/14.
(150175811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
148467
L
U X E M B O U R G
Rucio Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 167.500,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 174.030.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159676/9.
(150175847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Ramillies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 55.128.
Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2015.
Référence de publication: 2015159677/10.
(150175690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Silver Diamond TEHB24 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 174.462.
Les comptes annuels de la société Silver Diamond TEHB24 S.à r.l. au 31/12/2014 ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159698/10.
(150175797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Robert Half Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 134.472.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Robert Half Holding S. à r. l.
Exequtive Partners S.A.
<i>Gérant de catégorie Ci>
Référence de publication: 2015159668/12.
(150175958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
EPF Garden Towers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 120.538.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2015.
EPF Garden Towers S.à r.l.
Mr. Richard Crombie / Mr. Mark Doherty
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2015159345/13.
(150175695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
148468
L
U X E M B O U R G
Cheapside S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 16.858,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 94.706.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2015.
Référence de publication: 2015159263/10.
(150176027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Circle Moment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 150.338.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CIRCLE MOMENT S.A.
Référence de publication: 2015159267/10.
(150176157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Duva SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 10.529.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DEVA SPF S.A.
Signatures
Référence de publication: 2015159322/11.
(150175610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Financière 3P S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 173.956.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
FINANCIÉRE 3P S.A.
Référence de publication: 2015159367/11.
(150175824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Gold Ocean S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 162.377.
Le bilan de la société au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015159385/12.
(150175681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
148469
L
U X E M B O U R G
Djedefre S.A. Holding, Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 108.352.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159314/9.
(150175720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
E.S.L. Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 46, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 170.449.
Le Bilan au 31 Décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015159325/10.
(150176182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
B C L (Business Central Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3340 Huncherange, 30, rue de la Résistance.
R.C.S. Luxembourg B 146.261.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PINHEIRO Samantha.
Référence de publication: 2015159154/10.
(150175438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Minit International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 7.197.
Les comptes annuels au 31/03/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Minit International S.A.
Signature
Référence de publication: 2015159586/12.
(150176105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Frans S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 103.842.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2015159373/13.
(150175929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
148470
L
U X E M B O U R G
ISM Conseil, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 68, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 150.447.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159467/9.
(150175771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Lasting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 96.394.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2015159533/10.
(150176141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Levita S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 96.392.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2015159536/10.
(150176138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Molandi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 69.367.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MOLANDI HOLDING S.A.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015159594/12.
(150175575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
Holdinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 165.467.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2015159425/13.
(150175777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
148471
L
U X E M B O U R G
Vidar Shipowning S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 34-36, Parc d'Activités Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 196.413.
In the year two thousand and fifteen on fifteenth day of September,
before us Maître Marc LOESCH, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of VIDAR SHIPOWNING SA a société anonyme governed by
the laws of Luxembourg, with registered office at 11, route des Trois Cantons, L-8399 Windhof, Grand Duchy of Luxem-
bourg, incorporated following a deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of
Luxembourg, of 22 April 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1,182 of 7
th
May 2015 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 196413 (the
"Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.
The meeting was declared open at 6.15 p.m. by Me Nirida Nhouyvanisvong, with professional address in Luxembourg,
in the chair,
who appointed as secretary Me Matthieu De Donder, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Me Cristiana Musteanu, with professional address in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the
following:
(i) That the agenda of the meeting was the following:
<i>Agendai>
1 To transfer the registered office of the Company from 11, route des Trois Cantons, L-8399 Windhof to 34-36, Parc
d'Activités Capellen, L-8308 Capellen.
2 To amend article 4.1 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the transfer of the registered
office.
3 To amend the corporate object of the Company in order to delete the words “the construction” in the first paragraph
of article 2 of the articles of incorporation of the Company. The said paragraph shall read as follows:
“The objects of the company are the purchase, the sale, the chartering, the freighting and the management of sea-going
vessels, as well as all financial, maritime and commercial operations directly and indirectly relating to this. The company
may, both in Luxembourg and abroad, perform the following activities:”
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
the shares held by the shareholders are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present,
the proxyholders of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, after having been signed by the proxyholders, the members of the
board of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
(iv) That the whole share capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared
that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally
convened.
(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to transfer the registered office of the Company from 11,
route des Trois Cantons, L-8399 Windhof to 34-36, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen.
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to amend article 4.1 of the articles of incorporation of the
Company in order to reflect the above resolution. Said article will from now on read as follows:
“ 4.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Mamer.”
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to amend the corporate object of the Company in order to
delete the words “the construction” in the first paragraph of article 2 of the articles of incorporation of the Company. The
said paragraph shall read as follows:
148472
L
U X E M B O U R G
“The objects of the company are the purchase, the sale, the chartering, the freighting and the management of sea-going
vessels, as well as all financial, maritime and commercial operations directly and indirectly relating to this. The company
may, both in Luxembourg and abroad, perform the following activities:”
There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 6.30 p.m..
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all known to the undersigned notary by their surname, first
name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze le quinzième jour du mois de septembre,
par-devant nous Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VIDAR SHIPOWNING SA, une société anonyme régie par
le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 11, route des Trois Cantons, L-8399 Windhof, Grand-Duché de Lu-
xembourg, constituée suivant acte de Maître Paul BETTINGEN notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de
Luxembourg en date du 22 Avril 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1182
du 7 mai 2015 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 196413 (la
«Société»). Les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis lors.
L'assemblée a été déclarée ouverte à 18.15 heures sous la présidence de Maître Nirida Nhouyvanisvong, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
qui a désigné comme secrétaire Maître Matthieu De Donder, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Cristiana Musteanu, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Transfert du siège social de la Société du 11, route des Trois Cantons, L-8399 Windhof au 34-36, Parc d'Activités
Capellen, L-8308 Capellen.
2 Modification de l'article 4.1 des statuts de la Société, afin de refléter le transfert du siège social.
3 Modification de l'objet social de la Société par la suppression des mots «la construction» dans le premier alinéa de
l'article 2 des statuts de la Société. Ledit alinéa sera désormais rédigé comme suit:
«La Société a pour objet l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que toutes
opérations financières, maritimes et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement. La Société peut, tant au
Luxembourg qu'à l'étranger, réaliser les activités suivantes:»
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du bureau
et le notaire soussigné resteront également annexées au présent acte.
(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont
déclaré avoir été dûment avisés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont
renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.
(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur tous les points inscrits
à l'ordre du jour.
(vi) Que l'assemblée a adopté, à chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé de transférer le siège social de la société du 11, route des
Trois Cantons, L-8399 Windhof au 34-36, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen.
148473
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé de modifier l'article 4.1 des statuts de la Société pour
refléter la résolution ci-dessus. Ledit article sera dorénavant rédigé comme suit:
« 4.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Mamer.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé de modifier l'objet social de la Société par la suppression
des mots «la construction» dans le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société. Ledit alinéa sera désormais rédigé
comme suit:
«La Société a pour objet l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que toutes
opérations financières, maritimes et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement. La Société peut, tant au
Luxembourg qu'à l'étranger, réaliser les activités suivantes:»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée à 18.30 heures.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire soussigné par nom, prénom
usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: N. Nhouyvanisvong, M. De Donder, C. Musteanu, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 18 septembre 2015. GAC/2015/7971. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 23 septembre 2015.
Référence de publication: 2015158268/130.
(150174472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.
Global Emergency Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 157.798.
In the year two thousand and fifteen, on the ninth of September,
Before us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Global Emergency Services S.à r.l., a Lu-
xembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 51, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under num-
ber B 157.798, and having a share capital amounting to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) (the Company).
The Company has been incorporated on December 17, 2010, pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 262, page 12548, and dated February 9, 2011. The articles of association of the Company (the Articles) have not
been amended since its incorporation.
THERE APPEARED:
Investindustrial III L.P., a limited partnership organised and existing under the laws of United Kingdom, having its
registered office at 180-186 Brompton Road, 3
rd
floor, SW3 1HQ London, United Kingdom, registered with the United
Kingdom Companies House under number LP 10560, represented by its general partner Investindustrial Partners Limited,
having its registered office at 180-186 Brompton Road, 3
rd
floor, SW3 1HQ London, United Kingdom, registered in
London under number 01316019 (the Sole Shareholder),
here represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, Grand Duchy of Luxem-
bourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, representing the entire share capital of the Company,
has requested the undersigned notary to record that:
148474
L
U X E M B O U R G
I. The Company’s share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by one
hundred twenty-five thousand (125,000) shares with a nominal value of ten eurocents (EUR 0.10) each, all subscribed and
fully paid up.
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
(i) Waiver of convening notice;
(ii) Amendment of article 8.3 of the articles of association of the Company (the Articles); and
(iii) Miscellaneous.
III. The Meeting hereby takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notice require-
ments, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 8.3 of the Articles, which shall henceforth read as follows:
“ 8.3. Representation.
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by any manager, acting individually, under its/his/her sole
signature.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been
delegated in accordance with the provisions of article 8.1 (ii) above.”
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand two hundred euros (EUR
1,200.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing parties, he signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le neuf septembre.
par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Global Emergency Services S.à r.l., une
société à responsabilité limitée ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.798 et ayant un capital social de
EUR 12.500 (la Société).
La Société a été constituée suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, le 17 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Memorial)
numéro 262, page 12548, le 9 février 2011. Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas été modifiés depuis.
A COMPARU:
Investindustrial III L.P., un limited partnership du Royaume-Uni, ayant son siège social au 180-186 Brompton Road, 3
rd
floor, SW3 1HQ, Londres, immatriculé au United Kingdom Companies House sous le numéro LP10560, représenté par
son manager Investindustrial Advisors Limited, ayant son siège social à 180-186 Brompton Road, 3
rd
floor, SW3 1HQ,
Londres, Royaume-Uni enregistrée à Londres sous le numéro 01316019 (l’Associé Unique),
ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché
de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
148475
L
U X E M B O U R G
I. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500), représenté par cent
vingt-cinq mille (125.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de dix cents (EUR 0,10)
chacune.
II. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
(i) Renonciation aux formalités de convocation;
(ii) Modification de l’article 8.3 des statuts de la Société (les Statuts); et
(iii) Divers.
III. L’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l’Assemblée renonce aux formalités de convocation, l’Associé
Unique représenté à l’Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite
connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué à l’avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 8.3 des Statuts, lequel se lit désormais comme suit:
« 8.3. Représentation.
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toute circonstance par tout gérant, agissant individuellement sous sa
seule signature.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués conformément aux dispositions de l'article 8.1 (ii) ci-dessus.»
Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des parties com-
parantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux mandataires, lesdits mandataires ont signé avec le notaire instrumentant, le
présent acte.
Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 14 septembre 2015. Relation GAC/2015/7704. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015157947/114.
(150173998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.
Starlyst UK Investments Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SOF-10 Starlight 16 GBP S.à r.l.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 191.263.
In the year two thousand fifteen, on the seventeenth day of the month of September.
Before Us, Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. SOF-10 Starlight 15 GBP S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of Luxembourg and
having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, registered with the Registre du Commerce et
des Sociétés under number B 191.265,
here represented by Ben Brouscher, private employee, residing professionally at L-9242 Diekirch, 4 rue Alexis Heck,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on September 16
th
, 2015.
The proxy signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed
for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated above, is the sole shareholder of “SOF-10 Starlight 16 GBP S.à r.l.”, a société
à responsabilité limitée having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, established under the
laws of Luxembourg, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés of luxembourg under number B 191.263,
148476
L
U X E M B O U R G
incorporated by deed enacted by Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on October 16, 2014
published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on November 25, 2014 under number 3535. The
articles of incorporation have not been amended since.
The appearing party, represented as stated above, requested to the notary to enact that the agenda of the meeting is the
following:
<i>Agendai>
1. Amendment of the registered name of the Company, to be changed into “Starlyst UK Investments Lux S.à r.l”.
2. Amendment of Article 1 of the Articles of Association of the Company to reflect such action.
3. Miscellaneous.
Then the sole shareholder took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to change the name of the Company, from “SOF-10 Starlight 16 GBP S.à r.l.” into “Starlyst
UK Investments Lux S.à r.l.”.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder resolves to amend Article 1 of the Articles of Asso-
ciation, which will henceforth read as follows:
“ Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
“Starlyst UK Investments Lux S.à r.l.” (the “Company”), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular
by the law dated August 10, 1915 on commercial companies as amended (the “Company Law”) and by the present articles
of association (the “Articles”).”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result
of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).
There being no further business, the meeting was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Diekirch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, they signed together with us, the notary, the
present original deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois de septembre.
Par-devant Nous, Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
1. SOF-10 Starlight 15 GBP S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante sous les lois du Lu-
xembourg et ayant son siège au L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite auprès du Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro B 191.265,
ici représentée par Ben Brouscher, employé privé, demeurant professionnellement à L-9242 Diekirch, 4 rue Alexis Heck,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg le 16 septembre 2015.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie, représentée comme dit ci-avant, déclare être l'associée unique de la société à responsabilité limitée
«SOF-10 Starlight 16 GBP S.à r.l.» ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 191 263, constituée suivant acte reçu
pardevant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg en date du 16 Octobre 2014 publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 25 Novembre 2014 sous le numéro 3535. Les statuts de la société n'ont
pas été modifiés depuis.
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire d'acter comme suit que l'ordre du jour de
l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de la dénomination sociale de la société, à changer en «Starlyst UK Investments Lux S.à r.l.».
2. Modification de l'article 1 des statuts de la société en conséquence.
148477
L
U X E M B O U R G
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associée unique, ce dernier a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide de changer la dénomination sociale de la société, de «SOF-10 Starlight 16 GBP S.à r.l.» en
«Starlyst UK Investments Lux S.à r.l.».
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'associée unique décide de modifier l'article
1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Starlyst UK Invest-
ments Lux S.à r.l.» (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi») et par les présent statuts (les «Statuts»).»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200.-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: B. BROUSCHER, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 18 septembre 2015. Relation: DAC/2015/15551. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 24 septembre 2015.
Référence de publication: 2015158218/99.
(150174048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.
Logs Holdings Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 200.216.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of the month of September.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
German Holdings VIII S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 196.901 and having a
share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500),
represented by Mr François-Xavier Joyeux, juriste, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated
17
th
September 2015 which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company “Logs Holdings Topco S.à r.l.” (société à responsabilité limitée) which is
hereby established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Logs Holdings
Topco S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
148478
L
U X E M B O U R G
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.
The Company may further give guarantees (including up-stream and side-stream guarantees), grant security interests,
grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the
same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case
may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,
economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500)
represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25) each.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares
upon resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%)
of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business
of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
148479
L
U X E M B O U R G
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to
act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the
board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of
the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.
148480
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal
to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed
by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in
the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year, save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2015.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies;
in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Transitory dispositioni>
The first accounting year shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December 2015.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up in cash the following shares:
148481
L
U X E M B O U R G
Subscriber
Number
of shares
Subscription
price (EUR)
German Holdings VIII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12,500
Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles
of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
- BRE/Management 8 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at
35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Lu-
xembourg under number B 195.140.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,
the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the English
language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between
the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn am achtzehnten Tag des Monats September,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen,
German Holdings VIII S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxembur-
gischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünf-
hundert Euro (EUR 12.500) beträgt, und die im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der nummer B
196.901 eingetragen ist,
hier vertreten durch Herrn François-Xavier Joyeux, juriste, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-
schriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 17. September 2015, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei
der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungssatzung
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "Logs Holdings Topco S.à r.l." wie folgt zu
beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
"Logs Holdings Topco S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die
gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und
durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Ver-
waltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben (einschließlich up-stream als auch sidestream Bürgschaften), Sicherheiten
leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt
oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-
geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
148482
L
U X E M B O U R G
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder - Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-
liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und
alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-
denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
Dieser kann, durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die
Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende
solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung
auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölf tausend fünf
hundert euros (EUR 12.500), eingeteilt in fünf hundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfund-
zwanzig euro (EUR 25).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung
vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesellschaftsanteile
durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht
anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die
keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
148483
L
U X E M B O U R G
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen
Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder
einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“
und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder
(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder
von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
148484
L
U X E M B O U R G
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-
schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember
2015 enden.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich
nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
148485
L
U X E M B O U R G
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember 2015 enden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt
in bar eingezahlt und gezeichnet:
Einzahler
Zahl der
Geschäftsanteile
Einzahlungspreis
(EUR)
German Holdings VIII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.
<i>Außerordentliche Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
- BRE/Management 8 S.A. eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 35, avenue
Monterey, L-2163 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer
B 195.140.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen
Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: F.-X. JOYEUX, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/30207. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 25. September 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015158040/453.
(150174580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.
Saphilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2F, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 199.990.
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of September,
before Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Saphilux S.à r.l, a Luxembourg société à
responsabilité limitée, having its registered office at 2F Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy Lu-
xembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 199.990 and having
a share capital of EUR 12,500 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Martine
Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on September 7, 2015, in the process of publication in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since.
148486
L
U X E M B O U R G
THERE APPEARED:
FPCI (fonds professionnel de capital investissement) Astorg V, represented by its management company Astorg Part-
ners, a French société par actions simplifiée, with a share capital of EUR 675,000, whose registered office is at 68 rue du
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, registered with the registre du commerce et des sociétés of Paris under number 419
838 545 (the Sole Shareholder),
duly represented by Peggy Simon, employee, with professional address in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a
proxy given under private seal.
The proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present
deed for the purpose of the registration formalities.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:
I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Amendment of the articles of association of the Company (the Articles) in order to add an English version of the
Articles;
2. Miscellaneous.
III. The Sole Shareholder resolves to take the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the Articles in order to add an English version thereto, without any change to
the existing French version of the Articles (which will be reflected in the French version of the present deed), so that they
read henceforth as follows:
I. “Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “Saphilux S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law
of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. If the Board determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary
measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
148487
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five
hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior
approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
Transfer of shares to third parties following the death of a shareholder is subject to prior approval by shareholders
representing at least three-quarters of the share capital.
A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.3. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose or the
redemption results from a reduction in the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
7.3. The sole shareholder or the shareholders, as the case may be, may decide to appoint managers of two different
classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B managers.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which
in principle shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have
full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the
meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented.
(vi) Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has
been appointed, by all the managers present or represented.
(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
148488
L
U X E M B O U R G
(viii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) Subject to article 8.3 (iii), the Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of
any two (2) managers.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
(iii) Where different classes of managers have been appointed, the Company shall be bound towards third parties in all
matters by the joint signatures of any class A manager and any class B manager.
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the managers or any
manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
9.2. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the sole manager.
9.3. The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the sole manager.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting) or
in writing by circular shareholders' resolutions (Written Shareholders' Resolutions).
(ii) If the resolutions are adopted by Written Shareholders' Resolutions, the text of the resolutions is communicated to
all the shareholder in accordance with the Articles. Written Shareholders Resolutions signed by all the shareholders are
valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings or consulted in writing following a request from any manager
or from shareholders representing one half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.
(iii) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to
be represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by Written Shareholders' Resolutions, shall be passed by share-
holders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or written
consultation, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall
be adopted at the second General Meeting or written consultation by a majority of the votes cast, irrespective of the
proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder shall exercise all powers granted by
the Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
148489
L
U X E M B O U R G
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
owed by its managers and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders'
Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d'entreprises agréés).
14.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration
and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal
Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the
distribution of an interim dividend; and
(v) If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must
refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Com-
pany's assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.
148490
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le dix-huitième jour de septembre,
par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Saphilux S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 2F, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199.990 et
disposant d'un capital social de EUR 12.500 (la Société). La Société a été constituée suivant un acte de Maître Martine
Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 7 septembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont jamais été modifiés depuis.
A COMPARU:
FPCI (fonds professionnel de capital investissement) Astorg V, représenté par sa société de gestion Astorg Partners,
une société par actions simplifiée de droit français, disposant d'un capital social de EUR 675.000, dont le siège social se
situe au 68 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous
le numéro 419 838 545 (l'Associé Unique),
dûment représentée par Peggy Simon, employée, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Modification des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y ajouter une version anglaise;
2. Divers.
III. L'Associé Unique décide de prendre la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Associé Unique décide de modifier les Statuts afin d'y ajouter une version anglaise, sans modification de la version
française des Statuts en vigueur reproduite ci-dessous:
«I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est “Saphilux S.àr.l.” (la Société). La Société est une société à respon-
sabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut
être transféré dans la commune par décision des gérants. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique
ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à compromettre
les activités normales de la Société au lieu de son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger,
le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures
provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise,
ainsi que la gestion de ces participations, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. La Société peut notamment
acquérir, par voie de souscription, achat et échange ou de toute autre manière, tout titre de participation, part sociale, action
ou autre valeur mobilière, obligations, créances, bons, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus générale-
ment, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au
148491
L
U X E M B O U R G
développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et
la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres et obligations et de tout autre instrument financier de toute
nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées
ou à toute autre société. La Société peut également consentir des sûretés, gager, nantir, céder, grever de charges ou de toute
autre manière créer et accorder des garanties sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles
de toute autre société et, de manière générale, pour son propre bénéfice ou celui de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut exercer aucune activité réglementée relevant du secteur financier sans avoir obtenu d'au-
torisation préalable à cet effet.
3.3. La Société peut faire usage de toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses inves-
tissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires et de taux d'intérêt et tout autre risque.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze cinq cents (12.500)
parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable
des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-quarts
des droits détenus par les survivants.
Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes
à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants peuvent ne pas être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
7.3. L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de Catégorie A et un ou
plusieurs gérants de Catégorie B.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,
qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
148492
L
U X E M B O U R G
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures
à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir
parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une
réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions
se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.
(vi) Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun
président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.
(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) Sous réserve de l'article 8.3 (iii), la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures
conjointes de deux (2) gérants.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
(iii) Si l'associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou plusieurs gérants de
Catégorie B, la Société sera engagée, visà-vis des tiers, par la signature conjointe d'un gérant de Catégorie A et d'un gérant
de Catégorie B.
Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les
associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement
convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans
la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
148493
L
U X E M B O U R G
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale
ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale
ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des
Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-
quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la
Loi à l'Assemblée Générale.
12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions
Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.
Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la
loi.
14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la
durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants
sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,
les associés doivent reverser l'excès à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié des associés
détenant les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être
associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des
associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
148494
L
U X E M B O U R G
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, email
ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Résolutions
Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui
ensemble, constituent un seul et unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.”
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte
en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 22 septembre 2015. Relation: GAC/2015/8061. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): N. DIEDERICH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 24 septembre 2015.
Référence de publication: 2015158180/472.
(150174642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.
Shire Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 605.016,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 181.573.
In the year two thousand and fifteen, on the fourteenth day of September.
Before Maître Jacques Kesseler, notary residing at Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held
an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Shire Luxembourg Finance S.à r.l.", a "société à respon-
sabilité limitée" incorporated under Luxembourg law, having its registered office at 7A, rue Robert Stumper, L-2557
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number
B.181.573 (the “Company”), incorporated by a notarial deed enacted on 5 November 2013, published in the “Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations” number 3275 dated 24 December 2013 and lastly amended by a deed enacted on 18
December 2014, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 614 dated 5 March 2015.
The meeting is presided by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, residing professionally in Pétange, Grand-
Duchy of Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Ms. Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange, Grand-
Duchy of Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Ms. Laetitia ZUANEL, private employee, residing professionally in Pétange, Grand-
Duchy of Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder of the Company, Shire Ireland Finance Limited, a company incorporated under Irish law, having
its registered office at 5, Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland, acting through its Luxembourg branch,
Shire Ireland Finance Limited, Luxembourg Branch, having its registered address at 7A, rue Robert Stumper, L-2557
Luxembourg, duly represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy given under private
seal, (the “Sole Shareholder” or the “Subscriber”) and the number of shares held by it is shown on an attendance list. That
list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.
II. - As it appears from the attendance list, the 605,014 (six hundred five thousand fourteen) shares with a nominal value
of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that
the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.
148495
L
U X E M B O U R G
III. - The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Approval of the increase of the share capital of the Company by an amount of USD 2 (two United States Dollars) so
as to increase it from its current amount of USD 605,014 (six hundred five thousand fourteen United States Dollars) to an
amount of USD 605,016 (six hundred five thousand sixteen United States Dollars) by the issuance of 2 (two) mandatory
redeemable preferred shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, subject to the payment of a
global share premium amounting to USD 91,949,647 (ninety-one million nine hundred forty-nine thousand six hundred
forty-seven United States Dollars), to be allocated to the mandatory redeemable preferred share premium account of the
Company, the whole to be fully paid up through a contribution in kind;
3. Subscription and payment by Shire Ireland Finance Limited, acting through Shire Ireland Finance Limited, Luxem-
bourg Branch, of the new mandatory redeemable preferred shares by way of a contribution in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Approval of the subsequent amendment of the first paragraph of article eight of the articles of association of the
Company pursuant to the above resolutions; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to notice of the extraordinary general meeting, which should
have been sent to it prior to this meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda
and considers the extraordinary general meeting to be validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon
all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the
disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 2 (two United States Dollars) (the
“Capital Increase”) so as to raise it from its current amount of USD 605,014 (six hundred five thousand fourteen United
States Dollars) to USD 605,016 (six hundred five thousand sixteen United States Dollars) by the issuance of 2 (two)
mandatory redeemable preferred shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the “MRPS”), as
permitted by article eight of the articles of association of the Company, subject to the payment of a global share premium
amounting to USD 91,949,647 (ninety-one million nine hundred forty-nine thousand six hundred forty-seven United States
Dollars) (the “MRPS Premium”), to be allocated to the mandatory redeemable preferred share premium account of the
Company (the “MRPS Premium Account”), the whole to be fully paid up through a contribution in kind (the “Contribution”)
of a claim held by the Sole Shareholder of an amount of USD USD 91,949,649 (ninety-one million nine hundred forty-
nine thousand six hundred forty-nine United States Dollars) (the “Claim”).
<i>Third resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and the payment for the MRPS and the MRPS Premium by the Sole Shareholder,
through the Contribution of the Claim.
<i>Subscriber's Intervention - Subscription - Payment:i>
Thereupon intervenes the Subscriber, here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed. The Subscriber
declares to subscribe for the MRPS, subject to the payment of the MRPS Premium, through the Contribution.
<i>Evaluation:i>
The total value of the Contribution to be made by the Sole Shareholder to the Company amounts globally to USD
91,949,649 (ninety-one million nine hundred forty-nine thousand six hundred forty-nine United States Dollars) and will
be allocated as follows:
- USD 2 (two United States Dollars) to the share capital; and
- USD 91,949,647 (ninety-one million nine hundred forty-nine thousand six hundred forty-seven United States Dollars)
to the MRPS Premium Account.
This valuation has been approved by the managers of the Company, pursuant to a statement of contribution value dated
14 September 2015, whereby the managers of the Company acknowledge their responsibility as managers in the case of a
capital increase. This statement of contribution value shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the
formality of registration.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statement and resolutions, the shareholding of the Company will be composed of:
148496
L
U X E M B O U R G
Shire Ireland Finance Limited acting through its Luxembourg branch, Shire Ireland Finance Limited, Luxembourg
Branch, for (i) 605,000 (six hundred five thousand) ordinary shares with a nominal value of USD 1 (one United States
Dollar) each and (ii) 16 (sixteen) MRPS with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statement and resolutions, it is resolved to amend the first paragraph of article eight
of the Articles to be read as follows:
“ Art. 8. The Company's share capital is set at USD 605,016 (six hundred five thousand sixteen United States Dollars)
represented by 605,000 (six hundred five thousand) ordinary shares with a nominal value of USD 1 (one United States
Dollar) each (the “Ordinary Shares”) and 16 (sixteen) MRPS with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar)
each.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le quatorzième jour septembre.
Par devant Maître Jacques Kesseler, notaire résidant à Pètange, Grand-duché de Luxembourg, soussigné.
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire des associés de «Shire Luxembourg Finance S.à r.l.», une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181.573
(la «Société»), constituée par acte notarié le 5 novembre 2013, dont les statuts ont été publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 3275, en date du 24 décembre 2013 et dernièrement modifié par un acte reçu le 18
décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 614 du 05 mars 2015.
L'assemblée est présidée par Mme. Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, résidant professionnellement à
Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mme. Marisa GOMES, employée privée, résidant professionnellement à Pétange,
Grand-Duché de Luxembourg et l'assemblée désigne comme scrutateur Mme. Laetitia ZUANEL, employée privée, résidant
professionnellement à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg
Le président a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I.- L'associé unique de la Société, Shire Ireland Finance Limited, une société constituée selon le droit irlandais, ayant
son siège social au 5, Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlande, agissant à travers sa succursale luxem-
bourgeoise Shire Ireland Finance Limited, Luxembourg Branch, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557
Luxembourg (l'«Associé Unique» ou le «Souscripteur»), dûment représentée par Mme. Sofia Afonso-Da Chao Conde,
prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé et le nombre de parts détenues décrit sur la liste de présence.
Cette liste de présence et ladite procuration, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire agissant au nom des
parties comparantes et le notaire instrumentaire, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec
celui-ci.
II.- Il ressort de la liste de présence, que les 605.014 (six cent cinq mille quatorze) parts sociales de 1 USD (un Dollar
Américain) chacune représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée
peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, et dont l'Associé Unique déclare expressément
avoir été dûment informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 2 USD (deux Dollars Américains) afin de le porter de
son montant actuel de 605.014 USD (six cent cinq mille quatorze Dollars Américains) à 605.016 USD (six cent cinq mille
seize Dollars Américains) par l'émission de 2 actions préférentielles avec rachat obligatoire de la Société d'une valeur
nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, soumis au paiement d'une prime d'émission d'un montant de 91.949.647
USD (quatre-vingt-onze millions neuf cent quarante-neuf mille six cent quarante-sept Dollars Américains), devant être
alloué au compte de prime d'émission d'actions préférentielles avec rachat obligatoire de la Société, l'ensemble devant être
entièrement libéré par un apport en nature;
148497
L
U X E M B O U R G
3. Souscription et paiement par Shire Ireland Finance Limited, agissant à travers Shire Ireland Finance Limited, Lu-
xembourg Branch des nouvelles actions préférentielles avec rachat obligatoire de la Société au moyen d'un apport en nature;
4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente de l'article 8, paragraphe 1 des statuts de la Société en conséquence des résolutions qui
précèdent; et
6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée
générale; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère être valablement con-
voqué à la présente assemblée générale extraordinaire et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points
portés à l'ordre du jour. De plus il est décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition
l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 2 USD (deux Dollars Américains) (l'«Augmen-
tation de Capital»), afin de le porter de son montant actuel de 605.014 USD (six cent cinq mille quatorze Dollars Américains)
à 605.016 USD (six cent cinq mille seize Dollars Américains) par l'émission de 2 actions préférentielles avec rachat
obligatoire d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune (les «APRO»), tel qu'autorisé par l'Article 8
des statuts de la Société, soumis au paiement d'une prime d'émission d'un montant de 91.949.647 USD (quatre-vingt-onze
millions neuf cent quarante-neuf mille six cent quarante-sept Dollars Américains) (la «Prime d'Emission APRO»), devant
être allouée au compte de prime d'émission des actions préférentielles avec rachat obligatoire de la Société (le «Compte
de Prime APRO»), le tout devant être entièrement libéré par un apport en nature (l'«Apport») consistant en une créance
détenue par l'Associé Unique d'un montant de 91.949.649 USD (quatre-vingt-onze millions neuf cent quarante-neuf mille
six cent quarante-neuf Dollars Américains) (la «Créance»).
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement des APRO et du Compte d'émission APRO par l'Associé Unique
par l'Apport de la Créance.
<i>Intervention du Souscripteur - Souscription - Paiementi>
Intervient alors le Souscripteur, ici représenté par Mme. Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée. Le Souscripteur déclare
souscrire aux APRO, moyennant le paiement de la Prime d'Emission APRO au moyen de l'Apport.
<i>Evaluationi>
La valeur totale de l'Apport réalisé par l'Associé Unique à la Société s'élève à un montant global de 91.949.649 USD
(quatre-vingt-onze millions neuf cent quarante-neuf mille six cent quarante-neuf Dollars Américains) qui seront alloué
comme suit:
- 2 USD (deux Dollars Américains) au capital social; et
- de 91.949.647 USD (quatre-vingt-onze millions neuf cent quarante-neuf mille six cent quarante-sept Dollars Améri-
cains) au Compte de Prime APRO;
Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport
en date du 14 septembre 2015, dans laquelle les gérants reconnaissent leur responsabilité en tant que gérants en cas d'aug-
mentation de capital. Cette déclaration sur la valeur de l'apport restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec
lui.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'actionnariat de la Société sera composée de:
Shire Ireland Finance Limited agissant à travers sa succursale luxembourgeoise Shire Ireland Finance Limited, Luxem-
bourg Branch, avec (i) 605.000 (six cent cinq mille) actions ordinaire d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain)
chacune et (ii) 16 (seize) APRO d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune.
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l'Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de
modifier l'article 8, paragraphe 1 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 605.016 USD (six cent cinq mille seize Dollars Américains), représenté
par 605.000 (six cent cinq mille Dollars Américains) actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar amé-
ricain) chacune (les «Actions Ordinaires») et 16 (seize) APRO d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain)
chacune».
148498
L
U X E M B O U R G
Aucun autre point n'ayant été soulevé, l'assemblée a été clôturée.
A la suite de quoi, le présent acte notarié a été fait et passé à Pétange, au même jour qu'indiqué en tête.
Lecture ayant été faite de ce document aux personnes présentes, elles ont signé avec nous, notaire, l'original du présent
acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la personne présente à l'assemblée, le
présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: Conde, Gomes, Zuanel, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 septembre 2015. Relation: EAC/2015/21195. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015158188/206.
(150173994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.
TrefilARBED Grembergen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 24-26, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 6.215.
Le Conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la société du 19, avenue de la Liberté, L-2930
Luxembourg, au 24-26, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, avec date d'effet au 24 septembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 25 septembre 2015.
Référence de publication: 2015159002/11.
(150174793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.
Anetorre SOCIMI Holdo S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Tin Investment S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 196.599.
In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth day of September.
Before Us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared
Anetorre Holdco S.à r. l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade and companies’ register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number
B192.908 and having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500);
represented by Me François-Xavier Joyeux, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy
dated 17 September 2015 which after having been signed ne varietur shall remain attached to the present deed to be
submitted together with it to the registration formalities,
being the sole shareholder of Tin Investment S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée),
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg and being registered with the Luxembourg trade and companies’ register (Registre de Commerce et
des Sociétés) under number B196.599 (the “Company”), incorporated by a deed of Maître Cosita Delvaux, notary residing
in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 29 April 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the "Mémorial") on 7 July 2015 number 1677.
The appearing party, represented as stated above, declared and the notary recorded as follows:
I. That the appearing party is the sole shareholder of the Company and holds the five hundred (500) shares with a par
value of twenty-five Euros (EUR 25) each in issue in the Company so that the entire share capital is represented and
decisions can be validly taken by the sole shareholder.
II. That the sole shareholder wishes to take a decision on the following item of the agenda:
- Change of the name of the Company into “Anetorre SOCIMI Holdco S.à r.l.” and consequential amendment of Article
1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
148499
L
U X E M B O U R G
“ Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Anetorre SOCIMI
Holdco S.à r.l." (the "Company") is existing among the subscribers and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.”
After the foregoing was approved by the sole shareholder, it took the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The sole shareholder resolved to change the name of the Company into “Anetorre SOCIMI Holdco S.à r.l.” and to
consequentially amend Article 1 of the articles of the Company as follows:
“ Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Anetorre SOCIMI
Holdco S.à r.l." (the "Company") is existing among the subscribers and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation”.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of this amendment to the articles of association are estimated at approximately EUR 1,600.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party the present deed is worded in English followed by and German translation. On request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by its name, first name,
civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am Siebzehnten Tag des Monats September.
Vor dem Notar Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen
Anetorre Holdco S.à r. l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) errichtet und
bestehend unter luxemburgischen Recht, mit Sitz in der 2-4, rue Eugène Ruppert, L.2453 Luxemburg, eingetragen im
Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer B 192.908 und mit einem Gesellschaftskapital
von zwölftausendfünfhundert Euro (12,500 EUR),
hier vertreten durch Herr François-Xavier Joyeux, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer
Vollmacht vom 17. September 2015, welche nach Unterzeichnung ne varietur der Urkunde beigefügt sein wird, um mit
dieser Urkunde bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden,
als Alleiniger Gesellschafter der Tin Investment S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, und
eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer B196.599 (die „Gesellschaft“),
gegründet am 29. April 2014 durch Urkunde des Notar Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, veröffentlicht am 7 Juli 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“), unter
Nummer 1677.
Die erschienene Partei, wie oben dargestellt vertreten, erklärte und ersuchte den Notar folgendes zu beurkunden:
I. Die erschienene Partei ist der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft und hält fünfhundert (500) ausgegebenen
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR25), so dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist,
und rechtsgültig über alle Punkte der Tagessordnung entschieden werden kann:
II. Der Punkt über den ein Beschluss getroffen werden soll ist der folgende:
- Änderung des Namens der Gesellschaft in „Anetorre SOCIMI Holdco S.à r.l.“ und folgliche Änderung des Artikels 1
der Satzung der Gesellschaft, welches wie folgt lauten soll:
„ Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem
Namen „Anetorre SOCIMI Holdco S.à r.l." (die „Gesellschaft") besteht zwischen den Ausstellern und allen Personen, die
gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die
entsprechende Gesetzgebung geregelt.“
Danach wurde der folgende Beschluss vom Alleinigen Gesellschafter getroffen:
<i>Alleiniger Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschloss, den Namen der Gesellschaft in „Anetorre SOCIMI Holdco S.à r.l.“ abzuändern
und den Artikel 1 der Satzung wie folgt abzuändern:
„ Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem
Namen „Anetorre SOCIMI Holdco S.à r.l." (die „Gesellschaft") besteht zwischen den Ausstellern und allen Personen, die
148500
L
U X E M B O U R G
gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die
entsprechende Gesetzgebung geregelt.“
<i>Kosten, Schätzungi>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Satzungsänderung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.600.- geschätzt.
Worüber die vorliegende Urkunde an oben bezeichnetem Tag in Luxemburg niedergeschrieben wurde.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei,
diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Auf Ersuchen der
vorgenannten Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische
Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung des Dokuments an dem Bevollmächtigen der erschienenen Partei, die dem Notar nach ihrem Nachna-
men, Vornamen, Zivilzustand und Wohnsitz bekannt ist, haben dieser Bevollmächtigte und der Notar diese Urkunde
zusammen unterzeichnet.
Gezeichnet: F. X. JOYEUX, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/29891. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 24. September 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015158237/105.
(150174335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.
Parker Hannifin Partnership S.C.S., Société en Commandite simple.
Siège social: L-2182 Luxembourg, 2, rue Gerhard Mercator.
R.C.S. Luxembourg B 158.172.
In the year two thousand and fifteen, on the fourteen day of September.
Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange (Grand-Duchy of Luxembourg)
There appeared,
(i) PARKER HANNIFIN PARTNER I GP, a general partnership formed pursuant to the laws of Bermuda, with registered
office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda, here represented by Maître Nathalie Houllé,
attorney at law with professional residence in Howald (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy issued under
private signature;
(ii) PARKER HANNIFIN PARTNER II GP, a general partnership formed pursuant to the laws of Bermuda, with
registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda, here represented by Maître Nathalie
Houllé, attorney at law with professional residence in Howald (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy issued
under private signature; and
(iii) PARKER HANNIFIN (BERLUX) Ltd., an exempted company incorporated with limited liability organised under
the laws of Bermuda, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, re-
gistered with the Bermuda Registrar of Companies under number 45527, here represented by Maître Nathalie Houllé,
attorney at law with professional residence in Howald (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy issued under
private signature.
The proxies having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and by the
undersigned notary shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The prenamed are all the partners in PARKER HANNIFIN PARTNERSHIP S.C.S., société en commandite simple
having its registered office at 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under number 158.172, incorporated on December 1
st
, 2010 by deed of Maître Francis KESSELER,
published in the Mémorial C number 666 on April 7, 2011 (the “Partnership”). The articles of association of the Partnership
have been amended for the last time by deed of the undersigned notary dated September 9, 2014, published in the Mémorial
C number 3156 on October 29, 2014.
Which appearing parties, represented as mentioned above, requested the undersigned notary to draw up the following:
I. That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
148501
L
U X E M B O U R G
<i>Agendai>
1) In the definitions section of the articles of association of the Partnership, amendment of the following defined term
so as to read:
“Subsidiary Sharing Percentages” means the percentages in which each Partner shares in the Subsidiary Profits and
Losses of the respective Subsidiaries as set forth hereafter:
Name
Country
PH
Partner
I
PH
Partner
II
General
Partner
Olaer Fawcett Christie Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Olaer Italiana SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italy
5%
95%
0%
Parker Hannifin Holding EMEA S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lux
5%
95%
0%
Parker Hannifin Europe S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lux
95%
5%
0%
Parker Hannifin Lux Finco S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lux
95%
5%
0%
Parker Hannifin Europe Sarl, Luxembourg, Switzerland Branch,
Etoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CH
95%
5%
0%
Parker Hannifin Lux Finco LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US
95%
5%
0%
Parker Hannifin Holding EMEA LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US
5%
95%
0%
Parker Hannifin (Luxembourg) Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lux
95%
5%
0%
Parker International Capital Management Hungary Limited Liability
Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hungary
95%
5%
0%
Parker Hannifin France Finance SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France
95%
5%
0%
Parker Hannifin 2007 UK LLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
95%
5%
0%
Parker Hannifin (Gibraltar) Lux Finco Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gibraltar
95%
5%
0%
Parker Hannifin (Gibraltar) Luxembourg Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gibraltar
95%
5%
0%
Parker Hannifin GesmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Austria
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Austria GesmbH . . . . . . . . . . . Austria
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Austria GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Austria
5%
95%
0%
Parker Hannifin GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Germany
5%
95%
0%
Parker Hannifin Holding GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Germany
5%
95%
0%
Parker Hannifin BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
Parker Hannifin BeLux SPRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgium
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Belgium SPRL . . . . . . . . . . . . Belgium
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Belgium BVBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgium
5%
95%
0%
Parker Canada Holding Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada
5%
95%
0%
Parker Canada Investment Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada
5%
95%
0%
Parker Ontario Holding Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada
5%
95%
0%
Parker Hannifin Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada
5%
95%
0%
Parker Hannifin Italy srl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italy
5%
95%
0%
Parker Hannifin Czech Republic s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czech
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Czech Republic s.r.o. . . . . . . . . Czech
5%
95%
0%
Parker Hannifin Industrial s.r.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czech
5%
95%
0%
Parker-Hannifin s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czech
5%
95%
0%
Parker Hannifin Danmark ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denmark
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Denmark ApS . . . . . . . . . . . . . Denmark
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Denmark ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denmark
5%
95%
0%
Parker Middle East FZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubai
5%
95%
0%
Parker Italy (PH Espana Holding) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US
5%
95%
0%
Parker Hannifin Industries & Assets Holding S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Spain
5%
95%
0%
Parker Hannifin Espana S.L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spain
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Finland OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finland
5%
95%
0%
Parker Hannifin OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finland
5%
95%
0%
Parker Hannifin France Holding SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Parker Hannifin France SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing France SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Olaer Industries Sarl (merged February 1, 2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
148502
L
U X E M B O U R G
Olaer Manufacturing SAS (merged February 1, 2015) . . . . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Parker Hannifin Verwaltungs-GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Germany
5%
95%
0%
Parker Hannifin Gebaeudeverwaltung eins GmbH & Co. KG . . . . . . . . . Germany
5%
95%
0%
Parker Hannifin Gebaeudeverwaltung zwei GmbH & Co. KG . . . . . . . . Germany
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . Germany
5%
95%
0%
Warner Lewis GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Germany
5%
95%
0%
Parker Sales (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ireland
5%
95%
0%
Parker Hannifin Israel Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israel
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Italy srl . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italy
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing srl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italy
5%
95%
0%
VFP Limitada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mozambique
5%
95%
0%
Parker Hannifin VAS Netherlands B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration) B.V. . . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Hose) B.V. . . . . . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration and Separation)
B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netherlands
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Pneumatic) B.V. . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Polyflex) B.V. . . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
GSF Beheer B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
GSF Europe B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
GSF Kunststoffen B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
Twin Filter BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
Parker Hannifin (Norway) Holding A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
5%
95%
0%
Parker Hannifin AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
5%
95%
0%
Parker ScanRope AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
5%
95%
0%
Parker Maritime AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
5%
95%
0%
Parker Hannifin VAS Norway AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
5%
95%
0%
Parker Hannifin Sales Poland Sp z.o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poland
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Poland Sp Z.o.o. . . . . . . . . . . . Poland
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Poland Sp Z.o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poland
5%
95%
0%
Parker Hannifin Portugal Unipessoal LDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal
5%
95%
0%
Parker Hannifin (Africa) Pty. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. Africa
5%
95%
0%
VFP Fueling Pty. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. Africa
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Spain SL . . . . . . . . . . . . . . . . . Spain
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Spain SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spain
5%
95%
0%
Parker Hannifin Aktiebolag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sweden
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sweden
5%
95%
0%
Parker Iklim Kontrol Sistemieri san. Ve Tic. A.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turkey
5%
95%
0%
Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Sirket . . . . . . . . . . . . . . . Turkey
5%
95%
0%
Parker Hannifin Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Commercial Hydraulics Pensions Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing (UK) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Parker Hannifin (Holdings) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Parker Hannifin Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Alenco (Holdings) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Parker Hannifin (GB) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Kittiwake Procal Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Kittiwake Developments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Kittiwake Holroyd Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
PpTek Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
2) Amendment of the articles of association of the Partnership as follows, in part, to ratify and confirm that the General
Partner(s)' exercise of discretion in prior years pursuant to the parties' agreement and provide additional clarity on such
matters in the articles of association.
3) Amendment of the Article 15.2(b) so as to read:
148503
L
U X E M B O U R G
“Payments between Subsidiaries that are taken into account for purposes of determining Subsidiary Profits and Losses
shall be deemed to be made for United States federal income tax purposes from gross income (excluding income from
dividends or similar distributions) of the Paying Subsidiary. In the event that the paying Subsidiary has insufficient gross
income to support such allocation, the General Partner(s) shall, consistent with its prior exercise of discretion under Section
15.4(a), deem such payments to be made for United States federal income tax purposes from gross income of the Partnership
(excluding income from dividends or similar distributions) attributable to another Subsidiary created or organized in the
same country as the Paying Subsidiary.”
4) Amendment of the Article 15.3 (i) so as to read:
“Foreign Income Tax Expense shall be allocated to the Partners as follows. The General Partner(s) shall treat Subsidiary
Profits and Losses for each Subsidiary as a separate category of Partnership net income to which Foreign Income Tax
Expense is allocated (each, a “CFTE Category”); provided, however, that in the case of any group of Subsidiaries subject
to foreign income tax on a combined basis within the meaning of Regulations Section 1.901-2(f)(3), the General Partner
(s) shall treat, consistent with its past practice, the Profits and Losses of the Partnership attributable to such Subsidiaries
as a single CFTE Category. The General Partner(s) shall make appropriate adjustments to the CFTE Category for items of
Profit and Loss not recognized for foreign tax purposes to prevent separating Foreign Income Tax Expense from the related
foreign income.”
II. That the extraordinary general meeting of the Partnership has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of the Partnership unanimously resolved to amend, in the definitions section of the articles of
association of the Partnership, the following defined term so as to read:
“Subsidiary Sharing Percentages” means the percentages in which each Partner shares in the Subsidiary Profits and
Losses of the respective Subsidiaries as set forth hereafter:
Name
Country
PH
Partner
I
PH
Partner
II
General
Partner
Olaer Fawcett Christie Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Olaer Italiana SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italy
5%
95%
0%
Parker Hannifin Holding EMEA S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lux
5%
95%
0%
Parker Hannifin Europe S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lux
95%
5%
0%
Parker Hannifin Lux Finco S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lux
95%
5%
0%
Parker Hannifin Europe Sarl, Luxembourg, Switzerland Branch,
Etoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CH
95%
5%
0%
Parker Hannifin Lux Finco LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US
95%
5%
0%
Parker Hannifin Holding EMEA LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US
5%
95%
0%
Parker Hannifin (Luxembourg) Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lux
95%
5%
0%
Parker International Capital Management Hungary Limited Liability
Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hungary
95%
5%
0%
Parker Hannifin France Finance SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France
95%
5%
0%
Parker Hannifin 2007 UK LLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
95%
5%
0%
Parker Hannifin (Gibraltar) Lux Finco Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gibraltar
95%
5%
0%
Parker Hannifin (Gibraltar) Luxembourg Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gibraltar
95%
5%
0%
Parker Hannifin GesmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Austria
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Austria GesmbH . . . . . . . . . . . Austria
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Austria GmbH (FKA Parker Origa
Pneumatic GmbH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Austria
5%
95%
0%
Parker Hannifin GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Germany
5%
95%
0%
Parker Hannifin Holding GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Germany
5%
95%
0%
Parker Hannifin BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
Parker Hannifin BeLux SPRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgium
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Belgium SPRL . . . . . . . . . . . . Belgium
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Belgium BVBA (FKA Advanced
Products BVBA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgium
5%
95%
0%
Parker Canada Holding Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada
5%
95%
0%
Parker Canada Investment Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada
5%
95%
0%
Parker Ontario Holding Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada
5%
95%
0%
Parker Hannifin Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada
5%
95%
0%
148504
L
U X E M B O U R G
Parker Hannifin Italy srl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italy
5%
95%
0%
Parker Hannifin Czech Republic s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czech
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Czech Republic s.r.o. . . . . . . . . Czech
5%
95%
0%
Parker Hannifin Industrial s.r.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czech
5%
95%
0%
Parker-Hannifin s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czech
5%
95%
0%
Parker Hannifin Danmark ApS (FKA Parker Hannifin Sales Aps) . . . . . Denmark
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Denmark ApS . . . . . . . . . . . . . Denmark
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Denmark ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denmark
5%
95%
0%
Parker Middle East FZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubai
5%
95%
0%
Parker Italy (PH Espana Holding) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US
5%
95%
0%
Parker Hannifin Industries & Assets Holding S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Spain
5%
95%
0%
Parker Hannifin Espana S.L. (FKA Parker Hannifin Espana S.A.) . . . . . Spain
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Finland OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finland
5%
95%
0%
Parker Hannifin OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finland
5%
95%
0%
Parker Hannifin France Holding SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Parker Hannifin France SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing France SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Olaer Industries Sarl (merged February 1, 2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Olaer Manufacturing SAS (merged February 1, 2015) . . . . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Parker Hannifin Verwaltungs-GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Germany
5%
95%
0%
Parker Hannifin Gebaeudeverwaltung eins GmbH & Co. KG . . . . . . . . . Germany
5%
95%
0%
Parker Hannifin Gebaeudeverwaltung zwei GmbH & Co. KG . . . . . . . . Germany
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . Germany
5%
95%
0%
Warner Lewis GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Germany
5%
95%
0%
Parker Sales (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ireland
5%
95%
0%
Parker Hannifin Israel Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israel
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Italy srl . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italy
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing srl (FKA Parker ITR srl) . . . . . . . . . . . . Italy
5%
95%
0%
VFP Limitada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mozambique
5%
95%
0%
Parker Hannifin VAS Netherlands B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration) B.V. . . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Hose) B.V. . . . . . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration and Separation)
B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netherlands
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Pneumatic) B.V. . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Polyflex) B.V. . . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
GSF Beheer B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
GSF Europe B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
GSF Kunststoffen B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
Twin Filter BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Netherlands
5%
95%
0%
Parker Hannifin (Norway) Holding A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
5%
95%
0%
Parker Hannifin AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
5%
95%
0%
Parker ScanRope AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
5%
95%
0%
Parker Maritime AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
5%
95%
0%
Parker Hannifin VAS Norway AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
5%
95%
0%
Parker Hannifin Sales Poland Sp z.o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poland
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Poland Sp Z.o.o. . . . . . . . . . . . Poland
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Poland Sp Z.o.o.
(FKA Parker Hannifin Sp Z.o.o.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poland
5%
95%
0%
Parker Hannifin Portugal Unipessoal LDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal
5%
95%
0%
Parker Hannifin (Africa) Pty. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. Africa
5%
95%
0%
VFP Fueling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. Africa
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Spain SL . . . . . . . . . . . . . . . . . Spain
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Spain SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spain
5%
95%
0%
Parker Hannifin Aktiebolag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sweden
5%
95%
0%
148505
L
U X E M B O U R G
Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sweden
5%
95%
0%
Parker lklim Kontrol Sistemieri san. Ve Tic. A.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turkey
5%
95%
0%
Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Sirket . . . . . . . . . . . . . . . Turkey
5%
95%
0%
Parker Hannifin Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Commercial Hydraulics Pensions Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing (UK) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Parker Hannifin (Holdings) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Parker Hannifin Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Alenco (Holdings) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Parker Hannifin (GB) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Kittiwake Procal Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Kittiwake Developments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Kittiwake Holroyd Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
PpTek Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
<i>Second resolutioni>
The general meeting of the Partnership unanimously resolved to amend the articles of association of the Partnership in
part, to ratify and confirm that the General Partner(s)' exercise of discretion in prior years pursuant to the parties' agreement
and provide additional clarity on such matters in the articles of association.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of the Partnership unanimously resolved to amend Article 15.2(b) so as to read:
“Payments between Subsidiaries that are taken into account for purposes of determining Subsidiary Profits and Losses
shall be deemed to be made for United States federal income tax purposes from gross income (excluding income from
dividends or similar distributions) of the Paying Subsidiary. In the event that the paying Subsidiary has insufficient gross
income to support such allocation, the General Partner(s) shall, consistent with its prior exercise of discretion under Section
15.4(a), deem such payments to be made for United States federal income tax purposes from gross income of the Partnership
(excluding income from dividends or similar distributions) attributable to another Subsidiary created or organized in the
same country as the Paying Subsidiary.”
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of the Partnership unanimously resolved to amend Article 15.3 (i) so as to read:
“Foreign Income Tax Expense shall be allocated to the Partners as follows. The General Partner(s) shall treat Subsidiary
Profits and Losses for each Subsidiary as a separate category of Partnership net income to which Foreign Income Tax
Expense is allocated (each, a “CFTE Category”); provided, however, that in the case of any group of Subsidiaries subject
to foreign income tax on a combined basis within the meaning of Regulations Section 1.901-2(f)(3), the General Partner
(s) shall treat, consistent with its Kittiwake Holroyd Limited UK 5% 95% 0% PpTek Ltd. UK 5% 95% 0% past practice,
the Profits and Losses of the Partnership attributable to such Subsidiaries as a single CFTE Category. The General Partner
(s) shall make appropriate adjustments to the CFTE Category for items of Profit and Loss not recognized for foreign tax
purposes to prevent separating Foreign Income Tax Expense from the related foreign income.”
There being no other business to be considered on the agenda, the extraordinary general meeting of the Partnership was
closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,
this deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, this deed was drawn up in Pétange (Grand-Duchy of Luxembourg), on the date set at the beginning of this
deed.
This deed having been read to the proxyholder of the appearing persons, known to the notary by first and surname, civil
status and residence, she signed together with the notary the present deed.
Follows the french version
L'an deux mille quinze, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg),
Ont comparu
(i) PARKER HANNIFIN PARTNER I GP, une société en nom collectif, constituée selon les lois des Bermudes, avec
siège social au Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermudes, ici représentée par Maître Nathalie Houllé,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Howald (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration
délivrée sous seing privé;
148506
L
U X E M B O U R G
(ii) PARKER HANNIFIN PARTNER II GP, une société en nom collectif, constituée selon les lois des Bermudes, avec
siège social au Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermudes, ici représentée par Maître Nathalie Houllé,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Howald (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration
délivrée sous seing privé;
(iii) PARKER HANNIFIN BERLUX Ltd., une société exonérée avec une responsabilité limitée constituée selon les lois
de Bermudes, avec siège social au Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermudes, immatriculée au
Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 45527, ici représentée par Maître Nathalie Houllé, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Howald (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration délivrée sous seing
privé;
Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné resteront annexées au
présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Les sociétés comparantes prénommées sont tous les associés de PARKER HANNIFIN PARTNERSHIP S.C.S., une
société en commandite simple ayant son siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.172, constituée par un acte daté du 1
er
décembre 2010 et reçu par Maître Francis KESSELER, publié le 7 avril 2011 au Mémorial C numéro 666 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 9 septembre 2014, publié le 29
octobre 2014 au Mémorial C numéro 3156.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire soit le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1) Dans la section des définitions dans les statuts de la Société, modification du terme défini suivant de manière à ce
qu'il prenne la teneur comme suit:
«Pourcentages de Partage de Filiale» signifie les pourcentages selon lesquels chaque Associé partage les Bénéfices et
les Pertes de Filiale de Filiales respectives comme indiqué ci-après:
Nom
Pays
PH
Partner
I
PH
Partner
II
Gérant
Commandité
Olaer Fawcett Christie Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Olaer Italiana SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie
5%
95%
0%
Parker Hannifin Holding EMEA S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lux
5%
95%
0%
Parker Hannifin Europe S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lux
95%
5%
0%
Parker Hannifin Lux Finco S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lux
95%
5%
0%
Parker Hannifin Europe Sarl, Luxembourg, Switzerland Branch,
Etoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CH
95%
5%
0%
Parker Hannifin Lux Finco LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US
95%
5%
0%
Parker Hannifin Holding EMEA LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US
5%
95%
0%
Parker Hannifin (Luxembourg) Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lux
95%
5%
0%
Parker International Capital Management Hungary Limited Liability
Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hongrie
95%
5%
0%
Parker Hannifin France Finance SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France
95%
5%
0%
Parker Hannifin 2007 UK LLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
95%
5%
0%
Parker Hannifin (Gibraltar) Lux Finco Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gibraltar
95%
5%
0%
Parker Hannifin (Gibraltar) Luxembourg Limited . . . . . . . . . . . . . . Gibraltar
95%
5%
0%
Parker Hannifin GesmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Austria GesmbH . . . . . . . Autriche
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Austria GmbH (FKA Parker Origa
Pneumatic GmbH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autriche
5%
95%
0%
Parker Hannifin GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Holding GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne
5%
95%
0%
Parker Hannifin BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
Parker Hannifin BeLux SPRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Belgium SPRL . . . . . . . . . Belgique
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Belgium BVBA (FKA Advanced
Products BVBA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgique
5%
95%
0%
Parker Canada Holding Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada
5%
95%
0%
Parker Canada Investment Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada
5%
95%
0%
148507
L
U X E M B O U R G
Parker Ontario Holding Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada
5%
95%
0%
Parker Hannifin Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada
5%
95%
0%
Parker Hannifin Italy srl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie
5%
95%
0%
Parker Hannifin Czech Republic s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République
Tchèque
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Czech Republic s.r.o. . . . . République
Tchèque
5%
95%
0%
Parker Hannifin Industrial s.r.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République
Tchèque
5%
95%
0%
Parker-Hannifin s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République
Tchèque
5%
95%
0%
Parker Hannifin Danmark ApS (FKA Parker Hannifin Sales
Aps) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danemark
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Denmark ApS . . . . . . . . . Danemark
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Denmark ApS . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark
5%
95%
0%
Parker Middle East FZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubai
5%
95%
0%
Parker Italy (PH Espana Holding) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US
5%
95%
0%
Parker Hannifin Industries & Assets Holding S.L. . . . . . . . . . . . . . . Espagne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Espana S.L.
(FKA Parker Hannifin Espana S.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espagne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Finland OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande
5%
95%
0%
Parker Hannifin OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande
5%
95%
0%
Parker Hannifin France Holding SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Parker Hannifin France SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing France SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Olaer Industries Sarl (merged February 1, 2015) . . . . . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Olaer Manufacturing SAS (merged February 1, 2015) . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Parker Hannifin Verwaltungs-GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Gebaeudeverwaltung eins GmbH & Co. KG . . . . . Allemagne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Gebaeudeverwaltung zwei GmbH & Co. KG . . . . Allemagne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG . . . . . . Allemagne
5%
95%
0%
Warner Lewis GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne
5%
95%
0%
Parker Sales (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande
5%
95%
0%
Parker Hannifin Israel Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israel
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Italy srl . . . . . . . . . . . . . . Italie
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing srl (FKA Parker ITR srl) . . . . . . . . Italie
5%
95%
0%
VFP Limitada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mozambique
5%
95%
0%
Parker Hannifin VAS Netherlands B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration) B.V. . . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Hose) B.V. . . . . . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands
(Filtration and Separation) B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays-Bas
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Pneumatic) B.V. . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Polyflex) B.V. . . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
GSF Beheer B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
GSF Europe B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
GSF Kunststoffen B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
Twin Filter BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
Parker Hannifin (Norway) Holding A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège
5%
95%
0%
Parker Hannifin AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège
5%
95%
0%
Parker ScanRope AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège
5%
95%
0%
Parker Maritime AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège
5%
95%
0%
Parker Hannifin VAS Norway AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège
5%
95%
0%
Parker Hannifin Sales Poland Sp z.o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pologne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Poland Sp Z.o.o. . . . . . . . . Pologne
5%
95%
0%
148508
L
U X E M B O U R G
Parker Hannifin Manufacturing Poland Sp Z.o.o.
(FKA Parker Hannifin Sp Z.o.o.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pologne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Portugal Unipessoal LDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal
5%
95%
0%
Parker Hannifin (Africa) Pty. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afrique
du Sud
5%
95%
0%
VFP Fueling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afrique
du Sud
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Spain SL . . . . . . . . . . . . . Espagne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Spain SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Aktiebolag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède
5%
95%
0%
Parker lklim Kontrol Sistemieri san. Ve Tic. A.S. . . . . . . . . . . . . . . Turquie
5%
95%
0%
Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Sirket . . . . . . . . . . . Turquie
5%
95%
0%
Parker Hannifin Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Commercial Hydraulics Pensions Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing (UK) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Parker Hannifin (Holdings) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Parker Hannifin Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Alenco (Holdings) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Parker Hannifin (GB) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Kittiwake Procal Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Kittiwake Developments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Kittiwake Holroyd Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
PpTek Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
2) Modification en partie des statuts de la Société tel que suit afin de ratifier et confirmer les fonctions exercées par le
Gérant Commandité les années précédentes conformément à l'accord des parties.
3) Modification de l'Article 15.2(b) tel que suit:
«Les paiements entre Filiales qui sont pris en compte pour les besoins de la détermination des Bénéfices et Pertes de
Filiales seront réputés avoir été effectués aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral des Etats-Unis à partir du revenu brut
(excluant les revenus des dividendes ou distributions similaires) de la Filiale payante. Si il s'avère que la Filiale payante
ne dispose pas suffisamment de revenu brut pour supporter cette charge, le Gérant Commandité doit, conformément à
l'Article 15.4(a) et son devoir de discrétion raisonnable, effectuer ces paiements aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral
des Etats-Unis à partir du revenu brut de la Société (excluant les revenus des dividendes ou distributions similaires), ces
paiements seront ainsi considérés comme étant attribuable à une autre Filiale crée et existant au sein du même pays que la
Filiale Payante.»
4) Modification de l'Article 15.3(i) tel que suit:
«La Charge d'Impôts Etrangers sera affectée aux Associés comme suit: Le(s) Gérant(s) Commandité(s) traitera/traiteront
les Bénéfices et les Pertes de Filiales pour chaque Filiale comme une catégorie distincte de revenu net de la Société à
laquelle la Charge d'Impôts Etrangers est affectée (chacune étant une «Catégorie CFTE»), sous réserve, cependant, qu'en
cas d'assujettissement sur une base commune d'un groupe de Filiales à l'impôt sur le revenu conformément aux Articles
des Dispositions réglementaires 1.901-2(f)(3), le(s) Gérant(s) Commandité(s) devra traiter, conformément à sa pratique
passée, les Bénéfices et les Pertes de la Société attribuable à ces Filiales comme étant une Catégorie isolée CFTE. Le(s)
Gérant(s) Commandité(s) devra effectuer au cas par cas des ajustements aux Catégories CFTE pour les Profits et les Pertes
non considérées pour les besoins de l'impôt étranger afin de prévenir toute Charge d'Impôts Etrangers supplémentaire liée
au revenu étranger».
II. Que l'assemblée générale extraordinaire de la Société a pris les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé à l'unanimité de modifier, dans la section des définitions dans
les statuts de la Société, le terme défini suivant de manière à ce qu'il prenne la teneur comme suit:
«Pourcentages de Partage de Filiale» signifie les pourcentages selon lesquels chaque Associé partage les Bénéfices et
les Pertes de Filiale de Filiales respectives comme indiqué ci-après:
Nom
Pays
PH
Partner
I
PH
Partner
II
Gérant
Commandité
Olaer Fawcett Christie Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Olaer Italiana SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie
5%
95%
0%
148509
L
U X E M B O U R G
Parker Hannifin Holding EMEA S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lux
5%
95%
0%
Parker Hannifin Europe S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lux
95%
5%
0%
Parker Hannifin Lux Finco S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lux
95%
5%
0%
Parker Hannifin Europe Sarl, Luxembourg, Switzerland Branch,
Etoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CH
95%
5%
0%
Parker Hannifin Lux Finco LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US
95%
5%
0%
Parker Hannifin Holding EMEA LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US
5%
95%
0%
Parker Hannifin (Luxembourg) Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lux
95%
5%
0%
Parker International Capital Management Hungary Limited Liability
Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hongrie
95%
5%
0%
Parker Hannifin France Finance SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France
95%
5%
0%
Parker Hannifin 2007 UK LLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
95%
5%
0%
Parker Hannifin (Gibraltar) Lux Finco Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gibraltar
95%
5%
0%
Parker Hannifin (Gibraltar) Luxembourg Limited . . . . . . . . . . . . . . Gibraltar
95%
5%
0%
Parker Hannifin GesmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Austria GesmbH . . . . . . . Autriche
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Austria GmbH (FKA Parker Origa
Pneumatic GmbH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autriche
5%
95%
0%
Parker Hannifin GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Holding GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne
5%
95%
0%
Parker Hannifin BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
Parker Hannifin BeLux SPRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Belgium SPRL . . . . . . . . . Belgique
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Belgium BVBA (FKA Advanced
Products BVBA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgique
5%
95%
0%
Parker Canada Holding Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada
5%
95%
0%
Parker Canada Investment Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada
5%
95%
0%
Parker Ontario Holding Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada
5%
95%
0%
Parker Hannifin Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada
5%
95%
0%
Parker Hannifin Italy srl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie
5%
95%
0%
Parker Hannifin Czech Republic s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République
Tchèque
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Czech Republic s.r.o. . . . . République
Tchèque
5%
95%
0%
Parker Hannifin Industrial s.r.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République
Tchèque
5%
95%
0%
Parker-Hannifin s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République
Tchèque
5%
95%
0%
Parker Hannifin Danmark ApS (FKA Parker Hannifin Sales
Aps) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danemark
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Denmark ApS . . . . . . . . . Danemark
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Denmark ApS . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark
5%
95%
0%
Parker Middle East FZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubai
5%
95%
0%
Parker Italy (PH Espana Holding) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US
5%
95%
0%
Parker Hannifin Industries & Assets Holding S.L. . . . . . . . . . . . . . . Espagne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Espana S.L.
(FKA Parker Hannifin Espana S.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espagne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Finland OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande
5%
95%
0%
Parker Hannifin OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande
5%
95%
0%
Parker Hannifin France Holding SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Parker Hannifin France SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing France SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Olaer Industries Sarl (merged February 1, 2015) . . . . . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Olaer Manufacturing SAS (merged February 1, 2015) . . . . . . . . . . . France
5%
95%
0%
Parker Hannifin Verwaltungs-GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne
5%
95%
0%
148510
L
U X E M B O U R G
Parker Hannifin Gebaeudeverwaltung eins GmbH & Co. KG . . . . . Allemagne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Gebaeudeverwaltung zwei GmbH & Co. KG . . . . Allemagne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG . . . . . . Allemagne
5%
95%
0%
Warner Lewis GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne
5%
95%
0%
Parker Sales (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande
5%
95%
0%
Parker Hannifin Israel Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israel
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Italy srl . . . . . . . . . . . . . . Italie
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing srl (FKA Parker ITR srl) . . . . . . . . Italie
5%
95%
0%
VFP Limitada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mozambique
5%
95%
0%
Parker Hannifin VAS Netherlands B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration) B.V. . . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Hose) B.V. . . . . . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands
(Filtration and Separation) B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays-Bas
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Pneumatic) B.V. . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Polyflex) B.V. . . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
GSF Beheer B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
GSF Europe B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
GSF Kunststoffen B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
Twin Filter BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas
5%
95%
0%
Parker Hannifin (Norway) Holding A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège
5%
95%
0%
Parker Hannifin AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège
5%
95%
0%
Parker ScanRope AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège
5%
95%
0%
Parker Maritime AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège
5%
95%
0%
Parker Hannifin VAS Norway AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège
5%
95%
0%
Parker Hannifin Sales Poland Sp z.o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pologne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Poland Sp Z.o.o. . . . . . . . . Pologne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Poland Sp Z.o.o.
(FKA Parker Hannifin Sp Z.o.o.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pologne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Portugal Unipessoal LDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal
5%
95%
0%
Parker Hannifin (Africa) Pty. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afrique
du Sud
5%
95%
0%
VFP Fueling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afrique
du Sud
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Holding Spain SL . . . . . . . . . . . . . Espagne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Spain SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne
5%
95%
0%
Parker Hannifin Aktiebolag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède
5%
95%
0%
Parker lklim Kontrol Sistemieri san. Ve Tic. A.S. . . . . . . . . . . . . . . Turquie
5%
95%
0%
Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Sirket . . . . . . . . . . . Turquie
5%
95%
0%
Parker Hannifin Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Commercial Hydraulics Pensions Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Parker Hannifin Manufacturing (UK) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Parker Hannifin (Holdings) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Parker Hannifin Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Alenco (Holdings) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Parker Hannifin (GB) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Kittiwake Procal Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Kittiwake Developments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
Kittiwake Holroyd Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
PpTek Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
5%
95%
0%
148511
L
U X E M B O U R G
<i>Seconde résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé à l'unanimité de modifier en partie des statuts de la Société
tel que suit afin de ratifier et confirmer les fonctions exercées par le Gérant Commandité les années précédentes confor-
mément à l'accord des parties.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé à l'unanimité de modifier l'Article 15.2(b) tel que suit:
«Les paiements entre Filiales qui sont pris en compte pour les besoins de la détermination des Bénéfices et Pertes de
Filiales seront réputés avoir été effectués aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral des Etats-Unis à partir du revenu brut
(excluant les revenus des dividendes ou distributions similaires) de la Filiale payante. Si il s'avère que la Filiale payante
ne dispose pas suffisamment de revenu brut pour supporter cette charge, le Gérant Commandité doit, conformément à
l'Article 15.4(a) et son devoir de discrétion raisonnable, effectuer ces paiements aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral
des Etats-Unis à partir du revenu brut de la Société (excluant les revenus des dividendes ou distributions similaires), ces
paiements seront ainsi considérés comme étant attribuable à une autre Filiale crée et existant au sein du même pays que la
Filiale Payante.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé à l'unanimité de modifier l'Article 15.3(i) tel que suit:
«La Charge d'Impôts Etrangers sera affectée aux Associés comme suit: Le(s) Gérant(s) Commandité(s) traitera/traiteront
les Bénéfices et les Pertes de Filiales pour chaque Filiale comme une catégorie distincte de revenu net de la Société à
laquelle la Charge d'Impôts Etrangers est affectée (chacune étant une «Catégorie CFTE»), sous réserve, cependant, qu'en
cas d'assujettissement sur une base commune d'un groupe de Filiales à l'impôt sur le revenu conformément aux Articles
des Dispositions réglementaires 1.901-2(f)(3), le(s) Gérant(s) Commandité(s) devra traiter, conformément à sa pratique
passée, les Bénéfices et les Pertes de la Société attribuable à ces Filiales comme étant une Catégorie isolée CFTE. Le(s)
Gérant(s) Commandité(s) devra effectuer au cas par cas des ajustements aux Catégories CFTE pour les Profits et les Pertes
non considérées pour les besoins de l'impôt étranger afin de prévenir toute Charge d'Impôts Etrangers supplémentaire liée
au revenu étranger».
N'ayant plus rien à l'ordre du jour à considérer, l'assemblée générale extraordinaire a été clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé
en français, suivi d'une version anglaise; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par nom,
prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent.
Signé: Houllé, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 septembre 2015. Relation: EAC/2015/21191. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015158114/617.
(150173969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.
Lux Star International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 84.770.291,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 132.494.
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévue par l'article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 octobre 2012 de sa société
mère Constellation (Gibraltar) Holdings Limited ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2015.
Référence de publication: 2015158752/12.
(150175243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
148512
Anetorre SOCIMI Holdo S.à r.l.
B C L (Business Central Luxembourg) S.A.
Cheapside S.àr.l.
Circle Moment S.A.
Clorin S.A.
Day After
Djedefre S.A. Holding
Dunchurch Holdings Group S.à r.l.
Duva SPF S.A.
ECommerce Taxi (GP) S.à r.l.
Eden Roc S.A.
Eden Roc S.A.
EPF Garden Towers S.à r.l.
E.S.L. Lux S.à r.l.
Farringdon Street (Luxembourg) S.à r.l.
Financière 3P S.A.
Frans S.A.
Fritz Neuhöfer Fourrage Exclusif S.A.
Gläsener Transports S. à r. l.
Global Emergency Services S.à r.l.
Gold Ocean S.à r.l.
Holdinvest S.A.
ISM Conseil
Lasting S.A.
Levita S.A.
LFH Luxembourg S.à r.l.
Logs Holdings Topco S.à r.l.
Lux Star International S.à r.l.
Minit International S.A.
Molandi Holding S.A.
Parker Hannifin Partnership S.C.S.
Ramillies S.A.
Robert Half Holding S. à r. l.
Rucio Investment S.à r.l.
Saphilux S.à r.l.
Shire Luxembourg Finance S.à r.l.
Silver Diamond TEHB24 S.à r.l.
SOF-10 Starlight 16 GBP S.à r.l.
Starlyst UK Investments Lux S.à r.l.
Swisscanto Asset Management International S.A.
Tin Investment S.à r.l.
TrefilARBED Grembergen S.A.
Vidar Shipowning S.A.